logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 261

2 février 2015

SOMMAIRE

AC Technologies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12482

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco

II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12486

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco

I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12483

Alter Sana s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12505

Cencom Group SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12525

DWS Euro-Bonds (Long)  . . . . . . . . . . . . . . .

12490

DWS Euro-Bonds (Medium)  . . . . . . . . . . . .

12490

DWS Eurorenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12490

DWS India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12490

DWS Russia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12489

DWS Türkei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12489

DWS Vermögensmandat  . . . . . . . . . . . . . . .

12489

Eurizon Multiasset Fund  . . . . . . . . . . . . . . . .

12492

Fairacre Properties (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . .

12516

Flagstone Capital Management Luxem-

bourg SICAF - FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12493

Gammaquest Investment Company S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12505

Generation IM Credit Master Fund, FCP-

SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12493

GIS High Conviction Equity (USD)  . . . . . .

12489

Global Emerging Markets Balance Portfo-

lio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12492

GPB International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

12498

Hadrian S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12495

Homelooking s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12508

ING Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12492

Jayefkay Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12489

Lux Bauelemente S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

12501

Markcis s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12510

MGI WASHENG Investment S.A.  . . . . . . .

12525

Mivalve S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12496

MUGC Ashmore Latin America USD Bond

Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12493

Netzaberg Luxembourg SPS 5 S.à r.l.  . . . .

12491

Netzaberg Luxembourg SPS 8 S.à r.l.  . . . .

12508

Parest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12492

Petro Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12496

ProLogis European Finance XIX S.à r.l.  . .

12512

ProLogis European Finance XX S.à r.l.  . . .

12517

ProLogis France XVI S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . .

12512

ProLogis France XX S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . .

12512

ProLogis France XXVII S.à.r.l.  . . . . . . . . . .

12512

ProLogis France XXVI S.à.r.l.  . . . . . . . . . . .

12512

ProLogis France XXXVIII S.à r.l.  . . . . . . . .

12512

PVM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12491

PWM Mandat - DWS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12491

Rigo Trading S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12496

SAVOLDELLI & fils s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

12482

Schwedeneck Properties S.à r.l.  . . . . . . . . .

12482

SCORE Special Opportunities  . . . . . . . . . . .

12491

SCORE Special Opportunities  . . . . . . . . . . .

12491

Serrano S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12482

Siris S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12490

Sosna s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12503

Syntegra Investments III S. à r.l.  . . . . . . . . .

12526

UnionProtect: Europa (CHF) . . . . . . . . . . . .

12492

12481

L

U X E M B O U R G

SAVOLDELLI & fils s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 235, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 59.542.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2014209641/10.
(140233702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Schwedeneck Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 131.137.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Schwedeneck Properties S.a r.l.
SGG S.A.

Référence de publication: 2014209612/11.
(140234545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

AC Technologies, Société Anonyme.

Siège social: L-9970 Leithum, 2, Driicht.

R.C.S. Luxembourg B 107.060.

Die Damen und Herren Aktionäre werden eingeladen zur

AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

welche am <i>16. Februar 2015 um 15:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Notarin Anja HOLTZ, 19B, rue Louis Pasteur,

L-4276 Esch/Alzette stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Satzungsänderung zur Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien, um den Vorschriften des Gesetzes vom 14.

August 2014 zu genügen.

2. Sonstiges.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015013102/15.

Serrano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 43.094.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>23 février 2015 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2014;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2014;
4. Vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015013103/10/18.

12482

L

U X E M B O U R G

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 164.966.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of December.
Before Us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A., a Luxem-

bourg société anonyme, incorporated by a notarial deed drawn up on 24 November 2011, having its registered office at
14, boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies ("RCS") under number B 164.966 and whose articles of association (the "Articles") have been published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under number 2979, page 142948 dated 6
December 2011 (the “Company”). The Articles have been amended for the last time on 29 October 2014 pursuant to
a deed of the undersigned notary published in the Mémorial under number 3766, page 180733 dated 8 December 2014.

The extraordinary general meeting of the Company (the "Meeting") is opened at 3.00 p.m. and elected as chairman

Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Mondorf-les-Bains.

The chairman appointed as secretary Mr Chris Oberhag, private employee, residing professionally in Mondorf-les-

Bains.

The Meeting elected as scrutineer Mr Chris Oberhag, prenamed.
The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:
I. The names of the shareholders represented at the Meeting by proxies (together the "Appearing Shareholders") and

the number of shares held by them are shown on an attendance list at the end of these minutes. This attendance list has
been signed ne varietur with the proxy forms by the shareholders represented at the Meeting by proxies, the notary, the
chairman, the scrutineer and the secretary.

II. The attendance list shows that the whole share capital of the Company is represented. The Appearing Shareholders

have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the Meeting beforehand and have waived all
convening requirements and formalities. The Meeting can validly decide on all the items of the below agenda.

III. The agenda of the Meeting was the following:

<i>Agenda

1. To resolve to reduce the Company’s share capital by an amount of fifty million five hundred thousand Euros (EUR

50,500,000.00) from its current amount of three hundred fifty-three million nine hundred thousand four hundred thirty-
two euro and seventy-five euro cent (EUR 353,900,432.75) to three hundred three million four hundred thousand four
hundred thirty-two euro and seventy-five euro cent (EUR 303,400,432.75) by the cancellation of five billion fifty million
(5,050,000,000) Shares held by the Company (the “Share Capital Decrease”);

2. To amend the first sentence of article 5 of the Articles (Share Capital) to reflect the Share Capital Decrease which

shall now read as follows:

“ Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at three hundred three million four hundred thousand four

hundred thirty-two euro and seventy-five euro cent (EUR 303,400,432.75), fully paid up and represented by thirty billion
three hundred forty million forty-three thousand two hundred seventy-five (30,340,043,275) shares (the "Shares") with
a par value one Euro cent (EUR 0.01) per share.”

3. Miscellaneous.
The Meeting, declares and requests the undersigned notary to act that:

<i>First resolution

The Meeting resolves to reduce the Company’s share capital by an amount of fifty million five hundred thousand Euros

(EUR 50,500,000.00) from its current amount of three hundred fifty-three million nine hundred thousand four hundred
thirty-two euro and seventy-five euro cent (EU 353,900,432.75) to three hundred three million four hundred thousand
four hundred thirty-two euro and seventy-five euro cent (EUR 303,400,432.75) by the cancellation of five billion fifty
million (5,050,000,000) Shares held by the Company (the “Share Capital Decrease”).

Reimbursement
According to article 69 (2) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 and as amended

from time to time, which establishes a legal protection in favor of creditors of the Company, in case the share capital
reduction is to be carried out by means of a repayment to shareholders or a waiver of their obligation to pay up their
shares, creditors whose claims predate the publication of the minutes of the meeting in the Mémorial may, within 30 days
from such publication, apply for the constitution of security to the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arron-
dissement dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters. The president may only reject such an

12483

L

U X E M B O U R G

application if the creditor already has adequate safeguards or if such security is unnecessary, having regard to the assets
of the Company. Additionally, the Company will not carry out the share capital decrease before getting the authorization
according to article 7 of the Articles.

<i>Second resolution

Further to the previous resolution, the Meeting resolves to amend the 1 

st

 paragraph of article 5 of the Articles (Share

Capital) to reflect the Share Capital Decrease, which shall henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at three hundred three million four hundred thousand four

hundred thirty-two euro and seventy-five euro cent (EUR 303,400,432.75), fully paid up and represented by thirty billion
three hundred forty million forty-three thousand two hundred seventy-five (30,340,043,275) shares (the "Shares") with
a par value one Euro cent (EUR 0.01) per share."

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection this deed, have been estimated at about two thousand two hundred euros (EUR 2,200.-).

There being no further business, the meeting is closed at 3.13 p.m..

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des voranstehenden Textes

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dreiundzwanzigsten Dezember,
wurde vor dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,
eine Hauptversammlung der Aktiengesellschaft Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A. (die "Aktiengesell-

schaft"), eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (société anonyme) mit
Gesellschaftssitz in 14, boulevard F. D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Han-
dels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 164.966,
gegründet durch notarielle Urkunde aufgenommen am 24. November 2011, die Satzung wurde am 6. Dezember 2011 im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") unter der Nummer 2979, Seite 142948 veröffentlicht.

Die Satzung der Aktiengesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch eine von dem unterzeichnenden Notar am 29.

Oktober 2014 aufgenommenen Urkunde, im Mémorial veröffentlicht unter der Nummer 3766, Seite 180733 vom 8.
Dezember 2014.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft (die "Hauptversammlung") wird um 15.00 Uhr eröffnet und

wählt als Vorsitzenden Herr Frank Stolz-Page, Privatangestellteer, mit Berufsanschrift in Bad-Mondorf.

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Herrn Chris Oberhag, mit Berufsanschrift in Bad-Mondorf.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herrn Chris Oberhag, vorbenannt.
Sodann stellt der Vorsitzende fest und bittet den Notar zu beurkunden:
I. Dass aus einer dieser Urkunde beigefügten Anwesenheitsliste, die Namen der Aktionäre, die auf dieser Hauptver-

sammlung  durch  Vollmachten  vertreten  sind  (die  "Erschienenen  Aktionäre")  und  die  von  ihnen  gehaltenen  Aktien
hervorgehen. Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet,
bleibt zusammen mit den Vollmachten dieser Urkunde, mit welcher sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Die Anwesenheitsliste belegt, dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist. Dass die Erschienenen Aktionäre

bestätigen, von der Tagesordnung Kenntnis zu haben, demgemäß ausdrücklich auf eine förmliche Einberufung verzichten
und sich zu dieser Versammlung ordnungsgemäß einberufen erklären. Die Hauptversammlung kann daher über alle Punkte
der Tagesordnung wirksam entscheiden.

III. Dass die Tagesordnung dieser Versammlung folgende Punkte umfasst:

<i>Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um fünfzig Millionen fünfhunderttausend Euro

(EUR 50.500.000,00) von derzeit dreihundertdreiundfünfzig Millionen neunhunderttausend vierhundertzweiundreißig Eu-
ro und fünfundsiebzig Euro Cent (EUR 353.900.432,75) auf dreihundertdrei Millionen vierhunderttausend vierhundert-
zweiundreißig Euro und fünfundsiebzig Euro Cent (EUR 303.400.432.75) durch die Vernichtung von fünf Milliarden fünfzig
Millionen (5.050.000.000) Aktien, die durch die Gesellschaft gehalten werden (die „Kapitalherabsetzung“);

12484

L

U X E M B O U R G

2. Abänderung des fünften Artikels der Satzung (Gesellschaftskapital) im Zuge der Kapitalherabsetzung, so dass dieser

von nun an wie folgt lautet:

„ Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt dreihundertdrei

Millionen vierhunderttausend vierhundertzweiundreißig Euro und fünfundsiebzig Euro Cent (EUR 303.400.432,75) und
ist in dreißig Milliarden dreihundertvierzig Millionen dreiundvierzigtausend zweihundertfünfundsiebzig (30.340.043.275)
Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt.“

3. Sonstiges
Die Versammlung erklärt und ersucht den unterzeichnenden Notar wie folgt zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von fünfzig Millionen fünfhunderttausend Euro

(EUR 50.500.000,00) von derzeit dreihundertdreiundfünfzig Millionen neunhunderttausend vierhundertzweiundreißig Eu-
ro und fünfundsiebzig Euro Cent (EUR 353.900.432,75) auf dreihundertdrei Millionen vierhunderttausend vierhundert-
zweiundreißig Euro und fünfundsiebzig Euro Cent (EUR 303.400.432.75) durch die Vernichtung von fünf Milliarden fünfzig
Millionen (5.050.000.000) Aktien, die durch die Gesellschaft gehalten werden (die „Kapitalherabsetzung“).

<i>Zweiter Beschluss

Gemäß Artikel 69 (2) des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in geänderter

Fassung, welche einen Gläubigerschutz im Falle von Kapitalherabsetzungen für den Fall vorsieht, dass die Kapitalherab-
setzung durch Rückzahlung an die Aktionäre erfolgt oder eine Entbindung der Aktionäre von ihrer Verpflichtung ihre
Aktien einzuzahlen, so können Gläubiger, deren Forderungen vor der Veröffentlichung des Protokolls der Hauptver-
sammlung im Amtsblatt (Mémorial) entstanden ist, innerhalb von dreißig Tagen ab der Veröffentlichung beim Vorsitzenden
Richter des in Handelssachen tagenden tribunal d'arondissement im Eilverfahren die Stellung von Sicherheiten beantragen.
Der Vorsitzende kann diesen Antrag nur abweisen, wenn der Gläubiger bereits über ausreichende Sicherheiten verfügt
oder wenn solche in Anbetracht des Vermögens der Gesellschaft nicht notwendig sind. Zusätzlich kann die Gesellschaft
die Kapitalherabsetzung nicht durchführen, bevor sie die Zustimmung gemäß Artikel 7 der Satzung eingeholt hat..

<i>Dritter Beschluss

Ferner zu dem oben genannten Beschluß, beschließt die Versammlung den 1. Satz des Artikels 5 der Satzung der

Gesellschaft (Gesellschaftskapital) zu ändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt dreihundertdrei

Millionen vierhunderttausend vierhundertzweiundreißig Euro und fünfundsiebzig Euro Cent (EUR 303.400.432,75) und
ist in dreißig Milliarden dreihundertvierzig Millionen dreiundvierzigtausend zweihundertfünfundsiebzig (30.340.043.275)
Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."

<i>Kosten

Jegliche Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder sonstigen Ausgaben gleich welcher Art, die die Gesellschaft aufgrund

dieser notariellen Urkunde zu tragen hat, werden auf ungefähr zweitausendzweihundert Euro (EUR 2.200,-) geschätzt.

Die Versammlung wird um 15.13 Uhr geschlossen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der Erschienenen in englischer Sprache samt deutscher Übersetzung abgefasst wurde. Auf Ersu-
chen der gleichen Erschienenen soll im Falle von Divergenzen zwischen der englischen und der deutschen Fassungen, die
englische Fassung Vorrang haben.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Bad-Mondorf, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, am zum Beginn

dieses Dokuments genannten Datum.

Nachdem das Dokument den Erschienenen vorgelesen worden war, unterzeichneten diese gemeinsam mit dem Notar

die vorliegende Urkunde.

Signé: F.Stolz-Page, C. Oberhag, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2015. GAC/2015/147. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015490/160.
(150018210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

12485

L

U X E M B O U R G

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 165.370.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of December.
Before Us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A., a Luxem-

bourg société anonyme, incorporated by a notarial deed drawn up on 24 November 2011, having its registered office at
14, Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies ("RCS") under number B 165.370 and whose articles of association (the "Articles") have been published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under number 127, page 6056 dated 17 January
2012 (the “Company”). The Articles have been amended for the last time on 31 January 2014 pursuant to a deed of the
undersigned notary published in the Mémorial under number 3769, page 180878 on 8 December 2014.

The extraordinary general meeting of the Company (the "Meeting") is opened at 3.15 p.m. and elected as chairman

Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Mondorf-les-Bains.

The chairman appointed as secretary Mr Chris Oberhag, private employee, residing professionally in Mondorf-les-

Bains.

The Meeting elected as scrutineer Mr Chris Oberhag, prenamed.
The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:
I. The names of the shareholders represented at the Meeting by proxies (together the "Appearing Shareholders") and

the number of shares held by them are shown on an attendance list at the end of these minutes. This attendance list has
been signed ne varietur with the proxy forms by the shareholders represented at the Meeting by proxies, the notary, the
chairman, the scrutineer and the secretary.

II. The attendance list shows that the whole share capital of the Company is represented. The Appearing Shareholders

have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the Meeting beforehand and have waived all
convening requirements and formalities. The Meeting can validly decide on all the items of the below agenda.

III. The agenda of the Meeting was the following:

<i>Agenda

1. Resolution to reduce the Company's share capital by an amount of ten million five hundred thousand Euros (EUR

10,500,000.00) from its current amount of sixty-five million six hundred ninety-six thousand ninety-six Euro and twenty-
five Euro Cent (EUR 65,696,096.25) to fifty-five million one hundred ninety-six thousand ninety-six Euro and twenty-five
Euro Cent (EUR 55,196,096.25) by the cancellation of one billion fifty million (1,050,000,000) Shares held by the Company
(the "Share Capital Decrease").

2. To amend the first sentence of article 5 of the Articles (Share Capital) to reflect the above mentioned share capital

decrease, which shall now read as follows:

Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at fifty-five million one hundred ninety-six thousand ninety-

six Euro and twenty-five Euro Cent (EUR 55,196,096.25), fully paid up and represented by five billion five hundred nineteen
Million six hundred nine thousand six hundred twenty-five (5,519,609,625) shares (the "Shares") with a par value one
Euro cent (EUR 0.01) per share."

3. Miscellaneous.
The Meeting declares and requests the undersigned notary to act that:

<i>First resolution

The Meeting resolves to reduce the Company's share capital by an amount of ten million five hundred thousand Euros

(EUR 10,500,000.00) from its current amount of sixty-five million six hundred ninety-six thousand ninety-six Euro and
twenty-five Euro Cent (EUR 65,696,096.25) to fifty-five million one hundred ninety-six thousand ninety-six Euro and
twenty-five Euro Cent (EUR 55,196,096.25) by the cancellation of one billion fifty million (1,050,000,000) Shares held by
the Company (the "Share Capital Decrease").

REIMBURSEMENT
According to article 69 (2) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 and as amended

from time to time, which establishes a legal protection in favor of creditors of the Company, in case the share capital
reduction is to be carried out by means of a repayment to shareholders or a waiver of their obligation to pay up their
shares, creditors whose claims predate the publication of the minutes of the meeting in the Mémorial may, within 30 days
from such publication, apply for the constitution of security to the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arron-
dissement dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters. The president may only reject such an

12486

L

U X E M B O U R G

application if the creditor already has adequate safeguards or if such security is unnecessary, having regard to the assets
of the Company. Additionally, the Company will not carry out the share capital decrease before getting the authorization
according to article 7 of the Articles.

<i>Second resolution

Further to the previous resolution, the Meeting resolves to amend the first sentence of article 5 of the Articles (Share

Capital) to reflect the share capital decrease, which shall read as follows:

Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at fifty-five million one hundred ninety-six thousand ninety-

six Euro and twenty-five Euro Cent (EUR 55,196,096.25), fully paid up and represented by five billion five hundred nineteen
Million six hundred nine thousand six hundred twenty-five (5,519,609,625) shares (the "Shares") with a par value one
Euro cent (EUR 0.01) per share."

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection this deed, have been estimated at about two thousand Euro (EUR 2,000).

There being no further business, the meeting is closed at 3.25 p.m..

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, they signed together with the notary

the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des voranstehenden Textes

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dreiundzwanzigsten Dezember,
wurde vor dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,
eine Hauptversammlung der Aktiengesellschaft Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A. (die "Aktiengesell-

schaft"), eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (société anonyme) mit
Gesellschaftssitz in 14, boulevard F. D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Han-
dels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 165.370,
gegründet durch notarielle Urkunde aufgenommen am 24. November 2011, die Satzung wurde am 17. Januar 2012 im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") unter der Nummer 127, Seite 6056 veröffentlicht. Die
Satzung der Aktiengesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch eine von dem unterzeichnenden Notar am 29. Oktober
2014 aufgenommene Urkunde, im Mémorial veröffentlicht unter der Nummer 3769, Seite 180878 am 8. Dezember 2014.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft (die "Hauptversammlung") wird um 15.15 Uhr eröffnet und

wählt als Vorsitzenden Herr Frank Stolz-Page, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in Bad Mondorf.

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Herrn Chris Oberhag, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in Bad Mon-

dorf.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herrn Chris Oberhag, vorbenannt.
Sodann stellt der Vorsitzende fest und bittet den Notar zu beurkunden:
I. Dass aus einer dieser Urkunde beigefügten Anwesenheitsliste, die Namen der Aktionäre, die auf dieser Hauptver-

sammlung  durch  Vollmachten  vertreten  sind  (die  "Erschienenen  Aktionäre")  und  die  von  ihnen  gehaltenen  Aktien
hervorgehen. Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet,
bleibt zusammen mit den Vollmachten dieser Urkunde, mit welcher sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Die Anwesenheitsliste belegt, dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist. Dass die Erschienenen Aktionäre

bestätigen, von der Tagesordnung Kenntnis zu haben, demgemäß ausdrücklich auf eine förmliche Einberufung verzichten
und sich zu dieser Versammlung ordnungsgemäß einberufen erklären. Die Hauptversammlung kann daher über alle Punkte
der Tagesordnung wirksam entscheiden.

III. Dass die Tagesordnung dieser Versammlung folgende Punkte umfasst:

<i>Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von zehn Millionen fünfhundert-

tausend Euro (EUR 10.500.000,-) von derzeit fünfundsechzig Millionen sechshundertsechsundneunzigtausend sechsund-
neunzig Euro und fünfundzwanzig Euro Cent (EUR 65.696.096.25,-) auf fünfundfünzig Millionen einhundertsechsundneun-
zigtausend sechsundneunzig Euro und fünfundzwanzig Euro Cent (EUR 55.196.096,25), durch die Vernichtung von einer
Milliarde fünfzig Millionen (1.050.000.000) Aktien die von der Gesellschaft gehalten werden (die „Kapitalherabsetzung“).

12487

L

U X E M B O U R G

2. Den Artikel 5 der Satzung (Gesellschaftskapital) der Kapitalherabsetzung entsprechend abzuändern, der von nun an

wie folgt lauten soll:

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt fünfundfünzig Mil-

lionen einhundertsechsundneunzigtausend sechsundneunzig Euro und fünfundzwanzig Euro Cent (EUR 55.196.096,25)
und  ist  in  fünf  Milliarden  fünfhundertneunzehn  Millionen  sechshundertneuntausend  sechshundertfünfundzwanzig
(5.519.609.625) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."

3. Sonstiges.
Die Versammlung erklärt und ersucht den unterzeichnenden Notar wie folgt zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von zehn Millionen fünfhunderttausend Euro

(EUR 10.500.000,-) von derzeit fünfundsechzig Millionen sechshundertsechsundneunzigtausend sechsundneunzig Euro und
fünfundzwanzig Euro Cent (EUR 65.696.096.25,-) auf fünfundfünzig Millionen einhundertsechsundneunzigtausend sechs-
undneunzig Euro und fünfundzwanzig Euro Cent (EUR 55.196.096,25), durch die Vernichtung von einer Milliarde fünfzig
Millionen (1.050.000.000) Aktien die von der Gesellschaft gehalten werden, herabzusetzen (die „Kapitalherabsetzung“).

RÜCKZAHLUNG
Gemäß Artikel 69 (2) des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in geänderter

Fassung, welche einen Gläubigerschutz im Falle von Kapitalherabsetzungen für den Fall vorsieht, dass die Kapitalherab-
setzung durch Rückzahlung an die Aktionäre erfolgt oder eine Entbindung der Aktionäre von ihrer Verpflichtung ihre
Aktien einzuzahlen, so können Gläubiger, deren Forderungen vor der Veröffentlichung des Protokolls der Hauptver-
sammlung im Amtsblatt (Mémorial) entstanden ist, innerhalb von dreißig Tagen ab der Veröffentlichung beim Vorsitzenden
Richter des in Handelssachen tagenden tribunal d'arondissement im Eilverfahren die Stellung von Sicherheiten beantragen.
Der Vorsitzende kann diesen Antrag nur abweisen, wenn der Gläubiger bereits über ausreichende Sicherheiten verfügt
oder wenn solche in Anbetracht des Vermögens der Gesellschaft nicht notwendig sind. Zusätzlich kann die Gesellschaft
die Kapitalherabsetzung nicht durchführen, bevor sie die Zustimmung gemäß Artikel 7 der Satzung eingeholt hat.

<i>Zweiter Beschluss

Ferner zu dem oben genannten Beschluss, beschließt die Versammlung den 1. Satz des Artikels 5 der Satzung der

Gesellschaft (Gesellschaftskapital) zu ändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt fünfundfünzig Mil-

lionen einhundertsechsundneunzigtausend sechsundneunzig Euro und fünfundzwanzig Euro Cent (EUR 55.196.096,25)
und  ist  in  fünf  Milliarden  fünfhundertneunzehn  Millionen  sechshundertneuntausend  sechshundertfünfundzwanzig
(5.519.609.625) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."

<i>Kosten

Jegliche Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder sonstigen Ausgaben gleich welcher Art, die die Gesellschaft aufgrund

dieser notariellen Urkunde zu tragen hat, werden auf ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000) geschätzt.

Die Versammlung wird um 15.25 Uhr geschlossen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der Erschienenen in englischer Sprache samt deutscher Übersetzung abgefasst wurde. Auf Ersu-
chen der gleichen Erschienenen soll im Falle von Divergenzen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, die
englische Fassung Vorrang haben.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Bad-Mondorf, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, am zum Beginn

dieses Dokuments genannten Datum.

Nachdem das Dokument den Erschienenen vorgelesen worden war, unterzeichneten diese gemeinsam mit dem Notar

die vorliegende Urkunde.

Signé: F. Stolz-Page, C. Oberhag, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2015. GAC/2015/148. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015491/161.
(150018239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

12488

L

U X E M B O U R G

DWS Türkei, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil- DWS Türkei - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von

Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015713/10.
(150019036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

DWS Russia, Fonds Commun de Placement.

Das  Verwaltungsreglement  -  Besonderer  Teil-  DWS  Russia  -  wurde  beim  Handels-  und  Gesellschaftsregister  von

Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015714/10.
(150019037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

DWS Vermögensmandat, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil- DWS Vermögensmandat - wurde beim Handels- und Gesellschaftsre-

gister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015712/10.
(150019035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

GIS High Conviction Equity (USD), Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil- GIS High Convection Equity (USD) - wurde beim Handels- und Ge-

sellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015711/10.
(150019034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Jayefkay Partners S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 8, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 162.465.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

er

 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2402 du 7 octobre 2011 .

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

JAYEFKAY PARTNERS S.A.

Référence de publication: 2014209304/14.
(140234339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

12489

L

U X E M B O U R G

DWS India, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil- DWS India - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Lu-

xemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015715/10.
(150019038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

DWS Eurorenta, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - DWS Eurorenta - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von

Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015716/10.
(150019039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

DWS Euro-Bonds (Long), Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - DWS Euro-Bonds (Long) - wurde beim Handels- und Gesellschaftsre-

gister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015717/10.
(150019040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

DWS Euro-Bonds (Medium), Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - DWS Euro-Bonds (Medium) - wurde beim Handels- und Gesellschafts-

register von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015718/10.
(150019041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Siris S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 121.084.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29.12.2014.

<i>Pour: SIRIS S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2014208571/14.
(140232761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

12490

L

U X E M B O U R G

SCORE Special Opportunities, Fonds Commun de Placement.

Die Änderungsvereinbarung betreffend des Verwaltungsreglements und des Sonderreglements des Score Special Op-

portunities, welche am 12.01.2015 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VPB-FINANCE S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2015006842/10.
(150006713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

SCORE Special Opportunities, Fonds Commun de Placement.

Die konsolidierte Fassung des Verwaltungsreglements und des Sonderreglements des Score Special Opportunities,

welche am 02.02.2015 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VPB-FINANCE S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2015006843/10.
(150006746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

PVM, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Axxion S.A. / Banque de Luxembourg
Unterschriften
<i>Verwaltungsgesellschaft / Verwahrstelle

Référence de publication: 2015010397/10.
(150012346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

PWM Mandat - DWS, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil- PWM Mandat - DWS - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015709/10.
(150019032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Netzaberg Luxembourg SPS 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 133.223.

Veuillez noter que l'associé Al-Rayyan 2 Luxembourg S.à.r.l ainsi que le gérant unique Cyan S.à.r.l. ont leur son siège

social au 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

<i>Pour Netzaberg Luxembourg SPS 5 S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014206079/14.
(140230623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

12491

L

U X E M B O U R G

Parest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 140.172.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014209514/10.
(140234039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Global Emerging Markets Balance Portfolio, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - Global Emerging Markets Balance Portfolio - wurde beim Handels- und

Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015710/10.
(150019033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

ING Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 6.041.

L’extrait du recueil des signatures autorisées du 22 janvier 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012771/10.
(150014533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.

UnionProtect: Europa (CHF), Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 1. Januar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsre-

gister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Januar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014206539/10.
(140229244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Eurizon Multiasset Fund, Fonds Commun de Placement.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société de gestion Eurizon Capital S.A. du 25 juillet 2014

que le fonds commun de placement de droit luxembourgeois à compartiments multiples EURIZON MULTIASSET FUND
a été mis en liquidation avec date d'effet 16 janvier 2015, suite à la fusion par absorption de la totalité des compartiments
de la structure dans des compartiments du fonds commun de placement de droit luxembourgeois à compartiments
multiples EURIZON EASYFUND et EURIZON MANAGER SELECTION FUND.

La clôture de la susdite liquidation est intervenue le 16 janvier 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURIZON CAPITAL S.A.
Jérôme DEBERTOLIS

Référence de publication: 2015013998/7255/14.

12492

L

U X E M B O U R G

MUGC Ashmore Latin America USD Bond Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié de MUGC/ASHMORE LATIN AMERICA USD BOND FUND a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015013705/9.
(150016359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Generation IM Credit Master Fund, FCP-SIF, Fonds Commun de Placement.

The amended management regulations with respect to the common fund Generation IM Credit Master Fund, FCP-SIF

have been filed with the Luxembourg Trade and Companies Register.

Le règlement de gestion modifié concernant le fonds commun de placement Generation IM Credit Master Fund, FCP-

SIF a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Generation Investment Management S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015015038/13.
(150017594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Flagstone Capital Management Luxembourg SICAF - FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAF

- Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 141.810.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-second of December.
Before Us Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains.

Was held:

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Flagstone Capital Management Luxembourg SICAF-FIS (in

liquidation), a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) qualifying as a Société d'Investissement à
Capital fixe - fonds d’investissement spécialisé, with registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, duly
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B number 141.810. The company
has been constituted by deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, on 8 September 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2455 of 8 October
2008. The articles of incorporation of the company (the “Articles”) have been amended several times and the last time
on 30 December 2011 pursuant to a deed of Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, published in the Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 587 of 6 March 2012.

The company was put into liquidation by deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated

23 December, 2013 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 911 of 9 April 2014.

The meeting of the sole shareholder is opened at 4.15 p.m. and presided over by Mr Frank Stolz-Page, private employee,

residing professionally at Mondorf-les-Bains.

The chairman has appointed as secretary Mrs Brigitte Wahl, private employee, residing professionally at Mondorf-les-

Bains.

The meeting has appointed as scrutineer Mr Chris Oberhag, private employee, with same professional address.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I. That the agenda of the present meeting is the following:
1. To appoint a chairman of the meeting.
2. To submit, table and approve the audited financial statements of the company for the period 1 January 2013 to 23

December 2013 as set out in Annex 1 hereto.

3. To submit, table, hear and approve the report of the liquidator, Vanessa Molloy, (with professional address at 56,

Charles Martel, L-2134 Luxembourg) on the application of the corporate assets and to submit and table the accounts and
supporting documents of the company as set out in Annex 2 hereto.

12493

L

U X E M B O U R G

4. To table and approve the report of the réviseur d’entreprises agréé à la liquidation, PricewaterhouseCooper, Société

Coopérative, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, as set out in Annex 3 hereto.

5. Grant discharge (quitus) to the company’s directors, Vanessa Molloy, Kavitha Ramachandran and Robert Francis

Kuzloski for the performance of their mandates up to the date of the liquidation of the company on 23 December 2014.

6. To grant discharge (quitus) to the liquidator, Vanessa Molloy, with professional address at 56, Charles Martel, L-2134

Luxembourg, for the performance of all her duties during, and in connection with, the liquidation of the company.

7. To discharge the réviseur d’entreprises agréé à la liquidation, PricewaterhouseCoopers S.à r.l. of 400, route d'Esch,

L-1471 Luxembourg, for the performance of all its duties during, and in connection with the liquidation of the company.

8. To resolve to close the liquidation of the company and to distribute the net result of the liquidation to the sole

shareholder.

9. To resolve on the safekeeping of the company’s books and records and to decide that the company’s documents

and books be kept for five (5) years from the date of publication of the closing of the liquidation in the Mémorial C and
the Recueil des Sociétés et Associations at the registered office address of the Company, 58, rue Charles Martel, L-2134
Luxembourg.

10. To resolve on the cancellation of the shares in the company and the deletion of the company’s share register.
11. Miscellaneous.
II. That the sole shareholder present or represented as well as the shares held by it are shown on an attendance list

set up and certified by the members of the bureau, which, after signature “ne varietur” by the sole shareholder present
or the proxy holder of the sole shareholder represented and the members of the board of the meeting, shall remain
attached to the present deed together with the proxies to be filed at the same time.

III. That it results from that attendance list that all 136,691,733 (one hundred and thirty-six million, six hundred and

ninety-one thousand, seven hundred and thirty-three), i.e. 100% of the share capital of the company, is duly represented
at this meeting.

In conformity with article 67-1 (2) of the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, the meeting is regularly

constituted and the represented sole shareholder consider itself to have been duly informed of the agenda and therefore
waives any convening notice.

All these facts having been explained by the chairman and recognised correct by the members of the meeting, the

meeting proceeds to its agenda.

The meeting having considered the agenda, the chairman submits to the vote of the members of the meeting the

following resolutions which are adopted in each case of unanimous vote.

<i>First resolution

The meeting of the sole shareholder acknowledges that Mr Frank Stolz-Page, aforementioned, has been appointed as

chairman of the present extraordinary general meeting.

<i>Second resolution

The meeting of the sole shareholder submits and tables the audited financial statements of the company for the period

commencing on 1 January 2013 and ending on 23 December 2013 as set out in Annex 1 hereto, which shall remain
attached to the present deed to be filed at the same time.

<i>Third resolution

The meeting of the sole shareholder submits, tables and hears the report of the liquidator, Mrs Vanessa MOLLOY on

the application of the corporate assets and also submits and tables the accounts and supporting documents of the company
as set out in Annex 2 hereto, which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

<i>Fourth resolution

The meeting of the sole shareholder decides to table the report of the réviseur d’entreprise agrée à la liquidation,

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., with registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, on the liquidation, as
set out in Annex 3 hereto, which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

<i>Fifth resolution

The meeting of the sole shareholder decides to approve the audited financial statements of the company for the period

running from 1 January 2013 to 23 December 2013.

<i>Sixth resolution

The meeting of the sole shareholder decides to approve the report of the liquidator and the accounts and supporting

documents of the liquidation.

12494

L

U X E M B O U R G

<i>Seventh resolution

The meeting of the sole shareholder decides to approve the report of the réviseur d’entreprise agréé à la liquidation,

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., aforementioned.

<i>Eighth resolution

The meeting of the sole shareholder decides to grant discharge (quitus) to the directors of the company, Robert

Kuzloski, Vanessa Molloy and Kavitha Ramachandran, for the performance of their mandates up to the date of liquidation
of the company.

<i>Ninth resolution

The meeting of the sole shareholder decides to grant discharge (quitus) to the liquidator of the company, Mrs Vanessa

MOLLOY, for the performance of all her duties during, and in connection with, the liquidation of the company.

<i>Tenth resolution

The meeting of the sole shareholder decides to discharge the réviseur d’entreprise agréé à la liquidation, Pricewate-

rhouseCoopers S.à r.l., for the performance of all its duties during, and in connection with the liquidation of the company.

<i>Eleventh resolution

The meeting of the sole shareholder decides to close the liquidation of Flagstone Capital Management Luxembourg

SICAF-FIS, and to distribute the net result of the liquidation to the sole shareholder.

<i>Twelfth resolution

The meeting of the sole shareholder resolves that the company’s books and records shall be kept for a period of five

(5) years from the date of publication of the closing of the liquidation in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations at the former registered office address of the company at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

<i>Thirteenth resolution

The meeting of the sole shareholder resolves to cancel all the shares in the company and to delete the company’s

share register.

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever which shall be borne by the

company as a result of the present deed is estimated to be approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500).

There being no further business, the meeting is closed at 4.25 p.m..

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the

day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the Bureau, said members of the Bureau signed together with us, the notary, the

present original deed.

Signé: F. Stolz-Page, B. Wahl, C. Oberhag, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher, A.C., le 6 janvier 2015. GAC/2015/138. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015799/123.
(150018512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Hadrian S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 159.389.

Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Hadrian S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015001583/11.
(150001140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

12495

L

U X E M B O U R G

Mivalve S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.

R.C.S. Luxembourg B 160.281.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique tenue le 5 décembre 2014

L'assemblée générale décide de clore la liquidation volontaire de la société et celle-ci cesse donc d'exister à compter

de ce jour.

Les livres et documents de la société seront conservés pour une durée de cinq années au moins au 4, rue Jean-Pierre

Probst L-2352 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014206041/16.
(140231428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Petro Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.270.780,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 142.127.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

A l'issue des résolutions prises par l'Associé Unique de la Société lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue

le 22 décembre 2014 à Luxembourg, il a été résolu ce qui suit:

- de clôturer la liquidation de la Société,
- de conserver les documents légaux et les livres de la Société au siège social de la Société à savoir au 174, route de

Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci pour une période de cinq ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014206217/16.
(140229705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Rigo Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 58.422.

L'an deux mille quinze, le seize janvier.
Par-devant nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Rigo Trading S.A.» (ci-après la «Société»), une société

anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 58422, constituée selon acte notarié en date du 28 février 1997, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 321, le 25 juin 1997. Les statuts ont été modifiés la dernière fois en vertu
d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 3801, le 10 décembre 2014.

L'assemblée s'est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Luis Aguerre Enriquez, Doctor en Derecho,

résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a désigné Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg comme

secrétaire et Monsieur Alexander Olliges, Rechtsanwalt, résidant professionnellement à Luxembourg comme scrutateur
et approuve la constitution du bureau de l'assemblée.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

12496

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1. Modifications des pouvoirs de signature de la Société et modification corrélative de l'article 16 des statuts; et
2. Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires, les mandataires des ac-
tionnaires représentés, les membres du bureau de l'assemblée ainsi que le notaire soussigné, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés,
signées ne varietur, par les parties comparantes et le notaire, resteront attachées au présent acte.

III. Il ressort de la liste de présence susmentionnée que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à

la présent assemblée et les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable et renoncent aux formalités relatives à la convocation.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut en conséquence valablement délibérer sur tous les

points figurant à l'ordre du jour.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires adopte, et

requiert le notaire instrumentant d'acter, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de modifier les pouvoirs de signature de la Société afin que la Société soit engagée à l'égard

des tiers en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique au cas où la Société aura un seul administrateur
et de modifier l'article 16 des statuts en conséquence, qui sera désormais rédigé comme suit:

« Art. 16. La Société est engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances par (i) la signature de l'administrateur

unique ou, si la société a plusieurs administrateurs, par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par (ii) la
signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été
délégué par le conseil d'administration dans les limites d'une telle délégation.»

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 17.00 heures.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, lesdits comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of January.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

the extraordinary general meeting of the shareholders of Rigo Trading S.A. (the “Company”), a société anonyme

existing under Luxembourg law, having its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 58422, incorporated
pursuant to a notarial deed on 28 February 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 321 on 25 June 1997. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the
undersigned notary dated 26 November 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 3801 on 10 December 2014.

The meeting was opened at 4.30 p.m. with Mr. Luis Aguerre Enriquez, Doctor en Derecho, in the chair, professionally

residing in Luxembourg.

The meeting further appointed as secretary Ms. Alina Rymalova, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg

and

as scrutineer Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg and approves the composi-

tion of the board of the meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record the following:

I. The agenda of the present meeting is the following:

<i>Agenda

1. Amendments to the signatory powers of the Company and subsequent amendment of article 16; and
2. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented
shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the

12497

L

U X E M B O U R G

same time with the registration authorities. The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary,
shall remain annexed to this deed.

III. It appears from the above-mentioned attendance list, that the entire share capital of the Company is present or

represented at the meeting and the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got
knowledge of the agenda prior to this meeting and waive any convening formalities.

IV. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders takes, and requires the notary

to record the following resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting resolves to amend the signatory powers of the Company so that the Company may be bound in

all circumstances by the sole signature of the sole director in case the Company has only one director and subsequently
resolves to amend article 16 of the articles of association which shall henceforth be worded:

“ Art. 16. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole

director, or, if the Company has several directors, by the joint signature of any two (2) directors or by (ii) the joint
signatures or the sole signature of any person(s) to whom such power may have been delegated by the board of directors
within the limits of such delegation.”

There being no further business, the meeting was closed at 5.00 p.m.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing parties known to the notary by name, first name and residence, the

said appearing parties signed together with the notary the present deed.

Signé: L. A. ENRIQUEZ, A. RYMALOVA, A. OLLIGES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 janvier 2015. Relation: EAC/2015/1705. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015013809/102.
(150016380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

GPB International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 178.974.

In the year two thousand and fifteen, on the eighth of January,
before Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Marc Loesch,

notary residing in Mondorf-les-Bains, momentarily absent, the latter will remain depositary of the present deed,

was held:

an extraordinary general meeting of shareholders of GPB International S.A., a société anonyme, having its registered

office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number B 178.974, incorporated pursuant to a notarial deed on 10 July 2013, published in the Luxembourg official
gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) on 12 September 2013, number 2239 (the “Company”). The
articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joëlle Baden,
notary residing in Luxembourg, on 10 October 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
on 25 October 2013, number 2665.

The general meeting was opened at 9.30 a.m. with Mr Paul Mousel, licencié en droit, residing professionally in Lu-

xembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Sebastian Jans, licencié en droit, residing professionally in Luxembourg.
The general meeting appointed as scrutineer Mrs Eliane Atzenhoffer, assistante administrative, residing professionally

in Luxembourg.

The board of the general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to

state:

I. That the agenda of the meeting is the following:
1) Increase of the share capital of the Company from its current amount of twenty million euro (EUR 20,000,000.-)

by an amount of ten million euro (EUR 10,000,000.-) up to thirty million euro (EUR 30,000,000.-);

2) Subscription and payment of newly issued shares;
3) Amendment of article 5 of the articles of association of the Company; and
4) Miscellaneous.

12498

L

U X E M B O U R G

II. That the represented sole shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of its

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxy of the represented shareholder, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to

the present deed.

III. That the whole share capital being represented at the present general meeting and all the represented shareholder

declaring that he had had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were
necessary.

IV. That the present general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting then takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the share capital from its current amount of EUR twenty million (EUR

20,000,000.-) by an amount of ten million euro (EUR 10,000,000.-) up to thirty million euro (EUR 30,000,000.-) through
the issue of ten thousand (10,000) new shares of the Company having a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000.-).

<i>Subscription and payment

The newly issued shares of the Company are subscribed by the sole shareholder Gazprombank (Joint-stock Company),

its abbreviated name is Bank GPB (JSC), a legal entity founded and acting uder legislation of the Russian Federation having
its registered address in 16, Bulding 1, Nametkina Str., 117420 Moscow Russia, registration certificate Nr. 354 issued on
November 13, 2001 by the Central Bank of Russian Federation, (main state registration number: 1027700167110, INN
7744001497),

here represented by Paul Mousel, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 25 December 2014.
The proxy, after having been signed ne variateur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

hereto.

The shares in the Company for a total amount of ten million euro (EUR 10,000,000.-), are subscribed as follows:

GPB (JSC), prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,000)
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,000)

The ten thousand (10,000) newly issued shares are fully paid up in cash, so that the amount of ten million euro (EUR

10,000,000.-) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary by a bank certificate.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to amend article 5 of the articles of association as follows:

“ Art. 5. Share capital.
(1) The Company’s share capital is set at thirty million euro (EUR 30,000,000.-) divided into thirty thousand (EUR

30,000) shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000) each.”

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated extraordinary general meeting, are estimated at approximately four thousand seven hundred
euro (EUR 4,700).

There being no further business, the meeting is terminated at 10.00 a.m..

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; upon request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary the

present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am achten Januar.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Danielle Kolbach mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, handelnd in Vertretung

von Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Mondorf-les-Bains, abwesend, welch letzterer Depositar der Urkunde erbleibt,

sind die Aktionäre der GPB International S.A., einer luxemburgischen Aktiengesellschaft (société anonyme), mit dem

Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter

12499

L

U X E M B O U R G

der Nummer B 178.974 und gegründet gemäß einer notariellen Urkunde vom 10. Juli 2013, welche im Amtsblatt (Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations) Nummer 2239 vom 12. September 2013 veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft“),
zur einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten
Mal am 10. Oktober 2013 durch eine notarielle Urkunde von Me Joëlle Baden geändert, Notar wohnhaft in Luxemburg,
veröffentlicht im Amtsblatt vom 25. Oktober 2013, Nummer 2665.

Die Generalversammlung wurde um 9.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herr Paul Mousel, licencié en droit, geschäftan-

sässig in Luxemburg, eröffnet,

welcher Herr Sebastian Jans, licencié en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Schriftführer berufen hat.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Frau Eliane Atzenhoffer, assistante administrative, geschäftsansässig

in Luxemburg.

Sodann die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist, erklärt der Vorsitzende folgendes:
I. Dass die gegenwärtige Generalversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1) Erhöhung des Aktienkapitals von derzeit zwanzig Millionen Euro (EUR 20.000.000,-) um einen Betrag von zehn

Millionen Euro (EUR 10.000.000,-) auf dreißig Millionen Euro (EUR 30.000.000,-);

2) Zeichnung und Zahlung der ausgegebenen Aktien;
3) Abänderung von Art. 5 der Satzung; und
4) Verschiedenes.
II. Dass der vertretene Alleinaktionär, sein Vertreter sowie die Anzahl der Aktien auf einer Liste eingetragen sind.

Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigeführt, um mit derselben einregistriert zu werden, und ord-
nungsgemäß von dem bevollmächtigten Vertreter des Alleinaktionärs sowie vom Versammlungsvorstand unterschrieben.

Die Vollmacht wird nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienenen Parteien der gegenwärtigen Urkunde als

Anlage beigefügt.

III. Dass das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Generalversammlung anwesend oder vertreten ist, dass alle

anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, Kenntnis vom Termin der Generalversammlung und von der Tages-
ordnung gehabt zu haben und dass somit keine Einladungen erforderlich waren.

IV.  Dass  die  gegenwärtige  Generalversammlung  ordnungsgemäß  zusammen  getreten  und  sodann  zu  vorstehender

Tagesordnung beschlussfähig ist.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der Alleinaktionär beschließt das Aktienkapital der Gesellschaft von derzeit zwanzig Millionen Euro (EUR 20.000.000,-)

um einen Betrag von zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-) durch Ausgabe von zehntausend (10.000) neuen Aktien,
mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000) auf dreißig Millionen Euro (EUR 30.000.000,-) zu erhöhen.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die neu ausgegebenen Aktien der Gesellschaft werden durch den Alleinaktionär Gazprombank (Joint-stock Company)

eine juristische Person, deren Abbreviatur Bank GPB (JSC) ist und die nach dem Recht der Russischen Föderation agiert,
mit dem Sitz in 16, Gebäude 1, Nametkina Str. 117420 Moskau, Russland, und mit dem durch die Zentralbank der Rus-
sischen Föderation am 13. November 2001 ausgestelltem Registrierungszertifikat Nummer 354 und der Eintragung in das
Staatsregister für Juristische Personen unter (Nummer 1027700167110, INN 7744001497),

hier vertreten durch Paul Mousel, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht

vom 25. Dezember 2014 gezeichnet.

Die Vollmacht wird nach ne variateur Unterzeichnung durch den Vertreter des Erschienenen und den unterzeichn-

enden Notar der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die neu ausgegebenen Aktien für einen Gesamtbetrag von zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-) werden wie folgt

gezeichnet:

GPB (JSC), vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10.000)
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10.000)

Alle zehntausend (10.000) neu ausgegebenen Aktien wurden vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein

Betrag in Höhe von zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichnenden Notar
nachgewiesen wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleinaktionär beschließt Art. 5 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

„ Art. 5. Aktienkapital.
(1)  Das  gezeichnete  Aktienkapital  beträgt  dreißig  Millionen  Euro  (EUR  30.000.000,-)  eingeteilt  in  dreißigtausend

(30.000) Aktien, mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie.“

12500

L

U X E M B O U R G

<i>Kosten

Die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass

der gegenwärtigen außerordentlichen Generalversammlung entstehen, werden auf ungefähr viertausend siebenhundert
Euro (EUR 4.700) geschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Generalversammlung um 10.00 Uhr für geschlossen erklärt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt, erstellt wird.
Der unterzeichnende Notar versteht und spricht Englisch und bestätigt hiermit dass auf Wunsch der erschienenen

Personen, die vorliegende notarielle Urkunde in Englisch verfasst wurde und eine deutsche Fassung beigefügt ist; auf
Wunsch der erschienenen Personen, hat im Falle eines Widerspruches zwischen der englischen und der deutschen Fas-
sung die englische Fassung Vorrang.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Signé: P. Mousel, S. Jans, E. Atzenhoffer, D. Kolbach.
Enregistré à Grevenmacher, A.C., le 19 janvier 2015. GAC/2015/575. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015831/154.
(150018254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Lux Bauelemente S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 57, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 193.984.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den dreizehnten Tag im Monat Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Herr Frank GUTEKUNST, Schlosser, geboren in Saarbrücken am 7. November 1964, wohnhaft in D-66557 Illingen,

Industriestr. 16, und

2.- Herr Marco Luigi COTELLESSA, Arbeiter, geboren in Luxemburg, am 19. Februar 1971, wohnhaft in L-3651 Kayl,

44, rue Joseph Muller.

Diese Erschienenen ersuchen den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorbenannten Erschienenen errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Be-

zeichnung „Lux Bauelemente S.à r.l.“.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Dudelange.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren und Gütern jeglicher Art mit Ausnahme von Pharma-

zeutika und Waffen.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Vertrieb und die Montage von Fenster, Türen, Tore, Geländer, Treppen,

Sonnenschutz und Schilder sowie Glasreparaturen und Glasaustausch.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft im In- und Ausland jede Art finanzieller, beweglicher und unbeweglicher, kom-

merzieller  und  industrieller  Operationen  tätigen,  welche  sie  zur  Verwirklichung  und  Förderung  ihres  Zweckes  für
notwendig erachtet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhundert

(100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen

und Verlusten der Gesellschaft.

12501

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Le-

benden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindes-

tens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden

von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Ums-

tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung

ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die,
in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum

Buchwert an den Nachfolger auszuzahlen.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den

Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern

ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Vorübergehende Bestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.

<i>Zeichnung der Anteile

Die einhundert (100) Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Frank GUTEKUNST, vorbenannt, einundfünfzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 Anteile

2.- Marco Luigi COTELLESSA, vorbenannt, neunundvierzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 Anteile

TOTAL: EINHUNDERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Anteile

Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen
wurde.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf eintausendeinhundert EURO (EUR 1.100,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-

sammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt:
Herr Frank GUTEKUNST, vorbenannt.

12502

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers.
3.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-3450 Dudelange, 57, rue du Commerce.
Der Notar hat die Erschienenen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Erschienenen ausdrücklich anerkennen.

<i>Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten

Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Frank Gutekunst, Marco Luigi Cotellessa, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 14 janvier 2015. LAC/2015/1086. Reçu 75,- €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole Frising.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 27. Januar 2015.

Référence de publication: 2015015144/102.
(150017978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Sosna s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 3, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 193.924.

STATUTS

L'an deux mil quinze, le douze janvier,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Artur SOSNA, directeur, né à Rosenberg, Pologne, le 25 mars 1974, demeurant à L-8011 Strassen, 237A,

route d'Arlon.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «SOSNA s.à r.l.»

Art. 2. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour

compte de tiers, par voie traditionnelle ou par internet, l'organisation d'événements, ainsi que la vente de formations et
le commerce de toute marchandise non spécialement réglementée.

La société pourra assurer tous mandats d'administrateurs, rémunérés ou non, d'autres sociétés luxembourgeoises ou

étrangères.

D'une façon générale, la société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobi-

lières, financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles
d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (Eur 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent

vingt-cinq Euros (Eur 125,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de

l'actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi
coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales

bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

12503

L

U X E M B O U R G

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les

présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-

vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se

faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant

les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve

légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Frais:

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent
Euros (Eur 1.100,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présente-

ment fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à

l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des
Notaires en date du 16 mai 2001.

<i>Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et

déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du
code pénal luxembourgeois.

<i>Souscription

Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au

notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Artur SOSNA préqualifié.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quinze.

12504

L

U X E M B O U R G

<i>Assemblée générale

Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constitué en Assemblée Générale et a pris à

l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le siège social est fixé à L-1136 Luxembourg, 3, Place d'Armes.
2) La société sera gérée par un gérant unique: Monsieur Artur SOSNA, directeur, né à Rosenberg, Pologne, le 25 mars

1974, demeurant à L-8011 Strassen, 237A, route d'Arlon.

3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être

identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: A. SOSNA, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1432. Reçu soixante-quinze euros.

75,-€

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole Frising.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 26 janvier 2015.

Référence de publication: 2015014655/103.
(150016685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Gammaquest Investment Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 490.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 156.566.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Référence de publication: 2015000278/10.
(140234989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Alter Sana s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 193.925.

STATUTS

L'an deux mil quinze, le sept janvier,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

Ont comparu:

Madame Isabelle MARBEHANT, employée, née à Arlon, Belgique, le 18 septembre 1972, demeurant à B-6860 Leglise,

26, rue de la Distillerie,

Monsieur Philippe MELONI, employé, né à Boussu, Belgique, le 07 novembre 1971, demeurant à L-8217 Mamer, 41,

Op Bierg,

Monsieur Jean Philippe CLAESSENS, employé, né à Liège, Belgique, le 22 avril 1968, demeurant à B-6741 Vance, 15,

rue de la Petite Chauvière,

Monsieur Pascal DUFOUR, employé, né à Soignies, Belgique, le 13 mai 1975, demeurant à B-6720 Habay-la-Neuve, 8,

rue du Crucifix, et

Monsieur François LEYNEN, employé, né à Namur, Belgique, le 22 septembre 1982, demeurant à B-6747 Saint Léger,

12, rue Lackman.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre

eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «ALTER SANA

s.à r.l.»

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Mamer.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

12505

L

U X E M B O U R G

La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour

compte de tiers ou en participation avec ceux-ci toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à:

1. La fabrication, l'importation, l'exportation, la représentation, la commission, le courtage, la consignation, le condi-

tionnement, l'achat et la vente de tous produits chimiques, pharmaceutiques et de beauté, ainsi que dealers sous-produits
succédanés ou dérivés et en général de tous produits ou objets se rapportant directement ou indirectement à l'industrie
et au commerce de la chimie, de la pharmacie et d'articles de beauté.

2. La société pourra acquérir, exploiter et céder des brevets ou licences ayant trait, directement ou indirectement aux

opérations se rapportant à l'objet social. Cette énumération est simplement énumérative et non limitative.

3. Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des services

techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, fournir des conseils, son assistance, agir
en tant qu'intermédiaire, faire du commissionnement et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan
de l'administration, de la vente, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de
la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de service et de management au sens le plus large de ces termes
à toutes personnes physiques ou morales quelconques, exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'ex-
pertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

4. La fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités de la société. Ces services

peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en qualité de conseiller externe ou d'organe.

5. La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur pour compte de sociétés tierces.
6. La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10

août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

7. Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au

détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises
et de tous produits.

La société peut réaliser son objet social en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent

les mieux appropriées. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la
profession.

La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la
réalisation.

Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre

moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à
favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et
services.

Art. 4. Le capital social est fixé à vingt mille Euros (Eur 20.000,-) divisé en huit cents (800) parts sociales sans désignation

de valeur nominale.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de

l'actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi
coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales

bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les

présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-

vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

12506

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se

faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant

les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve

légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Frais:

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille deux
cents Euros (Eur 1.200,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention des comparants qu'avant toute activité commerciale de la société présen-

tement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social.

Les comparants reconnaissent avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives

à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre
des Notaires en date du 16 mai 2001.

<i>Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels de cette opération

et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1
du code pénal luxembourgeois.

<i>Souscription

Les 800 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au

notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites comme suit:

Madame Isabelle MARBEHANT, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 parts sociales
Monsieur Philippe MELONI, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 parts sociales
Monsieur Jean Philippe CLAESSENS, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 parts sociales
Monsieur Pascal DUFOUR, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 parts sociales
Monsieur François LEYNEN, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 parts sociales
TOTAL: huit cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 parts sociales

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quinze.

<i>Assemblée générale

Les fondateurs prénommés, détenant l'intégralité des parts sociales, se sont constitués en Assemblée Générale et ont

pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le siège social est fixé à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
2) La société sera gérée par un gérant, savoir:

12507

L

U X E M B O U R G

Monsieur François LEYNEN, employé, né à Namur, Belgique, le 22 septembre 1982, demeurant à B-6747 Saint Léger,

12, rue Lackman.

3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte, après

s'être identifiés au moyen d'une copie de leurs cartes d'identité.

Signé: I. MARBEHANT, P. MELONI, J.P. CLAESSENS, P. DUFOUR, F. LEYNEN, C. MINES
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/800. Reçu: soixante-quinze Euros (€

75,00)

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour copie conforme,

Capellen, le 27 janvier 2015.

Référence de publication: 2015014046/145.
(150016697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Netzaberg Luxembourg SPS 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 133.450.

Veuillez noter que l'associé Al-Rayyan 2 Luxembourg S.à.r.l ainsi que le gérant unique Cyan S.à.r.l. ont leur son siège

social au 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

<i>Pour Netzaberg Luxembourg SPS 8 S.àr.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014206082/14.
(140230640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Homelooking s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8248 Mamer, 2, Op Paasseleck.

R.C.S. Luxembourg B 193.919.

STATUTS

L'an deux mil quinze, le six janvier,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Madame Evelyne CLAUDE, chargée d'affaires, née à Jarville-la-Malgrange, France, le 03 juin 1960, demeurant à L-8248

Mamer, 2, op Paasseleck.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «HOMELOOKING

s.à r.l.».

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Mamer.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet le commerce de matériel d'équipement de la maison et l'aménagement intérieur spécialisé

dans la salle de bain, incluant la coordination entre les différents corps de métier.

De manière générale, la société pourra passer tous actes et prendre toutes dispositions de nature à faciliter la réali-

sation de son objet social.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (Eur 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent

vingt-cinq Euros (Eur 125,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de

l'actif net en cas de dissolution.

12508

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi
coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales

bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les

présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-

vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se

faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant

les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve

légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Frais:

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent
Euros (Eur 1.100,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention de la comparante qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social.

La comparante reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à

l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des
Notaires en date du 16 mai 2001.

<i>Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, la comparante déclarent être le bénéficiaire réel de cette opération et

déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du
code pénal luxembourgeois.

12509

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription

Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au

notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associée unique Madame Evelyne CLAUDE, préqualifiée.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quinze.

<i>Assemblée générale

La fondatrice prénommée, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constituée en Assemblée Générale et a pris

à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le siège social est fixé à L-8248 Mamer, 2, op Paasseleck.
2) La société sera gérée par une gérante unique: Madame Evelyne CLAUDE, chargée d'affaires, née à Jarville-la-Mal-

grange, France, le 03 juin 1960, demeurant à L-8248 Mamer, 2, op Paasseleck.

3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte, après

s'être identifiée au moyen de sa carte d'identité.

Signé: E. CLAUDE, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg 1 Actes Civils, le 7 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/415. Reçu soixante-quinze euros 75,-

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 26 janvier 2015.

Référence de publication: 2015014332/100.
(150016630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Markcis s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2181 Luxembourg, 6, rue G.C. Marshall.

R.C.S. Luxembourg B 193.922.

STATUTS

L'an deux mil quinze, le six janvier,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Francis MICHAUD, directeur marketing, né à Enghien-les-Bains, France, le 04 août 1951, demeurant à L-2181

Luxembourg, 6, rue G.C. Marshall.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «MARKCIS s.à

r.l.»

Art. 2. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la prestation de services et de conseils marketing et commerciaux aux entreprises,

associations et établissements d'activités économiques ou culturelles de toutes natures.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.
D'une façon générale, la société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobi-

lières, financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles
d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (Eur 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent

vingt-cinq Euros (Eur 125,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de

l'actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois

12510

L

U X E M B O U R G

quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi
coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales

bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les

présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-

vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se

faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant

les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve

légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Frais:

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent
Euros (Eur 1.100,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présente-

ment fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à

l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des
Notaires en date du 16 mai 2001.

<i>Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et

déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du
code pénal luxembourgeois.

12511

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription

Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au

notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Francis MICHAUD préqualifié.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quinze.

<i>Assemblée générale

Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constitué en Assemblée Générale et a pris à

l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le siège social est fixé à L-2181 Luxembourg, 6, rue G.C. Marshall.
2) La société sera gérée par un gérant unique: Monsieur Francis MICHAUD, directeur marketing, né à Enghien-les-

Bains, France, le 04 août 1951, demeurant à L-2181 Luxembourg, 6, rue G.C. Marshall.

3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être

identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: F. MICHAUD, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 7 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/413. Reçu soixante-quinze euros. 75,-

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 26 janvier 2015.

Référence de publication: 2015014458/101.
(150016671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

ProLogis European Finance XIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.588.

ProLogis France XVI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 72.783.

ProLogis France XX S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.057.

ProLogis France XXVI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.276.

ProLogis France XXVII S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.277.

ProLogis France XXXVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.123.

In the year two-thousand and fourteen on the nineteenth day of December.

12512

L

U X E M B O U R G

Before us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(1) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis European Finance XIX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered

office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 141.588 and incorporated by a deed of the undersigned notary dated
September 5 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2420 of October 3

rd

 , 2008, whose articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary of the 10 

th

 day

of December, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 282 of the 31 

st

 day of

January, 2014,

hereinafter referred to as the “Absorbing Company”,
(2) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XVI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 72.783 and incorporated by a notarial deed enacted on 25 

th

 November 1999, published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, number 68 of the 20 

th

 day of January, 2000, and whose articles have not been

amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 1”,
(3) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 78.057 and incorporated by a notarial deed on the 21 

st

 day of September, 2000, published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, number 201 of the 16 

th

 day of March 2001, whose articles of association have not

been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 2”,
(4) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXVI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office

at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 78.276 and incorporated by a notarial deed enacted on the 12 

th

 day of October, 2000 published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 253 of the 9 

th

 day of April, 2001, whose articles of association

have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 3”,
(5) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXVII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office

at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 78.277 and incorporated by a notarial deed enacted on the 12 

th

 day of October 2000, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 254 of the 10 

th

 day of April, 2001, whose articles have not

been amended since then,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 4”,
(6) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXXVIII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office

at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 86.123 and incorporated by a notarial enacted on the 13 

th

 day of February, 2002, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 830 of the 31 

st

 day of May, 2002 whose articles of association

have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 5”, together with the 4 aforementioned Absorbed Companies

referred to as the “Absorbed Companies” and together with the Absorbing Company referred to as the “Merging Com-
panies”.

The appearing parties, represented in the manner hereabove stated, have requested the undersigned notary to record

the following declarations and statements:

12513

L

U X E M B O U R G

that in accordance with the merger proposal in notarial form, following a deed of the undersigned notary on November

th

 , 2014, published in the Mémorial C, number 3428 of the 18 

th

 day of November, 2014, ProLogis European Finance

XIX S.à r.l. (the “Absorbing Company”), and

ProLogis France XVI S.à r.l., (the “Absorbed Company 1”),
ProLogis France XX S.à r.l. (the “Absorbed Company 2”),
ProLogis France XXVI S.à r.l. (the “Absorbed Company 3”),
ProLogis France XXVII S.à r.l. (the “Absorbed Company 4”),
ProLogis France XXXVIII S.à r.l. (the “Absorbed Company 5”),
contemplated to merge under the simplified procedure regime provided for in Section XIV, Sub-Section III, namely

the Articles 278 to 283 of the law of 10 August 1915 on commercial companies;

- that no shareholder of the Absorbing Company and the Absorbed Companies required, during the period of one (1)

month following the publication of the merger proposal in the Mémorial C, an extraordinary general meeting, to be
convened in order to resolve on the approval of the merger;

- in conformity with articles 273 and 274 of the Law of 10 August 1915 and subject to the publication of this deed in

the Mémorial C:

(i) the merger will become effective and entail ipso jure the universal transfer, both as between the merging companies

and towards third parties, of all assets and liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company;

From an accounting perspective, the Merger will not be considered as accomplished with effect as of 1 

st

 January 2014

as stipulated in the Merger Proposal of the 4 

th

 day of November 2014, but with effect as of the 19 

th

 day of December,

2014, the date from which the accounting operations of each of the Absorbed Companies will be assumed for the account
of the Absorbing Company.

(ii) following the merger, the Absorbed Companies cease to exist;
(iii) following the absorption of the Absorbed Companies by the Absorbing Company, the shares of the Absorbed

Companies shall be cancelled and all books, documents and other corporate records of the Absorbed Companies shall
be kept during the legal period (five (5) years) at the registered office of the Absorbing Company, being currently 34-38,
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 279 as amended of the law of August 10 

th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs and expenses

The Absorbing Company shall bear all costs, charges and expenses relating to the present constat de fusion.
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Absorbing Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand eight hundred Euro
(EUR 1,800).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version and that at the request of the appearing persons and in case of divergences between
the two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

(1) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis European Finance XIX S.à r.l., une société à responsabilité

limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.588 et constituée suivant un
acte du notaire instrumentant en date du 5 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2420 du 3 octobre 2008, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant du 10 décembre
2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 282 du 31 janvier 2014,

ci-après désignée la «Société Absorbante»,

12514

L

U X E M B O U R G

(2) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XVI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.783 et constituée suivant acte notarié en
date du 25 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 68 du 20 janvier 2000,

ci-après désignée la «Société Absorbée 1»,
(3) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.057 et constituée suivant un acte notarié
en date du 21 septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 201 du 16 mars 2001,
dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 2»,
(4) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXVI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.276 et constituée suivant un acte notarié
en date du 12 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 253 du 9 avril 2001, et
dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 3»,
(5) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXVII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.277 et constituée suivant un acte notarié
en date du 12 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 254 du 10 avril 2001,
et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis cette date,

ci-après désignée la «Société Absorbée 4»,
(6) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXXVIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée

ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.123 et constituée suivant acte notarié
en date du 13 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 830 du 31 mai 2002, dont
les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 5»,ci-après désignée la «Société Absorbée 5», collectivement avec les 4 Sociétés

Absorbées précitées qualifiées de «Sociétés Absorbées» et collectivement avec la Société Absorbante les «Sociétés Fu-
sionnantes».

Les comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter les décla-

rations et constatations suivantes:

- qu’aux termes d’un projet de fusion établi sous forme notariée, suivant acte du notaire soussigné en date du 4

novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3428 du 18 novembre 2011, ProLogis
European Finance XIX S.à r.l. (la «Société Absorbante») et

ProLogis France XVI S.à r.l. (la «Société Absorbée 1»),
ProLogis France XX S.à r.l. (la «Société Absorbée 2»),
ProLogis France XXVI S.à r.l. (la «Société Absorbée 3»),
ProLogis France XXVII S.à r.l. (la «Société Absorbée 4»),
ProLogis France XXXVIII S.à r.l. (la «Société Absorbée 5»),
ont projeté de fusionner selon la procédure de fusion simplifiée telle que prévue à la Section XIV, Sous-section III,

notamment les Articles 278 à 283 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;

- qu’aucun associé de la Société Absorbante et des Sociétés Absorbées n’a requis, pendant le délai d’un (1) mois suivant

la publication du projet de fusion, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d’une assemblée
générale extraordinaire, afin de décider de l'approbation de la fusion;

12515

L

U X E M B O U R G

- conformément aux articles 273 et 274 de la Loi du 10 août 1915 et sous réserve de la publication de cet acte au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

(i) la fusion deviendra définitive et entraînera de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusion-

nantes qu’à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante;

Pour des besoins comptables, la Fusion ne sera pas considérée réalisé avec effet au 1 

er

 janvier 2014 tel que stipulé

dans  le  projet  de  fusion  du  4  novembre  2014,  mais  avec  effet  au  19  décembre  2014,  date  à  laquelle  les  opérations
comptables de chacune des Sociétés Absorbées seront accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

(ii) que suite à la fusion intervenue, les Sociétés Absorbées cessent d’exister;
(iii) que suite encore à l'absorption des Sociétés Absorbées par la Société Absorbante, les parts sociales des Sociétés

Absorbées seront annulées et tous

(iv) les livres et autres dossiers de ces dernières seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la

Société Absorbante, étant actuellement au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais et dépenses

La Société Absorbante supportera tous les frais, charges et dépenses relatifs au présent accord.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

Absorbante en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille huit cents Euros (EUR 1.800).

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande des mêmes comparantes et
en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. CASSELLS, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 22 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62321. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010085/226.
(150011278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Fairacre Properties (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 110.855.

Par résolutions prises en date du 17 décembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Stuart Howard Russell, avec adresse au 4-7, Manchester Street, Clearwater House,

W1U 3AE Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat;

- Acceptation de la démission de Nicholas Ashley West, avec adresse au 20, Balderton Street, W1K 6LT London,

Royaume-Uni, de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat;

- Reclassification du mandat du gérant de catégorie B, Alan Dundon, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, en gérant de catégorie A, avec effet immédiat

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Référence de publication: 2015000881/17.
(150000230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2015.

12516

L

U X E M B O U R G

ProLogis European Finance XX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.975,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.584.

ProLogis France XII S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 812,500.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 71.107

ProLogis France LV S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 107.330

ProLogis France LXXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 122.455

ProLogis France XLII S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 12,500.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 88.895

ProLogis France CIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 137.201

ProLogis France XCI S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 124.865

ProLogis France C S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 132.491

ProLogis France CI S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 132.490

ProLogis France XXXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 37,500.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 76.433

ProLogis France LXIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 117.019

ProLogis France LXXV S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 121.729

12517

L

U X E M B O U R G

ProLogis France LVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 109.213

ProLogis France LXXVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 122.107

ProLogis France LXXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 121.727

ProLogis France CIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 139.502

(the “Absorbed Companies”)

In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of December.
Before us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(1) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis European Finance XX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered

office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 141.584 and incorporated by a deed of the undersigned notary dated 5

th

 September, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2418 of October 3 

rd

 ,

2008, whose articles of association have been amended pursuant to a notarial deed of the 19 

th

 day of November, 2014,

not published yet,

hereinafter referred to as the “Absorbing Company”,
(2) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 71.107 and incorporated by a notarial deed enacted on 26 

th

 July 1999, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, number 797 of the 26 

th

 day of October, 1999, and whose articles have been amended for

the last time pursuant to a notarial deed of the 15 

th

 day of July, 2003 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations number 897 of September 2 

nd

 , 2003,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 1”,
(3) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LV S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 107.330 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 6 

th

 day of April, 2005, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 832 of the 31 

st

 day of August, 2005, whose articles of

association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 2”,
(4) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LXXX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office

at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 122.455 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on December 6 

th

 , 2006,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 130 of the 7 

th

 day of February 2007, whose

articles of association have not been amended since,

12518

L

U X E M B O U R G

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 3”,
(5) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XLII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 88.895 and incorporated by a notarial deed enacted on the 19 

th

 day of August, 2002, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1534 of the 24 

th

 day of October, 2002, whose articles have been amended

for the last time pursuant to a notarial deed of the 25 

th

 day of September, 2002 published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations number 1673 of November 22 

nd

 , 2002,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 4”,
(6) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France CIV S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 137.201 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 10 

th

 day of March, 2008,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 930 of the 15 

th

 day of April, 2008, whose

articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 5”,
(7) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XCI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 124.865 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 23 

rd

 day of February, 2007,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 826 of the 9 

th

 day of May, 2007, whose articles

of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 6”,
(8) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France C S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 132.491 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 14 

th

 day of September, 2007,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2543 of the 8 

th

 day of November, 2007,

whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 7”,
(9) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France CI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 132.490 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 14 

th

 day of September, 2007,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2548 of the 9 

th

 day of November, 2007,

whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 8”,
(10) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXXIII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office

at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 76.433 and incorporated by a notarial deed enacted on the 13 

th

 day of June, 2000, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 768 of the 19 

th

 day of October, 2000, whose articles have

been amended for the last time pursuant to a notarial deed of the 26 

th

 day of November, 2002 published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations number 52 of the 17 

th

 day of January, 2003,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 9”,
(11) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LXIX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 117.019 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 31 

st

 day of May, 2006, published

12519

L

U X E M B O U R G

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1516 of the 8 

th

 day of August, 2006, whose articles of

association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 10”,
(12) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LXXV S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office

at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 121.729 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 30 

th

 day of October,

2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2441 of the 29 

th

 day of December,

2006, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 11”,
(13) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LVIII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 109.213 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 1 

st

 day of July 2005, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1154 of the 5 

th

 day of November, 2005, whose articles

of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 12”,
(14) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LXXVII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office

at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 122.107 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 17 

th

 day of November,

2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 60 of the 26 

th

 day of January, 2007,

whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 13”,
(15) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LXXIII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office

at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 121.727 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 30 

th

 day of October,

2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2403 of the 27 

th

 day of December,

2006, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 14”,
(16) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France CIX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 139.502 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 5 

th

 day of June, 2008, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1715 of the 11 

th

 day of June, 2008, whose articles of

association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 15”, together with the 14 aforementioned Absorbed Companies

referred to as the “Absorbed Companies” and together with the Absorbing Company referred to as the “Merging Com-
panies”.

The appearing parties, represented in the manner hereabove stated, have requested the undersigned notary to record

the following declarations and statements:

that in accordance with the merger proposal in notarial form, following a deed of the undersigned notary on November

th

 , 2014, published in the Mémorial C, number 3428 of the 18 

th

 day of November, 2014, ProLogis European Finance

XX S.à r.l. (the “Absorbing Company”), and

ProLogis France XII S.à r.l., (the “Absorbed Company 1”),
ProLogis France LV S.à r.l. (the “Absorbed Company 2”),
ProLogis France LXXX S.à r.l. (the “Absorbed Company 3”),
ProLogis France XLII S.à r.l. (the “Absorbed Company 4”),
ProLogis France CIV S.à r.l. (the “Absorbed Company 5”),

12520

L

U X E M B O U R G

ProLogis France XCI S.à r.l. (the “Absorbed Company 6”),
ProLogis France C S.à r.l. (the “Absorbed Company 7”),
ProLogis France CI S.à r.l. (the “Absorbed Company 8”),
ProLogis France XXXIII S.à r.l. (the “Absorbed Company 9”),
ProLogis France LXIX S.à r.l. (the “Absorbed Company 10”),
ProLogis France LXXV S.à r.l. (the “Absorbed Company 11”),
ProLogis France LVIII S.à r.l. (the “Absorbed Company 12”),
ProLogis France LXXVII S.à r.l. (the “Absorbed Company 13”),
ProLogis France LXXIII S.à r.l. (the “Absorbed Company 14”),
ProLogis France CIX S.à r.l. (the “Absorbed Company 15”),
contemplated to merge under the simplified procedure regime provided for in Section XIV, Sub-Section III, namely

the Articles 278 to 283 of the law of 10 August 1915 on commercial companies;

- that no shareholder of the Absorbing Company and the Absorbed Companies required, during the period of one (1)

month following the publication of the merger proposal in the Mémorial C, an extraordinary general meeting, to be
convened in order to resolve on the approval of the merger;

- in conformity with articles 273 and 274 of the Law of 10 August 1915 and subject to the publication of this deed in

the Mémorial C:

(i) the merger will become effective and entail ipso jure the universal transfer, both as between the merging companies

and towards third parties, of all assets and liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company;

From an accounting perspective, the Merger will not be considered as accomplished with effect as of 1 

st

 January 2014

as stipulated in the Merger Proposal of the 4 

th

 day of November 2014, but with effect as of the 19 

th

 day of December,

2014, the date from which the accounting operations of each of the Absorbed Companies will be assumed for the account
of the Absorbing Company.

(ii) following the merger, the Absorbed Companies cease to exist;
(iii) following the absorption of the Absorbed Companies by the Absorbing Company, the shares of the Absorbed

Companies shall be cancelled and all books, documents and other corporate records of the Absorbed Companies shall
be kept during the legal period (five (5) years) at the registered office of the Absorbing Company, being currently 34-38,
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 279 as amended of the law of August 10 

th

 ,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs and expenses

The Absorbing Company shall bear all costs, charges and expenses relating to the present constat de fusion.
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Absorbing Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand eight hundred Euro
(EUR 1,800).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version and that at the request of the appearing persons and in case of divergences between
the two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre.
par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

(1) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis European Finance XX S.à r.l., une société à responsabilité

limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.584 et constituée suivant un
acte du notaire instrumentant en date du 5 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

12521

L

U X E M B O U R G

numéro 2418 du 3 octobre 2008, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 19 novembre 2014, en voie
de publication, ci-après désignée la «Société Absorbante»,

(2) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71.707 et constituée suivant acte notarié en
date du 26 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 797 du 26 octobre 1999, dont
les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 15 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 897 du 2 septembre 2003,

ci-après désignée la «Société Absorbée 1»,
(3) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LV S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.730 et constituée suivant un acte du notaire
instrumentant en date du 6 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 832 du 31
août 2005, dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 2»,
(4) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LXXX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.445 et constituée suivant un acte du notaire
instrumentant en date du 6 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 130 du
7 février 2007, et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 3»,
(5) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XLII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.895 et constituée suivant un acte notarié
en date du 19 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1534 du 24 octobre 2002,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié du 25 septembre 2002, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1673 du 22 novembre 2002,

ci-après désignée la «Société Absorbée 4»,
(6) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France CIV S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.201 et constituée suivant acte du notaire
instrumentant en date du 10 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 930 du 15
avril 2008, dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 5»,
(7) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XCI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.865 et constituée suivant un acte du notaire
instrumentant en date du 23 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 826 du 9
mai 2007, et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 6»,
(8) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France C S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son

siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.491 et constituée suivant un acte du notaire ins-

12522

L

U X E M B O U R G

trumentant en date du 14 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2543 du
8 novembre 2007, et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 7»,
(9) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France CI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.490 et constituée suivant un acte du notaire
instrumentant en date du 14 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2548
du 9 novembre 2007, et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 8»,
(10) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXXIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.433 et constituée suivant un acte notarié
en date du 13 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 768 du 19 octobre 2000, et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié du 26 novembre 2002, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 52 du 17 janvier 2003,

ci-après désignée la «Société Absorbée 9»,
(11) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LXIX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.019 et constituée suivant un acte du notaire
instrumentant en date du 31 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1516 du 8
août 2006, et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 10»
(12) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LXXV S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.729 et constituée suivant un acte du notaire
instrumentant en date du 30 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2441 du
29 décembre 2006, et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 11»
(13) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LVIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.213 et constituée suivant un acte du notaire
instrumentant en date du 1 

er

 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1154 du

5 novembre 2005, et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 12»
(14) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LXXVII S.à r.l., une société à responsabilité limitée

ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.207 et constituée suivant un acte du
notaire instrumentant en date du 17 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
60 du 26 janvier 2007, et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 13»
(15) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LXXIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.727 et constituée suivant un acte du notaire

12523

L

U X E M B O U R G

instrumentant en date du 30 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2403 du
27 décembre 2006, et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 14»
(16) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France CIX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.502 et constituée suivant un acte du notaire
instrumentant en date du 5 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1715 du 11
juin 2008, et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 15», collectivement avec les 14 Sociétés Absorbées précitées qualifiées de

«Sociétés Absorbées» et collectivement avec la Société Absorbante les «Sociétés Fusionnantes».

Les comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter les décla-

rations et constatations suivantes:

- qu’aux termes d’un projet de fusion établi sous forme notariée, suivant acte du notaire soussigné en date du 4

novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3428 du 18 novembre 2011, ProLogis
European Finance XX S.à r.l. (la «Société Absorbante») et

ProLogis France XII S.à r.l. (la «Société Absorbée 1»),
ProLogis France LV S.à r.l. (la «Société Absorbée 2»),
ProLogis France LXXX S.à r.l. (la «Société Absorbée 3»),
ProLogis France XLII S.à r.l. (la «Société Absorbée 4»),
ProLogis France CIV S.à r.l. (la «Société Absorbée 5»),
ProLogis France XCI S.à r.l. (la «Société Absorbée 6»),
ProLogis France C S.à r.l. (la «Société Absorbée 7»),
ProLogis France CI S.à r.l. (la «Société Absorbée 8»),
ProLogis France XXXIII S.à r.l. (la «Société Absorbée 9»),
ProLogis France LXIX S.à r.l. (la «Société Absorbée 10»),
ProLogis France LXXV S.à r.l. (la «Société Absorbée 11»),
ProLogis France LVIII S.à r.l. (la «Société Absorbée 12»),
ProLogis France LXXVII S.à r.l. (la «Société Absorbée 13»),
ProLogis France LXXIII S.à r.l. (la «Société Absorbée 14»),
ProLogis France CIX S.à r.l. (la «Société Absorbée 15»),
ont projeté de fusionner selon la procédure de fusion simplifiée telle que prévue à la Section XIV, Sous-section III,

notamment les Articles 278 à 283 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;

- qu’aucun associé de la Société Absorbante et des Sociétés Absorbées n’a requis, pendant le délai d’un (1) mois suivant

la publication du projet de fusion, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d’une assemblée
générale extraordinaire, afin de décider de l'approbation de la fusion;

- conformément aux articles 273 et 274 de la Loi du 10 août 1915 et sous réserve de la publication de cet acte au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

(i) la fusion deviendra définitive et entraînera de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusion-

nantes qu’à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante;

Pour des besoins comptables, la Fusion ne sera pas considérée réalisé avec effet au 1 

er

 janvier 2014 tel que stipulé

dans  le  projet  de  fusion  du  4  novembre  2014,  mais  avec  effet  au  19  décembre  2014,  date  à  laquelle  les  opérations
comptables de chacune des Sociétés Absorbées seront accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

(ii) que suite à la fusion intervenue, les Sociétés Absorbées cessent d’exister;
(iii) que suite encore à l'absorption des Sociétés Absorbées par la Société Absorbante, les parts sociales des Sociétés

Absorbées seront annulées et tous

(iv) les livres et autres dossiers de ces dernières seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la

Société Absorbante, étant actuellement au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais et dépenses

La Société Absorbante supportera tous les frais, charges et dépenses relatifs au présent accord.

12524

L

U X E M B O U R G

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

Absorbante en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille huit cents Euros (EUR 1.800).

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande des mêmes comparantes et
en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. CASSELLS, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 22 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62320. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 16 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010087/451.
(150011499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

MGI WASHENG Investment S.A., Société Anonyme,

(anc. Cencom Group SA).

Siège social: L-55322163 Luxembourg, 296, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 139.732.

L'an deux mil quinze, le quatorze janvier,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société CENCOM GROUP S.A., avec siège à L-5532 Remich, 6, rue Enz,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 139.732, constituée sous la dénomi-
nation de APOLLO INVEST S.A. aux termes d'un acte reçu par Maître Roger ARRENSDORF, alors notaire de résidence
à Mondorf-les-Bains, en date du 13 juin 2008, publié au Mémorial C numéro 1777 du 18 juillet 2008, et dont les statuts
ont été modifiés aux termes d'une assemblée générale extraordinaire actée par Maître Roger ARRENSDORF, notaire de
résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 16 mars 2011, publiée au Mémorial C numéro 1329 du 18 juin 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alexander CLAESSENS, économiste, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Manon HOFFMANN, employée privée, demeurant à Differdange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique GILSONBARATON, employée privée, demeurant à Gar-

nich.

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des

actionnaires sont renseignés sur une liste de présences, laquelle, après avoir été signée ne varietur, restera annexée aux
présentes.

Monsieur le président constate, et l'assemblée approuve, que toutes les 100 actions émises de la société sont vala-

blement représentées, ainsi qu'il résulte de la liste de présences susmentionnée et que tous les actionnaires présents ou
représentés renoncent à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l'avance l'ordre du jour de la présente
assemblée.

Ceci exposé, Monsieur le Président met au vote les résolutions suivantes qui seront approuvées à l'unanimité:
Dénomination sociale:
La dénomination de la société est modifié en MGI WASHENG Investment SA.
L'article 1 

er

 des statuts est modifié comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les personnes comparantes et toutes celles qui deviendront

propriétaires des actions créées par la suite une société anonyme luxembourgeoise dénommée MGI WASHENG Invest-
ment S.A.»

Siège social:
Le siège de la société est transféré à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
La première phrase de l'article 3 des statuts est modifiée comme suit:
«Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.»

12525

L

U X E M B O U R G

Pouvoirs de signature:
La société est engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.

Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et résidences, tous

ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. CLAESSENS, M. HOFFMANN, V. BARATON, C. MINES
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1439. Reçu soixante-quinze euros.

75,-€

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 26 janvier 2015.

Référence de publication: 2015014151/51.
(150016722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Syntegra Investments III S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 109.690.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-third of December,
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of Syntegra Investments III S.à r.l., a Luxembourg

private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, with a share capital of EUR 12,600, and registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under the number B 109690 (the Company).

The Company was incorporated on 27 July 2005 pursuant to a deed of Maître Bettingen, notary residing in Niederanven,

Grand-Duchy of Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1355 dated
9 December 2005. The articles of association have been amended most recently by a notarial deed of Maître Marc Loesch,
notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 1 

st

 March 2013, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1089 dated 8 May 2013.

THERE APPEARED:

The Limited Partnership Syntegra Capital Fund III L.P., registered under the laws of England, and having its principal

place of business at 17, Hanover Square, London W1S 1HU, United Kingdom, registered under number LP009577, here
represented by its Manager, Syntegra Capital Investors Limited, as delegated by its General Partner, Syntegra Capital III
Ltd., being the sole shareholder of the Company (the “Shareholder”), here represented by Mrs Alexandra Fuentes, private
employee, with professional address in Luxembourg, in virtue of a proxy given under private seal on 22 December 2014
in London.

The said proxy, signed "ne varietur” by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Shareholder, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That all of the one hundred and twenty-six (126) shares having a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each,

representing the entire subscribed share capital of the Company of twelve thousand six hundred Euros (EUR 12,600.-)
are duly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the
agenda;

II. That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
2. Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;

and

4. Discharge (quitus) of the managers of the Company for the performance of their respective mandates.
After deliberation, the following resolutions were taken by the Shareholder:

<i>First resolution

The Shareholder resolves to put the Company into voluntary liquidation as from the date of signature of this deed.

12526

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The  Shareholder  appoints  as  Liquidator  Aztec  Financial  Services  (Luxembourg)  S.A.,  a  Luxembourg  public  limited

liability company (société anonyme) having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, and
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 131.192.

<i>Third resolution

The Shareholder resolve that the Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of

the co-ordinated law on commercial companies of August 10 

th

 , 1915 (the “Law”).

The Liquidator is required to prepare an inventory of all assets and liabilities of the Company.
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.
The Liquidator can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without prior authorisation of the

shareholders’ meeting in the cases where it is required.

The Liquidator will be empowered to distribute the assets in specie and will be empowered to make an interim dividend

to the Company’s shareholders, which interim dividend may be affected by way of endorsement of any promissory note
(s) in the possession of the Company to the Company’s shareholders.

The Liquidator can, under its own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several

proxies parts of its powers which the Liquidator will define and for the terminated duration.

The Shareholder further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance

payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholder of the Company, in accordance with article
148 of the Law.

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolves to grant full discharge to the managers of the Company for the performance of their res-

pective mandates until the date hereof.

Nothing else being on the agenda the meeting was closed.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1.500.- (one thousand five hundred euros).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the said proxy holder signed together

with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé de Syntegra Investments III S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel,
avec un capital social de douze mille six cent euros (EUR 12,600.-) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.690 (la Société). La Société a été constituée le 27 juillet 2005 en vertu
d’un acte de notaire Maître Bettingen, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1355 du 9 décembre 2005. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été
modifiés pour la dernière fois le 1 

er

 mars 2013 par un acte de Maître Marc Loesch, de résidence à Mondorf-les-Bains,

Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1089 du 8 mai 2013.

A COMPARU

1) Syntegra Capital Fund III L.P., une société en commandite, constituée et régie par les lois du Royaume Uni, ayant

son siège social au 17 Hanover Square, Londres W1S 1HU, Royaume Uni et immatriculée sous le numéro LP00957, ici
représentée par son gérant, Syntegra Capital Investors Limited, tel que désigné par son associé commandité gérant,
Syntegra Capital III Ltd., représenté par son mandataire, Madame Alexandra Fuentes, employée privée, avec adresse
professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration signée sous seing privé le 22 décembre 2014 à Londres.

Ladite procuration, après avoir signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et par

le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

12527

L

U X E M B O U R G

L’Associé, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’intégralité des cent vingt-six (126) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune,

représentant l’intégralité du capital social souscrit de la Société d’un montant de douze mille six cent euros (EUR 12,600),
sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent considérée comme dûment constituée et apte
à valablement délibérer sur les points suivants de l’ordre du jour reproduit ci-dessous;

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Nomination du liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;

et

4. Décharge (quitus) accordé aux gérants pour l’exercice de leurs mandats respectifs.
III. L’Associé approuve les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé décide avec effet immédiat de procéder à la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’Associé décide de nommer Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A., une société anonyme, ayant son siège social

au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 131.192, en tant que Liquidateur.

<i>Troisième résolution

L’Associé décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144 et seq.

de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée (la Loi).

L’Associé décide également d’instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin

qu’il réalise l’ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L’Associé décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la

Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’assemblée
générale des associés. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d’autres tâches à
une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L’Associé décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation,

afin qu’il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation
de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L’Associé décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d’effectuer, à sa discrétion, tous verse-

ments d’avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux associés, conformément à l’article 148 de la Loi.

<i>Quatrième résolution

L’Associé décide d’accorder décharge aux gérants de la Société pour l’exercice de leurs mandats respectifs jusqu’à la

date des présentes.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte sont estimés à environ EUR 1.500.- (mille cinq cents euros).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la demande des parties comparantes ci-dessus, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte original.
Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 janvier 2015. 2LAC/2015/76. Reçu douze euros EUR 12,-

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Référence de publication: 2015003399/146.
(150003051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

12528


Document Outline

AC Technologies

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A.

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A.

Alter Sana s.à r.l.

Cencom Group SA

DWS Euro-Bonds (Long)

DWS Euro-Bonds (Medium)

DWS Eurorenta

DWS India

DWS Russia

DWS Türkei

DWS Vermögensmandat

Eurizon Multiasset Fund

Fairacre Properties (Lux) S.à r.l.

Flagstone Capital Management Luxembourg SICAF - FIS

Gammaquest Investment Company S.à r.l.

Generation IM Credit Master Fund, FCP-SIF

GIS High Conviction Equity (USD)

Global Emerging Markets Balance Portfolio

GPB International S.A.

Hadrian S.à r.l.

Homelooking s.à r.l.

ING Luxembourg

Jayefkay Partners S.A.

Lux Bauelemente S.à r.l.

Markcis s.à r.l.

MGI WASHENG Investment S.A.

Mivalve S.A.

MUGC Ashmore Latin America USD Bond Fund

Netzaberg Luxembourg SPS 5 S.à r.l.

Netzaberg Luxembourg SPS 8 S.à r.l.

Parest S.A.

Petro Lux S.à r.l.

ProLogis European Finance XIX S.à r.l.

ProLogis European Finance XX S.à r.l.

ProLogis France XVI S.àr.l.

ProLogis France XX S.à.r.l.

ProLogis France XXVII S.à.r.l.

ProLogis France XXVI S.à.r.l.

ProLogis France XXXVIII S.à r.l.

PVM

PWM Mandat - DWS

Rigo Trading S.A.

SAVOLDELLI &amp; fils s.à r.l.

Schwedeneck Properties S.à r.l.

SCORE Special Opportunities

SCORE Special Opportunities

Serrano S.A.

Siris S.A.

Sosna s.à r.l.

Syntegra Investments III S. à r.l.

UnionProtect: Europa (CHF)