logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 262

2 février 2015

SOMMAIRE

Avoca International Funds (Luxembourg)

SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12560

Babcock & Brown France Retail Portfolio

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12530

Belair Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12530

BlackRock Global Real Estate Opportunity

Fund (Luxembourg) B S.à r.l.  . . . . . . . . . .

12531

BlackRock Global Real Estate Opportunity

Fund (Luxembourg) C S.à r.l.  . . . . . . . . . .

12531

BTG Pactual Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

12530

DIERA S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12574

Dimcar Renting SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12537

Discovery Medical Holdings S.A. . . . . . . . . .

12545

ING Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12560

International Entertainment S.A.  . . . . . . . .

12545

La Financière du Mont de l'Enclume  . . . . .

12530

Luxcarta S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12530

Orogen Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

12537

Patron Ridlerstrasse S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

12550

ProLogis European Finance XVII S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12551

Prospector S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12535

Providance Music S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12535

Q3DI S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12535

Quilvest Strategic Fund SCA SIF  . . . . . . . .

12536

Raso S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12538

Renton Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

12532

Rieste S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12533

Roninvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12531

RPM Lux Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12533

Schmidt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12532

Scholzen Real Estate A.G.  . . . . . . . . . . . . . .

12533

Schreinerei Jodocy AG . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12536

Scripps Media Investments II  . . . . . . . . . . . .

12533

SD & Morgan Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12542

Sealed Air Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

12532

Secogest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12534

Sepat Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12536

Shamrock Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

12535

SHCO 37 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12536

Shine Angel Investments . . . . . . . . . . . . . . . .

12532

Silmar s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12539

SL Investment General Partners Fund

SCA, SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12543

Société Civile Immobilière Maro  . . . . . . . .

12534

Société de Recherche Cosmétique S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12531

Southwark Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

12531

SUPERNAP International S.A.  . . . . . . . . . .

12534

Texhold S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12551

Thor Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12534

Tontec Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12546

Trias Holdco C - T S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

12540

Xena Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

12576

Yoshi Productions S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

12576

12529

L

U X E M B O U R G

Luxcarta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 160.535.

Mme Katia CAMBON a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B de la société Luxcarta S.à r.l., R.C.S.

Luxembourg B 160.535.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Katia CAMBON.

Référence de publication: 2015000402/10.
(140235259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

La Financière du Mont de l'Enclume, Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 54.508.

Les Comptes Annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015000406/10.
(140235078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Belair Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 180.549.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2015.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015001350/11.
(150001147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Babcock &amp; Brown France Retail Portfolio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 137.285.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015001343/11.
(150000735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

BTG Pactual Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 179.455.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Carsten SÖNS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015001374/12.
(150001070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

12530

L

U X E M B O U R G

BlackRock Global Real Estate Opportunity Fund (Luxembourg) B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 130.326.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2015.

Référence de publication: 2015001337/10.
(150001057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

BlackRock Global Real Estate Opportunity Fund (Luxembourg) C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 130.896.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2014.

Référence de publication: 2015001338/10.
(150000951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Société de Recherche Cosmétique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 4, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 168.847.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 5 janvier 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015001850/11.
(150000875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Roninvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8081 Bertrange, 90, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 54.590.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2015001836/11.
(150001009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Southwark Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 117.460.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05/01/2015.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2015001853/12.
(150000418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

12531

L

U X E M B O U R G

Shine Angel Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 172.940.

Les comptes annuels du 19 novembre 2012 au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015001847/10.
(150001160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Schmidt, Société Anonyme.

Siège social: L-9912 Ulflingen, 1B, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 142.892.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Troisvièrges, le 16/12/2014.

Référence de publication: 2015001864/10.
(150001205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Sealed Air Luxembourg S.à r.l., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 89.671.

Les statuts coordonnés au 19/11/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05/01/2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015001844/12.
(150001121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Renton Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 521.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 167.898.

Suite aux résolutions de l'associé unique de la Société en date du 16 décembre 2014, les décisions suivantes ont été

prises:

Démission du gérant de classe B suivant à compter du 31 décembre 2014:
Madame Nathalie Chevalier, née le 2 mars 1977 à Kapellen, Belgique, avec adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Nomination du gérant de classe B suivant à compter du 1 

er

 janvier 2015 pour une durée indéterminée:

Monsieur Erik van Os, né le 20 Février 1973 à Maastricht, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la société est comme suit:
Patrick van Denzen, gérant de classe A
Erik van Os, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Patrick van Denzen
<i>Gérant de classe A

Référence de publication: 2015001825/22.
(150000797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

12532

L

U X E M B O U R G

Scholzen Real Estate A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 17, Op der Haart.

R.C.S. Luxembourg B 172.496.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 5 janvier 2015.

Référence de publication: 2015001865/10.
(150001294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Rieste S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 112.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 157.806.

- Il est pris acte de la démission de Monsieur Laurent VOUIN de son mandat de gérant, suite à la réception de sa lettre

de démission, avec effet au 18 juillet 2014.

Fait à Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Certifié sincère et conforme
RIESTE S.A R.L.

Référence de publication: 2015001827/13.
(150000991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Scripps Media Investments II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 165.800.

Par résolutions prises en date du 22 décembre 2014 l'associé a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Nathalie Dessoy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Manfred Schneider, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Référence de publication: 2015001841/15.
(150000979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

RPM Lux Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 135.777.000,00.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 110.355.

<i>Extrait des résolutions de l'associée unique prises en date du 12 décembre 2014

1. L'associée unique prend acte de et accepte la démission de Monsieur Luc HANSEN de son mandat de gérant de

catégorie A.

2. L'associée unique décide de nommer pour une durée indéterminée, Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme nouveau gérant de catégorie
A.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Référence de publication: 2015001839/16.
(150000802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

12533

L

U X E M B O U R G

Secogest, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7570 Mersch, 29, rue Nic Welter.

R.C.S. Luxembourg B 77.586.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015001871/10.
(150000622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Société Civile Immobilière Maro, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 43, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg E 2.581.

DISSOLUTION

<i>Extrait d'acte du 31.12.2014

Monsieur Manuel Joaquim OLIVEIRA DA ROSA décide de radier la société civile immobilière MARO au 31.12.2014

en raison d'une cessation d'activité.

Manuel Joaquim OLIVEIRA DA ROSA.

Référence de publication: 2015001885/12.
(150000749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

SUPERNAP International S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 2.500.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 181.781.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la Société en date du 13 décembre 2013 que M. Khaled

Bishara, né le 27 juillet 1971 au Caire, Egypte, ayant son adresse professionnelle au 124, El-Nil Street, 12411 Agouza,
Egypte a été nommé délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet au 13 décembre 2013 et pour une durée
indéterminée.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

<i>Pour la Société
Mandataire

Référence de publication: 2015001900/15.
(150000821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Thor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 3.880.000,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 187.918.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 17 décembre 2014

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter les démissions de Stefan Holmér et Szymon Bodjanski de leurs fonctions de gérants de la Société avec

effet au 1 

er

 décembre 2014.

- de nommer Michael Anatolitis, né le 13 octobre 1980 à Lefkosia, Chypre et résidant professionnellement au 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg et Andrea Pabst, née le 6 avril 1974 à Gladbeck, Allemagne et résidant professionnel-
lement au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg aux fonctions de gérants de la Société avec effet au 1 

er

 décembre 2014

et ce pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Référence de publication: 2015001908/17.
(150000760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

12534

L

U X E M B O U R G

Providance Music S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 78.335.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015001819/9.
(150000409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Q3DI S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 165.784.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015001822/9.
(150000727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Shamrock Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 101.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 176.371.

EXTRAIT

La Société prend acte du changement d'adresse de Monsieur Patrick Faherty, Associé et Gérant de classe A de la

Société, au 19, Elmstone road, SW6 5TL Londres, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Référence de publication: 2015001846/13.
(150000982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Prospector S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 41, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 62.219.

EXTRAIT

1. Le siège social de la société a été transféré au L-1840 Luxembourg, 41, boulevard Joseph II
2. Madame Catherine Dessoy a donné sa démission comme administrateur.
L'assemblée générale décide de nommer comme administrateurs pour une nouvelle période de six ans:
- Madame Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 41, boulevard

Joseph II

- Madame Yasmine Birgen-Ollinger, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 41, boulevard

Joseph II

- Monsieur Christoph Ehinger, conseiller économique, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 41, bou-

levard Joseph II

Le mandat du commissaire aux comptes Fidu-Concept a également été reconduit pour une nouvelle période de six

ans.

Ces mandants expireront à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2020.

Luxembourg, le 21 novembre 2014.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015001818/23.
(150000477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

12535

L

U X E M B O U R G

Sepat Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.050,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 121.842.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2014.

Référence de publication: 2015001873/10.
(150000551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Schreinerei Jodocy AG, Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 92.547.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Troisvierges, le 5 janvier 2015.

Référence de publication: 2015001866/10.
(150001289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Quilvest Strategic Fund SCA SIF, Société d'Investissement à capital variable - fonds d'investissement

spécialisé sous la forme d'une société en commandite par actions.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 48, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 158.516.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18 Décembre 2014.

Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises venant à échéance.

<i>Réviseur d'entreprises

Deloitte S.A., société ayant son siège social 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

QUILVEST STRATEGIC FUND SCA SIF

Référence de publication: 2015001821/14.
(150000528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

SHCO 37 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 170.502.

Conformément à l'article 3 (1) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Intertrust (Luxembourg)

S.à r.l. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 29 mai 2013 pour une durée indéterminée
entre les deux sociétés:

<i>- Société domiciliée

* SHCO 37
* Immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170502
* Dont le siège social sis au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg fait l'objet de la présente dénonciation

<i>- Agent domiciliataire:

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l. ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
et ce avec effet au 30 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2015001875/20.
(150000925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

12536

L

U X E M B O U R G

Orogen Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 55.522.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 4 Octobre 2013:

La démission de l'administrateur Thomas D.McKeith, avec adresse au 38, Thornbill Wy, WA 6018 Churchlands, Aus-

tralie a été acceptée avec effet du 30 Septembre 2013;

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014206141/13.
(140229568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Dimcar Renting SC, Société Civile.

Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 5.544.

STATUTS

1. Monsieur FLASSCHOEN Jonathan, né le 19 septembre 1983 à Liège (Belgique), demeurant à B-4130 TILF, 23, Allée

de la Fraineuse;

2. Madame FILIPPOVA Anna, née le 9 septembre 1986 à Moscou (Russie), demeurant à B-4130 TILF, 23, Allée de la

Fraineuse;

Lesquels comparants ont décidé d’acter les statuts d’une Société Civile qu’ils déclarent constituer entre eux comme

suit le 05/01/2015:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une Société Civile régie par la loi de 1915 sur les Sociétés Commerciales et Civiles, telle qu’elle

a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code Civil Luxembourgeois.

Art. 2. La Société a pour objet la détention, l’utilisation et la mise à disposition de biens mobiliers à des fins privées.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indi-
rectement à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La dénomination est: DIMCAR RENTING SC.

Art. 4. Le siège social est établi à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue, il pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l’assemblée générale.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 6. Le capital social est fixé à 100,00 EUR, répartis en 100 parts de 1,00 EUR chacune et constitué par l’apport en

numéraire sur un compte ouvert pour la société.

Art. 7. En raison de leur apport, il est attribué 50 parts à la Société Monsieur FLASSCHOEN Jonathan et 50 parts à

Madame FILIPPOVA Anna, les comparants ci-dessus mentionnés. La mise des associés ne pourra être augmentée que de
leur accord représentant au moins 50% des parts. L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande du gérant ou
des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des

tiers non-associés sans l’accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l’un des associés de ses
parts sociales, les autres associés bénéficieront d’un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et
agréé d’année en année lors de l’assemblée générale statuant le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de
préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation
d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le
capital restant.

Art. 9. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants

n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l’associé
décédé. Toutefois, les héritiers devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu’à régularisation,
désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la Société.

Art. 10. La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l’unanimité de tous les associés.

12537

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Le gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour

compte de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle de son
gérant.

Art. 12. Le bilan est soumis à l’approbation des associés, qui décident de l’emploi des bénéfices. Les bénéfices sont

répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

Art. 13. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du

Code Civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la Société.

Art. 14. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation du

gérant ou sur convocation d’un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le troisième vendredi
de juin de chaque année à 15 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l’année écoulée et pour fixer la valeur des
parts conformément à l’article 6. L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions
sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutes modifications des statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.

Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que

l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution à 100 EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

A l’instant, les parties comparantes représentant l’intégralité du capital social se sont réunies en assemblée générale

extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions
suivantes:

1. Monsieur FLASSCHOEN Jonathan, précité, est nommé gérant,
2. La société EDISYS SA, 65, Route d’Esch L-3340 Huncherange, RCS Luxembourg B139924, est nommée co-gérant
3. Le siège de la Société est établi à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue.
Lu, accepté et signé par les parties intervenantes.
Référence de publication: 2015002985/71.
(150002235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Raso S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7569 Mersch, 14, rue des Soeurs Franciscaines.

R.C.S. Luxembourg B 94.814.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le dix-septième jour du mois de décembre.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

1. Monsieur Raymond Henri SOISSON, commerçant, né à Esch-sur-Alzette, le 7 mai 1943, demeurant à L-7569 Mersch,

14, rue des Soeurs Franciscaines.

I.- Lequel comparant, a requis le notaire soussigné d’acter qu’il est le seul et unique associé de la société «RASO S.à

r.l.», une société à responsabilité limitée avec siège social à L-7569 Mersch, 14, rue des Soeurs Franciscaines, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.814, constituée suivant acte reçu par
Maître Fernand UNSEN, notaire alors de résidence à Diekirch, en date du 6 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 883 du 20 août 2003, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte reçu par Maître Fernand UNSEN, prénommé, en date du 6 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1581 du 27 juillet 2007 (ci-après la "Société").

II.- Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000,-EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent cinquante

euros (150.-EUR) chacune.

III.- La répartition des parts sociales de la Société est actuellement la suivante:

- Monsieur Raymond Henri SOISSON, pré-qualifié, cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

12538

L

U X E M B O U R G

IV.-  Le  comparant,  Monsieur  Raymond  Henri  SOISSON,  pré-qualifié,  en  sa  qualité  d’associé  unique,  représentant

l’intégralité du capital social de la Société, s’est ensuite réuni en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se considère
dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes:

1.- Le comparant, Monsieur Raymond Henri SOISSON, pré-qualifié, a décidé en tant qu’associé unique de la Société,

de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation.

2.-  Le  comparant,  Monsieur  Raymond  Henri  SOISSON,  pré-qualifié,  en  sa  qualité  d’associé  unique  et  bénéficiaire

économique final de l’opération, assume le rôle de liquidateur de la Société.

3.- Le comparant, Monsieur Raymond Henri SOISSON, pré-qualifié, déclare que les activités de la Société ont cessé,

qu’en vertu des comptes établis de la Société au 20 novembre 2014 tout le passif connu de la Société, y compris le passif
lié à la liquidation de la Société, a été payé ou dûment provisionné, que le comparant, représenté comme dit ci-avant,
Monsieur Raymond Henri SOISSON, pré-qualifié, en tant qu’associé unique est investi de tout l’actif et qu'il s'engage
solidairement, indivisiblement et personnellement avec la Société à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement
encore exister à charge de la Société dissoute et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa propre
personne.

Dans  ce  contexte,  le  comparant,  Monsieur  Raymond  Henri  SOISSON,  pré-qualifié,  déclare,  en  particulier,  que  la

Société n’a plus eu d’activités quelconques après le 17 décembre 2014.

4.- L’associé unique, Monsieur Raymond Henri SOISSON, pré-qualifié, accomplira, enregistrera, exécutera ou entre-

prendra toute autre étape requise afin de transférer à lui-même tout l’actif et/ou passif impayé de la Société.

5.- Partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
6.- Décharge pleine et entière est accordée au gérant unique pour l’exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
7.- Les livres comptables et tous autres documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans, à

compter de la date des présentes, à l’ancien siège social de la Société dissoute à L-7569 Mersch, 14, rue des Soeurs
Franciscaines.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l’avoir social de ou remboursement à, l’associé

unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69(2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter
de la publication et sous réserve qu’aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n’aura exigé la
constitution de sûretés.

9.- Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement au montant de mille deux cents
euros (EUR 1.200,-).

DONT ACTE, fait et passé à Diekrich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. H. SOISSON, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 18 décembre 2014. Relation: DIE/2014/16450. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 22 décembre 2014.

Référence de publication: 2014206276/63.
(140230065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Silmar s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 44.647.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 4 décembre 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a nommé Maître Yann Baden, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, liquidateur
de la société Silmar s.à r.l. dont le siège social à L-6601 Wasserbillig, 40-42, Grand-Rue, a été dénoncé en date du 26 avril
2001, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44647, en remplacement
de Maître Anja Holtz, liquidateur nommé suivant jugement de mise en liquidation du 26 avril 2001.

Pour extrait conforme
Me Yann Baden
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014206399/15.
(140230606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

12539

L

U X E M B O U R G

Trias Holdco C - T S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 192.534.

In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of December.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Trias Holdco B - T S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6A route de Trèves, L-2633 Sennin-
gerberg, of which the registration with the Luxembourg register of commerce and companies is pending, the corporate
capital of which is fixed at EUR 12,500,

here represented by Massimiliano della Zonca, private employee, with professional address at 6A Route de Trèves,

L-2633 Senningerberg,

by virtue of a proxy, given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the person appearing and by the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- Trias Holdco B - T S.à r.l., prenamed is the sole current shareholder (the “Sole Shareholder”) of Trias Holdco C -T

S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6A, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, of which
the registration with the Luxembourg register of commerce and companies is pending, the corporate capital of which is
fixed at EUR 12,500 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on December 1 

st

2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

- that the agenda is as follows:
1. - Addition of a new article 25, and subsequently renumbering of the other articles of the Company's articles of

incorporation;

2. - Miscellaneous.
The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution:

The sole shareholder decides to add a new article 25 “U.S. Tax Matters” as follows:

“H. U.S. Tax Matters

Art. 25. U.S. Tax Matters.
25.1 The Company shall operate in a manner that does not adversely affect the ability of NorthStar Realty Finance

Corp. (“NRFC”) and its affiliates (NRFC and each such affiliate, an “NRFC Entity”) to qualify as real estate investment
trusts (“REITs”) under the United Stated federal income tax laws. As such, in order to preserve each NRFC Entity's
qualification as a REIT under the United States Internal Revenue Code of 1986, as amended (the “Code”), the Company
and each of its subsidiaries shall (a) operate in a manner so as to satisfy the gross income and asset tests applicable to
REITs under Code Sections 856(c)(2)- (4) as though each of the Company and its subsidiaries were REITs; (b) notify
NRFC in advance of the Company or any subsidiary entering into any hedging transaction; (c) instruct each subsidiary
and asset manager, as applicable, to provide any information required by NRFC for the purposes of verifying that income
constitutes qualifying “rents from real property” as defined in Code Section 856(d) and United States Treasury Regulations
section 1.856-4, including, without limitation, (i) the annual completion of property questionnaires, and any necessary
updates, cataloging the services provided to tenants and the manner of delivery of any such services at each property
held by a subsidiary and (ii) any other information necessary for the relevant NRFC Entity to comply with the requirements
necessary to qualify as a REIT; (d) to the extent necessary to ensure that rents paid at a property qualify as “rents from
real property” as defined in Code Section 856(d), the Company or any subsidiary shall discontinue or restructure the
provision of any services provided to tenants at such property that Trias Holdings-T (US), LLC (“Trias Holdings”) or
NRFC determines may jeopardize the qualification of any NRFC Entity as a REIT; (e) not take any action or make any
election that would cause any property not to be constitute a qualifying asset producing qualifying income for REIT
purposes; and (f) not engage in any transactions that could reasonably be characterized as a “prohibited transaction”
subject to tax under Code Section 857(b)(6) without Trias Holdings or NRFC's consent.

25.2 The Company and all of its subsidiaries will elect, for United States tax purposes under United States Treasury

Regulations section 301.7701-3, to be classified as either partnerships or disregarded entities; provided, however, that
NRFC may also, at its discretion, make a change to such entity classification election with respect to any subsidiary in

12540

L

U X E M B O U R G

order to elect to treat such subsidiary as a corporation for United States tax purposes for the purposes of electing to
treat such subsidiary as a taxable REIT subsidiary of NRFC under Code section 856(l). NRFC and Trias Holdings are
hereby authorized to make the United States entity classification elections referred to above on IRS Form 8832 with
respect to the Company and each subsidiary, and both of NRFC and Trias Holdings are authorized to sign such form on
behalf of such entities and obtain United States taxpayer identification numbers for such entities in order to facilitate such
elections. If, notwithstanding the authorization provided above, NRFC and Trias Holdings reasonably determine that
other signatures are required to make such elections, the Company will obtain such signatures on IRS Form 8832. In
order to facilitate the making of entity classification election with respect to any entities that will be newly formed in the
future, the Company shall provide notice to Trias Holdings within 30 days after the formation of any future entities.”

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to renumber the other articles of the Company's articles of incorporation.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le neuvième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx notaire, de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

A comparu:

Trias Holdco B -T S.à r.l., une société à responsabilité limitée (société à responsabilité limitée) constituée et existant

en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
dont l'inscription au registre luxembourgeoise du commerce et des sociétés est en cours, dont le capital social est fixé
à EUR 12.500,

ici représentée par Massimiliano della Zonca, employé privé, demeurant professionnellement au 6A, route de Trèves,

L-2633 Senningerberg en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le représentant de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui

suit:

- que Trias Holdco B -T S.à r.l., précitée, est le seul actuel associé (l'«Associé Unique») de Trias Holdco C -T S.à r.l.,

(la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1 

er

 décembre 2014, une société à

responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6A,
Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, dont l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
est en cours, dont le capital social est fixé à EUR 12.500, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations,

- que l'agenda est le suivant:
1. - Ajout d'un nouvel article 25, et par conséquent renumérotation des autres articles des statuts de la Société;
2 - Divers.
La partie comparante a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'associé unique décide d'ajouter un nouvel article 25 “Question en matière de fiscalité américaine” comme suit:

«H - Question en matière de fiscalité américaine

Art. 25. Question en matière de fiscalité américaine.
25.1 La Société doit fonctionner d'une manière qui n'affecte pas la capacité de NorthStar Realty Finance Corp. ("NRFC")

et ses filiales (NRFC et chaque filiale, une «Entité NRFC») à être qualifié de fiducies de placement immobilier («FPI») en
vertu des lois fédérales sur l'impôt sur le revenu des Etats Unis. Dans ce but, afin de préserver la qualification de chaque
Entité NRFC de FPI en vertu du «Internal Revenue Code» des États-Unis de 1986, tel que modifié (le «Code»), la Société
et chacune de ses filiales doivent

(a) fonctionner de manière à satisfaire les critères de revenu et d'actifs bruts applicables aux FPI en vertu de l'article

856 (c) (2) - (4) du Code comme si tant la Société et ses filiales étaient des FPI; (b) aviser NRFC à l'avance si la Société
ou une filiale devaient conclure toute transaction de couverture; (c) charger chaque filiale et gestionnaire d'actifs, le cas
échéant, de fournir toute information requise par NRFC à fin de vérifier que le revenu correspond à des «loyers des
biens immobiliers» tels que définis dans l'article 856 (d) du Code et les articles 1,856 à 4 du règlement du Trésor des
États-Unis, y compris, sans s'y limiter, (i) la réalisation annuelle de questionnaires de propriété, et les mises à jour né-
cessaires, cataloguer les services fournis aux locataires et la manière utilisée pour la remise desdits services à chaque

12541

L

U X E M B O U R G

biens détenus par une filiale et (ii) toute autre information nécessaire pour l'entité NRFC concernée de se conformer
aux exigences nécessaires pour être qualifié de FPI; (d) dans la mesure nécessaire pour s'assurer que les loyers payés soit
considérés comme "loyers des biens immobiliers" tel que définis à l'article 856 (d) du Code, la Société ou une filiale doivent
interrompre ou restructurer la prestation de tous les services fournis aux locataires de propriétés que Trias-T Holdings
(US), LLC ("Trias Holdings») ou NRFC détermineraient comme compromettant la qualification d'une Entité NRFC en
tant que FPI; (e) de ne prendre aucune action ou de ne faire aucun choix qui aurait pour conséquence qu'un bien ne puisse
constituer un actif susceptible de produire un revenu admissible en tant que FPI; et (f) de ne pas s'engager dans toute
transaction qui pourraient raisonnablement être considérées comme une "transaction interdite" assujettie à l'impôt en
vertu de l'article 857 (b) (6) du Code sans le consentement de Trias Holdings ou de NRFC.

25.2 La Société et l'ensemble de ses filiales choisiront, à des fins fiscales et selon la loi américaine en vertu du règlement

du Trésor des États-Unis dans ses articles 301,7701 à 3, être classés comme des partenariats ou des entités ignorées; à
condition, toutefois, que NRFC puisse également, à sa discrétion, apporter une modification à ce choix de classification
de l'entité par rapport à une filiale afin de choisir de traiter ladite filiale comme une société aux fins de l'impôt fédéral
américain et de traiter cette filiale comme une filiale de FPI de NRFC imposable en vertu de l'article 856 (l) du Code.
NRFC et Trias Holdings sont autorisés à faire une classification des entités américaines respectivement au choix visé ci-
dessus sur le formulaire IRS 8832 et ce, à l'égard de la Société et de chaque filiale, et tant NRFC que Trias Holdings sont
autorisés à signer ledit formulaire au nom de ces entités et obtenir des États-Unis les numéros d'identification des con-
tribuables pour ces entités afin de faciliter ce choix. Si, malgré l'autorisation prévue ci-dessus, NRFC et Trias Holdings
raisonnablement déterminent que d'autres signatures sont nécessaires pour rendre effectif un tel choix, la Société ob-
tiendra les signatures sur le formulaire IRS 8832. Afin de faciliter la classification du choix des entités à l'égard de celles
qui seront nouvellement formées à l'avenir, la Société devra fournir un avis à Trias Holdings dans les 30 jours suivant la
formation de toute entité future.»

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de renuméroter les autres articles des statuts de la Société.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparante ci-

avant,  le  présent  acte  est  rédigé  en  langue  anglaise,  suivi  d'une  version  française,  et  qu'à  la  demande  des  mêmes
comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: M. DELLA ZONCA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2014. Relation: LAC/2014/59709. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Référence de publication: 2014206480/149.

(140229541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

SD &amp; Morgan Invest, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 186.577.

<i>Extrait du Conseil de Gérance du 27 novembre 2014

Conformément à l'article 4.2 des statuts de la Société, le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de

la société du 38, Avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg au 11, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, avec
effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2014206373/13.

(140230106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

12542

L

U X E M B O U R G

SL Investment General Partners Fund SCA, SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la

forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 163.833.

DISSOLUTION

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FOURTEEN ON THE NINTH DAY OF DECEMBER.
Before the undersigned, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

SL Investment General Partners S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg,

with its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163.790 (the Sole Shareholder)

here represented by Mrs Laetitia Boeuf, private employee whose professional address is 5, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 2 December 2014.

After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, this

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record that:
- the Sole Shareholder holds all of the shares in SL Investment General Partners Fund SCA, SICAV-SIF, an investment

company with variable capital (société d’investissement à capital variable) organised as a multicompartment specialised
investment fund (fonds d’investissement spécialisé) in the form of a corporate partnership limited by shares (société en
commandite  par  actions-SCA),  having  its  registered  office  at  5,  allée  Scheffer,  L-2520  Luxembourg,  Grand  Duchy  of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163.833 (the
Fund);

- the Fund was incorporated on 23 September 2011, pursuant to a deed drawn up by Maître Martine Schaeffer, a

notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the Mémorial) under number 2864, page 137435 of 23 November 2011. The Fund’s articles of association
(the Articles) have not been amended since its incorporation;

- the Fund’s share capital is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), fully paid, represented by one (1) mana-

gement share and one thousand and five hundred (1,500) ordinary shares in registered form with a par value of one
thousand Euro (EUR 1000.-) per management share and twenty Euro (EUR 20.-) per ordinary share;

- after hearing the report of the board of managers of SL Investment General Partners S.à r.l., as general partner of

the Fund (the General Partner) (the Board) in respect of the Fund’s annual accounts for the financial year ended 31
December 2013 (the Accounts), as well as the liquidation accounts as at 9 December 2014 the Sole Shareholder resolves
to:

(i) approve the Accounts as of 31 December 2013;
(ii) approve the liquidation accounts as of 9 December 2014 (the Liquidation Accounts);
(iii) to confirm the receipt of the audit report as of the date of the liquidation;
- the Sole Shareholder has full and complete knowledge of the Articles and of the Fund’s financial situation;
- the Sole Shareholder, in its capacity as sole shareholder of the Fund, resolves to dissolve the Fund with immediate

effect and to put it into liquidation (liquidation volontaire);

- the Sole Shareholder, declares that:
(i) the activity of the Fund has ceased;
(ii) the liquidation accounts have been prepared and show that all the known liabilities of the Fund have been settled

or fully provided for;

(iii) it will receive all the outstanding assets of the Fund; and
(iv) it will assume all hidden or unknown liabilities (if any);
- the Sole Shareholder resolves to grant full discharge to the General Partner and the approved external auditor

(réviseur  d’entreprises  agréé)  of  the  Fund  for  the  performance  of  their  mandates  from  the  date  of  their  respective
appointments up to the date of the present meeting;

- the Sole Shareholder resolves to confirm that the Fund is hereby liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Shareholder resolves to keep the books, documents and records of the Fund at the offices of CACEIS Bank

Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg for a period of five years after the publication of this deed in the
Mémorial and to pay any and all costs associated with the liquidation;

- the Sole Shareholder resolves to grant power to any employee of CACEIS Bank Luxembourg, acting individually:
(i) to carry-out and perform any formalities necessary to complete and file any outstanding tax returns of the Fund

(including, but not limited to, tax returns relating to financial years 2013 and 2014; and

12543

L

U X E M B O U R G

(ii) to undertake any formalities necessary in connection with filing the Accounts and closing the Fund’s liquidation;
- Miscellaneous.
these powers expiring one year after the closing of the Fund’s liquidation.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at EUR 1,700.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the persons appearing, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

WHEREOF this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date first stated above.
The document having been read to the authorised representative of the Sole Shareholder, known to the notary by

name, family name, civil status and residence, said person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'AN DEUX MILLE QUATORZE, LE NEUVIÈME JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE.
Par-devant Nous, Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

SL Investment General Partners S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social à 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.790 (l’Associé Unique),

ici dûment représentée par Madame Laetitia Boeuf, employée, ayant son adresse professionnelle à 5, Allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 2 décembre 2014.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire agissant au nom de l’Associé Unique et le notaire

instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

L’Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
- l’Associé Unique détient toutes les actions de SL Investment General Partners Fund SCA, SICAV-SIF, une société

d’investissement à capital variable, organisée comme un fonds d’investissement spécialisé à compartiments multiples et
sous la forme d’une société en commandite par actions, ayant son siège social à 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
163.833 (le Fonds);

- le Fonds a été constitué le 23 septembre 2011 suivant un acte dressé par Maître Martine Schaeffer, notaire de

résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le Mémorial), Numéro 2864, page 137435, le 23 novembre 2011. Les statuts du Fonds (les Statuts) n’ont pas été amendés
depuis sa constitution.

- le capital social du Fonds est fixé à trente et un mille euros (EUR 31 000), les actions ont été entièrement libérées.

Le capital social est représenté par une (1) action de commandité et mille cinq cent (1500) actions ordinaires sous la
forme d’actions nominatives et ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1000) par action de commandité et de
vingt euros (EUR 20) par action ordinaire;

- suite à l’audition du rapport du conseil de gérance de SL Investment General Partners S.à r.l., en tant qu’associé

commandité du Fonds (l’Associé Commandité) (le Conseil de Gérance) au sujet de l’approbation des comptes annuels
du  Fonds  pour  l’exercice  se  clôturant  au  31  décembre  2013  (les  Comptes  Annuels)  ainsi  que  pour  les  comptes  de
liquidation au 9 décembre 2014, l’Associé Unique décide de:

(i) approuver les Comptes Annuels arrêtés au 31 décembre 2013;
(ii) approuver les comptes de liquidation au 9 décembre 2014 (les Comptes de Liquidation);
(iii) confirmer la réception du rapport d’audit à la date de la dissolution;
- l’Associé Unique a pleinement connaissance des Statuts et de la situation financière du Fonds;
- l’Associé Unique, en sa qualité d’associé unique du Fonds, décide de dissoudre le Fonds avec effet immédiat et de le

mettre en liquidation volontaire;

- l’Associé Unique déclare que:
(i) l’activité du Fonds a cessé;
(ii) les Comptes de Liquidation ont été préparés et montrent que le passif connu du Fonds a été payé ou provisionné;
(iii) il va recevoir tous les actifs de la Société;
(iv) il s’engage à prendre à sa charge tout passif caché ou inconnu éventuel.
- L’Associé Unique décide d’accorder une décharge pleine et entière à l’Associé Commandité et au réviseur d’entre-

prise agréé du Fonds pour l’exécution de leurs mandats depuis la date de leur nomination jusqu’à la date de la présente
assemblée;

12544

L

U X E M B O U R G

- L’Associé Unique décide de confirmer que partant, la liquidation du Fonds est à considérer comme faite et clôturée;
- L’Associé Unique décide de conserver les documents et pièces relatifs au Fonds dans les bureaux de CACEIS Bank

Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, durant une période de cinq (5) ans à compter de la publication de
cet acte au Mémorial et de payer l’entièreté des frais liés à la dissolution;

- L’Associé Unique décide d’accorder un mandat de représentation individuel à tous les employés de CACEIS Bank

Luxembourg afin de:

(i) faire et exécuter toutes les formalités nécessaires afin de compléter et déposer et enregistrer toute déclaration

fiscale manquante du Fonds (y compris, mais non limité aux déclarations fiscales concernant les exercices 2013 et 2014);
et

(ii) faire tout le nécessaire pour déposer / enregistrer les Comptes Annuels et tout ce qui est requis en relation avec

la clôture de la liquidation du Fonds;

- divers.
Ces pouvoirs expirant un an après la clôture de la liquidation du Fonds.

<i>Frais

Les dépenses, frais et charges de quelque nature que ce soit, incombant au Fonds en raison du présent acte sont

estimés à environ EUR 1.700,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Donc acte, fait et passé date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Le document ayant été lu au mandataire de l’Associé Unique, connu sous le prénom, nom, état civil et domicile, ledit

mandataire a signé conjointement avec le notaire le présent acte.

Signé: L. BOEUF, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 décembre 2014. Relation: LAC/2014/59864. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014206406/143.
(140230113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Discovery Medical Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 146.168.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Référence de publication: 2014209023/10.
(140234425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

International Entertainment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 148.749.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2014209276/11.
(140233785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

12545

L

U X E M B O U R G

Tontec Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 35.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 192.991.

STATUTES

In the year two thousand fourteen. On the tenth day of the month of December.
Before us Me Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

TONTEC INVESTMENT LIMITED, a limited company incorporated under the laws of Hong Kong, having its registered

office at Unit 1211, Telford House, 16 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong,

duly represented by Mr Philippe PONSARD, ingénieur commercial, residing at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to draw up the following

articles of a limited liability company to be incorporated.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is Tontec Europe S. à r. l..

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 35,000 (thirty-five thousand Euro) divided into 350 (three

hundred fifty) corporate units with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial

Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may

only be done in accordance with the law on Commercial Companies.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by at least two managers who need not to be members and who are appointed

by the general meeting of members.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any two managers

or by the individual signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with
the public administration, the company is validly represented by one manager, whose signature legally commits the com-
pany.

12546

L

U X E M B O U R G

Written resolutions approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the board

of managers' meetings.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Collective decisions of members shall be adopted at general meetings.
However, the holding of general meetings shall not be obligatory where the number of members does not exceed 25

(twenty-five). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to
be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on

Commercial Companies.

Art. 15. The business year begins on 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 16. Every year on 31 December, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant

legislation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2015.

<i>Subscription and payment

The 350 (three hundred fifty) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, TONTEC INVEST-

MENT LIMITED, above named.

All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR

35,000 (thirty-five thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on Commercial Companies

have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

EUR 1,150.- (one thousand one hundred fifty euro).

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as mentioned above, representing the whole of the corporate capital, passed

the following resolutions:

<i>First resolution

Are appointed managers of the company, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
1. Mr Philippe PONSARD, ingénieur commercial, born on 16 March 1967 in Arlon, Belgium, residing professionally at

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

2. Mr Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, born on 12 January 1955 in Cesena (Forli), Italy, residing

professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

12547

L

U X E M B O U R G

3. Mr Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, born on 22 April 1959 in Luxembourg, residing professionally

at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.

<i>Second resolution

The company's registered office is located at 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the appearing party, known

to the notary by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mil quatorze. Le dix décembre.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

TONTEC INVESTMENT LIMITED, une limited company soumise au droit de Hong Kong, ayant son siège social à Unit

1211, Telford House, 16 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong,

ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, spécialement mandaté à cet effet par pro-

curation donnée sous seing privé.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

La société prend la dénomination de Tontec Europe S. à r. l..

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 35.000 (trente-cinq mille euros) représenté par 350 (trois cent cinquante) parts

sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que

dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

12548

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par au moins deux gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, ou par

la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul gérant sera toutefois
suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire quand le nombre des associés n'est pas supérieur à 25

(vingt-cinq). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées
et émettra son vote par écrit.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et paiement

Les 350 (trois cent cinquante) parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, TONTEC INVEST-

MENT LIMITED, prénommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

EUR 35.000 (trente-cinq mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été
donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi sur les sociétés commerciales

se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.150,- (mille cent

cinquante euros).

12549

L

U X E M B O U R G

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants de la société avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts:
1. Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, né le 16 mars 1967 à Arlon, Belgique, demeurant profession-

nellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

2. Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Forli), Italie,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

3. Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

Les gérants pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. PONSARD, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 décembre 2014. Relation: LAC/2014/59870. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014206473/232.
(140230045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Patron Ridlerstrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 179.140.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 19 décembre 2014

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Emmanuel Mougeolle de son poste de gérant de la société avec effet au 19

décembre 2014.

- Nomination de M. Steve van den Broek, directeur de sociétés, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, résidant

professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 19 décembre
2014 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- M. Steve van den Broek, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2014206166/20.
(140229574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

12550

L

U X E M B O U R G

Texhold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 26.648.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
TEXHOLD S.A.
Signature

Référence de publication: 2014208637/12.
(140232082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

ProLogis European Finance XVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.497.

and
ProLogis Belgium S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 18,000.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 60.855;
ProLogis France V S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 13,000.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 69.528;
ProLogis France XXI S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 12,500.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 78.121;
ProLogis France XXII S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 12,500.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 78.122;
ProLogis France XXIX S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 50,000.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 80.091;
ProLogis France XXX S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 12,500.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 80.005;
ProLogis France XXXIV S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 12,500.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 83.484;

12551

L

U X E M B O U R G

ProLogis France XXXV S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 12,500.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 83.485;
ProLogis France XXXIX S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 12,500.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 86.812;
ProLogis France XL S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 12,500.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 87.178;
ProLogis France XLI S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 12,500.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 87.179;
ProLogis France LII S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 15,000.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 104.618;
ProLogis France LVII S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 15,000.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 107.332;
ProLogis France CXVI S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 15,000.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 141.591;
ProLogis Spain V S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 675,000.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 78.789;
ProLogis Spain VI S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 585,000.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 78.790;
ProLogis Spain VII S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Subscribed capital: EUR 375,000.-
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 78.791;
In the year two-thousand and fourteen, on the nineteenth day of December.
Before us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

12552

L

U X E M B O U R G

(1) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis European Finance XVII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered

office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 139.497 and incorporated by a deed of the undersigned notary dated
June 5 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1700 of July 10 

th

 , 2008,

whose articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary of November 11 

th

 , 2009,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2546 of December 30 

th

 , 2009,

hereinafter referred to as the “Absorbing Company”,
(2) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis Belgium S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38,

avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 60.855 and incorporated by a notarial deed enacted on September 19 

th

 , 1997, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, number 711 of December 19 

th

 , 1997, and whose articles have been amended for the last

time pursuant to a notarial of September 15 

th

 , 1999 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

number 917 of December 2 

nd

 , 1999,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 1”,
(3) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France V S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 69.528 and incorporated by a notarial deed enacted on April 20 

th

 , 1999, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, number 513 of July 6 

th

 , 1999, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 2”,
(4) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 78.121 and incorporated by a notarial deed on September 29 

th

 , 2000, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, number 213 of March 21 

st

 , 2001, whose articles of association have not been amended

since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 3”,
(5) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 78.122 and incorporated by a notarial deed enacted on September 29 

th

 , 2000, published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, number 215 of March 21 

st

 , 2001, whose articles of association have not been

amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 4”,
(6) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXIX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office

at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 80.091 and incorporated by a notarial deed enacted on December 21 

st

 , 2000, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, number 652 of August 21 

st

 , 2001, whose articles of association have not been

amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 5”,
(7) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 80.005 and incorporated by a notarial deed enacted on December 19 

th

 , 2000, published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, number 632 of August 13 

th

 , 2001, whose articles of association have not been

amended since,

12553

L

U X E M B O U R G

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 6”,
(8) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXXIV S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office

at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 83.484 and incorporated by a notarial deed enacted on August 9 

th

 , 2001, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, number 148 of January 28 

th

 , 2002, whose articles of association have not been

amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 7”,
(9) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXXV S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office

at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 83.485 and incorporated by a notarial deed enacted on August 9 

th

 , 2001, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, number 149 of January 28 

th

 , 2002, whose articles of association have not been

amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 8”,
(10) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXXIX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office

at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 86.812 and incorporated by a notarial deed enacted on March 25 

th

 , 2002, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1002 of July 2 

nd

 , 2002, whose articles of association have not been

amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 9”,
(11) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XL S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 87.178 and incorporated by a notarial deed enacted on April 24 

th

 , 2002, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, number 1079 of July 15 

th

 , 2002, whose articles of association have not been amended

since, hereinafter referred to as the “Absorbed Company 10”,

(12) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XLI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 87.179 and incorporated by a notarial deed enacted on April 24 

th

 , 2002, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, number 1079 of July 15 

th

 , 2002, whose articles of association have not been amended

since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 11”,
(13) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 104.618 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on December 2 

nd

 , 2004, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 188 of March 2 

nd

 , 2005, whose articles of association

have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 12”,
(14) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LVII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 107.332 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on April 6 

th

 , 2005, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 832 of August 31 

st

 , 2005, whose articles of association have

not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 13”,

12554

L

U X E M B O U R G

(15) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France CXVI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office

at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 141.591 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on September 5 

th

 , 2008,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2420 of October 3 

rd

 , 2008, whose articles

of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 14”,
(16) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis Spain V S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38,

avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 78.789 and incorporated by a notarial deed enacted on November 9 

th

 , 2000, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, number 377 of May 22 

nd

 , 2001, whose articles of association have been amended pursuant

to a notarial deed on December 8 

th

 , 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number

587 of July 31 

st

 , 2001,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 15”,
(17) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis Spain VI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38,

avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 78.790 and incorporated by a notarial deed enacted on November 9 

th

 , 2000, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, number 377 of May 22 

nd

 , 2001, whose articles of association have been amended pursuant

to a notarial deed on December 8 

th

 , 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number

588 of July 31 

st

 , 2001,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 16”,
(18) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis Spain VII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 78.791 and incorporated by a notarial deed enacted on November 9 

th

 , 2000, published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, number 377 of May 22 

nd

 , 2001, whose articles of association have been amended

pursuant to a notarial deed on December 8 

th

 , 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

number 587 of July 31 

st

 , 2001,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 17”, together with the 16 aforementioned Absorbed Companies

referred to as the “Absorbed Companies”

and together with the Absorbing Company referred to as the “Merging Companies”,
The appearing parties, represented in the manner hereabove stated, have requested the undersigned notary to record

the following declarations and statements:

- that in accordance with the merger proposal in notarial form, following a deed of the undersigned notary on No-

vember 4 

th

 , 2014, published in the Mémorial C, number 3426 of the 18 

th

 day of November, 2014, ProLogis European

Finance XVII S.à r.l. (the “Absorbing Company”), and

ProLogis France Belgium S.à r.l., (the “Absorbed Company 1”),
ProLogis France V S.à r.l. (the “Absorbed Company 2”),
ProLogis France XXI S.à r.l. (the “Absorbed Company 3”),
ProLogis France XXII S.à r.l. (the “Absorbed Company 4”),
ProLogis France XXIX S.à r.l. (the “Absorbed Company 5”),
ProLogis France XXX S.à r.l. (the “Absorbed Company 6”),
ProLogis France XXXIV S.à r.l. (the “Absorbed Company 7”),
ProLogis France XXXV S.à r.l. (the “Absorbed Company 8”),
ProLogis France XXXIX S.à r.l. (the “Absorbed Company 9”),
ProLogis France XL S.à r.l. (the “Absorbed Company 10”),
ProLogis France XLI S.à r.l. (the “Absorbed Company 11”),
ProLogis France LII S.à r.l. (the “Absorbed Company 12”),
ProLogis France LVII S.à r.l. (the “Absorbed Company 13”),

12555

L

U X E M B O U R G

ProLogis France CXVI S.à r.l. (the “Absorbed Company 14”),
ProLogis Spain V S.à r.l. (the “Absorbed Company 15”),
ProLogis Spain VI S.à r.l. (the “Absorbed Company 16”),
ProLogis Spain VII S.à r.l. (the “Absorbed Company 17”),
contemplated to merge under the simplified procedure regime provided for in Section XIV, Sub-Section III, namely

the Articles 278 to 283 of the law of 10 August 1915 on commercial companies;

- that no shareholder of the Absorbing Company and the Absorbed Companies required, during the period of one (1)

month following the publication of the merger proposal in the Mémorial C, an extraordinary general meeting, to be
convened in order to resolve on the approval of the merger;

- in conformity with articles 273 and 274 of the Law of 10 August 1915 and subject to the publication of this deed in

the Mémorial C:

(i) the merger will become effective and entail ipso jure the universal transfer, both as between the merging companies

and towards third parties, of all assets and liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company;

From an accounting perspective, the Merger will not be considered as accomplished with effect as of 1 

st

 January 2014

as stipulated in the Merger Proposal of the 4 

th

 day of November 2014, but with effect as of the 19 

th

 day of December,

2014, the date from which the accounting operations of each of the Absorbed Companies will be assumed for the account
of the Absorbing Company.

(ii) following the merger, the Absorbed Companies cease to exist;
(iii) following the absorption of the Absorbed Companies by the Absorbing Company, the shares of the Absorbed

Companies shall be cancelled and all books, documents and other corporate records of the Absorbed Companies shall
be kept during the legal period (five (5) years) at the registered office of the Absorbing Company, being currently 34-38,
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 279 as amended of the law of August 10 

th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs and expenses

The Absorbing Company shall bear all costs, charges and expenses relating to the present constat de fusion.
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Absorbing Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand eight hundred Euro
(EUR 1,800).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version and that at the request of the appearing persons and in case of divergences between
the two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre.
par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

(1) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis European Finance XVII S.à r.l., une société à responsabilité

limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.497 et constituée suivant un
acte du notaire instrumentant en date du 5 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
1700 du 10 juillet 2008, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant du 11 novembre 2009,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2546 du 30 décembre 2009,

ci-après désignée la «Société Absorbante»,
(2) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis Belgium S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son

siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.855 et constituée suivant acte notarié en date du 19

12556

L

U X E M B O U R G

septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 711 du 19 décembre 1997, dont
les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 15 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 917 du 2 décembre 1999,

ci-après désignée la «Société Absorbée 1»,
(3) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France V S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son

siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69.528 et constituée suivant un acte notarié en date du
20 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 513 du 6 juillet 1999, dont les statuts
n’ont pas été modifiés jusqu’á ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 2»,
(4) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.121 et constituée suivant un acte notarié
en date du 29 septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 213 du 21 mars 2001,
et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’á ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 3»,
(5) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.122 et constituée suivant un acte notarié
en date du 29 septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 215 du 21 mars 2001,
et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’á ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 4»,
(6) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXIX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.091 et constituée suivant acte notarié en
date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 652 du 20 août 2001,
dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’á ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 5»,
(7) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.005 et constituée suivant un acte notarié
en date du 19 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 632 du 13 août 2001,
et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’á ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 6»,
(8) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXXIV S.à r.l., une société à responsabilité limitée

ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.484 et constituée suivant un acte notarié
en date du 9 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 148 du 28 janvier 2002, et
dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’á ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 7»,
(9) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXXV S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.485 et constituée suivant un acte notarié

12557

L

U X E M B O U R G

en date du 9 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 149 du 28 janvier 2002, et
dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’á ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 8»,
(10) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXXIX S.à r.l., une société à responsabilité limitée

ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.812 et constituée suivant un acte notarié
en date du 25 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1002 du 2 juillet 2002, et
dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’á ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 9»,
(11) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XL S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.178 et constituée suivant un acte notarié
en date du 24 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1079 du 15 juillet 2002, et
dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’á ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 10»,
(12) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XLI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.179 et constituée suivant un acte notarié
en date du 24 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1079 du 15 juillet 2002, et
dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’á ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 11»,
(13) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.618 et constituée suivant un acte du notaire
instrumentant en date du 2 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 188 du
2 mars 2005, et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’á ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 12»,
(14) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LVII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.332 et constituée suivant un acte du notaire
instrumentant en date du 6 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 832 du 31
août 2005, et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’á ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 13»,
(15) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France CXVI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.591 et constituée suivant un acte du notaire
instrumentant en date du 5 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2420
du 3 octobre 2008, et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’á ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 14»,
(16) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis SPAIN V S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son

siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.789 et constituée suivant un acte notarié en date du
9 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 377 du 22 mai 2001, dont les

12558

L

U X E M B O U R G

statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 587 du 31 juillet 2001,

ci-après désignée la «Société Absorbée 15»,
(17) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis SPAIN VI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son

siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.790 et constituée suivant un acte notarié en date du
9 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 377 du 22 mai 2001, dont les
statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 588 du 31 juillet 2001,

ci-après désignée la «Société Absorbée 16»,
(18) ProLogis Directorship S.àr.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis SPAIN VII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.791 et constituée suivant un acte notarié
en date du 9 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 377 du 22 mai 2001,
dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 587 du 31 juillet 2001,

ci-après désignée la «Société Absorbée 17», collectivement avec les 16 Sociétés Absorbées précitées qualifiées de

«Sociétés Absorbées» et collectivement avec la Société Absorbante les «Sociétés Fusionnantes»;

Les comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter les décla-

rations et constatations suivantes:

- qu’aux termes d’un projet de fusion établi sous forme notariée, suivant acte du notaire soussigné en date du 4

novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3426 du 18 novembre 2011, ProLogis
European Finance XVII S.à r.l. (la «Société Absorbante») et

ProLogis Belgium S.à r.l. (la «Société Absorbée 1»),
ProLogis France V S.à r.l. (la «Société Absorbée 2»),
ProLogis France XXI S.à r.l. (la «Société Absorbée 3»),
ProLogis France XXII S.à r.l. (la «Société Absorbée 4»),
ProLogis France XXIX S.à r.l. (la «Société Absorbée 5»),
ProLogis France XXX S.à r.l. (la «Société Absorbée 6»),
ProLogis France XXXIV S.à r.l. (la «Société Absorbée 7»),
ProLogis France XXXV S.à r.l. (la «Société Absorbée 8»),
ProLogis France XXXIX S.à r.l. (la «Société Absorbée 9»),
ProLogis France XL S.à r.l. (la «Société Absorbée 10»),
ProLogis France XLI S.à r.l. (la «Société Absorbée 11»),
ProLogis France LII S.à r.l. (la «Société Absorbée 12”),
ProLogis France LVII S.à r.l. (la «Société Absorbée 13»),
ProLogis France CXVI S.à r.l. (la «Société Absorbée 14»),
ProLogis Spain V S.à r.l. (la «Société Absorbée 15»),
ProLogis Spain VI S.à r.l. (la «Société Absorbée 16»),
ProLogis France VII S.à r.l. (la «Société Absorbée 17»),
ont projeté de fusionner selon la procédure de fusion simplifiée telle que prévue à la Section XIV, Sous-section III,

notamment les Articles 278 à 283 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;

- qu’aucun associé de la Société Absorbante et des Sociétés Absorbées n’a requis, pendant le délai d’un (1) mois suivant

la publication du projet de fusion, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d’une assemblée
générale extraordinaire, afin de décider de l’approbation de la fusion;

- conformément aux articles 273 et 274 de la Loi du 10 août 1915 et sous réserve de la publication de cet acte au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

(i) la fusion deviendra définitive et entraînera de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusion-

nantes qu’à l’égard de tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante;

Pour des besoins comptables, la Fusion ne sera pas considérée réalisé avec effet au 1 

er

 janvier 2014 tel que stipulé

dans  le  projet  de  fusion  du  4  novembre  2014,  mais  avec  effet  au  19  décembre  2014,  date  à  laquelle  les  opérations
comptables de chacune des Sociétés Absorbées seront accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

12559

L

U X E M B O U R G

(ii) que suite à la fusion intervenue, les Sociétés Absorbées cessent d’exister;
(iii) que suite encore à l’absorption des Sociétés Absorbées par la Société Absorbante, les parts sociales des Sociétés

Absorbées seront annulées et tous

(iv) les livres et autres dossiers de ces dernières seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la

Société Absorbante, étant actuellement au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais et dépenses

La Société Absorbante supportera tous les frais, charges et dépenses relatifs au présent accord.
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

Absorbante en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille huit cents Euros (EUR 1.800).

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande des mêmes comparantes et
en cas de divergences entre les deux versions, la version Anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte

Signé: P. CASSELLS, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62322. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010086/511.
(150011638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

ING Funds, Société d'Investissement à Capital Variable,

(anc. Avoca International Funds (Luxembourg) SICAV).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.574.

In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of the month of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of “Avoca International Funds (Luxembourg) SICAV”,

an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) qualifying as an undertaking for
collective investment in transferable securities within the meaning of Part I of the law of 17 December 2010 relating to
undertakings for collective investment, as amended (the "2010 Law"), existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered with the Register
of Trade and Companies of Luxembourg under the number B 127.574 (the "Company"). The Company was incorporated
pursuant to a notarial deed dated 11 May 2007 drawn up by Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1005 of 30 May 2007,
and its articles of incorporation were last amended on 24 June 2011 pursuant to a notarial deed drawn up by Maître Carlo
Wersandt, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2055 of 5 September 2011.

The Meeting was opened at 11.45 p.m. CET. at 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The Meeting elected as Chairman Mrs Louise Chiappalone, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as Secretary Mr Jean-Baptiste Simba, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elected as Scrutineer Mr Silvano Del Rosso, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:
1. the names of the shareholders present at the meeting or represented at the Meeting by proxies (together the

"Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list at the end of these minutes. This
attendance list has been signed ne varietur with the proxy forms by the shareholders represented at the Meeting by
proxies, the notary, the chairman, the scrutineer and the secretary;

12560

L

U X E M B O U R G

2. the attendance list shows that all the shares representing the entire share capital of the Company, are present or

represented at the Meeting so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Shareholders
have been beforehand informed;

3. all the shareholders of the Company being present or represented at the Meeting, and all the shareholders of the

Company having stated that they have been informed of the agenda of the Meeting, the Meeting is held without prior
notice; and

4. the agenda of the Meeting is the following:
1. CHANGE OF Name OF THE COMPANY
Change of name of the Company into "ING Funds" as of November 19 

th

 , 2014 and, as a consequence, amendment

of article 1 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

Art. 1. Denomination. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter

issued, a company in the form of a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable under the
name of ING Funds (hereinafter referred to as the "Company")."

2. AMENDMENTS OF ARTICLES
Amendments of the articles of incorporation of the Company by replacing the references to "the law of 20 December

2002 on undertakings for collective investment" by "the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective
investment", performing the relevant legal updates and discarding the French translation.

3. APPOINTMENT OF NEW DIRECTORS
Appointment of:
- Mr. Dirk Buggenhout in replacement of Mr. Jonathan Sharkey;
- Mr. Johannes Stoter in replacement of Mrs. Martina Corrigan; and
- Mr. Benoit De Belder in replacement of Mr. Michael Gilleran;
as members of the board of directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be

held in 2015.

4. APPROVAL OF ING ASSET MANAGEMENT B.V. AS INVESTMENT MANAGER
Approval of (i) the board of directors' decision to appoint ING Asset Management B.V. as investment manager of the

Company; (ii) the termination of the distribution agreement with Avoca Capital Holdings; (iii) the amendments to the
prospectus of the Company relating to the appointment of such new investment manager and of the new directors; and
(iv) the waiver of the one month period notice before the entry into force of these changes in accordance with CSSF
Circular 14/591.

After deliberation, the following resolutions were taken by the general meeting of the shareholders of the Company:

<i>First resolution

The Meeting RESOLVES to change the name of the Company into "ING Funds" as of November 19 

th

 , 2014 and, as

a consequence, amend article 1 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

Art. 1. Denomination. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter

issued, a company in the form of a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable under the
name of ING Funds (hereinafter referred to as the "Company")."

<i>Second resolution

The Meeting RESOLVES to amend the articles of incorporation of the Company by replacing the references to "the

law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment" by "the law of 17 December 2010 relating to
undertakings for collective investment" and to perform the relevant legal updates, so that to be read as follows:

I. Denomination, Duration, Corporate Object, Registered office

Art. 1. Denomination. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter

issued, a company in the form of a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable under the
name of ING Funds (hereinafter referred to as the “Company”).

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited period of time. The Company may be dissolved by a

resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 3. Corporate object. The sole object of the Company is the collective investment of its assets in transferable

securities or other permitted assets, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the
results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and deve-

lopment of its object in the broadest sense in the frame of Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating
to undertakings for collective investment as amended from time to time.

12561

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Grand Duchy of Luxembourg. Branches

or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the
Company.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by a decision of

the board of directors of the Company.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economical, social or military deve-

lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
rarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall
have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg company.

II. Share capital, Variations of the Share capital, Characteristics of the shares.

Art. 5. Share capital. The share capital of the Company shall be at any time equal to the total net assets of the various

sub-funds of the Company, as defined in Article 11 hereof. The capital of the Company must reach the equivalent amount
of one million two hundred and fifty thousand euro (EUR 1,250,000) within the first six months following its approval by
the regulator, and thereafter may not be less than this amount.

The initial share capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) fully paid-up and represented

by three thousand one hundred (3,100) shares with no par value, as defined in Article 8 hereof.

Art. 6. Variations in share capital. The share capital may be increased or decreased as a result of the issue by the

Company of new fully paid-up shares or the repurchase by the Company of existing shares from its shareholders.

Art. 7. Sub-funds. The board of directors of the Company may, at any time, establish several pools of assets, each

constituting a sub-fund, a compartiment within the meaning of Article 181 of the Luxembourg law dated 17 December
2010 relating to undertakings for collective investment as amended from time to time.

The board of directors shall attribute specific investment objectives and policies and a denomination to each sub-fund.

Art. 8. Classes of shares. The board of directors of the Company may, at any time, issue classes of shares within one

or more sub-funds. These classes of shares may differ in, inter alia, their charging structure, dividend policy or type of
target investors.

Initially, two classes of shares, class A shares and class B shares, shall be issued. Other classes of shares, once created,

shall differ in their characteristics as more fully described in the current version of the prospectus of the Company from
time to time.

Art. 9. Form of the shares. The Company shall issue shares of each sub-fund and each class of shares in uncertificated

registered form.

A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such share register shall set forth the

name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the class of each such
share, the amounts paid for each such share, the transfer of shares and the dates of such transfers. The share register is
conclusive evidence of ownership. The Company treats the registered owner of a share as the absolute and beneficial
owner thereof.

The transfer of a registered share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of

shareholders, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons
holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence of transfer other ins-
truments of transfer satisfactory to the Company.

Any owner of registered shares has to indicate to the Company an address to be maintained in the share register. All

notices and announcements of the Company given to owners of registered shares shall be validly made at such address.
Any shareholder may, at any moment, request in writing amendments to his address as maintained in the share register.
In case no address has been indicated by an owner of registered shares, the Company is entitled to deem that the necessary
address of the shareholder is at the registered office of the Company.

The shares are issued only upon the acceptance of the subscription and the receipt of the subscription price under

the conditions as set out in the current prospectus.

The Company will recognise only one holder in respect of each share in the Company. In the event of joint ownership,

the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person shall
have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company.

Art. 10. Limitation to the ownership of shares. The Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership

of shares in the Company by any person, firm, partnership or corporate body, if in the sole opinion of the Company such
holding may be detrimental to the interests of the existing shareholders or of the Company, if it may result in a breach
of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed
to tax disadvantages, fines or penalties that it would not have otherwise incurred (such persons, firms, partnerships or
corporate bodies shall be determined by the board of directors). In addition, shares may not be offered or sold, directly

12562

L

U X E M B O U R G

or indirectly, in the United States of America or its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction, or to
citizens or residents thereof.

For such purposes, the Company may, at its discretion and without liability:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears that such registration or

transfer would or may eventually result in the beneficial ownership of said share by a person who is precluded from
holding shares in the Company;

b) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares in the Company, either

alone or in conjunction with any other person, is a beneficial owner of shares, compulsorily purchase from any such
shareholder all shares held by such shareholder; or

c) where it appears to the Company that one or more persons are the owners of a proportion of the shares in the

Company which would render the Company subject to tax or other regulations of jurisdictions other than Luxembourg,
compulsorily repurchase all or a proportion of the shares held by such shareholders.

In such cases enumerated at a) to c) (inclusive) hereabove, the following proceedings shall be applicable:
1) The Company shall serve a notice (hereinafter referred to as the “redemption notice”) upon the holders of shares

subject to compulsory repurchase; the redemption notice shall specify the shares to be repurchased as aforesaid, the
redemption proceed (as defined here below) to be paid for such shares and the place at which this price is payable. Any
such notice may be served upon such shareholder by registered mail, addressed to such shareholder at his address as
indicated in the share register. Immediately after the close of business on the date specified in the redemption notice,
such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in the redemption notice and the share register shall
be amended accordingly.

2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be purchased (hereinafter referred to as the

“redemption proceeds”) shall be an amount equal to the net asset value per share of the class and the sub-fund to which
the shares belong, determined in accordance with Article 11 hereof, as at the date of the redemption notice.

3) Subject to all applicable laws and regulations, payment of the redemption proceeds will be made to the owner of

such shares in the currency in which the shares are denominated, and will be deposited by the Company with a bank in
Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such owner upon surrender of the
share certificate, if issued, representing the shares specified in such redemption notice. Upon deposit of such redemption
proceeds as aforesaid, no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further
interest in such shares or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder
appearing as the owner thereof to receive the redemption proceeds so deposited (without interest) from such bank upon
effective surrender of the share certificate, if issued, as aforesaid.

4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article 11 shall not be questioned or invalidated in

any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person at the date of any
redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

The Company may also, at its discretion and without liability, decline to accept the vote of any person who is precluded

from holding shares in the Company at any meeting of shareholders of the Company.

Specifically, the Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any

“US person”, meaning a citizen or resident of the United States of America or of any of its territories or possessions or
areas subject to its jurisdiction. Furthermore, class B shares are reserved to institutional investors only.

III. Net asset value, Issue and repurchase of shares, Suspension of the calculation of the net asset value

Art. 11. Net asset value. The net asset value per share of each class of shares in each sub-fund of the Company shall

be determined at least twice per month by the Company (every such day for determination of the net asset value being
referred to herein as the “valuation day”) on the basis of the last available prices, provided that such valuation day is any
full working day in Luxembourg when the banks are open for business.

The net asset value per share is expressed in the reference currency of each sub-fund and, for each class of shares for

all sub-funds, is determined by dividing the value of the total assets of each sub-fund properly allocable to such class of
shares less the value of the total liabilities of such sub-fund properly allocable to such class of shares by the total number
of shares of such class outstanding on such valuation day.

If after the calculation of the net asset value in Luxembourg, there has been a material change in the quotations on the

markets on which a substantial portion of the investments attributable to a particular sub-fund are dealt or quoted, the
Company may, in order to safeguard the interests of shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry
out a second valuation. All requests for subscription or redemption received to be executed on the first valuation will
be executed on the second valuation.

Upon the creation of a new sub-fund, the total net assets allocated to each class of shares of such sub-fund shall be

determined by multiplying the number of shares of a class issued in the sub-fund by the applicable purchase price per
share. The amount of such total net assets shall be subsequently adjusted when shares of such class are issued or repur-
chased according to the amount received or paid as the case may be.

The valuation of the net asset value per share of the different classes of shares shall be made in the following manner:

12563

L

U X E M B O U R G

The assets of the Company shall be deemed to include:
1) any cash in hand or on deposit including any outstanding interest that has not yet been received and any interest

accrued on these deposits up until the valuation day;

2) all bills and promissory notes payable at sight as well as all accounts receivable (including proceeds from the disposal

of securities for which the price has not yet been paid);

3) all transferable securities, money market instruments, units, shares, debt securities, option or subscription rights

and other investments owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments in
a manner not inconsistent with paragraph a) below with regards to fluctuations in the market value of securities caused
by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);

4) all dividends and distributions receivable by the Company in cash or securities to the extent that the Company is

aware thereof;

5) all outstanding interest that has not yet been received and all interest accrued up until the valuation day on securities

or other interest bearing assets owned by the Company, unless such interest is included in the principal of the securities;

6) the liquidating value of all futures, forward, call or put options contracts the Company has an open position in;
7) all swap contracts entered into by the Company; and
8) any other assets whatsoever, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
a) the value of any cash on hand or on deposit;
b) bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends, interest declared or accrued and

not yet received, all of which are deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid
or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such discount as may be considered appropriate
in such case to reflect the true value thereof;

c) securities and money market instruments listed on a recognised stock exchange or dealt on any other regulated

market that operates regularly, is recognised and is open to the public, will be valued at their latest available prices, or,
in the event that there should be several such markets, on the basis of their latest available prices on the main market
for the relevant security;

d) in the event that the latest available price does not, in the opinion of the board of directors, truly reflect the fair

market value of the relevant securities and money market instruments, the value of such securities will be defined by the
board of directors based on the reasonably foreseeable sales proceeds determined prudently and in good faith;

e) securities and money market instruments not listed or traded on a stock exchange or not dealt on another regulated

market will be valued on the basis of the probable sales proceeds determined prudently and in good faith by the board
of directors;

f) the liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on exchanges or on other regulated markets

shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the board of directors, on a basis
consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward or options contracts
traded on exchanges or on other regulated markets shall be based upon the last available settlement prices of these
contracts on exchanges and regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded
by the Company; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect
to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such
value as the board of directors may deem fair and reasonable. All other securities and other assets will be valued at fair
market value as determined in good faith pursuant to procedures established by the board of directors;

g) the value of swaps shall be determined by applying a recognised and transparent valuation method on a regular basis;

and

h) all other securities and other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to

procedures established by the board of directors.

Any assets held in a particular sub-fund not expressed in the reference currency will be translated into the reference

currency at the rate of exchange prevailing in a recognised market at the time specified in the prospectus of the Company
on the relevant valuation day.

The liabilities of the Company shall be deemed to include:
i) all loans, bills and accounts payable;
ii) all accrued or payable administrative expenses (including the management fees, fees regarding the custodian, ma-

nagement company, listing agent, central administration (including domiciliary, corporate and paying agent functions) and
registrar and transfer agent, and any other third party fees);

iii) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payment of money or

property;

iv) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the relevant valuation day, as determined

from time to time by the board of directors, and other reserves, if any, authorised and approved by the board of directors;
and

12564

L

U X E M B O U R G

v) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares of the

Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable and all
costs incurred by the Company, which shall comprise the fees payable to the board of directors (including all reasonable
out-of-pocket expenses), management company, investment advisors (if any), investment managers, accountants, custo-
dian, listing agent, central administration, registrar and transfer agent, permanent representatives in places of registration,
distributors, if any, trustees, fiduciaries, correspondent banks and any other agent employed by the Company, fees for
legal and auditing services, costs of any proposed listings and of maintaining such listings, promotion, printing, reporting
and publishing expenses (including reasonable marketing and advertising expenses and costs of preparing, translating and
printing in different languages) of prospectuses, addenda, explanatory memoranda, registration statements, annual reports
and semi-annual reports, all taxes levied on the assets and the income of the Company (in particular, the taxe d’abon-
nement and any stamp duties payable), registration fees and other expenses payable to governmental and supervisory
authorities in any relevant jurisdictions, insurance costs, costs of extraordinary measures carried out in the interests of
shareholders (in particular, but not limited to, arranging expert opinions and dealing with legal proceedings) and all other
operating expenses, including the cost of buying and selling assets, customary transaction fees and charges charged by
custodian banks or their agents (including free payments and receipts and any reasonable out-of-pocket expenses, i.e.
stamp taxes, registration costs, scrip fees, special transportation costs, etc.), customary brokerage fees and commissions
charged by banks and brokers for securities transactions and similar transactions, interest and postage, telephone, facsimile
and telex charges. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an
estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such
period.

The net assets of the Company are at any time equal to the total of the net assets of the sub-funds.
As between the shareholders, each sub-fund shall be treated as a separate legal entity.
Vis-à-vis third parties, the Company shall constitute one single legal entity. However, each sub-fund is regarded as

being separate from the others and is liable for all of its own obligations. The assets, commitments, charges and expenses
which cannot be allocated to one specific sub-fund will be charged to the different sub-funds proportionally to their
respective net assets.

All shares in the process of being redeemed by the Company shall be deemed to be issued until the close of business

on the valuation day applicable to the redemption. The redemption price is a liability of the Company from the close of
business on this date until paid.

All shares issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be deemed issued from

the close of business on the valuation day applicable to the subscription. The subscription price is an amount owed to
the Company from the close of business on such day until paid.

As far as possible, all investments and divestments chosen and in relation to which action is taken by the Company up

to the valuation day shall be taken into consideration in the valuation.

Art. 12. Issue, redemption and conversion of shares. The board of directors is authorised to issue further fully paid-

up shares of each class and of each sub-fund at any time at a price based on the net asset value per share for each class
of shares and for each sub-fund determined in accordance with Article 11 hereof, as of such valuation day as is determined
in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine. Such price may be increased
by applicable front-end charges, if any, as approved from time to time by the board of directors.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly

authorised person, the duty of accepting subscriptions and of receiving payment for such new shares.

The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with

the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from an auditor
(réviseur d'entreprises agréé) and in compliance with the investment policy of the concerned sub-fund.

All new share subscriptions shall be entirely paid in, and the shares issued carry the same rights as those shares in

existence on the date of the issuance. Payment for shares must be received by the custodian in accordance with the
procedure, and within the delay determined by the board of directors, as described in the prospectus of the Company.

If the directors determine that it would be detrimental to the existing shareholders of the Company to accept a

subscription for shares of any sub-fund that represents more than 10% of the net assets of such sub-fund, then they may
postpone the acceptance of such subscription and, in consultation with the incoming shareholder, may require him to
stagger his proposed subscription over an agreed period of time.

The Company may reject any subscription in whole or in part, and the directors may, at any time and from time to

time and in their absolute discretion without liability and without notice, discontinue the issue and sale of shares of any
class in any one or more sub-funds.

Any  shareholder  may  request  the  redemption  of  all  or  part  of  his  shares  by  the  Company  under  the  terms  and

conditions set forth by the board of directors in the prospectus and within the limits as provided in this Article 12. The
redemption proceed per share shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not
exceed 3 business days from the relevant valuation day, as it is determined in accordance with such policy as the board
of directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and the transfer documents

12565

L

U X E M B O U R G

have been received by the Company. The redemption price shall be equal to the net asset value per share relative to the
class and to the sub-fund to which it belongs, determined in accordance with the provisions of Article 11 hereof, decreased
by charges and commissions, if any, at the rate provided in the prospectus. Any such request for redemption must be
filed by such shareholder in written form at the registered office of the Company in Luxembourg or with any other legal
entity appointed by the Company for the redemption of shares. The request shall be accompanied by the certificate(s)
for such shares, if issued. The relevant redemption price may be rounded down to the nearest eurocent (0.01).

The Company shall ensure that at all times each sub-fund has enough liquidity to enable satisfaction of any requests

for redemption of shares.

If as a result of any request for redemption, the aggregate net asset value of the shares held by a shareholder in any

class of shares would fall below such value as determined by the board of directors and described in the prospectus of
the Company, then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance
of such shareholder’s holding of shares in such class.

Further, if at any given date redemption requests pursuant to this Article 12 and conversion requests exceed 10% of

the net assets of any one sub-fund, such requests may be subject to additional procedures as set forth in the prospectus.
On the next valuation day following that period, these redemption and conversion requests will be met in priority to
later requests.

The Company will have the right, if the board of directors so determines and with the consent of the shareholder

concerned, to satisfy payment of the redemption price to any shareholder in kind by allocating to such shareholder
investments from the pool of assets set up in connection with such classes of shares equal in value (calculated in a manner
as described in Article 11 hereof) as of the valuation day on which the redemption price is calculated to the value of
shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and
reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders of the relevant class of shares, and the
valuation used may be confirmed by a special report of the auditor. The cost of such transfer shall be borne by the
transferee.

Shares redeemed by the Company shall be cancelled in the books of the Company.
Any shareholder is entitled within a given class to request the conversion of all or part of his shares, provided that the

board of directors may:

a) set terms and conditions as to the right for and frequency of conversion of shares between sub-funds; and
b) subject conversions to the payment of such charges and commissions as it shall determine.
If as a result of any request for conversion, the aggregate net asset value of the shares held by a shareholder in any

class of shares would fall below such value as determined by the board of directors and described in the prospectus of
the Company, then the Company may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance
of such shareholder’s holding of shares in such class.

Such a conversion shall be effected on the basis of the net asset value of the relevant shares of the different sub-funds,

determined in accordance with the provisions of Article 11 hereof. The relevant number of shares may be rounded down
to the nearest eurocent (0.01).

The shares which have been converted into another sub-fund will be cancelled.
The requests for subscription, redemption and conversion shall be received at the location designated to and for this

effect by the board of directors.

Art. 13. Suspension of the calculation of the net asset value and of the issue, the redemption and the conversion of

shares. The Company may suspend the determination of the net asset value per share of one or more sub-funds and the
issue, redemption or conversion of any classes of shares in the following circumstances:

a) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which a substantial portion of the

investments of the Company attributable to the relevant sub-fund from time to time is quoted or dealt in or when one
ore more foreign exchange markets in the currency in which a substantial portion of the assets of the sub-fund is deno-
minated are closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended,
provided that such restriction or suspension affects the valuation of the investments of the Company attributable to the
sub-fund quoted thereon;

b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Company as a result

of which disposal or valuation of assets owned by the Company attributable to the relevant sub-fund would be imprac-
ticable;

c) during any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price

or value of any of the investments of the relevant sub-fund or the current price or value on any stock exchange or other
market in respect of the assets attributable to the sub-fund;

d) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the

redemption of shares of the relevant sub-fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acqui-
sition of investments or payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the board of directors, be
effected at normal rates of exchange;

12566

L

U X E M B O U R G

e) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to the relevant sub-

fund cannot promptly or accurately be ascertained;

f) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of winding-up the

Company or a sub-fund;

g) during any period when the Net Asset Value per Share of one or more undertakings for collective investment in

which any Fund has invested and the assets of which represent a significant part of the proportion of assets of such Fund,
can not be calculated with accuracy and can not reflect the true market value of the Net Asset Value of the undertaking
(s) for collective investment during a Valuation Day; or

h) any other situation provided for in the Luxembourg law dated 17 December 2010 relating to undertakings for

collective investment as amended from time to time.

The suspension of the determination of the net asset value per share of a sub-fund shall have no effect on the deter-

mination of the net asset value per share or on the issue, redemption and conversion of shares of any other sub-fund
that is not suspended.

Any request for subscription, redemption or conversion shall be irrevocable except in the event of a suspension of

the determination of the net asset value per share.

Notice of the beginning and of the end of any period of suspension will be published in a Luxembourg daily newspaper

and in any other newspaper(s) selected by the board of directors, as well as in the official publications specified for the
respective countries in which Company shares are sold. The Luxembourg regulatory authority, and the relevant autho-
rities of any Member States in which shares of the Company are marketed, will be informed of any such suspension.
Notice will likewise be given to any subscriber or shareholder, as the case may be, applying for subscription or redemption
of shares in the relevant sub-fund.

Under exceptional circumstances, which may adversely affect the rights of shareholders, the board of directors re-

serves  the  right  to  conduct  the  necessary  sales  of  transferable  securities  before  setting  the  share  price  at  which
shareholders can apply to have their shares redeemed or converted. In this case, subscriptions, redemptions and con-
version applications in process shall be dealt with on the basis of the net asset value thus calculated after the necessary
sales.

Suspended subscription, redemption and conversion applications may be withdrawn by written notice provided that

the Company receives such notice before the suspension ends.

Suspended  subscriptions,  redemptions  and  conversions  shall  be  executed  on  the  first  valuation  day  following  the

resumption of net asset value calculation by the Company.

IV. General shareholders’ meetings

Art. 14. General provisions. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent

the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts
relating to the operations of the Company.

Art. 15. Annual general shareholders’ meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance

with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may
be specified in the notice of the meeting, on the second Friday in August at 11:00 a.m.. If such day is a bank holiday, then
the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held
abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders of classes of shares. The shareholders of the class of shares issued in respect

of any sub-fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such class
of shares in such sub-fund. In addition, the shareholders of any class of shares may hold, at any time, general meetings to
decide on any matters which relate exclusively to such class of shares. The general provisions set out in these articles of
incorporation, as well as in the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended from time
to time, shall apply to such meetings.

Art. 17. Functioning of shareholders’ meetings. The quorum and time required by law shall govern the notice for and

conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share, regardless of the class and of the sub-fund to which it belongs, is entitled to one vote, subject to the

limitations imposed by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission. Fractions of shares are not entitled to a vote.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

12567

L

U X E M B O U R G

Further, the shareholders of each class and of each sub-fund will deliberate and vote separately (subject to the con-

ditions of quorum and majority voting as provided by law) on the following items:

1. apportionment of the net profits of their sub-fund and class; and
2. resolutions affecting the rights of the shareholders of one class or of one sub-fund vis-à-vis of the other classes and/

or sub-funds.

Art. 18. Notice to the general shareholders' meetings. Shareholders shall meet upon call by the board of directors.

To the extent required by law, the notice shall be published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations of
Luxembourg, in a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the board of directors may decide.

V. Management of the company

Art. 19. Management. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members

who need not to be shareholders of the Company. However, if the Company is incorporated by a sole shareholder or
if it is noted at a general meeting of shareholders that the Company only has a sole shareholder, the composition of the
board of directors may be limited to two members until the ordinary general meeting of shareholders following the
observation of the existence of more than one shareholder.

Art. 20. Duration of the functions of the directors, renewal of the board of directors. The directors shall be elected

by the general shareholders' meeting for a period not exceeding six years and until their successors are elected and
qualified, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by
resolution adopted by the shareholders.

In case a legal person is appointed as director, such person shall appoint a permanent representative to carry out this

function in the name and on behalf of the legal person. The representative is subject to the same conditions and endorses
the same civil liability as those he would be subject to in carrying out this function in his own name and on his own behalf,
without prejudice to the joint liability of the legal person he represents. The legal person may remove its representative
only by simultaneously appointing a successor.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy on a provisional basis until the next general
meeting of shareholders.

Art. 21. Committee of the board of directors. The board of directors shall choose from among its members a chairman,

and may chose from among its members one or more vice-chairmen. It may also chose a secretary, who need not be a
director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the share-
holders.

Art. 22. Meetings and deliberations of the board of directors. The board of directors shall meet upon call by the

chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting, provided the place of meeting will be
outside of the United Kingdom.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another director by a majority vote to preside at such meetings. For
general meetings of shareholders and in the case no director is present, any other person may be appointed as chairman.

The board of directors from time to time may appoint officers of the Company, including a general manager, any

assistant managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the
Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors. Officers need not be directors
or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein, shall have the powers and
duties given to them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least three days in advance

of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram,
telex or facsimile transmission of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meetings of the board of directors by appointing, in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile transmission, another director as his proxy. One director may replace several other directors.

Any director who is not physically present at the location of a meeting may participate in such a meeting of the board

of directors by conference call or similar means of communication equipment, whereby all persons participating in the
meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting, provided that the conference call or similar means of communication will originate from outside of the United
Kingdom.

Directors may not bind the Company by their individual signature, except as specifically permitted by resolution of

the board of directors.

12568

L

U X E M B O U R G

The board of directors can deliberate or act validly only if at least fifty per cent of the directors are present or

represented at a meeting of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. The chairman shall have the casting vote.

Resolutions signed by all members of the board of directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letters, cables, telegrams, telexes, facsimile transmission and similar means. The date of such a
resolution shall be the date of the last signature.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its

powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to natural persons or corporate entities
which need not be members of the board.

Art. 23. Minutes. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman, or in his

absence, by the chairman pro-tempore who presides at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

such chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 24. Engagement of the Company vis-à-vis third persons. The Company shall be engaged by the signature of two

members of the board of directors or by the individual signature of any duly authorised director or officer of the Company
or by the individual signature of any other person to whom authority has been delegated by the board of directors from
time to time.

Art. 25. Powers of the board of directors. The board of directors determines the general orientation of the manage-

ment and of the investment policy, as well as the guidelines to be followed in the management of the Company, always
in application of the principle of risk diversification.

Art. 26. Interest. No contract or other transaction which the Company and any other corporation or firm might enter

into shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company are
interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
corporation or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

The term “personal interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any position, relationship with or

interest in any matter, position or transaction involving the Company, their subsidiaries and associated companies or such
other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.

Art. 27. Indemnification of the directors. The Company shall indemnify any director or officer, and his heirs, executors

and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request,
of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.

Art. 28. Allowances to the board of directors. The general meeting of shareholders may allow the members of the

board of directors, as remuneration for services rendered, a fixed annual sum, as directors’ remuneration, such amount
being carried as general expenses of the Company and which shall be divided at the discretion of the board of directors
among themselves.

Furthermore, the members of the board of directors may be reimbursed for any expenses incurred on behalf of the

Company insofar as they are reasonable.

The remuneration of the chairman or the secretary of the board of directors as well as those of the general manager

(s) and officers shall be fixed by the board.

Art. 29. Management Company, Advisor, investment managers, custodian and other contractual parties. The Company

shall enter into a fund management agreement with a management company established in the Grand Duchy of Luxem-
bourg (the “Management Company”) and duly approved pursuant to the Chapter 15 of the Luxembourg law dated 17
December 2010 relating to undertakings for collective investment as may be amended from time to time. According to
the fund management agreement, the Management Company will provide the Company with central administration ser-

12569

L

U X E M B O U R G

vices and distribution services and, in respect of the investment policies of the sub-funds, with investment management
services.

The Management Company may enter into one or more investment management or advisory agreements with any

company based in the Grand Duchy of Luxembourg or in a foreign country (the “Manager(s)”) by virtue of which the
Manager(s) shall provide the Management Company with advice, recommendations and management services connected
with the sub-funds’ investment policies.

The Managers may enter into investment advisory agreements with any company based in the Grand Duchy of Lu-

xembourg or in a foreign country (the “Investment Advisor”) in order to be advised and assisted while managing their
portfolios.

The Shareholders are informed by the Company’s prospectus of the management fees paid out for the investment

services carried out by the Managers and the Investment Advisors.

In addition, the Management Company shall enter into service agreements with other contractual parties, for example

an administrative, corporate and domiciliary agent to fulfil the role of administration centrale as defined in the Institut
Monétaire Luxembourgeois Circular 91/75 of 21 January 1991 and a global distributor having the power to appoint
distributors and intermediaries to offer and sell the shares of the Company to investors.

The Company shall enter into a custody agreement with a bank (hereinafter referred to as the “custodian”) which

shall satisfy the requirements of the Luxembourg law dated 17 December 2010 relating to undertakings for collective
investment as amended from time to time. All transferable securities and cash of the Company are to be held by or to
the order of the custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by
law.

In the event of the custodian desiring to retire the board of directors shall use their best endeavours to find another

bank to be custodian in place of the retiring custodian and the board of directors shall appoint such bank as custodian.
The board of directors may terminate the appointment of the custodian but shall not remove the custodian unless and
until a successor custodian shall have been appointed in accordance with these provisions to act in the place thereof.

Art. 30. Investment Policies and Restrictions. The board of directors, based upon the principle of risk spreading, has

the power to determine (i) the investment objectives and policies to be applied in respect of each sub-fund, (ii) the hedging
strategy to be applied to specific classes of shares within particular sub-funds and (iii) the course of conduct of the
management and business affairs of the Company, all within the restrictions as shall be set forth by the board of directors
in compliance with applicable laws and regulations in Luxembourg.

Within those restrictions, the board of directors may decide that investments be made in:
a) transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market within the

meaning of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial
instruments;

b) transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market in a Member State which

operates regularly and is recognised and open to the public. For the purpose of these Articles of Incorporation, the term
"Member State" refers to a member state of the European Union, it being understood that the states that are contracting
parties to the agreement creating the European Economic Area other than the Member States of the European Union,
within the limits set forth by this agreement and related acts, are considered as equivalent to Member States of the
European Union;

c) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-

Member State or dealt in on another regulated market in a non-Member State which operates regularly and is recognised
and open to the public, located within any other country of Europe, Asia, Oceania, the American continents or Africa;

d) recently issued transferable securities and money market instruments provided that the terms of issue include an

undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or to another regulated
market referred to under a) to c) above and that such admission is secured within one year of the issue;

e) shares or units of UCITS authorised according to the UCITS Directive and/or other UCI within the meaning of the

first and second indent of article 1(2) of the UCITS Directive, should they be situated in a Member State or not, provided
that:

(i) such other UCIs are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the

CSSF to be equivalent to that laid down in Community law, and that cooperation between authorities is sufficiently
ensured;

(ii) the level of guaranteed protection for share- or unitholders in such other UCIs is equivalent to that provided for

share- or unitholders in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending and uncovered
sales of transferable securities and money market instruments are equivalent to the requirements of the UCITS Directive;

(iii) the business of the other UCI is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of

the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;

(iv) no more than 10% of the UCITS or the other UCI assets, whose acquisition is contemplated, can be, according

to its fund rules and instruments of incorporation, invested in aggregate in shares or units of other UCITS or other UCIs;

12570

L

U X E M B O U R G

(v) the sub-funds may not invest in shares or units of other UCITS or other UCIs for more than 10% of their assets,

unless otherwise provided in the investment policy of a particular sub-fund;

f) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing

in no more than twelve (12) months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State or,
if the registered office of the credit institution is situated in a country, provided that it is subject to prudential rules
considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Community law;

g) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market referred

to under in a), b) and c) above, and/or OTC derivatives, provided that:

(i) the underlying consist of instruments covered by paragraphs a) to h), financial indices, interest rates, foreign exchange

rates or currencies, in which the Company may invest according to the investment objectives of its sub-funds;

(ii) the counterparties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging

to the categories approved by the CSSF; and

(iii) the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or

closed by an offsetting transaction at any time at their fair market value at the Company’s initiative;

h) money market instruments other than those dealt in on a regulated market and referred to in paragraphs a) to c)

above, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings, and
provided that they are:

(i) issued or guaranteed by a central, regional or local authority, a central bank of a Member State, the European Central

Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State, by
one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States
belong; or

(ii) issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to under a) to c) above;

or

(iii) issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by

Community law or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the CSSF
to be at least as stringent as those laid down by Community law; or

(iv)  issued  by  other  bodies  belonging  to  the  categories  approved  by  the  CSSF  provided  that  investments  in  such

instruments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, second and third indent, and
provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount at least to ten million Euro (EUR 10,000,000)
and which presents and publishes its annual accounts in accordance with Fourth Directive 78/660/EEC, is an entity which,
within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the group
or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity line.

The Company may further invest up to 100% of the net assets of any sub-fund, in accordance with the principle of risk

spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, its local
authorities, a Member  State  of the  OECD  or  public international bodies of which  one or more  Member  States are
members, provided that in such event the sub-fund must hold securities from at least six different issues, but securities
from any one issue may not account for more than 30% of the total amount.

Investments in each sub-fund of the Company may be made either directly or indirectly through subsidiaries, as the

board of directors may from time to time decide.

The Company is authorised to employ techniques and instruments relating to transferable securities provided that

such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management and/or to protect its assets
and commitments.

The board of directors, acting in the best interests of the Company, may decide, in the manner described in the sales

documents for the shares of the Company, that (i) all or part of the assets of the Company or of any sub-fund be co-
managed on a segregated basis with other assets held by other investors, including other UCI and/or their sub-funds, or
that (ii) all or part of the assets of two or more sub-funds be co-managed amongst themselves on a segregated or on a
pooled basis.

VI. Auditor

Art. 31. Auditor. The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be

supervised by an auditor who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to respectability and professional
experience and who shall perform the duties foreseen by the Luxembourg law dated 17 December 2010 relating to
undertakings for collective investment as amended from time to time. The auditors shall be elected by the general meeting
of shareholders.

VII. Annual accounts

Art. 32. Accounting year. The first accounting year of the Company began on 1 May 2010 and terminated on 31 March

2011. Afterwards, the accounting year of the Company shall begin on 1 April each year and end on 31 March of the
following year.

12571

L

U X E M B O U R G

The consolidated currency of the Company is EUR.

Art. 33. Distribution. At the annual general meeting of shareholders, the shareholders of each class of each sub-fund

shall determine, at the proposal of the board of directors, whether, and if so the amount thereof, dividends are to be
distributed to the shareholders of the Company, within the limits prescribed by the Luxembourg law dated 17 December
2010 relating to undertakings for collective investment as amended from time to time.

In each sub-fund, interim dividends may, subject to such further conditions as set forth by law and subject to the

decision of the board of directors, be paid out on shares.

Dividends which are not claimed within a period of five years starting from their payment date will become statute-

barred for their beneficiaries and will revert to the relevant sub-fund.

VIII. Dissolution and liquidation

Art. 34. Dissolution of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution taken by the general

meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements as defined in Article 17 hereof.

Whenever the capital falls below two thirds of the minimum capital as provided by the Luxembourg law 17 December

2010 relating to undertakings for collective investment as amended from time to time, the board of directors has to
submit the question of the dissolution of the Company to the general meeting of shareholders. The general meeting for
which no quorum shall be required shall decide on simple majority of the votes of the shares represented at the meeting.

The question of the dissolution of the Company shall also be referred to the general meeting of shareholders whenever

the capital falls below one quarter of the minimum capital as provided by the Luxembourg law dated 17 December 2010
relating to undertakings for collective investment as amended from time to time in such event the general meeting shall
be held without quorum requirements and the dissolution may be decided by the shareholders holding one quarter of
the votes present or represented at that meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets

of the Company have fallen below two thirds or one quarter of the legal minimum as the case may be. The issue of new
shares by the Company shall cease on the date of publication of the notice of the general shareholders' meeting, to which
the dissolution and liquidation of the Company shall be proposed.

One or more liquidators shall be appointed by the general meeting of shareholders to realise the assets of the Company,

subject to the supervision of the relevant supervisory authority in the best interests of the shareholders.

The proceeds of the liquidation of each sub-fund, net of all liquidation expenses, shall be distributed by the liquidators

among the holders of shares in each class in accordance with their respective rights. The amounts not claimed by sha-
reholders at the end of the liquidation process shall be deposited, in accordance with Luxembourg law, with the Caisse
de Consignation in Luxembourg on behalf of their beneficiaries until the statutory limitation period has lapsed.

Art. 35. Termination, division and amalgamation of sub-funds and/or classes of shares. The directors may decide at

any moment the termination, division and/or amalgamation of any sub-fund. In the case of termination of a sub-fund, the
shares will be redeemed against cash at the net asset value per share determined on the valuation day as described in the
prospectus of the Company. If more than one sub-fund and/or class of shares are offered the directors may offer to the
concerned shareholders the conversion of their class of shares into classes of shares of another sub-fund, under terms
fixed by the directors and described in the prospectus of the Company.

In the event that for any reason the value of the net assets in any sub-fund or of any class of shares within a sub-fund

has decreased to an amount determined by the directors from time to time to be the minimum level for such sub-fund
or such class of shares to be operated in an economically efficient manner, or if a change in the economic or political
situation relating to the sub-fund concerned would have material adverse consequences on the investments of that sub-
fund, or as a matter of economic rationalization, the directors may decide to compulsorily redeem all the shares of the
relevant classes issued in such sub-fund at the net asset value per share, taking into account actual realisation prices of
investments and realisation expenses and calculated on the valuation day at which such decision shall take effect.

The Company shall serve a notice to the shareholders of the relevant class of shares prior to the effective date of the

compulsory redemption, which will indicate the reasons for and the procedure of the redemption operations. Registered
shareholders will be notified in writing. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to maintain equal treatment
between, the shareholders of the Company, the shareholders of the sub-fund concerned may continue to request re-
demption or conversion of their shares free of charge, taking into account actual realisation prices of investments and
realisation expenses and prior to the date effective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred on the board of directors by the preceding paragraph hereof, the general

meeting of shareholders of any one or all classes of shares issued in any sub-fund may, upon proposal of the board of
directors, redeem all the shares of the relevant classes and refund to the shareholders the net asset value of their shares,
taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses and calculated on the valuation day
at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders
that shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented.

Assets which may not be distributed to their owners upon the implementation of the redemption will be deposited

with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.

12572

L

U X E M B O U R G

All redeemed shares will be cancelled in the books of the Company.
The liquidation of a sub-fund shall not involve the liquidation of another sub-fund. Only the liquidation of the last sub-

fund of the Company involves the liquidation of the Company.

Under the same circumstances as provided in the second paragraph of this Article 35, the board of directors may

decide to allocate the assets of any sub-fund or class of shares to those of another existing sub-fund or class of shares
within the Company or to another undertaking for collective investment organised under the provisions of Part I of the
Luxembourg law dated 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment as amended from time to
time or to another sub-fund or class of shares within such undertakings for collective investment (hereinafter referred
to as the “new sub-fund or class of shares”) and to redesignate the classes of shares concerned as shares of another class
(following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement
to  shareholders).  Such  decision  will  be  published  in  the  same  manner  as  described  hereabove  (and,  in  addition,  the
publication will contain information in relation to the new sub-fund or class of shares), at least one month before the
date on which the amalgamation becomes effective in order to enable shareholders to request redemption or conversion
of their shares free of charge during such period.

Under the same circumstances provided for under this Article 35 the board of directors may decide to reorganise a

sub-fund or class of shares by means of a division into two or more sub-funds or classes of shares. Such decision will be
published in the same manner as described hereabove (and, in addition, the publication will contain information about
the two or more new sub-funds or classes of shares) one month before the date on which the division becomes effective
in order to enable the shareholders to request redemption of their shares free of charge during such period.

Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, an amalgamation or

division of sub-funds or classes of shares within the Company may be decided upon by a general meeting of shareholders
of the classes of shares in the sub-fund concerned for which there shall be no quorum requirements and which will decide,
upon such amalgamation or division, by resolution taken by simple majority of those present or represented.

A contribution of the assets and of the liabilities distributable of any sub-fund or class of shares to another undertaking

for collective investment referred to hereinbefore or to another sub-fund or class of shares within such undertaking for
collective investment shall require a resolution of the shareholders of the classes of shares issued in the sub-fund con-
cerned taken with fifty percent (50%) quorum requirement of the shares in issue and adopted at two thirds majority of
the shares present or represented at such meeting, except when such an amalgamation is to be implemented with a
Luxembourg undertaking for collective investment of the contractual type (fonds commun de placement) or a foreign
based undertaking for collective undertakings, in which case resolutions shall be binding only on such shareholders who
have voted in favour of such amalgamation.

Art. 36. Liquidation. In case of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators (who may be natural persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution
and which shall determine their powers and their compensation.

The net product of the liquidation of each sub-fund shall be distributed by the liquidators to the shareholders of each

sub-fund in proportion to the number of shares which they hold in that sub-fund. The amounts not claimed by the
shareholders at the end of the liquidation shall be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg. If these
amounts were not claimed before the end of a period of five years, the amounts shall become statute-barred and cannot
be claimed any more.

Art. 37. Expenses borne by the Company. The formation expenses will be paid by the Company and will be amortised

over a five-year period in equal instalments. Sub-funds created after the incorporation of the Company will only bear the
formation and preliminary expenses relating to their own launching, which will be amortised over a five-years period in
equal installments.

The Company bears all its running costs as foreseen in Article 11 hereof.

Art. 38. Amendment of the articles of incorporation. These articles of incorporation may be amended from time to

time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and majority voting requirements provided by the laws of
Luxembourg.

Any  amendment  of  the  terms  and  conditions  of  the  Company  which  has  as  an  effect  of  decreasing  the  rights  or

guarantees of the shareholders or which imposes on them additional costs, shall only come into force after a period of
three months starting at the date of the approval of the amendment by the general shareholders' meeting. During these
three months, the shareholders may continue to request the redemption of their shares under the conditions in force
before the relevant amendment.

Art. 39. General provisions. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time, the
Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment as amended from time to time.

The Meeting further RESOLVES to discard the French translation of the articles of incorporation of the Company.

12573

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The Meeting RESOLVES to appoint:
- Mr. Dirk Buggenhout, residing professionally in 2595 AS, The Hague, 65 Schenkkade, The Netherlands,
in replacement of Mr. Jonathan Sharkey;
- Mr. Johannes Stoter, residing professionally in 2595 AS, The Hague, 65 Schenkkade, The Netherlands,
in replacement of Mrs. Martina Corrigan; and
- Mr. Benoit De Belder, residing professionally in 2595 AS, The Hague, 65 Schenkkade, The Netherlands,
in replacement of Mr. Michael Gilleran;
as members of the board of directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be

held in 2015.

<i>Fourth resolution

The Meeting RESOLVES to approve the board of directors' decision to appoint ING Asset Management B.V. as in-

vestment manager of the Company and the termination of the distribution agreement with Avoca Capital Holdings.

The Meeting further RESOLVES to approve the amendments to the prospectus of the Company relating to the ap-

pointment of such new investment manager and of the new directors and the waiver of the one month period notice
before the entry into force of these changes in accordance with CSSF Circular 14/591.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing known to the notary by their name, first names, civil status

and residence, those persons signed together with the notary the present deed.

Signé: L. CHIAPPALONE, J.-B. SIMBA, S. DEL ROSSO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2014. Relation: LAC/2014/56505. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 23 janvier 2015.

Référence de publication: 2015014812/798.
(150017366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.

DIERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternacht, rue Henri Tudor, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 96.170.

Im Jahre zweitausend und vierzehn, am neunzehnten Tag des Monats Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Edouard DELOSCH, mit Amtswohnsitz in Diekirch (Großherzogtum Lu-

xemburg).

Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft („société anony-

me“) DIERA S.A., mit Gesellschaftssitz in L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha, und eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister zu Luxemburg unter der Nummer B 96.170, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den
Notar, Maître Camille MINES, mit dem Amtswohnsitz in Capellen, am 19. September 2003, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1157 vom 5. November 2003 (die „Gesellschaft“). Die Satzung der
Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert gemäß einer Urkunde von Notar, Maître Paul Decker, mit damaligen
Amtswohnsitz in Luxemburg, vom 28. Oktober 2010, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 2817 vom 23. Dezember 2010.

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre wird um Uhr eröffnet und findet statt unter dem Vorsitz

von Herr Ralf GASPER, Bürokaufmann, wohnhaft in Dreitalstr. 7, D-54668 Ferschweiler.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre Herrn Dieter

STELKER, Schlosser, beruflich wohnhaft in Echternach.

Der Vorsitzende bestimmt zum Stimmenzähler der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre Herr Her-

man-Josef LENZ, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Echternach.

Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden

Notar Folgendes zu beurkunden:

(i) Die Tagesordnung lautet wie folgt:

12574

L

U X E M B O U R G

<i>Tagesordnung

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von der aktuellen Adresse in L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha zur

Adresse in L-6468 Echternach, rue Henri Tudor, Zone Industrielle;

2. Abänderung des Artikels 1 Absatz 3 der Satzung um sie dem obigen Beschluss anzupassen;
3. Abberufung von Herrn Paul-Hubertus NELKE als Verwaltungsratsmitglieder;
4. Ernennung von Herrn Stefan DR.-ING. DIETZ als neues Verwaltungsratsmitglied;
5. Erneuerung der Mandate von Herrn Dieter STELKER und Herrn Ralf GASPER als Verwaltungsratsmitglieder;
6. Abberufung von der Gesellschaft ABAKUS SERVICE S.A. als Kommissar;
7. Ernennung von Herr Herrmann-Josef LENZ als neuen Kommissar;
8. Verschiedenes.
(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand

einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertre-
tenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben
bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Die durch die erscheinenden Parteien "ne varietur" abgezeichneten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben

vorliegender Urkunde ebenfalls beigefügt.

(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger außerordentlicher Generalversammlung der Aktionäre an-

wesend oder vertreten und da die anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der außerordentlichen
Generalversammlung der Aktionäre über die Tagesordnung unterrichtet worden zu sein und diese zu kennen, erübrigen
sich Einberufungsbescheide.

(v) Die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre, die das gesamte Gesellschaftskapital ver-

tritt, ist ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen einstimmig folgende Bes-

chlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt den Gesellschaftssitz, mit sofortiger Wirkung,

von der aktuellen Adresse in L2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha zur Adresse in L-6468 Echternach, rue Henri
Tudor, Zone Industrielle zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt den vorerwähnten Beschluss durch Artikel 1,

Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

Art. 1. (Absatz 3). “Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Echternach.“

<i>Dritter Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt Herrn Paul-Hubertus NELKE, Buchhalter, gebo-

ren  am  29.  Mai  1952,  in  Blankenburg/Harz,  berufsansässig  in  50,  rue  Nicolas  Martha,  L-2233  Luxembourg  in  seiner
Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung abzurufen.

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt Herrn Paul-Hubertus NELKE, vorgenannt, Ent-

lastung für die Ausübung ihres Mandates als Verwaltungsratsmitglied zu erteilen.

<i>Vierter Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt folgende Person als neues Mitglied des Verwal-

tungsrats für eine Dauer die mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2020 endet zu ernennen:

Herr Stefan DR.-ING. DIETZ, Maschinenbauingenieur, geboren am. 15. November 1959 in Hellersen J Lüdenscheid,

wohnhaft in D-66121 Saarbrücken, Schafbrücke, Grumbachtalweg,95.

<i>Fünfter Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Mandate von Herrn Dieter STELKER, Schlos-

ser, geboren am 30. November 1962 in Trier, wohnhaft in Beim Heiligenhäuschen 10, D-54320 Waldrach, und Herrn
Ralf GASPER, Bürokaufmann, geboren am 06. Februar 1969 in Bitburg, wohnhaft in Dreitalstr. 7, D-54668 Ferschweiler,
als Verwaltungsratsmitglieder, für die Dauer von sechs Jahren, endend am Tage der ordentlichen Generalversammlung
im Jahre 2020, zu erneuern.

<i>Sechster Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Aktiengesellschaft ABAKUS SERVICE S.A.,

mit Sitz in L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der
Nummer B 75.829, in seiner Eigenschaft als Kommissar der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung abzurufen.

12575

L

U X E M B O U R G

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt der Gesellschaft ABAKUS SERVICE S.A., vorge-

nannt, Entlastung für die Ausübung seines Mandates als Kommissar der Gesellschaft zu erteilen.

<i>Siebter Beschluss

Die  außerordentliche  Generalversammlung  der  Aktionäre  beschließt  Herr  Herrmann-Josef  LENZ,  geboren  am

16.05.1955  in  Eigelscheid,  wohnhaft  in  Meisenberg-Hinderhausen  10,  4780  St.Vith-Belgien,  als  neuen  Kommissar  der
Gesellschaft zu ernennen.

Sein Mandat wird am Tage der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2020 enden.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die außerordentliche Generalversammlung der

Aktionäre um Uhr für geschlossen.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-) geschätzt.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Diekirch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nachdem die Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

erschienenen Personen vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: R. GASPER, D. STELKER, H.-J. LENZ, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2014. Relation: DIE/2014/16678. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 29 Dezember 2014.

Référence de publication: 2014209020/100.
(140233531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Yoshi Productions S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 15, route d'Eschdorf.

R.C.S. Luxembourg B 155.368.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015000705/9.
(140235025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Xena Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.797.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 19 décembre 2014:
- Ancienne situation associée:

Mr. Arvind TIKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000 parts sociales

- Nouvelle situation associée:

Parts

sociales

AT Holdings Europe Coöperatieve U.A., société coopérative,
ayant son siège à 2811 EL Reeuwijk, 15a,
Pascalstraat, Pays-bas, Registre de commerce Nr. 54145686 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Xena Investments S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015000702/21.
(140235119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

12576


Document Outline

Avoca International Funds (Luxembourg) SICAV

Babcock &amp; Brown France Retail Portfolio S.à r.l.

Belair Holding S.A.

BlackRock Global Real Estate Opportunity Fund (Luxembourg) B S.à r.l.

BlackRock Global Real Estate Opportunity Fund (Luxembourg) C S.à r.l.

BTG Pactual Holding S.à r.l.

DIERA S.A.

Dimcar Renting SC

Discovery Medical Holdings S.A.

ING Funds

International Entertainment S.A.

La Financière du Mont de l'Enclume

Luxcarta S.à r.l.

Orogen Investment S.A.

Patron Ridlerstrasse S.à r.l.

ProLogis European Finance XVII S.à r.l.

Prospector S.A.

Providance Music S.A.

Q3DI S.C.A.

Quilvest Strategic Fund SCA SIF

Raso S.à r.l.

Renton Investments S.à r.l.

Rieste S.à r.l.

Roninvest S.A.

RPM Lux Holdco S.à r.l.

Schmidt

Scholzen Real Estate A.G.

Schreinerei Jodocy AG

Scripps Media Investments II

SD &amp; Morgan Invest

Sealed Air Luxembourg S.à r.l.

Secogest

Sepat Properties S.à r.l.

Shamrock Investments S.à r.l.

SHCO 37 S.à r.l.

Shine Angel Investments

Silmar s.à r.l.

SL Investment General Partners Fund SCA, SICAV-SIF

Société Civile Immobilière Maro

Société de Recherche Cosmétique S.à r.l.

Southwark Investment S.à r.l.

SUPERNAP International S.A.

Texhold S.A.

Thor Holdings S.à r.l.

Tontec Europe S.à r.l.

Trias Holdco C - T S.à r.l.

Xena Investments S.à r.l.

Yoshi Productions S.àr.l.