logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 207

27 janvier 2015

SOMMAIRE

Aquinnotec S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9890

BC Concept  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9890

BCR S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9890

Betafence Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

9896

Bishop Infrastructure Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9896

Brand Ladenbau Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9896

BroadCom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9890

CAJCAG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9890

Car Tec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9890

C&C IP (N°2) Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9896

Eurofins Agrosciences Services LUX Hold-

ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9930

Eurofins Analyses Environnementales pour

les Industriels France LUX Holding  . . . . .

9934

Eurofins Analyses pour la Construction

France LUX Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9932

Eurofins Forensics LUX Holding . . . . . . . . .

9927

Eurofins GSC LUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9925

Eurofins Hydrologie France LUX Holding

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9928

Eurofins International Holdings LUX  . . . .

9923

Firewall Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

9897

Fondation Edmond Israël  . . . . . . . . . . . . . . .

9936

F.T.A. Communication Technologies

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9936

GLL AMB Generali South Express S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9930

Heilbronn S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9895

Hobaco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9895

Hobsons Benelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9894

IAV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9895

Interlatsco Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

9895

Interpalos S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9895

Inteuro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9895

Lynx Group Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9891

Manimmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9892

Mano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9893

Marine Projects (Luxembourg) S.A.  . . . . .

9892

Market Development International  . . . . . .

9891

Marlis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9892

Marsh & McLennan Europe S.à r.l.  . . . . . . .

9894

Maxime S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9892

MC Constructions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9891

MC Participations s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

9891

Meat Co Maghreb S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

9893

MedBridge Investments S.C.A.  . . . . . . . . . .

9894

Megafit S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9893

Menuiserie Hermes S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

9893

Menuiserie Jos. Dostert  . . . . . . . . . . . . . . . . .

9891

Menuiserie Majoie Michel S.A. . . . . . . . . . . .

9891

Meranti Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

9894

M ET M S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9892

Molycorp Luxembourg Holdings S.à r.l.  . .

9893

Promark Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9935

9889

L

U X E M B O U R G

BCR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 3, rue Emile Lavandier.

R.C.S. Luxembourg B 142.331.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207655/9.
(140232992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

BC Concept, Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 24, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.021.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207654/9.
(140233029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

BroadCom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6150 Altlinster, 7, rue de Junglinster.

R.C.S. Luxembourg B 121.091.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207645/9.
(140232823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Aquinnotec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7649 Freckeisen, 5, Um Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 135.552.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207608/9.
(140232821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

CAJCAG S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.599.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207727/9.
(140233397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Car Tec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 131, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 83.620.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207732/9.
(140232616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

9890

L

U X E M B O U R G

MC Participations s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7480 Tuntange, 23, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 134.886.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208293/9.
(140233496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

MC Constructions, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7516 Rollingen, 14, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 52.785.

Les comptes annuels au 15 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208292/9.
(140231994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Menuiserie Majoie Michel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 71, rue de Hobscheid.

R.C.S. Luxembourg B 73.229.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208299/9.
(140233541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Menuiserie Jos. Dostert, Société Anonyme.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 106, Kohlenberg.

R.C.S. Luxembourg B 73.713.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208298/9.
(140232532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Market Development International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1139 Luxembourg, 67, rue des Sept Arpents.

R.C.S. Luxembourg B 18.489.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208253/9.
(140232430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Lynx Group Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 38, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 179.066.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208241/9.
(140233250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

9891

L

U X E M B O U R G

Maxime S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3380 Noertzange, 62, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 29.798.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2014208243/10.
(140232423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

M ET M S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1731 Luxembourg, 47, rue de Hesperange.

R.C.S. Luxembourg B 181.530.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2014208242/10.
(140232303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Manimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 52.512.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 17 octobre 2014 que:
- Gestman S.A. a démissionné de son poste de commissaire.
- A été nommée au poste de Commissaire en remplacement du commissaire démissionnaire:
* Gestal Sàrl, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 184722 avec siège social au 23, rue Aldringen -

L-1118 Luxembourg.

- Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2015.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014208276/16.
(140232110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Marlis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8223 Mamer, 4, rue de Londres.

R.C.S. Luxembourg B 178.862.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208283/9.
(140233476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Marine Projects (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 54.441.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208282/9.
(140233246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

9892

L

U X E M B O U R G

Mano, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 162, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 43.963.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014208279/10.
(140233124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Megafit S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 85.282.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
MEGAFIT S.A., SPF

Référence de publication: 2014208295/11.
(140232965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Menuiserie Hermes S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9181 Tadler, 2, Emwee.

R.C.S. Luxembourg B 111.754.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014208297/10.
(140232129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Molycorp Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 170.252.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014208263/12.
(140233269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Meat Co Maghreb S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 166.464.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2014208256/11.
(140232289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

9893

L

U X E M B O U R G

MedBridge Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.875.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Référence de publication: 2014208257/10.
(140231921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Marsh &amp; McLennan Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.020.000,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 191.997.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales conclu en date du 23 décembre 2014, que l'associé unique de la

Société, MMC UK Group Ltd. une société du Royaume-Uni, ayant son siège social à 1, Tower Place West, Tower Place,
London EC3R BU, a cédé l'intégralité des parts sociales de la Société, soit 1.020.000 parts sociales, à la société Marsh &amp;
McLennan Companies Regional Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 74, rue de
Merl,  L-2146  Luxembourg,  immatriculée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg,  sous  le
numéro B192785.

Suite au transfert des parts sociales, dont la date effective est fixée au 23 décembre 2014, Marsh &amp; McLennan Com-

panies Regional Holdings S.à r.l., détient 1.020.000 parts sociales de la Société, représentant l'intégralité du capital social
de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014208255/19.
(140233101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Meranti Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 85.333.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208259/9.
(140232311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Hobsons Benelux, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 104.067.

FERMETURE D'UNE SUCCURSALE

II est à noter que la société HOBSONS BENELUX, succursale de HOBSONS BELGIUM, société de droit Belge im-

matriculée au registre de commerce de Belgique sous le numéro RPM 0433.997.794 (Arr.Jud.Bruxelles) a cessé toute
activité à compter du 15 novembre 2014.

Celle-ci peut donc être radiée du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Eric CHARBET
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014207011/16.
(140230808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9894

L

U X E M B O U R G

Hobaco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 36.239.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207010/9.
(140232148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

IAV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4974 Dippach, 4B, rue Centrale.

R.C.S. Luxembourg B 143.083.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207029/9.
(140230517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Heilbronn S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 36, rue Alphonse Munchen.

R.C.S. Luxembourg B 113.358.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207004/9.
(140231557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Interpalos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5341 Moutfort, 8, Cité Ledenberg.

R.C.S. Luxembourg B 56.982.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207056/9.
(140232121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Inteuro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 93.041.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207057/9.
(140230669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Interlatsco Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 9.472.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207053/9.
(140230510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9895

L

U X E M B O U R G

Bishop Infrastructure Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 795.246,30.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 175.350.

<i>Extrait des résolutions des associés en date du 19 décembre 2014

Les associés de la Société ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Stefan Holmer de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 1 

er

 décembre 2014.

- de nommer Michael Anatolitis, né le 13 octobre 1980 à Lefkosia, Chypre et résidant professionnellement au 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg, aux fonctions de gérant de la Société avec effet au 1 

er

 décembre 2014 et ce pour une

durée illimitée.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Référence de publication: 2014205267/15.
(140229423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

C&amp;C IP (N°2) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 173.096.

<i>Extrait rectificatif au dépôt L140226790 du 19 décembre 2014

Suite aux résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 18 décembre 2014 et non en date du 18

novembre 2014, il résulte que:

- le mandat du gérant de classe A en fonction Elizabeth HODGINS a été renouvelé avec effet immédiat et ce pour une

période illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour C&amp;C IP (N°2) SARL

Référence de publication: 2014205324/14.
(140228667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Brand Ladenbau Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 19, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 40.082.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014207679/10.
(140232032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Betafence Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 109.542.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2014207637/11.
(140232074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

9896

L

U X E M B O U R G

Firewall Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 191.674.

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth of December.
Before us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

1. Firewall Investments, S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, incorporated and governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,
having its registered office at Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share
capital of thirty one thousand euro (EUR 31,000.-), and registered with the Luxembourg Company and Trade Register
under number B191622,

here represented by Julia Szafranska, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, and
2. Firewall Management MIP, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated

and governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at Boulevard de la Foire 1,
L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), and registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number B191637,

here represented by Julia Szafranska, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, and The said proxies,

initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be
filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders, representing the entire share capital of Firewall Holding, S.à r.l. (hereinafter

the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Lu-
xembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) registered with the Luxembourg
Company and Trade Register under number B191674 incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary
residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, on 6 November 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations. The articles of association have not been amended since.

The appearing parties representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda

1. Decrease of par value of one euro (EUR 1.-) to par value of one cent (EUR 0,01.-).
2. Creation of new class of shares, referred to as the ordinary shares (the “Ordinary Shares”) having nominal value of

one cent (EUR 0,01.-) and conversion of the existing twelve thousand five hundred shares (12,500) themselves subdivided
into: one thousand two hundred fifty (1,250) series 1 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 1 Shares”), one thousand two hundred fifty (1,250) series 2 redeemable shares having a par value of one
euro (EUR 1.-) each (the “Tranche 2 Shares”), one thousand two hundred fifty (1,250) series 3 redeemable shares having
a  par  value  of  one  euro  (EUR  1.-)  each  (the  “Tranche  3  Shares”),  one  thousand  two  hundred  fifty  (1,250)  series  4
redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each (the “Tranche 4 Shares”), one thousand two hundred
fifty (1,250) series 5 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each (the “Tranche 5 Shares”), one
thousand two hundred fifty (1,250) series 6 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each (the “Tranche
6 Shares”), one thousand two hundred fifty (1,250) series 7 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-)
each (the “Tranche 7 Shares”), one thousand two hundred fifty (1,250) series 8 redeemable shares having a par value of
one euro (EUR 1.-) each (the “Tranche 8 Shares”), one thousand two hundred fifty (1,250) series 9 redeemable shares
having a par value of one euro (EUR 1.-) each (the “Tranche 9 Shares”); and one thousand two hundred fifty (1,250) series
10 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each (the “Tranche 10 Shares”) all having a par value of
one euro (EUR 1.-) each, into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Ordinary Shares, without cancellation
of shares.

3. Creation of new classes of shares (each a “Share Class“) hereinafter referred to as class A redeemable shares (the

“Class A Shares”); class B redeemable shares (the “Class B Shares”); class C redeemable shares (the “Class C Shares”);
class D redeemable shares (the “Class D Shares”); class E redeemable shares (the “Class E Shares”); class F redeemable
shares (the “Class F Shares”); class G redeemable shares (the “Class G Shares”); class H redeemable shares (the “Class
H Shares”); class I redeemable shares (the “Class I Shares”); and class J redeemable shares (the “Class J Shares”) all having
a par value of one cent (EUR 0,01.-) each.

4. Increase of the share capital of the Company by one million euro (EUR 1,000,000.-) so as to bring it from its current

amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to one million twelve thousand five hundred euro (EUR
1,012,500) by issuance of: ten million (10,000,000) Class A Shares; ten million (10,000,000) Class B Shares; ten million
(10,000,000) Class C Shares; ten million (10,000,000) Class D Shares; ten million (10,000,000) Class E Shares; ten million
(10,000,000) Class F Shares; ten million (10,000,000) Class G Shares; ten million (10,000,000) Class H Shares; ten million

9897

L

U X E M B O U R G

(10,000,000) Class I Shares; and ten million (10,000,000) Class J Shares all having a par value of one cent (EUR 0,01.-)
each.

5. Full restatement of the articles of association of the Company.
6. Miscellaneous.

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to decrease the par value of the shares in the share capital of the

Company from one euro (EUR 1.-) to one euro cent (EUR 0.01.-).

<i>Second Resolution

The general meeting of shareholders resolves to create new class of shares, referred to as the Ordinary Shares having

par value of one euro cent each (EUR 0.01.-) and to convert the existing twelve thousand five hundred shares (12,500)
themselves subdivided into one thousand two hundred fifty (1,250) Tranche 1 Shares, one thousand two hundred fifty
(1,250) Tranche 2 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) Tranche 3 Shares, one thousand two hundred fifty
(1,250) Tranche 4 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) Tranche 5 Shares, one thousand two hundred fifty
(1,250) Tranche 6 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) Tranche 7 Shares, one thousand two hundred fifty
(1,250) Tranche 8 Shares, one thousand two hundred fifty (1,250) Tranche 9 Shares, and one thousand two hundred fifty
(1,250) Tranche 10 Shares; all having a par value of one euro (EUR 1.-) each into one million two hundred fifty thousand
(1,250,000) Ordinary Shares having nominal value of one cent (EUR 0,01.-) as follows:

(i) eleven thousands (11,000) shares, themselves subdivided into one thousand one hundred (1,100) Tranche 1 Shares,

one thousand one hundred (1,100) Tranche 2 Shares, one thousand one hundred (1,100) Tranche 3 Shares, one thousand
one hundred (1,100) Tranche 4 Shares, one thousand one hundred (1,100) Tranche 5 Shares, one thousand one hundred
(1,100) Tranche 6 Shares, one thousand one hundred (1,100) Tranche 7 Shares, one thousand one hundred (1,100)
Tranche 8 Shares, one thousand one hundred (1,100) Tranche 9 Shares and one thousand one hundred (1,100) Tranche
10 Shares held by Firewall Investments, S.A., aforementioned, are converted into one million one hundred thousand
(1,100,000) Ordinary Shares having par value of one euro cent each (EUR 0.01.-);

(ii) one thousand five hundred (1,500) shares, themselves subdivided into one hundred fifty (150) Tranche 1 Shares,

one hundred fifty (150) Tranche 2 Shares, one hundred fifty (150) Tranche 3 Shares, one hundred fifty (150) Tranche 4
Shares, one hundred fifty (150) Tranche 5 Shares, one hundred fifty (150) Tranche 6 Shares, one hundred fifty (150)
Tranche 7 Shares, one hundred fifty (150) Tranche 8 Shares, one hundred fifty (150) Tranche 9 Shares and one hundred
fifty (150) Tranche 10 Shares held by Firewall Management MIP, S.à r.l., aforementioned, are converted into one hundred
fifty thousand (150,000) Ordinary Shares having par value of one euro cent each (EUR 0.01.-);

<i>Third Resolution

The  general  meeting  of  shareholders  resolves  to  create  new  classes  of  shares  (each  a  “Share  Class“)  hereinafter

referred to as class A redeemable shares (the “Class A Shares”); class B redeemable shares (the “Class B Shares”); class
C redeemable shares (the “Class C Shares”); class D redeemable shares (the “Class D Shares”); class E redeemable shares
(the “Class E Shares”); class F redeemable shares (the “Class F Shares”); class G redeemable shares (the “Class G Shares”);
class H redeemable shares (the “Class H Shares”); class I redeemable shares (the “Class I Shares”); and class J redeemable
shares (the “Class J Shares”) all having a par value of one cent (EUR 0,01.-) each.

<i>Fourth Resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase of the share capital of the Company by one million euro

(EUR 1,000,000.-) so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to one
million twelve thousand five hundred euro (EUR 1,012,500) by issuance of: ten million (10,000,000) Class A Shares; ten
million (10,000,000) Class B Shares; ten million (10,000,000) Class C Shares; ten million (10,000,000) Class D Shares; ten
million (10,000,000) Class E Shares; ten million (10,000,000) Class F Shares; ten million (10,000,000) Class G Shares; ten
million (10,000,000) Class H Shares; ten million (10,000,000) Class I Shares; and ten million (10,000,000) Class J Shares
all having a par value of one cent (EUR 0,01.-) each.

<i>Subscription and payment

All one hundred million (100,000,000) new shares have been subscribed as follows:
(i) Firewall Investments S.A., aforementioned, subscribed seventy seven million five hundred thousand two hundred

(77,500,200) shares for the price of twelve million four hundred forty thousand euro (EUR 12,440,000.-) subdivided as
follows:

(a) Seven million seven hundred fifty thousand twenty (7,750,020) Class A Shares;
(b) Seven million seven hundred fifty thousand twenty (7,750,020) Class B Shares;
(c) Seven million seven hundred fifty thousand twenty (7,750,020) Class C Shares;
(d) Seven million seven hundred fifty thousand twenty (7,750,020) Class D Shares;
(e) Seven million seven hundred fifty thousand twenty (7,750,020) Class E Shares;

9898

L

U X E M B O U R G

(f) Seven million seven hundred fifty thousand twenty (7,750,020) Class F Shares;
(g) Seven million seven hundred fifty thousand twenty (7,750,020) Class G Shares;
(h) Seven million seven hundred fifty thousand twenty (7,750,020) Class H Shares;
(i) Seven million seven hundred fifty thousand twenty (7,750,020) Class I Shares; and
(j) Seven million seven hundred fifty thousand twenty (7,750,020) Class J Shares.
The total of twelve million four hundred forty thousand euro (EUR 12,440,000.-) is allocated as follows: seven hundred

seventy-five thousand and two euro (EUR 775,002.-) is allocated to the share capital and eleven million six hundred sixty-
four thousand nine hundred ninety-eight euro (EUR 11,664,998.-) is allocated pro rata to the share premium stapled to
each Share Class.

(ii) Firewall Management MIP, S.à r.l., aforementioned, subscribed twenty two million four hundred ninety nine thousand

eight hundred (22,499,800) shares for the price of three million six hundred eleven thousand five hundred seventy-one
euro (EUR 3,611,571.-) subdivided as follows:

(a) two million two hundred forty nine thousand nine hundred eighty (2,249,980) Class A Shares;
(b) two million two hundred forty nine thousand nine hundred eighty (2,249,980) Class B Shares.-;
(c) two million two hundred forty nine thousand nine hundred eighty (2,249,980) Class C Shares;
(d) two million two hundred forty nine thousand nine hundred eighty (2,249,980) Class D Shares;
(e) two million two hundred forty nine thousand nine hundred eighty (2,249,980) Class E Shares;
(f) two million two hundred forty nine thousand nine hundred eighty (2,249,980) Class F Shares;
(g) two million two hundred forty nine thousand nine hundred eighty (2,249,980) Class G Shares;
(h) two million two hundred forty nine thousand nine hundred eighty (2,249,980) Class H Shares;
(i) two million two hundred forty nine thousand nine hundred eighty (2,249,980) Class I Shares; and
(j) two million two hundred forty nine thousand nine hundred eighty (2,249,980) Class J Shares.
The total of three million six hundred eleven thousand five hundred seventy-one euro (EUR 3,611,571.-) is allocated

as follows: two hundred twenty four thousand nine hundred ninety-eight euro (EUR 224,998.-) is allocated to the share
capital and three million three hundred eighty six thousand five hundred seventy three euro (EUR 3,386,573.-) is allocated
pro rata to the share premium stapled to each Share Class.

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of sixteen million fifty-

one hundred five hundred seventy-one euro (EUR 16,051,571.-) is as of now available to the Company, as it has been
justified to the undersigned notary.

<i>Sixth Resolution

The general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of association of the Company, which shall

now be read as follows:

“A. Definitions

Acceptance Period

has the meaning ascribed to in article 8.3

Asset Sale

means a sale by the Company or any other member of the Group of all or substantially
all of the Group’s business, assets and undertakings to a single buyer or to one or
more buyers as part of a single transaction or series of connected transactions (other
than as part of a Reorganisation Transaction)

Available Amount

has the meaning ascribed to in article 6.13

Board

has the meaning ascribed to in article 15.1

Business Day

means any day other than a Saturday, Sunday or bank or public holiday in England, the
Grand Duchy of Luxembourg and Munich and Frankfurt, Germany

Cancellation Amount

has the meaning ascribed to in article 6.13

Class Period

has the meaning ascribed to in article 6.13

Completion

means completion of the acquisition of Waterlogic Plc

Company

Firewall Holding S.à r.l.

Convening Notice

has the meaning ascribed to in article 11

Debt Securities

any preferred equity certificates, shareholder loans (including the Shareholder Loans)
loan notes, preference Shares and any debt or debt like security in each case, of the
Company from time to time and having the rights and being subject to the restrictions
set out in any Shareholders Agreement and the relevant instrument constituting such
security

Dragged Shares

has the meaning ascribed to in article 9.2

Drag-Along Notice

has the meaning ascribed to in article 9.2

Dragging Investors

has the meaning ascribed to in article 9.1

9899

L

U X E M B O U R G

Drag Transferee

Has the meaning ascribed to in article 9.1

Encumbrance

a mortgage, charge, pledge, lien, option, restriction, equity, right of first refusal, right
of pre-emption, third party right or interest, other encumbrance or Share interest of
any kind, or other type of agreement or arrangement having similar effect

Exit

means a Sale, Asset Sale, IPO or Winding Up

Group

means the Company and any undertaking which is a subsidiary undertaking of the
Company from time to time and references to “Group Company” and “member of
the Group” shall be construed accordingly

Interim Accounts

has the meaning ascribed to in article 6.13

Interim Account Date

has the meaning ascribed to in article 6.13

Investor

Firewall Investments, S.A., a public limited liability company (société anonyme)
organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered
office at Boulevard de la Foire 1, L-1528, Luxembourg

Investor Manager

has the meaning ascribed to in article 16.1

IPO

means the admission of the whole of any class of the issued share capital of the
Company or any Group Company (including any New Holding Company) to trading
on a regulated market or other internationally recognised investment exchange

Law

Shall mean the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended from
time to time

New Holder

has the meaning ascribed to in article 9.8

New Holding Company

means any new holding company of the Company, formed for the purpose of
facilitating a Reorganisation Transaction, Refinancing or an IPO

New Issue

any issue of Securities following Completion other than an Excluded Issue

Pro-Rata Portion

in relation to each shareholder:
(a) for any New Issue of or including any Debt Securities, a proportion calculated by
dividing (i) the total amount outstanding (including all unpaid amounts of principal and
interest) on all Debt Securities held by such Security Holder by (ii) the total amount
outstanding (including all unpaid amounts of principal and interest) on all Debt
Securities (other than Debt Securities held by one Group Company in another Group
Company) then in issue; and
(b) for any other New Issue of Shares, a proportion calculated by dividing the number
of all Shares held by such Security Holder at the relevant time by the total number of
Shares then in issue

Profit Entitlement

has the meaning ascribed to in article 6.13

Remaining Shareholders

has the meaning ascribed to in article 9.1

Required Exit

has the meaning ascribed to in article 9.1.

Rollover Managers

are certain individuals whose names and addresses are set out in the schedule of the
Shareholders Agreement and any person who adheres to such Shareholders
Agreement as a Rollover Manager pursuant to a Deed of Adherence in accordance
with such Shareholders Agreement

Sale

means the sale and transfer of at least 75 per cent. of the Shares to a third party on
arm’s length terms as part of a single transaction or a series of related transactions

Security

Debt Security and any Shares

Security Holder

any person holding Securities

Shares

means the share capital in the Company

Share Capital Table

means a document appended to the Shareholders Agreement setting out (i) the fully
diluted share capital structure of the Company (ii) the number, class and subscription
amounts of Shares issued to respective shareholders; and (iii) the Shareholder Loans.

Share Premium Accounts

has the meaning ascribed to in article 5.4

Shareholders Agreement

any shareholders agreement to be entered into between the shareholders in relation
to the Company which is in force from time to time, if any

Shareholders Loan

means the subordinated loans issued pursuant to the Shareholder Loan Agreements
as contemplated by the Share Capital Table each with a coupon of 10 per cent. PIK

Shareholder Loan Agreements Any interest bearing subordinated loan agreements as contemplated by the Share

Capital Table

Tag -Along Notice

has the meaning ascribed to in article 8.2

Tag-Along Purchaser

has the meaning ascribed to in article 8.1

Tag-Along Right

has the meaning ascribed to in article 8.1

9900

L

U X E M B O U R G

Tag-Along Sale

has the meaning ascribed to in article 8.1

Tag-Along Shares

has the meaning ascribed to in article 8.1

Tagging Shareholder

has the meaning ascribed to in article 8.2

Transfer

(i) any direct or indirect sale, transfer or other disposition (including by way of
contractual or other arrangement which transfers the economic risk and reward or
otherwise substantially mimics the effect of a sale, or by way of Encumbrance) of any
Shares (including any voting rights attached thereto); (ii) any direction (by way of
renunciation or otherwise) by a holder of Shares, or a person entitled to an issue or
transfer of Shares, that Shares be issued or transferred to a person other than himself;
or (iii) any agreement to do any of the foregoing

Winding Up

means a distribution pursuant to a winding up, dissolution or liquidation of the
Company or any New Holding Company (including following an Asset Sale)

B. Name - Purpose - Duration - Registered - Office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Firewall Holding, S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association and any agreement among
the shareholders, as the case may be.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the Board. It may

be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the Board.

4.4 In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural

disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary
circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

C. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at one million twelve thousand five hundred euro (EUR 1,012,500.-), represented

by one hundred one million two hundred fifty thousand (101,250,000) Shares, themselves subdivided as follows:

(a) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary Shares having nominal value of one cent (EUR 0.01.-)

each (the “Ordinary Shares”);

(b) ten million (10,000,000) class A shares having a par value of one cent (EUR 0.01.-) each (the “Class A Shares”);
(b) ten million (10,000,000) class B shares having a par value of one cent (EUR 0.01.-) each (the “Class B Shares”);
(c) ten million (10,000,000) class C shares having a par value of one cent (EUR 0.01.-) each (the “Class C Shares”);
(d) ten million (10,000,000) class D shares having a par value of one cent (EUR 0.01.-) each (the “Class D Shares”);

9901

L

U X E M B O U R G

(e) ten million (10,000,000) class E shares having a par value of one cent (EUR 0.01.-) each (the “Class E Shares”);
(f) ten million (10,000,000) class F shares having a par value of one cent (EUR 0.01.-) each (the “Class F Shares”);
(g) ten million (10,000,000) class G shares having a par value of one cent (EUR 0.01.-) each (the “Class G Shares”);
(h) ten million (10,000,000) class H shares having a par value of one cent (EUR 0.01.-) each (the “Class H Shares”);
(i) ten million (10,000,000) class I shares having a par value of one cent (EUR 0.01.-) each (the “Class I Shares”); and
(j) ten million (10,000,000) class J shares having a par value of one cent (EUR 0.01.-) each (the “Class J Shares (the

“Class J Shares” and together with Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class
F Shares, Class G Shares, Class H Shares,Class I Shares, the “Classes”

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Any new Shares shall be offered by preference to the existing shareholder(s) in accordance with the Shareholders

Agreement, if any.

5.4 The Company may establish share premium accounts (the "Share Premium Accounts") into which any premium

paid on any Class of Shares is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Accounts are to be taken
by the Shareholders subject to the 1915 Law and these Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into Shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The Shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.7 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of one or more Classes, in whole but

not in part, consisting of the repurchase and cancellation of all Shares in issue in such Class, as may be determined from
time to time by the Board whereby Shareholders agree with any redemption in line with article 6.8.

6.8 A reduction of share capital through the repurchase of a Class may only be made within the respective Class

Periods (as defined below):

i. The period for the Class A Shares is the period starting on 18 December 2014 and ending no later than on 31

December 2015 (the “Class A Period”).

ii. The period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on no later

than 31 December 2016 (the “Class B Period”).

iii. The period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later

than on 31 December 2017 (the “Class C Period”).

iv. The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later

than on 31 December 2018 (the “Class D Period”).

v. The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no later

than 31 December 2019 (the “Class E Period”).

vi. The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no later

than 31 December 2020 (the “Class F Period”).

vii. The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no later

than 31 December 2021 (the “Class G Period”).

viii. The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later

than on 31 December 2022 (the “Class H Period”).

ix. The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than

on 31 December 2023 (the “Class I Period”).

x. The period for the Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later than

on 31 December 2024 (the “Class J Period”).

6.9 Where a Class has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption and

cancellation of such Class(es) can be made during a new period (the “New Period”) which shall start on the date after
the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of another
class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the day
after the Class J Period and the Class(es) not repurchased and not cancelled in their respective Class Period shall come
in the order from class A to class J (to the extent not previously repurchased and cancelled) and subject to the New
Period being started.

6.10 For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a Class shall take place prior to

the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case
may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such Class and shall continue to end
on the day such as initially defined in the Articles above.

9902

L

U X E M B O U R G

6.11 Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due

and payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt
the Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.

6.12 The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the Board in

its reasonable discretion and within the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, Board can
choose at its sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount the freely distributable
reserves either in part or in totality.

6.13 For the purposes of these Articles, the following capitalised terms shall have the following meanings:
- “Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)

increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be, by the amount of the capital reduction and
legal reserve reduction relating to the Class to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses)
expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles,
each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting), (iii) any
dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles and (iv) any Profit Entitlement
so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+OD+PE)
Whereby:
AA = Available Amount.
NP = net profits (including carried forward profits).
P = any freely distributable reserves.
CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be

cancelled.

L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.
OD = any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles.
PE = Profit Entitlement.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed

by the Board in good faith and with the view to the Company’s ability to continue as a going concern.

- “Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a

remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes
and any receivable which in the opinion of the Board will be paid to the Company in the short term less any indebtedness
or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating
to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as Shares, stock or securities
of other kind held by the Company.

- “Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class

Period (or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available
Liquidities relating to the relevant Class Period (or New Period).

- “Class Period” shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period,

the Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.

- “Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
- “Interim Account Date” shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before

the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class.

- “Profit Entitlement” shall mean the preferred dividends of the Classes, except of the class repurchased.

Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The Shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the Shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders of a majority of three quarters of the share capital and subject to article 7.5.

7.5 Subject to any Shareholders Agreement, any person who holds, or becomes entitled to hold any Shares of the

Company shall not Transfer any of its Shares without consent of the Investor. The Board shall refuse to register any
purported transfer of the Shares in violation of this 7.5, except with consent of the Investor. The purported transferor
shall not have any rights towards the Company in respect of such shares.

9903

L

U X E M B O U R G

7.7 Any transfer of Shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.8 In the event of death, the Shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by
the surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

7.9 Transfers of Shares are further subject to the provisions of any Shareholders agreement, as applicable.

Art. 8. Tag Along.
8.1 Subject to any Shareholders Agreement, if the Investor proposes to make a Transfer of any Shares in the Company

or if the Shares of the Investor are to be Transferred, to a third party (a “Tag-Along Purchaser”) (the “Tag-Along Sale”),
the Investor shall procure that each of the other shareholder has the opportunity (“Tag-Along Right”) to sell to the Tag-
Along Purchaser for the same consideration and on the same terms (including participating in any escrow arrangements
on the same terms), a Pro Rata Portion of its Shares pursuant to such Tag-Along Sale (the “Tag-Along Shares”). The Tag-
Along Right shall not apply to any Transfer of Shares following or as part of an IPO which shall be governed by the
provisions of any lock-up agreement and/or orderly marketing agreement.

8.2 Not less than fifteen (15) Business Days prior to the completion of any proposed Tag-Along Sale, the Investor shall

deliver to the Company and the other shareholders a written notice (a “Tag-Along Notice”) which notice shall set out
(to the extent not described in any accompanying documents):

- the type and amount of consideration to be paid by the Tag-Along Purchaser for each share;
- details of the person who has expressed an interest in acquiring any of the Shares; and
- all other material terms and conditions, if any, of such transaction.
8.3 If a Shareholder wishes to exercise its Tag-Along Right (in such event, a “Tagging Shareholder”), the Tagging

Shareholder shall notify the Investor within ten (10) Business Days following the date of the Tag-Along Notice that it
wishes to exercise its Tag-Along Right (the “Acceptance Period”). Any shareholder that does not notify the Investor
within the Acceptance Period shall be deemed to have waived its Tag-Along Right.

8.4 Following the expiry of the Acceptance Period, the Investor shall deliver to each Tagging Shareholder, not less

than five (5) Business Days prior to the completion of the proposed Tag-Along Sale, a definitive agreement (along with
any ancillary transfer instruments) to effect the sale of his Tag-Along Shares to the Tag-Along Purchaser.

8.5 Not less than two (2) Business Days prior to the proposed Transfer, the Tagging Shareholder shall return to the

Investor the duly executed documents. If a Tagging Shareholder fails to comply with this article 8.5 in full not less than
two (2) Business Days prior to the proposed Transfer, it shall be deemed to have waived its Tag-Along Rights.

8.6 Each Tagging Shareholder shall bear his share of the costs of the Tag-Along Sale, pro-rata to the proceeds received

by him in the Tag-Along Sale. Each Tagging Shareholder shall be entitled to receive his consideration pursuant to the Tag-
Along Sale (less his share of the costs of the Tag-Along Sale) at the same time as the Investor.

8.7 The Investor shall furnish or shall procure that the Tag-Along Purchaser furnishes such evidence of completion of

such Tag-Along Sale as may be reasonably requested by any Tagging Shareholder.

8.8 If some or all of the shareholders waive, or are deemed to have waived, their Tag-Along Rights, the Tag-Along Sale

is permitted to be made provided:

- it is completed within sixty (60) days of the expiry of the Acceptance Period (or, where any anti-trust or regulatory

conditions are required to be satisfied before the Tag-Along Sale can be completed, the long-stop date for the satisfaction
of such conditions in the Tag-Along Sale documentation (as agreed between the Investor and the Tag-Along Purchaser);
and

- it takes place on terms and conditions no more favourable in any material respect to those stated on the Tag-Along

Notice.

8.9 If the Tag-Along Sale is not completed within the period set out in article 8, the Investor shall promptly return to

the Tagging Shareholder all documents (if any) previously delivered in respect of the Tag-Along Sale, and all the restrictions
on Transfer contained in this Agreement with respect to Shares held or owned by the Investor and such Tagging Share-
holder shall again be in effect.

9. Drag Along.
9.1 If the Investor wishes to make a Transfer of its Shares in connection with an Exit (the “Dragging Investors”), then

the Investor shall have the right to require all other shareholders (the “Remaining) to transfer on a pro rata basis a
corresponding portion of their respective Shares to the proposed transferee (the “Drag Transferee”) (a “Required Exit”).

9.2 The Investor may effect a Required Exit by giving written notice to the Remaining Shareholders (the “Drag-Along

Notice”) at least ten (10) Business Days prior to the anticipated closing date of such Required Exit. The Drag-Along
Notice shall specify:

- that the Remaining Shareholders are required to transfer all of their Shares in the event of a Required Exit (“Dragged

Shares”);

9904

L

U X E M B O U R G

- the person to whom the Dragged Shares are to be Transferred;
- the consideration for the Dragged Shares which shall, for each Dragged Share on terms no less favourable (including

as to participating in any escrow arrangements on the same terms) for the corresponding Share being sold by the Dragging
Investors (and, for these purposes, the Ordinary Shares shall be deemed to constitute a single class of Share and the
Shareholder Loans shall be deemed to constitute a single class of Share); and

- the terms of any proposed date of the Transfer.
9.3 Where a Drag Transferee is offering to pay any part of the consideration due to the Dragging Investors or the

Remaining Shareholders in a non-cash manner as part of the Required Exit then in such event each of the Dragging
Investors and the Remaining Shareholders shall receive the consideration due from the Dragged Transferee in the same
proportion as regards cash and non-cash consideration.

9.4 The validity of a drag pursuant to these provisions shall not be affected by the Drag Transferee offering different

forms of consideration to the Dragging Investors and/or the Remaining Shareholders:

- on the date of the Transfer, the value of the consideration offered per Dragged Share is at least equal to the value

offered for the corresponding Share of the Dragging Investors; and

- to the extent that the Dragging Investors are receiving cash as consideration for their Shares, each Remaining Sha-

reholder shall also be entitled to receive cash consideration on equivalent terms to the Dragging Investors, in respect of
the same class of Shares and in the same proportions.

9.5 The Drag-Along Notice shall be accompanied by copies of all documents required to be executed by the Remaining

Shareholders to give effect to the Required Exit and such Required Exit shall, subject to article 9.3, be on no less favourable
terms and conditions as shall have been agreed between the Dragging Investors and the Drag Transferee.

9.6 Each Remaining Shareholder, upon receipt of the Drag-Along Notice and accompanying documents, shall be obliged

to:

- sell all of their Dragged Shares, and participate in the Required Exit (including giving warranties as to the title to their

Dragged Shares and their capacity to transfer the Dragged Shares on the same basis as the Dragging Investors);

- return to the Investor by no later than two (2) Business Days prior to the anticipated date of the Transfer, the duly

executed documents;

- vote their Shares in favour of the Required Exit at any meeting of Shareholders (or any class thereof) called to vote

on or approve the Required Exit and/or consent in writing to the Required Exit;

- procure (in as far as they are reasonably able) that any manager of the Company designated by it vote in favour of

the Required Exit; and

- bear an amount of any costs of a Required Exit in the same proportions as the consideration (of whatever form)

received by him bears to the aggregate consideration paid pursuant to the Required Exit.

9.7 Nothing in this article 8 shall require the Drag Transferee to offer equality of treatment to Rollover Managers with

respect to any opportunities to acquire Shares in the Drag Transferee’s ownership structure.

9.8 Following the issue of a Drag-Along Notice, if any person is issued or otherwise acquires any new or additional

Shares (a “New Holder”), a Drag-Along Notice shall be deemed to have been served upon such New Holder on the
same terms as the previous Drag-Along Notice. The New Holder will be bound to sell and transfer all such new Shares
acquired by him or it to the Drag Transferee or as it may direct and the provisions article 23 shall apply to the New
Holder (with necessary modification) in respect of its holding of such new Shares.

9.9 If the Required Exit has not been completed by the earlier of (i) the one hundred twentieth (120 

th

 ) day following

the date of the Drag-Along Notice (or, where any anti-trust or regulatory conditions are required to be satisfied before
the  Required  Exit  can  be  completed,  the  long-stop  date  for  the  satisfaction  of  such  conditions  in  the  Required  Exit
documentation (as agreed between the Investor and the third party purchaser)); or (ii) the Investor sending a written
notice to the Remaining Shareholders that the Required Exit will not be completed, the Drag-Along Notice shall cease
to be of effect and each Remaining Shareholder shall be irrevocably released from such obligations under the Drag-Along
Notice and the rights of the Investor pursuant to this article 9 shall be reinstated.

D. Decisions of the shareholders

Art. 10. Collective decisions of the shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

10.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns.
10.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

10.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference

9905

L

U X E M B O U R G

made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 11. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting
setting out the agenda, place and time of the meeting (the “Convening Notice”). Other meetings of shareholders may be
held at such place and time as may be specified in the respective Convening Notices of meeting. All Convening Notices
shall be sent to shareholders at least ten (10) Business Days before any meeting, except if the Board decides on a lesser
period. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 12. Quorum and vote.
12.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds Shares.
12.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital, including at all times the Investor. If such quorum is not constituted at the meeting of the Company within half
an hour from the time appointed for the meeting or if during the meeting a quorum ceases to be present for a period
exceeding 10 minutes, the meeting shall be adjourned for four (4) weeks whereupon the meeting will be quorate not-
withstanding  the  absence  of  any  Rollover  Manager.  If  no  majority  is  reached  in  a  first  meeting  or  proposed  written
resolution, the shareholders may be convened a second time with the same agenda or receive such proposed written
resolution a second time by registered letter, decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of
the votes validly cast whichever is the fraction of the share capital represented.

Art. 13. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 14. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

E. Management

Art. 15. Powers of the sole manager - Composition and powers of the Board.
15.1  Subject  to  any  Shareholders  Agreement,  the  Company  shall  be  managed  by  one  or  several  managers.  If  the

Company has several managers, the managers form a board of managers (the “Board”).

15.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “Board” used in these articles of association is to
be construed as a reference to the “sole manager”.

15.3 The Board is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary

or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these
articles of association to the general meeting of shareholders.

15.4 The Company grants a power of attorney to EPIC I GP S.à r.l., a private limited liability company (société à

responsabilité limitée), incorporated and exiting under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
address at Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with Luxembourg
Company and Trade Register under number B186222 (the “Proxyholder”), acting individually and with full power of
substitution, to act on behalf of and represent the Company, itself acting individually or by a power of attorney as the
case may be, at any shareholders or interest holders’ meeting or resolution in writing of any company, corporation,
partnership or any other entity and/or any subsidiary thereof in which the Company holds directly or indirectly Shares,
interests or any other participation in respect of (and only in this respect) (i) the appointment or dismissal of directors,
managers or other members of any managing, governing and/or supervisory body for which the Company is entitled to
vote (ii) the amendment of the articles, partnership agreement or bylaws, as the case may be, with respect to the ap-
pointment or dismissal of directors, managers or other members of any managing, governing and/or supervisory body
for which the Company is entitled to vote.

Art. 16. Appointment, removal and term of office of managers.
16.1 Subject to any Shareholders Agreement and in accordance with article 15.4, the Investor shall have the right to

propose for appointment the managers to the Board (the “Investor Managers” and “Investor Manager” shall be construed
accordingly), it being provided that the Rollover Managers may be entitled from time to time and subject to conditions
set out in any Shareholders Agreement to propose for appointment one (1) manager who shall not be a Rollover Manager.

The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office in accordance with article 16.4.

16.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

9906

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Vacancy in the office of a manager.
17.1 Subject to any Sharehodlers Agreement, the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal

incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time
not exceeding the initial mandate of the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of share-
holders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions and article
16.

17.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 18. Convening meetings of the Board.
18.1 Subject to any Shareholders Agreement, Board shall meet upon call by any manager. The meetings of the Board

shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

18.2 Subject to any Shareholders Agreement, written notice of any meeting of the Board accompanied by a written

agenda specifying the business of the meeting along with relevant documents must be sent to managers twenty-four (24)
hours at least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature
and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of
each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed
document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and
location determined in a prior resolution adopted by the Board which has been communicated to all managers.

18.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the Board.

Art. 19. Conduct of meetings of the Board.
19.1 The Board may elect among its members a chairman, it being provided that the chairman shall be proposed for

appointment by an Investor Manager. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall
be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board. The chairman, if any, shall not have a casting vote
19.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the Board. In his absence, the Board may appoint another manager
as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such meeting.

19.3 Any manager may act at any meeting of the Board by appointing another manager as his proxy either in writing,

or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient
proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

19.4 Meetings of the Board may also be held by conference-call or video conference or by any other means of com-

munication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an
effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at
such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

19.5 The Board may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at

a meeting including at least one (1) Investor Manager.

19.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting it being

provided that that when the majority of Investor Managers vote in favour or against a matter, such decision shall be
deemed to carry the majority of the Board votes at the relevant meeting. The chairman, if any, shall not have a casting
vote.

19.7 The Board may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by fac-

simile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately,
the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of
the last signature.

19.8 The majority of the meetings of the Board shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at the registered

office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting.

Art. 20. Minutes of the meeting of the Board; Minutes of the decisions of the sole manager.
20.1 The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman

pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be
produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers.

20.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 21. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the

joint signature of any two (2) managers, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom
such signatory power may have been delegated by the Board within the limits of such delegation.

Art. 22. Conflict of interests. Where a manager has an interest which can reasonably be regarded as likely to give rise

to a personal or professional conflict of interest, the manager shall if so requested by the Board, take such additional
steps as may be necessary or desirable for the purpose of managing such conflict of interest, including compliance with

9907

L

U X E M B O U R G

any procedures laid down from time to time by the Board for the purpose of managing conflicts of interest generally (if
any) and/or any specific procedures approved by the Board for the purpose of or in connection with the situation or
matter in question, including, without limitation:

- absenting himself from any meetings of the Board (or any committee thereof) at which the relevant situation or

matter falls to be considered; and

- not reviewing documents or information made available to the Board (or any committee thereof) generally in relation

to such situation or matter and/or arranging for such documents or information to be reviewed by a professional adviser
to ascertain the extent to which it might be appropriate for him to have access to such documents or information.

F. Audit and supervision

Art. 23. Auditor(s).
23.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

23.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

23.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
23.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

23.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

G. Financial - Year - Annual - Accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 24. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 25. Annual accounts and allocation of profits.
25.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board draws up an inventory of the Company's

assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

25.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.

25.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

25.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

25.5 Upon recommendation of the Board, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of

the  Company’s  profits  shall  be  used  in  accordance  with  the  Law,  these  articles  of  association  and  any  Shareholders
Agreement.

25.6 Subject to any Shareholders Agreement, dividends shall be allocated and paid in the following order:
i. the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.60% of the nominal value of the Ordinary

Shares;

ii. the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.10% of the nominal value of the Class

A Shares;

iii. the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.15% of the nominal value of the Class

B Shares;

iv. the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.20% of the nominal value of the Class

C Shares;

v. the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.25% of the nominal value of the Class

D Shares;

vi. the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.30% of the nominal value of the Class

E Shares;

vii. the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.35% of the nominal value of the Class

F Shares;

viii. the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.40% of the nominal value of the Class

G Shares;

ix. the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.45% of the nominal value of the Class

H Shares;

9908

L

U X E M B O U R G

x. the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.50% of the nominal value of the Class I

Shares;

xi. the holder(s) of the Class J Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.55% of the nominal value of the Class J

Shares;

the balance shall be distributed to the holder(s) of the relevant Class of Shares pursuant to a decision taken by the

general meeting of Shareholders subject to compliance with the terms of the Shareholders Agreement.

Art. 26. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
26.1 The Board may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the Board

showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits
since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by
losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow
to be distributed.

26.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

H. Liquidation

Art. 27. Liquidation.
27.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

27.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of Shares of the Company held by them subject to compliance with the
terms of the Shareholders Agreement.

I. Final clause - Governing law

Art. 28. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law and any Shareholders Agreement. Inter patres any Shareholders Agreement shall prevail to the extent
permitted.”

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at five thousand seven hundred euro (EUR 5,700,-).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes

Am achtzehnten Tag des Monats Dezember im Jahre zweitausendvierzehn,
vor dem unterzeichnenden Notar Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Diekirch, im Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

1. Firewall Investments S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend nach dem Recht des

Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg, Großherzogtums
Luxemburg, mit einem Grundkapital von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) und eingetragen im Gesellschafts-
und Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 191622,

hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, Anwältin mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht,

und

2. Firewall Management MIP S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in Boulevard de la Foire
1, L-1528 Luxembourg, Großherzogtums Luxemburg, mit einem Stammkapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-) und eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 191637,

hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, Anwältin mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht.

9909

L

U X E M B O U R G

Diese Vollmachten, unterzeichnet mit ne variatur durch die Bevollmächtigte der erschienenen Parteien und den Notar,

verbleiben als Anhang bei dieser Urkunde um zur selben Zeit bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Die erschienenen Parteien sind Gesellschafter und repräsentieren gemeinsam das gesamte Stammkapital der Firewall

Holding S.à r.l. (von hieran die “Gesellschaft”), einer société à responsabilitée limitée mit Gesellschaftssitz in Boulevard
de la Foire 1, L-1528 Luxembourg mit einem Stammkapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ein-
getragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 191674, gegründet entsprechend der
Urkunde des Maître Edouard Delosch, Notar mit Sitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg, am 6. November 2014,
noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Der Gesellschaftsvertrag wurde seitdem
noch nicht geändert.

Die erschienenen Parteien, welche das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten, erklären, unter Verzicht auf

sämtliche  Benachrichtigungserfordernisse,  die  Gesellschafterversammlung  ist  ordnungsgemäß  zusammengetreten,  und
kann wirksam über die folgende Tagesordnung beraten:

<i>Tagesordnung

1. Herabsetzung des Nennwertes von einem Euro (EUR 1,-) auf einen Euro Cent (0,01 EUR).
2. Schaffung einer neuen Anteilsklasse, welche als gewöhnliche Anteile bezeichnet werden (die „Gewöhnliche Anteile“),

mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) und Umwandlung der bestehenden zwölftausendfünfhundert
(12.500) Anteile, unterteilt in tausendzweihundertfünfzig (1.250) Tranche 1 Anteile; tausendzweihundertfünfzig (1.250)
Tranche 2 Anteile; tausendzweihundertfünfzig (1.250) Tranche 3 Anteile; tausendzweihundertfünfzig (1.250) Tranche 4
Anteile; tausendzweihundertfünfzig (1.250) Tranche 5 Anteile; tausendzweihundertfünfzig (1.250) Tranche 6 Anteile; tau-
sendzweihundertfünfzig (1.250) Tranche 7 Anteile; tausendzweihundertfünfzig (1.250) Tranche 8 Anteile; tausendzwei-
hundertfünfzig (1.250) Tranche 9 Anteile; tausendzweihundertfünfzig (1.250) Tranche 10 Anteile, alle mit einem Nennwert
von  einem  Euro  (EUR  1,-),  in  eine  Millionen  zweihundertfünfzigtausend  (1.250.000)  Gewöhnliche  Anteile,  ohne  eine
Rücknahme von Anteilen.

3.  Schaffung  von  neuen  Anteilsklassen  (eine  jede  als  „Anteilsklasse“),  im  Folgenden  als  rücknehmbare  Anteile  der

Anteilsklasse A (die „Anteilsklasse A Anteile“); rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse B (die „Anteilsklasse B Anteile“);
rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse C (die „Anteilsklasse C Anteile“); rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse D (die
„Anteilsklasse D Anteile“); rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse E (die „Anteilsklasse E Anteile“); rücknehmbare An-
teile der Anteilsklasse F (die „Anteilsklasse F Anteile“); rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse G (die „Anteilsklasse G
Anteile“); rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse H (die „Anteilsklasse H Anteile“); rücknehmbare Anteile der Anteils-
klasse I (die „Anteilsklasse I Anteile“); rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse J (die „Anteilsklasse J Anteile“), bezeichnet,
welche jeweils einen Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) haben.

4. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um eine Million Euro (EUR 1.000.000), um das aktuelle Stammkapital

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf eine Million zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 1.012.500,-) zu
erhöhen, durch Ausgabe von zehn Millionen (10.000.000) Anteilsklasse A Anteile; zehn Millionen (10.000.000) Anteils-
klasse B Anteile; zehn Millionen (10.000.000) Anteilsklasse C Anteile; zehn Millionen (10.000.000) Anteilsklasse D Anteile;
zehn Millionen (10.000.000) Anteilsklasse E Anteile; zehn Millionen (10.000.000) Anteilsklasse F Anteile; zehn Millionen
(10.000.000) Anteilsklasse G Anteile; zehn Millionen (10.000.000) Anteilsklasse H Anteile; zehn Millionen (10.000.000)
Anteilsklasse I Anteile; zehn Millionen (10.000.000) Anteilsklasse J Anteile, jeweils mit einem Nennwert von einem Euro
Cent (EUR 0,01).

5. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft.
6. Verschiedenes.

<i>Erster Beschluss

Die  Hauptversammlung  der  Gesellschafter  beschließt  die  Herabsetzung  des  Nennwertes  der  Anteile,  welche  das

Stammkapital bilden von einen Euro (EUR 1,-) auf einen Euro Cent (EUR 0,01).

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt die Schaffung von neuen Anteilsklassen, welche als Gewöhnliche

Anteile bezeichnet werden, mit einem jeweiligen Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) und die Umwandlung der
bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile, unterteilt in tausendzweihundertfünfzig (1.250) Tranche 1 An-
teile; tausendzweihundertfünfzig (1.250) Tranche 2 Anteile; tausendzweihundertfünfzig (1.250) Tranche 3 Anteile; tau-
sendzweihundertfünfzig (1.250) Tranche 4 Anteile; tausendzweihundertfünfzig (1.250) Tranche 5 Anteile; tausendzwei-
hundertfünfzig (1.250) Tranche 6 Anteile; tausendzweihundertfünfzig (1.250) Tranche 7 Anteile; tausendzweihundert-
fünfzig  (1.250)  Tranche  8  Anteile;  tausendzweihundertfünfzig  (1.250)  Tranche  9  Anteile;  tausendzweihundertfünfzig
(1.250) Tranche 10 Anteile, alle mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-), in einer Millionen zweihundertfünfzig-
tausend (1.250.000) Gewöhnliche Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro Cent (EUR 0,01) wie folgt:

(i) elftausend (11,000) Anteile, wiederrum unterteilt in tausendeinhundert (1.100) Tranche 1 Anteile, tausendeinhun-

dert  (1.100)  Tranche  2  Anteile,  tausendeinhundert  (1.100)  Tranche  3  Anteile,  tausendeinhundert  (1.100)  Tranche  4
Anteile, tausendeinhundert (1.100) Tranche 5 Anteile, tausendeinhundert (1.100) Tranche 6 Anteile, tausendeinhundert

9910

L

U X E M B O U R G

(1.100) Tranche 7 Anteile, tausendeinhundert (1.100) Tranche 8 Anteile, tausendeinhundert (1.100) Tranche 9 Anteile,
tausendeinhundert (1.100) Tranche 10 Anteile, welche von Firewall Investments, S.A., wie zuvor erwähnt, gehalten wer-
den, werden zu eine Millionen einhunderttausend (1.100.000) Gewöhnlichen Anteilen mit einem Nennwert von einem
Euro Cent (EUR 0,01) umgewandelt;

(ii) tausendfünfhundert (1,500) Anteile, wiederrum unterteilt in einhundertfünfzig (150) Tranche 1 Anteile, einhun-

dertfünfzig (150) Tranche 2 Anteile, einhundertfünfzig (150) Tranche 3 Anteile, einhundertfünfzig (150) Tranche 4 Anteile,
einhundertfünfzig (150) Tranche 5 Anteile, einhundertfünfzig (150) Tranche 6 Anteile, einhundertfünfzig (150) Tranche 7
Anteile, einhundertfünfzig (150) Tranche 8 Anteile, einhundertfünfzig (150) Tranche 9 Anteile, einhundertfünfzig (150)
Tranche  10  Anteile, welche  von  Firewall  Management MIP,  S.à r.l., wie  zuvor erwähnt, gehalten  werden,  werden zu
einhundertfünfzigtausend (150.000) Gewöhnlichen Anteilen mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) um-
gewandelt;

<i>Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt die Schaffung von neuen Anteilsklasse (jede eine „Anteilsklasse“),

welche im Folgenden Gewöhnliche Anteile als rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse A (die „Anteilsklasse A Anteile“);
rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse B (die „Anteilsklasse B Anteile“); rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse C (die
„Anteilsklasse C Anteile“); rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse D (die „Anteilsklasse D Anteile“); rücknehmbare
Anteile der Anteilsklasse E (die „Anteilsklasse E Anteile“); rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse F (die „Anteilsklasse
F Anteile“); rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse G (die „Anteilsklasse G Anteile“); rücknehmbare Anteile der An-
teilsklasse H (die „Anteilsklasse H Anteile“); rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse I (die „Anteilsklasse I Anteile“);
rücknehmbare Anteile der Anteilsklasse J (die „Anteilsklasse J Anteile“), bezeichnet werden, welche jeweils einen Nenn-
wert von einem Euro Cent (EUR 0,01) haben.

<i>Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt das Stammkapital der Gesellschaft um eine Million Euro (EUR

1.000.000) zu erhöhen, um das aktuelle Stammkapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) auf eine Million
zwölftausendtausendfünfhundert Euro (EUR 1.012.500,-) zu erhöhen, durch Ausgabe von zehn Millionen (10.000.000)
Anteilsklasse A Anteile; zehn Millionen (10.000.000) Anteilsklasse B Anteile; zehn Millionen (10.000.000) Anteilsklasse C
Anteile; zehn Millionen (10.000.000) Anteilsklasse D Anteile; zehn Millionen (10.000.000) Anteilsklasse E Anteile; zehn
Millionen  (10.000.000)  Anteilsklasse  F  Anteile;  zehn  Millionen  (10.000.000)  Anteilsklasse  G  Anteile;  zehn  Millionen
(10.000.000) Anteilsklasse H Anteile; zehn Millionen (10.000.000) Anteilsklasse I Anteile; zehn Millionen (10.000.000)
Anteilsklasse J Anteile, jeweils mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01).

<i>Zeichnung und Einzahlung

Einhundert Millionen (100.000.000) neue Anteile wurden sämtlich wie folgt gezeichnet:
(i) Firewall Investments, S.A., wie zuvor erwähnt, zeichnete siebenundsiebzig Millionen fünfhunderttausendzweihundert

(77.500.200) Anteile zum Preis von zwölf Millionen vierhundertvierzigtausend Euro (EUR 12.440.000,-), die sich wie folgt
zusammensetzen:

a) sieben Millionen siebenhundertfünfzigtausendzwanzig (7.750.020) Anteilsklasse A Anteile;
b) sieben Millionen siebenhundertfünfzigtausendzwanzig (7.750.020) Anteilsklasse B Anteile;
c) sieben Millionen siebenhundertfünfzigtausendzwanzig (7.750.020) Anteilsklasse C Anteile;
d) sieben Millionen siebenhundertfünfzigtausendzwanzig (7.750.020) Anteilsklasse D Anteile;
e) sieben Millionen siebenhundertfünfzigtausendzwanzig (7.750.020) Anteilsklasse E Anteile;
f) sieben Millionen siebenhundertfünfzigtausendzwanzig (7.750.020) Anteilsklasse F Anteile;
g) sieben Millionen siebenhundertfünfzigtausendzwanzig (7.750.020) Anteilsklasse G Anteile;
h) sieben Millionen siebenhundertfünfzigtausendzwanzig (7.750.020) Anteilsklasse H Anteile;
i) sieben Millionen siebenhundertfünfzigtausendzwanzig (7.750.020) Anteilsklasse I Anteile;
j) sieben Millionen siebenhundertfünfzigtausendzwanzig (7.750.020) Anteilsklasse J Anteile;
Die Gesamtsumme von zwölf Millionen vierhundertvierzigtausend Euro (EUR 12.440.000,-) verteilt sich wie folgt:

siebenhundertfünfundsiebzigtausendzwei Euro (EUR 775.002,-) entfallen auf das Stammkapital und elf Millionen sechs-
hundertvierundsechzigtausendneunhundertachtundneunzig (EUR 11.664.998,-) entfällt pro rata auf das Agio der Anteile
jeder Anteilsklasse.

(ii) Firewall Management MIP, S.à r.l., wie zuvor erwähnt, zeichnete zweiundzwanzig Millionen vierhundertneunund-

neunzigtausendachthundert (22.499.800) Anteile zum Preis von drei Millionen sechshundertelftausendfünfhunderteinund-
siebzig Euro (EUR 3.611.571,-), die sich wie folgt zusammensetzen:

a) zwei Millionen zweihundertneunundvierzigtausendneunhundertachtzig (2. 249.980) Anteilsklasse A Anteile;
b) zwei Millionen zweihundertneunundvierzigtausendneunhundertachtzig (2. 249.980) Anteilsklasse B Anteile;
c) zwei Millionen zweihundertneunundvierzigtausendneunhundertachtzig (2. 249.980) Anteilsklasse C Anteile;
d) zwei Millionen zweihundertneunundvierzigtausendneunhundertachtzig (2. 249.980) Anteilsklasse D Anteile;

9911

L

U X E M B O U R G

e) zwei Millionen zweihundertneunundvierzigtausendneunhundertachtzig (2. 249.980) Anteilsklasse E Anteile;
f) zwei Millionen zweihundertneunundvierzigtausendneunhundertachtzig (2. 249.980) Anteilsklasse F Anteile;
g) zwei Millionen zweihundertneunundvierzigtausendneunhundertachtzig (2. 249.980) Anteilsklasse G Anteile;
h) zwei Millionen zweihundertneunundvierzigtausendneunhundertachtzig (2. 249.980) Anteilsklasse H Anteile;
i) zwei Millionen zweihundertneunundvierzigtausendneunhundertachtzig (2. 249.980) Anteilsklasse I Anteile;
j) zwei Millionen zweihundertneunundvierzigtausendneunhundertachtzig (2.249.980) Anteilsklasse J Anteile;
Die Gesamtsumme von drei Millionen sechshundertelftausendfünfhunderteinundsiebzig Euro (EUR 3.611.571,-) verteilt

sich  wie  folgt:  zweihundertvierundzwanzigtausendneunhundertachtundachtzig  Euro  (EUR  224.988,-)  entfallen  auf  das
Stammkapital und drei Millionen dreihundertsechsundachtzigtausendfünfhundertdreiundsiebzig (EUR 3.386.573,-) entfällt
pro rata auf das Agio der Anteile jeder Anteilsklasse.

Die gezeichneten Anteile sind vollständig in bar eingezahlt, sodass der Gesamtbetrag von sechzehn Millionen einund-

fünfzigtausendfünfhunderteinundsiebzig  Euro  (EUR  16.051.571,-)  der  Gesellschaft  von  diesem  Zeitpunkt  an,  wie  dem
unterzeichneten Notar nachgewiesen, zur Verfügung steht.

<i>Sechster Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, die Satzung der Gesellschaft vollständig neu zu fassen, die nun wie

folgt lautet:

A. Definitionen

Abschluss

meint den Abschluss der Übernahme von Waterlogic Plc

Abwicklung

meint ein Angebot mit dem Ziel der Abwicklung, Auflösung oder Liquidation der
Gesellschaft oder anderer Neuer Holding Gesellschaften (einschließlich dem
folgenden Asset Verkauf)

Annahmeperiode

hat die Bedeutung wie in Artikel 8.3 beschrieben

Anteile

meint die Anteile an der Gesellschaft

Asset Verkauf

meint den Verkauf durch die Gesellschaft oder andere Konzernmitglieder oder
Tochterunternehmen von Geschäftsbetrieben, Konzernkapitals und
Konzernunternehmen an einen einzelnen Käufer oder an einen oder mehrere
Käufer als Teil einer einzigen oder einer Reihe von damit in Verbindung stehenden
Transaktionen (anders als Teil einer Reorganisationstransaktion)

Ausstieg

meint Verkauf, Asset Verkauf, Börsengang oder Abwicklung

Belastung

eine Hypothek, Belastung, Verpfändung, Pfandrecht, Option, Einschränkung,
Aktien-Vorkaufsrecht, Bezugsvorrecht, Rechte Dritter oder Beteiligungen,
sonstige Belastungen oder Teile anderer Interessen jeglicher Art oder anderer Art
von Abkommen oder Vereinbarungen mit ähnlicher Wirkung

Benötigter Ausstieg

hat die Bedeutung wie in Artikel 9.1 beschrieben

Börsengang

meint die Aufnahme der gesamten ausgegebenen Anteile der Gesellschaft oder
jeder anderen Gruppengesellschaft (einschließlich jeder Neuen Holding
Gesellschaft) zum Handel an einem regulierten Markt oder jeder anderen
international anerkannten Wertpapierbörse

Drag Übernehmer

hat die Bedeutung wie in Artikel 9.1 beschrieben

Drag-Along Notiz

hat die Bedeutung wie in Artikel 9.2 beschrieben

Dragged Anteile

hat die Bedeutung wie in Artikel 9.2 beschrieben

Dragging Investor

hat die Bedeutung wie in Artikel 9.1 beschrieben

Einberufungschreiben

hat die Bedeutung wie in Artikel 11 beschrieben

Einziehungsbetrag

hat die Bedeutung wie in Artikel 6.13 beschrieben

Geschäftführerrat

hat die Bedeutung wie in Artikel 15.1 beschrieben

Geschäftstag

entspricht jedem anderen Tag außer Samstag, Sonntag oder bankbetrieblichen
oder gesetzlichen Feiertag in England, Luxembourg, München und Frankfurt am
Main, Deutschland

Gesellschaft

Firewall Holding S.à r.l.

Gesellschafterdarlehen

meint die nachrangigen Darlehen ausgegeben nach den
Gesellschafterdarlehnsvereinbaru ngen, welche im Grundkapitalverzeichnis
bezeichnet sind mit jeweils einem Kupon von 10 Prozent

Gesellschafterdarlehensvereinbar
ungen

jede verzinsliche nachrangige Gesellschafterdarlehnsvereinbaru ng, wie im
Grundkapitalverzeichnis bezeichnet

Gesellschaftervereinbarungen

jede Gesellschaftervereinbarung, die zwischen den Gesellschafter eingegangen
werden soll in Bezug auf die Gesellschaft, sofern nötig

9912

L

U X E M B O U R G

Gesetz von 1915

meint das Gesetz vom 10. Agust 1915 über Handelsgesellschaften in seiner
aktuellen Fassung

Gewinnbeteiligung

hat die Bedeutung wie in Artikel 6.13 beschrieben

Grundkapitalverzeichnis

meint ein Dokument was der Gesellschaftervereinbarung angehängt ist und (i) die
gesamte verwässerte Grundkapitalstruktur (ii) die Anzahl, Klasse und
Zeichnungsbeträge der ausgegebenen Anteile an die jeweiligen Gesellschafter und
(iii) die Gesellschafterdarlehen aufzeigt

Gruppe

meint die Gesellschaft und jedes Tochterunternehmen und darunter sind auch zu
verstehen die „Gruppengesellschaft“ und „Gruppenmitglied“

Investor

Firewall Investments, S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) errichtet mit
Sitz in Boulevard de la Foire 1, L-1528, Luxembourg, im Großherzogtum
Luxembourg

Investor Manager

hat die Bedeutung wie in Artikel 16.1 beschrieben

Klassenperiode

hat die Bedeutung wie in Artikel 6.13 beschrieben

Neuausgabe

jede neue Ausgabe von Wertpapieren nach dem Abschluss, außer einer
Ausgeschlossenen Ausgabe

Neue Holding Gesellschaft

meint jede neue Holding-Gesellschaft der Gesellschaft, gegründet zu dem Zweck
eine Reorganisationstransaktion, Refinanzierung oder einen Börsengang zu
ermöglichen

Neuer Gesellschafter

hat die Bedeutung wie in Artikel 9.8 beschrieben

Pro Rata Portion

in Bezug auf jeden Gesellschafter:
für jede Neuausgabe von oder einschließlich Schuldverschreibungen, ein Betrag
berechnet durch Teilung von (i) dem gesamten ausstehenden Betrag (einschließlich
aller unbezahlter Beträge von Kapital und Zinsen) für alle Schuldverschreibungen
gehalten von solche einem Wertpapierhalter durch (ii) den gesamten
ausstehenden Betrag (einschließlich aller unbezahlter Beträge von Kapital und
Zinsen) für alle dann betreffende Schuldverschreibungen und für jede Neuausgabe
von Anteilen, ein Betrag errechnet durch Teilung der Anzahl aller Anteile gehalten
von einem solchen Wertpapierhalter zur jeweiligen Zeit durch die dann in Rede
stehenden Anteile.

Rollover Manager

sind bestimmte Individuen, wessen Namen und Adressen sich aus dem Programm
der Gesellschaftervereinbarungen entnehmen lassen und jede andere Person die
aufgrund einer dieser Gesellschaftervereinbarung entsprechenden Urkunde Teil
dieser Gesellschaftervereinbarung als Rollover Manager ist

Schuldverschreibungen

alle Vorzugsaktien Gesellschafterdarlehen (einschließlich der
Gesellschafterdarlehen), Schuldschein, Vorzugsanteile, und Schuldtitel oder
ähnliche Titel, wonach der Gesellschaft das jeweilige Recht daran zusteht, sie aber
den in den Gesellschaftervereinbarungen und mit ihnen verbundenen relevanten
Instrumenten bestimmten Bedingungen unterliegt

Tag Along Anteil

hat die Bedeutung wie in Artikel 8.1 beschrieben

Tag Along Käufer

hat die Bedeutung wie in Artikel 8.1 beschrieben

Tag Along Notiz

hat die Bedeutung wie in Artikel 8.2 beschrieben

Tag Along Recht

hat die Bedeutung wie in Artikel 8.1 beschrieben

Tag Along Verkauf

hat die Bedeutung wie in Artikel 8.1 beschrieben

Tagging Gesellschafter

hat die Bedeutung wie in Artikel 8.3 beschrieben

Übertragung

(i) jeder direkte oder indirekte Verkauf, Übertragung oder andere Verfügung
(einschließlich vertraglicher Anordnungen, die das ökonomische Risiko und den
Vorteil übertragen oder auf andere Weise den Effekt eines Verkaufs oder
Belastung herbeiführen) von jedweden Anteilen (einschließlich der damit
verbundenen Stimmrechte) (ii) jede Entscheidung (durch Verzicht oder auf andere
Weise) eines Gesellschafters oder anderer Personen die berechtigt sind an einer
Ausgabe oder Übertragung von Anteilen teilzuhaben, sodass die Anteile an jemand
anderen als an ihn ausgegeben und übertragen werden oder (iii) jedwede
Absprache die Vorgenanntes vorsieht

Übrige Gesellschafter

hat die Bedeutung wie in Artikel 9.1 beschrieben

Verfügbarer Betrag

hat die Bedeutung wie in Artikel 6.13 beschrieben

Verkauf

meint den Verkauf und Übertragung von mindestens 75 Prozent der Anteile an
eine dritte Person zu marktüblichen Bedingungen im Rahmen einer einzigen
Transaktion oder einer Reihe von in Verbindung dazu stehenden Transaktionen

9913

L

U X E M B O U R G

Wertpapier

Schuldpapiere und andere Anteile

Wertpapierhalter

jede Person die Wertpapiere hält

Zwischenabschluss

hat die Bedeutung wie in Artikel 6.13 beschrieben

Zwischenabschlussdatum

hat die Bedeutung wie in Artikel 6.13 beschrieben

B. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Firewall Holding, S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“), dieser Satzung und, falls dies der
Fall ist, Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie

solche,  welche  geistiges  Eigentum  oder  Grundeigentum  betreffen  vornehmen,  die  ihr  zur  Erreichung  dieser  Zwecke
förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft ist für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden

welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführerrates verlegt

werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführerrates im Groß-

herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführerrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwick-

lungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

C. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt eine Million zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 1.012.500,-) und

setzt sich zusammen aus:

(a) einer Million (1.000.000) gewöhnlichen Anteilen mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01,-) (die

“Gewöhnlichen Anteile“);

(b) zehn Millionen (10.000.000) Klasse A Anteilen mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01,-) (die

“Klasse A Anteile”);

(c) zehn Millionen (10.000.000) Klasse B Anteilen mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01,-) (die

“Klasse B Anteile”);

(d) zehn Millionen (10.000.000) Klasse C Anteilen mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01,-) (die

“Klasse C Anteile”);

(e) zehn Millionen (10.000.000) Klasse D Anteilen mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01,-) (die

“Klasse D Anteile”);

9914

L

U X E M B O U R G

(f) zehn Millionen (10.000.000) Klasse E Anteilen mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01,-) (die

“Klasse E Anteile”);

(g) zehn Millionen (10.000.000) Klasse F Anteilen mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01,-) (die

“Klasse F Anteile”);

(h) zehn Millionen (10.000.000) Klasse G Anteile mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01,-) (die

“Klasse G Anteile”);

(i) zehn Millionen (10.000.000) Klasse H Anteilen mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01,-) (die

“Klasse H Anteile”);

(j) zehn Millionen (10.000.000) Klasse I Anteilen mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01,-) (die

“Klasse I Anteile”) und

(k) zehn Millionen (10.000.000) Klasse J Anteilen mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01,-) (die

“Klasse J Anteile” und zusammen mit den Klasse A Anteilen, Klasse B Anteilen, Klasse C Anteilen, Klasse D Anteilen,
Klasse E Anteilen, Klasse F Anteilen, Klasse G Anteilen, Klasse H Anteilen und Klasse I Anteilen, die „Klassen“).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für

eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jeder neue Anteil soll, sofern welche bestehen, bevorzugt den bereits existierenden Gesellschafter angeboten

werden.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch die vollständige Einziehung einer oder mehrerer Klassen

herabgesetzt werden, bestehend aus dem Rückkauf und der Einziehung aller ausgegebenen Anteile in einer solchen Klasse,
wie jeweils vom Geschäftsführerrat festgelegt, wobei die Gesellschafter jeder Einziehung im Einklang mit Artikel 6.8ff.
zustimmen.

6.6 Eine Herabsetzung des Gesellschaftskapitals durch den Rückkauf einer Klasse soll nur innerhalb der jeweils gel-

tenden Klassenperiode (wie unten definiert) erfolgen:

i. Die Periode für die Klasse A Anteile ist der Zeitraum beginnend am 18 Dezember 2014 und endend nicht später als

am 31 Dezember 2015 (die “Klasse A Periode").

ii. Die Periode für die Klasse B Anteile ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse A Periode und endend nicht später

als am 31 Dezember 2016 (die “Klasse B Periode").

iii. Die Periode für die Klasse C Anteile ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse B Periode und endend nicht später

als am 31 Dezember 2017 (die “Klasse C Periode").

iv. Die Periode für die Klasse D Anteile ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse C Periode und endend nicht später

als am 31 Dezember 2018 (die “Klasse D Periode").

v. Die Periode für die Klasse E Anteile ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse D Periode und endend nicht später

als am 31 Dezember 2019 (die “Klasse E Periode").

vi. Die Periode für die Klasse F Anteile ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse E Periode und endend nicht später

als am 31 Dezember 2020 (die “Klasse F Periode").

vii. Die Periode für die Klasse G Anteile ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse F Periode und endend nicht später

als am 31 Dezember 2021 (die “Klasse G Periode").

viii. Die Periode für die Klasse H Anteile ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse G Periode und endend nicht

später als am 31 Dezember 2022 (die “Klasse H Periode").

ix. Die Periode für die Klasse I Anteile ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse H Periode und endend nicht später

als am 31 Dezember 2023 (die “Klasse I Periode").

x. Die Periode für die Klasse J Anteile ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse I Periode und endend nicht später

als am 31 Dezember 2024 (die “Klasse J Periode").

6.7 Wenn eine Klasse nicht innerhalb der jeweiligen Klassenperiode zurückgekauft und eingezogen wurde, kann der

Rückkauf und der Einzug einer solchen Klasse während einer neuen Periode (die „Neue Periode“) erfolgen, welche am
Tag nach der letzten Klassenperiode beginnt (oder falls dies der Fall ist, der Tag nach dem Ende der direkt vorangegan-
genen Neuen Periode einer anderen Klasse) und nicht später als ein Jahr nach dem Beginn dieser Neuen Periode endet.
Die  erste  Neue  Periode  soll  am  Tag  nach  der  Klasse  J  Periode  beginnen  und  die  noch  nicht  zurückgekaufte(n)  und
eigezogene(n) Klasse(n) richten sich nach der Reihenfolge von Klasse A bis Klasse J (bis zu dem Maß, dass sie noch nicht
zurückgekauft und eingezogen sind), sofern sie Teil der beginnenden Neuen Periode sind.

9915

L

U X E M B O U R G

6.8 Um Zweifel auszuschießen, im Falle, dass ein Rückkauf und Einzug einer Klasse einen Tag vor dem letzten Tag der

jeweiligen Klassenperiode (oder falls dies der Fall ist, Neuen Periode) stattfindet, soll die sich anschließende Klassenpe-
riode (oder falls dies der Fall ist, Neuen Periode) am Tag nach dem Rückkauf und Einzug der jeweiligen Klasse beginnen
und soll weiterhin am Tage enden, wie in den Artikeln zuvor bestimmt.

6.9 Der Einziehungsbetrag wird für die Gesellschaft fällig und zahlbar an die Gesellschafter pro-rata zu ihrem Anteil an

der jeweiligen Klasse(n) nach Rückkauf und Einzug der gesamten jeweiligen Klasse(n). Um Zweifel auszuschließen erlischt
die Verbindlichkeit der Gesellschaft durch Aufrechnung, Bar- oder Sachzahlung.

6.10 Der Einziehungsbetrag, wie im Absatz zuvor genannt, welcher einbehalten werden soll, soll vom Geschäftsfüh-

rerrat nach billigem Ermessen und im besten Unternehmensinteresse beschlossen werden. Um Zweifel auszuschließen,
der Geschäftsführerrat entscheidet nach seinem eigenen Ermessen, ob er frei verfügbare Reserven ganz oder zum Teil
dem Einziehungsbetrag einverleibt oder herausnimmt.

6.11 Für den Zweck dieser Satzung, sollen die folgenden Begriffe folgende Bedeutung haben:
- „Verfügbarer Betrag“ meint den Gesamtbetrag des Nettogewinns der Gesellschaft (einschließlich Gewinnvorträgen)

erhöht durch (i) jede frei ausschüttbare Rücklage und (ii) falls dies der Fall ist, um den Betrag der Kapitalherabsetzung
und  Herabsetzung  der  gesetzlichen  Rücklage  hinsichtlich  der  einzuziehende  Klasse,  aber  herabgesetzt  um  (i)  jegliche
Verluste (einschließlich Verlustvorträgen) dargestellt als Pluswert, (ii) jegliche Beträge, die gemäß der jeweiligen Zwi-
schenabschlüsse entsprechend dem Gesetz von 1915 oder der Satzung in die Rücklage eingestellt werden müssen (um
Zweifel auszuschließen, ohne doppelte Buchführung), (iii) jegliche Ausschüttungen, die den Inhaber(n) von Gewöhnlichen
Anteilen nach der Satzung zustehen und (iv) jegliche Gewinnbeteiligung, so dass gilt:

AA = (NP + P + CR) - (L + LR + OD + PE)
Wobei gilt:
AA = Verfügbarer Betrag
NP = Nettogewinn (einschließlich Gewinnvorträgen)
P = jede frei ausschüttbare Rücklage
CR = der Betrag der Kapitalherabsertung und Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage hinsichtlich der einzuziehende

Klasse

L = Verluste (einschließlich Verlustvorträgen), dargestellt als Pluswert
LR = jegliche Beträge, die gemäß der jeweiligen Zwischenabschlüsse entsprechend dem Gesetz von 1915 oder der

Satzung in die Rücklage einzustellen sind

OD = jegliche Ausschüttungen, die den Inhaber(n) von Gewöhnlichen Anteilen nach der Satzung zustehen
PE = jegliche Gewinnbeteiligung
Der Verfügbare Betrag muss in den Zwischenabschlüssen für die jeweilige Klassen Periode festgelegt werden und soll

vom Geschäftsführerrat im guten Glauben und mit Blick auf die Unternehmensfortführung bewertet werden.

- „Verfügbare Liquide Mittel“ meinen (i) das gesamte Geld der Gesellschaft (mit Ausnahme von Geld in Termineinlagen

mit einer Restlaufzeit von mehr als sechs (6) Monaten), (ii) jegliche marktgängige Geldmarktinstrumente, Anleihen und
Schuldverschreibungen und jede Forderung, welche nach Ansicht des Geschäftsführerrats innerhalb naher Zukunft an die
Gesellschaft gezahlt werden abzüglich jeglicher Verschuldung oder anderen Schulden der Gesellschaft, welche auf Grund-
lage des Zwischenabschlusses in Bezug auf die jeweilige Klassenperiode (oder Neuen Periode, sofern vorhanden) innerhalb
von weniger als sechs (6) Monaten zu zahlen sind und (iii) alle Vermögenswerte wie Anteile, Aktien oder Wertpapiere
anderer Art, die von der Gesellschaft gehalten werden.

- „Einziehungsbetrag“ meint einen Wert, welcher den Verfügbaren Betrag in Bezug auf die jeweilige Klassenperiode

(oder Neuen Periode, wenn dies der Fall ist) nicht übersteigt, vorausgesetzt, dass der Einziehungsbetrag nicht höher sein
kann als die Verfügbaren Liquiden Mittel in Bezug auf die jeweilige Klassenperiode (oder Neue Periode).

- “Klassenperiode” meint jeweils die Klasse A Periode, die Klasse B Periode, die Klasse C Periode, die Klasse D Periode,

die Klasse E Periode, die Klasse F Periode, die Klasse G Periode, die Klasse H Periode, die Klasse I Periode und die Klasse
J Periode.

- “Zwischenabschluss” meint Zwischenanschlüsse der Gesellschaft am jeweiligen Zwischenabschlussdatum.
- „Zwischenabschlussdatum“ meint das Datum, welches nicht früher als dreißig (30) Tage, aber nicht später als zehn

(10) Tage vor dem Tag des Rückkaufs und Einziehung der jeweiligen Klasse liegt.

- „Gewinnbeteiligung“ meint die Vorzugsdividende der Klassen, ausgenommen von der rückkaufbaren Klasse.

Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

9916

L

U X E M B O U R G

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden nach Artikel 7.5

7.5 Vorbehaltlich jeglicher Vereinbarung der Gesellschafter, jede Person, die Anteile der Gesellschaft hält, oder be-

rechtigt  wird  zu  halten,  darf  eine  Übertragung  von  Anteilen  nicht  ohne  Einwilligung  des  Investors  vornehmen.  Der
Geschäftsführerrat soll jede Eintragung einer angeblichen Übertragung entgegen dieses 7.5 verweigern, sofern nicht der
Investor einwilligt. Dem angeblich Übertragenden stehen keine Rechte gegenüber der Gesellschaft in Bezug auf solche
Anteile zu.

7.7 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.8 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung der

überlebenden Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln der von Ihnen gehaltenen Rechte übertragen werden.
Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden
Ehepartner/in übertragen werden oder jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

7.9 Übertragungen von Anteilen sind ferner Teil von Bestimmungen durch jegliche Gesellschaftervereinbarung, sofern

anwendbar.

Art. 8. Tag Along.
8.1 Vorbehaltlich jeglicher Gesellschaftervereinbarungen, wenn der Investor eine Übertragung von Anteilen vorschlägt

oder Anteile des Investors an eine dritte Person (ein „Tag-Along Käufer“) (der „Tag-Along Verkauf“) Übertragen werden,
soll der Investor dafür sorgen, dass jeder der anderen Gesellschafter die Möglichkeit erhält („Tag Along Recht“) an den
Tag-Along Käufer zu den gleichen Rechten und gleichen Bedingungen die einem solchen Tag-Along Verkauf entsprechen
(einschließlich der Teilnahme an irgendwelchen Treuhandvereinbarungen zu den gleichen Bedingungen), Pro Rata Portion
seiner Anteile zu verkaufen (die „Tag-Along Anteile“). Das Tag-Along Recht gilt nicht für Übertragungen von Anteilen,
die ganz oder teilweise einem Börsengang folgen, welches sich nach Bestimmungen von lock-up Vereinbarungen und/oder
geordneten Vertriebsvereinbarungen richtet.

8.2 Nicht weniger als fünfzehn (15) Geschäftstage vor dem Vollzug eines jedweden angebotenen Tag-Along Verkauf,

soll der Investor der Gesellschaft und den anderen Gesellschaftern eine geschriebene Notiz (eine „Tag-Along Notiz“)
abliefern, welche folgendes enthalten muss (in dem Maße, was nicht in Begleitdokumenten beschrieben ist):

- die Art und Höhe der Gegenleistung welche durch den Tag-Along Käufer pro Anteil zu zahlen ist;
- Angaben zu der Person, welche ein Interesse am Erwerb von einigen Anteilen angezeigt hat und..
- alle anderen wesentlichen Bedingungen, sofern vorhanden, für eine solche Transaktion.
8.3 Wenn ein Gesellschafter es wünscht sein Tag-Along Recht auszuüben (in dem Fall, ein “Tagging Gesellschafter”),

muss der Tagging Gesellschafter dem Investor innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach der Tag-Along Notiz anzeigen,
dass er wünscht sein Tag-Along Recht auszuüben (die „Annahmeperiode“). Jeder Gesellschafter der dem Investor nicht
innerhalb der Annahmeperiode anzeigt, dass er sein Tag-Along Recht ausüben will, wird behandelt als hätte er auf sein
Tag-Along Recht verzichtet.

8.4 Nach Ablauf der Annahmeperiode, soll der Investor jedem Tagging Gesellschafter, nicht weniger als in fünf (5)

Geschäftstagen vor dem Vollzug des angebotenen Tag-Along Verkaufs eine endgültige Vereinbarung (einschließlich aller
Nebentransferinstrumente) zukommen lassen, die den Verkauf seiner Tag-Along Anteile an den Tag-Along Käufer wirk-
sam werden lässt.

8.5 Nicht weniger als zwei (2) Geschäftstage vor der angebotenen Übertragung, soll der Tagging Gesellschafter die

ordnungsgemäß ausgeführten Dokumente an den Investor zurückgeben. Wenn ein Tagging Gesellschafter es nicht schafft
innerhalb von weniger als zwei (2) Geschäftstagen vor der angebotenen Übertragung diesem Artikel 8.5 zu entsprechen,
so gilt als hätte er auf sein Tag-Along Recht verzichtet.

8.6 Jeder Tagging Gesellschafter trägt seinen Anteil an den Kosten des Tag-Along Verkaufs, pro-rata seiner Erlöse, die

er aus dem Tag-Along Vekauf erhalten hat. Jeder Tagging Gesellschafter ist berechtigt seine Gegenleistung zu dem Tag-
Along Verkauf (abzüglich seines Teils an den Kosten des Tag-Along Verkaufs) zur gleichen Zeit wie der Investor zu
erhalten.

8.7 Der Investor liefert oder soll sicherstellen, dass der Tag-Along Käufer solch einen Nachweis über den Vollzug eines

solchen Tag-Along Verkaufs liefert, wie es vernünftigerweise von einem Tagging Gesellschafter gefordert werden kann.

8.8 Wenn einige oder alle Gesellschafter auf ihr Tag-Along Recht verzichten, oder als auf ihr Recht verzichtet zu haben

angesehen werden, so ist dem Tag-Along Verkauf gestattet sich nach folgendem zu richten:

- er ist innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Ablauf der Annahmeperiode (oder, dort wo anti-trust oder regulatorische

Bedingungen vor dem Vollzug des Tag-Along Verkaufs zu erfüllen sind, dem Stoppdatum für die Befriedigung solcher
Bedingungen in der Tag-Along Verkaufsdokumentation (wie zwischen dem Investor und dem Tag-Along Käufer verein-
bart)) vollzogen und

9917

L

U X E M B O U R G

- er erfolgt zu Bedingungen die in wesentlichen Punkten nicht günstiger sind als die in der Tag-Along Notiz angegebenen

Bedingungen.

8.9 Wenn der Tag-Along Verkauf nicht innerhalb der in Artikel 8 angegeben Frist vollzogen ist, soll der Investor

unverzüglich alle Dokumente (sofern vorhanden) an die Tagging Gesellschafter zurückgeben, welche vorher an ihn in
Bezug auf den Tag-Along Verkauf geliefert worden sind und alle Beschränkungen in Bezug auf Übertragungen von Anteilen,
die dem Investor oder solch einem Tagging Gesellschafter gehören oder gehalten werden, welche in dieser Vereinbarung
enthalten sind, treten wieder in Kraft.

9. Drag Along.
9.1 Wünscht der Investor eine Übertragung seiner Anteile im Zusammenhang mit einem Ausstieg (der „Dragging

Investor“), so soll der Investor das Recht haben, dass alle anderen Gesellschafter (die „Übrigen Gesellschafter“) dazu
verpflichtet  sind auf  einer  pro  rata  Basis einen  entsprechenden  Teil ihrer  jeweiligen Anteile an den vorgeschlagenen
Erwerber zu übertragen (der „Drag Übernehmer“) (ein „Benötigter Ausstieg“).

9.2 Der Investor kann einen Benötigten Ausstieg durch eine schriftliche Notiz (die „Drag-Along Notiz“) auslösen, die

er zehn (10) Geschäftstage vor dem voraussichtlichen Abschlussdatum eines solchen Benötigten Ausstiegs an die Übrigen
Gesellschafter richtet. Die Drag-Along Notiz soll enthalten:

- dass die Übrigen Gesellschafter verpflichtet sind im Falle eines Benötigten Ausstieges all ihre Anteile zu übertragen

(„Dragged Anteile“);

- die Person an die, die Dragged Anteile zu Übertragen sind;
- die Gegenleistung für die Dragged Anteile, welche nicht weniger günstigen Bedingungen (einschließlich irgendwelcher

Nebenabsprachen zu wesentlichen Punkten zu gleichen Bedingungen) für jeden Dragged Anteil folgen soll, als für den
entsprechenden Anteil, welcher von dem Dragging Investor verkauft wird (und, zu diese Zwecken, gilt als hätten die
Gewöhnlichen Anteile eine eigene Anteilsklasse gebildet und auch als hätten die Gesellschafterdarlehen eine eigene An-
teilsklasse gebildet) und..

- die Bedingungen eines geplanten Zeitpunkts für die Übertragung.
9.3 Wenn ein Drag Übernehmer anbietet, dass er einen Teil der gegenüber dem Dragging Investor oder den Übrigen

Gesellschaftern fälligen Gegenleistung in einer nicht zahlungswirksamen Weise als Teil des Benötigten Ausstiegs zu zahlen,
soll in diesem Fall jeder von den Dragging Investoren und den Übrigen Gesellschaftern die fällige Gegenleistung von dem
Drag Übernehmer in Bar- und Sachleistungen zu gleichen Verhältnis erhalten.

9.4 Die Gültigkeit eines Drags gemäß diesen Bestimmungen soll nicht durch das Angebot des Drag Übernehmers von

unterschiedlichen Formen von Gegenleistungen an die Dragging Investoren und/oder den Übrigen Gesellschaftern berührt
werden:

- am Tag der Übertragung, der Wert der pro Dragged Anteil angebotenen Gegenleistung ist mindestens gleich dem

angebotenen Wert des entsprechenden Anteils des Dragging Investors und..

- in dem Maße, dass die Dragging Investoren Bargeld als Gegenleistung für ihre Anteile erhalten, jeder Übrige Gesell-

schafter soll auch berechtigt sein Bargeld als Gegenleistung zu erhalten, entsprechend den gleichen Bedingungen wie für
die Dragging Investoren in Bezug auf die gleiche Anteilsklasse und dem gleichen Teil.

9.5 Der Drag-Along Notiz sollen Kopien aller Dokumente beigefügt sein, welche durch die Übrigen Gesellschafter

auszuführen sind, um dem Benötigten Ausstieg Wirksamkeit zu verleihen und solch ein Benötigter Ausstieg soll, gemäß
Artikel 9.3, nicht weniger günstigen Bedingungen unterliegen als solche, die zwischen den Dragging Investoren und dem
Drag Übernehmer vereinbart worden sind.

9.6 Jeder Übrige Gesellschafter ist nach Erhalt der Drag-Along Notiz und den Begleitdokumenten zu folgendem ver-

pflichtet:

- Verkauf aller ihrer Dragged Anteile und Teilnahme am Benötigten Ausstieg (einschließlich dem Geben von Sicher-

heiten an dem Titel ihrer Dragged Anteile und der Fähigkeit die Dragged Anteile auf derselben Basis als die Dragging
Investoren zu übertragen);

- Rückgabe der ordnungsgemäß ausgeführten Dokumente an den Investor nicht später als zwei (2) Geschäftstage vor

dem voraussichtlichen Datum der Übertragung;

- Wahl ihrer Anteile zugunsten des Benötigten Ausstiegs bei jeder Gesellschafterversammlung (oder jeder Klasse

davon) einberufen zur Abstimmung oder Genehmigung des Benötigten Ausstiegs und/oder schriftlichen Genehmigung
des Benötigten Ausstiegs;

- Sicherstellung (soweit ihnen vernünftigerweise möglich), dass jeder von ihr ernannte Geschäftsführer der Gesellschaft

zugunsten des Benötigten Ausstiegs stimmt und..

- Tragung von einem Teil der Kosten des Benötigten Ausstiegs im gleichen Verhältnis der Gegenleistung (in welcher

Form auch immer), die sie von ihm erhalten haben, zu der angemessenen Gegenleitung, welche entsprechend dem Be-
nötigten Ausstieg bezahlt wurde.

9.7 Nichts in diesem Artikel 8 verlangt von dem Drag Übernehmer den Rollover Managern gleiche Behandlung anzu-

bieten in Bezug auf jegliche Möglichkeit Anteile an der Drag Übernehmer Eigentümerstruktur zu erwerben.

9918

L

U X E M B O U R G

9.8 Im Anschluss an die Ausstellung einer Drag-Along Notiz, jede Person die neue oder zusätzliche Anteile ausgibt

oder erwirbt (ein „Neuer Gesellschafter“), eine Drag-Along Notiz wird als an einen solchen Neuen Gesellschafter be-
reitgestellt angesehen zu den gleichen Bedingungen wie der vorherigen Drag-Along Notiz. Der Neue Gesellschafter wird
verpflichtet solch neue von ihm erworbenen Anteile an den Drag Übernehmer zu verkaufen und zu übertragen oder aber,
falls dies direkt und dafür gelten die Bedingungen des Artikel 23 an den Neuen Gesellschafter (mit der nötigen Änderung)
in Bezug auf seine Beteiligung an solch neuen Anteilen.

9.9 Wenn der Vollzug des Benötigten Ausstiegs nicht frühestens (i) am einhundertzwanzigsten (120) Tag nach dem

Tag der Drag-Along Notiz vollendet ist oder (ii) der Investor eine schriftliche Notiz an die Übrigen Gesellschafter ver-
sendet worin angegeben ist, dass der Benötigte Ausstieg nicht vollendet wird, soll die Drag-Along Notiz außer Kraft treten
und jeder Übrige Gesellschafter soll unwiderruflich von den Bedingungen der Drag-Along Notiz befreit werden und die
Rechte des Investors gemäß Artikel 9 treten wieder in Kraft.

D. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 10. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
10.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz

und diese Satzung übertragen wurden.

10.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
10.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich ge-
fasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und
übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

10.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 11. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesell-

schafter  hat,  muss  jährlich  innerhalb  von  sechs  (6)  Monaten  vor  dem  Ende  des  Geschäftsjahres  mindestens  eine
Gesellschafterversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abge-
halten werden, wie im Einberufungsschreiben, welche Tagesordnung, Ort und Zeitpunkt, zu dieser Versammlung genauer
bestimmt (das „Einberufungsschreiben“). Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in dem entsprechenden Einberufungsschreiben genauer bestimmt werden. Alle Einberufungen sollen den Ge-
sellschaftern mindestens zehn (10) Geschäftstage vor jeder Versammlung zugestellt werden, es sei denn der Geschäfts-
führerrat bestimmt eine kürzere Frist. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und
auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige An-
kündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 12. Quorum und Abstimmung.
12.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
12.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,

bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben und zu jeder Zeit den Investor umfassen. Falls eine solche Mehrheit nicht erreicht
wird innerhalb einer halben Stunde seit der einberufenen Zeit oder dass eine Mehrheit während der Versammlung für
mehr als 10 Minuten zusammenbricht, soll die Versammlung für vier (4) Wochen vertagt werden, wobei die Versammlung
beschlussfähig sein wird unabhängig von der Abwesenheit von Rollover Managern. Falls diese Mehrheit in einer ersten
Gesellschafterversammlung oder einer ersten schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können
die Gesellschafter ein weiteres Mal mit derselben Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben
schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Entscheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgege-
benen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 13. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 14. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

E. Geschäftsführung

Art. 15. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführerrates.
15.1 Vorbehaltlich anderer Gesellschaftervereinbarungen, wird Gesellschaft die durch einen oder mehrere Geschäfts-

führer  geleitet.  Falls  die  Gesellschaft  mehrere  Geschäftsführer  hat,  bilden  diese  einen  Geschäftsführerrat  (den  “Ge-
schäftsführerrat“).

9919

L

U X E M B O U R G

15.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-

führer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführerrat“ als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

15.3 Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln und

alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

15.4 Die Gesellschaft bevollmächtigt die EPIC I GP,S.à r.l., eine GmbH (société à responsabilité limitée) mit Sitz am

Boulevard de la Foire 1, L-1528 Großherzogtum Luxembourg eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B186222
(die „Bevollmächtigte“) die Gesellschaft selbst, mit Untervertretungsvollmacht, in ihrem Namen bei jeder Aktionärs- oder
Interessenversammlung oder schriftlichen Beschlüssen von Unternehmen, Gesellschaften oder anderen juristischen Per-
sonen an denen die Gesellschaft Aktien, Anteile oder andere Interessen hält nur in Bezug auf (i) die Bestellung und
Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern, Geschäftsführern oder anderen Mitgliedern von führenden, beherrschenden
oder überwachenden Organen an deren Entscheidung die Gesellschaft mitzuwirken hat und (ii) Änderungen von diesen
Satzungen, von Gesellschaftsverträgen oder Geschäftsordnungen, welche die Bestellung oder Abberufung von Verwal-
tungsratsmitgliedern, Geschäftsführern oder anderen Mitgliedern von führenden, beherrschenden oder überwachenden
Organen betreffen und an deren Entscheidung die Gesellschaft mitzuwirken hat, zu vertreten.

Art. 16. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
16.1 Vorbehaltlich anderer Gesellschaftervereinbarungen, und im Einklang mit Artikel 15.4, erhält der Investor das

Recht für die Wahl des Geschäftsführerrates Vorschläge zu machen (die „Investor Managers“ und „Investor Manager“
soll gleichbedeutend ausgelegt werden), vorausgesetzt, dass die Rollover Manager berechtigt werden und gemäß den
Bedingungen von Gesellschaftervereinbarungen, dass sie einen (1) Geschäftsführer für die Wahl benennen der kein Roll-
over Manager ist. Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge
und Amtszeit festlegt und Artikel 15.4 entspricht.

16.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Gesellschafterbeschluss, die mehr als die Hälfte

des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.

Art. 17. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
17.1 Vorbehaltlich anderer Gesellschaftervereinbarungen, scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähig-

keit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen
Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten
Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften und
Artikel 13.4 über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

17.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-

züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 18. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1  Vorbehaltlich  anderer  Gesellschaftervereinbarungen,  der  Geschäftsführerrat  versammelt  sich  auf  Einberufung

eines Mitglieds. Die Geschäftsführerratssitzungen finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der
Gesellschaft statt.

18.2 Vorbehaltlich anderer Gesellschaftervereinbarungen, die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24)

Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats schriftlich geladen mit den
wichtigen Dokumenten, aus der sich ergibt was Thema der Sitzung ist außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Geschäftsführer
schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben,
wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen
des Geschäftsführerrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsfüh-
rerrats bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

18.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführerrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.

Art. 19. Durchführung von Geschäftsführer-ratssitzungen.
19.1 Der Geschäftsführerrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen, vorausgesetzt, dass der

Vorsitzende für die Wahl von einem Investor Manager vorgeschlagen worden ist. Der Geschäftsführerrat kann auch einen
Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführerrats sein muss und der für die Proto-
kollführung  der  Sitzungen  des  Geschäftsführerrats  verantwortlich  ist.  Der  Vorsitzende,  falls  vorhanden,  hat  keine
ausschlaggebende Stimme.

19.2  Sitzungen  des  Geschäftsführerrats  werden,  falls  vorhanden,  durch  den  Vorsitzenden  des  Geschäftsführerrats

geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrats durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

9920

L

U X E M B O U R G

19.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein

anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kom-
munikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied
des Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

19.4 Eine Sitzung des Geschäftsführerrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes

Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und
tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleich-
bedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft
abgehalten erachtet.

19.5 Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist und mindestens einen (1) Investor Manager umfasst.

19.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführerrats teil-

nehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst, vorausgesetzt, dass wenn die Mehrheit der Investor für oder gegen
eine Sache stimmt, gilt ebendiese Mehrheit als die Mehrheit der Stimmen bei der Sitzung des Geschäftsführerrats. Der
Vorsitzende des Geschäftsführerrats, falls vorhanden, hat im Falle von Stimmgleichheit die entscheidende Stimme.

19.7 Der Geschäftsführerrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per

Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

19.8 Die Mehrheit der Geschäftsführerratssitzungen soll im Großherzogtum Luxembourg am Sitz der Gesellschaft

stattfinden oder an jedem anderen Ort in Luxembourg, welcher sich aus dem Einberufungsschreiben einer solche Sitzung
ergibt.

Art. 20. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
20.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführerrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführerrates (falls vor-

handen) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem
Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführer-
rates (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet.

20.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-

schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.

Art. 21. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) durch die

gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, oder durch (ii) die gemeinsame Unterschrift oder die
alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat übertra-
gen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis wirksam verpflichtet.

Art. 22. Interessenskonflikt. Dort wo ein Geschäftsführer ein Interesse hat, bei welchem vernünftigerweise als wahr-

scheinlich anzusehen ist, zu einem persönlichen oder beruflichen Interessenskonflikt zu führen, soll der Geschäftsführer,
wenn dies vom Geschäftsführerrat gefordert, solche Schritte unternehmen, die nötig oder wünschenswert sind um einen
solchen Interessenskonflikt zu lösen, einschließlich der Einhaltung von den Bedingungen die vom Geschäftsführerrat zur
Lösung solcher Interessenskonflikte (wenn vorhanden) beschlossen wurden und/oder anderen Verfahren, die durch den
Verwaltungsrat beschlossen worden sind mit dem Ziel oder der Verbindung entsprechend der in Frage stehenden Situ-
ation oder Sache, einschließlich, ohne Beschränkung:

- fernhalten seinerseits von jeder Verwaltungsratssitzung (oder einem Ausschuss davon), die die in Frage stehende

Situation oder Sache zum Gegenstand hat und..

- keinen Einblick zu nehmen in Dokumente oder Informationen, welche dem Geschäftsführerrat (oder jedem Ausschuss

davon) zugänglich gemacht worden sind in Verbindung mit dieser Situation oder Sache und/oder zusammenstellen von
solchen Dokumenten oder Informationen, die von einem professionellen Berater überprüft werden sollen, um das Aus-
maß zu ermitteln, ob er für den Zugang zu solchen Dokumenten oder Informationen geeignet ist.

F. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 23. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
23.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

23.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
23.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

9921

L

U X E M B O U R G

23.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend

das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss von Unternehmen in seiner ge-
änderten Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

23.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

G. Geschäftsjahr - Jahresabschlussgewinne - Abschlagsdividenden

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 25. Jahresabschluss und Gewinn.
25.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführerrat erstellt im Einklang

mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.

25.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

25.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

25.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

25.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführerrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit dem Gesetz

von 1915, den Bestimmungen dieser Satzung und jeder Gesellschaftervereinbarung, wie der verbleibende Bilanzgewinn
der Gesellschaft verwendet werden soll.

25.6 Vorbehaltlich anderer Gesellschaftervereinbarungen, sollen Ausschüttungen in folgender Reihenfolge zugeordnet

und verteilt werden:

i. die Inhaber von Gewöhnlichen Anteilen sind berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,60% des Nominalwertes

von Gewöhnlichen Anteilen;

ii. die Inhaber von Klasse A Anteilen sind berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,10% des Nominalwertes von

Klasse A Anteilen;

iii. die Inhaber von Klasse B Anteilen sind berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,15% des Nominalwertes von

Klasse B Anteilen;

iv. die Inhaber von Klasse C Anteilen sind berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,20% des Nominalwertes von

Klasse C Anteilen;

v. die Inhaber von Klasse D Anteilen sind berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,25% des Nominalwertes von

Klasse D Anteilen;

vi. die Inhaber von Klasse E Anteilen sind berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,30% des Nominalwertes von

Klasse E Anteilen;

vii. die Inhaber von Klasse F Anteilen sind berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,35% des Nominalwertes von

Klasse F Anteilen;

viii. die Inhaber von Klasse G Anteilen sind berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,40% des Nominalwertes von

Klasse G Anteilen;

ix. die Inhaber von Klasse H Anteilen sind berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,45% des Nominalwertes von

Klasse H Anteilen;

x. die Inhaber von Klasse I Anteilen sind berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,50% des Nominalwertes von

Klasse I Anteilen;

xi. die Inhaber von Klasse J Anteilen sind berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,55% des Nominalwertes von

Klasse J Anteilen;

der Restbetrag soll an die Inhaber der jeweiligen Anteilsklasse ausgeschüttet werden entsprechend der Entscheidung

der Gesellschafterversammlung gemäß den Bestimmungen in der Gesellschaftervereinbarung.

Art. 26. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
26.1 Der Geschäftsführerrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom

Geschäftsführerrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung
stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen
Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert
durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer Rücklage zugeführt
werden müssen, übersteigen.

9922

L

U X E M B O U R G

26.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

H. Liquidation

Art. 27. Liquidation.
27.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

27.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt, gemäß den
Bestimmungen in der Gesellschaftervereinbarung..

I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 28. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Kosten und Ausgaben

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass

dieser Beschlüsse entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünftausendsiebenhundert Euro (EUR 5.700,-).

Diese notarielle Urkunde wurde in Luxemburg an dem am Anfang dieses Dokuments genannten Tag aufgenommen.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der er-

schienenen Parteien auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und auf Anfrage derselben
erschienenen Parteien im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung
vorrangig sein soll.

Nachdem dieses Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vorn-

amen und Wohnort bekannt ist, vorgelesen worden ist, unterzeichnete die Bevollmächtigte der erschienen Parteien dieses
Dokument zusammen mit dem Notar.

Gezeichnet: J. SZAFRANSKA, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 19 décembre 2014. Relation: DIE/2014/16491. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 30. Dezember 2014.

Référence de publication: 2015000245/1497.
(140235246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Eurofins International Holdings LUX, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.000.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 157.959.

L'an DEUX-MILLE QUATORZE, le vingt-deux décembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signée.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée dénommée «Eurofins International Holdings

LUX», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, constituée suivant acte reçu par-devant Maître Blanche
Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxembourg en date du 20 décembre 2010 publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-507 le 17 mars 2011. Les statuts de la
société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 9 juillet 2013 publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-2092 le 28 août 2013.

La séance est ouverte à 10:00 heures, sous la présidence de Judit Nadhazi, demeurant professionnellement à Bruxelles

BE-1950, Chaussée de Malines 455.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Anthony THILLMANY, demeurant profes-

sionnellement à Esch-sur-Alzette.

9923

L

U X E M B O U R G

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les TRENTE MIL-

LIONS (30.000.000) parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (EUR 1,-) chacune, représentant l’intégralité du
capital social de TRENTE MILLIONS D'EUROS (EUR 30.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée,
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l’associé représenté demeureront annexées aux présentes avec

lesquelles elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation de capital pour le porter de TRENTE MILLIONS D'EUROS (EUR 30.000.000,-) à TRENTE-DEUX

MILLIONS D'EUROS (EUR 32.000.000,-) par la création et l’émission de DEUX MILLIONS (2.000.000) parts sociales
nouvelles ayant une valeur nominale de UN EURO (EUR 1,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les
anciennes, en contrepartie d'un apport d'une créance de CENT TRENTE-QUATRE MILLIONS VINGT MILLE EUROS
(EUR  134.020.000,-)  dont  DEUX  MILLIONS  D'EUROS  (EUR  2.000.000,-)  seront  alloués  au  capital  social  et  CENT
TRENTE-DEUX MILLIONS VINGT MILLE EUROS (EUR 132.020.000,-) seront alloués à la prime d'émission.

2.-  Souscription  et  libération  de  DEUX  MILLIONS  (2.000.000)  parts  sociales  par  la  société  dénommée  «Eurofins

Scientific S.E.», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B167775, libéré intégralement moyennant l’apport d'une créance d'un
montant de CENT TRENTE-QUATRE MILLIONS VINGT MILLE EUROS (EUR 134.020.000,-).

3.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
4.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de porter le capital social de TRENTE MILLIONS D'EUROS (EUR 30.000.000,-) à TREN-

TE-DEUX  MILLIONS  D'EUROS  (EUR  32.000.000,-)  par  voie  d'augmentation  de  capital  à  concurrence  de  DEUX
MILLIONS D'EUROS (EUR 2.000.000,-) par la création et l’émission de DEUX MILLIONS (2.000.000) parts sociales
nouvelles ayant une valeur nominale de UN EURO (EUR 1,-) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les
parts sociales anciennes.

Cette  augmentation  de  capital  sera  réalisée  par  un  apport  en  nature  d'un  montant  de  CENT  TRENTE-QUATRE

MILLIONS VINGT MILLE EUROS (EUR 134.020.000,-) dont DEUX MILLIONS D'EUROS (EUR 2.000.000,-) seront al-
loués au capital social et CENT TRENTE-DEUX MILLIONS VINGT MILLE EUROS (EUR 132.020.000,-) seront alloués à
la prime d'émission, par la création et l’émission de DEUX MILLIONS (2.000.000) parts sociales nouvelles, constitué par
une créance envers la société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des DEUX MILLIONS (2.000.000) parts sociales nouvelles l’associé

actuel suivant:

- la société dénommée «Eurofins Scientific S.E.», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, immatri-

culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B167775,

Laquelle a déclaré souscrire les DEUX MILLIONS (2.000.000) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par

incorporation au capital social, la renonciation définitive et irrévocable et la conversion en capital d'une créance certaine,
liquide et exigible d'un montant de CENT TRENTE-QUATRE MILLIONS VINGT MILLE EUROS (EUR 134.020.000,-)
existant à son profit et détenue envers la société «Eurofins International Holdings LUX», préqualifiée, et en annulation
de cette même créance à due concurrence.

Cet apport fait l’objet d'un rapport établi en date du 18 décembre 2014 par le conseil de gérance, et qui conclut de la

manière suivante:

<i>"Conclusion

Sur base de nos diligences, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la valeur globale de l’apport

ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale ainsi qu'à la prime d’émission des parts sociales de la
Société à émettre en contrepartie.".

Lequel rapport après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant demeurera annexé

aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

'' Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de TRENTE-DEUX MILLIONS D'EUROS (EUR 32.000.000,-) représenté

par TRENTE-DEUX MILLIONS (32.000.000) parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (EUR 1,-) chacune.

9924

L

U X E M B O U R G

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.''.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à € 6.700.-.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: NADHAZI, THILLMANY, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23/12/2014. Relation: EAC/2014/18004. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 30/12/2014.

Référence de publication: 2015000210/91.
(140234712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Eurofins GSC LUX, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.500.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 121.155.

L'an DEUX-MILLE QUATORZE, le vingt-deux décembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signée.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée dénommée «Eurofins GSC LUX», ayant son

siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, constituée suivant acte reçu par-devant Maître Paul Bettingen, notaire
de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg en date du 25 octobre 2006 publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-2353 le 16 décembre 2006. Les statuts de la société ont été
modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 21 décembre 2012 publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-340 le 12 février 2013.

La séance est ouverte à 10:00 heures, sous la présidence de Judit Nadhazi, demeurant professionnellement à Bruxelles

BE-1950, Chaussée de Malines 455.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Anthony THILLMANY, demeurant profes-

sionnellement à Esch-sur-Alzette.

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les HUIT MILLE

(8.000) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune, représentant l’inté-
gralité du capital social de UN MILLION D'EUROS (EUR 1.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée,
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l’associé représenté demeureront annexées aux présentes avec

lesquelles elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation de capital pour le porter de UN MILLION D'EUROS (EUR 1.000.000,-) à UN MILLION CINQ CENT

MILLE EUROS (EUR 1.500.000,-) par la création et l’émission de QUATRE MILLE (4.000) parts sociales nouvelles ayant
une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations
que les anciennes, en contrepartie d'un apport d'une créance de SEIZE MILLIONS VINGT-DEUX MILLE EUROS (EUR
16.022.000,-) dont CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 500.000,-) seront alloués au capital social et QUINZE MILLIONS
CINQ CENT VINGT-DEUX MILLE EUROS (EUR 15.522.000,-) seront alloués à la prime d'émission.

2.- Souscription et libération de QUATRE MILLE (4.000) parts sociales par la société dénommée «Eurofins International

Holdings LUX», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B157959, libéré intégralement moyennant l’apport d'une créance d'un
montant de SEIZE MILLIONS VINGT-DEUX MILLE EUROS (EUR 16.022.000,-).

3.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.

9925

L

U X E M B O U R G

4.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de porter le capital social de UN MILLION D'EUROS (EUR 1.000.000,-) à UN MILLION

CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 1.500.000,-) par voie d'augmentation de capital à concurrence de CINQ CENT MILLE
EUROS (EUR 500.000,-) par la création et l’émission de QUATRE MILLE (4.000) parts sociales nouvelles ayant une valeur
nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les parts
sociales anciennes.

Cette augmentation de capital sera réalisée par un apport en nature d'un montant de SEIZE MILLIONS VINGT-DEUX

MILLE EUROS (EUR 16.022.000,-) dont CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 500.000,-) seront alloués au capital social et
QUINZE MILLIONS CINQ CENT VINGT-DEUX MILLE EUROS (EUR 15.522.000,-) seront alloués à la prime d'émission,
par la création et l’émission de QUATRE MILLE (4.000) parts sociales nouvelles, constitué par une créance envers la
société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des QUATRE MILLE (4.000) parts sociales nouvelles l’associé actuel

suivant:

- la société dénommée «Eurofins International Holdings LUX», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val

Fleuri, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B157959,

Laquelle a déclaré souscrire les QUATRE MILLE (4.000) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par in-

corporation au capital social, la renonciation définitive et irrévocable et la conversion en capital d'une créance certaine,
liquide et exigible d'un montant de SEIZE MILLIONS VINGT-DEUX MILLE EUROS (EUR 16.022.000,-) existant à son
profit et détenue envers la société «Eurofins GSC LUX», préqualifiée, et en annulation de cette même créance à due
concurrence.

Cet apport fait l’objet d'un rapport établi en date du 18 décembre 2014 par le conseil de gérance, et qui conclut de la

manière suivante:

<i>"Conclusion

Sur base de nos diligences, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la valeur globale de l’apport

ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale ainsi qu'à la prime d’émission des parts sociales de la
Société à émettre en contrepartie.".

Lequel rapport après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant demeurera annexé

aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

'' Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 1.500.000,-) repré-

senté par DOUZE MILLE (12.000) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-)
chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.''.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à € 5.200.-.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: NADHAZI, THILLMANY, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23/12/2014. Relation: EAC/2014/17998. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 30/12/2014.

Référence de publication: 2015000208/91.
(140234613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

9926

L

U X E M B O U R G

Eurofins Forensics LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 310.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 154.225.

L'an DEUX-MILLE QUATORZE, le vingt-deux décembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signée.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée dénommée «Eurofins Forensics LUX Hold-

ing», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, constituée suivant acte reçu pardevant Maître Blanche
Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxembourg en date du 13 juillet 2010 publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-1696 le 19 août 2010. Les statuts de la
société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 18 décembre 2013 publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-356 le 7 février 2014.

La séance est ouverte à 10:00 heures, sous la présidence de Judit Nadhazi, demeurant professionnellement à Bruxelles

BE-1950, Chaussée de Malines 455.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Anthony Thillmany, demeurant profession-

nellement à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les TROIS MILLE

(3.000) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de TROIS CENT MILLE EUROS (EUR 300.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en con-
séquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l’associé représenté demeureront annexées aux présentes avec

lesquelles elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation de capital pour le porter de TROIS CENT MILLE EUROS (EUR 300.000,-) à TROIS CENT DIX

MILLE EUROS (EUR 310.000,-) par la création et l’émission de CENT (100) parts sociales nouvelles ayant une valeur
nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les anciennes, en contre-
partie d'un apport d'une créance de TROIS CENT TRENTE-TROIS MILLE EUROS (EUR 333.000,-) dont DIX MILLE
EUROS (EUR 10.000,-) seront alloués au capital social et TROIS CENT VINGT-TROIS MILLE EUROS (EUR 323.000,-)
seront alloués à la prime d'émission.

2.- Souscription et libération de CENT (100) parts sociales par la société dénommée «Eurofins France Holding», ayant

son siège social à F-44300 Nantes (France), Rue Pierre Adolphe Bobierre, Bâtiment Site de la Géraudière, immatriculée
auprès du registre de commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro TI 528 643 000, libéré intégralement moyen-
nant l’apport d'une créance d'un montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS MILLE EUROS (EUR 333.000,-).

3.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
4.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de porter le capital social de TROIS CENT MILLE EUROS (EUR 300.000,-) à TROIS CENT

DIX MILLE EUROS (EUR 310.000,-) par voie d'augmentation de capital à concurrence de DIX MILLE EUROS (EUR
10.000,-) par la création et l’émission de CENT (100) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de CENT EUROS
(EUR 100,-) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les parts sociales anciennes.

Cette augmentation de capital sera réalisée par un apport en nature d'un montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS

MILLE EUROS (EUR 333.000,-) dont DIX MILLE EUROS (EUR 10.000,-) seront alloués au capital social et TROIS CENT
VINGT-TROIS MILLE EUROS (EUR 323.000,-) seront alloués à la prime d'émission, par la création et l’émission de CENT
(100) parts sociales nouvelles, constitué par une créance envers la société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des CENT (100) parts sociales nouvelles l’associé actuel suivant:
-  la  société  dénommée  «Eurofins  France  Holding»,  ayant  son  siège  social  à  F-44300  Nantes  (France),  Rue  Pierre

Adolphe Bobierre, Bâtiment Site de la Géraudière, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro TI 528 643 000,

9927

L

U X E M B O U R G

Laquelle a déclaré souscrire les CENT (100) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par incorporation au

capital social, la renonciation définitive et irrévocable et la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible
d'un montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS MILLE EUROS (EUR 333.000,-) existant à son profit et détenue envers
la société «Eurofins Forensics LUX Holding», préqualifiée, et en annulation de cette même créance à due concurrence.

Cet apport fait l’objet d'un rapport établi en date du 18 décembre 2014 par le conseil de gérance, et qui conclut de la

manière suivante:

<i>"Conclusion

Sur base de nos diligences, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la valeur globale de l’apport

ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale ainsi qu'à la prime d’émission des parts sociales de la
Société à émettre en contrepartie.".

Lequel rapport après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant demeurera annexé

aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

'' Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de TROIS CENT DIX MILLE EUROS (EUR 310.000,-) représenté par

TROIS MILLE CENT (3.100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.''.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à € 1.800.-.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: NADHAZI, THILLMANY, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23/12/2014. Relation: EAC/2014/18002. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 30/12/2014.

Référence de publication: 2015000207/88.
(140234650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Eurofins Hydrologie France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 165.611.

L'an DEUX-MILLE QUATORZE, le vingt-deux décembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signée.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée dénommée «Eurofins Hydrologie France LUX

Holding», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, constituée suivant acte reçu par-devant Maître
Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxembourg en date du 22 décembre 2011
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-265 le 31 janvier 2012. Les statuts
de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 18 décembre 2013 publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-318 le 4 février 2014.

La séance est ouverte à 10:00 heures, sous la présidence de Judit Nadhazi, demeurant professionnellement à Bruxelles

BE-1950, Chaussée de Malines 455.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Anthony Thillmany, demeurant profession-

nellement à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les MILLE SEPT

CENT CINQUANTE (1.750) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, représentant

9928

L

U X E M B O U R G

l’intégralité du capital social de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (EUR 175.000,-) sont dûment représentées
à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée
ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l’associé représenté demeureront annexées aux présentes avec

lesquelles elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation de capital pour le porter de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (EUR 175.000,-) à CINQ

CENT MILLE EUROS (EUR 500.000,-) par la création et l’émission de TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE (3.250)
parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, investies des mêmes droits et
obligations que les anciennes, en contrepartie d'un apport d'une créance de DOUZE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-
HUIT MILLE EUROS (EUR 12.668.000,-) dont TROIS CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (EUR 325.000,-) seront alloués
au capital social et DOUZE MILLIONS TROIS CENT QUARANTE-TROIS MILLE (EUR 12.343.000,-) seront alloués à la
prime d'émission.

2.- Souscription et libération de TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE (3.250) parts sociales par la société dé-

nommée «Eurofins France Holding», ayant son siège social à F-44300 Nantes (France), Rue Pierre Adolphe Bobierre,
Bâtiment Site de la Géraudière, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro
TI 528 643 000, libéré intégralement moyennant l’apport d'une créance d'un montant de DOUZE MILLIONS SIX CENT
SOIXANTE-HUIT MILLE EUROS (EUR 12.668.000,-).

3.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
4.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de porter le capital social de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (EUR 175.000,-)

à CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 500.000,-) par voie d'augmentation de capital à concurrence de TROIS CENT VINGT-
CINQ MILLE EUROS (EUR 325.000,-) par la création et l’émission de TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE (3.250)
parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, donnant les mêmes droits et
avantages que les parts sociales anciennes.

Cette augmentation de capital sera réalisée par un apport en nature d'un montant de DOUZE MILLIONS SIX CENT

SOIXANTE-HUIT MILLE EUROS (EUR 12.668.000,-) dont TROIS CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (EUR 325.000,-)
seront alloués au capital social et DOUZE MILLIONS TROIS CENT QUARANTE-TROIS MILLE (EUR 12.343.000,-)
seront alloués à la prime d'émission, par la création et l’émission de TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE (3.250)
parts sociales nouvelles, constitué par une créance envers la société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE (3.250) parts sociales

nouvelles l’associé actuel suivant:

-  la  société  dénommée  «Eurofins  France  Holding»,  ayant  son  siège  social  à  F-44300  Nantes  (France),  Rue  Pierre

Adolphe Bobierre, Bâtiment Site de la Géraudière, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro TI 528 643 000,

Laquelle a déclaré souscrire les TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE (3.250) parts sociales nouvelles et les libérer

intégralement par incorporation au capital social, la renonciation définitive et irrévocable et la conversion en capital d'une
créance certaine, liquide et exigible d'un montant de DOUZE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE EUROS
(EUR 12.668.000,-) existant à son profit et détenue envers la société «Eurofins Hydrologie France LUX Holding», pré-
qualifiée, et en annulation de cette même créance à due concurrence.

Cet apport fait l’objet d'un rapport établi en date du 17 décembre 2014 par le conseil de gérance, et qui conclut de la

manière suivante:

<i>"Conclusion

Sur base de nos diligences, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la valeur globale de l’apport

ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale ainsi qu'à la prime d’émission des parts sociales de la
Société à émettre en contrepartie.".

Lequel rapport après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant demeurera annexé

aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

9929

L

U X E M B O U R G

'' Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 500.000,-) représenté par CINQ

MILLE (5.000) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.''.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à € 5.300.-.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: NADHAZI, THILLMANY, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23/12/2014. Relation: EAC/2014/18003. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 30/12/2014.

Référence de publication: 2015000209/94.
(140234725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

GLL AMB Generali South Express S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 212.500,00.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 140.582.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

L'Assemblée générale extraordinaire de la Société du 22 décembre 2014 a décidé de clôturer la liquidation volontaire.

Les livres et documents sociaux seront déposés pour une période d'au moins 5 années au bureau de la société Avega
Services (Luxembourg) S.à r.l., 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.

Pour extrait
Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.
Signature
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2014205640/17.
(140229405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Eurofins Agrosciences Services LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.800.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 129.408.

L'an DEUX-MILLE QUATORZE, le vingt-deux décembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signée.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée dénommée «Eurofins Agrosciences Services

LUX Holding», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, constituée suivant acte reçu par-devant Maître
Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxembourg en date du 5 juillet 2007 publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-1722 le 14 août 2007. Les statuts de la
société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 18 décembre 2013 publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-317 le 4 février 2014.

La séance est ouverte à 10:00 heures, sous la présidence de Judit Nadhazi, demeurant professionnellement à Bruxelles

BE-1950, Chaussée de Malines 455.

9930

L

U X E M B O U R G

Madame la Présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Anthony Thillmany, demeurant profession-

nellement à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CINQUANTE-

TROIS MILLE SIX CENTS (53.600) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-)
chacune, représentant l’intégralité du capital social de SIX MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (EUR 6.700.000,-) sont
dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer
et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les
membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l’associé représenté demeureront annexées aux présentes avec

lesquelles elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation de capital pour le porter de SIX MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (EUR 6.700.000,-) à SIX

MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (EUR 6.800.000,-) par la création et l’émission de HUIT CENTS (800) parts
sociales nouvelles ayant une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune, investies des mêmes
droits et obligations que les anciennes, en contrepartie d'un apport d'une créance de DEUX MILLIONS CENT QUATRE-
VINGT TROIS MILLE EUROS (EUR 2.183.000,-) dont CENT MILLE EUROS (EUR 100.000,-) seront alloués au capital
social et DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT TROIS MILLE EUROS (EUR 2.083.000,-) seront alloués à la prime d'émis-
sion.

2.- Souscription et libération de HUIT CENTS (800) parts sociales par la société dénommée «Eurofins International

Holdings LUX», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B157959, libéré intégralement moyennant l’apport d'une créance d'un
montant de DEUX MILLIONS CENT QUATRE-VINGT TROIS MILLE EUROS (EUR 2.183.000,-).

3.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
4.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de porter le capital social de SIX MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (EUR 6.700.000,-)

à SIX MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (EUR 6.800.000,-) par voie d'augmentation de capital à concurrence de
CENT MILLE EUROS (EUR 100.000,-) par la création et l’émission de HUIT CENTS (800) parts sociales nouvelles ayant
une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que
les parts sociales anciennes.

Cette augmentation de capital sera réalisée par un apport en nature d'un montant de DEUX MILLIONS CENT QUA-

TRE-VINGT TROIS MILLE EUROS (EUR 2.183.000,-) dont CENT MILLE EUROS (EUR 100.000,-) seront alloués au capital
social et DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT TROIS MILLE EUROS (EUR 2.083.000,-) seront alloués à la prime d'émis-
sion, par la création et l’émission de HUIT CENTS (800) parts sociales nouvelles, constitué par une créance envers la
société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des HUIT CENTS (800) parts sociales nouvelles l’associé actuel suivant:
- la société dénommée «Eurofins International Holdings LUX», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val

Fleuri, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B157959,

Laquelle a déclaré souscrire les HUIT CENTS (800) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par incorpo-

ration au capital social, la renonciation définitive et irrévocable et la conversion en capital d'une créance certaine, liquide
et exigible d'un montant de DEUX MILLIONS CENT QUATRE-VINGT TROIS MILLE EUROS (EUR 2.183.000,-) existant
à son profit et détenue envers la société «Eurofins Agrosciences Services LUX Holding», préqualifiée, et en annulation
de cette même créance à due concurrence.

Cet apport fait l’objet d'un rapport établi en date du 17 décembre 2014 par le conseil de gérance, et qui conclut de la

manière suivante:

<i>"Conclusion

Sur base de nos diligences, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la valeur globale de l’apport

ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale ainsi qu'à la prime d’émission des parts sociales de la
Société à émettre en contrepartie.".

Lequel rapport après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant demeurera annexé

aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

9931

L

U X E M B O U R G

'' Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de SIX MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (EUR 6.800.000,-) repré-

senté par CINQUANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENTS (54.400) parts sociales d'une valeur nominale de CENT
VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.''.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à € 2.900.-.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: NADHAZI, THILLMANY, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23/12/2014. Relation: EAC/2014/17999. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 30/12/2014.

Référence de publication: 2015000204/92.
(140234651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Eurofins Analyses pour la Construction France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 800.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 165.607.

L'an DEUX-MILLE QUATORZE, le vingt-deux décembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signée.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée dénommée «Eurofins Analyses pour la Cons-

truction France LUX Holding», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, constituée suivant acte reçu
par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxembourg en date du
22 décembre 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-278 le 1 

er

février 2012. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 25
mars 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-1243 le 27 mai 2013.

La séance est ouverte à 10:00 heures, sous la présidence de Judit Nadhazi, demeurant professionnellement à Bruxelles

BE-1950, Chaussée de Malines 455.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Anthony Thillmany, demeurant profession-

nellement à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les SEPT MILLE

CINQ CENTS (7.500) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, représentant l’inté-
gralité du capital social de SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 750.000,-) sont dûment représentées à la
présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur
les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée
ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l’associé représenté demeureront annexées aux présentes avec

lesquelles elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation de capital pour le porter de SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 750.000,-) à HUIT

CENT MILLE EUROS (EUR 800.000,-) par la création et l’émission de CINQ CENTS (500) parts sociales nouvelles ayant
une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les anciennes,
en  contrepartie  d'un  apport  d'une  créance  de  UN  MILLION  HUIT  CENT  SOIXANTE-ET-UN  MILLE  EUROS  (EUR
1.861.000,-) dont CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000,-) seront alloués au capital social et UN MILLION HUIT
CENT ONZE MILLE EUROS (EUR 1.811.000,-) seront alloués à la prime d'émission.

9932

L

U X E M B O U R G

2.- Souscription et libération de CINQ CENTS (500) parts sociales par la société dénommée «Eurofins France Hold-

ing», ayant son siège social à F-44300 Nantes (France), Rue Pierre Adolphe Bobierre, Bâtiment Site de la Géraudière,
immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro TI 528 643 000, libéré intégra-
lement moyennant l’apport d'une créance d'un montant de UN MILLION HUIT CENT SOIXANTE-ET-UN MILLE EUROS
(EUR 1.861.000,-).

3.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
4.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de porter le capital social de SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 750.000,-)

à HUIT CENT MILLE EUROS (EUR 800.000,-) par voie d'augmentation de capital à concurrence de CINQUANTE MILLE
EUROS (EUR 50.000,-) par la création et l’émission de CINQ CENTS (500) parts sociales nouvelles ayant une valeur
nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les parts sociales anciennes.

Cette augmentation de capital sera réalisée par un apport en nature d'un montant de UN MILLION HUIT CENT

SOIXANTE-ET-UN MILLE EUROS (EUR 1.861.000,-) dont CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000,-) seront alloués
au capital social et UN MILLION HUIT CENT ONZE MILLE EUROS (EUR 1.811.000,-) seront alloués à la prime d'émis-
sion, par la création et l’émission de CINQ CENTS (500) parts sociales nouvelles, constitué par une créance envers la
société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée  décide  d'admettre  à  la  souscription  des  CINQ  CENTS  (500)  parts  sociales  nouvelles  l’associé  actuel

suivant:

-  la  société  dénommée  «Eurofins  France  Holding»,  ayant  son  siège  social  à  F-44300  Nantes  (France),  Rue  Pierre

Adolphe Bobierre, Bâtiment Site de la Géraudière, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro TI 528 643 000,

Laquelle a déclaré souscrire les CINQ CENTS (500) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par incor-

poration au capital social, la renonciation définitive et irrévocable et la conversion en capital d'une créance certaine, liquide
et exigible d'un montant de UN MILLION HUIT CENT SOIXANTE-ET-UN MILLE EUROS (EUR 1.861.000,-) existant à
son profit et détenue envers la société «Eurofins Analyses pour la Construction France LUX Holding», préqualifiée, et
en annulation de cette même créance à due concurrence.

Cet apport fait l’objet d'un rapport établi en date du 17 décembre 2014 par le conseil de gérance, et qui conclut de la

manière suivante:

<i>"Conclusion

Sur base de nos diligences, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la valeur globale de l’apport

ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale ainsi qu'à la prime d’émission des parts sociales de la
Société à émettre en contrepartie.".

Lequel rapport après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant demeurera annexé

aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

'' Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de HUIT CENT MILLE EUROS (EUR 800.000,-) représenté par HUIT

MILLE (8.000) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.''.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à € 2.700.-.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: NADHAZI, THILLMANY, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23/12/2014. Relation: EAC/2014/18006. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

9933

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 30/12/2014.

Référence de publication: 2015000205/92.
(140234711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Eurofins Analyses Environnementales pour les Industriels France LUX Holding, Société à responsabilité

limitée.

Capital social: EUR 1.680.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 165.609.

L'an DEUX-MILLE QUATORZE, le vingt-deux décembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signée.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée dénommée «Eurofins Analyses Environne-

mentales pour les Industriels France LUX Holding», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, constituée
suivant acte reçu pardevant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxem-
bourg en date du 22 décembre 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro
C-277 le 1 

er

 février 2012. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné

en date du 13 juillet 2012 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-2023 le
14 août 2012.

La séance est ouverte à 10:00 heures, sous la présidence de Judit Nadhazi, demeurant professionnellement à Bruxelles

BE-1950, Chaussée de Malines 455.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Anthony Thillmany, demeurant profession-

nellement à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CENT VINGT-

CINQ (125) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du
capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) sont dûment représentées à la présente assemblée,
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l’associé représenté demeureront annexées aux présentes avec

lesquelles elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation de capital pour le porter de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) à QUATRE-

VINGT MILLE EUROS (EUR 80.000,-) par la création et l’émission de SIX CENT SOIXANTE-QUINZE (675) parts sociales
nouvelles ayant une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations
que les anciennes, en contrepartie d'un apport d'une créance de UN MILLION SIX CENT QUATRE-VINGT MILLE
EUROS (EUR 1.680.000,-) dont SOIXANTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 67.500,-) seront alloués au capital
social et UN MILLION SIX CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 1.612.500,-) seront alloués à la prime
d'émission.

2.- Souscription et libération de SIX CENT SOIXANTE-QUINZE (675) parts sociales par la société dénommée «Eu-

rofins France Holding», ayant son siège social à F-44300 Nantes (France), Rue Pierre Adolphe Bobierre, Bâtiment Site de
la Géraudière, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro TI 528 643 000,
libéré intégralement moyennant l’apport d'une créance d'un montant de UN MILLION SIX CENT QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (EUR 1.680.000,-).

3.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
4.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de porter le capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) à

QUATRE-VINGT MILLE EUROS (EUR 80.000,-) par voie d'augmentation de capital à concurrence de SOIXANTE-SEPT
MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 67.500,-) par la création et l’émission de SIX CENT SOIXANTE-QUINZE (675) parts
sociales nouvelles ayant une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, donnant les mêmes droits et avan-
tages que les parts sociales anciennes.

9934

L

U X E M B O U R G

Cette augmentation de capital sera réalisée par un apport en nature d'un montant de UN MILLION SIX CENT QUA-

TRE-VINGT  MILLE  EUROS  (EUR  1.680.000,-)  dont  SOIXANTE-SEPT  MILLE  CINQ  CENTS  EUROS  (EUR  67.500,-)
seront alloués au capital social et UN MILLION SIX CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 1.612.500,-)
seront alloués à la prime d'émission, par la création et l’émission de SIX CENT SOIXANTE-QUINZE (675) parts sociales
nouvelles, constitué par une créance envers la société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des SIX CENT SOIXANTE-QUINZE (675) parts sociales nouvelles

l’associé actuel suivant:

-  la  société  dénommée  «Eurofins  France  Holding»,  ayant  son  siège  social  à  F-44300  Nantes  (France),  Rue  Pierre

Adolphe Bobierre, Bâtiment Site de la Géraudière, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro TI 528 643 000,

Laquelle a déclaré souscrire les SIX CENT SOIXANTEQUINZE (675) parts sociales nouvelles et les libérer intégra-

lement par incorporation au capital social, la renonciation définitive et irrévocable et la conversion en capital d'une créance
certaine, liquide et exigible d'un montant de UN MILLION SIX CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (EUR 1.680.000,-)
existant à son profit et détenue envers la société «Eurofins Analyses Environnementales pour les Industriels France LUX
Holding», préqualifiée, et en annulation de cette même créance à due concurrence.

Cet apport fait l’objet d'un rapport établi en date du 17 décembre 2014 par le conseil de gérance, et qui conclut de la

manière suivante:

<i>"Conclusion

Sur base de nos diligences, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la valeur globale de l’apport

ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale ainsi qu'à la prime d’émission des parts sociales de la
Société à émettre en contrepartie.".

Lequel rapport après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant demeurera annexé

aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

'' Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (EUR 80.000,-) représenté par HUIT

CENTS (800) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.''.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à € 2.600.-.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: NADHAZI, THILLMANY, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23/12/2014. Relation: EAC/2014/18000. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 30/12/2014.

Référence de publication: 2015000206/96.
(140234726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Promark Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 47.174.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208442/9.
(140233032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

9935

L

U X E M B O U R G

F.T.A. Communication Technologies S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.875.350,00.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 71.499.

<i>Rectificatif du dépôt RCS N° L140230206 du 24/12/2014

Il est à noter que:
ATLANTA BROADBAND COMMUNICATIONS, LLC, enregistrée sous le N° 8039068 auprès du Business Services

and Regulation of Georgia, U.S.A., sise 1955 River Forest Drive, à 30068 Marietta, GA, U.S.A., a seulement cédé

1.740  parts  de  valeur  nominale  EUR  145  chacune  dans  F.T.A.  COMMUNICATION  TECHNOLOGIES  S.AR.L.  (la

«Société») sur les 3.480 parts qu'elle détenait

A
F.T.A. SATELITTE COMMUNICATION TECHOLOGIES S.à r.l., RCS Luxembourg B 38.420, sise 18, Duchscherstroos

à L - 6868 WECKER.

Suite à ces cessions, le capital social de la Société est désormais réparti entre les 5 associés suivants:
1. F.T.A. SATELITTE COMMUNICATION TECHOLOGIES S.à r.l.: 16.738 parts
2. ATLANTA BROADBAND COMMUNICATIONS, LLC.: 1.740 parts
3. Eli BLOCH: 2 parts
4. Gil LAIFER: 600 parts et
5. Tomer BENTZION: 750 parts.
Soit au total 19.830 parts sociales de valeur nominale EUR 145,- chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
LG@vocats
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014207906/28.
(140232195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Fondation Edmond Israël, Fondation.

Siège social: L-1885 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg G 111.

1. Monsieur Claude de Kémoularia a démissionné du Conseil d'Administration le 10 novembre 2004
2. Monsieur Edmond Israel a démissionné du Conseil d'Administration le 4 février 2011
3. Monsieur Horst Günter Krenzler a démissionné du Conseil d'Administration le 20 juillet 2012
4. Monsieur Albert Bressand a démissionné du Conseil d'Administration le 30 novembre 2014
5. Monsieur Helmut Haussmann a démissionné du Conseil d'Administration le 30 novembre 2014
6. Monsieur Marc Hoffmann a démissionné du Conseil d'Administration le 30 novembre 2014
7. Monsieur Thomas Rabe a démissionné du Conseil d'Administration le 30 novembre 2014
8. Monsieur Jacques Santer a démissionné du Conseil d'Administration le 30 novembre 2014
La personne suivante a été élue comme président au Conseil d'Administration

- Jeffrey Tessler

42, Avenue J.F. Kennedy

L - 1855 Luxembourg

Le Conseil d'Administration est actuellement composé des membres suivants:
- Jeffrey Tessler, Président
- André Roelants
- Oscar Max Lewisohn

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014207952/24.
(140232692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

9936


Document Outline

Aquinnotec S.à r.l.

BC Concept

BCR S.à r.l.

Betafence Luxembourg

Bishop Infrastructure Luxembourg S.à r.l.

Brand Ladenbau Sàrl

BroadCom S.A.

CAJCAG S.A.

Car Tec S.A.

C&amp;C IP (N°2) Sàrl

Eurofins Agrosciences Services LUX Holding

Eurofins Analyses Environnementales pour les Industriels France LUX Holding

Eurofins Analyses pour la Construction France LUX Holding

Eurofins Forensics LUX Holding

Eurofins GSC LUX

Eurofins Hydrologie France LUX Holding

Eurofins International Holdings LUX

Firewall Holding S.à r.l.

Fondation Edmond Israël

F.T.A. Communication Technologies S.à.r.l.

GLL AMB Generali South Express S.à r.l.

Heilbronn S. à r.l.

Hobaco S.A.

Hobsons Benelux

IAV S.à r.l.

Interlatsco Holding S.A.

Interpalos S.à r.l.

Inteuro S.A.

Lynx Group Sàrl

Manimmo S.A.

Mano

Marine Projects (Luxembourg) S.A.

Market Development International

Marlis S.à r.l.

Marsh &amp; McLennan Europe S.à r.l.

Maxime S.à r.l.

MC Constructions

MC Participations s.à r.l.

Meat Co Maghreb S.à r.l.

MedBridge Investments S.C.A.

Megafit S.A., SPF

Menuiserie Hermes S. à r.l.

Menuiserie Jos. Dostert

Menuiserie Majoie Michel S.A.

Meranti Investments S.à r.l.

M ET M S.à r.l.

Molycorp Luxembourg Holdings S.à r.l.

Promark Holding S.A.