logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3904

17 décembre 2014

SOMMAIRE

Almus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187346

Berkeley 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187368

D.H. Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187346

Eccica S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187391

Euro-Steel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187391

Finedining S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187370

IVG Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

187346

Kabam Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

187348

PolyOne Manufacturing S.à r.l.  . . . . . . . . . .

187363

Premium Coffee Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

187392

Racol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187349

Rakuten UK Shopping S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

187349

RDM International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

187350

Realfund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187350

Red Carnations Hotels (Europe) S.A.  . . . .

187351

Red Carnations Hotels (Europe) S.A.  . . . .

187351

Red Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187351

REGENTS PARK (Founder) S.à r.l.  . . . . . .

187351

REGENTS PARK (Founder) S.à r.l.  . . . . . .

187352

REGENTS PARK (Founder) S.à r.l.  . . . . . .

187352

Ribeauvillé Investments S.A.  . . . . . . . . . . . .

187352

Ribeauvillé Investments S.A.  . . . . . . . . . . . .

187352

R.J. Claessens & Partners Sàrl  . . . . . . . . . . .

187349

Rosy Blue Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

187349

Rowan Finanz S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187349

Rudolf STEINER Fonds fir Waldorfpädago-

gik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187348

Santa Capital I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187353

Saposa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187365

Sartcom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187365

Sauren Fonds-Select Sicav  . . . . . . . . . . . . . .

187365

Sausalito S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187366

Schëfflenger Majoretten ASBL  . . . . . . . . . .

187353

Seema Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

187355

S.E.I. Luxembourg S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

187352

Setup Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

187361

Shannon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187360

Sinaf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187366

Sinbuild S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187366

Sit-Net S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187366

SkyCom S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187363

SLK Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187367

Teamlog Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187392

Urban Biofood S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187392

Valartis Health Care Eins S.à r.l. . . . . . . . . .

187392

187345

L

U X E M B O U R G

Almus S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 100.788.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014189933/11.
(140212174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

D.H. Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 172.326.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/11/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014190114/12.
(140212030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

IVG Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 150.381.

In the year two thousand fourteen, on the fourteenth day of November;
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

IVG Institutional Funds GmbH, a limited liability company organized under the laws of the Federal Republic of Germany,

whose registered office is at THE SQUAIRE 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, registered with the Amtsgericht
Frankfurt am Main, under the number HRB 91062,

here  represented  by  Mr  Jörg  Niedermeyer,  Rechtsanwalt,  residing  in  Luxembourg,  by  virtue  of  a  proxy,  given  in

Frankfurt am Main, on 13 November 2014.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of IVG Luxembourg S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à

responsabilité limitée, having its registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B150381, incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo
Wersandt, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on 15 December 2009, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Memorial C”) N° 240 on 4 February 2010. The articles of association
have been amended the last time by a notarial deed of Maître Carlo Wersandt notary residing in Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, on 22 July 2014 which has been published in the Mémorial C N° 2934 on 14 October 2014.

The appearing party representing the whole corporate capital and having waived any notice requirement requires the

notary to enact the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to grant authority to the board of managers to pay interim dividends on the basis of

interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution.
The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits
carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve
which the Law of 10 August 1915 on commercial companies (the “1915 Law”) or the articles of association of the Company
do not allow to be distributed.

The sole shareholder further resolves that any share premium, assimilated premium or other distributable reserve

may be freely distributed to the sole shareholder subject to the provisions of the Law and the articles of association of
the Company.

187346

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

Consequently to the first resolution, the sole shareholder resolves to insert a new article 16 into the articles of

association of the Company, which shall read as follows:

“ Art. 16. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums. The Board of Managers may decide to pay

interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the Board of Managers showing that sufficient
funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the
last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve which the Law of 10 August 1915 on commercial companies (the “1915 Law”) or
these articles of association do not allow to be distributed.

Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the sole share-

holder subject to the provisions of the Law and these articles of association.”

Due to this insertion, the following articles will be renumbered accordingly.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,000.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a German translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the German text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name, civil
status and residence, the proxyholder of the appearing party signed the present deed together with the notary.

Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am vierzehnten Tag im November,
Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

ERSCHIEN

IVG  Institutional  Funds  GmbH,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  nach  dem  Recht  der  Bundesrepublik

Deutschland,  mit  Gesellschaftssitz  in  THE  SQUAIRE  18,  Am  Flughafen,  60549  Frankfurt  am  Main,  eingetragen  beim
Amtsgericht Frankfurt unter der Nummer 91062,

hier vertreten durch Herrn Jörg Niedermeyer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer am 13. Novem-

ber 2014 in Frankfurt am Main erteilten Vollmacht.

Diese Vollmacht wird nach Paraphierung „ne varietur“ durch den Notar und die Bevollmächtigte vorliegender Urkunde

als Anlage beigefügt, um mit dieser Urkunde registriert zu werden.

Die erschienene Partei ist alleiniger Gesellschafter der IVG Luxembourg S.à r.l., (die „Gesellschaft“) einer luxembur-

gischen société à responsabilité limitée mit Gesellschaftssitz in 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, eingetragen
im Handels- und Firmenregister von Luxemburg unter der Nummer B 150381, gegründet durch notarielle Urkunde,
ausgestellt von Notar Carlo Wersandt mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxembourg, am 15. Dezember 2009,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial C“) N° 240 am 4. Februar 2010. Die
Satzung wurde zuletzt durch notarielle Urkunde, ausgestellt von Notar Carlo Wersandt mit Amtssitz in Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, am 22. Juli 2014 geändert, veröffentlicht im Mémorial C N° 2934 am 14. Oktober 2014.

Die erschienene Partei vertritt das gesamte Gesellschaftskapital, hat auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet und

bittet den Notar, die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den Geschäftsführerrat zu ermächtigen, Abschlagsdividenden auf Grundlage

von Zwischenabschlüssen zahlen zu können, welche vom Geschäftsführerrat vorbereitet wurden und belegen, dass aus-
reichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der
seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Ge-
winne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach
dieser Satzung oder dem modifizierten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften einer Rücklage zuge-
führt werden müssen, übersteigen.

Der Geschäftsführerrat beschließt darüber hinaus, dass das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare

Rücklagen, im Einklang mit den Bestimmungen des modifizierten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften und den Regelungen dieser Satzung, frei an den alleinigen Gesellschafter ausgeschüttet werden können.

187347

L

U X E M B O U R G

<i>Zweiter Beschluss

In Folge des ersten Beschlusses beschließt der alleinige Gesellschafter, einen neuen Artikel 16 der Satzung der Ge-

sellschaft einzufügen, der wie folgt lauten soll:

“ Art. 16. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven. Der Geschäftsführerrat kann Abschlagsdividenden

auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom Geschäftsführerrat vorbereitet wurden und belegen, dass
ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe
der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene
Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach
dieser Satzung oder dem modifizierten Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften einer Rücklage zugeführt
werden müssen, übersteigen.

Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des modifizierten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Regelungen dieser Satzung, frei an
den alleinigen Gesellschafter ausgeschüttet werden.“

Infolge dieser Einfügung werden die darauf folgenden Artikel entsprechend neu nummeriert.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Ge-

sellschaft aus Anlass des vorliegenden Aktes entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 1.000.-.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt

hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die deutsche
Fassung maßgeblich sein soll.

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt aufgenommen

wurde. Sie wurde der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen und von Letzterer und dem unterzeichn-
enden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. NIEDERMEYER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 novembre 2014. Relation: LAC/2014/55092. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 2. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014191932/118.
(140214107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Kabam Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 159.497.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191937/10.
(140213620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Rudolf STEINER Fonds fir Waldorfpädagogik, Fondation.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 45, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg G 154.

Monsieur BASTIEN René, demeurant à L-5869 Alzingen 28 rue Pierre Stein, a été nommé le 18 novembre 2014 par

le conseil d'administration du "Veräin fir Waldorfpädagogik Letzebuerg", comme administrateur au conseil d'administra-
tion.

Référence de publication: 2014192107/10.
(140213361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

187348

L

U X E M B O U R G

R.J. Claessens &amp; Partners Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5553 Remich, 28, Quai de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 132.076.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014192102/10.
(140214168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Rakuten UK Shopping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 117.514.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 69708 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192103/10.
(140214103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Rosy Blue Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1513 Luxembourg, 63, boulevard Prince Félix.

R.C.S. Luxembourg B 72.280.

Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2013.

Marcus J. DIJKERMAN
<i>Gérant

Référence de publication: 2014192105/13.
(140213492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Rowan Finanz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 180.891.

Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 10 septembre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 octobre 2014.

Référence de publication: 2014192106/11.
(140213881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Racol, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 131.225.

EXTRAIT

Changement d'adresse de Monsieur Christophe Fender et Monsieur Luc Sunnen, gérants de catégorie A de la société

Racol S.à r.l.

Changement d'adresse avec effet immédiat au 23, rue des Bruyères L-1274 Howald
Changement d'adresse de Monsieur Alan Foley, gérant de catégorie B de la société Racol S.à r.l.
Changement d'adresse avec effet immédiat au 2 Grand Parade, Dublin 6, Ireland
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

187349

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 01/12/2014.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014192110/17.
(140213487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

RDM International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 161.756.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WILSON ASSOCIATES
11, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2014192113/13.
(140214180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Realfund, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 97.522.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:

La société dénommée «Wilbur Associates Ltd», ayant son siège social à 8188 Nassau Bahamas, Elizabeth Avenue &amp;

Shirley Street S-E2, IBC 185200,

ici représentée par Monsieur Michel BOURKEL, conseiller économique, demeurant professionnellement à L-2763

Luxembourg, 33, rue Sainte Zithe,

agissant en sa qualité d'administrateur avec pouvoir d'engager ladite société.
Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:
I. Que la société anonyme REALFUND ("la Société"), ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 8, Place Winston

Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 97522, a été
constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée, en date du 11 décembre 2003, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations le 13 janvier 2004, numéro 40.

Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER,

préqualifiée, en date du 19 juillet 2006, publié au Mémorial C numéro 1767 du 21 septembre 2006.

II. Que le comparant détient trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (€ 10.-), représentant

l’entièreté du capital émis de la Société.

III. Que le comparant dûment représenté déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l’état

financier de la susdite Société.

IV. Que le comparant dûment représenté en tant que seul actionnaire, déclare expressément procéder à la dissolution

de la Société.

V. Qu'un bilan de clôture de la société REALFUND a été établi.
VI. Que le comparant dûment représenté déclare que les dettes connues seront payées et en outre qu'ils prennent à

leur charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond de tous les engagements sociaux.

VII.- Que la Société autorise les mandants, ainsi que le délégué des mandants dûment autorisé, à signer les documents

et actes pouvant être requis pour dissoudre la Société.

VIII. Que décharge pleine et entière est accordée par le comparant dûment représenté aux administrateurs et au

commissaire aux comptes de la Société pour l’exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

IX. Qu'il sera procédé à l’annulation des actions de la Société.
X. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social à L- 1340

Luxembourg, 8, Place Winston Churchill.

187350

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le représentant du comparant a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: BOURKEL, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28/11/2014. Relation: EAC/2014/16250. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 02/12/2014.

Référence de publication: 2014192114/47.
(140213811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Red Carnations Hotels (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 83.501.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 1 

<i>er

<i> décembre 2014

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2014:

- Mr. Gavin TOLLMAN, directeur, demeurant au 9, Sentier des Saules, 1205 Genève, Président;
- Mr Jonathan RAGGETT, manager, demeurant au 35, Charles Street, W1J 5EB Londres, Royaume-Uni;
- Mr. Marc FISCHER, lawyer, demeurant au 2, route de Genève, 1180 Rolle/VD, Suisse.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2014:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192115/18.
(140213745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Red Carnations Hotels (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 83.501.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192116/9.
(140213746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Red Luxembourg S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 120.740.

Il résulte que le siège social au 16 rue de Nassau L-2213 Luxembourg de la société Red Luxembourg S.A. immatriculée

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.120740 a été dénoncé le 22 septembre 2014
avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192117/10.
(140214133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

REGENTS PARK (Founder) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 150.687.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192118/9.
(140214044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

187351

L

U X E M B O U R G

REGENTS PARK (Founder) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 150.687.

Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192119/9.
(140214100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

REGENTS PARK (Founder) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 150.687.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192120/9.
(140214101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Ribeauvillé Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 97.549.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192121/9.
(140214012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Ribeauvillé Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 97.549.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue extraordinairement le 24 novembre 2014

1. Les associés prennent acte et acceptent la démission de Monsieur Luc HANSEN de son mandat d'administrateur

de la société avec effet immédiat.

2. Est nommé nouvel administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2016:

Monsieur  Reno  Maurizio  TONELLI,  licencié  en  sciences  politiques,  demeurant  professionnellement  au  2,  avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 24 novembre 2014.

Référence de publication: 2014192122/16.
(140214018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

S.E.I. Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 274, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 47.071.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour S.E.I. LUXEMBOURG S.àr.l
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014192128/12.
(140214009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

187352

L

U X E M B O U R G

Santa Capital I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 155.767.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 Décembre 2014.

TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2014192132/13.
(140213817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Schëfflenger Majoretten ASBL, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3857 Schifflange, 1, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg F 10.186.

STATUTS

Il est formé une association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 et modifiée par les lois des 22 février

1984 et 04 mars 1994 et les présents statuts.

Chapitre 1 

er

 . - Dénomination, objet, siège.

Art. 1 

er

 .  L'association est dénommée: Schëfflenger Majoretten ASBL.

Elle a pour but la démonstration, la promotion et le développement des traditions dans les domaines des Majorettes

et de toutes les activités facilitant la réalisation de son objet. Le siège de l’association se situe a Schifflange.

Art. 2. L'association peut créer des sections, dont l’organisation sera déterminée par le comité. Elle peut s'affilier.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée. Elle est neutre en matière politique et religieuse.

Chapitre 2. - Membres, admissions, démissions, exclusions et cotisations.

Art. 4. L'association se compose de membres actifs et de membres honoraires, personnes physiques ou morales. Le

nombre des membres est illimité.

Art. 5. Les membres payent une cotisation annuelle fixée par le comité.
Toute personne désirant faire partie de l’association comme membre actif fera une demande écrite au comité.
La qualité de membre n'est acquise qu'après avoir payé la cotisation et le droit d'entrée prononcé par le comité.

Art. 6.  En  dehors  des  membres  titulaires,  le  club  pourra  admettre  des  membres  honoraires.  Sont  admis  comme

membres honoraires toutes personnes honorables qui seront désignées par le comité.

Art. 7. La qualité de membre se perd:
a) par la démission écrite parvenue au comité.
b)  est  réputé  démissionnaire:  le  membre  qui  dans  le  délai  d'un  mois  après  réception  d'une  lettre  recommandée,

l’invitant à régler la cotisation ou le droit d'entrée ou des dettes vis-à-vis de l’association, aura négligé de le faire.

c) Par l’exclusion pour motifs graves, prononcé par le comité.
d) Par le refus de payer la cotisation

Art. 8. En cas de décès d'un membre, ses héritiers n'auront aucun droit sur le fonds social. En cas de démission et

d'exclusion, le membre n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement de ses cotisations.

Chapitre 3. - Administration.

Art. 9. L'association est administrée par un comité, composé de 4 (quatre) membres au moins et de 9 (neuf) au plus.
Les membres, ayant introduit une demande et lesquels ont payé la cotisation, sont élus par l’assemblée générale pour

une durée de 4 (quatre) ans, révocables par elle à tout moment.

Les membres du comité désignent entre eux par vote un président, un secrétaire, un trésorier et un vice-président.

Art. 10. Les membres du comité sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d'un siège, il sera pourvu au remplacement lors de la prochaine assemblée générale.
Les autres candidatures seront reçues jusqu'au début des opérations de vote.

187353

L

U X E M B O U R G

Art. 11. En cas d'invalidité ou de décès d'un membre du comité, un autre membre du comité peut prendre les fonctions

de ce dernier jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 12. Le comité peut compter un ou plusieurs membres pour assurer des tâches déterminées. Ce ou ces derniers

ne disposent toutefois que d'une voix consultative.

Art. 13. Le comité se réunira sur convocation du président chaque fois que le réclame l’intérêt de l’association.
Il se réunira au moins une fois par mois.

Art. 14. Les décisions du comité sont valables lorsque la moitié de ses membres est présente. Les décisions seront

prises à la majorité des voix; en cas de partage la voie du président est prépondérante.

Art. 15. Les délibérations du comité sont constatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre, tenu au siège social

et signés par le président et le secrétaire.

Art. 16. Le comité a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour la gestion des affaires de

l’association; tout ce qui n'est réservé expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa com-
pétence.

Art. 17. L'association est valablement engagée à l’égard des tiers par une seule signature du président, du vice-président

et/ou du secrétaire, dans la limite des pouvoirs qui leur ont été conférés.

Art. 18. Pour les opérations bancaires, deux signatures sont nécessaires. Les deux membres pouvant ordonner une

transaction ou payement se composent entre le président, le secrétaire, le trésorier et le vice-président.

Art. 19. La gestion du trésorier est contrôlée par deux ou trois vérificateurs des comptes, majeurs, membres ou pas

membres de l’association, sans faire partie du comité.

Les vérificateurs des comptes sont désignés chaque année par l’assemblée générale.

Chapitre 4. - Assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

Art. 20. L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an.

Art. 21. Les membres sont convoqués par avis postal, par voie de presse et/ou par Internet.
Les convocations contiendront l’ordre du jour.
Le président ou le vice-président assume la direction de l’assemblée.

Art. 22. L'assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres présents. Elle prend

ses décisions à la majorité simple des votants, sauf les restrictions imposées à ce sujet par la loi et les présents statuts.

Seul les membres disposant d'une carte de membre valable ont le droit de vote qui est égal pour tous.

Art. 23. L'assemblée générale a le droit:
- de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de la société en se conformant à ce sujet aux règles établies

par la loi;

- de nommer et révoquer les membres du comité et les réviseurs de caisse;
- d'approuver annuellement le budget et les comptes établies par le comité;
- la fixation du montant des cotisations.

Art. 24. En général, aucune décision ne peut être prise sur un objet ne figurant pas à l’ordre du jour. Toutefois, en cas

d'urgence, l’assemblée générale pourra déroger à cette disposition sur proposition du comité.

Art. 25. L'assemblée décide par vote secret ou à main levée. Le vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées.

Art. 26. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent.

Art. 27. Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre spécial conservé au siège de la société

où tous les associés pourront prendre connaissance.

Chapitre 5. - Année sociale, bilan, budget.

Art. 28. L'année sociale commence le 1 

er

 Janvier et finit le 31 

ème

 décembre.

Art. 29. Chaque année le conseil d'administration soumettra à l’approbation de l’assemblée générale le bilan ainsi le

compte des recettes et des dépenses de l’année écoulée et le budget de l’année suivante.

Chapitre 6. - Statuts, dissolution, liquidation.

Art. 30. Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions prévues par les art. 4, 8 et 9 de la loi du

21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 04 mars 1994, sur les associations sans but
lucratif.

187354

L

U X E M B O U R G

Art. 31. La dissolution de l’association est régie par l’art. 20 de la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par

les lois des 22 février 1984 et 04 mars 1994, sur les association sans but lucratif.

Art. 32. En cas de dissolution, les fonds de l’association reviendront, après apurement de toutes les dettes, charges et

frais de liquidation, à un oeuvre de bienfaisance de son choix.

Chapitre 7. - Dispositions générales.

Art. 33. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les membres du comité se référeront à la loi du 21 avril 1928,

telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 04 mars 1994, sur les association sans but lucratif.

Président: LAUTERBACH Charles, né le 10/08/1955 à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise. 117 A, avenue

de la Gare, L-4873, Lamadelaine - Profession: Pensionnaire

Vice-président: HENTGES Sylvie, née le 05/05/1954 à Differdange, de nationalité luxembourgeoise. 10, rue du Canal,

L-4050, Esch/Alzette - Profession: Femme de charge

Secrétaire: BOURQUEL Kelly, née le 18/09/1995 à Esch/Alzette, de nationalité luxembourgeoise. 153, rue Principal,

L-4698, Lasauvage - Profession: Étudiant Trésorier: KOMES Samantha, née le 08/01/1995 à Luxembourg, de nationalité
luxembourgeoise. 120-122, route de Pétange, L-4645, Niederkorn - Profession: Étudiant

Fait à Schifflange, le 1 

er

 novembre 2014.

Signatures.

Référence de publication: 2014192134/103.
(140214097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Seema Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NOK 97.598,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 135.615.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-first day of November,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Seema Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée

governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of six million six hundred and one
thousand one hundred ninety Norwegian Krone (NOK 6,601,190.-), with registered office at 2, rue du Fossé, L-1536
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed dated 14 December 2007, published
in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  number  425  of  19  February  2008  and  registered  with  the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 135615 (the "Company"). The articles of incorpo-
ration of the Company have for the last time been amended following a notarial deed of the undersigned notary dated
23 October 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was declared open at 12.11 p.m. by Me Mélody Brunot, with professional address in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Me Cristiana Musteanu, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg.

The meeting elected as scrutineer Me Maxime Bertomeu-Savalle, with professional address in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record

the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda

1 To approve the redemption of two million one hundred ninety-five thousand three hundred fifty-two (2,195,352)

preference class D shares of the Company, three million nine hundred seventeen thousand nine hundred twenty-eight
(3,917,928) preference class E shares of the Company, ninety-seven thousand five hundred seventy-eight (97,578) ordinary
class A shares of the Company, ninety-seven thousand five hundred seventy-eight (97,578) ordinary class B shares of the
Company, ninety-seven thousand five hundred seventy-eight (97,578) ordinary class C shares of the Company and ninety-
seven thousand five hundred seventy-eight (97,578) ordinary class D shares of the Company, with a nominal value of one
Norwegian Krone (NOK 1.-) each.

2 To reduce the corporate capital of the Company by an amount of six million five hundred and three thousand five

hundred ninety-two Norwegian Krone (NOK 6,503,592.-) so as to reduce it from its current amount of six million six
hundred and one thousand one hundred ninety Norwegian Krone (NOK 6,601,190.-) to ninety-seven thousand five
hundred ninety-eight Norwegian Krone (NOK 97,598.-) by cancellation of two million one hundred ninety-five thousand

187355

L

U X E M B O U R G

three hundred fifty-two (2,195,352) preference class D shares of the Company, three million nine hundred seventeen
thousand nine hundred twenty-eight (3,917,928) preference class E shares of the Company, ninety-seven thousand five
hundred seventy-eight (97,578) ordinary class A shares of the Company, ninety-seven thousand five hundred seventy-
eight (97,578) ordinary class B shares of the Company, ninety-seven thousand five hundred seventy-eight (97,578) ordinary
class C shares of the Company and ninety-seven thousand five hundred seventy-eight (97,578) ordinary class D shares
of the Company with a nominal value of one Norwegian Krone (NOK 1.-) each, so redeemed.

3 To amend the first paragraph of article 5, article 7 and article 24 of the Company’s articles of incorporation to reflect

the capital decrease.

4 To confer all and any powers to the Company’s managers to implement the above resolutions.
5 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the

undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented

declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolved to approve the redemption of two million one hundred ninety-five

thousand three hundred fifty-two (2,195,352) preference class D shares of the Company, three million nine hundred
seventeen  thousand  nine  hundred  twenty-eight  (3,917,928)  preference  class  E  shares  of  the  Company,  ninety-seven
thousand five hundred seventy-eight (97,578) ordinary class A shares of the Company, ninety-seven thousand five hundred
seventy-eight (97,578) ordinary class B shares of the Company, ninety-seven thousand five hundred seventy-eight (97,578)
ordinary class C shares of the Company and ninety-seven thousand five hundred seventy-eight (97,578) ordinary class D
shares of the Company, with a nominal value of one Norwegian Krone (NOK 1.-) each, which shall therefore be effective
immediately.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to reduce the corporate capital of the Company by an amount of six

million five hundred and three thousand five hundred ninety-two Norwegian Krone (NOK 6,503,592.-) so as to reduce
it from its current amount of six million six hundred and one thousand one hundred ninety Norwegian Krone (NOK
6,601,190.-) to ninety-seven thousand five hundred ninety-eight Norwegian Krone (NOK 97,598) by cancellation of two
million one hundred ninety-five thousand three hundred fifty-two (2,195,352) preference class D shares of the Company,
three million nine hundred seventeen thousand nine hundred twenty-eight (3,917,928) preference class E shares of the
Company, ninety-seven thousand five hundred seventy-eight (97,578) ordinary class A shares of the Company, ninety-
seven thousand five hundred seventy-eight (97,578) ordinary class B shares of the Company, ninety-seven thousand five
hundred seventy-eight (97,578) ordinary class C shares of the Company and ninety-seven thousand five hundred seventy-
eight (97,578) ordinary class D shares of the Company with a nominal value of one Norwegian Krone (NOK 1.-) each,
so redeemed.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5, article 7 and article 24 of the

articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions.

The first paragraph of article 5 will from now on read as follows:

Art. 5. Corporate capital. The share capital of the Company amounts to ninety-seven thousand five hundred ninety-

eight Norwegian Krone (NOK 97,598.-) divided into ninety-seven thousand five hundred seventy-eight (97,578) ordinary
class E shares (the "Ordinary Shares") and twenty (20) common shares (the "Common Shares") with a nominal value of
one Norwegian Krone (NOK 1.-) each.”

Article 7 will from now on read as follows:

“ Art 7. Increase and Reduction of Capital - Repurchase of own shares. The issued and/or authorised capital of the

Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules
set by the Law, the Articles for any amendment of these Articles and in due consideration of the terms of any shareholder
agreement as from time to time in effect.

187356

L

U X E M B O U R G

In case of any issue of shares each shareholder is entitled but not obliged to subscribe for such proportion of the

capital increase which the aggregate nominal value of shares held by him on the date immediately prior to the capital
increase bears to the aggregate of the total nominal value of shares then in issue on the same terms as the other share-
holders but only to the extent that such shareholder who subscribes for the newly issued shares also subscribes for any
other equity or debt securities in the same proportions and on the same terms as the other shareholders subscribe in
the framework of the respective capital increase, provided that each shareholder may agree to waive, and actually waive,
such preferential subscription right in circumstances agreed upon under a shareholders' agreement entered into between
the shareholders of the Company from time to time.

The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation. The acquisition shall be made in

compliance with the conditions and limits established by the Law and by these Articles and in due consideration of any
shareholders agreement entered into between the shareholders of the Company from time to time.

The Company shall repurchase Ordinary Shares on a pro rata basis between existing shareholders of the Company

holding Ordinary Shares.

The price at which the Ordinary Shares shall be purchased shall be calculated by reference to the economic rights, as

set out in article 24 of these Articles, attaching to any

Ordinary Shares to be repurchased.
The Company may repurchase its own shares subject to the following additional conditions:
(a) the Company may only repurchase shares that have been fully paid up;
(b) a repurchase at the relevant price can only be done to the extent the Company's freely distributable reserves allow

for repurchase or by using the proceeds of a new issuance of shares made with a view to carrying out such repurchase.”

Article 24 will from now on read as follows:

“ Art. 24. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company (the "Net Profits") at least five per

cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal
Reserve will cease to be compulsory as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the
nominal value of the issued capital of the Company. For the avoidance of doubt, the Net Profits shall be determined, and
distributions on shares shall be made as a consequence, in due consideration of any interest payment or other payments
to be made on relevant debt instruments issued by the Company from time to time.

Distributions on shares may be made out of Net Profits, share premium, carried forward profits, free reserves and all

other distributable sums (the "Distribution Amounts").

After the allocation to the Legal Reserve, and subject to the conditions that sufficient funds are available and the

shareholders deciding on such coupon distribution, the holders of Common Shares are each entitled to a fixed coupon
of zero point five per cent (0.5%) on the nominal value of their respective Common Shares distributed out of the remainder
of the Net Profits (the "Coupon Distribution").

After payment of the relevant Coupon Distribution and of amounts due under any debt instruments as from time to

time in issue and subject to compliance with the distribution entitlements of convertible instruments as from time to time
in issue, the general meeting of shareholders may, in consideration of any shareholders agreement as from time to time
in effect, distribute the Distribution Amounts to the Ordinary Shares as in issue at the time of the distribution, which
shall share pro rata in such distribution.

Subject to the conditions fixed by the Laws, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to

the shareholders. The Board of Managers fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.”

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolved to confer all and any powers to the Company’s managers to implement

the above resolutions.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).

The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of
divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 12.21 p.m..

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,

first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt et unième jour du mois de novembre,

187357

L

U X E M B O U R G

par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des associés de Seema Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée

régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de six millions six cent un mille cent quatre-vingt-dix couronnes
norvégiennes (NOK 6.601.190.-), ayant son siège social au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, constituée par acte notarié du 14 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 425 du 19 février 2008 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 135615 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné
en date du 23 octobre 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 12.11 heures sous la présidence de Maître Mélody Brunot, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Maître Cristiana Musteanu, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Maxime Bertomeu-Savalle, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour

1 Rachat de deux millions cent quatre-vingt-quinze mille trois cent cinquante-deux (2.195.352) parts sociales préfé-

rentielles de catégorie D de la Société, trois millions neuf cent dix-sept mille neuf cent vingt-huit (3.917.928) parts sociales
préférentielles de catégorie E, quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de
catégorie A de la Société, quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de
catégorie B de la Société, quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de
catégorie C de la Société et quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de
catégorie D de la Société d'une valeur nominale d'une couronne norvégienne (NOK 1.-) chacune.

2 Réduction du capital social de la Société d’un montant de six millions cinq cent trois mille cinq cent quatre-vingt-

douze couronnes norvégiennes (NOK 6.503.592,-) afin de le réduire de son montant actuel de six millions six cent un
mille cent quatre-vingt-dix couronnes norvégiennes (NOK 6.601.190.-) à quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatre-
vingt-dix-huit couronnes norvégiennes (NOK 97.598,-) par annulation de deux millions cent quatre-vingt-quinze mille
trois cent cinquante-deux (2.195.352) parts sociales préférentielles de catégorie D de la Société, trois millions neuf cent
dix-sept mille neuf cent vingt-huit (3.917.928) parts sociales préférentielles de catégorie E, quatre-vingt-dix-sept mille cinq
cent soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de catégorie A de la Société, quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent
soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de catégorie B de la Société, quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent
soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de catégorie C de la Société et quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent
soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de catégorie D de la Société d'une valeur nominale d'une couronne
norvégienne (NOK 1.-) chacune ainsi rachetées.

3 Modification de l’alinéa premier de l’article 5, de l’article 7 et de l’article 24 des statuts de la Société afin de refléter

la réduction de capital.

4 Délégation de tous pouvoirs aux gérants de la société pour la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus.
5 Divers.
(ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales détenues par les associés, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les associés présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

(iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été signées par les membres du bureau et le notaire

soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iv) Que l’intégralité du capital social était représentée à l’assemblée et tous les associés présents ou représentés ont

déclaré avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d’être formellement convoqués.

(v) Que l’assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points

portés à l’ordre du jour.

(vi) Que l’assemblée a pris, chaque fois à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés a décidé d’approuver le rachat de deux millions cent quatre-vingt-quinze mille trois

cent cinquante-deux (2.195.352) parts sociales préférentielles de catégorie D de la Société, de trois millions neuf cent
dix-sept mille neuf cent vingt-huit (3.917.928) parts sociales préférentielles de catégorie E, de quatre-vingt-dix-sept mille
cinq cent soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de catégorie A de la Société, de quatre-vingt-dix-sept mille

187358

L

U X E M B O U R G

cinq cent soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de catégorie B de la Société, de quatre-vingt-dix-sept mille
cinq cent soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de catégorie C de la Société et de quatre-vingt-dix-sept mille
cinq cent soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de catégorie D de la Société d'une valeur nominale d'une
couronne norvégienne (NOK 1.-) chacune, ce rachat prenant effet immédiatement.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés a décidé de réduire le capital social de la Société d’un montant de six millions cinq

cent trois mille cinq cent quatre-vingt-douze couronnes norvégiennes (NOK 6.503.592,-) afin de le réduire de son montant
actuel de six millions six cent un mille cent quatre-vingt-dix couronnes norvégiennes (NOK 6.601.190.-) à quatre-vingt-
dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit couronnes norvégiennes (NOK 97.598,-) par annulation de deux millions
cent quatre-vingt-quinze mille trois cent cinquante-deux (2.195.352) parts sociales préférentielles de catégorie D de la
Société, trois millions neuf cent dix-sept mille neuf cent vingt-huit (3.917.928) parts sociales préférentielles de catégorie
E, quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de catégorie A de la Société,
quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de catégorie B de la Société,
quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de catégorie C de la Société et
quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-dix-huit (97.578) parts sociales ordinaires de catégorie D de la Société d'une
valeur nominale d'une couronne norvégienne (NOK 1.-) chacune ainsi rachetées.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des associés a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5, l’article 7 et l’article 24 des

statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus.

Le premier alinéa de l’article 5 sera dorénavant rédigé comme suit:

« Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit couronnes

norvégiennes (NOK 97.598,-) divisé en quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-dix-huit (97.578) parts sociales
ordinaires de catégorie E (les "Parts Sociales Ordinaires") et vingt (20) parts sociales communes (les "Parts Sociales
Communes") d'une valeur nominale d’une couronne norvégienne (NOK 1.-) chacune.»

L’article 7 sera dorénavant rédigé comme suit:

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social - Rachat de parts sociales. Le capital souscrit et/ou autorisé de la

Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises par la Loi, aux Statuts pour toute modification des présents Statuts et en tenant compte des termes de tout
pacte d'associé alors en vigueur.

Dans l’hypothèse d'une émission de parts sociales, chaque associé est en droit mais n'est pas obligé de souscrire à une

proportion d'augmentation de capital égale à la valeur nominale totale des parts sociales qu'il détient à la date précédant
immédiatement l’augmentation de capital par rapport à la valeur nominale totale des parts sociales alors en circulation
aux mêmes termes que les autres associés, mais seulement dans la mesure où cet associé, qui souscrit aux nouvelles parts
sociales, souscrit également à tout autre titre participatif ou de dette dans les mêmes proportions et aux mêmes termes
que les autres associés qui souscrivent dans le cadre de cette augmentation de capital, sous réserve que chaque associé
puisse accepter de renoncer, et en fait renonce au droit préférentiel de souscription dans les conditions acceptées dans
un pacte d'associés qui pourrait être conclu entre les associés de la Société.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate. Le rachat doit être réalisé

conformément aux conditions et dans les limites fixées par la Loi et par les présents Statuts et en considération de tout
pacte d'associés qui pourrait être conclu entre les associés de la Société.

La Société doit racheter les Parts Sociales Ordinaires de manière proportionnelle entre les associés existants de la

Société qui détiennent des Parts Sociales Ordinaires.

Le prix auquel les Parts Sociales Ordinaires doivent être rachetées doit être calculé par référence aux droits écono-

miques, tels que fixés à l’article 24 des présents Statuts, attribués à toute Part Sociale Ordinaire à racheter.

La Société peut racheter ses propres parts sociales sous réserve des conditions supplémentaires suivantes:
(a) La Société ne peut racheter que les parts sociales qui ont été entièrement libérées;
(b) un rachat à un prix approprié ne peut être fait que dans la mesure où les réserves librement distribuables de la

Société permettent ce rachat ou par l’utilisation des procédures d'émission de nouvelles parts sociales réalisées avec
l’intention de procéder à ce rachat.»

L’article 24 sera dorénavant rédigé comme suit:

« Art. 24. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de l’exercice (les «Bénéfices Nets»), il sera prélevé au moins

cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve légale (la «Réserve Légale»). Cette affectation à la Réserve Légale
cessera d'être obligatoire lorsque la Réserve Légale aura atteint dix pour cent (10%) de la valeur nominale du capital social
de la Société. Pour éviter tout doute, les Bénéfices Nets doivent être déterminés, et les distributions sur les Parts Sociales
doivent être réalisées en conséquence, en considération de tout paiement de participation ou de tous autres paiements
à faire sur les instruments de dettes concernés émis par la Société de temps à autre.

187359

L

U X E M B O U R G

Les distributions sur parts sociales peuvent être réalisées sur les Bénéfices Nets, la prime d'émission, les bénéfices

reportés et toutes autres sommes distribuables (les «Montants Distribuables»).

Après affectation à la Réserve Légale, et sous réserve que des fonds suffisants soient disponibles et que les associés

approuvent une telle distribution de coupons, les détendeurs de Parts Sociales Communes sont chacun en droit de
recevoir un coupon de zéro virgule cinq pour cent (0,5%) de la valeur nominale de leurs Parts Sociales Communes
respectives, payé avec le solde des Bénéfices Nets (la «Distribution de Coupons»).

Après paiement de la Distribution de Coupons et des sommes dues à raison de tout instrument de dettes émis et

sous réserve des exigences de distributions d'instruments convertibles qui pourraient être émis, l’assemblée générale des
associés peut, eu égard à tout pacte d'associés qui pourrait être alors en vigueur, distribuer les Montants Distribuables
aux Parts Sociales Ordinaires en circulation à la date de la distribution, qui sera réparti sur une base proportionnelle.

Sous réserve des conditions fixées par les Lois, le Conseil de Gérance peut procéder au versement d'acomptes sur

dividendes aux associés. Le Conseil de Gérance fixe le montant ainsi que la date de paiement de cet acompte sur divi-
dendes.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des associés a décidé de donner tous pouvoirs aux gérants de la société pour la mise en oeuvre

des résolutions ci-dessus.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.21 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. Brunot, C. Musteanu, M. Bertomeu-Savalle, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 25 novembre 2014. REM/2014/2565. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192137/294.
(140213911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Shannon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.226.932,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 1, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 162.792.

<i>Extrait des décisions du Conseil de gérance tenu en date du 03 Septembre 2014

Le Conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la société au 1, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg avec

effet au 15 Juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Christophe Cahuzac
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014192140/15.
(140213529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

187360

L

U X E M B O U R G

Setup Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 121, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 192.266.

STATUTS

L’an deux mil quatorze, le vingtième jour du mois de novembre.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Madame Alessia PADUANO, employée privée, née le 5 juillet 1973 à Napoli (Italie), demeurant à L-5698 Welfrange,

16, Réimecherwee.

Laquelle comparante, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté

les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de:
„Setup Luxembourg S.à r.l.“

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg de l’accord des associés.

Art. 4. La Société a pour objet l’exploitation d'une maison d'édition et d'une agence de publicité comprenant tous

travaux de création, de conseil en communication et de gestion de budgets publicitaires.

L'activité de la Société comprend également la consultation, la programmation, le développement et l’exploitation

d'applications informatiques, de services multimédia, ainsi que tous produits de communication numérique ou interactive.

La Société peut également organiser et réaliser des événements et manifestations à caractère scientifique, culturel,

éducatif, récréatif ou professionnel en relation avec l’activité commerciale pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui.

En outre la Société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières ou de toutes espèces,
l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La Société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale

et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

La Société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immo-

bilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social. D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance
et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO (EUR 12.500.-) représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des

associés représentant au moins 75 % du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l’assemblée

générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

187361

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la

gérance.

Une décision n’est valablement prise qu'après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour

cent (50%) du capital social.

Aussi longtemps que la société n’a qu'un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l’assemblée générale des

associés par la loi ou par les présents statuts.

Les résolutions prises par l’associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2015.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part

dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, la comparante souscrit l’intégralité du capital comme suit:

Madame Alessia PADUANO, prénommée, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l’associé unique se donne quittance et décharge:
Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO

(EUR 12.500.-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il lui en a été justifié.

<i>Évaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille cent euros (1.100.-EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l’associé préqualifié, exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale, a

pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Alessia PADUANO, prénommée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique. En cas de pluralité de gérants, la

société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.

2) Le siège social est établi à L-1741 Luxembourg, 121 rue de Hollerich.
Le notaire instrumentant a rendu la comparante attentive au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

<i>Pouvoirs

La comparante donne pouvoir à tous clercs et employés de l’Étude du notaire soussigné, à l’effet de faire dresser et

signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

187362

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Alessia Paduano, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 21 novembre 2014. LAC / 2014 / 55205. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014192139/113.
(140213660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

SkyCom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5433 Niederdonven, 32, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 49.002.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 décembre 2014.

<i>Pour la société Skycom Sàrl
Signature

Référence de publication: 2014192142/12.
(140213899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

PolyOne Manufacturing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.020,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 168.801.

In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of November.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Spartech Luxembourg Holding Company S.à r.l., a “société à responsabilité limitée” governed by the laws of Luxem-

bourg, with registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share
capital of twenty-five thousand twenty Euros (EUR 25,020.-) and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 168.794, (the “Sole Shareholder”);

hereby represented by Carmen André, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

established on 3 November 2014.

The said proxy after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
It is the Sole Shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the

name of “Spartech International Manufacturing S.à r.l.” having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 168.801 and incorporated pursuant to a deed of Maître Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated 11
May 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1530 page 73424 dated 19 June
2012 (hereafter referred to as the “Company”). The Company’s articles of incorporation (the “Articles”) have been
amended on 27 June 2012 pursuant to a deed of Maître Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2021 page 96963 dated 14 August 2012.

The share capital of the Company is currently set at twenty thousand twenty United States Dollars (USD 20,020.-)

represented by one thousand and one (1,001) shares (parts sociales) of twenty United States Dollars (USD 20.-) each,
all subscribed and fully paid-up.

The appearing party, duly represented as stated hereinabove, having recognized to be fully informed of the resolutions

to be taken, has decided to vote on all items of the following agenda:

a. Decision to change the corporate denomination of the Company into “PolyOne Manufacturing S.à r.l.”; and
b. Subsequent modification of Article 4 of the articles of incorporation of the Company (“Denomination”).
Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

187363

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to change the corporate denomination of the Company into “PolyOne Manufacturing

S.à r.l.”.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder RESOLVES to amend the Article 4 of the Articles

of the Company (“Denomination”), so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination “PolyOne Manufacturing S.à r.l.”
There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,000.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le treizième jour du mois de novembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Spartech Luxembourg Holding Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg,

ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital
social de vingt-cinq mille vingt Euros (EUR 25.020,-) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 168.794, (l’«Associé Unique»);

Ici représentée par Carmen André, Juriste, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu d’une procuration

établie le 3 novembre 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour les besoins d’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Qu'elle est l’Associé Unique d’une société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «Spartech Inter-

national Manufacturing S.à r.l.» ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.801
et constituée suivant acte de Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 mai 2012, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1530 page 73424 en date du 19 juin 2012 (ci-après désignée
comme la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés le 27 juin 2012 suivant acte de Maître
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2021
page 96963 en date du 14 août 2012.

Le capital social de la Société s’élève actuellement à vingt mille vingt dollars américains (USD 20.020,-) représenté par

mille et une (1.001) parts sociales d’une valeur nominale de vingt dollars américains (USD 20,-) chacune, toutes entière-
ment souscrites et libérées.

La partie comparante, dûment représentée comme décrit ci-dessus, a reconnu être dûment informée des résolutions

à prendre, a décidé de voter sur tous les points de l’agenda reproduit ci-après:

a. Décision de changer la dénomination sociale de la Société en «PolyOne Manufacturing S.à r.l.»; et
b. Modification subséquente de l’article 4 des statuts de la Société («Dénomination»).
En conséquence et sur base de l’agenda repris ci-dessus, l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique DECIDE de changer la dénomination sociale de la Société en «PolyOne Manufacturing S.à r.l.».

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’Associé Unique DECIDE de modifier l’article 4 des Statuts de la Société,

qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: «PolyOne Manufacturing S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

187364

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du

présent acte, sont estimés à EUR 1.000.-.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le

présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE notarié, dressé et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire.
Signé: C. ANDRÉ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 novembre 2014. Relation: LAC/2014/55083. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192145/102.
(140214093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Saposa S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Capital social: EUR 1.012.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 148.521.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014192147/12.
(140213999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Sartcom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 20, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 184.255.

Par la présente, je vous informe de la démission de PME Xpertise en tant que commissaire aux comptes de la société

SARTCOM S.A. (RCSL B 184.255).

Le 02 décembre 2014.

PME Xpertise

Référence de publication: 2014192148/11.
(140214169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Sauren Fonds-Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 68.351.

<i>Auszug aus dem Protokoll Ordentliche Generalversammlung SAUREN FONDS-SELECT SICAV

Die Ordentliche Generalversammlung der SAUREN FONDS-SELECT SICAV vom 26. November 2014 hat folgende

Beschlüsse gefasst:

Zur Wiederwahl des Verwaltungsrates stellen sich

- Eckhard Sauren

Vorsitzender

- Claude Kremer

Mitglied

- Bernhard Singer

Mitglied

- Ulrich Janinhoff

Mitglied

Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.

187365

L

U X E M B O U R G

Die genannten Herren werden einstimmig von den Aktionären bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung

im Jahr 2015 als Verwaltungsrat gewählt.

Die Aktionäre beschließen einstimmig, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2015, Pricewate-

rhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, als Wirtschaftsprüfer wieder zu
wählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 26. November 2014.

<i>Für SAUREN FONDS-SELECT SICAV
DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2014192149/25.
(140213820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Sausalito S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grande Rue.

R.C.S. Luxembourg B 173.273.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014192150/12.
(140214043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Sinbuild S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 180.901.

Le bilan approuvé au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192163/10.
(140214111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Sit-Net S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4448 Soleuvre, 15, rue Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 76.338.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192164/9.
(140214025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Sinaf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 40.824.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SINAF S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2014192161/12.
(140213671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

187366

L

U X E M B O U R G

SLK Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 67.567.

L'an deux mille quatorze, le dix-septième jour du mois de novembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “SLK HOLDING SPF”, établie et ayant

son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 67567, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Frank MOLITOR, notaire
alors de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 14 décembre 1998, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 135 du 3 mars 1999,

et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le

notaire instrumentant, en date du 25 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2843 du 28 décembre 2010.

L'assemblée est présidée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le Président désigne Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement

à Luxembourg, comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Manette OLSEM, diplômé ès sciences économiques, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Abandon avec effet immédiat du statut de société de gestion de patrimoine familial (“SPF”); suppression dans les

statuts de toute référence à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial
(“SPF”);

2. Modification du premier alinéa de l’article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante: “Il est constitué par

les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions créées ci-après, une société
anonyme luxembourgeoise, dénommée “SLK HOLDING S.A.””;

3. Changement du libellé de l’objet social (article 2 des statuts) pour lui donner la teneur suivante: “La société a pour

objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière économique, commerciale et
financière ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation et la liquidation d’un patrimoine
mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente, l’échange, la location, la transfor-
mation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens mobiliers et immobiliers,
bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre compte que
pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations commerciales, indus-
trielles et financières, mobilières et immobilière se rattachant à directement ou indirectement à son objet; elle pourra
prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés; elle
pourra emprunter sous toutes les formes; elle pourra en outre investir dans l’acquisition de marques, brevets ou d’autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser
directement ou indirectement son extension ou son développement.”;

4. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l’assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée générale, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

187367

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'abandonner, avec effet immédiat, le statut de société de gestion de patrimoine familial (“SPF”),

et décide de supprimer dans les statuts toute référence à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de
gestion de patrimoine familial (“SPF”).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 1 

er

 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

“  Art. 1 

er

 . (premier alinéa).  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront

propriétaires des actions créées ci-après, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée “SLK HOLDING S.A.”.”

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer le libellé de l’objet social (article 2 des Statuts) pour lui donner la teneur suivante:

“ Art. 2. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière

économique, commerciale et financière ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation et
la  liquidation  d’un  patrimoine  mobilier  et  immobilier;  elle  pourra  notamment  employer  ses  fonds  à  l’achat,  la  vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises
et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilière se rattachant à directement ou indi-
rectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés; elle pourra emprunter sous toutes les formes; elle pourra en outre investir dans l’ac-
quisition de marques, brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature que se soit et effectuer
toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son développement.”

En l’absence d’autres points à l’ordre du jour, le Président ajourne l’assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de neuf cent quarante
euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. BRAUN, J-M. POOS, M. OLSEM, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 novembre 2014. LAC/2014/54736. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192166/92.
(140213963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Berkeley 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.754.

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of November,
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Berkeley Limited, an exempted company incorporated with limited liability under the laws of the Cayman Islands,

having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY-KY1-9005 George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered
with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number WK-222235,

here represented by Ms. Gersende Masfayon, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

187368

L

U X E M B O U R G

Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Berkeley 1 S.à r.l. (hereinafter the “Company”),

a société à responsabilité limitée, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number 132.754, incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on 26 September 2007 pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2653 on 20 November 2007. The articles of association were amended for the last time pursuant
to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, dated 20 January 2009 and published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 377 on 20 February 2009.

The Sole Shareholder, representing the entire share capital of the Company, requested the undersigned notary to

record the following resolutions:

<i>First resolution

In accordance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “1915

Law”), the Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into
liquidation.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to grant full discharge to the sole manager

of the Company for the exercise of his mandate.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr. John Sutherland, born on 2 December 1964 in Lower Hutt, New Zealand,

residing at 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Luxembourg, as liquidator of the Company with effect upon the date of the
present resolution of the Sole Shareholder and until full discharge is granted to him (the “Liquidator”).

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves that:
- the Liquidator shall prepare a report in respect of the results of the liquidation of the Company, in accordance with

article 151 of the 1915 Law;

- the Company shall be bound by the sole signature of the Liquidator, acting individually, or by the joint or single

signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the Liquidator; and

- the Liquidator shall have the broadest powers to perform its duties as provided for by articles 144 to 148 of the

1915 Law, and may accomplish all acts provided for by Article 145 without requesting further authorizations of the general
meeting of shareholders of the Company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le dix-huit novembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Berkeley Limited, une exempted limited liability company existant sous les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social

à 190, Elgin Avenue, KY-KY1-9005 George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans, inscrite au registre des sociétés des Iles
Caïmans sous le numéro WK-222235,

ici représentée par Gersende Masfayon, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé.

La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire, restera annexée au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.

Laquelle partie comparante est l’associé unique (l’«Associé Unique») de Berkeley 1 S.à r.l. (ci-après mentionnée comme

la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
132.754, constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg en date du 26 septembre 2007 suivant acte notarié de
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations sous le numéro 2653 le 20 novembre 2007. Les statuts ont été modifiés la dernière fois

187369

L

U X E M B O U R G

suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, prénommé, en date du 20 janvier 2009 et publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations sous le numéro 377, en date du 20 février 2009.

L’Associé Unique, représentant l’intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée (la «Loi de 1915»), l’Associé Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de mettre la Société
en liquidation.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de donner pleine et entière décharge au gérant

unique de la Société pour l’exercice de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de nommer Monsieur John Sutherland, né le 2 décembre 1964 à Lower Hutt, Nouvelle-

Zélande, résidant professionnellement au 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Luxembourg, en tant que liquidateur de la
Société avec effet à compter de la date de la présente résolution de l’Associé Unique et jusqu’à ce que quitus lui soit
donné (le «Liquidateur»).

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide que:
- le Liquidateur préparera un rapport sur les résultats de la liquidation de la Société, conformément à l’article 151 de

la Loi de 1915;

- la Société sera engagée par la seule signature du Liquidateur, agissant individuellement, ou par la signature conjointe

ou individuelle de toute(s) personne(s) à qui le Liquidateur aura délégué ses pouvoirs; et

- le Liquidateur disposera des plus larges pouvoirs pour effectuer sa mission tels que prévu par les articles 144 à 148

de la Loi de 1915 et pourra accomplir tous les actes prévus par l’Article 145 sans devoir requérir des autorisations
supplémentaires auprès de l’assemblée générale des associés de la Société.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français et qu'à la demande de la partie comparante et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et

résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. MASFAYON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 novembre 2014. Relation: LAC/2014/55100. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192340/108.
(140214427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Finedining S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.012.500,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 169.987.

<i>Rectificatif du depot L140160688 déposé le 10/09/2014

In the year two thousand fourteen, on the third day of the month of September.
Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

FINEDINING (CAYMAN) LIMITED, a company limited by shares governed by the laws of the Cayman Islands, having

its registered address at South Church Street, Ugland House, KY - KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands and regis-
tered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC-270383,

here represented by Flora Gibert, notary’s clerk with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg, by virtue of a proxy given privately.

187370

L

U X E M B O U R G

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "Finedining S.à r.l.", a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
address at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 169.987, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître
Joseph Elvinger, dated 4 July 2012, whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") number 1969 (page 94480) on 8 August 2012 (the "Company").
The Articles of the Company were amended for the last time on 3 October 2012 pursuant to a deed of the notary Maître
Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C number 2950
(page 141578) on 5 December 2012.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolution taken

in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915,
as amended, pursuant to which a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the
general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or
drawn up in writing:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to redesignate all the existing classes of shares in the share capital of the Company into

the following new classes of shares in the Company with the rights and obligations as set forth in the Articles as amended
by the fourth resolution as follows:

- twenty million one hundred twenty-five thousand (20,125,000) Class A Shares are redesignated as twenty million

one hundred twenty-five thousand (20,125,000) class A 1 shares;

- twenty million one hundred twenty-five thousand (20,125,000) Class B Shares are redesignated as twenty million one

hundred twenty-five thousand (20,125,000) class B 1 shares;

- twenty million one hundred twenty-five thousand (20,125,000) Class C Shares are redesignated as twenty million

one hundred twenty-five thousand (20,125,000) class C 1 shares;

- twenty million one hundred twenty-five thousand (20,125,000) Class D Shares are redesignated as twenty million

one hundred twenty-five thousand (20,125,000) class D 1 shares;

- twenty million one hundred twenty-five thousand (20,125,000) Class E Shares are redesignated as twenty million one

hundred twenty-five thousand (20,125,000) class E 1 shares;

- twenty million one hundred twenty-five thousand (20,125,000) Class F Shares are redesignated as twenty million one

hundred twenty-five thousand (20,125,000) class F 1 shares;

- twenty million one hundred twenty-five thousand (20,125,000) Class G Shares are redesignated as twenty million

one hundred twenty-five thousand (20,125,000) class G 1 shares;

- twenty million one hundred twenty-five thousand (20,125,000) Class H Shares are redesignated as twenty million

one hundred twenty-five thousand (20,125,000) class H 1 shares;

- twenty million one hundred twenty-five thousand (20,125,000) Class I Shares are redesignated as twenty million one

hundred twenty-five thousand (20,125,000) class I 1 shares; and

- twenty million one hundred twenty-five thousand (20,125,000) Class J Shares are redesignated as twenty million one

hundred twenty-five thousand (20,125,000) class J 1 shares.

The existing share premium of the Company will be available in respect of all shares of the Company.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company by seventeen Euro (EUR 17) from

its present amount of two million twelve thousand five hundred Euro (EUR 2,012,500) to two million twelve thousand
five hundred seventeen Euro (EUR 2,012,517), by creating and issuing.

- one hundred seventy (170) class A 1 shares;
- one hundred seventy (170) class B 1 shares;
- one hundred seventy (170) class C 1 shares:
- one hundred seventy (170) class D 1 shares;
- one hundred seventy (170) class E 1 shares;
- one hundred seventy (170) class F 1 shares;
- one hundred seventy (170) class G 1 shares;
- one hundred seventy (170) class H 1 shares;
- one hundred seventy (170) class I 1 shares; and
- one hundred seventy (170) class J 1 shares;

187371

L

U X E M B O U R G

(the "New Class 1 Shares"), each of these New Class 1 Shares having a par value of one Euro cent (0.01 EUR), and

being issued and fully paid up on the terms and conditions as set out in the Articles as amended by the fourth resolution.

The New Class 1 Shares are subscribed and fully paid up by FINEDINING (CAYMAN) LIMITED, prenamed, being the

sole existing shareholder of the Company.

Such New Class 1 Shares are paid up by a contribution in cash of an amount of eighteen Euro seventy Cents (EUR

18.70) to be allocated as follows: seventeen Euro (EUR 17.-) is allocated to the share capital of the Company and one
Euro seventy Cents (EUR 1.70) is allocated to the legal reserve of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company by two million four thousand four

hundred eighty-three Euro (EUR 2,004,483) from its present amount of two million twelve thousand five hundred Euro
(EUR 2,012,517) to four million seventeen thousand Euro (EUR 4,017,000), by creating and issuing the following new
classes of shares:

- twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class A 2 shares;
- twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class B 2 shares;
- twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class C 2 shares:
- twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class D 2 shares;
- twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class E 2 shares;
- twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class F 2 shares;
- twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class G 2 shares;
- twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class H 2 shares;
- twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class I 2 shares; and
- twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class J 2 shares;
(the "New Shares"), each of these New Shares having a par value of one Euro cent (0.01 EUR), and being issued on

the terms and conditions as set out in the Articles as amended by the fourth resolution, by a contribution in kind consisting
in:

- a freely transferable and unquestioned claim held by FIBA Beteiligungsund Anlage GmbH, a company incorporated

under the laws of Austria, having its registered office at Am See 28, A-5310 Mondsee, Austria, registered with the Austrian
commercial register under number FN236576 g ("FIBA") (the "Claim"). The Claim is contributed by FIBA to the Company
for an aggregate total amount of one hundred nine million nine hundred eighty thousand Euro (EUR 109,980,000) (the
"Contribution in Kind"), and this amount is allocated as follows: two million four thousand four hundred eighty-three
Euro (EUR 2,004,483) is allocated to the share capital of the Company, one hundred seven million seven hundred seventy-
five thousand sixty-eight Euro and seventy Cents (EUR 107,775,068.70) is allocated to the share premium account which
shall be available in respect of all shares of the Company and two hundred thousand four hundred forty-eight Euro and
thirty Cents (EUR 200,448.30) is allocated to the legal reserve of the Company.

The New Shares are wholly subscribed by FIBA.

<i>Subscription and Payment

FIBA, represented by Flora Gibert prenamed, declares to subscribe for all the New Shares of one Euro cent (EUR

0.01) each for a total issue price of one hundred nine million nine hundred eighty thousand Euro (EUR 109,980,000). The
total amount of one hundred nine million nine hundred eighty thousand Euro (EUR 109,980,000) is allocated as follows:
two million four thousand four hundred eighty-three Euro (EUR 2,004,483) is allocated to the share capital of the Company
and  one  hundred  seven  million  seven  hundred  seventy-five  thousand  sixty-eight  Euro  and  seventy  Cents  (EUR
107,775,068.70) is allocated to the share premium account which shall be available in respect of all shares of the Company
and two hundred thousand four hundred forty-eight Euro and thirty Cents (EUR 200,448.30) is allocated to the legal
reserve of the Company, and paid by the Contribution in Kind described above.

<i>Documents evidencing the valuation of the Contribution in Kind

The value of the Claim has been calculated and evaluated at one hundred nine million nine hundred eighty thousand

Euro (EUR 109,980,000) on the basis of the following documents, which will remain here annexed:

- a power of attorney duly executed by FIBA as subscriber of all the New Shares confirming the subscription of the

two hundred million four hundred fortyeight thousand three hundred (200,448,300) New Shares; and

- a valuation report from the management of the Company certifying the valuation of the Claim,

<i>Effective implementation of the Contribution in Kind

FIBA, represented as stated above, declares that:
- it has the power to transfer the Claim to the Company;

187372

L

U X E M B O U R G

- that the Claim exists, is unquestioned and freely transferable; and
- the transfer of the Claim will be effective from the date of the notarial deed enacting the increase of share capital of

the Company by creating and issuing the New Shares.

The Sole Shareholder and FIBA, represented as stated above, declare that:
- all further formalities have been carried out in the Grand Duchy of Luxembourg and in Germany in order to duly

formalise the transfer of the Claim to the Company and to render it effective anywhere and towards any third party.

Upon becoming shareholder of the Company pursuant to the third resolution, FIBA joins the Sole Shareholder (re-

ferred to with FIBA as the "Shareholders") in passing the following resolution:

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to fully restate the Articles of the Company in order to reflect the above decisions and to

include specific provisions regarding a shareholders' agreement relating to the Company, which shall henceforth read as
follows:

1. Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of Finedining

S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from
time to time (the "1915 Law").

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by the Board of Managers

if the Company has at the time a Board of Managers; or

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution

of the Shareholders (a "Shareholders’ Resolution") passed in accordance with these Articles - including Article 13.4 -and
the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which

would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Managers as
appropriate in the circumstances described in the previous sentence.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the

Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds
and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as invest-
ments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the

business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Board of Managers thinks fit and to lend

money and give credit in each case to any person with or without security;

3.4 to the extent necessary or desirable for the purposes of the other objects of the Company, to borrow, raise and

secure the payment of money in any way the Board of Managers thinks fit, including by the issue (to the extent permitted
by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not,
whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to
purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for

the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;

3.6 to the extent necessary or desirable for the purposes of the other objects of the Company, to enter into any

guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of the obligations of and/
or the payment of any money by any person (including any body corporate in which the Company has a direct or indirect
interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise has a direct or indirect
interest in the Company or any body corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect interest and any person
who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company receiving any consideration
or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part

187373

L

U X E M B O U R G

of the Company's undertaking, property or assets (present and future) or by other means; for the purposes of this Article
3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction
of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible
for, any indebtedness or financial obligations of any other person;

3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or

privilege over or in respect of it;

3.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of

the undertaking of the Company, for such consideration as the Board of Managers thinks fit, including for shares, deben-
tures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in
part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve,
manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with
all or any part of the property and rights of the Company;

3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,

agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone
or with another person or persons;

3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements

with or in favour of any person) that are in the opinion of the Board of Managers (as appropriate) incidental or conducive
to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity

of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.

4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

5. Share capital.
5.1 The issued share capital of the Company is four million seventeen thousand Euro (EUR 4,017,000) divided into:
twenty million one hundred twenty-five thousand one hundred seventy (20,125,170) class A 1 shares (the "Class A 1

Shares");

twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class A 2 shares (the "Class A 2 Shares");
twenty million one hundred twenty-five thousand one hundred seventy (20,125,170) class B 1 shares (the "Class B 1

Shares");

twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class B 2 shares (the "Class B 2 Shares");
twenty million one hundred twenty-five thousand one hundred seventy (20,125,170) class C 1 shares (the "Class C 1

Shares");

twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class C 2 shares (the "Class C 2 Shares");
twenty million one hundred twenty-five thousand one hundred seventy (20,125,170) class D 1 shares (the "Class D 1

Shares");

twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class D 2 shares (the "Class D 2 Shares");
twenty million one hundred twenty-five thousand one hundred seventy (20,125,170) class E 1 shares (the "Class E 1

Shares");

twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class E 2 shares (the "Class E 2 Shares");
twenty million one hundred twenty-five thousand one hundred seventy (20,125,170) class F 1 shares (the "Class F 1

Shares");

twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class F 2 shares (the "Class F 2 Shares");
twenty million one hundred twenty-five thousand one hundred seventy (20,125,170) class G 1 shares (the "Class G 1

Shares");

twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class G 2 shares (the "Class G 2 Shares");
twenty million one hundred twenty-five thousand one hundred seventy (20,125,170) class H 1 shares (the "Class H 1

Shares");

twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class H 2 shares (the "Class H 2 Shares");
twenty million one hundred twenty-five thousand one hundred seventy (20,125,170) class I 1 shares (the "Class I 1

Shares");

twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class I 2 shares (the "Class I 2 Shares");
twenty million one hundred twenty-five thousand one hundred seventy (20,125,170) class J 1 shares (the "Class J 1

Shares"); and

twenty million forty-four thousand eight hundred thirty (20,044,830) class J 2 shares (the "Class J 2 Shares"), each

having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) and the rights and obligations set out in these Articles. The Class 1 Shares

187374

L

U X E M B O U R G

and the Class 2 Shares have the same rights and obligations, except as provided for in Article 8 of these Articles or in
any Shareholders' Agreement.

5.2 The Ordinary Share capital of the Company may be reduced exclusively through the repurchase and subsequent

cancellation of all the issued shares of one or more classes of Ordinary Shares (an "Ordinary Share Redemption") in the
following order (Provided always that the share capital of the Company shall not be reduced below Eur 12,500):

the Class J Shares;
the Class I Shares;
the Class H Shares;
the Class G Shares;
the Class F Shares;
the Class E Shares;
the Class D Shares;
the Class C Shares;
the Class B Shares; and
the Class A Shares.
5.3 Upon an Ordinary Share Redemption becoming effective, the holders of the Ordinary Shares which are repurchased

by the Company as part of the Ordinary Share Redemption (the "Redeemed Ordinary Shares") will be paid the Redemp-
tion Price for each Redeemed Ordinary Share of the relevant Class.

5.4 In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share

is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s) subject to any appor-
tionment to any class or classes of Shares made by Shareholders Resolution passed by a majority in number of the
Shareholders representing three quarters of the Shares.

5.5 The Shares are in registered form.
5.6 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.
5.7 The subscribed share capital may be increased and new Shares may be issued in accordance with the conditions

required for the amendment of the Articles, with the 1915 Law and with the provisions of any Shareholders' Agreement.

6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the

Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that
representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend
and other payment rights.

7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Share-

holders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;

7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding

at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged
by Article 189 of the 1915 Law;

7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of Articles 189 and 190 of the 1915 Law.
7.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of any Shareholders' Agreement (including in relation to drag-

along or tag-along).

8. Management.
8.1 The Company will be managed by as many managers as are determined by Shareholders' Resolution, but not less

than three (3) managers and not more than four (4) managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'
Resolution passed in accordance with Luxembourg Law, these Articles and any Shareholders' Agreement as follows:

8.1.1 In the event that the Company has three Managers, one Manager will be nominated by notice in writing to the

Company by the holders of a majority of the Class 2 Shares, whereas the other Managers will be nominated by notice in
writing by the holders of a majority of the Class 1 Shares;

8.1.2 In case the Company has four Managers, two Managers will be nominated in writing by the holders of a majority

of the Class 2 Shares, whereas the other Managers will be nominated by notice in writing by the holders of a majority of
the Class 1 Shares;

The Managers will constitute a board of managers or conseil de gérance (the "Board of Managers").

187375

L

U X E M B O U R G

8.2 For the avoidance of doubt, no person shall be a Manager unless he or she has been nominated by the Holders of

a majority of the Class 1 Shares or the Holders of a majority of the Class 2 Shares in accordance with Article 8.1 or has
been deemed to have been so nominated in accordance with Article 8.1 and the Board of Managers shall only be validly
constituted if at least 3 Managers have been appointed in accordance with these provisions as required by Article 8.1.

8.3 For the avoidance of doubt, Martin Mix and Wolfgang Zettel are deemed to have been nominated by the holders

of a majority of the Class 1 Shares and Georg Bryan-Orr is deemed to have been nominated by the holders of a majority
of the Class 2 Shares and are the sole managers of the company.

8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with

Luxembourg Law, these Articles and any Shareholders' Agreement.

9. Powers of the managers. The Board of Managers may take all or any action which is necessary or useful to realise

any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles or any
Shareholders Agreement to be decided upon by the Shareholders.

10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company is validly bound or

represented towards third parties by:

10.1 the joint signature of any two Managers;
10.2 the sole signature of any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.

11. Agent of the managers. The Board of Managers may delegate any of their powers for specific tasks to one or more

ad hoc agents (which may include one or more Managers) and will determine any such agent’s powers and responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

12. Board meetings.
12.1 The Board of Managers shall appoint a chairman (the "Chairman") in accordance with any Shareholders' Agree-

ment.

12.2 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") shall be held at least quarterly per calendar year.
12.3 Board Meetings are convened by the Chairman in writing with at least fourteen (14) days' notice. Any Manager

is entitled, subject to specifying the subjects of the agenda, to request the Chairman to convene a Board Meeting, and if
the Chairman does not comply with such request, such Manager may convene the Board Meeting himself. In case of
urgency, the Chairman may reduce the notice period to not less than two (2) days in order to convene the Board Meetings
and furthermore he may convene the Board of Managers orally, by telephone, in text form or in writing. The day on
which the convening notice is sent out and the day on which the Board Meeting is held are not taken into consideration
for the calculation of the notice period. The subjects of the agenda should be included in the convening notice. For the
purposes of this Article, (a) a notice 'in writing' will include (without limitation) a copy of the notice signed by the Chairman
or the Manager convening the Board Meeting as appropriate sent by (i) telefascimile or (ii) by e-mail as a pdf attachment;
and (b) 'text form' means any textual form, including by SMS or by an e-mail setting out the notice by without the need
to attach a copy of the signed notice as a pdf attachment. The requirements for the convocation of Board Meetings
mentioned above in this Article 12.3 may be waived with the consent of all the Managers.

12.4 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's

Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person
or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.7.

12.5 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if all of the Managers are present or represented

(even if they abstain from voting). If such quorum is not reached, a new Board Meeting should be convened, in accordance
with Article 12.3, with the same agenda and respecting a notice period of at least five (5) days, or in case of urgency, of
at least two (2) days. In such a Board Meeting, the Board of Managers can validly debate and take decisions if at least two
(2) Managers are present or represented.

12.6 Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority (with the Chairman having the casting

vote in the event of a tie), subject to the provisions relating to reserved matters of any Shareholders' Agreement.

12.7 Subject as provided in any Shareholders' Agreement, a Manager or his Manager's Representative may validly

participate in a Board Meeting through the medium of conference telephone, video conference or similar form of com-
munications equipment provided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other
throughout the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall
be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the
Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting,
notwithstanding that fewer than the number of directors (or their representatives) required to constitute a quorum are
physically present in the same place.

12.8 Subject as provided in any Shareholders' Agreement, a resolution in writing signed by all the Managers (or in

relation to any Manager, his Manager's Representative) shall be as valid and effective if it had been passed at a Board

187376

L

U X E M B O U R G

Meeting duly convened and held and may consist of one or several documents in the like form each signed by or on behalf
of one or more of the Managers concerned.

12.9 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified

by any Manager present at the Meeting.

13. Shareholders' resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the Holder (regardless of whether the

shareholding comprises Class 1 Shares or Class 2 Shares).

13.2 Subject as provided in Articles 5.4, 13.2, 13.4, 13.5 and by Luxembourg Law and the provisions relating to reserved

matters in any Shareholders' Agreement (together the "Shareholder Resolution Provisos"), Shareholders' Resolutions
are only valid if they are passed by (a) a majority of the votes cast in respect of the resolution and (b) as required by
Luxembourg Law, by Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the
first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered
letter and the resolution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented
(subject to the Shareholder Resolution Provisos).

13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their

participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

13.4 Subject as provided in Article 13.2, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered

Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders repre-
senting three quarters of the Shares.

13.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint

the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.

13.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying

with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening
requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised
representative.

13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

13.8 The quorum for a Shareholders' Meeting shall be Shareholders present or represented at the meeting holding at

least 75% of the Shares unless all the Shareholders have waived these quorum requirements either in writing or, at the
relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative, subject as provided in Articles 13.2, 13.4,
13.5, the provisions of Luxembourg Law and the Shareholder Resolution Provisos, provided that if that quorum is not
reached at the first Shareholders' Meeting, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered
letter and the resolution may be passed at the second Shareholders' Meeting irrespective of the numbers of present or
represented Shares, except as provided in Articles 13.2, 13.4, 13.5, the provisions of Luxembourg Law and the Shareholder
Resolution Provisos.

13.9
13.9.1 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed

by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the
precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted.

13.9.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis

mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. For the avoidance of doubt, subject to the Shareholder
Resolution Provisos, Shareholders' Resolutions passed by written resolution are only valid if they are passed by Share-
holders holding more than three quarters of the Shares irrespective of whether or not all the Shareholders have voted,
provided that if that figure is not reached within 8 days of the draft written resolution being circulated by any Manager
to  Shareholders  for  signature,  then  the  written  resolution  may  be  recirculated  by  any  Manager  to  Shareholders  for
signature and, subject to the Shareholder Resolution Provisos the resolution may be passed by a majority of the votes
cast in writing, irrespective of the number of Shares represented and irrespective of whether or not all the Shareholders
have voted. Written resolutions of Shareholders shall be validly passed immediately upon receipt by the Company of
original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the
requirements as provided in Article 13.9.1 and this Article 13.9.2, irrespective of whether all Shareholders have voted or
not. For the avoidance of doubt, written resolutions may be circulated to Shareholders by facsimile transmission or an
e-mail attachment or by letter or any other method permitted by law.

14. Business year.

14.1 The Company’s financial year starts on 1 

st

 January and ends on the 31 

st

 December of each year provided that,

as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on the
following 31 December (all dates inclusive).

187377

L

U X E M B O U R G

14.2 If at the time the Company has more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be

held each year pursuant to Article 196 of the 1915 Law on the first Tuesday of the month of June at 11:00 of each year.
If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business day.

15. Distributions on shares.
15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted

and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve
fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Board of Managers shall propose, if they think it is appropriate, that cash available for
remittance be distributed.

15.3 The payment of any dividend (including interim dividends) shall be made in accordance with the provisions of any

Shareholders' Agreement and, in the case of a dividend in respect of any Ordinary Shares in accordance with the following
provisions:

a) First, the holders of Class A Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing

0.65% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class B Shares shall be granted a right
to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.60% of the nominal value of the Shares issued by the Company.
The holders of Class C Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.55% of
the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class D Shares shall be granted a right to receive,
pro rata, a preferred dividend representing 0.50% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders
of Class E Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.45% of the nominal
value of the Shares issued by the Company. The holders of Class F Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a
preferred dividend representing 0.40% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class
G Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.35% of the nominal value of
the Shares issued by the Company. The holders of Class H Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred
dividend representing 0.30% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class I Shares
shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.25% of the nominal value of the Shares
issued by the Company.

For the avoidance of doubt, the payments to be made under (a) are to be made on a pari passu basis between the

holders of the relevant class of Shares.

b) After the distribution set out under a) above, all remaining income available for further distribution (the "Excess")

in the Company, if any, shall be paid to the holders of Class J Shares (or if the Class J Shares have been cancelled and do
not exist anymore, to the holders of the Class I Shares; or if the Class I Shares have been cancelled and do not exist
anymore, to the holders of the Class H Shares; or if the Class H Shares have been cancelled and do not exist anymore,
to the holders of the Class G Shares; or if the Class G Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the
holders of the Class F Shares; or if the Class F Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of
the Class E Shares; or if the Class E Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of the Class D
Shares; or if the Class D Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of the Class C Shares; or
if the Class C Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of the Class B Shares; or if the Class
B Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of the Class A Shares).

For the avoidance of doubt, the payments to be made under (b) are to be made on a pari passu basis between the

holders of the relevant class of Ordinary Shares.

15.4 The Board of Managers may, subject to compliance with any Shareholders' Agreement, decide to pay interim

dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed,
where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according
to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned
shall be reimbursed by the Shareholder(s).

16. Dissolution and liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in

accordance with Luxembourg Law and Article 13 and any Shareholders' Agreement. If at the time the Company has only
one Shareholder, that Shareholder may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the
assets and liabilities, known or unknown, of the Company.

17. Definitions, interpretation and Luxembourg law.
17.1 Definitions:
17.1.1 "Available Amount" equals: (W + X + Y) - Z where W, X, Y and Z are the following amounts taken from the

Interim Accounts without double counting:

"W" means the net profits of the Company including carried forward profits less any losses of the Company including

carried forward losses;

187378

L

U X E M B O U R G

"X" means any freely distributable share premium and other freely distributable reserves of the Company other than

any premia included in Y and, for the avoidance of doubt, other than any share premium which only relates to shares
other than the Redeemed Shares;

"Y" means the amount paid up by way of par value and share premium on the Redeemed Shares;
"Z" means any sums to be placed into or retained in a non-distributable reserve pursuant to the requirements of law

or these Articles;

17.1.2 “Bankrupt” has the meaning given in article 437 of the Luxembourg Commercial Code;
17.1.3 “Board of Managers” has the meaning given by Article 8.1;
17.1.4 “Business Day” means a day other than a Saturday, Sunday or public holiday in Luxembourg;
17.1.5 "Class 1 Shareholders" means the holders at the relevant time of the Class 1 Shares and " Class 1 Shareholder"

shall be construed accordingly;

17.1.6 "Class 2 Shareholders" means the holders at the relevant time of the Class 2 Shares and " Class 2 Shareholder"

shall be construed accordingly;

17.1.7 "Class 1 Shares" means the Class A 1 Shares, the Class B 1 Shares, the Class C 1 Shares, the Class D 1 Shares,

Class E 1 Shares, Class F 1 Shares, Class G 1 Shares, Class H 1 Shares, Class I 1 Shares and the Class J 1 Shares;

17.1.8 "Class 2 Shares" means the Class A 2 Shares, the Class B 2 Shares, the Class C 2 Shares, the Class D 2 Shares,

Class E 2 Shares, Class F 2 Shares, Class G 2 Shares, Class H 2 Shares, Class I 2 Shares and the Class J 2 Shares;

17.1.9 "Class A Shares" means the Class A 1 Shares and the Class A 2 Shares;
17.1.10 "Class B Shares" means the Class B 1 Shares and the Class B 2 Shares;
17.1.11 "Class C Shares" means the Class C 1 Shares and the Class C 2 Shares;
17.1.12 "Class D Shares" means the Class D 1 Shares and the Class D 2 Shares;
17.1.13 "Class E Shares" means the Class E 1 Shares and the Class E 2 Shares;
17.1.14 "Class F Shares" means the Class F 1 Shares and the Class F 2 Shares;
17.1.15 "Class G Shares" means the Class G 1 Shares and the Class G 2 Shares;
17.1.16 "Class H Shares" means the Class H 1 Shares and the Class H 2 Shares;
17.1.17 "Class I Shares" means the Class I 1 Shares and the Class I 2 Shares;
17.1.18 "Class J Shares" means the Class J 1 Shares and the Class J 2 Shares;
17.1.19 "Distributions" means all payments to be made by the Company in respect of the Shares including (a) in respect

of dividends, yield, repurchase, cancellation and/or redemption and (b) on or following a liquidation or dissolution of the
Company;

17.1.20 "Interim Accounts" are management accounts of the Company;
17.1.21 “Liquidation” means any voluntary or involuntary or compulsory liquidation, bankruptcy, dissolution or winding

up of the affairs of the Company;

17.1.22 "Ordinary Share Redemption" has the meaning given to it in Article 5.2;
17.1.23 "Ordinary Shares" means the Class 1 Shares and the Class 2 Shares;
17.1.24 "Redeemed Ordinary Share" has the meaning given to it by Article 5.3;
17.1.25 "Redemption Price" equals the Total Redemption Amount in relation to the relevant Class or Classes of Shares

divided by the total number of Redeemed Ordinary Shares of the relevant Class or Classes of Shares;

17.1.26 “Registered Address” means the address (or e-mail address or fax number as appropriate) of a Shareholder

as recorded in the share register of the Company;

17.1.27 "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed

accordingly;

17.1.28 “Shareholders Agreement” means any shareholders agreement to be entered into between FINEDINING

(CAYMAN) LIMITED and FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH as such agreement may be amended, restated, supple-
mented or otherwise modified from time to time in accordance with the terms thereof;

17.1.29 "Shareholders' Resolution" has the meaning given to it by Article 2.2.2;
17.1.30 “Shares” means the shares in the capital of the Company in issue from time to time;
17.1.31 "Total Redemption Amount" is such amount as is determined by resolution of the Board of Managers and

approved by general meeting of the Shareholders in each case consistent with the terms of any Shareholders' Agreement,
not exceeding the Available Amount.

17.2 In these Articles:
17.2.1 a reference to:
(a) any statutory provision or statute or council directive includes all modifications thereto and all re-enactments (with

or without modification) thereof and all subordinate legislation made thereunder, in each case for the time being in force,
except where the context requires otherwise;

187379

L

U X E M B O U R G

(b) a “person” includes a reference to an individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,

state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative
body (whether or not having a separate legal personality);

(c) a document is a reference to that document as amended, restated, varied, novated, supplemented or replaced from

time to time;

(d) a person includes, where appropriate, a reference to that person's legal personal representatives, successors and

permitted assigns;

(e) one gender shall include each gender; and
(f) the singular includes the plural and vice versa (unless the context otherwise requires).
17.2.2 The headings in these Articles do not affect their interpretation.
17.2.3 The ejusdem generis principle of construction shall not apply to these Articles. Accordingly general words shall

not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular class of
acts, matters or things or by examples falling within the general words.

17.3 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law."

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to seven thousand Euros.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a German version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his/her name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Followed by the German translation of the above:

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dritten Tag des Monats September,
ist vor Uns, dem unterzeichnenden Notar Joseph Elvinger, Notar, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg,

ERSCHIENEN

FINEDINING (CAYMAN) LIMITED, eine nach dem Recht der Kaimaninseln gegründete Aktiengesellschaft, mit Ge-

sellschaftssitz  in  South  Church  Street,  Ugland  House,  KY  -  KY1-1104  Grand  Cayman,  Kaimaninseln,  und  im  Gesell-
schaftsregister der Kaimaninseln eingetragen unter der Nummer MC-270383,

hier vertreten durch Flora Gibert geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund einer erteilten Vollmacht;
Die vorgenannte Vollmacht, nach "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten des Erschienenen und den

amtierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Der Erschienene ist der alleinige Gesellschafter (der "Alleinige Gesellschafter") von "Finedining S.à r.l.", eine Luxem-

burger Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B
169.987, gegründet durch eine notarielle Urkunde, welche von dem Notar Joseph Elvinger, Notar, am 4. Juli 2012 erstellt
wurde, dessen Satzung (die "Satzung") im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial C") unter der
Nummer 1969 (Seite 94480) am 8. August 2012 veröffentlicht wurde (die "Gesellschaft"). Die Satzung wurde zum letzten
Mal am 3. Oktober 2012, durch eine notarielle Urkunde des Notars Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sanem, Groß-
herzogtum  Luxemburg,  welche  im  Mémorial  C  unter  der  Nummer  2950  (Seite  141578)  am  5.  Dezember  2012
veröffentlicht wurde, abgeändert.

Der Erschienene, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ersucht den Notar, gemäß den Bedingungen des

Artikels 200-2 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in abgeänderter Form, nach
welchem der alleinige Gesellschafter einer société à responsabilité limitée die Machtbefugnisse einer Hauptversammlung,
in Form eines Protokolls oder in Form eines Schreibens, ausführen kann, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, alle bestehenden Klassen von Stammgeschäftsanteilen am Kapital der Gesell-

schaft in die folgenden neuen Klassen von Stammgeschäftsanteilen der Gesellschaft, mit den in der durch den vierten
Beschluss geänderten Satzung aufgeführten Rechten und Pflichten, wie folgt abzuändern:

- Zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Stammgeschäftsanteile der Klasse A werden in

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Klasse A 1 Stammgeschäftsanteile umgewandelt;

- Zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Stammgeschäftsanteile der Klasse B werden in

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Klasse B 1 Stammgeschäftsanteile umgewandelt;

187380

L

U X E M B O U R G

- Zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Stammgeschäftsanteile der Klasse C werden in

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Klasse C 1 Stammgeschäftsanteile umgewandelt;

- Zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Stammgeschäftsanteile der Klasse D werden in

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Klasse D 1 Stammgeschäftsanteile umgewandelt;

- Zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Stammgeschäftsanteile der Klasse E werden in

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Klasse E 1 Stammgeschäftsanteile umgewandelt;

- Zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Stammgeschäftsanteile der Klasse F werden in

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Klasse F 1 Stammgeschäftsanteile umgewandelt;

- Zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Stammgeschäftsanteile der Klasse G werden in

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Klasse G 1 Stammgeschäftsanteile umgewandelt;

- Zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Stammgeschäftsanteile der Klasse H werden in

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Klasse H 1 Stammgeschäftsanteile umgewandelt;

-  Zwanzig  Millionen  einhundertfünfundzwanzigtausend  (20.125.000)  Stammgeschäftsanteile  der  Klasse  I  werden  in

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Klasse I 1 Stammgeschäftsanteile umgewandelt;

-  Zwanzig  Millionen  einhundertfünfundzwanzigtausend  (20.125.000)  Stammgeschäftsanteile  der  Klasse  J  werden  in

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend (20.125.000) Klasse J 1 Stammgeschäftsanteile umgewandelt;

Das bestehende Aufgeld der Gesellschaft wird im Hinblick auf alle Stammgeschäftsanteile der Gesellschaft verfügbar

gemacht.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, das ausgegebene Kapital der Gesellschaft um siebzehn Euro (EUR 17) vom

aktuellen Betrag in Höhe von zwei Millionen zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 2.012.500) auf zwei Millionen zwölf-
tausendfünfhundertsiebzehn Euro (EUR 2.012.517) zu erhöhen, durch die Schaffung und Ausgabe von:

- einhundertsiebzig (170) Klasse A 1 Stammgeschäftsanteile;
- einhundertsiebzig (170) Klasse B 1 Stammgeschäftsanteile;
- einhundertsiebzig (170) Klasse C 1 Stammgeschäftsanteile;
- einhundertsiebzig (170) Klasse D 1 Stammgeschäftsanteile;
- einhundertsiebzig (170) Klasse E 1 Stammgeschäftsanteile;
- einhundertsiebzig (170) Klasse F 1 Stammgeschäftsanteile;
- einhundertsiebzig (170) Klasse G 1 Stammgeschäftsanteile;
- einhundertsiebzig (170) Klasse H 1 Stammgeschäftsanteile;
- einhundertsiebzig (170) Klasse I 1 Stammgeschäftsanteile; und
- einhundertsiebzig (170) Klasse J 1 Stammgeschäftsanteile;
(die "Neuen Klasse 1 Stammgeschäftsanteile"), mit einem Nennwert von je einem Eurocent (0,01 EUR) pro Neue

Klasse 1 Stammgeschäftsanteil, und ausgegeben und vollständig eingezahlt gemäß Bedingungen und Voraussetzungen der
Satzung, welche im vierten Beschluss angegeben ist.

Die Neuen Klasse 1 Stammgeschäftsanteile werden gezeichnet und vollständig eingezahlt durch die obengenannte

FINEDINING (CAYMAN) LIMITED, welche alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist.

Die Neuen Klasse 1 Stammgeschäftsanteile werden durch Bareinlage in Höhe von siebzehn Euro (EUR 18,70) einge-

zahlt, welche wie folgt aufgeteilt werden: siebzehn Euro (EUR 17,-) werden in voller Höhe dem Kapital der Gesellschaft
zugeordnet und ein Euro siebzig (EUR 1,70) werden der gesetzlichen Rücklage zugeordnet.

Die Bescheinigung über das Bestehen und die Summe der Einlage wurden dem unterzeichnenden Notar vorgelegt.

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, das ausgegebene Kapital der Gesellschaft um zwei Millionen viertausendvier-

hundertdreiundachtzig Euro (EUR 2.004.483) zu erhöhen, so dass das aktuelle Gesellschaftskapital von zwei Millionen
zwölftausendfünfhundertsiebzehn Euro (EUR 2.012.517) auf vier Millionen siebzehntausend Euro (EUR 4.017.000) erhöht
wird, indem neue Stammgeschäftsanteilsklassen geschaffen und ausgegeben werden:

- Zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20,044,830) Klasse A 2 Stammgeschäftsanteile;
- Zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20,044,830) Klasse B 2 Stammgeschäftsanteile;
- Zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20,044,830) Klasse C 2 Stammgeschäftsanteile;
- Zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20,044,830) Klasse D 2 Stammgeschäftsanteile;
- Zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20,044,830) Klasse E 2 Stammgeschäftsanteile;
- Zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20,044,830) Klasse F 2 Stammgeschäftsanteile;
- Zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20,044,830) Klasse G 2 Stammgeschäftsanteile;
- Zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20,044,830) Klasse H 2 Stammgeschäftsanteile;
- Zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20,044,830) Klasse I 2 Stammgeschäftsanteile;

187381

L

U X E M B O U R G

- Zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20,044,830) Klasse J 2 Stammgeschäftsanteile;
(die "Neuen Stammgeschäftsanteile"), wobei jeder Neue Stammgeschäftsanteil einen Nennwert von einem Eurocent

(0,01 EUR) hat und, gemäß den Bedingungen und Konditionen der Satzung, welche im vierten Beschluss geändert wurde,
ausgegeben und komplett durch folgende Sacheinlage eingezahlt:

- eine frei übertragbare und unstreitige Forderung gehalten von FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH, eine Gesellschaft

mit beschränkter Haftung österreichischen Rechts, mit Gesellschaftssitz Am See 28, A-5310 Mondsee, Österreich, und
eingetragen im österreichischen Firmenbuch unter der Nummer FN236576g ("FIBA") (die "Forderung"), Die Forderung
wird von FIBA für die Gesellschaft zu einem Gesamtbetrag von einhundertneun Millionen neunhundertachtzigtausend
Euro (EUR 109.980.000) eingelegt (die "Sacheinlage"), und dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt: zwei Millionen viertau-
sendvierhundertdreiundachtzig Euro (EUR 2.004.483) werden dem Kapital der Gesellschaft zugeteilt, einhundertsieben
Millionen siebenhundertfünfundsiebzigtausendachtundsechzig Euro und siebzig Cent (EUR 107.775.068,70) werden dem
Aufgeldkonto zugeteilt, welches hinsichtlich aller Anteile verfügbar gemacht wird, und zweihunderttausendvierhunder-
tachtundvierzig Euro und dreißig Cent (EUR 200.448,30) werden der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeteilt.

Die Neuen Stammgeschäftsanteile werden komplett von FIBA gezeichnet.

<i>Zeichnung- und Einzahlung

FIBA, vertreten durch Flora Gibert, wie oben angegeben, erklärt alle Neuen Stammgeschäftsanteile zu je einem Cent

(EUR 0,01) und zu einem gesamten Emissionspreis von einhundertneun Millionen neunhundertachtzigtausend Euro (EUR
109.980.000)  zu  zeichnen.  Der  Gesamtbetrag  von  einhundertneun  Millionen  neunhundertachtzigtausend  Euro  (EUR
109.980.000) wird wie folgt aufgeteilt: zwei Millionen viertausendvierhundertdreiundachtzig Euro (EUR 2.004.483) werden
dem Kapital der Gesellschaft zugeteilt, einhundertsieben Millionen siebenhundertfünfundsiebzigtausendachtundsechzig
Euro und siebzig Cent (EUR 107.775.068,70) werden dem Aufgeldkonto zugeteilt und zweihunderttausendvierhunder-
tachtundvierzig Euro und dreißig Cent (EUR 200.448,30) werden der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeteilt,
und eingezahlt gegen die Sacheinlage wie oben beschrieben.

<i>Dokumente, die den Wert der Sacheinlage belegen

Der Wert der Forderung wurde berechnet und bewertet mit einem Ergebnis von einhundertneun Millionen neun-

hundertachtzigtausend Euro (EUR 109.980.000) auf Basis folgender Dokumente, welche hier als Anhang beigefügt werden:

- Eine Bevollmächtigung, die von FIBA, als Unterzeichner der Neuen Stammgeschäftsanteile, ausgeführt wird und die

die Zeichnung von zweihundert Millionen vierhundertachtundvierzigtausenddreihundert (200.448.300) Neuen Stamm-
geschäftsanteilen bestätigt; und

- Bewertungsgutachten der Geschäftsführung der Gesellschaft welche den Wert der Forderung bestätigt.

<i>Wirksame Umsetzung der Sacheinlage

FIBA, vertreten durch einen Bevollmächtigten, wie oben angegeben, erklärt:
- bevollmächtigt zu sein, die Forderung an die Gesellschaft zu übertragen;
- dass die Forderung existiert und dass sie unstreitig und frei übertragbar ist; und
- dass die Übertragung der Forderung mit der Unterzeichnung der notariellen Urkunde, welche die Kapitalerhöhung

sowie die Zeichnung und Ausgabe der Neuen Stammgeschäftsanteile beurkundet, wirksam wird.

Der Alleinige Gesellschafter und FIBA, vertreten durch einen Bevollmächtigten, wie oben angegeben, bestätigen:
- dass alle Förmlichkeiten, bezüglich einer ordnungsgemäßen Übertragung der Forderung an die Gesellschaft, im Groß-

herzogtum Luxemburg und in Deutschland erfüllt wurden, so dass diese überall und gegen jede dritte Person ausgeführt
werden kann.

Nachdem FIBA Gesellschafter der Gesellschaft wurde, beschließt FIBA zusammen mit dem Alleinigen Gesellschafter

(nachstehend: zusammen mit FIBA, die "Gesellschafter") folgenden Beschluss:

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die Satzung der Gesellschaft komplett abzuändern um die obengenannten Beschlüsse

umzusetzen und die spezifischen Bestimmungen bezüglich der Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern in Bezug auf
die Gesellschaft einzubeziehen, die wie folgt gefasst wird:

1. Rechtsform und name der gesellschaft. Die Gesellschaft besteht in der Rechtsform einer Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter dem Namen "Finedining S.à r.l." (im Folgenden die "Gesell-
schaft"). Die Gesellschaft unterliegt insbesondere dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften in der jeweils gültigen Fassung (im Folgenden das "Gesetz von 1915") und den Vorschriften dieser Satzung (im
Folgenden die "Satzung").

2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft (der "Sitz") ist in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).
2.2 Der Gesellschaftssitz kann verlegt werden:

187382

L

U X E M B O U R G

2.2.1 innerhalb derselben Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg durch den Rat der Geschäftsführer für den Fall,

dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat; oder

2.2.2 an jeden Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg (inner- oder außerhalb derselben Gemeinde) durch

Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter (im Folgenden die "Beschlüsse der Hauptversammlung") gemäß der
vorliegenden Satzung (einschließlich Artikel 13.4) und der jeweils geltenden Fassung der Gesetze des Großherzogtums
Luxemburgs, einschließlich des Gesetzes von 1915 (das "Luxemburger Recht").

2.3 Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der ordnungsgemäße Geschäftsverkehr zwischen

diesem Sitz und dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher, gesellschaft-
licher oder sonstiger Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, welche, ungeachtet der vorübergehenden Sitzverlegung, stets eine Luxemburger Gesellschaft bleibt. Der
Beschluss über die vorübergehende Sitzverlegung der Gesellschaft wird entsprechend durch den Rat der Geschäftsführer
getroffen in den im vorigen Satz beschriebenen Umständen.

2.4 Niederlassungen oder andere Repräsentanzen können sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland

eröffnet werden.

3. Gesellschaftszweck. Gesellschaftszweck ist es:
3.1 als Beteiligungsgesellschaft ("Holdinggesellschaft") zu fungieren und die geschäftlichen Tätigkeiten der juristischen

Personen, an denen sie direkt oder indirekt eine Beteiligung hält, zu koordinieren. Hierunter fallen auch der Teiloder
Gesamterwerb (ob durch originäre Zeichnung, Ausschreibung, Kauf, Tausch oder anderweitig) von Aktien, Anteilen,
Schuldverschreibungen, Obligationen, Anleihen sowie von sonstigen Vermögensgenständen und Wertpapieren jeglicher
Art, mit dem Ziel, diese als Anlage zu halten, zu tauschen, zu verkaufen oder auf sonstige Weise zu disponieren;

3.2 alle möglichen Handelsgeschäfte auszuführen sowie Gewerbe zu betreiben und das gesamte Geschäft oder Teile

des Geschäfts, die Liegenschaften und/oder Verbindlichkeiten jeder Person, die entsprechende Geschäfte ausübt, zu er-
werben, abzuwickeln und auszuüben;

3.3 Geld und Vermögensmittel der Gesellschaft anzulegen oder mit diesen zu handeln, Kredite und Darlehen zu ge-

währen, und zwar zu den Bedingungen, die von den Geschäftsführern als angemessen erachtet werden, mit oder ohne
Stellung von Sicherheiten;

3.4 soweit erforderlich oder erwünscht zur Erfüllung anderer Gesellschaftszwecke, Kredite in jeglicher Form aufzu-

nehmen oder sonstige Kreditfazilitäten zu nutzen, Gelder aufzubringen zu den Bedingungen, die von den Geschäftsführern
als  angemessen  erachtet  werden.  Dies  umfasst  auch  Ausgabe,  Erwerb,  Umwandlung,  Einlösung  und  Abrechnung  von
Schuldscheinen und sonstigen dauerhaften oder anderen, konvertierbaren oder nicht konvertierbaren Forderungs- oder
Kapitalinstrumenten, unabhängig davon, ob das (bestehende oder zukünftige) Unternehmenseigentum oder noch nicht
aufgerufenes Kapital ganz oder teilweise belastet werden (soweit dies nach Luxemburger Recht zulässig ist);

3.5 Beteiligungen an Dritten zu erwerben oder mit diesen zu verschmelzen, zu fusionieren, sich zusammenzuschließen,

in eine Partnerschaft oder eine andere Vereinbarung zum Zwecke der Profitteilung zu treten, eine Interessensgemein-
schaft oder eine Kooperation einzugehen, Gemeinschaftsunternehmen zu gründen, gegenseitige Zugeständnisse oder
anderweitige Vereinbarungen mit beliebigen Personen, einschließlich der eigenen Mitarbeiter, zu treffen;

3.6 soweit erforderlich oder erwünscht zur Erfüllung anderer Gesellschaftszwecke, Garantien, Garantieverträge oder

Bürgschaften abzuschließen sowie Sicherheiten für die Erfüllung der sich hieraus ergebenen Verpflichtungen bereitzustel-
len. Darunter fallen auch Geldleistungen von einer beliebigen Person (unter Einbeziehung aller juristischen Personen, an
denen die Gesellschaft eine direkte oder indirekte Beteiligung in beliebiger Höhe hält sowie jeder Person ("einer Hol-
dinggesellschaft"), die direkt oder indirekt eine Beteiligung an der Gesellschaft hält oder der gleichen Unternehmensgruppe
angehört sowie jede Person, die auf sonstige Weise mit der Gesellschaft geschäftlich oder unternehmerisch verbunden
ist), unabhängig davon, ob die Gesellschaft dadurch (mittelbar oder unmittelbar) eine Gegenleistung oder einen Vorteil
erhält und unabhängig davon, ob eine persönliche Zusage oder eine Hypothek, eine Belastung oder ein Zurückbehal-
tungsrecht über einen Teil oder die Gesamtheit der Verpflichtungen der Gesellschaft, das Eigentum oder das (aktuelle
und zukünftige) Vermögen oder Sonstiges besteht. Der Begriff "Garantie" im Sinne dieses Artikels 3.6 umfasst jede Art
von Verbindlichkeit, unabhängig von ihrer genauen Bezeichnung und zugleich die Verpflichtung, diese zu bezahlen, zu
erfüllen, finanzielle Mittel für die Bezahlung und Begleichung zur Verfügung zu stellen, Zahlungen im Fall des Zahlungs-
ausfalls sicherzustellen und abzusichern beziehungsweise anderweitig für die Verbindlichkeiten oder finanzielle Verpflich-
tungen anderer Personen zu haften;

3.7 bewegliches oder unbewegliches Vermögen (Grundbesitz) zu kaufen, zu pachten, auszutauschen, zu mieten oder

anderweitig zu erwerben. Dies umfasst zudem sämtliche sonstigen diesbezüglichen Rechte oder Sonderrechte;

3.8 jede Art von beweglichen oder unbeweglichen Vermögen sowie Teile oder die Gesamtheit der Verpflichtungen

der Gesellschaft zu verkaufen, zu verleihen auszutauschen, zu vermieten oder darüber zu verfügen, soweit dies von den
Geschäftsführern als angemessen erachtet wird. Dies umfasst Aktien, Schuldverschreibungen und andere Sicherheiten,
welche entweder bereits ganz oder teilweise eingezahlt wurden, von beliebigen Personen, unabhängig davon, ob sie (ganz
oder teilweise) vergleichbare Zwecke verfolgen. Ferner umfasst dies auch das Recht, Gesellschaftsanteile, Schuldver-
schreibungen und andere erworbene Sicherheiten zu halten sowie Eigentum und Rechte der Gesellschaft in Teilen oder

187383

L

U X E M B O U R G

als Ganzes zu verbessern, zu verwalten, zu entwickeln, zu verkaufen, auszutauschen, zu verleihen, zu belasten, darüber
zu verfügen, Optionsrechte zu übertragen, zu verwerten oder anderweitig damit zu verfahren;

3.9 jede Art von Handlungen, die in den einzelnen Absätzen dieses Artikels 3 genannt sind (a) weltweit, (b) als Ge-

schäftsherr, Bevollmächtigter, Vertragspartner, Treuhänder oder sonstiges, (c) von oder über einen Treuhänder, Bevoll-
mächtigten,  Nachunternehmer  oder  sonstigen  (d)  eigenständig  oder  zusammen  mit  einer  oder  mehreren  anderen
Personen vorzunehmen;

3.10 jede Art von Handlungen, die von den Geschäftsführern für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks oder für die

Ausführung aller ihrer Kompetenzen als förderlich oder zielführend erachtet werden, vorzunehmen (dies umfasst den
Abschluss, die Ausführung oder die Ausübung von Verträgen, Urkunden, Abkommen und Vereinbarungen mit oder zu-
gunsten beliebiger Personen);

STETS UNTER DER VORAUSSETZUNG, dass die Gesellschaft keine Transaktionen tätigt, welche in den Bereich der

reglementierten Tätigkeiten des Finanzsektors fallen oder eine Geschäftserlaubnis nach Luxemburger Recht voraussetzen,
solange sie jeweils keine entsprechende Erlaubnis besitzt.

4. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine unbeschränkte Zeitdauer errichtet.

5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das ausgegebene Gesellschaftskapital beträgt vier Millionen siebzehntausend Euro (EUR 4.017.000,-), eingeteilt in:
zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausendeinhundertsiebzig (20.125.170) Klasse A 1 Stammgeschäftsanteile

(die "Klasse A 1 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20.044.830) Klasse A 2 Stammgeschäftsanteile (die "Klasse

A 2 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausendeinhundertsiebzig (20.125.170) Klasse B 1 Stammgeschäftsanteile

(die "Klasse B 1 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20.044.830) Klasse B 2 Stammgeschäftsanteile (die "Klasse

B 2 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausendeinhundertsiebzig (20.125.170) Klasse C 1 Stammgeschäftsanteile

(die "Klasse C 1 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20.044.830) Klasse C 2 Stammgeschäftsanteile (die "Klasse

C 2 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausendeinhundertsiebzig (20.125.170) Klasse D 1 Stammgeschäftsanteile

(die "Klasse D 1 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20.044.830) Klasse D 2 Stammgeschäftsanteile (die "Klasse

D 2 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausendeinhundertsiebzig (20.125.170) Klasse E 1 Stammgeschäftsanteile

(die "Klasse E 1 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20.044.830) Klasse E 2 Stammgeschäftsanteile (die "Klasse

E 2 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausendeinhundertsiebzig (20.125.170) Klasse F 1 Stammgeschäftsanteile

(die "Klasse F 1 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20.044.830) Klasse F 2 Stammgeschäftsanteile (die "Klasse

F 2 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausendeinhundertsiebzig (20.125.170) Klasse G 1 Stammgeschäftsanteile

(die "Klasse G 1 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20.044.830) Klasse G 2 Stammgeschäftsanteile (die "Klasse

G 2 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausendeinhundertsiebzig (20.125.170) Klasse H 1 Stammgeschäftsanteile

(die "Klasse H 1 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20.044.830) Klasse H 2 Stammgeschäftsanteile (die "Klasse

H 2 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausendeinhundertsiebzig (20.125.170) Klasse I 1 Stammgeschäftsanteile

(die "Klasse I 1 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20.044.830) Klasse I 2 Stammgeschäftsanteile (die "Klasse

I 2 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen einhundertfünfundzwanzigtausendeinhundertsiebzig (20.125.170) Klasse J 1 Stammgeschäftsanteile

(die "Klasse J 1 Stammgeschäftsanteile");

zwanzig Millionen vierundvierzigtausendachthundertdreißig (20.044.830) Klasse J 2 Stammgeschäftsanteile (die "Klasse

J 2 Stammgeschäftsanteile");

187384

L

U X E M B O U R G

mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01) und den in dieser Satzung dargelegten Rechten und Pflichten.

Die Klasse 1 Stammgeschäftsanteile und die Klasse 2 Stammgeschäftsanteile haben die gleiche Rechte und Pflichten, vor-
behaltlich des Artikels 8 dieser Satzung oder einer etwaigen Gesellschaftervereinbarung.

5.2 Das Kapital der Stammgeschäftsanteile der Gesellschaft kann nur durch den Rückkauf und die anschließende An-

nullierung aller ausgegebenen Gesellschaftsanteile einer oder mehreren Klassen von Stammgeschäftsanteilen reduziert
werden (der "Rückkauf der Stammgeschäftsanteile") und dies in der nachstehenden Reihenfolge (immer vorausgesetzt,
dass das Gesellschaftskapital der Gesellschaft nicht unter EUR 12.500,- herabgesetzt wird):

die Klasse J Stammgeschäftsanteile;
die Klasse I Stammgeschäftsanteile;
die Klasse H Stammgeschäftsanteile;
die Klasse G Stammgeschäftsanteile;
die Klasse F Stammgeschäftsanteile;
die Klasse E Stammgeschäftsanteile;
die Klasse D Stammgeschäftsanteile;
die Klasse C Stammgeschäftsanteile;
die Klasse B Stammgeschäftsanteile; und
die Klasse A Stammgeschäftsanteile.
5.3 Beim Wirksamwerden eines Rückkaufs der Stammgeschäftsanteile, wird den Besitzern der im Rahmen eines Rück-

kaufs der Stammgeschäftsanteile durch die Gesellschaft zurückgekauften Stammgeschäftsanteile (die "Zurückgekauften
Stammgeschäftsanteile") der Rückkaufs Preis für jeden Rückgekauften Stammgeschäftsanteil der betreffenden Klasse ge-
zahlt.

5.4 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital, kann ein Aufgeldkonto eröffnet werden, auf welches etwaige Anteilsaufgelder

einzuzahlen sind. Der Betrag dieses Kontos steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung, vorausgesetzt die etwaigen
Zuteilungen an eine Klasse oder Klassen von Stammgeschäftsanteilen erfolgte durch einen Beschluss der Hauptversamm-
lung,  der  von  einer  zahlenmäßigen  Mehrheit  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  der  Stammgeschäftsanteile  halten,
angenommen worden sind.

5.5 Alle Stammgeschäftsanteile sind Namensanteile.
5.6 Alle Stammgeschäftsanteile haben die gleichen Rechte, vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in dieser

Satzung.

5.7 Das ausgegebene Gesellschaftkapital kann erhöht werden und neue Stammgeschäftsanteile können ausgegeben

werden im Einklang mit den zur Änderung der Satzung benötigten Bedingungen, mit dem Gesetz von 1915 und den
Bestimmungen einer etwaigen Gesellschaftervereinbarung.

6. Unteilbarkeit der gesellschaftsanteile.
6.1 Die Anteile sind unteilbar.
6.2 In begründeten Einzelfällen können mehrere Personen als Inhaber desselben Anteils eingetragen werden. Voraus-

setzung dafür ist, dass alle Inhaber der Anteile die Gesellschaft schriftlich darüber in Kenntnis setzen, welcher Inhaber als
Vertreter fungieren soll. Die Gesellschaft wird diesen Anteileninhaber so behandeln, als ob er der einzige Inhaber sei.
Dies gilt auch im Hinblick auf Abstimmungen, Dividenden oder sonstige Zahlungsansprüche.

7. Übertragung der Anteile.
7.1 Solange die Gesellschaft nur einen Anteilseigner hat, sind die Anteile frei übertragbar.
7.2 Sofern die Gesellschaft mehr als einen Anteilseigner hat, gilt:
7.2.1 Anteile dürfen, mit Ausnahme von Sterbefällen, nicht an Nichtgesellschafter übertragen werden. Es sei denn, dass

Anteilseigner, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, der Übertragung in der Hauptversammlung
zugestimmt haben.

7.2.2 Die Übertragung von Anteilen an Nichtgesellschafter infolge Sterbefalls bedarf der Zustimmung von Gesellschaf-

tern, die mindestens drei Viertel der Anteile der Hinterbliebenen halten oder das Vorliegen eines der in Artikel 189 des
Gesetz von 1915 vorgesehenen Umstände;

7.2.3 Die Übertragung von Anteilen unterliegt den Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes von 1915.
7.3 Die Übertragung von Anteilen unterliegt den Bestimmungen etwaiger Gesellschaftervereinbarungen (einschließlich

in Bezug auf Drag-along oder Tagalong).

8. Geschäftsführung.
8.1 Die Gesellschaft wird von so vielen Geschäftsführern verwaltet, wie durch Beschluss der Gesellschafter bestimmt

wird, doch nicht weniger als drei (3) Geschäftsführer und nicht mehr als vier (4) Geschäftsführer, ("Geschäftsführer"),
welche durch Beschluss der Gesellschafter im Einklang mit Luxemburger Recht, dieser Satzung und etwaigen Gesell-
schaftervereinbarungen wie folgt ernannt werden:

187385

L

U X E M B O U R G

8.1.1 Im Falle, dass die Gesellschaft über drei Geschäftsführer verfügt, wird ein Geschäftsführer von den Anteilsinhabern

der Klasse 2 Stammgeschäftsanteile durch schriftliche Benachrichtigung an die Gesellschaft ernannt, wohingegen die an-
deren Geschäftsführer von den Anteilsinhabern der Klasse 1 Stammgeschäftsanteile durch schriftliche Benachrichtigung
ernannt werden;

8.1.2 Falls die Gesellschaft über vier Geschäftsführer verfügt, werden zwei Geschäftsführer von den Anteilsinhabern

der Klasse 2 Stammgeschäftsanteile durch schriftliche Benachrichtigung an die Gesellschaft ernannt, während die anderen
Geschäftsführer von den Anteilsinhabern der Klasse 1 Stammgeschäftsanteile durch schriftliche Notiz an die Gesellschaft
ernannt werden;

Die Geschäftsführer bilden einen Geschäftsführerrat (oder conseil de gérance) (der "Rat der Geschäftsführer").
8.2 Um jeden Zweifel auszuschließen, kann niemand Geschäftsführer werden wenn er oder sie nicht von einer Mehrheit

von  Anteilsinhabern  der  Klasse  1  Stammgeschäftsanteile  oder  von  einer  Mehrheit  von  Anteilsinhabern  der  Klasse  2
Stammgeschäftsanteile im Einklang mit Artikel 8.1 ernannt wurde oder als im Einklang mit Artikel 8.1 ernannt worden
erachtet wird und der Rat der Geschäftsführer ist nur gültig gebildet, wenn mindestens 3 Geschäftsführer im Einklang mit
diesen Bestimmungen ernannt wurden wie in Artikel 8.1 vorgesehen.

8.3 Um jeden Zweifel auszuschließen, gelten Martin Mix und Wolfgang Zettel als von einer Mehrheit von Anteilsinha-

bern der Klasse 1 Stammgeschäftsanteile ernannt und Georg Bryan-Orr gilt als von einer Mehrheit von Anteilsinhabern
der Klasse 2 Stammgeschäftsanteile ernannt und sind die einzige Geschäftsführer der Gesellschaft.

8.4 Ein Geschäftsführer kann jederzeit und aus beliebigem Grund durch einen Beschluss der Gesellschafter, welcher

im Einklang mit dieser Satzung, Luxemburger Recht und etwaigen Gesellschaftervereinbarungen gefasst worden ist, ab-
berufen werden.

9. Befugnisse der Geschäftsführung. Der Rat der Geschäftsführer ist befugt, alle Geschäfte der Gesellschaft vorzuneh-

men, die notwendig oder zweckmäßig sind, um den Gesellschaftszweck zu erfüllen, außer solchen, die durch das Gesetz,
diese Satzung oder etwaigen Gesellschaftervereinbarungen ausdrücklich den Gesellschaftern vorbehalten sind.

10. Rechtmässige Vertretung. Die Gesellschaft wird, gemäß Luxemburger Recht und der vorliegenden Satzung, ge-

genüber Dritten wie folgt vertreten und/oder wirksam verpflichtet:

10.1 durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils zwei Geschäftsführern;
10.2 durch die alleinige Unterschrift einer anderen Person, sofern dieser Person entsprechende Befugnisse gemäß

Artikel 11 übertragen worden sind.

11. Ad-hoc Bevollmächtigte. Der Rat der Geschäftsführer kann seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben jeweils auf

einen oder mehrere Ad-Hoc Bevollmächtigte übertragen (hierzu können auch einer oder mehrere Geschäftsführer zäh-
len). Er legt diesbezüglich sowohl die Dauer der Vertretung, den Verantwortungsbereich, die Vergütung (falls einschlägig)
als auch jede andere Bedingung fest.

12. Geschäftsführerversammlung.
12.1 Der Rat der Geschäftsführer ernennt im Einklang mit etwaigen Gesellschaftervereinbarungen einen Vorsitzenden

(der "Vorsitzende").

12.2 Sitzungen des Rats der Geschäftsführer ("Geschäftsführerversammlung") finden mindestens viermal pro Kalen-

derjahr statt.

12.3 Geschäftsführerversammlungen werden durch den Vorsitzenden mit einer Frist von mindestens vierzehn (14)

Tagen schriftlich einberufen. Jeder Geschäftsführer ist berechtigt, unter Angabe der Tagesordnungspunkte jederzeit vom
Vorsitzenden die Einberufung einer Geschäftsführerversammlung zu verlangen und, wenn der Vorsitzende diesem Ver-
langen nicht nachkommt, selbst einzuberufen. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist auf nicht weniger als
zwei (2) Tage verkürzen und außerdem mündlich, fernmündlich, in Textform oder schriftlich einberufen. Bei der Berech-
nung der Frist werden jeweils der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. Mit der
Einberufung sind die Tagesordnungspunkte mitzuteilen. Im Sinne dieses Artikels, (a) umfasst eine "schriftliche" Einberu-
fungsnachricht  die  Kopie  der  vom  Vorsitzenden  oder  dem  Geschäftsführer,  der  die  Geschäftsführerversammlung
einberuft, wie jeweils anwendbar unterschriebenen Einberufungsnachricht übersandt per (i) Telefax oder (ii) E-Mail als
PDF-Anhalt und (b) Textform umfasst jegliche textliche Form, inbegriffen per SMS oder per E-Mail, die die Einberufungs-
nachricht darlegt ohne den Bedarf eine Kopie der unterschriebenen Einberufungsnachricht als PDF-Anhang beizufügen.
Auf die oben in diesem Artikel 12.3 genannten Anforderungen für die Einberufung der Geschäftsführerversammlungen
kann mit der Zustimmung aller Geschäftsführer verzichtet werden.

12.4 Jeder Geschäftsführer kann sich durch ein anderen Geschäftsführer (nicht aber durch eine beliebige andere Per-

son)  auf  einer  Geschäftsführerversammlung  vertreten  lassen  (der  "Vertreter  eines  Geschäftsführers"),  um  in  seinem
Namen an der Sitzung teilzunehmen, zu verhandeln, abzustimmen und sämtliche Funktionen auszuüben. Ein Geschäfts-
führer  kann  als  Vertreter  für  mehrere  Geschäftsführer  auf  einer  Geschäftsführerversammlung  auftreten,  unter  der
Voraussetzung (unbeschadet etwaiger Quorumerfordernisse), dass mindestens zwei Geschäftsführer physisch auf der
Geschäftsführerversammlung persönlich anwesend sind oder aber unter der Voraussetzungen des Artikels 12.7 persönlich
an der Geschäftsführerversammlung teilnehmen.

187386

L

U X E M B O U R G

12.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur wirksam beraten und Beschlüsse fassen, wenn alle Geschäftsführer anwe-

send oder vertreten sind (auch wenn diese sich der Stimme enthalten). Falls solch ein Quorum nicht erreicht wird, wird
gemäß Artikel 12.3 eine neue Geschäftsführerversammlung einberufen, mit der gleichen Tagesordnung und mit Einhaltung
einer Frist von mindestens fünf (5) Tagen, oder im Notfall, von mindestens zwei (2) Tagen. In solch einer Geschäftsfüh-
rerversammlung kann der Rat der Geschäftsführer wirksam debattieren und Entscheidungen fällen, wenn mindestens zwei
(2) Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

12.6  Die  Entscheidungen  der  Geschäftsführerversammlung  werden  durch  einfache  Mehrheit  getroffen  (wobei  der

Vorsitzende im Fall von Stimmengleichheit über eine Ausschlag gebende Stimme verfügt), vorbehaltlich der sich in etwaigen
Gesellschaftervereinbarungen auf vorbehaltene Angelegenheiten beziehenden Bestimmungen.

12.7 Vorbehaltlich etwaiger Gesellschaftervereinbarungen, kann ein Geschäftsführer beziehungsweise dessen Vertre-

ter wirksam an einer Geschäftsführerversammlung via Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleich-
bares Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt, dass alle Teilnehmer während der Sitzung in der Lage sind, sich
gegenseitig zu hören und zu sprechen. Alle in dieser Weise teilnehmenden Personen gelten als persönlich in der Sitzung
anwesend, werden im Quorum mitgezählt und können ihre Stimme abgeben. Alle Geschäfte, die auf diese Art und Weise
von den Geschäftsführern getätigt werden, gelten nach Maßgabe des Luxemburger Rechts im Sinne dieser Satzung als
zulässig und wirksam in der Geschäftsführerversammlung getätigt. Dies gilt auch dann, wenn weniger als die für eine
Abstimmung vorausgesetzte Anzahl von Geschäftsführern (oder deren Vertretern) physisch an demselben Ort anwesend
sind.

12.8 Vorbehaltlich etwaiger Gesellschaftervereinbarungen, ist ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsfüh-

rern  (beziehungsweise  dem  jeweiligen  Vertreter  eines  Geschäftsführers)  unterzeichnet  wurde,  ordnungsgemäß  und
rechtskräftig und steht einem Beschluss, der in einer ordnungsgemäß einberufenen sowie abgehaltenen Geschäftsführer-
versammlung  gefasst  wurde,  gleich.  Ein  solcher  Beschluss  kann  aus  einem  oder  mehreren  ähnlichen  Dokumenten
bestehen, die jeweils von den betreffenden Geschäftsführern oder deren Vertretern unterschrieben wurden.

12.9 Jeder in der Geschäftsführerversammlung anwesende Geschäftsführer kann die Sitzungsprotokolle der Geschäfts-

führerversammlung unterschreiben und die Auszüge der Sitzungsprotokolle beglaubigen.

13. Beschlüsse der Gesellschafter.
13.1 Jeder Gesellschafter hat eine Stimme pro Anteil, dessen Anteilsinhaber er ist (unabhängig davon ob der Anteilbesitz

Klasse 1 Stammgeschäftsanteile oder Klasse 2 Stammgeschäftsanteile umfasst).

13.2 Vorbehaltlich der Regelungen in den Artikeln 5.4, 13.2, 13.4, 13.5 und dem Luxemburger Recht und der sich in

etwaigen Gesellschaftervereinbarungen auf vorbehaltene Angelegenheiten beziehenden Bestimmungen (zusammen die
"Provisos der Beschlüsse der Gesellschafter") sind Beschlüsse der Gesellschafter nur wirksam, wenn sie (a) von einer
Mehrheit der im Zusammenhang mit dem Beschluss abgegebenen Stimmen gefasst wurden (b) wenn sie gemäß Luxem-
burger Recht von Gesellschaftern verabschiedet werden, die mindestens die Hälfte der Anteile halten. Soweit diese Anzahl
bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten schriftlichen Beschluss nicht erreicht wird, sollen die Gesellschafter ein
zweites Mal per Einschreiben einberufen oder konsultiert werden. Die Entscheidung kann sodann mit der Mehrheit der
anwesenden Stimmen ergehen, unabhängig von der Anzahl der vertretenen Anteile (vorbehaltlich der Provisos der Be-
schlüsse der Gesellschafter).

13.3 Die Verpflichtung eines Gesellschafters zur Erhöhung seiner Beteiligung gegenüber an der Gesellschaft sowie die

Änderung der Nationalität der Gesellschaft können nur durch einen einstimmigen Beschluss erfolgen.

13.4 Vorbehaltlich der Regelungen in Artikel 13.3 werden Beschlüsse, die die Änderung dieser Satzung zum Gegenstand

haben (einschließlich der Verlegung des Gesellschaftssitzes), soweit nichts anderes bestimmt ist, von den Gesellschaftern,
die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, mit einfacher Mehrheit beschlossen.

13.5 Ein Beschluss, der die Auflösung oder die Art der Liquidierung der Gesellschaft zum Gegenstand hat, muss im

Einklang mit dem Luxemburger Recht verabschiedet werden.

13.6 Eine Hauptversammlung der Gesellschafter ("Hauptversammlung") kann ohne Einhaltung aller oder irgendeiner

der Einberufungserfordernisse und -formalitäten wirksam beraten und Entscheidungen treffen, wenn alle Gesellschafter
auf die entsprechenden Einberufungserfordernisse und -formalitäten entweder schriftlich oder auf der jeweiligen Haupt-
versammlung, persönlich oder durch einen bevollmächtigten Stellvertreter, verzichtet haben.

13.7 Ein Gesellschafter kann auf einer Hauptversammlung vertreten sein, indem er schriftlich (auch per Fax, E-Mail

oder dergleichen) einen Stellvertreter oder Bevollmächtigten, der kein Gesellschafter zu sein braucht, benennt.

13.8 Das Quorum für eine Hauptversammlung liegt bei Gesellschaftern die anwesend oder vertreten sind und min-

destens 75% der Stammgeschäftsanteile besitzen es sei denn, alle Gesellschafter haben auf diese Quorum-Anforderungen,
schriftlich oder, bei der entsprechenden Hauptversammlung, in Person oder durch einen Bevollmächtigten, vorbehaltlich
der Bestimmungen von Artikel 13.3, 13.4, 13.5, der Bestimmungen des Luxemburger Rechts und der Provisos der Be-
schlüsse der Gesellschafter verzichtet. Dem ist vorausgesetzt, dass falls das Quorum bei der ersten Hauptversammlung
nicht erreicht wird, die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreiben einberufen oder konsultiert werden, und der
Beschluss bei der zweiten Hauptversammlung ungeachtet der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Stammgeschäfts-
anteilen, abgesehen der Bestimmungen von Artikel 13.3, 13.4, 13.5, der Bestimmungen des Luxemburger Rechts und der
Provisos der Beschlüsse der Gesellschafter, gefasst wird.

187387

L

U X E M B O U R G

13.9
13.9.1 Soweit die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können Beschlüsse, anstatt auf Ge-

sellschafterversammlungen, auch schriftlich ergehen. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den genauen Text der zu
fassenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

13.9.2 Die Mehrheitserfordernisse, die im Hinblick auf die Verabschiedung von Beschlüssen auf Gesellschafterver-

sammlungen  gelten,  finden  auch  auf  schriftliche  Beschlüsse  entsprechend  Anwendung  (mutatis  mutandis).  Um  jeden
Zweifel auszuschließen, vorbehaltlich der Provisos der Beschlüsse der Gesellschafter, sind Beschlüsse der Gesellschafter
nur dann verabschiedet, wenn sie von Gesellschaftern verabschiedet wurden, die mindestens drei Viertel der Stammge-
schäftsanteile besitzen, ohne Rücksicht darauf ob alle Gesellschafter abgestimmt haben, vorausgesetzt, dass falls diese
Anzahl nicht binnen 8 Tagen nach dem Versenden durch einen Geschäftsführer des Entwurfs des schriftlichen Beschlusses
zur Unterschrift durch die Gesellschafter erreicht wurde, kann der schriftliche Beschluss wieder durch einen Geschäfts-
führer an die Gesellschafter versendet werden und, vorbehaltlich der Provisos der Beschlüsse der Gesellschafter, kann
der schriftliche Beschluss durch eine Mehrheit der schriftlichen Abstimmungen, ohne Rücksicht auf die Anzahl der ver-
tretenen Stammgeschäftsanteile und darauf, ob alle Gesellschafter abgestimmt haben, verabschiedet werden. Die schrift-
lichen Beschlüsse der Gesellschafter sollen mit dem Eingang der Originalkopien (oder per Fax oder Email gesendete
Kopien) der Stimmabgaben der Gesellschafter, vorbehaltlich der Regelungen in den Artikeln 13.9.1 und 13.9.2, als gültig
verabschiedet gelten, unabhängig davon, ob alle Gesellschafter abgestimmt haben. Um Zweifel auszuschließen können
schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter per Fax oder E-Mail-Anhang oder Schreiben oder jeder anderen durch Gesetz
vorgesehene Methode übersendet werden.

14. Geschäftsjahr.
14.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Januar des Jahres und endet jeweils am 31. Dezember

des Jahres. Als Übergangsbestimmung beginnt das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft am Tag der Gründung der Ge-
sellschaft und endet am folgenden 31. Dezember (jeweils einschließlich).

14.2 Soweit die Gesellschaft zum maßgeblichen Zeitpunkt mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, müssen

gemäß Artikel 196 des Gesetzes von 1915 mindestens einmal im Jahr, am ersten Dienstag des Monats Juni um 11 Uhr
Gesellschafterversammlungen abgehalten werden. Sollte dieser Tag kein Bankarbeitstag, sein wird diese Versammlung am
folgenden Bankarbeitstag abgehalten.

15. Ergebnisbeteiligung und Ausschüttungen.
15.1 Vom Nettogewinn, welcher in Übereinstimmung mit den anwendbaren rechtlichen Bestimmungen ermittelt wur-

de, werden fünf Prozent (5%) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung
der Rücklage endet, wenn diese Rücklage einen Betrag erreicht hat, der zehn (10%) Prozent des Gesellschaftskapitals
entspricht 15.2 Sofern ausschüttungsfähige Beträge bei der Gesellschaft vorhanden sind, und soweit gesetzlich zulässig
und  durch  diese  Satzung  erlaubt,  soll  die  Ausschüttung  von  verfügbarem  ausschüttbarem  Kapital  durch  den  Rat  der
Geschäftsführer vorgeschlagen werden, falls diese es für angemessen halten.

15.3 Die Auszahlung etwaiger Dividenden (einschließlich Interimsdividenden) wird im Einklang mit den Bestimmungen

etwaiger Gesellschaftervereinbarungen und, im Fall von Dividenden bezüglich Stammgeschäftsanteilen im Einklang mit
folgenden Bestimmungen erfolgen:

(a) Zuerst, sollen die Inhaber der Klasse A Stammgeschäftsanteile ein pro rata Recht auf Vorzugsdividende von 0,65%

des Nennwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Stammgeschäftsanteile erhalten. Die Inhaber der Klasse B Stamm-
geschäftsanteile  sollen  ein  pro  rata  Recht  auf  Vorzugsdividende  von  0,60%  des  Nennwerts  der  von  der  Gesellschaft
ausgegebenen Stammgeschäftsanteile erhalten. Die Inhaber der Klasse C Stammgeschäftsanteile sollen ein pro rata Recht
auf Vorzugsdividende von 0,55% des Nennwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Stammgeschäftsanteile erhalten.
Die Inhaber der Klasse D Stammgeschäftsanteile sollen ein pro rata Recht auf Vorzugsdividende von 0,50% des Nennwerts
der von der Gesellschaft ausgegebenen Stammgeschäftsanteile erhalten. Die Inhaber der Klasse E Stammgeschäftsanteile
sollen ein pro rata Recht auf Vorzugsdividende von 0,45% des Nennwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Stamm-
geschäftsanteile erhalten. Die Inhaber der Klasse F Stammgeschäftsanteile sollen ein pro rata Recht auf Vorzugsdividende
von 0,40% des Nennwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Stammgeschäftsanteile erhalten. Die Inhaber der Klasse
G Stammgeschäftsanteile sollen ein pro rata Recht auf Vorzugsdividende von 0,35% des Nennwerts der von der Gesell-
schaft ausgegebenen Stammgeschäftsanteile erhalten. Die Inhaber der Klasse H Stammgeschäftsanteile sollen ein pro rata
Recht auf Vorzugsdividende von 0,30% des Nennwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Stammgeschäftsanteile
erhalten. Die Inhaber der Klasse I Stammgeschäftsanteile sollen ein pro rata Recht auf Vorzugsdividende von 0,25% des
Nennwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Stammgeschäftsanteile erhalten.

Um Zweifel auszuschließen, sollen die Auszahlungen die unter (a) getätigt werden auf einer pari passu Basis zwischen

den Inhabern der jeweiligen Klasse von Stammgeschäftsanteilen erfolgen.

(b) Nach der unter (a) hier oben vorgesehenen Ausschüttung, wird das eventuell zur Verteilung in der Gesellschaft

verbleibende Einkommen (der "Überschuss"), an die Inhaber der Klasse J Stammgeschäftsanteile ausgeschüttet (oder falls
die Klasse J Stammgeschäftsanteile annulliert wurden und nicht mehr existieren, an die Inhaber der Klasse I Stammge-
schäftsanteile; oder falls die Klasse I Stammgeschäftsanteile annulliert wurden und nicht mehr existieren, an die Inhaber
der Klasse H Stammgeschäftsanteile; oder falls die Klasse H Stammgeschäftsanteile annulliert wurden und nicht mehr

187388

L

U X E M B O U R G

existieren, an die Inhaber der Klasse G Stammgeschäftsanteile; oder falls die Klasse G Stammgeschäftsanteile annulliert
wurden und nicht mehr existieren, an die Inhaber der Klasse F Stammgeschäftsanteile; oder falls die Klasse F Stammge-
schäftsanteile annulliert wurden und nicht mehr existieren, an die Inhaber der Klasse E Stammgeschäftsanteile; oder falls
die Klasse E Stammgeschäftsanteile annulliert wurden und nicht mehr existieren, an die Inhaber der Klasse D Stammge-
schäftsanteile; oder falls die Klasse D Stammgeschäftsanteile annulliert wurden und nicht mehr existieren, an die Inhaber
der Klasse C Stammgeschäftsanteile; oder falls die Klasse C Stammgeschäftsanteile annulliert wurden und nicht mehr
existieren, an die Inhaber der Klasse B Stammgeschäftsanteile; oder falls die Klasse B Stammgeschäftsanteile annulliert
wurden und nicht mehr existieren, an die Inhaber der Klasse A Stammgeschäftsanteile).

Um jeden Zweifel auszuschließen, sollen die Auszahlungen die unter (b) getätigt werden auf einer pari passu Basis

zwischen den Inhabern der jeweiligen Klasse von Stammgeschäftsanteilen erfolgen.

15.4 Der Rat der Geschäftsführer, vorbehaltlich des Einhaltens etwaiger Gesellschaftervereinbarungen, kann vor Ende

des Geschäftsjahres Interimsdividenden an die Gesellschafter auszahlen, sofern auf Grundlage eines Zwischenabschlusses
ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, wobei (i) der Betrag, welcher ausgeschüttet werden soll, den seit Ende des
letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinn zuzüglich des Gewinnvortrags sowie der Entnahmen aus den zu diesem Zweck
verfügbaren Rücklagen, und vermindert um den Verlustvortrag sowie aufgrund des sich aus dem Gesetzes ergebenden
und satzungsmäßiger Verpflichtungen in die Rücklagen einzustellende Beträge, nicht übersteigen und (ii) solche ausge-
schütteten Beträge, die nicht dem erzielten Gewinn entsprechen, sind von den Gesellschaftern zurückzuzahlen.

16. Auflösung und Liquidation. Die Liquidation der Gesellschaft soll durch die Versammlung der Gesellschafter im

Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts, Artikel 13 und etwaigen Gesellschaftervereinbarungen be-
schlossen werden. Wenn die Gesellschaft zum maßgeblichen Zeitpunkt lediglich einen alleinigen Gesellschafter hat, kann
dieser Gesellschafter nach eigenem Ermessen die Auflösung beschließen, indem er selbst alle, bekannten oder unbekann-
ten, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft übernimmt.

17. Definitionen, Interpretation und Luxemburger recht.
17.1 Definitionen:
17.1.1 "Verfügbarer Betrag" gleicht: (W + X + Y) - Z wobei W, X, Y und Z den folgenden, aus den Zwischenabschlüssen

stammenden Beträgen entsprechen, und dies ohne Doppelzählung:

"W" bedeutet den Reingewinn der Gesellschaft, einschließlich Gewinnvortrag abzüglich etwaigen Verlusten der Ge-

sellschaft einschließlich Verlustvorträgen;

"X" bedeutet etwaige frei ausschüttbare Anteilsprämien und andere frei ausschüttbare Reserven der Gesellschaft, mit

Ausnahme jeweiliger Prämien die unter Y betroffen sind und, um jeden Zweifel auszuschließen, mit Ausnahme jeder
Prämie die nur Stammgeschäftsanteile betreffen die nicht den Rückgekauften Stammgeschäftsanteilen entsprechen;

"Y" bedeutet den durch Nennbetrag und Anteilsprämie bezüglich der Rückgekauften Stammgeschäftsanteile einbe-

zahlten Betrag;

"Z" bedeutet jeden in eine nicht-ausschüttbare Reserve einbezahlten oder zurückbehaltenen Betrag bezüglich den

Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung;

17.1.2 "Bankrott" hat die in Artikel 437 des Luxemburger Handelsgesetzbuches festgelegte Bedeutung;
17.1.3 "Rat der Geschäftsführer" hat die in Artikel 8-1 gegebene Bedeutung;
17.1.4 "Bankarbeitstag" bedeutet jeden Tag außer einem Samstag, Sonntag oder gesetzlichem Feiertag in Luxemburg;
17.1.5 "Klasse 1 Gesellschafter" bedeutet den/die Inhaber zu dem betreffenden Zeitpunkt der Klasse 1 Stammge-

schäftsanteile;

17.1.6 "Klasse 2 Gesellschafter" bedeutet den/die Inhaber zu dem betreffenden Zeitpunkt der Klasse 2 Stammge-

schäftsanteile;

17.1.7 "Klasse 1 Stammgeschäftsanteile" bedeutet die Klasse A 1 Stammgeschäftsanteile, die Klasse B 1 Stammge-

schäftsanteile, die Klasse C 1 Stammgeschäftsanteile, die Klasse D 1 Stammgeschäftsanteile, die Klasse E 1 Stammge-
schäftsanteile,  die  Klasse  F  1  Stammgeschäftsanteile,  die  Klasse  G  1  Stammgeschäftsanteile,  die  Klasse  H  1
Stammgeschäftsanteile, die Klasse I 1 Stammgeschäftsanteile, und die Klasse J 1 Stammgeschäftsanteile;

17.1.8 "Klasse 2 Stammgeschäftsanteile" bedeutet die Klasse A 2 Stammgeschäftsanteile, die Klasse B 2 Stammge-

schäftsanteile, die Klasse C 2 Stammgeschäftsanteile, die Klasse D 2 Stammgeschäftsanteile, die Klasse E 2 Stammge-
schäftsanteile,  die  Klasse  F  2  Stammgeschäftsanteile,  die  Klasse  G  2  Stammgeschäftsanteile,  die  Klasse  H  2
Stammgeschäftsanteile, die Klasse I 2 Stammgeschäftsanteile, und die Klasse J 2 Stammgeschäftsanteile;

17.1.9 "Klasse A Stammgeschäftsanteile" bedeutet die Klasse A 1 Stammgeschäftsanteile und die Klasse A 2 Stamm-

geschäftsanteile;

17.1.10 "Klasse B Stammgeschäftsanteile" bedeutet die Klasse B 1 Stammgeschäftsanteile und die Klasse B 2 Stamm-

geschäftsanteile;

17.1.11 "Klasse C Stammgeschäftsanteile" bedeutet die Klasse C 1 Stammgeschäftsanteile und die Klasse C 2 Stamm-

geschäftsanteile;

17.1.12 "Klasse D Stammgeschäftsanteile" bedeutet die Klasse D 1 Stammgeschäftsanteile und die Klasse D 2 Stamm-

geschäftsanteile;

187389

L

U X E M B O U R G

17.1.13 "Klasse E Stammgeschäftsanteile" bedeutet die Klasse E 1 Stammgeschäftsanteile und die Klasse E 2 Stamm-

geschäftsanteile;

17.1.14 "Klasse F Stammgeschäftsanteile" bedeutet die Klasse F 1 Stammgeschäftsanteile und die Klasse F 2 Stammge-

schäftsanteile;

17.1.15 "Klasse G Stammgeschäftsanteile" bedeutet die Klasse G 1 Stammgeschäftsanteile und die Klasse G 2 Stamm-

geschäftsanteile;

17.1.16 "Klasse H Stammgeschäftsanteile" bedeutet die Klasse H 1 Stammgeschäftsanteile und die Klasse H 2 Stamm-

geschäftsanteile;

17.1.17 "Klasse I Stammgeschäftsanteile" bedeutet die Klasse I 1 Stammgeschäftsanteile und die Klasse I 2 Stammge-

schäftsanteile;

17.1.18 "Klasse J Stammgeschäftsanteile" bedeutet die Klasse J 1 Stammgeschäftsanteile und die Klasse J 2 Stammge-

schäftsanteile;

17.1.19 "Ausschüttung" bedeutet alle von der Gesellschaft bezüglich der Stammgeschäftsanteile einschließlich (a) be-

züglich der Dividenden, Rendite, Rückkauf, Annullierung und/oder Rücknahme und (b) bei oder nach der Liquidation oder
Auflösung der Gesellschaft zu leistende Zahlungen;

17.1.20 "Zwischenabschlüsse" sind Verwaltungskonten der Gesellschaft;
17.1.21 "Liquidation" bedeutet eine freiwillige oder unfreiwillige oder gezwungene Liquidation, Bankrott, Auflösung

oder Abwicklung der Geschäfte der Gesellschaft;

17.1.22 "Rückkauf der Stammgeschäftsanteile" hat die in Artikel 5.2 gegebene Bedeutung;
17.1.23 "Stammgeschäftsanteile" bedeutet die Klasse 1 Stammgeschäftsanteile und die Klasse 2 Stammgeschäftsanteile;
17.1.24 "Zurückgekaufte Stammgeschäftsanteile" hat die in Artikel 5.3 gegebene Bedeutung;
17.1.25 "Rückkaufs-Preis" bedeutet den Gesamtrückzahlungsbetrag hinsichtlich der jeweiligen Klasse oder Klassen von

Stammgeschäftsanteilen geteilt durch die gesamte Zahl der Zurückgekauften Stammgeschäftsanteile der jeweiligen Klasse
oder Klassen von Stammgeschäftsanteilen;

17.1.26 "Registrierte Anschrift" bedeutet die Briefanschrift (oder E-Mail Adresse oder Fax Nummer falls einschlägig)

eines Gesellschafters wie sie im Gesellschafterregister der Gesellschaft eingetragen ist;

17.1.27 "Gesellschafter" bedeutet den/die Inhaber zu dem betreffenden Zeitpunkt der Stammgeschäftsanteile;
17.1.28  "Gesellschaftervereinbarung"  bedeutet  etwaige  Gesellschaftervereinbarungen  die  zwischen  FINEDINING

(CAYMAN) LIMITED und FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH abgeschlossen werden, wie sie geändert, neu formuliert,
ergänzt oder anderenfalls von Zeit zu Zeit, im Einklang mit den darin enthaltenen Bestimmungen, modifiziert werden
können;

17.1.29 "Beschluss der Gesellschafter" hat die in Artikel 2.2.2 angegebene Bedeutung;
17.1.30 "Stammgeschäftsanteile" bedeutet die im Kapital der Gesellschaft von Zeit zu Zeit ausgegebene Anteile;
17.1.31 "Gesamtrückzahlungsbetrag" ist jener Betrag, der durch Beschluss des Rat der Geschäftsführer festgelegt und

von der Hauptversammlung der Gesellschafter in jedem Fall im Einklang mit den Bestimmungen einer etwaigen Gesell-
schaftervereinbarung genehmigt wurde, und der den Verfügbaren Betrag nicht überschreitet.

17.2 In der vorliegenden Satzung:
17.2.1 umfasst/umfassen:
(a) eine momentan gültige gesetzliche oder satzungsgemäße Regelung oder Richtlinie des Rats alle Änderungen dazu

und alle Wiederholungen (mit oder ohne Änderung) davon und alle nachrangigen Rechtsvorschriften, die diesen unter-
liegen außer wenn der Zusammenhang es anders erfordert;

(b) eine "Person" sowohl ein Individuum als auch eine Firma, eine Gesellschaft, ein Unternehmen oder ein anderes

Gesellschaftsorgan, die Regierung, den Staat oder eine Staatliche Agentur oder ein Joint Venture, einen Verein, eine
Partnerschaft, einen Betriebsrat oder den Arbeitnehmervertreter (mit oder ohne eigener Rechtspersönlichkeit);

(c) ein Dokument einen Verweis zu diesem Dokument wie es von Zeit zu Zeit modifiziert, neu formuliert, geändert,

erneuert, ergänzt oder ersetzt wurde;

(d) eine Person, falls anwendbar, einen Verweis an die Rechtsvertreter, Nachfolger und Zessionare dieser Person;
(e) ein Geschlecht jedes Geschlecht; und
(f) die Einzahl die Mehrzahl und umgekehrt (außer wenn der Zusammenhang es anders vorschreibt).
17.2.2 die Überschriften der vorliegenden Satzung haben keinen Einfluss auf ihre Interpretation oder Auslegung.
17.2.3 Das ejusdem generis Prinzip der Auslegung gilt nicht für die hiesige Satzung. Allgemeinen Begriffen darf kein

restriktiverer Sinn gegeben werden, auf Grund der Tatsache, dass ihnen Wörter vorangestellt sind oder ihnen folgen, die
auf Handlungen, Angelegenheiten oder Sachen hinweisen oder deren Beispiele einen allgemeinen Sinn haben.

17.3 Die Gesellschaft unterliegt über diese Satzung hinaus sämtlichen Luxemburger Rechtsvorschriften."

187390

L

U X E M B O U R G

<i>Kosten und Ausgaben

Jegliche Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Abgaben in jeglicher Art, die die Gesellschaft aufgrund dieser notariellen

Urkunde zu tragen hat, werden auf sieben tausend Euro geschätzt.

Worüber die notarielle Urkunde in Luxemburg aufgenommen wurde, An dem Tag und zu der Zeit, der bzw. die zu

Beginn dieses Dokuments genannt ist.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende

Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Version; auf Wunsch der erschienenen
Person soll bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Version maßgebend sein.

Nachdem das Dokument der erschienenen Person vorgelesen wurde, die dem Notar mit ihrem Nachnamen, Vorn-

amen,  Personenstand  und  Wohnsitz  bekannt  sind,  hat  diese  erschienene  Personen  gemeinsam  mit  dem  Notar  die
vorliegende Urkunde gezeichnet.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 4 septembre 2014. Relation: LAC/2014/41226. Reçu soixante quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): C.FRISING.

Référence de publication: 2014192505/1154.
(140214778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Eccica S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 64.089.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 novembre 2014 que Monsieur Claude

GEIBEN, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été nommé
administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Nicolas SCHAEFFER, décédé.

Luxembourg, le 26 novembre 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2014191798/15.
(140213551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Euro-Steel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3838 Schifflange, 18, rue Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 23.167.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 28 mars 2014.

Suite à la démission de Madame Maurizia Schmitz-Fiorelli, demeurant à 59, Cité op Soltgen, L - 3862 Schifflange, est

nommé Administrateur Monsieur Christian SCHMITZ, demeurant à 40, Schefflengerbierg, L - 3825 Schifflange.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019, les personnes suivantes sont

mandataires de la société:

Monsieur Lucien SCHMITZ, demeurant à 59, Cité op Soltgen, L - 3862 Schifflange, Président du Conseil d'Adminis-

tration et Administrateur-délégué.

Monsieur Joseph PERRARD, demeurant à 36, rue d'Arlon, L - 7513 Mersch, Administrateur.
Monsieur Christian SCHMITZ, demeurant à 40, Schefflengerbierg, L - 3825 Schifflange, Administrateur.
Euro Invest Management S.A., ayant son siège social à 282, route de Longwy, L - 1940 Luxembourg, Commissaire aux

comptes.

Luxembourg, le 27 novembre 2014.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour EURO-STEEL S.A.
Fiduciaire des Classes Moyennes

Référence de publication: 2014191816/22.
(140214175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

187391

L

U X E M B O U R G

Urban Biofood S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 140.127.

Il résulte d'une lettre de démission datée du 19 juillet 2014 que Monsieur Salim Georges ZAKHEM a démissionné de

son mandat d'administrateur de la société URBAN BIOFOOD S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 140 127, avec effet au 19 juillet 2014.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

CF Corporate Services
Société Anonyme
2, avenue Charles de Gaulle
L - 1653 Luxembourg

Référence de publication: 2014192206/15.
(140214105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Valartis Health Care Eins S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 132.959.

Durch Gesellschafterbeschluss vom 22. März 2013 wurde
Herr Frederic Königsegg, geschäftsansässig 2-4 Place du Molard, 1211 Genf, Schweiz.
zum Geschäftsführer der Kategorie „A“ der Valartis Health Care Eins S.à. r.l. auf unbestimmte Zeit ernannt.
Herr Königsegg übernimmt das Mandat von Herrn Volker Hemprich, der seinen Rücktritt als Geschäftsführer einge-

reicht hat.

Luxemburg, den 17. November 2014.

Valartis Health Care Eins S.à r.l.

Référence de publication: 2014192208/15.
(140213856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Premium Coffee Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 112.152.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014190535/11.
(140212201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Teamlog Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 140.476.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2014.

Référence de publication: 2014190703/11.
(140212355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

187392


Document Outline

Almus S.A.

Berkeley 1 S.à r.l.

D.H. Group S.A.

Eccica S.A.

Euro-Steel S.A.

Finedining S.à r.l.

IVG Luxembourg S.à r.l.

Kabam Luxembourg S.à r.l.

PolyOne Manufacturing S.à r.l.

Premium Coffee Holding S.A.

Racol

Rakuten UK Shopping S.à r.l.

RDM International S.à r.l.

Realfund

Red Carnations Hotels (Europe) S.A.

Red Carnations Hotels (Europe) S.A.

Red Luxembourg S.A.

REGENTS PARK (Founder) S.à r.l.

REGENTS PARK (Founder) S.à r.l.

REGENTS PARK (Founder) S.à r.l.

Ribeauvillé Investments S.A.

Ribeauvillé Investments S.A.

R.J. Claessens &amp; Partners Sàrl

Rosy Blue Investments S.à r.l.

Rowan Finanz S.à r.l.

Rudolf STEINER Fonds fir Waldorfpädagogik

Santa Capital I S.à r.l.

Saposa S.à r.l.

Sartcom S.A.

Sauren Fonds-Select Sicav

Sausalito S.à r.l.

Schëfflenger Majoretten ASBL

Seema Management S.à r.l.

S.E.I. Luxembourg S.àr.l.

Setup Luxembourg S.à r.l.

Shannon S.à r.l.

Sinaf S.A.

Sinbuild S.à r.l.

Sit-Net S.A.

SkyCom S.à r.l.

SLK Holding S.A.

Teamlog Lux S.à r.l.

Urban Biofood S.A.

Valartis Health Care Eins S.à r.l.