This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3801
10 décembre 2014
SOMMAIRE
1. Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182411
Action Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
182445
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182402
Alpinist S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182438
Altralux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182412
Ambos Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182448
Anthea - Contemporary Art Investment
Fund S.C.A., SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . .
182410
Apulia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182439
Aquatrans RhineShipping S.A. . . . . . . . . . . .
182408
ARA Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182438
ATL Aquatrans Logistics S.A. . . . . . . . . . . .
182416
Bears U.S. Corporate Bonds Fund . . . . . . .
182405
Chartreuse et Mont Blanc Global Holdings
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182403
Chartreuse et Mont Blanc Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182403
Club 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182402
Compagnie Européenne pour le Dévelop-
pement d'Entreprises Commerciales S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182406
Conteam S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182402
Digital Services XXIII 2 S.C.Sp . . . . . . . . . .
182406
Dogwalker.lu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182448
European Value Partners . . . . . . . . . . . . . . .
182409
FLE Holdco II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182441
FLE Property 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182447
FLE Property 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182441
Freo Germany II Partners (SCA) SICAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182412
Functional Devices S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
182443
GS Tele VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182441
HAIG premium Fund FIS . . . . . . . . . . . . . . .
182402
Hersteller-Vertretungen-Betriebs GmbH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182448
HF Main Insight S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182443
HVB Opti Select Balance . . . . . . . . . . . . . . .
182403
ICE Promotion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182409
Immolor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182448
Inventage Belux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
182448
Jetlag27 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182409
JPMorgan Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182406
KBL European Private Bankers S.A. . . . . .
182413
Laranaga Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182408
Lavanda South S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182442
LBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182438
Metec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182442
Mobility Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182442
Nerthus Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182411
Optique Milbert S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
182442
Orkid S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182442
Ortano Mare Development S.A. . . . . . . . . .
182416
PICTO-Communication Partner Sàrl . . . .
182440
Pirelli Finance (Luxembourg) S.A. . . . . . . .
182421
Platine SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182443
Pleximus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182444
Praine Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
182408
Rigo Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182421
Salon de Coiffure Angelsberg S. à. r. l. . . .
182444
Satisfactory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182413
Securitas2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182403
Silk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182403
Sirius Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182447
SMSC Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182435
Sofair International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
182412
South One Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182405
Ticketmaster Luxembourg Holdco 5, S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182447
Tivana Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182443
Unden S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182447
VMP EuroBlue Systematic . . . . . . . . . . . . . .
182405
W.P.S.-Luxembourg S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
182439
182401
L
U X E M B O U R G
Conteam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 148.941.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion des administrateurs du 15 octobre 2014 que:
1. Le siège social de la société est transféré, avec effet au 1
er
novembre 2014, de son adresse 63-65, Rue de Merl
L-2146 Luxembourg au 18, Rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Gustavo A. Strassener
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014183279/14.
(140207086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Club 1, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Für den Fonds gilt das Allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 14. November 2014 in Kraft trat. Das Verwal-
tungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 14. November 2014.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2014191886/11.
(140213612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.
HAIG premium Fund FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Für den Fonds gilt das Allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 14. November 2014 in Kraft trat. Das Verwal-
tungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 14. November 2014.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2014191887/11.
(140213655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014, Fonds Commun de Placement.
Mitteilung an die Anteilinhaber
Die CASO Asset Management S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft") gibt bekannt, dass der nachfolgend aufgeführte Fonds
aufgrund des Laufzeitendes am 28. November 2014 planmäßig aufgelöst wurde.
ISIN
WKN
Anteilklasse
Fondsname
LU0501082522
A1CWE0
A (EUR)
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014
LU0501083413
A1CWE3
I (EUR)
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014
Alle Anteilinhaber wurden vollständig ausbezahlt und demzufolge war eine Übertragung des Liquidationserlöses an die
Caisse de Consignation nicht erforderlich. Das Liquidationsverfahren für den zuvor genannten Fonds ist somit abges-
chlossen.
Senningerberg, Dezember 2014
Die Verwaltungsgesellschaft
Caso Asset Management S.A.
Référence de publication: 2014196421/755/16.
182402
L
U X E M B O U R G
Silk, Fonds Commun de Placement.
MITTEILUNG AN DIE ANLEGER DES TEILFONDS
Silk - Arab Falcons Fund (in Liquidation)
Anteilklasse R EUR: WKN A0RAC5 ; ISIN LU0389403501
Anteilklasse I EUR: WKN A0RAC6 ; ISIN LU0389403683
Anteilklasse R USD: WKN A0YETY ; ISIN LU0485223860
Hiermit werden die Anleger des Teilfonds Silk - Arab Falcons Fund (in Liquidation) darüber informiert, dass der
Teilfonds Silk - Arab Falcons Fund (in Liquidation) zum 3. Dezember 2014 liquidiert und aufgelöst wurde.
Der Liquidationserlös wurde mit Liquidationsabschluss ausgezahlt. Alle Anteilinhaber wurden erreicht, es erfolgt keine
Zahlung an die Caisse de Consignation. Die Liquidation ist somit abgeschlossen.
Luxemburg, im Dezember 2014
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Référence de publication: 2014196467/755/14.
HVB Opti Select Balance, Fonds Commun de Placement.
Die Änderungsvereinbarung betreffend das Sonderreglement des HVB Opti Select Balance, in Kraft getreten am 28.
November 2014, wurde Beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg-Stadt hinterlegt
Hinweis Zur Bekanntmachung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Association.
Luxemburg, den 28. November 2014
Structured Invest S.A.
Silvia Mayers / Maren Hermesdorf
Référence de publication: 2014195645/11.
(140189492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.
Securitas2007, Fonds Commun de Placement.
Das mit Wirkung vom 5. Januar 2015 geänderte Verwaltungsreglement 01/2015 des spezialisierten Investmentfonds
„Securitas2007“ wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 03.12.2014.
Anell / Görmer
<i>Directeur / Sous-Directeuri>
Référence de publication: 2014193407/11.
(140216095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.
Chartreuse et Mont Blanc Global Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 142.637.
Chartreuse et Mont Blanc Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 142.635.
In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth of November.
The undersigned Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg).
Acting on request of the company Chartreuse and Mont Blanc Global Holdings SA, a company incorporated under
the laws and regulations of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel and recorded register of Commerce and Companies under number B 142 637 (the Acquiring Com-
pany)
In accordance with the decision of the Board of Directors of the company Chartreuse and Mont Blanc Global Holdings
SA of 13 October 2014, a copy of which remain attached to this act, "ne varietur", to be filed with and recording with
him,
ON THE BASIS OF DOCUMENTS SUBMITTED TO HIM CERTIFIES THAT:
I. Following the JOINT MERGER PROJECT prepared and officially enacted by the undersigned notary dated August
28, 2014 and published in the Memorial C, Associations number 2457 September 12, 2014
182403
L
U X E M B O U R G
the company Chartreuse and Mont Blanc company Global Holdings SA, a company incorporated under the laws and
regulations of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-
Findel and registered with the Trade and Companies of Luxembourg under number B 142 637
as acquiring company (the "Absorbing Company")
and the company Chartreuse and Mont Blanc Holdings S.à rl, a private limited liability company incorporated under
the laws and regulations of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, with capital of one million nine hundred thirty-five thousand four hundred fifty-two euros (1,935,452
euros) and registered with the Register of Commerce and Companies under number B 142 635
as acquired company (the "Absorbed Company")
HAD PLANNED TO MERGE;
II. Since the publication of the predicted joint merger, it took more than a month;
III. Since a period of one (1) month following publication in the Memorial C, no shareholder(s) of the Absorbing
Company holding at least five percent of the shares of the subscribed capital has required, the convening of a general
meeting of shareholders of the Surviving Company, to decide whether to approve the merger;
IV. In accordance with Articles 273 and 274 of the Act of 10 August 1915 and subject to the publication of that act to
the Memorial C, Associations:
(a) The merger became final and ipso jure implicates theuniversal transmission both between the Merged Company
in respect of third parties, all the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Acquiring Company;
(b) Following the merger, the Absorbed Company ceases to exist;
(c) That after the absorption of the Absorbed Company by the Acquiring Company, the shares of the Absorbed
Company will be canceled and all books and other records of the past will be retained for the statutory period (five (5)
years) at the headquarters of the Absorbing Company.
This certificate is issued under section 273 of the Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended; the
requirements of section 279 of the Act are met.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; in the case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed is drawn up in Rambrouch, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first here above
mentioned.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix-sept novembre.
Le soussigné Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg),
Agissant la requête de la société Chartreuse et Mont Blanc Global Holdings S.A., une société anonyme constituée
conformément aux lois et règlements du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg-Findel et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
142.637 (la Société Absorbante),
Conformément à la décision du conseil d'administration de la prédite société Chartreuse et Mont Blanc Global Holdings
S.A. du 13 octobre 2014, dont une copie restera annexée au présent acte, signée «ne varietur», afin d'être soumise aux
formalités de l'enregistrement avec lui,
CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE ET SUR BASE DES DOCUMENTS LUI SOUMIS QUE:
I. Suivant le PROJET COMMUN DE FUSION dressé et acté par le notaire instrumentant en date du 28 août 2014 et
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2457 le 12 septembre 2014:
la société Chartreuse et Mont Blanc Global Holdings S.A., une société anonyme constituée conformément aux lois et
règlements du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel
et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.637
en tant que société absorbante (la «Société Absorbante») et
la société Chartreuse et Mont Blanc Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée conformément
aux lois et règlements du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxem-
bourg-Findel, ayant un capital social d'un million neuf cent trente-cinq mille quatre cent cinquante-deux euros (1.935.452
euros) et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.635
en tant que société absorbée (la «Société Absorbée»),
avaient projeté de fusionner;
II. Depuis la publication du prédit projet commun de fusion, il s'est écoulé plus d'un mois;
182404
L
U X E M B O U R G
III. Aucun associé de la Société Absorbante détenant au moins cinq pour cent des parts sociales du capital souscrit n'a
requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication au Mémorial C, la convocation d'une assemblée générale des
associés de la Société Absorbante, afin de décider de l'approbation de la fusion;
IV. Conformément aux articles 273 et 274 de la Loi du 10 août 1915 et sous réserve de la publication de cet acte au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
(a) la fusion est devenue définitive et entraîne de plein droit la transmission universelle tant entre les Sociétés Fusion-
nées qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;
(b) que suite à la fusion intervenue, la Société Absorbée cesse d'exister;
(c) que suite encore à l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, les parts sociales de la Société
Absorbée seront annulées et tous les livres et autres dossiers de ces dernières seront conservés pendant le délai légal
(cinq (5) ans) au siège de la Société Absorbante.
Le présent certificat est émis en application de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée, les conditions de l'article 279 de ladite loi étant remplies.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare le présent acte en langue
anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais
fera foi.
En foi de quoi, le présent acte a été fait et passé à Rambrouch, date qu'en-tête des présentes.
Signé: Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 19 novembre 2014. Relation: RED/2014/2365. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Kirsch.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 28 novembre 2014.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2014194103/99.
(140216676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.
Bears U.S. Corporate Bonds Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Le règlement de gestion modifié de BEARS U.S. CORPORATE BONDS FUND a été déposé au registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg le 5 décembre 2014.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2014.
Signature.
Référence de publication: 2014194381/9.
(140216534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.
South One Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Le règlement de gestion modifié de SOUTH ONE FUND a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2014.
MUGC Lux Management S.A.
Signature
Référence de publication: 2014194382/11.
(140216535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.
VMP EuroBlue Systematic, Fonds Commun de Placement.
Gemäß Beschluss des Vorstandes der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. wurde das Sondervermögen
am 3. Dezember 2014 durch Fusion auf das Sondervermögen Vilico aufgelöst. Das Liquidationsverfahren wurde vollständig
abgeschlossen. Alle Gelder konnten ausgezahlt werden. Eine Hinterlegung bei der Caisse de Consignation war daher nicht
notwendig.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Receuil des Sociétés et associations.
Munsbach, im Dezember 2014
Für den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft
Référence de publication: 2014196318/1346/11.
182405
L
U X E M B O U R G
JPMorgan Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 8.478.
AVIS DE FUSION DU COMPARTIMENT JPMORGAN FUNDS - EUROPE AGGREGATE PLUS BOND FUND (LE "
COMPARTIMENT ABSORBE ") AVEC LE COMPARTIMENT JPMORGAN FUNDS - EURO AGGREGATE BOND FUND
(LE " COMPARTIMENT ABSORBANT ")
Le Conseil d'administration de JPMorgan Funds a décidé de fusionner le Compartiment absorbé et le Compartiment
absorbant avec effet au 13 février 2015.
Les actionnaires du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant peuvent demander la conversion de leur
investissement dans un autre compartiment ou son rachat en envoyant une demande de conversion ou de rachat selon
les modalités habituelles, ou directement à la Société de gestion (JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.) à l'adresse
figurant ci-dessus. La commission de rachat et de conversion éventuellement applicable ne sera pas facturée pour toutes
les demandes reçues avant 14h30 HEC le 10 février 2015 pour le Compartiment absorbé et le 13 février 2015 pour le
Compartiment absorbant. Après 14h30 HEC le 10 février 2015, les actionnaires ne pourront pas souscrire, convertir ou
demander le rachat de leurs actions dans le Compartiment absorbé.
Nous recommandons aux actionnaires de consulter leur conseiller fiscal et en investissement, le cas échéant, avant de
prendre une décision finale.
Pour toute question, les actionnaires sont invités à contacter leur représentant local habituel ou la Société de gestion
à l'adresse figurant ci-dessus. Le rapport du réviseur d'entreprises de la Société sur la fusion, le document d'information
clé pour l'investisseur correspondant, le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel ainsi que l'avis complet
incluant des informations supplémentaires sur la fusion peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande à l'adresse
figurant ci-dessus.
<i>Veuillez noter que des exemplaires de la dernière version en vigueur du Prospectus sont disponibles gratuitement sur simple demande
auprès du correspondant centralisateur, BNP Paribas Securities Services et du commercialisateur en France, JPMorgan Asset Ma-
nagement (Europe) S.à r.l. Succursale de Paris. Vous pouvez également consulter la dernière version du Prospectus sur notre site
Internet: www.jpmorganassetmanagement.com.i>
Référence de publication: 2014196469/755/29.
CEDEC S.A., Compagnie Européenne pour le Développement d'Entreprises Commerciales S.A., Société
Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 36.412.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués à
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra <i>le vendredi le 19 décembre 2014i> à 11.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Ratification des décisions prises par le Conseil d'Administration du 6 novembre 2014.
2. Nomination de deux nouveaux membres du Conseil d'Administration.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014188702/14.
Digital Services XXIII 2 S.C.Sp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 192.014.
Excerpts of the limited partnership agreement (the “Limited Partnership Agreement”) of Digital Services
XXIII 2 S.C.Sp, a special limited partnership, executed on 20. November 2014
1. Partners who are jointly and severally liable. Digital Services Holding XXIII (GP) S.à r.l., a société à responsabilité
limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number B 188623 (the “General Partner”).
2. Name, Partnership’s Purpose, Registered Office, Business Year.
(i) Name
182406
L
U X E M B O U R G
The special limited partnership shall have the name: Digital Services XXIII 2 S.C.Sp (the “Partnership”).
(ii) Purpose
The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase,
subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and
the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing
and provision of internet services through such foreign subsidiaries (ecommerce covering goods and services of different
kinds) and the provision of logistic services, digital services and all other services relating to the aforementioned business.
The Partnership may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Partnership.
The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership
exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.
(iii) Registered Office
The Partnership shall have its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
(iv) Business Year The business year of the Partnership shall be the calendar year.
3. Designation of the manager and signatory powers. The management of the Partnership is incumbent upon the
General Partner.
The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the Partnership Agreement and
otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its
Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (négligence grave).
The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.
4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commences as from 20.
November 2014, for an indefinite term.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Auszüge aus dem Gesellschaftsvertrag (dem „Limited Partnership Agreement“) der Digital Services
XXIII 2 S.C.Sp, einer Partnerschaftsgesellschaft nach Luxemburgischen Recht (Special Limited Partner-
ship), geschlossen am 20. November 2014
1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften. Digital Services Holding XXIII (GP) S.à r.l., eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des
Großherzogtums Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter
der Nummer B 188623 (die „Komplementärin“).
2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.
(i) Name
Die Gesellschaft heißt: Digital Services XXIII 2 S.C.Sp (die „Gesellschaft“)
(ii) Zweck der Gesellschaft
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesell-
schaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und
Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienst-
leistungen durch ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich ECommerce bezüglich Waren und Dienstleistungen
jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen anderen Dienstleistun-
gen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.
Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicher-
heiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann
jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.
(iii) Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in der rue 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
(iv) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.
3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtie-
renden Komplementärin.
182407
L
U X E M B O U R G
Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger
Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft
wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird,
rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.
4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird am 20. November 2014 für eine unbegrenzte Dauer
gegründet.
Référence de publication: 2014184094/76.
(140207754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Aquatrans RhineShipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 118.276.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der Aquatrans Rhineshipping S.A., welche am <i>18. Dezember 2014i> um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz
mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
3. Beschlussfassung über Verlustverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014188018/17.
Praine Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 7B, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 80.417.
Les actionnaires sont priés d'assister à
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 décembre 2014i> à 10.00 heures, au siège social, 7B, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg pour
délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Proposition d'augmentation du capital social de la société par un apport en nature ;
2. Emission d'un emprunt obligataire convertible privé et fixation des modalités y relatives ;
3. Nomination statutaires et/ou modification du nombre et/ou des membres du conseil d'administration et/ou éven-
tuellement modifications statutaires en relation avec les organes de gestions et leurs pouvoirs.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014190807/17.
Laranaga Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 46.132.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 décembre 2014i> à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
182408
L
U X E M B O U R G
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2013.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014190808/1023/16.
Jetlag27 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 175.632.
Messieurs, Mesdames, les actionnaires, nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT
le <i>29 décembre 2014i> , à 11 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
•
Lecture des rapport du Conseil d'Administration et, du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,
•
Affectation du résultat
•
Questions diverses
A l'issue de cette assemblée se tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la dis-
solution ou non de la société conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 modifiée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014194611/18.
ICE Promotion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 159.858.
Messieurs, Mesdames, les actionnaires, nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT
le 29 décembre 2014, à 9 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
•
Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,
•
Affectation du résultat,
Questions diverses
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014194610/16.
European Value Partners, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 131.944.
Convening notice the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Of the shareholders of European Value Partners Société anonyme Registered Office: L-2220 Luxembourg, 534 rue de
Neudorf RCS Luxembourg: B 131944 (the " Company ").
Place: 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, c/o Durusu S.à r.l.
Date and Time : <i>December 29, 2014i> at 2.00 p.m. (Luxembourg Time)
Procedure: Meeting to be held in front of Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg
<i>Agenda:i>
• 1. Dissolution and liquidation of the Company;
• 2. Appointment of a liquidator;
• 3. Determination of the powers of the liquidator;
182409
L
U X E M B O U R G
• 4. Determination of the remuneration of the liquidator;
• 5. Discharge to the directors and to the independent auditor of the Company; and
• 6. Miscellaneous.
NB : It is anticipated that the Company be put into voluntary liquidation. The present notice is a convening notice as
per article 60-8 of the Luxembourg law of 5 April 1993 relating to the financial sector.
For any inquiry, the Company may be contacted as follows:
***
CONVOCATION A l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE
European Value Partners
Société anonyme
Siège social:
L-2220 Luxembourg, 534 rue de Neudorf
RCS Luxembourg: B 131944
(la " Société ")
Lieu: 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, c/o Durusu S.à r.l.
Date et Heure : 29 décembre 2014 à 14.00 (heure de Luxembourg)
Procédure: L'assemblée sera tenue par-devant Me Marc Lecuit, notaire de residence à Mersch, Grand-Duché de Lu-
xembourg
ORDRE DU JOUR
1. Dissolution et liquidation de la Société;
2. Désignation d'un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Détermination de la rémunération du liquidateur;
5. Décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé de la Société; et
6. Divers.
Note : Il est prévu de mettre la Société en liquidation volontaire. La présente convocation est une convocation sur
base de l'article 60-8 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Pour tout renseignement veuillez vous addresser
comme suit:
Référence de publication: 2014194000/45.
Anthea - Contemporary Art Investment Fund S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions
sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 166.758.
The Shareholders are hereby kindly convened to assist at the
Extraordinary General Meeting
of Shareholders ("the "Meeting") of the Fund on which will be held on the <i>30th of December 2014i> at 11:00 am (Lux-
embourg time) at the Fund's registered office to deliberate and vote on the following:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year ended on 31st December
2013
- Presentation of the activities report for the financial year ended on 31 December 2013;
- Presentation of the report of the Réviseur d 'Entreprises Agrée KPMG Luxembourg S.à r.l. for the financial year
ended on 31 December 2013;
- Accumulation of the net result for the financial year ended on 31 December 2013;
- Discharge of the Directors from all their duties during, for and in connection with, the financial year ended on 31
December 2013.
2. Powers and authorizations; and
3. Miscellaneous.
Please be informed that no quorum is required for the items on the agenda of the Meeting and the resolutions will be
passed by a simple majority of the votes cast. Each share has a voting right.
Shareholders may vote in person or by proxy.
If you are not able to attend personally this Meeting, please sign and date the enclosed proxy form and return it to:
182410
L
U X E M B O U R G
Ms. Shelley Houliston
Orange Field S.A.
40 avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
Email: Shelley.Houliston@orangefield.com
To be valid, proxy should be received in Luxembourg by the fund before 6 p.m. (Luxembourg Time) on the 29th
December 2014.
<i>The board of Managersi>
Référence de publication: 2014195647/35.
Nerthus Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 124.740.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le <i>29 décembre 2014i> à 10.00 heures, avec l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014196260/534/18.
1. Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 96.344.
Die Aktionäre der 1. SICAV werden hiermit zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der aktionäre eingeladen, die am <i>29. Dezember 2014i> um 16.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-
Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung des Artikel 3 § 12 der Satzung
Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition
eines US-Bürgers gestrichen.
2. Änderung der Satzung hinsichtlich redaktioneller Anpassungen in den Paragraphen 6 und 13
Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.
Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von
mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle,
in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite
Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts
einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist
kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.
Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
182411
L
U X E M B O U R G
Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden
gebeten sich bis spätestens 23. Dezember 2014 anzumelden.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der 1. SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax
00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014196468/755/33.
Altralux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 115.153.
Messieurs, Mesdames, les actionnaires, nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués,en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT
le <i>29 décembre 2014i> , à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
•
Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,
•
Affectation du résultat,
•
Questions diverses
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014194614/16.
Sofair International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 89.909.
Messieurs, Mesdames, les actionnaires, Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT
le <i>29 décembre 2014i> , à 16 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
•
Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,
•
Affectation du résultat
•
Questions diverses
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014194613/16.
Freo Germany II Partners (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société
d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 123.906.
The Partner are invited in his capacity as partner of the Partnership to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the partners of the Partnership, to be held at 8, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, on <i>24 Decemberi>
<i>2014i> at 10:00 CET, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. dissolution of the Company;
2. appointment of FREO Investment Management S.à r.l., as represented by Mr. Matthias Luecker, Mr. Sebastian Klatt,
Mr. Erwan Le Berre and Mr. Robert Faber as liquidator of the Company;
3. continuance of the existence of the Advisory Board during the term of dissolution; and
4. determination of the powers of the liquidator and the liquidation fee payable to the liquidator in the context of the
liquidation procedure.
182412
L
U X E M B O U R G
In case you cannot be present, but wish to be represented at such meeting, you may fill in, execute and return the
power of attorney attached to this convening notice to the address of the Partnership written above or return it to the
attention of Ms Maren Stadler-Tjan of Arendt & Medernach by email to maren.stadler-tjan@arendt.com and in copy by
email to Tanja Schuh: t.schuh@freogroup.com and Erwan Le Berre: e.leberre@freogroup.com no later than 03:00 pm
CET on 23 December 2014.
Mr Erwan Le Berre
Mr. Robert Faber
Title: Category A Manager / Title: Category B Manager
Référence de publication: 2014196356/250/26.
Satisfactory, Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 41.603.
Messieurs, Mesdames, les actionnaires, Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT
le <i>29 décembre 2014i> , à 14 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
•
Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,
•
Affectation du résultat
•
Questions diverses
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014194612/16.
KBL European Private Bankers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2955 Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 6.395.
Notice is hereby given to the noteholders of the Company that the first extraordinary general meeting of all the
noteholders of the Company held on 11th November 2014 and 4th December 2014 (the "First Meeting") could not validly
deliberate on the proposed agenda items due to the lack of quorum.
Therefore, we hereby kindly convene you, in your capacity as holder of the following notes (the "Notes") issued by
the Company (each a "Noteholder" and together the "Noteholders"):
- the EUR 200,000,000.- notes, registered under ISIN code: Xs0123488602 issued by the Company on 23 February
2001 and having as maturity date 23 February 2016 (the "First Issue");
- the EUR 13,893,000.- notes, registered under ISIN code: Xs0705502291 issued by the Company on 9 December
2011 and having as maturity date 9 June 2015 (the "Second Issue");
- the EUR 7,000,000.- notes, registered under ISIN code: Xs0718261802 issued by the Company on 20 January 2012
and having as maturity date 20 July 2015 (the "Third Issue");
- the EUR 4,107,000.- notes, registered under ISIN code: Xs0750991852 issued by the Company on 30 March 2012
and having as maturity date 30 September 2015 (the "Fourth Issue"); and
- the EUR 50,000,000.- notes, registered under ISIN code: Xs07509995693 issued by the Company on 22 April 2014
and having as maturity date 22 April 2017 (the "Fifth Issue"),
- the USD 2,580,000.- notes, registered under ISIN code: Xs1130054676 issued by the Company on 4 November 2014
and having as maturity date 4 November 2019 (the "Sixth Issue"),
- the USD 3,000,000.- notes, registered under ISIN code: Xs1120231276 issued by the Company on 7 November 2014
and having as maturity date 7 November 2019 (the "Seventh Issue"),
- the USD 4,000,000.- notes, registered under ISIN code: Xs1120231193 issued by the Company on 7 November 2014
and having as maturity date 7 November 2019 (the "Eighth Issue"),
to attend a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of all the Noteholders of the Company (the "Second Meeting"):
- the First Issue Noteholders' Meeting on 14th January 2015 at 10:00 A.M. Central European time;
182413
L
U X E M B O U R G
- the Second Issue Noteholders' Meeting on 14th January 2015 at 10:30 A.M. Central European time;
- the Third Issue Noteholders' Meeting on 14th January 2015 at 11:00 A.M. Central European time;
- the Fourth Issue Noteholders' Meeting on 14th January 2015 at 11:30 A.M. Central European time;
- the Fifth Issue Noteholders' Meeting on 14th January 2015 at 2:00 P.M. Central European time;
- the Sixth Issue Noteholders' Meeting on 14th January 2015 at 2:30 P.M. Central European time;
- the Seventh Issue Noteholders' Meeting on 14th January 2015 at 3:00 P.M. Central European time; and
- the Eighth Issue Noteholders' Meeting on 14th January 2015 at 3:30 P.M. Central European time,
which will be held at the registered office of the Company at 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
The purpose of the Second Meeting will be to approve the changes to be made to the corporate object of the Company
(the "Object Amendment").
Moreover, it is specifically pointed out that in accordance with article 3 (5) of the law of 5 April 1993 on financial
sector (as amended) (the "FSL"), the Object Amendment must be approved by the Luxembourg supervisory authority of
the financial sector, the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF") prior to its entry into force. Such
approval (agrément) was given by the CSSF to the Company on 23rd October 2014.
The Second Meeting will consider the same following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the extension of the current object clause of the Company and of the subsequent amendment of article
3 (object) of the articles of association of the Company which will now read as follows, as well as of any changes
that could be made to the below text to comply with regulatory (including CSSF) requirements applicable to the
Company:
"The object of the Company is to engage in all banking and financial operations of whatever kind, to receive from
the public deposits or other repayable funds, to grant credits for its own account and to perform all activities
reserved to banks, investment firms and other professionals of the financial sector and any financial, administrative,
management or advisory operations in connection directly or indirectly with the activities above described.
The object of the Company is also to engage in any insurance intermediary activities with respect to regulated
insurance companies approved in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, and to engage in any financial,
administrative, management or advisory operations directly or indirectly linked to those activities.
The Company may also carry out all activities of primary IT systems operator of the financial sector and secondary
IT systems and communication networks operator of the financial sector, as well as all the activities of administrative
agent of the financial sector.
Within its object, the Company may in particular, without limitation:
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg
or abroad;
- act as a partner or shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg
or foreign entities.
In addition, the Company shall be permitted to carry out all such commercial, advisory, movable or real estate
activities relating directly or indirectly to the Company's object or which may help to develop its fulfilment. The
Company may be interested by means of subscription, of contribution, of participation or in any other manner in
any company or undertaking having a similar, connected or supplementary activity to its own activity and capable
to develop one or several areas of its activity, in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad. The Company may
amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union
of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any such company or undertaking.
The Company may do all or any of the things provided in this article 3 (a) in any part of the world, (b) as principal,
agent, contractor, trustee or otherwise, (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise and (d)
alone or with another person or persons.".
2. Miscellaneous.
Please find below the general rules that govern the holding of the Second Meeting:
CONDITIONS FOR ATTENDANCE
The conditions for attendance or representation at the Second Meeting are as follows:
a) Conditions for personal attendance
Noteholders who elect to attend the Second Meeting must use their usual applicable contacting method for informing
their financial intermediary, with whom their Notes are on deposit, accordingly.
They must require their financial intermediary, with whom their Notes are on deposit, to send a Noteholders voting
certificate (the "Voting Certificate") for their Notes to the principal paying agent (for the First Issue) and/or the relevant
central registration bank (for the other Issues) no later than 48 hours before the time fixed for the relevant Second
Meeting.
182414
L
U X E M B O U R G
Such Voting Certificate must indicate clearly the number of Notes being blocked, the date such Notes are being
blocked, which must be no later than 48 hours before the time fixed for the Second Meeting, and a statement that (i) the
relevant Notes have been deposited at a bank or other depositary or blocked in an account with a clearing system and
will not be released until the conclusion of the Second Meeting, and (ii) the bearer of such Voting Certificate is entitled
to attend and vote at the Second Meeting in respect of the deposited Notes.
The Noteholders must bring a copy of such Voting Certificate to the Second Meeting.
b) Conditions for proxy voting
A Noteholder not wishing to attend and vote at the Second Meeting in person may give a block voting instruction
("Block Voting Instruction") stating that any person named in such document is authorised and instructed by the principal
paying agent or the relevant central registration bank to cast the votes attributable to the Notes so listed in accordance
with the instructions as set out in such document.
Noteholders must require their financial intermediary, with whom their Notes are on deposit, to send a Block Voting
Instruction for their Notes to the principal paying agent (for the First Issue) and/or the relevant central registration bank
(for the other Issues) no later than 24 hours before the time fixed for the Second Meeting.
Such Block Voting Instruction shall (i) indicate clearly the number of Notes being blocked, the date such Notes are
being blocked, which must be no later than 48 hours before the time fixed for the Second Meeting, (ii) state that the
votes attributable to the relevant Notes are to be cast in a particular way on each resolution to be put to the Second
Meeting and that, during the period of 48 hours before the time fixed for the Second Meeting such instructions may not
be amended or revoke, and (iii) authorize a named individual to vote in respect of the deposited Notes in accordance to
such instructions.
Block Voting Instruction shall be valid only if it is deposited at the registered office of the principal paying agent (for
the First Issue) and/or the relevant central registration bank (for the other Issues) at least 24 hours before the time fixed
for the relevant Second Meeting or the chairman decides otherwise before the Second Meeting proceeds to business.
Any vote by a proxy in accordance with the relevant Block Voting Instruction shall be valid even if such Block Voting
Instruction or any instruction pursuant to which it was given has been amended or revoked, provided that the principal
paying agent or the relevant central registration bank has not been notified in writing of such amendment or revocation
by the time which is 24 hours before the time fixed for the relevant Second Meeting. Unless revoked, any appointment
of a proxy under a Block Voting Instruction in relation to the Second Meeting shall remain in force in relation to any
resumption of such Second Meeting following an adjournment; provided, however, that no such appointment of a proxy
in relation to a meeting originally convened which has been adjourned for want of a quorum shall remain in force in
relation to such meeting when it is resumed. Any person appointed to vote at such a meeting must be re-appointed under
a Block Voting Instruction Proxy to vote at the meeting when it is resumed.
The proxy voter must bring a copy of such Block Voting Instruction to the Second Meeting.
A Voting Certificate or Block Voting Instruction shall be valid until the release of the deposited Notes to which it
relates. So long as a Voting Certificate or Block Voting Instruction is valid, the bearer thereof (in the case of a Voting
Certificate) or any proxy named therein (in the case of a Block Voting Instruction) shall be deemed to be the holder of
the Notes to which it relates for all purposes in connection with the Second Meeting. A Voting Certificate and a Block
Voting Instruction cannot be outstanding simultaneously in respect of the same Note.
c) Participation form
Noteholders who intends to participate to the Second Meeting either in person or by proxy in accordance with a
Block Voting Instruction shall announce their intention to participate to the Second Meeting by completing, signing, dating
and returning on no later than 12th January 2015 at the latest to the attention of the Company (KBL European Private
Bankers S.A, 43 boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, attention to: Mr. Pierre Adans-Dester), a participation form for
the relevant Second Meeting, that can be obtained at the registered office of the Company upon request, or upon request
to its financial intermediaries or the relevant central registration bank.
CONVENING NOTICES
The Second Meeting shall be convened by means of convening notices published twice, with a minimum interval of
fifteen days, and fifteen days before the Meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial")
and two Luxembourg newspapers. In the event that all the Noteholders of the Company are present or represented and
if they declare that they have been informed of the agenda of the Second Meeting, they may waive all convening require-
ments and formalities of publication.
QUORUM AND MAJORITY
Please note that pursuant to article 67-1 (3) of the law of 10th August 1915 on commercial companies (as amended),
Noteholders who are not present or represented at the Second Meeting shall be regarded as being present and as voting
for the Object Amendment.
The resolutions on the agenda may be passed without quorum requirements, by at least two thirds (2/3) of the votes
cast by the Noteholders present or represented.
182415
L
U X E M B O U R G
VOTING RIGHTS
Voting rights attaching to the Notes issued by the Company shall be commensurate with the portion of the loan which
they represent. Each note shall carry the right to at least one vote.
REQUEST FOR INFORMATION
Noteholders looking for more information can do so by contacting:
a) The Principal Paying Agent (for the First Issue):
KBL European Private Bankers SA.
43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg
Attention: Fiscal Agencies / Mr Geoffrey Zoller or Mrs. Isabelle Behin
Tel: 4797-1
Mail: kblux-fa.control@kbl.com
b) The central registration bank (for the other Issues):
Banque Internationale à Luxembourg (BIL)
69, route d'Esch | L-2953 Luxembourg
Attention : Corporate Trust / Marianne BEISSEL
Tel : 4590-1
Mail : Common.depository@bil.com
Luxembourg, on 8th December 2014,
Ernst-Wilhelm CONTZEN
Chairman
<i>The board of directors of the Companyi>
Référence de publication: 2014196470/755/166.
ATL Aquatrans Logistics S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 107.463.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionäre von Aquatrans Logistics S.A., welche am <i>18. Dezember 2014i> um 12.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der
nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Beschlussfassung über das Jahresergebnis
5. Verschiedenes
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014188021/17.
Ortano Mare Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 60.154.
In the year two thousand fourteen, on the fourth day of November,
Before Us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Ortano Mare Development S.A., a public limited
liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered
office at 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 60.154 (the Company). The Company has
been incorporated on July 15, 1997 pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing then
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on
October 30, 1997 number 597 page 28630. The articles of association of the Company have been amended for the last
182416
L
U X E M B O U R G
time on January 24, 2002 pursuant to an extraordinary general meeting of shareholders of the Company published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on May 29, 2002 number 815 page 39075.
The Meeting is opened at 5.05 p.m. and chaired by Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address
in Mondorf-les-Bains.
The Chairman appoints Mrs Brigitte Wahl, private employee, with professional address in Mondorf-les-Bains, as Se-
cretary of the Meeting.
The Meeting elects Mrs Karola Böhm, private employee, with professional address in Mondorf-les-Bains, as Scrutineer
of the Meeting (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau of
the Meeting).
The shareholders represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list
which, after having been signed by the representative(s) of the shareholders represented at the Meeting, the members
of the Bureau and the notary, will remain attached to the present minutes to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies from the shareholders represented at the present Meeting, signed by all the parties, will also remain
attached to the present minutes to be filed at the same time with the registration authorities.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares that:
I. It appears from the attendance list established and executed by the members of the Bureau that twenty-five thousand
one hundred (25,100) shares without par value, representing the entirety of the voting shares of the Company having an
issued share capital in an amount of six million two hundred twenty-two thousand one hundred twenty-seven Euro and
forty-seven cents (EUR 6,222,127.47), are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.
II. The agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of convening notices.
2. Transfer of the registered office (siège social) and central administration (administration centrale) of the Company
from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to the city of Vercelli, Italy, without the Company being
dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance as an Italian company in the legal form of a private
limited liability company (società a responsabilità limitata).
3. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (società a responsabilità limitata)
with the corporate name “Ortano Mare S.r.l.” and acceptance of the Italian nationality arising from the transfer of the
registered office (siège social) and central administration (administration centrale) of the Company from the city of
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to the city of Vercelli, Italy.
4. Confirmation that all the assets and liabilities of the Company will remain, further to the transfer of the registered
office (siège social) and central administration (administration centrale) of the Company from the city of Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, to the city of Vercelli, Italy, attached to the Company without discontinuation or restric-
tions.
5. Approval of the interim balance sheet of the Company as at the date of the Meeting.
6. Amendment and complete restatement of the articles of association of the Company in front of an Italian notary so
as to conform them to the laws of Italy in accordance with the terms provided.
7. (i) Acknowledgment and acceptance of the resignation of Mr. Pierre SCHILL, Mrs. Sabrina COLLETTE and Mrs.
Séverine FEITLER as directors of the Company and granting them full discharge (quitus) for the lawful performance of
their duties as directors of the Company from the date of their appointment until the date of this deed, and (ii) appointment
of Ms. Angioletta OLIVETTI as the Sole Director of the Company upon implementation of the transfer of the registered
office (siège social) and central administration (administration centrale) of the Company from the city of Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, to the city of Vercelli, Italy.
8. Delegation of powers to any lawyer or employee of Beerens & Avocats S.à r.l., Chiomenti Studio Legale and of
notary Marc Loesch, each acting and signing individually, to execute all formalities and do all acts in Luxembourg and Italy
necessary or useful for the purposes of the transfer of the registered office (siège social) and central administration
(administration centrale) of the Company from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to the city of
Vercelli, Italy, in accordance with any applicable law.
9. Miscellaneous.
III. After deliberation, the Meeting passes, by unanimous vote, the following resolutions:
<i>First Resolution:i>
The Meeting acknowledges that the entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting,
the shareholders of the Company waive the convening notices, considering themselves as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
182417
L
U X E M B O U R G
<i>Second Resolution:i>
The Meeting resolves to transfer the registered office (siège social) and central administration (administration centrale)
of the Company from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to the city of Vercelli, via Bazzi n. 16, Italy,
without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance as an Italian company
in the legal form of a private limited liability company (società a responsabilità limitata).
This resolution will be subject to the condition precedent of the registration of the Company in the Register of
Commerce and Companies of Vercelli, Italy.
<i>Third Resolution:i>
The Meeting resolves that the Company adopts the legal form of a private limited liability company (società a respon-
sabilità limitata) with the corporate name of “Ortano Mare S.r.l.”, and accepts that the Company acquires the Italian
nationality arising from the transfer of the registered office (siège social) and central administration (administration cen-
trale) of the Company from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to the city of Vercelli, Italy.
<i>Fourth Resolution:i>
The Meeting confirms that all the assets and liabilities of the Company will remain, further to the transfer of the
registered office (siège social) and central administration (administration centrale) of the Company from the city of
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to the city of Vercelli, Italy, attached to the Company without discontinuation
or restrictions.
<i>Fifth resolution:i>
The Meeting resolves to approve the interim balance sheet of the Company as at the date of this Meeting, a copy of
which shall remain attached to the present deed.
<i>Sixth resolution:i>
The Meeting resolves to amend and completely restate the articles of association of the Company in front of a notary
in Italy so as to conform them to the laws of Italy. The Meeting and, for the avoidance of any doubt, the shareholders of
the Company, who know and fully understand the Italian language, note and accept that the amended and restated articles
of the association of the Company (a draft copy of which has been tabled at the Meeting) are in the Italian language.
<i>Seventh resolution:i>
The Meeting resolves to (i) acknowledge and accept the resignation of Mr. Pierre SCHILL, Mrs. Sabrina COLLETTE
and Mrs. Séverine FEITLER as directors of the Company, effective as of the date hereof, and grant them full discharge
(quitus) for the lawful performance of their duties as directors of the Company from the date of their appointment until
the date of this deed, and (ii) appoint Ms. Angioletta OLIVETTI as the Sole Director of the Company upon implementation
of the transfer of the registered office (siège social) and central administration (administration centrale) of the Company
from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to the city of Vercelli, Italy
<i>Eighth resolution:i>
The Meeting resolves to appoint and authorise any lawyer or employee of Beerens & Avocats S.à r.l., Chiomenti Studio
Legale and of notary Marc Loesch, each acting and signing individually, to execute all formalities and do all acts in Lu-
xembourg and Italy necessary or useful for the purposes of the transfer of the registered office (siège social) and central
administration (administration centrale) of the Company from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to
the city of Vercelli, Italy, in accordance with any applicable law.
<i>Costs and expenses:i>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500.00).
There being no further business, the meeting is closed at 5.15 p.m..
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing persons
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surnames, names, civil status
and residence, the said persons appearing signed the present deed together with the notary.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois de novembre.
Par devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
182418
L
U X E M B O U R G
s’est tenue
une assemble générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de Ortano Mare Development S.A., une société
anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, rue Joseph Hackin, L-1746
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 60.154 (la Société). La Société a été constituée le 15 juillet 1997 suivant un acte
de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 597, page 28630 du 30 octobre 1997. Les statuts de
la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 24 janvier 2002 suivant une assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Société publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 815, page 39075 du 29 mai
2002.
L’Assemblée est ouverte à 17.05 heures et présidée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse
professionnelle à Mondorf-les-Bains.
Le Président nomme Madame Brigitte Wahl, employée privée, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, en
tant que Secrétaire de l’Assemblée.
L’Assemblée nomme Madame Karola Böhm, employée privée, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, en
tant que Scrutateur (de l’Assemblée (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant ensemble désignés le Bureau de
l’Assemblée).
Les actionnaires représentés à l’Assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste
de présence laquelle, après avoir été signée par le(s) mandataire(s) des actionnaires représentés à l’Assemblée, les mem-
bres du Bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées au présent
procès-verbal, après avoir été signées par toutes les parties, pour être soumises ensemble aux formalités de l’enregis-
trement.
Le Bureau ayant été ainsi formé, le Président déclare que:
I. Il ressort de la liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que vingt-cinq mille cent (25.100)
actions sans valeur nominale, représentant l’intégralité des actions votantes de la Société ayant un capital social émis d’un
montant de six millions deux cent vingt-deux mille cent vingt-sept Euros et quarante-sept cents (EUR 6.222.127,47), sont
dûment représentées à cette Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les
points de l’ordre du jour, reproduit ci-après.
II. L’ordre du jour de l’Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Transfert du siège social et de l’administration centrale de la Société de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, vers la ville de Vercelli, Italie, sans que la Société ne soit dissoute, mais au contraire, avec pleine continuation
de sa personnalité juridique en tant que société à responsabilité limitée de droit italien (società a responsabilità limitata).
3. Adoption par la Société de la forme juridique d’une société à responsabilité limitée (società a responsabilità limitata)
sous la dénomination de «Ortano Mare S.r.l.» et acceptation de la nationalité italienne découlant du transfert du siège
social et de l’administration centrale de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, vers la ville de Vercelli,
Italie.
4. Confirmation que tous les actifs et les passifs de la Société resteront, après le transfert du siège social et de l’ad-
ministration centrale de la Société de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, vers la ville de Vercelli, Italie,
affectés à la Société sans discontinuité ni restrictions.
5. Approbation du bilan intérimaire de la Société à la date de l’Assemblée.
6. Modification et refonte intégrale subséquente des statuts de la Société par-devant un notaire italien afin de les rendre
conformes aux lois d’Italie.
7. (i) Constat et acceptation de la démission de M. Pierre SCHILL, Mme Sabrina COLLETTE et Mme Séverine FEITLER,
en tant qu’administrateurs de la Société et quitus donné pour leurs mandats d’administrateurs de la Société à compter
de la date de leur nomination jusqu’à la date du présent acte, et (ii) nomination de Mme Angioletta OLIVETTI en tant
qu’Administrateur Unique de la Société à compter de la mise en oeuvre du transfert du siège social et de l’administration
centrale de la Société de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, vers la ville de Vercelli, Italie.
8. Délégation de pouvoirs à tout avocat ou employé de Beerens & Avocats S.à r.l., Chiomenti Studio Legale et du
notaire Marc Loesch, chacun agissant et signant individuellement, pour accomplir toutes formalités et tous actes au
Luxembourg et en Italie nécessaires ou utiles pour les besoins du transfert du siège social et de l’administration centrale
de la Société de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, vers la ville de Vercelli, Italie, conformément à
toute loi applicable.
9. Divers.
III. Après délibération, l’Assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
182419
L
U X E M B O U R G
<i>Première Résolutioni>
L’Assemblée constate que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, les actionnaires
renoncent aux formalités de convocation se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarent avoir une
parfaite connaissance de l’ordre du jour, lequel leur a été communiqué à l’avance.
<i>Deuxième Résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le siège social et l’administration centrale de la Société de la ville de Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, vers la ville de Vercelli, via Bazzi n. 16, Italie, sans que la Société ne soit dissoute, mais au
contraire, avec pleine continuation de sa personnalité juridique en tant que société à responsabilité limitée de droit italien
(società a responsabilità limitata).
Cette résolution sera soumise à la condition suspensive de l’inscription de la Société au Registre de Commerce et des
Sociétés de Vercelli, Italie.
<i>Troisième Résolutioni>
L’Assemblée décide que Société adopte la forme juridique d’une société à responsabilité limitée (società a responsabilità
limitata) sous la dénomination de «Ortano Mare S.r.l.» et accepte que la Société acquiert la nationalité italienne découlant
du transfert du siège social et de l’administration centrale de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, vers
la ville de Vercelli, Italie.
<i>Quatrième Résolutioni>
L’Assemblée confirme que tous les actifs et les passifs de la Société resteront, après le transfert du siège social et de
l’administration centrale de la Société de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, vers la ville de Vercelli,
Italie, affectés à la Société sans discontinuité ni restrictions.
<i>Cinquième Résolutioni>
L’Assemblée décide d’approuver le bilan intérimaire de la Société à la date de cette Assemblée, dont une copie restera
annexée au présent acte.
<i>Sixième Résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier et de refondre intégralement les statuts de la Société par devant un notaire italien
afin de les rendre conformes aux lois d’Italie. L’Assemblée et, afin d’éviter tout doute, les actionnaires de la Société, qui
connaissent et comprennent parfaitement la langue italienne, notent et acceptent que les statuts modifiés et refondus de
la Société (dont une copie a été présentée à l’Assemblée) soient rédigés en langue italienne.
<i>Septième Résolutioni>
L’Assemblée décide de (i) constater et accepter la démission de M. Pierre SCHILL, Mme Sabrina COLLETTE et Mme
Séverine FEITLER, en tant qu’administrateurs de la Société et de leur donner quitus pour leurs mandats d’administrateurs
de la Société à compter de la date de leur nomination jusqu’à la date du présent acte, et (ii) nommer Mme Angioletta
OLIVETTI en tant qu’Administrateur Unique de la Société à compter de la mise en oeuvre du transfert du siège social et
de l’administration centrale de la Société de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, vers la ville de Vercelli,
Italie.
<i>Huitième Résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer et d’autoriser tout avocat ou employé de Beerens & Avocats S.à r.l., Chiomenti Studio
Legale et du notaire Marc Loesch, chacun agissant et signant individuellement, pour accomplir toutes formalités et tous
actes au Luxembourg et en Italie nécessaires ou utiles pour les besoins du transfert du siège social et de l’administration
centrale de la Société de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, vers la ville de Vercelli, Italie, confor-
mément à toute loi applicable.
<i>Frais et Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison
du présent acte sont estimés à approximativement deux mille cinq cents euros (EUR 2.500).
Plus rien étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.15 heures.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes qu’à la demande des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. À la demande des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Lecture du document ayant été faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms, état
civil et résidences, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Stolz-Page, B. Wahl, K. Böhm, M. Loesch.
182420
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Remich, le 12 novembre 2014. REM/2014/2462. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 19 novembre 2014.
Référence de publication: 2014179352/237.
(140205697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2014.
Rigo Trading S.A., Société Anonyme,
(anc. Pirelli Finance (Luxembourg) S.A.).
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 58.422.
L'an deux mille quatorze, le vingt-six novembre.
Par-devant nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PIRELLI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. (ci-après la «So-
ciété»), une société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58422, constituée selon acte reçu par Maître Jacques
Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 321, le 25 juin 1997. Les statuts ont été modifiés la dernière fois en vertu d'un acte reçu par Maître
Cosita Delvaux, notaire de residence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 27 décembre 2012,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 306, le 7 février 2013.
L'assemblée s'est ouverte à 19.20 heures sous la présidence de Monsieur Alexander Olliges, Rechtsanwalt, résidant
professionellement à Luxembourg, qui a désigné Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg comme
secrétaire. L'assemblée élit Madame Elena Médagli, Rechtsanwältin, professionnellement résidant à Luxembourg comme
scrutatrice et approuve la constitution du bureau.
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de continuer la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
2. Changement du nom de la société de “PIRELLI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.” à “Rigo Trading S.A.” et modifi-
cation corrélative de l'article 1 des statuts.
3. Décision d'établir le siège social dans la municipalité de Niederanven, de transférer avec effet immédiat le siège social
de la société de 11-13, Boulevard de la Foire, L -1528 Luxembourg à 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, d'effacer
une partie de la deuxième phrase de l'article 2 du statuts et de modifier corrélativement l'article 2.
4. Extension de l'objet social de la société en ajoutant la partie suivante après le troisième paragraphe de l'article 4
des statuts:
«La société a également pour objet (i) l'acquisition par achat, enregistrement ou de toute autre manière ainsi que le
transfert par la vente, l'échange ou autre de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l'octroi de licence sur de
tels droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle
et industrielle.
La société peut en outre se charger de l'approvisionnement et notamment de l'achat de produits primaires pour les
activités des sociétés de son groupe, et de la distribution des biens produits par une des sociétés de son groupe sur le
marché luxembourgeois, et ceci à l'échelle mondiale aux clients des boutiques hors taxe et aux clients du marché de
détail.»
5. Introduction de la possibilité de nommer un administrateur unique selon les conditions prévues par la loi et modi-
fication corrélative de l'article 9 des statuts.
6. Modification du pouvoir de signature de la société d'une nécessité d'une signature conjointe de trois administrateurs
à une signature conjointe de deux administrateurs et modification corrélative de l'article 16 des statuts.
7. Décision de remplacer les références faîtes au «réviseur d'entreprises”» par la référence au «réviseur d'entreprises
agréé» afin de refléter les changements en droit des sociétés et de modifier en conséquence les articles 17, 22 et 28.
8. Modification de l'article 20 des statuts afin de refléter les changements en droit des sociétés de la manière suivante:
«Le conseil d'administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire
doit déposer ses actions au porteur en conformité avec les règles légales applicables.»
182421
L
U X E M B O U R G
9. Insertion d'un paragraphe additionnel et final dans l'article 29, qui sera désormais rédigé comme suit:
«Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux actionnaires
sous réserve des dispositions de la loi et des présents statuts.»
10. Décision d'ajouter une traduction anglaise aux statuts.
11. Constatation de la démission des administrateurs actuels et nomination d'un nouvel administrateur de la Société.
12. Remplacement de Ernst & Young comme commissaire de la société par KPMG Luxembourg S.à r.l..
13. Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont indiqués sur une liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires, les mandataires des ac-
tionnaires représentés, les membres du bureau de l'assemblée ainsi que le notaire soussigné, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés,
signées ne varietur, par les parties comparantes et le notaire, resteront attachées au présent acte.
III. Il ressort de la liste de présence susmentionnée que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à
la présent assemblée et les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable et renoncent aux formalités relatives à la convocation.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut en conséquence valablement délibérer sur tous les
points figurant à l'ordre du jour.
V. Que l'assemblée générale envisage d'ajouter une traduction en anglais à la version française des statuts suite aux
modifications des certains articles lesquelles seront approuvés une fois que ces modifications sont faites.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires adopte, et
requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L'assemblée générale constate sur la base des derniers comptes annuels pour l'exercice financier clos le 31 décembre
2013 et sur la base des informations accessibles, que la société a subis une perte de plus de soixante-quinze pourcent (75
%) du capital social et décide expressément de continuer la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer le nom de la société de “PIRELLI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.” à “Rigo
Trading S.A.” et de modifier l'article 1 des statuts de manière suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de Rigo Trading S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'établir le siège sociale dans la municipalité de Niederanven, de transférer avec effet
immédiat le siège sociale de la société de 11-13, Boulevard de la Foire, L -1528 Luxembourg à 6, route de Trèves, L-2633
Senningerberg et d'effacer une partie de la deuxième phrase de l'article 2 des statuts, qui sera désormais rédigé comme
suit:
« Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Niederanven. Il pourra être transféré à l'intérieur
de la commune du siège social par simple décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration aura le droit
d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le
Grand Duché de Luxembourg ainsi qu'à l'étranger.»
<i>Quatrième Résolutioni>
L'assemblée générale décide d'élargir l'objet social de la société en ajoutant la partie suivante après le troisième pa-
ragraphe de l'article 4 des statuts:
«La société a également pour objet (i) l'acquisition par achat, enregistrement ou de toute autre manière ainsi que le
transfert par la vente, l'échange ou autre de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l'octroi de licence sur de
tels droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle
et industrielle.
La société peut en outre se charger de l'approvisionnement et notamment de l'achat de produits primaires pour les
activités des sociétés de son groupe, et de la distribution des biens produits par une des sociétés de son groupe sur le
marché luxembourgeois, et ceci à l'échelle mondiale aux clients des boutiques hors taxe et aux clients du marché de
détail.»
<i>Cinquième Résolutioni>
L'assemblée générale décide d'introduire la possibilité de nommer un administrateur unique selon les conditions pré-
vues par la loi et de modifier l'article 9 des statuts, qui se lit désormais comme suit:
182422
L
U X E M B O U R G
« Art. 9. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser une année et en tout temps, révocables
par elle. Cependant, lorsque la société a été constituée par un actionnaire unique ou lorsqu'il apparaît, lors d'une assemblée
générale d'actionnaires, que toutes les actions émises par la société sont détenues par un actionnaire unique, la Société
peut être administrée par un administrateur unique jusqu'à la prochaine assemblée générale d'actionnaires consécutive à
l'augmentation du nombre d'actionnaires. Dans cette hypothèse, une référence au «conseil d'administration» utilisée dans
les présents statuts doit être entendue comme une référence à l'«administrateur unique».
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration. Le premier président peut être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du prési-
dent, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants peuvent
pourvoir au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.»
<i>Sixième Résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier le pouvoir de signature de la société d'une nécessité d'une signature conjointe
de trois administrateurs à une signature conjointe de deux administrateurs et de modifier l'article 16 des statuts en
conséquence de la manière suivante:
« Art. 16. Tous documents et actes et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont
signés au nom de la société conjointement par au moins deux administrateurs, le tout sauf délégations spéciales.»
<i>Septième Résolutioni>
L'assemblée générale décide de remplacer les références faites au «réviseur d'entreprises”» par la référence au «ré-
viseur d'entreprises agréé» afin de refléter les changements en droit des sociétés et de modifier les l'articles 17, 22 et 28
en conséquence de la manière suivante:
« Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires ou dans le cas prévu
par la loi par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs
émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser un an, et en tout temps, révocables par elle.
Tout commissaire ou réviseur d'entreprises agréé sortant est rééligible.»
« Art. 22. L'assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire ou du
réviseur d'entreprises agréé, votera sur l'approbation des comptes annuels et sur la distribution des profits, procédera
aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et le cas échéant au commissaire et
traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.
Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.»
« Art. 28. Chaque année à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans
les formes requises par la loi.
Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, l'administration soumettra le bilan de la société et le compte
de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire ou réviseur d'entreprises agréé qui, sur ce, établira son rapport.
Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le
rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises agréé ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par
la loi, seront déposés au siège social de la société, ou les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures
de bureau normales.»
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 20 des statuts afin de refléter les changements en droit des sociétés
de la manière suivante:
«Le conseil d'administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire
doit déposer ses actions au porteur en conformité avec les règles légales applicables.»
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'insérer un paragraphe additionnel et final dans l'article 29, qui sera désormais rédigé
comme suit:
«Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux actionnaires
sous réserve des dispositions de la loi et des présents statuts.»
182423
L
U X E M B O U R G
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'ajouter la traduction anglaise suivante des statuts en français, prenant en compte les
changements mentionnés, et décide que la version française continue de faire foi inter partes:
“Name - Registered office - Duration - Purpose
Art. 1. There hereby exists a Luxembourg public limited company (“société anonyme”) under the name of Rigo Trading
S.A.
Art. 2. The registered office of the company is established in the municipality of Niederanven. It may be transferred
within the municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors. The board of directors may
establish offices, branches, agencies or administrative offices anywhere, as the case may be, in the Grand-Duchy of Lux-
embourg as well as in foreign countries.
Art. 3. The duration of the company is unlimited.
Art. 4. The purpose of the company is the taking of interests in any form in other Luxembourg or foreign companies,
or the making of any other form of investment, the acquisition through the purchase, subscription or in any other manner,
as well as the disposal through the sale, exchange or in any other manner of any transferable securities and any monies,
as well as the management, control and development of such interests.
The company may participate in the establishment and in the development of any industrial or commercial undertaking
and may grant support through loans, guarantees or otherwise. The company shall be in charge of co-ordinating the
group's internal financial management. The company may lend or borrow with or without interest, provided that the
borrowed amounts may only be used for the needs of the company or companies which are subsidiaries of the company,
or for the needs of a company of the group; in general the company may carry out any transactions and activities directly
related to such purpose. The company may issue bonds and other debt certificates.
An additional purpose of the company is also the purchase, management, development through leasing or in any other
way and, as the case may be, the sale of buildings of any kind, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
A further purpose of the company is (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.
The Company may further take care of the procurement and in particular the purchase of raw materials for the activities
of the companies of its group, and the distribution of goods produced by a company of its group on the Luxembourg
market, and to duty free and retail customers worldwide.
The company may also carry out any industrial, commercial and financial transactions as well as transactions associated
with moveable and immoveable property, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad, which are directly or
indirectly linked, in whole or in part, to its corporate purpose. The Company may achieve its purpose directly or indirectly,
on its own behalf or for third parties, alone or in association, by conducting any operations or any activities which are
likely to favour the said purpose or the purpose of companies in which the group holds interests.
In general, the company may take any control and supervision measures and carry out any operations which it may
deem useful in achieving its corporate purpose and objective.
Capital - Shares
Art. 5. The subscribed share capital is set at thirteen million five hundred ninety-four thousand nine hundred ten euro
(EUR 13,594,910), divided into twenty-six thousand two hundred forty-five (26,245) shares with a par value of five hundred
eighteen euro (EUR 518) each.
All the shares are in bearer or registered form, at the option of the shareholders.
The authorised share capital is set at fifty-one million eight hundred thousand euro (EUR 51,800,000), divided into
hundred thousand (100,000) shares with a par value of five hundred eighteen euro (EUR 518) each.
The authorised share capital and the subscribed share capital of the company may be increased or reduced by a decision
of the general meeting of shareholders voting under the same conditions as for the amendment of the articles of asso-
ciation.
The board of directors may, for a period ending on 11 May 2014, increase the subscribed share capital from time to
time within the limits of the authorised share capital.
Such capital increases may, as determined by the board of directors, be subscribed for and issued in the form of shares
with or without share premium, to be fully or partially paid up, in cash, in kind or in compensation for uncontested,
current and immediately exercisable claims against the company, or, in case of adequate authorization of the general
meeting resolving on the constitution of such reserves or premium, even by incorporation of profits brought forward or
of available reserves or of share premium, as determined by the board of directors.
182424
L
U X E M B O U R G
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article will be considered to be automatically adapted to the change made.
The company may redeem its own shares, to the extent permitted by and under the conditions provided for by law.
Art. 6. The shares of the company may be in registered form or in bearer form, at the option of the shareholders,
subject to the restrictions foreseen by law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law on commercial com-
panies.
Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.
The company may issue certificates representing bearer shares. Such certificates will be signed by two directors.
Art. 7. The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the
company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one single person has been appointed
as the owner in relation to the company. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the owner
of legal title, or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and the pledgee.
Bonded loans
Art. 8. The board of directors may decide to issue bonded loans, by way of issue of bearer or other bonds, with any
denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.
The board of directors will determine the nature, price, rate of interest, issue and repayment conditions as well as any
other conditions in relation thereto.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
Administration - Supervision
Art. 9. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be
shareholders. The directors will be appointed by the general meeting of shareholders for a maximum period of one year
and they may be removed at any time by the general meeting of shareholders.
Where the Company has been incorporated by a single shareholder or where it appears at a general meeting of
shareholders that all the shares issued by the company are held by a sole shareholder, the company may be managed by
a sole director until the next general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In
such case, a reference to the “board of directors” used in these articles of association is to be construed as a reference
to the “sole director”.
Any leaving director is eligible for reappointment.
The board of directors will choose from among its members a chairman, and may choose one or several vice-chairmen
of the board of directors. The first chairman may be chosen by the general meeting of shareholders. In the absence of
the chairman the meetings of the board of directors will be chaired by a director present at the meeting and appointed
to that end.
In the event of a vacancy on the board of directors for any reason whatsoever, the remaining directors have the right
to provisionally fill the vacancy until the next general meeting; in this case, such next general meeting will definitively fill
such vacancy.
Art. 10. The board of directors shall meet upon call by the chairman or any two directors.
The directors will be convened separately to each meeting of the board of directors. Except in an emergency which
shall be specified in the convening notice, the convening notice shall be notified at least twenty-four hours before the
date fixed for the meeting.
The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented, as well as in all
the cases where the date of the meeting has been determined beforehand in a meeting. The meetings of the board of
directors are held at the place and at the date specified in the convening notice.
The board of directors can validly deliberate and take decisions only if a majority of its members is present or validly
represented.
Directors unable to be present may delegate in writing another member of the board to represent them and to vote
in their name. A director may represent several of his colleagues.
Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. Where the number of votes cast for and
against a resolution is equal, the chairman has a casting vote.
Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened
and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letter, telegram or telex.
182425
L
U X E M B O U R G
Any director having interests opposite to those of the company in a matter submitted to the approval of the board
will be obliged to inform the board thereof and his declaration will be recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board. At the next general meeting of shareholders, before votes are
taken on any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which a director has a personal interest
contrary to that of the company.
In the event of a member of the board of directors having to abstain due to a conflict of interest, the resolutions taken
by a majority of the other members of the board present or represented at the meeting and voting will be considered
valid.
Art. 11. The resolutions of the board of directors will be recorded in the minutes, to be filed in a special folder and
signed by at least one director.
Copies or extracts of such minutes must be signed by a director.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration
in the interest of the company.
All powers not expressly reserved by the law of 10 August 1915, as amended, or by these articles of association to
the general meeting of shareholders will fall within the competence of the board of directors.
Art. 13. The board of directors may delegate powers to one or several of its members. It may appoint proxies with
specific powers, and revoke such appointments at any time. It may also, with the prior approval of the general meeting
of shareholders, entrust day-to-day management of the company's business to one or several of its members, being in
such case called managing directors.
Art. 14. The board of directors may establish an executive committee made up of members of the board of directors
and set the number of its members. The executive committee may have such powers and authority to act on behalf of
the board of directors as determined by the board of directors in a prior resolution. Unless otherwise provided for by
the board of directors the executive committee will determine its own procedure for convening and holding its meetings.
The board of directors will fix, as the case may be, the remuneration of the members of the executive committee.
Art. 15. The board of directors will represent the company in court as plaintiff or as defendant. All writs or judicial
acts for or against the company are validly issued in the name of the company alone.
Art. 16. All documents and mandates will validly bind the company if they are jointly signed in the name of the company
by at least two directors, unless special delegations are provided for.
Art. 17. The audit of the company's affairs will be entrusted to one or more internal auditors (commissaires) or, in
the cases provided for by law, by one or several independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés), to be appointed
by the general meeting of shareholders which will determine their number, remuneration and term of their mandate
which cannot exceed one (1) year, and is at any time revocable by it. Such auditors may be removed at any time by the
general meeting of shareholders. Leaving internal auditors and independent auditor's (réviseur d'entreprises agréé) are
eligible for re-election.
General meetings of shareholders
Art. 18. The annual general meeting of shareholders may by simple resolution allocate to the directors an appropriate
remuneration for the performance of their mandate.
Art. 19. Any regularly constituted general meeting of shareholders will represent the entire body of shareholders. Its
decisions are binding on shareholders who are absent, opposed or abstain from voting.
Art. 20. The board of directors may require that in order to be admitted at general meetings, any owner of shares
shall deposit his bearer shares in accordance with the applicable legal provisions.
Art. 21. The annual general meeting of shareholders will be held on the first Thursday of the month of March of each
year at 12:00 (noon).
If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day at the same
time.
Extraordinary general meetings of shareholders will be convened and held at the place determined by the board of
directors.
Art. 22. The general meeting of shareholders will hear the report of the board of directors and of the internal auditor
or independent auditor (réviseur d'entreprises agréé), will vote on the approval of the annual accounts and on the
distribution of the profit, proceed to make all appointments required by these articles of association, grant discharge to
the directors and, as the case may be, the internal auditor and take such further action on other matters that may properly
come before it.
Each share entitles the holder to one vote.
Each shareholder is entitled to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
182426
L
U X E M B O U R G
Each shareholder is entitled to request a vote by secret ballot.
Art. 23. The general meeting of shareholders deliberating at a meeting with a quorum and with a majority as prescribed
by law may amend the articles of association in every respect except to the extent that the law imposes a limitation.
Art. 24. The board of directors, respectively the internal auditor, will be responsible for convening ordinary and
extraordinary general meetings of shareholders.
They will be obliged to convene a general meeting of shareholders whenever a group of shareholders representing at
least one fifth of the subscribed capital makes a request in writing indicating the agenda.
Notices convening general meetings of shareholders must contain the agenda for such meetings.
The board of directors may determine the form of proxies to be used and require them to be deposited at a time and
place which it shall determine.
Art. 25. The general meeting of shareholders is chaired by the chairman of the board of directors or, in his absence,
by the director who replaces him or by a person designated by the general meeting of shareholders.
The meeting will select from among the attendants the secretary and one or two scrutineers.
Art. 26. The minutes of the general meetings of shareholders will be signed by the members of the board (bureau)
and by any shareholder who wishes to do so.
However, in cases where decisions of the general meeting of shareholders have to be certified, copies or extracts for
use in court or elsewhere must be signed by a director.
Financial year - Balance sheet - Allocation of profits
Art. 27. The company's financial year starts on 1 January and ends on a 31 December of every year.
Art. 28. Each year, at the closing of financial year, the board of directors will draw up the annual accounts in the form
contemplated by law.
At the latest one month prior to the annual general meeting of shareholders, the board of directors will submit the
company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required
by law to the internal auditor or independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) who will thereupon draw up his
report.
A fortnight before the annual general meeting of shareholders the balance sheet and profit and loss statement, the
management report, the internal auditor's or independent auditor (réviseur d'entreprises agréé)'s report and such other
documents as may be required by law will be deposited at the registered office of the company where they will be available
for inspection by the shareholders during regular business hours.
Art. 29. The credit balance on the profit and loss statement, after deduction of the general expenses, social charges,
write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the board of directors, shall represent the
net profit of the company.
Every year, five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction ceases
to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the subscribed share capital.
The remaining balance of the net profit will be at the disposal of the general meeting of shareholders.
Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the board of directors within the limits of
the decision of the general meeting of shareholders.
The payment of interim dividends may be authorised by the board of directors, subject to respecting the relevant legal
requirements.
The general meeting of shareholders may decide to allocate profits and distributable reserves to the reimbursement
of the capital without reducing the corporate capital.
Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the relevant legal requirements as well as the provisions of these articles of association.
Winding up - Liquidation
Art. 30. It may be wound up by a decision of the general meeting of shareholders adopted at the same majority as
provided for amendments to the articles of association.
Art. 31. In the event of the winding up of the company the general meeting of shareholders will determine the method
of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.
An amount necessary to repay the paid up portion of each share will be deducted from net assets after settlement of
liabilities on liquidation; any surplus will be distributed equally between all shareholders.
General provision
Art. 32. As regards any matters which are not specified in these articles of association, the parties refer and submit to
the provisions of the Luxembourg law of 10 August 1915 as amended from time to time.”
182427
L
U X E M B O U R G
<i>Onzième résolutioni>
L'assemblée générale décide de prendre acte de la démission de tous les administrateurs de la Société, que la Société
ne comporte qu'un seul associé, et décide de nommer comme nouvel administrateur pour la période courant jusqu'à la
date de l'assemblée générale des associés statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2014:
- M. Conrad Carl Feßler, né à Böblingen (Allemagne) le 29 avril 1971, ayant son adresse professionnelle à 6, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg.
<i>Douzième résolutioni>
L'assemblée générale décide de révoquer et remplacer Ernst & Young par KPMG Luxembourg S.à r.l., ayant son siège
social 9, allée Scheffer au Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 149.133 en tant qu'auditeur de la Société pour la période courant jusqu'à la date de l'assemblée générale
des associés statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2014.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été clôturée à 20.00 heures.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est
rédigé en langue française suivi d'une traduction en anglais; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de
divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte français fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,
ledit mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of November.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
the extraordinary general meeting of the shareholders of PIRELLI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. (the “Company”),
a société anonyme existing under Luxembourg law, having its registered office at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 58422, incorporated pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, on 28 February 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 321 on 25 June 1997. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of Maître
Cosita Delvaux, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, dated 27 December 2012, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 306 on 7 February 2013.
The meeting was opened at 7.20. p.m. with Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt in the chair, professionally residing
in Luxembourg, who appointed as secretary Ms. Alina Rymalova, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms. Elena Medagli, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg and approves
the composition of the board.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary
to record the following:
I. The agenda of the present meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Decision on the continuation of the Company pursuant to article 100 of the Luxembourg law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended.
2. Change of the name of the Company from “PIRELLI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.” to “Rigo Trading S.A.” and
subsequent amendment of article 1 of the articles of association.
3. Decision to set the registered office in the municipality of Niederanven, transfer the registered office of the Company
from 11-13, Boulevard de la Foire, L -1528 Luxembourg to 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, to delete part of
the second sentence of article 2 of the articles of association, and to amend article 2 accordingly.
4. Widening of the corporate object of the Company by adding the following sections after the fourth paragraph of
article 4 of the articles of association:
“A further purpose of the company is (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
The Company may further take care of the procurement and in particular the purchase of raw materials for the activities
of the companies of its group, and the distribution of goods produced by a company of its group on the Luxembourg
market, and to duty free and retail customers worldwide.”
182428
L
U X E M B O U R G
5. Introduction of the possibility for a sole director to be appointed under the conditions provided by law and amend-
ment of article 9 of the articles of association accordingly.
6. Amendment of the power to sign of the Company from a necessity of a joint signature of three directors to a joint
signature of any two directors and subsequent amendment of article 16 accordingly.
7. Decision to replace references to a “réviseur d'entreprises” by a reference to a “réviseur d'entreprises agréé” in
order to reflect changes in company law and to amend articles 17, 22 and 28 accordingly.
8. Amendment of article 20 of the articles of association in order to reflect changes in company law as follows:
“The board of directors may require that in order to be admitted at general meetings, any owner of shares shall deposit
his bearer shares in accordance with the applicable legal provisions.
9. Insertion of an additional, final paragraph in article 29 which shall read as follows:
“Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the relevant legal requirements as well as the provisions of these articles.”
10. Decision to add an English translation to the articles of association.
11. Acknowledgement of the resignation of the current directors and appointment of a new director of the Company.
12. Replacement of Ernst & Young as auditor of the Company by KPMG Luxembourg S.à r.l.
13. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented
shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary,
shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III. It appears from the above-mentioned attendance list, that the entire share capital of the Company is present or
represented at the meeting meeting and the shareholders present or represented declaring that they have had due notice
and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waive any convening formalities.
IV. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
V. That the general meeting contemplates to add an English translation to the French version of the articles of asso-
ciation following amendments of certain articles and which will be resolved upon once these amendments have been
made.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders takes, and requires the notary
to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting acknowledges on the basis of the last annual accounts for the financial year ended on December
31, 2013 and information available, that the Company has incurred a loss of more than seventy-five percent (75%) of the
share capital and expressly resolves to continue the Company in accordance with article 100 of the law of 10 August
1915 concerning commercial companies, as amended.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to change the Company's name from “PIRELLI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.” to
“Rigo Trading S.A.” and amend article 1 of the articles of association as follows:
“ Art. 1. There exists a Luxembourg public limited company (société anonyme) under the name of “Rigo Trading S.A.”.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to set the registered office in the municipality of Niederanven, transfer the registered
office of the Company from 11-13, Boulevard de la Foire, L -1528 Luxembourg to 6, route de Trèves, L-2633 Sennin-
gerberg with immediate effect and to delete part of the second sentence of article 2 of the articles of association, which
shall henceforth read as follows:
“ Art. 2. The registered office of the company is established in the municipality of Niederanven. It may be transferred
within the municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors. The board of directors may
establish offices, branches, agencies or administrative offices anywhere, as the case may be, in the Grand-Duchy of Lux-
embourg as well as in foreign countries.”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to widen the corporate object of the Company by adding the following sections after
the fourth paragraph of article 4 of the articles of association:
“A further purpose of the company is (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
182429
L
U X E M B O U R G
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
The Company may further take care of the procurement and in particular the purchase of raw materials for the activities
of the companies of its group, and the distribution of goods produced by a company of its group on the Luxembourg
market, and to duty free and retail customers worldwide.”
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolves to introduce the possibility for a sole director to be appointed under the conditions
provided by law and subquent amendment of article 9 of the articles of association as follows:
“ Art. 9. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not
be shareholders. The directors will be appointed by the general meeting of shareholders for a maximum period of one
year and they may be removed at any time by the general meeting of shareholders.
Where the Company has been incorporated by a single shareholder or where it appears at a general meeting of
shareholders that all the shares issued by the company are held by a sole shareholder, the company may be managed by
a sole director until the next general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In
such case, a reference to the “board of directors” used in these articles of association is to be construed as a reference
to the “sole director”.
Any leaving director is eligible for reappointment.
The board of directors will choose from among its members a chairman, and may choose one or several vice-chairmen
of the board of directors. The first chairman may be chosen by the general meeting of shareholders. In the absence of
the chairman the meetings of the board of directors will be chaired by a director present at the meeting and appointed
to that end.
In the event of a vacancy on the board of directors for any reason whatsoever, the remaining directors have the right
to provisionally fill the vacancy until the next general meeting; in this case, such next general meeting will definitively fill
such vacancy.”
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting resolves to amend the power to sign of the Company from a necessity of a joint signature of
three directors to a joint signature of any two directors and resolves to amend article 16 of the articles of association
accordingly as follows:
“ Art. 16. All documents and mandates will validly bind the company if they are jointly signed in the name of the
company by at least two directors, unless special delegations are provided for.”
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting resolves to replace references to a “réviseur d'entreprises” by a reference to a “réviseur d'en-
treprises agréé” in order to reflect changes in company law and to amend articles 17, 22 and 28 accordingly as follows:
“ Art. 17. The audit of the company's affairs will be entrusted to one or more internal auditors (commissaires) or, in
the cases provided for by law, by one or several independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés), to be appointed
by the general meeting of shareholders which will determine their number, remuneration and term of their mandate
which cannot exceed one (1) year, and is at any time revocable by it. Such auditors may be removed at any time by the
general meeting of shareholders. Leaving internal auditors and independent auditor's (réviseur d'entreprises agréé) are
eligible for re-election.
Outgoing internal auditors and independent auditors are eligible for reelection.”
“ Art. 22. The general meeting of shareholders will hear the report of the board of directors and of the internal auditor
or independent auditor (réviseur d'entreprises agréé), will vote on the approval of the annual accounts and on the
distribution of the profit, proceed to make all appointments required by these articles of association, grant discharge to
the directors and, as the case may be, the internal auditor and take such further action on other matters that may properly
come before it.
Each share entitles the holder to one vote.
Each shareholder is entitled to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each shareholder is entitled to request a vote by secret ballot.”
“ Art. 28. Each year, at the closing of financial year, the board of directors will draw up the annual accounts in the form
contemplated by law.
At the latest one month prior to the annual general meeting of shareholders, the board of directors will submit the
company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required
by law to the internal auditor or independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) who will thereupon draw up his
report.”
182430
L
U X E M B O U R G
A fortnight before the annual general meeting of shareholders the balance sheet and profit and loss statement, the
management report, the internal auditor's or independent auditor (réviseur d'entreprises agréé)'s report and such other
documents as may be required by law will be deposited at the registered office of the company where they will be available
for inspection by the shareholders during regular business hours.”
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 20 of the articles of association in order to reflect changes in company
law as follows:
“ Art. 20. The board of directors may require that in order to be admitted at general meetings, any owner of shares
shall deposit his bearer shares in accordance with the applicable legal provisions.”
<i>Ninth resolutioni>
The general meeting resolves to insert an additional, final paragraph in article 29 which shall read as follows:
“Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the relevant legal requirements as well as the provisions of these articles.”
<i>Tenth resolutioni>
The general meeting resolves to add the following English translation of the French version of the articles of association,
taking into account the foregoing changes, and resolves that the French version shall continue to prevail inter partes:
“Name - Registered office - Duration - Purpose
Art. 1. There hereby exists a Luxembourg public limited company (“société anonyme”) under the name of Rigo Trading
S.A.
Art. 2. The registered office of the company is established in the municipality of Niederanven. It may be transferred
within the municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors. The board of directors may
establish offices, branches, agencies or administrative offices anywhere, as the case may be, in the Grand-Duchy of Lux-
embourg as well as in foreign countries.
Art. 3. The duration of the company is unlimited.
Art. 4. The purpose of the company is the taking of interests in any form in other Luxembourg or foreign companies,
or the making of any other form of investment, the acquisition through the purchase, subscription or in any other manner,
as well as the disposal through the sale, exchange or in any other manner of any transferable securities and any monies,
as well as the management, control and development of such interests.
The company may participate in the establishment and in the development of any industrial or commercial undertaking
and may grant support through loans, guarantees or otherwise. The company shall be in charge of co-ordinating the
group's internal financial management. The company may lend or borrow with or without interest, provided that the
borrowed amounts may only be used for the needs of the company or companies which are subsidiaries of the company,
or for the needs of a company of the group; in general the company may carry out any transactions and activities directly
related to such purpose. The company may issue bonds and other debt certificates.
An additional purpose of the company is also the purchase, management, development through leasing or in any other
way and, as the case may be, the sale of buildings of any kind, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
A further purpose of the company is (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.
The Company may further take care of the procurement and in particular the purchase of raw materials for the activities
of the companies of its group, and the distribution of goods produced by a company of its group on the Luxembourg
market, and to duty free and retail customers worldwide.
The company may also carry out any industrial, commercial and financial transactions as well as transactions associated
with moveable and immoveable property, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad, which are directly or
indirectly linked, in whole or in part, to its corporate purpose. The Company may achieve its purpose directly or indirectly,
on its own behalf or for third parties, alone or in association, by conducting any operations or any activities which are
likely to favour the said purpose or the purpose of companies in which the group holds interests.
In general, the company may take any control and supervision measures and carry out any operations which it may
deem useful in achieving its corporate purpose and objective.
Capital - Shares
Art. 5. The subscribed share capital is set at thirteen million five hundred ninety-four thousand nine hundred ten euro
(EUR 13,594,910), divided into twenty-six thousand two hundred forty-five (26,245) shares with a par value of five hundred
eighteen euro (EUR 518) each.
182431
L
U X E M B O U R G
All the shares are in bearer or registered form, at the option of the shareholders.
The authorised share capital is set at fifty-one million eight hundred thousand euro (EUR 51,800,000), divided into
hundred thousand (100,000) shares with a par value of five hundred eighteen euro (EUR 518) each.
The authorised share capital and the subscribed share capital of the company may be increased or reduced by a decision
of the general meeting of shareholders voting under the same conditions as for the amendment of the articles of asso-
ciation.
The board of directors may, for a period ending on 11 May 2014, increase the subscribed share capital from time to
time within the limits of the authorised share capital.
Such capital increases may, as determined by the board of directors, be subscribed for and issued in the form of shares
with or without share premium, to be fully or partially paid up, in cash, in kind or in compensation for uncontested,
current and immediately exercisable claims against the company, or, in case of adequate authorization of the general
meeting resolving on the constitution of such reserves or premium, even by incorporation of profits brought forward or
of available reserves or of share premium, as determined by the board of directors.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article will be considered to be automatically adapted to the change made.
The company may redeem its own shares, to the extent permitted by and under the conditions provided for by law.
Art. 6. The shares of the company may be in registered form or in bearer form, at the option of the shareholders,
subject to the restrictions foreseen by law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law on commercial com-
panies.
Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.
The company may issue certificates representing bearer shares. Such certificates will be signed by two directors.
Art. 7. The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the
company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one single person has been appointed
as the owner in relation to the company. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the owner
of legal title, or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and the pledgee.
Bonded loans
Art. 8. The board of directors may decide to issue bonded loans, by way of issue of bearer or other bonds, with any
denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.
The board of directors will determine the nature, price, rate of interest, issue and repayment conditions as well as any
other conditions in relation thereto.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
Administration - Supervision
Art. 9. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be
shareholders. The directors will be appointed by the general meeting of shareholders for a maximum period of one year
and they may be removed at any time by the general meeting of shareholders.
Where the Company has been incorporated by a single shareholder or where it appears at a general meeting of
shareholders that all the shares issued by the company are held by a sole shareholder, the company may be managed by
a sole director until the next general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In
such case, a reference to the “board of directors” used in these articles of association is to be construed as a reference
to the “sole director”.
Any leaving director is eligible for reappointment.
The board of directors will choose from among its members a chairman, and may choose one or several vice-chairmen
of the board of directors. The first chairman may be chosen by the general meeting of shareholders. In the absence of
the chairman the meetings of the board of directors will be chaired by a director present at the meeting and appointed
to that end.
In the event of a vacancy on the board of directors for any reason whatsoever, the remaining directors have the right
to provisionally fill the vacancy until the next general meeting; in this case, such next general meeting will definitively fill
such vacancy.
Art. 10. The board of directors shall meet upon call by the chairman or any two directors.
182432
L
U X E M B O U R G
The directors will be convened separately to each meeting of the board of directors. Except in an emergency which
shall be specified in the convening notice, the convening notice shall be notified at least twenty-four hours before the
date fixed for the meeting.
The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented, as well as in all
the cases where the date of the meeting has been determined beforehand in a meeting. The meetings of the board of
directors are held at the place and at the date specified in the convening notice.
The board of directors can validly deliberate and take decisions only if a majority of its members is present or validly
represented.
Directors unable to be present may delegate in writing another member of the board to represent them and to vote
in their name. A director may represent several of his colleagues.
Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. Where the number of votes cast for and
against a resolution is equal, the chairman has a casting vote.
Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened
and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letter, telegram or telex.
Any director having interests opposite to those of the company in a matter submitted to the approval of the board
will be obliged to inform the board thereof and his declaration will be recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board. At the next general meeting of shareholders, before votes are
taken on any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which a director has a personal interest
contrary to that of the company.
In the event of a member of the board of directors having to abstain due to a conflict of interest, the resolutions taken
by a majority of the other members of the board present or represented at the meeting and voting will be considered
valid.
Art. 11. The resolutions of the board of directors will be recorded in the minutes, to be filed in a special folder and
signed by at least one director.
Copies or extracts of such minutes must be signed by a director.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration
in the interest of the company.
All powers not expressly reserved by the law of 10 August 1915, as amended, or by these articles of association to
the general meeting of Article shareholders will fall within the competence of the board of directors.
Art. 13. The board of directors may delegate powers to one or several of its members. It may appoint proxies with
specific powers, and revoke such appointments at any time. It may also, with the prior approval of the general meeting
of shareholders, entrust day-to-day management of the company's business to one or several of its members, being in
such case called managing directors.
Art. 14. The board of directors may establish an executive committee made up of members of the board of directors
and set the number of its members. The executive committee may have such powers and authority to act on behalf of
the board of directors as determined by the board of directors in a prior resolution. Unless otherwise provided for by
the board of directors the executive committee will determine its own procedure for convening and holding its meetings.
The board of directors will fix, as the case may be, the remuneration of the members of the executive committee.
Art. 15. The board of directors will represent the company in court as plaintiff or as defendant. All writs or judicial
acts for or against the company are validly issued in the name of the company alone.
Art. 16. All documents and mandates will validly bind the company if they are jointly signed in the name of the company
by at least two directors, unless special delegations are provided for.
Art. 17. The audit of the company's affairs will be entrusted to one or more internal auditors (commissaires) or, in
the cases provided for by law, by one or several independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés), to be appointed
by the general meeting of shareholders which will determine their number, remuneration and term of their mandate
which cannot exceed one (1) year, and is at any time revocable by it. Such auditors may be removed at any time by the
general meeting of shareholders. Leaving internal auditors and independent auditor's (réviseur d'entreprises agréé) are
eligible for re-election.
General meetings of shareholders
Art. 18. The annual general meeting of shareholders may by simple resolution allocate to the directors an appropriate
remuneration for the performance of their mandate.
Art. 19. Any regularly constituted general meeting of shareholders will represent the entire body of shareholders. Its
decisions are binding on shareholders who are absent, opposed or abstain from voting.
182433
L
U X E M B O U R G
Art. 20. The board of directors may require that in order to be admitted at general meetings, any owner of shares
shall deposit his bearer shares in accordance with the applicable legal provisions.
Art. 21. The annual general meeting of shareholders will be held on the first Thursday of the month of March of each
year at 12:00 (noon).
If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day at the same
time.
Extraordinary general meetings of shareholders will be convened and held at the place determined by the board of
directors.
Art. 22. The general meeting of shareholders will hear the report of the board of directors and of the internal auditor
or independent auditor (réviseur d'entreprises agréé), will vote on the approval of the annual accounts and on the
distribution of the profit, proceed to make all appointments required by these articles of association, grant discharge to
the directors and, as the case may be, the internal auditor and take such further action on other matters that may properly
come before it.
Each share entitles the holder to one vote.
Each shareholder is entitled to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each shareholder is entitled to request a vote by secret ballot.
Art. 23. The general meeting of shareholders deliberating at a meeting with a quorum and with a majority as prescribed
by law may amend the articles of association in every respect except to the extent that the law imposes a limitation.
Art. 24. The board of directors, respectively the internal auditor, will be responsible for convening ordinary and
extraordinary general meetings of shareholders.
They will be obliged to convene a general meeting of shareholders whenever a group of shareholders representing at
least one fifth of the subscribed capital makes a request in writing indicating the agenda.
Notices convening general meetings of shareholders must contain the agenda for such meetings.
The board of directors may determine the form of proxies to be used and require them to be deposited at a time and
place which it shall determine.
Art. 25. The general meeting of shareholders is chaired by the chairman of the board of directors or, in his absence,
by the director who replaces him or by a person designated by the general meeting of shareholders.
The meeting will select from among the attendants the secretary and one or two scrutineers.
Art. 26. The minutes of the general meetings of shareholders will be signed by the members of the board (bureau)
and by any shareholder who wishes to do so.
However, in cases where decisions of the general meeting of shareholders have to be certified, copies or extracts for
use in court or elsewhere must be signed by a director.
Financial year - Balance sheet - Allocation of profits
Art. 27. The company's financial year starts on 1 January and ends on a 31 December of every year.
Art. 28. Each year, at the closing of financial year, the board of directors will draw up the annual accounts in the form
contemplated by law.
At the latest one month prior to the annual general meeting of shareholders, the board of directors will submit the
company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required
by law to the internal auditor or independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) who will thereupon draw up his
report.
A fortnight before the annual general meeting of shareholders the balance sheet and profit and loss statement, the
management report, the internal auditor's or independent auditor (réviseur d'entreprises agréé)'s report and such other
documents as may be required by law will be deposited at the registered office of the company where they will be available
for inspection by the shareholders during regular business hours.
Art. 29. The credit balance on the profit and loss statement, after deduction of the general expenses, social charges,
write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the board of directors, shall represent the
net profit of the company.
Every year, five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction ceases
to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the subscribed share capital.
The remaining balance of the net profit will be at the disposal of the general meeting of shareholders.
Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the board of directors within the limits of
the decision of the general meeting of shareholders.
The payment of interim dividends may be authorised by the board of directors, subject to respecting the relevant legal
requirements.
182434
L
U X E M B O U R G
The general meeting of shareholders may decide to allocate profits and distributable reserves to the reimbursement
of the capital without reducing the corporate capital.
Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the relevant legal requirements as well as the provisions of these articles of association.
Winding up - Liquidation
Art. 30. It may be wound up by a decision of the general meeting of shareholders adopted at the same majority as
provided for amendments to the articles of association.
Art. 31. In the event of the winding up of the company the general meeting of shareholders will determine the method
of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.
An amount necessary to repay the paid up portion of each share will be deducted from net assets after settlement of
liabilities on liquidation; any surplus will be distributed equally between all shareholders.
General provision
Art. 31. As regards any matters which are not specified in these articles of association, the parties refer and submit to
the provisions of the Luxembourg law of 10 August 1915 as amended from time to time.”
<i>Eleventh resolutioni>
The general meeting acknowledges the resignation of all current directors of the Company, acknowledges that the
Company has currently only one shareholder, and appoints the following person as new director for a period ending on
the date of the general meeting of shareholders deciding upon the annual accounts for the financial year 2014:
- Mr. Conrad Carl Feßler, born in Böblingen (Germany) on 29 April 1971, professionally residing at 6, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg.
<i>Twelfth resolutioni>
The general meeting resolves to revoke and replace Ernst & Young by KPMG Luxembourg S.à r.l., registered office at
9 allée Scheffer in Luxemburg and registered with the Luxembourg Trade and Companies‘ Register under number B
149.133 as auditor of the Company for a period ending on the date of the general meeting of shareholders deciding upon
the annual accounts for the financial year 2014.
There being no further business, the meeting was closed at 8.00. p.m..
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in French followed by a English translation. On the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the French and the English text, the French version shall prevail.
The document having been read to the appearing parties known to the notary by name, first name and residence, the
said appearing parties signed together with the notary the present deed.
Signé: A. OLLIGES, A. RYMALOVA, E. MEDAGLI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1
er
décembre 2014. Relation: EAC/2014/16348. Reçu soixante-quinze Euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2014192834/789.
(140214415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.
SMSC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 240.875,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 150.648.
In the year two thousand and fourteen, on the twentieth day of October,
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Microchip Technology Ireland Limited, an Irish company, having its registered office at 1 Stokes Place, Dublin 2, Ireland,
registered with the Irish trade and companies register under number 381811 (the “Sole Shareholder”),
Here represented by Mr. Régis Galiotto, notary’s clerk, residing professionally in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal, dated 7 October, 2014;
182435
L
U X E M B O U R G
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I. The appearing party is the sole shareholder of SMSC Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée), having its registered office at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 150.648, incorporated
by a notarial deed of 8 January 2010, enacted by Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of
Luxembourg) published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 332 dated 15 February 2010
(the “Company”).
The articles of association of the Company have been lastly amended by a notarial deed enacted by Maître Francis
Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg) on 5 May 2011, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 2382 dated 5 October 2011.
II. That the 240,875 (two hundred forty thousand eight hundred seventy five) shares with a nominal value of USD 1.-
(one United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the
meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly
informed beforehand.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Amendment of the financial year of the Company;
2. Subsequent amendment of article 17 and of the first paragraph of article 18 of the articles of association of the
Company in order to reflect such action; and
3. Any other business.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to change the financial year of the Company, currently from 1
st
March to the last
day of February, to bring it from 1
st
April to 31
st
March.
Consequently, the following financial year beginning on 1
st
March 2014 ended on 31
st
March 2014 and the current
one began on 1
st
April 2014 and will end on 31
st
March 2015.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder RESOLVES to amend article 17 and the first
paragraph of article 18 of the articles of incorporation to read as follows:
“ Art. 17. The Company’s financial year begins on 1
st
April and closes on 31
st
March.
Art. 18. Each year, as of 31
st
March, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up
the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.”
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is
closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the appearing person, known to the notary
by his surname, Christian name, civil status and residence, the said appearing person signed together with Us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
En l’an deux mille quatorze, le vingt octobre,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
182436
L
U X E M B O U R G
Microchip Technology Ireland Limited, une société irlandaise, ayant son siège social au 1 Stokes Place, Dublin 2, Irlande,
enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés irlandais sous le numéro 381811 (l’«Associé Unique»),
dûment représenté par Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 101, rue Cents,
L-1319 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 7 octobre
2014;
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte du comparant et
par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l’associé unique de SMSC Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée
selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.648, constituée
par acte notarié du 8 janvier 2010, reçu par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-
Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 332 en date du 15 février
2010 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié reçu par devant Maître Francis
Kesseler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) le 5 mai 2011, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2382 en date du 5 octobre 2011.
II. Les 240.875 (deux cent quarante mille huit cent soixante-quinze) parts sociales de la Société ayant une valeur
nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont repré-
sentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour sur lesquels
l’Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l’exercice social de la Société;
2. Modification subséquente de l’article 17 et du premier paragraphe de l’article 18 des statuts de la Société afin de
refléter cette action; et
3. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE de modifier l’exercice social de la Société, actuellement du 1
er
mars au dernier jour du
mois de février, pour le porter du 1
er
avril au 31 mars.
Par conséquent, l’exercice social ayant commencé le 1
er
mars 2014 s’est terminé le 31 mars 2014, si bien que l’exercice
en cours a commencé le 1
er
avril 2014 et se terminera le 31 mars 2015.»
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Associé Unique DECIDE de modifier l’article 17 et le premier para-
graphe de l’article 18 des statuts comme suit:
« Art. 17. L’exercice social de la Société commence le 1
er
avril et se termine le 31 mars.
Art. 18. Chaque année, au 31 mars, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui contiendra
l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements,
ainsi que les dettes du(des) gérant(s), du(des) commissaire(s) (s’il en existe) et du(des) associé(s) envers la Société.»
<i>Estimation des fraisi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à mille quatre cents Euros (1.400.- Euros).
Plus rien n'étant à l’ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n’ayant lieu, la séance est levée.
Dont Acte,
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu et traduit en un langage connu du comparant, connu du notaire par son prénom, nom, état
civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
182437
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49801. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 19 novembre 2014.
Référence de publication: 2014183818/123.
(140206226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Alpinist S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 53.863.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der Alpinist S.A., welche am <i>18. Dezember 2014i> um 16.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfol-
genden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012 und per 31.12.2013
3. Beschlussfassung über die Jahresergebnisse
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014188020/17.
ARA Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 167.193.
Sie werden hiermit zu einer
AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionäre von ARA Shipping S.A., welche am <i>18. Dezember 2014i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der
nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung.i>
1. Verlesung der Jahresberichte zum 31. Dezember 2013 des Verwaltungsrates sowie des Aufsichtskommissars;
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2013;
3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis;
4. Entlastung für die Verwaltungsratsmitglieder und den Aufsichtskommissar;
5. Verschiedenes.
<i>Der Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2014188697/17.
LBE, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 22.001.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 17 novembre 2014i>
Est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, administrateur démissionnaire:
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Monsieur Reno Maurizio TONELLI terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire qui viendra à échéance
lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.
Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.
Est nommé Président du conseil d'administration:
Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
182438
L
U X E M B O U R G
La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission
ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Référence de publication: 2014183573/22.
(140206476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Apulia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 148.212.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionäre von Apulia S.A., welche am <i>18. Dezember 2014i> um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden
Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014188698/17.
W.P.S.-Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.
R.C.S. Luxembourg B 55.323.
L'an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois de novembre;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1) Monsieur Dieter WISSMECK, ingénieur diplômé, né à Eisenach (République Fédérale d'Allemagne), le 1
er
janvier
1946, demeurant à D-66663 Merzig, 31, Wendelinusstrasse (République Fédérale d'Allemagne); et
2) Monsieur Eberhard PÜTZ, économiste, né à Freudenburg (République Fédérale d'Allemagne), le 10 novembre 1966,
demeurant à D-66663 Mettlach-Orscholz, 3, Beethoven Weg (République Fédérale d'Allemagne).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée “W.P.S.-Luxembourg S.àr.l.”, établie et ayant son siège social à L-2667 Lu-
xembourg, 35-37, rue Verte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
55323, (la “Société”), a été originairement constituée sous la dénomination sociale de “NICKEL ENTREPRISE S.à r.l.”,
suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie
(Grand-Duché de Luxembourg), en date du 18 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 468 du 20 septembre 1996,
et que les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à
Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 9 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 67 du 11 janvier 2006, contenant notamment l’adoption par la Société de sa dénomination sociale
actuelle;
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de la Société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire (l’“Assemblée”) et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent cinquante mille euros (450.000,- EUR)
afin de le porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) à neuf cent cinquante mille euros
(950.000,- EUR), par la création et l’émission de quatre mille cinq cents (4.500) parts sociales nouvelles d’une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
182439
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et libérationi>
L'Assemblée constate que les quatre mille cinq cents (4.500) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites
par:
- Monsieur Dieter WISSMECK, pré-qualifié, à concurrence de deux mille cinq cents (2.500) parts sociales, et
- Monsieur Eberhard PÜTZ, pré-qualifié, à concurrence de deux mille (2.000) parts sociales,
et libérées entièrement par les souscripteurs prédits moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme
de quatre cent cinquante mille euros (450.000,-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter l’augmentation de capital qui précède, l’Assemblée décide de modifier l’article 6 des Statuts et de lui
donner dorénavant la teneur suivante:
“ Art. 6. Le capital social est fixé à neuf cent cinquante mille euros (950.000,-EUR), représenté par neuf mille cinq cents
(9.500) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.”
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de deux mille euros et les
associés s'y engagent personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. WISSMECK, E. PÜTZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 novembre 2014. LAC/2014/52702. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 19 novembre 2014.
Référence de publication: 2014179544/59.
(140205901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2014.
PICTO-Communication Partner Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, 32, Zone d'Activités Zare.
R.C.S. Luxembourg B 174.046.
L'an deux mille quatorze, le trente octobre.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
- Monsieur Frédéric LIEGEOIS, indépendant, demeurant à F-54620 Ville-au-Montois (France), 4, Grand-Rue,
- Madame Sara BEGGIATO épouse LIEGEOIS, employée, demeurant à F-54620 Ville-au-Montois (France), 4, Grand-
Rue,
Les comparants sont les seuls associés de la société "PICTO-Communication Partner SARL", établie et ayant son siège
à L-4660 Differdange, 24, rue Michel Rodange, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 6 décembre
2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 415 du 20 février 2013, inscrite au registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.046.
Les comparants prennent, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les comparants décident de transférer le siège social de la commune de Differdange à la commune de Sanem et par
conséquent de modifier l’article 2 des statuts comme suit:
" Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Sanem."
<i>Deuxième résolutioni>
Les comparants fixent l’adresse à L-4384 Ehlerange, 32, Zone d'Activité Z.A.R.E.
Finalement, plus rien n'étant à l’ordre du jour la séance est levée.
182440
L
U X E M B O U R G
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: LIEGEOIS, BEGGIATO, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 octobre 2014. Relation: LAC / 2014 / 51110. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 19 novembre 2014.
Référence de publication: 2014179400/34.
(140205460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2014.
FLE Property 7, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 162.916.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 12 novembre 2014.i>
Le siège social a été transféré au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 novembre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FLE Property 7
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2014183438/13.
(140206106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
FLE Holdco II, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 157.669.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 12 novembre 2014.i>
Le siège social a été transféré au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 novembre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FLE Holdco II
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2014183430/13.
(140206413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
GS Tele VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 141.758.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014183479/13.
(140206834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
182441
L
U X E M B O U R G
Lavanda South S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 167.541.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014183594/9.
(140206612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Optique Milbert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5532 Remich, 3, rue Enz.
R.C.S. Luxembourg B 115.892.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Optique Milbert S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2014184402/12.
(140207491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Mobility Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 119.718.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 5 novembre 2014i>
L'Assemblée prend acte de et accepte la démission de Mademoiselle Céline JULIEN de son poste d'administrateur et
décide de nommer en remplacement Monsieur Eddy WIRTZ, employé privé, avec adresse professionnelle au 10A, rue
Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg. Le mandat du nouvel administrateur ainsi nommé viendra à échéance lors de
l'Assemblée Générale à tenir en 2018.
L'Assemblée prend acte de et accepte la démission de Madame Catherine CALVI de son poste d'administrateur et
décide de nommer en remplacement Madame Ludivine ROCKENS, employée privée, avec adresse professionnelle au
10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg. Le mandat du nouvel administrateur ainsi nommé viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014184370/17.
(140207137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Metec S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 21.173.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014184362/9.
(140207429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Orkid S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 167.777.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
182442
L
U X E M B O U R G
Extrait sincère et conforme
ORKID S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2014184415/12.
(140207253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Platine SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 35, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 141.264.
Par la présente, nous vous informons que la société PYXIS S.A., R.C. Luxembourg B 75.177, démissionne avec effet
immédiat de ses fonctions de Commissaire aux comptes dans votre société.
Luxembourg, le 21 Novembre 2014.
Corinne CHANTEREAU
<i>Administrateur-Déléguéei>
Référence de publication: 2014184449/12.
(140207552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.
HF Main Insight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 157.830,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 187.885.
L'adresse du gérant de classe A, Mark Lessing, a changé et est désormais au 1114, Avenue of America, 36
th
Floor,
10036 New York, Etats-Unis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Référence de publication: 2014184231/12.
(140207312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Functional Devices S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 164.598.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2014.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2014184171/11.
(140207592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Tivana Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 187.123.
Changement suivant le contrat de cession de parts du 31 octobre 2014:
- Ancienne situation associée:
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales
- Nouvelle situation associée:
Parts
sociales
Tivana Topco S.A., Société Anonyme, ayant son siège au 6, rue Eugène Ruppert ,
L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B191489 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
182443
L
U X E M B O U R G
<i>Extrait des résolutions prises par les associées en date du 31 octobre 2014i>
1. Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., a démissionné de son mandat de gérante avec effet au 31 octobre
2014.
2. Monsieur Brian Baker, administrateur de sociétés, né à Grande Prairie (Canada) le 3 avril 1970, demeurant profes-
sionnellement à Londres EC2M 3XD, Royaume-Uni, 99 Bishopsgate, a été nommé comme gérant pour une durée
indéterminée avec effet au 31 octobre 2014.
3. Monsieur Paul Sim, administrateur de sociétés, né à Adelaide, (Australia) le 7 avril 1974, demeurant professionnel-
lement à Londres EC2M 3XD, Royaune-Uni, 99 Bishopsgate, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée
avec effet au 31 octobre 2014.
4. Monsieur Jean Daigneault, administrateur de sociétés, né à Sherbrooke, (Canada) le 12 mars 1964, demeurant
professionnellement à Montreal, Quebec, Canada H3B 4W8, Suite 900, 1250 René Levesque Boulevard West, a été
nommé comme gérant pour une durée indéterminée avec effet au 31 octobre 2014.
5. Monsieur Jean-Paul Gennari, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette, (Luxembourg) le 25 janvier 1958,
demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Petrusse, a été nommé comme gérant pour
une durée indéterminée avec effet au 31 octobre 2014.
6. Monsieur Arjan Reinders, administrateur de sociétés, né à Leiderdorp, (Pays-Bas) le 4 mai 1975, demeurant pro-
fessionnellement à Amsterdam, 1082MS Pays-Bas, Gustav Mahlerplein 3, a été nommé comme gérant pour une durée
indéterminée avec effet au 31 octobre 2014.
7. Monsieur Andrew O'Shea, administrateur de sociétés, né à Dublin (Irlande) le 13 août 1981, demeurant profes-
sionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée
avec effet au 31 octobre 2014.
8. Monsieur Francesco Abbruzzese, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Luxembourg) le 7 juin 1971, de-
meurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant pour une durée
indéterminée avec effet au 31 octobre 2014.
9. Monsieur Douwe Terpstra, administrateur de sociétés, né à Leeuwarden (Pays-Bas) le 13 octobre 1958, demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant pour une durée indé-
terminée avec effet au 31 octobre 2014.
Luxembourg, le 20 Novembre 2014.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Tivana Midco S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014183862/48.
(140206855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Pleximus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 107.993.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un géranti>
Référence de publication: 2014184450/11.
(140207705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Salon de Coiffure Angelsberg S. à. r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6791 Grevenmacher, 14, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 35.882.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
182444
L
U X E M B O U R G
<i>Pour Salon de Coiffure Angelsberg S. à. r. l.
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2014184481/12.
(140207673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Action Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 186.967.
In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of November,
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
are taken resolutions of the sole shareholder of Action Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 46a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (R.C.S. Luxembourg) under the number B 186.967
(the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Marc Loesch dated 6 May 2014,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n° 1844 dated 15 July 2014. The articles of asso-
ciation of the Company (the Articles) have never been amended.
There appears:
Action Holding B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap) incorporated and existing under the
laws of the Netherlands, having its registered office at Perenmarkt 15, 1681 PG Zwaagdijk-Oost, the Netherlands, and
being registered with the Trade Register of the Netherlands under the number 36033397 (the Sole Shareholder),
represented by Mr Pol Theisen, lawyer, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on November 5, 2014.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following:
I. the Sole Shareholder holds 12,500 ordinary shares in the Company, having a nominal value of EUR 1 each, repre-
senting the entire subscribed share capital of the Company.
II. the Sole Shareholder has been called in order to resolve on the items contained in the following agenda:
(1) Waiver of the convening notices;
(2) Change of the signatory power system of the Company from its current sole signature system to a double signature
system;
(3) Subsequent amendment of article 12, paragraph 6, of the articles of association of the Company; and
(4) Miscellaneous.
III. the Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder
waives to the extent applicable any convening notice, considering itself as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda of the Meeting which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the signatory system of the Company from its current sole signature system
to a double signature system, so that from now on the Company shall be bound towards third parties by the signature
of the sole manager of the Company and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of
the board of managers of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 12, paragraph 6, of the Articles in order to reflect the changes approved
in the second resolution above so that it shall from now on read as follows:
“The Company shall be bound by the sole signature of its sole Manager, and, in case of plurality of Managers, by the
joint signature of any two members of the Board.”
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is approximately one thousand Euros (EUR 1,000).
182445
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the Sole Shareholder,
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the Sole Shareholder, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the year and day first
above written.
The document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, the said proxyholder signed together
with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois de novembre,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
sont pris des résolutions de l’associé unique de Action Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée con-
stituée et existante sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46a, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 12.500 EUR et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.967 (la Société). La Société a été constituée
par un acte du notaire instrumentaire du 6 mai 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n°
1844 du 15 juillet 2014. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas encore été modifiés.
A comparu:
Action Holding B.V., une société privée à responsabilité limitée (besloten vennootschap) constituée et existante sous
le droit du Pays-Bas, ayant son siège social au Perenmarkt 15, 1681 PG Zwaagdijk-Oost, Pays-Bas, et immatriculée auprès
du Registre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 36033397 (l’Associé Unique),
représentée par Monsieur Pol Theisen, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 5 novembre 2014.
Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, demande au notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. l’Associé Unique détient 12.500 parts sociales ordinaires de la Société, ayant une valeur nominale de 1 EUR chacune,
représentant la totalité du capital social souscrit de la Société;
II. l’Associé Unique a été convoqué pour résoudre aux points de l’ordre du jour suivant:
(1) Renonciation aux formalités de convocation;
(2) Modification du régime de signature statutaire de son régime de signature unique à un régime de signature conjointe;
(3) Modification de l’article 12, paragraphe 6, des statuts de la Société; et
(4) Divers.
III. l’Associé Unique prend les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Associé Unique renonce dans la mesure
applicable aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite con-
naissance de l’ordre du jour de l’Assemblée qui lui a été préalablement communiqué.
<i>Seconde résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier le régime de signature statutaire de son régime actuel de signature unique à un
régime de signature conjointe, afin que la Société soit dorénavant engagée envers des tiers par la signature unique du
gérant unique de la Société et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes de deux gérants de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l’article 12, paragraphe 6, des Statuts pour refléter les changements approuvés
dans la deuxième résolution ci-dessus, comme suit:
«La Société sera engagée par la seule signature du Gérant Unique et, en cas de pluralité de Gérants, par les signatures
conjointes de deux Gérants.»
<i>Estimation des coûtsi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille euros (EUR 1.000).
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l’a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
182446
L
U X E M B O U R G
Dont acte, fait et passé, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire de la partie comparante a signé ensemble
avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Theisen, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 12 novembre 2014. REM/2014/2465. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 19 novembre 2014.
Référence de publication: 2014178983/112.
(140205897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2014.
FLE Property 6, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 159.909.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 12 novembre 2014.i>
Le siège social a été transféré au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 novembre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FLE Property 6
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2014183437/13.
(140206101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Unden S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 87.601.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014185261/10.
(140208262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Ticketmaster Luxembourg Holdco 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 37.123.661,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 142.609.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Référence de publication: 2014185233/10.
(140208814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Sirius Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 179, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 152.989.
Le bilan et annexes au 31 août 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014183781/9.
(140206675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
182447
L
U X E M B O U R G
Ambos Group, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 112.675.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014185352/10.
(140209176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Hersteller-Vertretungen-Betriebs GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6492 Echternach, 2, rue Thoull.
R.C.S. Luxembourg B 32.358.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25/11/2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014185603/12.
(140209192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Immolor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9051 Ettelbruck, 75, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 137.326.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014185627/10.
(140208992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Inventage Belux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 113.764.
Les comptes annuels au 30/06/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Louis-Philippe Pirard.
Référence de publication: 2014185631/10.
(140209271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Dogwalker.lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 158.942.
Les comptes annuels pour la période allant du 01/01/2013 au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014185498/10.
(140209434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
182448
1. Sicav
Action Luxembourg S.à r.l.
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014
Alpinist S.A.
Altralux S.A.
Ambos Group
Anthea - Contemporary Art Investment Fund S.C.A., SICAV-FIS
Apulia S.A.
Aquatrans RhineShipping S.A.
ARA Shipping S.A.
ATL Aquatrans Logistics S.A.
Bears U.S. Corporate Bonds Fund
Chartreuse et Mont Blanc Global Holdings S.A.
Chartreuse et Mont Blanc Holdings S.à r.l.
Club 1
Compagnie Européenne pour le Développement d'Entreprises Commerciales S.A.
Conteam S.à r.l.
Digital Services XXIII 2 S.C.Sp
Dogwalker.lu S.à r.l.
European Value Partners
FLE Holdco II
FLE Property 6
FLE Property 7
Freo Germany II Partners (SCA) SICAR
Functional Devices S.A.
GS Tele VI S.à r.l.
HAIG premium Fund FIS
Hersteller-Vertretungen-Betriebs GmbH
HF Main Insight S.à r.l.
HVB Opti Select Balance
ICE Promotion S.A.
Immolor S.à r.l.
Inventage Belux S.à r.l.
Jetlag27 S.A.
JPMorgan Funds
KBL European Private Bankers S.A.
Laranaga Holding S.A.
Lavanda South S.A.
LBE
Metec S.A.
Mobility Invest
Nerthus Invest S.A.
Optique Milbert S.à r.l.
Orkid S.à r.l.
Ortano Mare Development S.A.
PICTO-Communication Partner Sàrl
Pirelli Finance (Luxembourg) S.A.
Platine SA
Pleximus S.à r.l.
Praine Management S.A.
Rigo Trading S.A.
Salon de Coiffure Angelsberg S. à. r. l.
Satisfactory
Securitas2007
Silk
Sirius Holding S.à r.l.
SMSC Holdings S.à r.l.
Sofair International S.A.
South One Fund
Ticketmaster Luxembourg Holdco 5, S.à r.l.
Tivana Midco S.à r.l.
Unden S.A.
VMP EuroBlue Systematic
W.P.S.-Luxembourg S.àr.l.