logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3647

1

er

 décembre 2014

SOMMAIRE

Art d'Eau Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175018

ASA Corporation s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

175018

Awadent Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175018

B & B Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

175018

BCF I Global S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175019

Benat Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175026

BE Sophia Lux I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175019

BE Sophia Lux II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175019

Brimag A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175010

Browne Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

175033

Calilux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175010

Climate Change Investment I S.A. SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175010

Digihold S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175021

DSM Capital Partners Funds  . . . . . . . . . . . .

175020

Fiduciaire Générale de Marnach S.à r.l.  . .

175011

First Street A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175042

Funckenhaus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175012

Green European Venture Capital S.A.  . . .

175010

Grove Second Unitholder S.à r.l.  . . . . . . . .

175012

Gyrfalcon Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

175010

Halcyon European Holdings S.à r.l.  . . . . . .

175011

Heraldic LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175011

Knight Estate Management S.A.  . . . . . . . . .

175012

La Couronne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175013

Lady Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175014

Langevin Siding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175015

L'Arancino S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175013

Liberty Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

175013

Librairie Diderich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175014

LSP International Holdings S.à r.l.  . . . . . . .

175014

Lubami Private S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . .

175014

Luciano Barbera Holdings S.à r.l.  . . . . . . . .

175013

Luxembourg Cargo Agency (LCA)  . . . . . .

175015

Luxflower SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175015

Magnetar Intermediate Solar Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175051

Malibu Holdings (Luxembourg) S.à r.l.  . . .

175016

Methanex Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

175016

Mezzanine Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

175015

Minimoyz S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175017

Norbert Boler G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . .

175016

Oliver Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175016

Panattoni Germany S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

175054

Phiolla S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175017

Phoenix Corporate S.A  . . . . . . . . . . . . . . . . .

175017

Placomar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175017

Socosme S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175012

Union Financière Immobilière Luxem-

bourgeoise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175011

Waldtec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175056

175009

L

U X E M B O U R G

Calilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 135.000,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 108.230.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2014172672/10.
(140197985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Brimag A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 17, op d'Schleid.

R.C.S. Luxembourg B 100.460.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172667/10.
(140197934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Climate Change Investment I S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 127.253.

Les comptes annuels au 30.06.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Thomas Goergen.

Référence de publication: 2014172691/11.
(140197999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Gyrfalcon Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 176.158.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Gyrfalcon Capital S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2014172004/11.
(140196407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Green European Venture Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 77.091.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2014 .

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2014171992/12.
(140196461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

175010

L

U X E M B O U R G

Union Financière Immobilière Luxembourgeoise, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 23.096.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014172454/9.
(140196206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Fiduciaire Générale de Marnach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 97.209.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014172820/10.
(140197887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Halcyon European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, Avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 159.785.

La Société a été constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 16 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1435 du 30 juin 2011.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Halcyon European Holdings S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014172006/14.
(140197125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Heraldic LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 173.294.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société, par résolutions écrites datées du 25 juin 2014, a décidé de transférer le siège social de

la Société au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

L'associé unique de la Société a également transféré son siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,

avec effet au 15 septembre 2014.

Les adresses professionnelles des gérants Antonis Tzanetis, Michiel Kramer, Thomas Sonnenberg et Heiko Dimmerling

ont également changé. Lesdits gérants résident dorénavant professionnellement au 2C, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg.

Le gérant Mats Eklund a également transféré son adresse professionnelle au 9 South Street, 3 

ème

 étage, Londres, W1K

2XA, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Heraldic LuxCo S.à r.l.

Référence de publication: 2014172008/20.
(140196207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

175011

L

U X E M B O U R G

Knight Estate Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 128.378.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173003/10.
(140197611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Funckenhaus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 267, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 25.095.

Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Romain URHAUSEN
<i>Le gérant

Référence de publication: 2014172849/11.
(140197312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Socosme S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 83.950.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 5 novembre 2014

Est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, administrateur démissionnaire:
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg.

Monsieur Marc ALBERTUS terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire qui viendra à échéance lors de

l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 5 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172390/16.
(140197126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Grove Second Unitholder S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.000,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 190.444.

Il résulte du transfert de parts sociales de la Société en date du 12 Septembre 2014, que 1,200,000 parts sociales

détenues dans la Société par Grove S. à r.l., ayant son adresse professionnelle au 2 rue du Fossé, 1536 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 189.930, ont été transférées comme suit:

1,200,000  parts  sociales  à  GROVE  FINCO  S.À  R.L.  ayant  son  siège  social  au  2  rue  du  Fossé,  1536  Luxembourg,

enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 190.656;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grove Second Unitholder S. à r.l.
Marielle Stijger
<i>Gérante

Référence de publication: 2014172000/17.
(140196241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

175012

L

U X E M B O U R G

L'Arancino S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 173.528.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173008/10.
(140198256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Luciano Barbera Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 190.977.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 07 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173020/10.
(140197441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Liberty Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 131.211.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 Novembre 2014.

Martinus C. J. WEIJERMANS
<i>Gérant A

Référence de publication: 2014173014/13.
(140197635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

La Couronne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 107.371.

<i>Extrait de la résolution des actionnaires de la Société prise en date du 3 septembre 2014

Il a été décidé:
- de prolonger le mandat de Monsieur Willem Siegfried Slettenhaar, résidant 36, Langestraat, NL-7491 AG Delden, en

tant qu'Administrateur A de la société et ce jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2020;

- de prolonger le mandat de Madame Petronella Johanna Sophia Dunselman, résidant 52-54 avenue du X Septembre,

L-2550 Luxembourg, en tant qu'Administrateur B de la société et ce jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année
2020;

- de prolonger le mandat de Madame Gezina Van der Kooi, résidant 36, Langestraat, NL-7491 AG Delden, en tant

qu'Administrateur A de la société et ce jusqu'à l' Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2020;

- de prolonger le mandat de CQuit B.V., résidant Twentepoort West 10-1, 7609 RD Almelo, Pays-Bas, et enregistré

sous le numéro 08184261 au Kamer van Koophandel aux Pays Bas en tant que commissaire aux comptes de la Société
et ce jusqu'à l' Assemblée Générale qui se tiendra en l' année 2020.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2014.

Référence de publication: 2014173009/21.
(140198208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

175013

L

U X E M B O U R G

Librairie Diderich, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 2, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 17.298.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2014173015/10.
(140197378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Lady Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 89.046.

EXTRAIT

Il est à noter que le siège social de la Fiduciaire Grand-Ducale S.A., commissaire aux comptes de la société, se situe

désormais au L-1510 Luxembourg, 60 avenue de la Faïencerie.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014173029/11.
(140197685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

LSP International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 159.728.

En vertu d'un contrat d'apport daté du 6 novembre 2014, l'associé unique de la Société a cédé l'intégralité du capital

social de la Société, représenté par 20.000 parts sociales d'une valeur nominale de USD 1 chacune, à Alberta Transmission
Holdings, LLC, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Delaware, dont le siège sociale est établi au 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington Delaware, USA 19808, immatriculée auprès du Secretary of State of Delaware
sous le numéro 5296495.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>LSP International Holdings, S.à r.l.
Mandataire

Référence de publication: 2014173040/16.
(140198045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Lubami Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 162.508.

Le Conseil d’administration de la société LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42 rue de

la Vallée, L - 2661 Luxembourg, a désigné en date du 30 octobre 2014, Monsieur Eric BREUILLE, 42 rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, comme représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour son compte
au conseil d’administration de la société LUBAMI PRIVATE S.A. SPF., en remplacement de Madame Roselyne MICHEL-
CANDIDO.

Luxembourg, le 30 octobre 2014.

<i>Pour LUBAMI PRIVATE S.A. SPF
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2014173045/17.
(140197749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

175014

L

U X E M B O U R G

Mezzanine Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 165.645.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014173082/9.
(140198156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Luxflower SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 64, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.798.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014173027/11.
(140197620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Langevin Siding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 310.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 148.950.

Par résolutions signées en date du 20 octobre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Nathalie Dessoy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg, au

mandat de gérant classe A, avec effet au 31 juillet 2014 et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Michael Anatolitis, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882

Luxembourg de son mandat de gérant classe A, avec effet au 31 juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2014.

Référence de publication: 2014173012/15.
(140197873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Luxembourg Cargo Agency (LCA), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1360 Luxembourg, Cargo Center Luxair.

R.C.S. Luxembourg B 100.667.

<i>Constatation de cession de parts sociales

Suite aux cessions de parts sociales faisant partie d'un apport dans la société «GLOBAL LOGISTIC SOLUTIONS

LUXEMBOURG S.A.» acté lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 octobre 2014 pardevant Maître
Martine Schaeffer, signées par les cédants et le cessionnaire et acceptées par la gérante au nom de la société, il en résulte
que le capital social de la société «LCA LUXEMBOURG II S.à r.l.» est désormais réparti comme suit:

«GLOBAL LOGISTIC SOLUTIONS LUXEMBOURG S.A.», avec siège social à L-9061 Ettelbruck,
26, Rue Michel Rodange et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le n° B 136 653. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Luxembourg-Aéroport, le 31 octobre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>L'associée unique

Référence de publication: 2014173050/19.
(140198024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

175015

L

U X E M B O U R G

Norbert Boler G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 24, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 103.947.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173113/10.
(140197933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Malibu Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 164.245.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF CORPORATE SERVICES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2014173056/12.
(140198111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Oliver Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Z.I. route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 22.053.

EXTRAIT

Suite à l'Assemblé Générale Ordinaire tenue de façon exceptionnelle au 15 Rue Robert Schumann L-4779 en date du

er

 octobre 2014, il en ressort les points suivants:

1. La démission de M. D'AVERSI René, Administrateur, demeurant professionnellement au 15, rue Robert Schuman,

L-4779 Pétange.

2. La nomination de M. CADOR Alexandre, Administrateur, demeurant professionnellement au 16, Avenue de la Gare,

L-4873 Lamadelaine, jusqu'à l'Assemblé Générale qui se tiendra en l'année 2019.

<i>Pour OLIVER HOLDINGS S.A.

Référence de publication: 2014173134/15.
(140198282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Methanex Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 200.002,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 172.158.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 6 novembre 2014 que:
(i) La démission de Monsieur Philippe SALPETIER, gérant de catégorie B de la Société, a été acceptée avec effet au 31

octobre 2014;

(ii) Monsieur Marc CHONG KAN, né à Paris, France, le 24 août 1964, résidant professionnellement au 16, avenue

Pasteur L-2310 Luxembourg a été nommé gérant de catégorie B avec effet au 31 octobre 2014 et ce pour une durée
indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173062/17.
(140197721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

175016

L

U X E M B O U R G

Minimoyz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8537 Hostert, 12, rue de Lannen.

R.C.S. Luxembourg B 176.603.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014173085/9.
(140198311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Placomar S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3225 Bettembourg, 144, Z.I. Scheleck 1.

R.C.S. Luxembourg B 160.354.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173181/10.
(140197866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Phiolla S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 177.205.

EXTRAIT

Par décision prise par le Conseil d'Administration réuni en date du 4 novembre 2014 à 10.00 au siège social:
Monsieur Philippe Vastapane, né le 15.09.1952 à Uccle (Belgique), et résidant au 5 rue Spierzelt 8063 Bertrange Lu-

xembourg est coopté administrateur en remplacement de Monsieur Jean Marc Debaty.

Son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur à savoir jusqu'à l'assemblée générale annuelle

amenée à statuer sur les comptes 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2014173179/16.
(140198199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Phoenix Corporate S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 187.467.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Phoenix Corporate S.A. tenue au siège

social de la société le 20 octobre 2014 que:

1- La société transfert son siège social au 26, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
2- Est révoqué Monsieur Nassim ZERARGUI de son poste de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
3- Est nommé au poste de commissaire aux comptes la société Louvigny Property S.A., ayant son siège au 26, Boulevard

Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Lu-
xembourg, section B, sous le numéro 112.420, pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 novembre 2014.

<i>Pour Phoenix Corporate S.A.
LPL Expert-Comptable Sàrl

Référence de publication: 2014173180/19.
(140197396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

175017

L

U X E M B O U R G

Art d'Eau Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 47, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 168.443.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014172608/10.
(140197888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Awadent Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 169.503.

Les comptes annuels au 13 octobre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 07/11/2014.

Référence de publication: 2014172615/10.
(140197845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

ASA Corporation s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 180.362.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du gérant unique tenue à la date du 02 octobre 2014 que le gérant unique a

décidé de transférer, avec effet au 02 octobre 2014, le siège social de la société du 3-7, Rue Schiller, L- 2519 Luxembourg
au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 octobre 2014.

<i>Pour le Gérant unique

Référence de publication: 2014172610/14.
(140198250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

B &amp; B Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7720 Colmar-Berg, 23, rue du Faubourg.

R.C.S. Luxembourg B 166.356.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de B &amp; B Consulting S.A.R.L. tenue le 31 octobre

<i>2014 à 11.00 heures au siège de la société

<i>1 

<i>er

<i> résolution

Est révoqué en sa qualité de gérant administratif Monsieur Guy CLEMENT, né le 19 novembre 1942 à Arlon (B) et

demeurant à L-7720 Colmar-Berg, 23 rue du Faubourg.

<i>2 

<i>ème

<i> résolution

Est désormais gérant unique Monsieur Bouziane BENHARA, employé privé, né à Thionville (France) le 14 avril 1972,

demeurant à L-7720 Colmar-Berg, 23, rue du Faubourg.

<i>3 

<i>ème

<i> résolution

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.

Colmar-Berg, le 31 octobre 2014.

Pour extrait conforme
Bouziane BENHARA

Référence de publication: 2014172617/20.
(140198235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

175018

L

U X E M B O U R G

BE Sophia Lux I, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 163.584.

EXTRAIT

Suivant contrat de transfert de parts sociales conclu en date du 31 Octobre 2014, Bensell Finance III B.V (le Cédant)

a cédé à Coöperatie Bensell Real Estate Investment III B.A. (le Cessionnaire) l'unique part sociale de classe A qu'il détenait
dans le capital social de la Société.

Il en découle que le Cédant n'est dès lors plus associé de la Société et que le Cessionnaire devient l'actionnaire unique

de la Société et détient l'intégralité du capital social à savoir les 12,500 parts sociales de classe A dans la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 6 Novembre 2014.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014172649/17.
(140198203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

BCF I Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 173.513.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

La liquidation de la Société, décidée par l'associé unique suivant acte du 24 octobre 2014 du notaire Maître Henri

Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg a été clôturée lors de la décision extraordinaire de l'associé unique de la
Société du 5 novembre 2014.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à partir de la date de

la clôture de la liquidation au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2014.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2014172647/18.
(140198307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

BE Sophia Lux II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 164.501.

EXTRAIT

Suivant contrat de transfert de parts sociales conclu en date du 5 Novembre 2014, l'actionnaire unique de la Société,

Coöperatie Bensell Real Estate Investment III B.A. (le Cédant), a cédé à BE Sophia Lux I , une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 163.584 et ayant un capital social de 12,500 euro (le Cessionnaire), l'intégralité
des parts sociales qu'il détenait dans la Société.

Il en découle que le Cédant n'est dès lors plus actionnaire de la Société et que le Cessionnaire devient l'actionnaire

unique de la Société et détient dorénavant l'intégralité du capital social à savoir les 12 500 parts sociales dans la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 Novembre 2014.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014172650/19.
(140198305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

175019

L

U X E M B O U R G

DSM Capital Partners Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1748 Senningerberg, 6, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 184.885.

In the year two thousand and fourteen, the seventeenth day of October.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of DSM Capital Partners Funds (hereafter referred

to as the "Company"), a société anonyme qualifying as a "Société d'Investissement à Capital Variable" having its registered
office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg and registered with the Luxembourg register of commerce and
companies under number B 184.885, incorporated on February 21 

st

 , 2014 pursuant to a deed of Maître Carlo WER-

SANDT, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 654
of March 13 

th

 2014. The articles of the Company have not bee amended yet.

The meeting begins with, Mrs. Marilyn Sellier, consultant, with professional address at 2, rue Albert Borschette L-1246

Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr. Marselo Patino, employee, with professional address at 2, rue

Albert Borschette L-1246 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Debra Adams, employee, with professional address at 2, rue Albert Borschette

L-1246 Luxembourg.

The Chairman states that the agenda is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to amend the first two paragraphs of article 4 of the articles of incorporation of the Company relating to

the registered office, to read as follows:

“ 4.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Lu-

xembourg.

4.2. The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Niederanven, or if and to the

extent authorised under Luxembourg law, within the Grand Duchy of Luxembourg, by a resolution of the board of
directors of the Company (the “Board of Directors”).”

2. Decision to transfer the registered office of the Company from its current location to 6, rue Lou Hemmer at L-1748

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg with effect from 20 

th

 October 2014 or any other date determined at the

meeting.

The Chairman then states that:
I. This general meeting has been duly convened by mail to the registered shareholders on October 8 

th

 2014.

The related copies of the said mail are deposited on the desk of the bureau of the meeting.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders as well as the number of

shares held by each of them are shown on an attendance list; the said list will be signed by the members of the Bureau
and shall remain annexed to the present Minutes. The proxies of the represented shareholders will also remain annexed
to the present minutes.

III. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that out of 4,476,562 shares in circulation, only 4,476,562

shares are duly represented at the present Meeting., representing 100% of the issued shares capital. The Meeting is
herewith regularly constituted in accordance with Article 67-1 (2) of the Law of 1915 and may validly deliberate on the
sole resolution on the agenda.

The Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolution:

<i>First resolution

The Meeting resolves to transfer the registered office of the Company from its current location to 6, rue Lou Hemmer

at L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg with effect from 20 

th

 October 2014 or any other date determined

at the meeting.

Votes in favour: 4,476,562
Vote(s) against: 0
Abstention(s): 0

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend the first two paragraphs of article 4 of the articles of incorporation of the Company

relating to the registered office, to read as follows:

175020

L

U X E M B O U R G

“ 4.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Lu-

xembourg.

4.2. The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Niederanven, or if and to the

extent authorised under Luxembourg law, within the Grand Duchy of Luxembourg, by a resolution of the board of
directors of the Company (the “Board of Directors”).”

Votes in favour: 4,476,562
Vote(s) against: 0
Abstention(s): 0
There being no further business before the Meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Signé: M. Sellier, M. Patino, D. Adams et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49702. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 4 novembre 2014.

Référence de publication: 2014170362/76.
(140195000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

Digihold S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 191.538.

STATUTS

L’AN DEUX MILLE QUATORZE
LE VINGT-NEUF OCTOBRE.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Cosita

DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée DIGIHOLD, ayant son

siège à 1320 Hamme-Mille (Beauvechain), rue du Chabut 27 (Belgique).

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Luc Talloen, notaire ayant résidé à Leuven (Belgique), le 22

juin 1995, publié aux Annexes du Moniteur belge du 14 juillet suivant, sous le numéro 950714-197.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître Carl

Maere, notaire associé à Leuven, le 17 juillet 2013, publié aux Annexes du Moniteur belge du 12 août suivant, sous le
numéro 20130812-126569.

La Société est immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0455.538.526 ci-après dénommée «la

Société».

L’assemblée est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Dirk ROESEMS, retraité et gérant de société,

demeurant à B-1320 Hamme-Mille (Beauvechain),

lequel Président a désigné comme secrétaire Madame Gisela KERREMANS, fonctionnaire européen, demeurant à

B-1320 Hamme-Mille (Beauvechain).

L’assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Fabio GASPERONI, employé, ayant son adresse professionnelle à Ca-

pellen.

L’assemblée ayant été constituée, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d’acter:
I- Que les associés représentés, le mandataire des associés représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent

sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire des associés
représentés ainsi que les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la
formalité de l’enregistrement. Les procurations des associés représentés, signées ne varietur, par la personne comparante
restera attachée à cet acte.

175021

L

U X E M B O U R G

II- Le président déclare que sur les trois mille trois cent quarante-huit (3.348) parts représentant l’intégralité du capital

social de la Société d’un montant total de CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000.-), la totalité des parts sociales est
représentée à la présente assemblée de sorte que l’assemblée au sujet de laquelle les associés ont été dûment informés,
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informé.
Ils confirment avoir renoncé à toute convocation officielle préalable.

III- Que par décision de l’assemblée générale des associés de la Société valablement adoptée par devant Maître Tim

CARNEWAL, notaire associé de résidence à Bruxelles (Belgique) en date du 27 octobre 2014, il a été décidé de transférer
le siège social, le principal établissement ainsi que l’administration centrale de la Société de Belgique au Grand-duché de
Luxembourg à partir du jour du présent acte sans que la Société ne soit dissoute, mais au contraire, avec complète
continuation de la personne morale. Le Président du bureau confirme que toutes les formalités requises conformément
aux lois belges donnant effet aux présentes résolutions ont été dûment accomplies.

IV- Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Approbation des comptes de la société arrêtés en date du 27 octobre 2014 par les gérants et les associés comme

étant exacts et approbation pour autant que de besoin des comptes approuvés en Belgique suivant Assemblée Générale.

2. Prise de connaissance et confirmation du transfert du siège social, principal établissement et administration centrale

de la Société de Belgique au Grand-duché de Luxembourg, à partir du jour de la présente réunion tenue à cet effet, sans
que la Société ne soit dissoute et avec continuation de la personnalité morale et juridique.

3. Fixation du capital social de la société au montant de 50.000 Euros représenté par trois mille trois cent quarante-

huit (3.348) parts sociales sans désignation de valeur nominale à attribuer comme suit:

- Monsieur Dirk ROESEMS: mille six cent soixante-quatorze (1.674) parts sociales,
- Madame Gisela KERREMANS: mille six cent soixante-quatorze (1.674) parts sociales.
4. Adoption par la Société de la forme légale d’une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant le

nom «DIGIHOLD S.à r.l.» et acceptation de la nationalité luxembourgeoise résultant du transfert du siège social, principal
établissement et administration centrale de la Société à Luxembourg.

5. Modification et complète refonte des statuts de la Société dans le but de les conformer aux lois luxembourgeoises,

en conséquence, la Société deviendra une société régie par les lois luxembourgeoises et soumise à la loi du 10 août 1915
telle qu’amendée (la Loi).

6. Prise de connaissance de la démission des gérants actuels de la Société en Belgique et décharge pleine (quitus) pour

l’exécution de leurs devoirs de la date de leur nomination comme gérant de la Société à la date de leur démission.

7. Nominations statutaires.
8. Etablissement du siège social de la Société au 89B, rue Pafebruch, L-8308 Capellen, Commune de Mamer, Grand-

duché de Luxembourg, et

9. Pouvoirs à conférer pour procéder aux formalités à réaliser tant en Belgique qu’au Grand-Duché de Luxembourg.
10. Divers.
I. Que les associés décident les résolutions suivantes, toutes à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les associés décident d’approuver les comptes de la société arrêtés au 27 octobre 2014 et approuvés par les gérants

et les associés et confirmés comme étant exacts. Ils décident d’approuver pour autant que de besoin ces comptes tels
qu’approuvés en Belgique et décident que ces comptes seront les comptes de clôture des opérations en Belgique et les
comptes d’ouverture au Grand-Duché de Luxembourg.

Une copie de ces comptes restera annexée aux présentes.

<i>Deuxième résolution

Les associés reconnaissent, et pour autant que de besoin confirment, que par une assemblée des associés qui s’est

tenue par devant Maître Tim CARNEWAL, notaire associé de résidence à Bruxelles (Belgique) en date du 27 octobre
2014, le tout en conformité avec la loi belge en la matière, le siège social, le principal établissement, l’administration
centrale et lieu de la gestion effective de la Société a été transféré de Belgique vers le Grand-duché de Luxembourg à
partir de ce jour, sans que la Société ne soit dissoute et avec continuation de la personnalité morale et juridique.

Les associés déclarent en conséquence que la société adopte la nationalité luxembourgeoise à partir d’aujourd’hui,

date du présent acte notarié.

Les associés déclarent de plus que toutes les formalités requises selon la législation belge pour donner effet à un tel

transfert ont été prises.

<i>Troisième résolution

Les associés décident que le capital social de la société est fixé au montant de cinquante mille euros (EUR 50.000)

représenté par trois mille trois cent quarante-huit (3.348) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes
attribuées aux associés de la société comme suit:

- Monsieur Dirk ROESEMS: mille six cent soixante-quatorze (1.674) parts sociales,

175022

L

U X E M B O U R G

- Madame Gisela KERREMANS: mille six cent soixante-quatorze (1.674) parts sociales,
Total: trois mille trois cent quarante-huit (3.348) parts sociales.
Il est en outre décidé que le surplus entre la valeur nette de la société et le montant versé dans le capital, sera versé

dans un compte prime d’émission.

<i>Quatrième résolution

Comme suite à l’assemblée des associés tenue en Belgique, la société a accepté la nationalité luxembourgeoise et est

depuis aujourd’hui, date du présent acte notarié, soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.

Les associés décident en outre que la Société adoptera la forme d’une société à responsabilité limitée ayant la déno-

mination de «DIGIHOLD S.à r.l.»

<i>Cinquième résolution

Comme conséquence des résolutions précédentes, les associés décident de modifier et d’effectuer une complète

refonte des statuts de la Société afin de les rendre conformes aux lois du Grand-duché de Luxembourg.

Les statuts refondus auront désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

“La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après “La
Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14 les
règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par
vente, échange ou autre, d’actifs de propriété intellectuelle, d’actifs de propriété industrielle, d’actions, d’obligations, de
reconnaissances  de  dettes,  notes  ou  autres  titres  de  quelque  forme  que  ce  soit,  et  la  propriété,  l’administration,  le
développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés
de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être convertibles

(à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-

action sur des biens mobiliers ou immobiliers et spécialement de propriété intellectuelle ou industrielle.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: «DIGIHOLD S.à r.l.»

Art. 5. Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à CINQUANTE MILLE EUROS (50.000.-EUR) représenté par trois mille trois cent

quarante-huit (3.348) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

175023

L

U X E M B O U R G

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Si les associés ont nommé plusieurs gérants, les dits gérants seront qualifiés de Gérants de Catégorie A (les «Gérants

de Catégorie A») ou de Gérants de Catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un Gérant de Catégorie A et d’un Gérant de Catégorie B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de cet agent, la durée de son mandat, ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du conseil de gérance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés

et, dans le cas où les associes ont nommé plusieurs gérants, si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de
Catégorie B sont présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions

prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des
documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax
ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.»

Il est confirmé par le Président du bureau que suite au transfert de siège de Belgique vers le Grand-Duché de Luxem-

bourg, les associés de la société restent les mêmes dans la société luxembourgeoise et le capital est détenu comme suit:

- Monsieur Dirk ROESEMS: mille six cent soixante-quatorze (1.674) parts sociales,

175024

L

U X E M B O U R G

- Madame Gisela KERREMANS: mille six cent soixante-quatorze (1.674) parts sociales,

Total: trois mille trois cent quarante-huit (3.348) parts sociales.

<i>Sixième résolution

Les associés décident de prendre connaissance de la démission, effective à la date du présent acte, des gérants actuels

de la Société en fonction avant le transfert de Belgique au Grand-duché de Luxembourg, de leurs fonctions de gérants
de la Société et de leur donner décharge pleine (quitus) pour l’exécution de leurs devoirs de la date de leur nomination
comme gérants de la Société à la date de leur démission.

Les associés décident de plus de nommer les personnes suivantes en qualité de gérants de la Société au Grand-Duché

de Luxembourg pour une durée indéterminée:

<i>Gérants de Catégorie A

- Monsieur Dirk ROESEMS, retraité et gérant de société, né à Louvain le 10 mars 1954, demeurant à B-1320 Hamme-

Mille (Beauvechain), rue du Chabut 27 (Belgique), numéro national 54.03.10-315.55;

- Madame Gisela KERREMANS, fonctionnaire européen, née à Eupen le 14 février 1955, demeurant à B-1320 Hamme-

Mille (Beauvechain), rue du Chabut 27 (Belgique), numéro national 55.02.14-214.50.

<i>Gérant de Catégorie B

Monsieur Thierry STAS, né le 20 juin 1969 à Bruxelles, demeurant professionnellement à 89B, rue Pafebruch, L-8308

Capellen, Commune de Mamer.

<i>Septième résolution

Les associés décident d’établir le siège social de la Société au 89B, rue Pafebruch, L-8308 Capellen, Commune de

Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).

<i>Huitième résolution

Les associés décident de donner pouvoirs à:

- «Accounting &amp; Tax Partners bvba», une société ayant son siège social à Industrieweg 4 bus 5, B-3001 Louvain inscrite

au registre des personnes morales sous le numéro BE0475026024 aux fins de procéder à toutes les formalités utiles et
nécessaires en Belgique pour réaliser le présent transfert de siège social, principal établissement, administration centrale
et lieu de la gestion effective de la Société de Belgique vers le Grand-Duché de Luxembourg,

- MAPRIMA Luxembourg S.A., une société anonyme ayant son siège social au 89B, rue Pafebruch, L-8308 Capellen,

Commune de Mamer, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 166.933, aux fins de procéder
à toutes les formalités utiles et nécessaires au Grand-Duché de Luxembourg pour réaliser le présent transfert de siège
social, principal établissement, administration centrale et lieu de la gestion effective de la Société de Belgique vers le
Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Estimation des coûts

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s’élèvent approximativement à EUR 4.600.

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est clôturée à heures.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite aux mandataires des parties comparantes, aux membres du bureau, tous connus

du notaire par nom, prénoms état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: D. ROESEMS, G. KERREMANS, F. GASPERONI, L. GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 octobre 2014. Relation: LAC/2014/50658. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé) I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 novembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014171874/241.

(140196940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

175025

L

U X E M B O U R G

Benat Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 191.559.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twenty-fourth day of the month of October;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg

“ALYA FINANCE S.à r.l.”, established and having its registered office in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen,
registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under the number 107689,

here represented by Mrs. Irina FERREIRA, private employee, residing professionally in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue

Edward Steichen, (the “Proxyholder”), by virtue of a proxy given under private seal on October 22, 2014 in Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg); such proxy, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating
notary officiating, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has requested the officiating notary to document the deed of incor-

poration of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which it deems to incorporate herewith
and the articles of association of which are established as follows:

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10 

th

 , 1915, on commercial companies,

as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of incorporation (hereafter the “Articles”), which specify in
the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate name. The Company will have the name “Benat Services S.à r.l.” (hereafter the “Company”).

Art. 3. Corporate objects.
3.1 The purpose of the Company is to provide directly or indirectly, in its own name or for the account of a third

party, concierge services in France.

3.2 Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and

stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

3.3 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are

directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.

3.4 The Company can generally undertake all industrial, commercial, civil, financial, investment or real estate operations

in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad which are connected directly or indirectly in whole or in part to the
corporate purpose.

3.5 The Company can achieve its objective directly or indirectly in its own name or for the account of a third party,

alone or in association, undertaking all operations by nature in favor of the corporate purpose or the purpose of the
companies in which it holds interests.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg).

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of its shareholders

deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.-EUR), repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.-EUR) each.

Art. 7. Changes on capital. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by

a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these
Articles.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets

of the Company and to one vote of the shareholders. If the Company has only one shareholder, the latter exercises all
powers which are granted by law and the Articles to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and the resolutions of the sole shareholder or of the

shareholders, as the case may be.

175026

L

U X E M B O U R G

The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever

reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the
sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is

admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. Transfer of shares. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are

freely transferable.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. Events affecting the company. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. Managers. The Company is managed by one or more manager(s), who need not be shareholders, appointed

by decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for an undetermined period of time.

Managers are eligible for re-election. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the

sole shareholder or the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their

tenure and the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.

Art. 13. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to

attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.

The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need

not be members of the board of managers.

Art. 14. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or two

members of the board.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if the majority of its members are present or represented.
Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to

vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or e-mail.

Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting.
A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board

shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.

In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority

of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.

At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall

be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.

In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference

calls.

Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

Art. 15. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by

at least one manager. Any power of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.

The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.

Art. 16. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is/are vested with the

broadest powers to perform all acts of management and disposition in the Company's interest. All powers not expressly
reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.

Art. 17. Delegation of powers. The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general

meeting of shareholders, as the case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members.

The managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.
The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.

175027

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and,

in case of plurality of managers, by the joint signature of any 2 members of the board of managers, with power of reciprocal
delegation.

Art. 19. Liability of the managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting

a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.

Art. 21. Decisions of the shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder

meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by

all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and
shall vote in writing.

Art. 22. Financial year. The Company's year starts on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December of the

same year.

Art. 23. Financial statements. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts

are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 24. Allocation of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general

expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits
of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Art. 25. Dissolution - Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one

or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remu-
neration.

Art. 26. Matters not provided. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

<i>Transitory disposition

The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31 

st

 of December 2014.

<i>Subscription and payment

The articles of association thus having been established, the five hundred (500) shares have been subscribed by the

sole shareholder, the company “ALYA FINANCE S.à r.l.”, pre-designated and represented as said before, and fully paid
up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.-
EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank
certificate, who states it expressly.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

175028

L

U X E M B O U R G

<i>Resolutions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following

resolutions as sole shareholder:

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr. Christian TAILLEUR, private employee, born in Metz (France), on May 17, 1967, residing professionally in L-2540

Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen;

- Mrs. Sofia SILVA, private employee, born in Viana do Castelo (Portugal), on January 10, 1980, residing professionally

in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen; and

- Mr. James BODY, private employee, born in Clare (Ireland), on April 5, 1976, residing professionally in L-2540

Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

2) The Company is validly bound in any circumstances and without restrictions by the joint signature of any two (2)

managers.

3) The address of the corporation is fixed in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred and twenty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois d'octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg “ALYA FI-

NANCE S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 107689,

ici représentée par Madame Irina FERREIRA, employée privée, demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg,

26-28, rue Edward Steichen (la “Mandataire”), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 22 octobre 2014
à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la Mandataire
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter l’acte

de constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont
établis comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité,

et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la “Loi”), ainsi que
par les statuts de la Société (ci-après les “Statuts”), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles excep-
tionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Dénomination. La Société aura la dénomination “Benat Services S.à r.l.” (ci-après la “Société”).

Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet, de façon directe ou indirecte pour son compte ou pour le compte de tiers la fourniture

de services de conciergerie en France.

3.2 Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

3.3 La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quel-

conques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de
promouvoir son développement ou extension.

175029

L

U X E M B O U R G

3.4 La Société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières

ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social.

3.5 La Société pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule

ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l’étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Modification du capital social. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout

moment par une décision de l’associé unique ou par une décision des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal

dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés. Si la Société
comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des
associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l’associé unique ou

de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers et successeurs de l’associé unique ou de l’assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons

que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les
actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l’actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l’exercice de leurs
droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l’associé unique ou de l’assemblée des associés,
suivant le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul pro-

priétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.

Art. 10. Cession de parts sociales. Dans l’hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-

ci sont librement transmissibles.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. Événements affectant la Société. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits

civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés

par une décision de l’associé unique ou par les associés, selon le cas, pour une durée indéterminée.

Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, les associés pourra décider la

révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement démissionner de ses
fonctions.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou les associés fixe leur nombre, la durée de leur mandat

et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).

L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Art. 13. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses

fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.

175030

L

U X E M B O U R G

Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.

Art. 14. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux

membres du conseil.

Les réunions sont tenues à l’endroit, au jour et à l’heure mentionnée dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et

voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.
Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l’approbation du conseil doit en informer

le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.

En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des

autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.

A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans

lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.

Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l’ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors

d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 15. Procès-verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des

procès verbaux signés par, ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l’alinéa qui précède. Les procurations
resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par le président.

Ces procès-verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.

Art. 16. Pouvoirs. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les

plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.

Art. 17. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut, avec l’autorisation préalable de l’associé unique ou l’as-

semblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.

Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.

Art. 18. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de

pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance, avec pouvoir de délégation
réciproque.

Art. 19. Événements affectant la gérance. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire

affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.

Art. 20. Responsabilité de la gérance. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 21. Décisions de l’associé ou des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale

des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par

écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à
chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 23. Bilan. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas

de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et
passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

175031

L

U X E M B O U R G

Art. 24. Répartition des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des

frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent
pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice.

3. L'associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 25. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou

plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 26. Dispositions générales. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts,

il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.

<i>Souscription et libération

Les statuts ayant été ainsi arrêtés, les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, la société

“ALYA FINANCE S.à r.l.”, pré-désignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice
prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se
trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une
attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare par les présentes avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplisse-
ment.

<i>Résolutions prises par l’associée unique

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions sui-

vantes en tant qu’associée unique:

1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Christian TAILLEUR, employé privé, né à Metz (France), le 17 mai 1967, demeurant professionnellement

à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen;

- Madame Sofia SILVA, employée privé, née le 10 janvier 1980 à Viana do Castelo (Portugal), demeurant profession-

nellement à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen; et

- Monsieur James BODY, employé privé, né à Clare (Irlande), le 5 avril 1976, demeurant professionnellement à L-2540

Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

2) La Société est valablement engagée et représentée par la signature de deux (2) gérants, en toutes circonstances et

sans restrictions.

3) L'adresse de la Société est fixée à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent vingt
euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

175032

L

U X E M B O U R G

Après lecture du présent acte à la Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ladite Mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: I. FERREIRA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 octobre 2014. LAC/2014/50108. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172622/379.
(140197607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Browne Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 190.623.

In the year two thousand and fourteen, on the tenth of October,
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette,

THERE APPEARED:

Browne Holding Guernsey Limited, a limited liability company organized under the laws of the Island of Guernsey,

having its registered office at Level 4 North, St. Julian’s Court, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WA
and registered with the Guernsey Registry of Companies under number 58998,

represented by Aïcha CISSE, lawyer, residing professionally in Luxembourg
by virtue of a power of attorney given under private seal on 09 October 2014.
Which power of attorney shall be signed ne varietur by the proxyholder of the above named party and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Who declared and requested the notary to state:
1) That “Browne Holding Guernsey Limited”, prenamed, is the sole shareholder of Browne Holding S.à r.l., a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 190.623 and incorporated by a deed of the undersigned notary on 24 September 2014
not yet published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations (the “Company”). The articles of association
of the Company (the “Articles”) have not been amended since then.

2) That the corporate capital of the Company is fixed at one hundred and twenty thousand Swedish Kronor (SEK

120,000) represented by one hundred and twenty thousand (120,000) shares having a nominal value of one Swedish Krona
(SEK 1) each.

3) After this had been set forth, the above named sole shareholder representing the entire corporate capital of the

Company, has decided to hold an extraordinary general meeting and to take the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to convert the one hundred and twenty thousand (120,000) shares of the Company

into one hundred and twenty thousand (120,000) ordinary shares of the Company with a nominal value of one Swedish
Krona (SEK 1) each.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to create nine (9) new classes of preference shares of the Company, which shall be

designated as classes A, B, C, D, E, F, G, H and I shares, each share having a nominal value of Swedish Krona (SEK 1).

The sole shareholder resolves that the financial rights attached to the new classes of shares and the conditions of their

repurchase and cancellation will be further determined in the Articles to be amended as per the following resolutions.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million eighty thousand

Swedish Kronor (SEK 1,080,000), so as to raise it from its present amount of one hundred and twenty thousand Swedish
Kronor (SEK 120,000) to one million two hundred thousand Swedish Kronor (SEK 1,200,000) by the creation and the
issue of:

- one hundred and twenty thousand (120,000) class A shares;
- one hundred and twenty thousand (120,000) class B shares;
- one hundred and twenty thousand (120,000) class C shares;
- one hundred and twenty thousand (120,000) class D shares;

175033

L

U X E M B O U R G

- one hundred and twenty thousand (120,000) class E shares;
- one hundred and twenty thousand (120,000) class F shares;
- one hundred and twenty thousand (120,000) class G shares;
- one hundred and twenty thousand (120,000) class H shares; and
- one hundred and twenty thousand (120,000) class I shares;
with a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1) each, being one million eighty thousand (1,080,000) new preference

shares in total with a nominal value of one Swedish Krona (SEK 1) each.

<i>Subscription and paying up

The one million eighty thousand (1,080,000) new preference shares with a nominal value of one Swedish Krona (SEK

1) each together with a total share premium of one billion seven hundred million nine hundred and twenty thousand
Swedish Kronor (SEK 1,700,920,000) have been subscribed as follows:

Browne Holding Guernsey Limited, prenamed, has subscribed to:
- one hundred and twenty thousand (120,000) class A shares;
- one hundred and twenty thousand (120,000) class B shares;
- one hundred and twenty thousand (120,000) class C shares;
- one hundred and twenty thousand (120,000) class D shares;
- one hundred and twenty thousand (120,000) class E shares;
- one hundred and twenty thousand (120,000) class F shares;
- one hundred and twenty thousand (120,000) class G shares;
- one hundred and twenty thousand (120,000) class H shares; and
- one hundred and twenty thousand (120,000) class I shares.
Such new shares are paid up by way of a contribution in cash for an aggregate amount of one billion seven hundred

and two million Swedish Kronor (SEK 1,702,000,000) (the “Contribution in Cash”).

Evidence of the aforementioned Contribution in Cash has been given to the undersigned notary.
The Contribution in Cash for a total amount of one billion seven hundred and two million Swedish Kronor (SEK

1,702,000,000) out of which:

-  one  million  eighty  thousand  Swedish  Kronor  (SEK  1,080,000)  shall  be  allocated  to  the  corporate  capital  of  the

Company; and

- one billion seven hundred million nine hundred and twenty thousand Swedish Kronor (SEK 1,700,920,000) shall be

allocated to the share premium account attached to the preference shares.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the sole shareholder resolves to amend the entire article 6 of the

Articles of the Company, which shall now read as follows:

“ Art. 6. Capital.
6.1.  The  corporate  capital  of  the  Company  is  fixed  at  one  million  two  hundred  thousand  Swedish  Kronor  (SEK

1,200,000) represented by one million two hundred thousand (1,200,000) shares having a nominal value of one Swedish
Krona (SEK 1) each, fully paid up, and divided into:

(i) one hundred and twenty thousand (120,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”);
(ii) one hundred and twenty thousand (120,000) class A shares (the “Class A Shares”);
(iii) one hundred and twenty thousand (120,000) class B shares (the “Class B Shares”);
(iv) one hundred and twenty thousand (120,000) class C shares (the “Class C Shares”);
(v) one hundred and twenty thousand (120,000) class D shares (the “Class D Shares”);
(vi) one hundred and twenty thousand (120,000) class E shares (the “Class E Shares”);
(vii) one hundred and twenty thousand (120,000) class F shares (the “Class F Shares”);
(viii) one hundred and twenty thousand (120,000) class G shares (the “Class G Shares”);
(ix) one hundred and twenty thousand (120,000) class H shares (the “Class H Shares”);and
(x) one hundred and twenty thousand (120,000) class I shares (the “Class I Shares”).
The Shares are in registered form only.
The Class A Shares to Class I Shares are hereinafter referred to as the “Preference Shares”. The Ordinary Shares and/

or the Preference Shares are referred to as the “Shares” and “Share” shall be construed accordingly.

The holders of the Shares are together referred to as the “Shareholders” and individually a “Shareholder”.
Each class of Shares will have the same rights, save as otherwise provided in the present Articles. Each Share is entitled

to one (1) vote at any general meeting of Shareholder(s).

175034

L

U X E M B O U R G

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholder(s) adopted in the manner

required for amendment of these Articles.

The capital of the Company may be reduced through the cancellation of one or more entire classes of Preference

Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such class(es).

In the event that the Company shall proceed to a reduction of share capital through the repurchase of a class of

Preference Shares, a notice setting forth the date of the repurchase and cancellation and the Cancellation Amount shall
be given by or on behalf of the Company not less than seven (7) days before the date of the repurchase and cancellation,
to the Shareholder(s) at such Shareholder(s) address as the Company shall have received notice thereof, provided ho-
wever, that neither a failure to give such notice nor any defect therein shall affect the validity of the proceeding for the
repurchase and cancellation.

A reduction of share capital through the repurchase of a class of Preference Shares may only be made within the

respective Class Periods.

The period for the Class A Shares is the period starting on the date of incorporation of the Company and ending no

later than on 31 December 2014 (the “Class A Period”).

The period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending no later than

on 31 December 2015 (the “Class B Period”).

The period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later than

on 31 December 2016 (the “Class C Period”).

The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later than

on 31 December 2017 (the “Class D Period”).

The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending no later than

on 31 December 2018 (the “Class E Period”).

The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending no later than

on 31 December 2019 (the “Class F Period”).

The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending no later than

on 31 December 2020 (the “Class G Period”).

The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later than

on 31 December 2021 (the “Class H Period”).

The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than

on 31 December 2022 (the “Class I Period”).

Where a class of Preference Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the

redemption and cancellation of such class(es) of Preference Shares can be made during a new period (the “New Period”)
which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately
preceding New Period of another class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first
New Period shall start on the day after the Class I Period and the classes of Preference Shares not repurchased and not
cancelled in their respective Class Period shall come in the order from class A to class I (to the extent not previously
repurchased and cancelled).

For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of Preference Shares shall take

place prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period
(or as the case may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of Preference
Shares and shall continue to end on the day such as initially defined in the Articles above.

Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due and

payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(ses). For the avoidance of doubt
the Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.

The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the Sole Manager

or, in case of plurality of managers the Board of Managers (as both terms defined below) in its reasonable discretion and
within the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the Sole Manager or, in case of plurality
the Board of Managers can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation
Amount the freely distributable reserves attached to the Preference Shares either in part or in totality.

For the purposes of these Articles, the following capitalised terms shall have the following meanings:
- “Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)

increased by (i) any freely distributable reserves attached to the Preference Shares and (ii) as the case may be, by the
amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be cancelled but
reduced by (i) any losses (included carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve
(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without
for the avoidance of doubt, any double counting), (iii) any dividends to which is(are) entitled the holder(s) of the Ordinary
Shares pursuant to the Articles and (iv) any Profit Entitlement so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+OD+PE)

175035

L

U X E M B O U R G

Whereby:
AA = Available Amount.
NP = net profits (including carried forward profits).
P = any freely distributable reserves attached to the Preference Shares.
CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be

cancelled.

L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.
OD = any dividends to which is(are) entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles.
PE = Profit Entitlement.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed

by the Sole Manager or, in case of plurality of managers the Board of Managers of the Company in good faith and with
the view to the Company’s ability to continue as a going concern.

- “Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a

remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes
and any receivable which in the opinion of the Sole Manager or, in case of plurality of managers the Board of Managers
will be paid to the Company in the short term less any indebtedness or other debt of the Company payable in less than
six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as
the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of other kind held by the Company.

- “Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class

Period (or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available
Liquidities relating to the relevant Class Period (or New Period).

- “Class Period” shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period,

the Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period and the Class I Period.

- “Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
- “Interim Account Date” shall mean the date not earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before

the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preference Shares.

- “Profit Entitlement” shall mean the preferred dividends of the Preference Shares.
6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up premium accounts into which any premium paid on any

Share is transferred. Thus, any amount of share premium paid into the Company on any Preference Shares shall be
allocated to a premium account attached to such Preference Shares. Similarly, any amount of share premium paid into
the Company on any Ordinary Shares shall be allocated to a premium account attached to such Ordinary Shares.

6.3. The share premium shall be distributed upon a decision of the Sole Manager or in case of plurality of managers,

the Board of Managers. The amount of share premium allocated to a premium account attached to the Preference Shares
shall be exclusively distributed to the holders of the Preference Shares. The amount of share premium allocated to a
premium account attached to the Ordinary Shares shall be exclusively distributed to the holders of Ordinary Shares.

6.4. Unless provided otherwise in the Articles, the Shares will have equal rights.”

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolves to insert a new article 16.3 in the Articles of the Company, which shall read as follows:

“ 16.3. The dividends declared may be paid in any currency selected by the Sole Manager or, as the case may be, the

Board of Managers and may be paid at such places and times as may be determined by the Sole Manager or, as the case
may be, the Board of Managers. The Sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers may make a final
determination of the exchange rate applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend
declared but not paid on a Share during five (5) years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be
forfeited by the holder of such Share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared
and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Shares.

In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:
16.3.1. the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.01% of the nominal value of the

Ordinary Shares;

16.3.2. the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.20% of the nominal value of the

Class A Shares;

16.3.3. the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.25% of the nominal value of the

Class B Shares;

16.3.4. the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.30% of the nominal value of the

Class C Shares;

175036

L

U X E M B O U R G

16.3.5. the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.35% of the nominal value of the

Class D Shares;

16.3.6. the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.40% of the nominal value of the

Class E Shares;

16.3.7. the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.45% of the nominal value of the

Class F Shares;

16.3.8. the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.50% of the nominal value of the

Class G Shares;

16.3.9. the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.55% of the nominal value of the

Class H Shares;

16.3.10. the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.60% of the nominal value of the

Class I Shares;

16.3.11. the balance shall be allocated to the holder(s) of the Preference Shares pursuant to a decision taken by the

general meeting of Shareholders.”

<i>Sixth resolution

The sole shareholder resolves to amend article 17.4 of the Articles of the Company, which shall now read as follows:

“ 17.4. The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to

reimburse the contribution made by the Shareholders on the Shares of the Company. The final surplus will be distributed
to the Shareholders in conformity with and so as to achieve on aggregate basis the same economic result as the distribution
rules set forth in article 16.3 of the present Articles.”

<i>Seventh resolution

The sole shareholder resolves that from the share premium account attached to the preference shares in the amount

of one billion seven hundred million nine hundred and twenty thousand Swedish Kronor (SEK 1,700,920,000), an amount
of one hundred and twenty thousand Swedish Kronor (SEK 120,000) shall be allocated to the legal reserve of the Com-
pany. After such allocation to the legal reserve of the Company, the amount of the share premium account attached to
the preference shares shall be equal to one billion seven hundred million eight hundred thousand Swedish Kronor (SEK
1,700,800,000).

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the

present deed, are estimated at approximately seven thousand Euro.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date mentioned at the beginning of

this document.

The document having been read to the representative of the appearing party, known to the undersigned notary, by

name, last name, civil status and residence, the said representative of the appearing party signed together with us, the
notary, the present deed.

Follows the french translation

L’an deux mille quatorze, le dix octobre,
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A COMPARU:

Browne Holding Guernsey Limited, une société à responsabilité limitée, organisée et existante selon les lois des Îles

de Guernsey, ayant son siège social au Level 4 North, St. Julian’s Court, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1
1WA et immatriculée au Registre des Sociétés de Guernsey sous le numéro 58998,

représentée par Aïcha CISSE, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le

09 octobre 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Qui a déclaré et demandé au notaire d’acter:
1) Que «Browne Holding Guernsey Limited», prénommée, est l’associé unique de Browne Holding S.à r.l., une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, imma-

175037

L

U X E M B O U R G

triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.623 et constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 septembre 2014 non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») n’ont dès lors pas été modifiés depuis.

2) Que le capital social de la Société est fixé à cent vingt mille couronnes suédoises (120.000 SEK) représenté par cent

vingt mille (120.000) parts sociales ayant une valeur nominale d’une couronne suédoise (1 SEK) chacune.

3) Ceci ayant été exposé, l’associé unique prénommé représentant l’intégralité du capital social de la Société a décidé

de tenir une assemblée générale extraordinaire et de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de convertir les cent vingt mille (120.000) parts sociales de la Société en cent vingt mille

(120.000) parts sociales ordinaires de la Société ayant une valeur nominale d’une couronne suédoise (1 SEK) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de créer neuf (9) nouvelles catégories de parts sociales préférentielles de la Société, à savoir

les parts sociales de catégorie A, B, C, D, E, F, G, H, et I, chaque part sociale ayant une valeur nominale d’une couronne
suédoise (1 SEK).

L’associé unique décide que les droits financiers attachés aux nouvelles catégories de parts sociales et les conditions

de leur rachat et annulation seront déterminés plus amplement dans les Statuts de la Société qui seront modifiés par les
résolutions suivantes.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de un million quatre-vingt mille cou-

ronnes suédoises (1.080.000 SEK) afin de le porter de son montant actuel de cent vingt mille couronnes suédoises (120.000
SEK) à un million deux cent mille couronnes suédoises (1.200.000 SEK) par la création et l’émission de:

- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie A;
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie B;
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie C;
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie D;
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie E;
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie F;
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie G;
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie H; et
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie I;
d’une valeur nominale d’une couronne suédoise (1 SEK) chacune, soit un million quatre-vingt mille (1.080.000) nouvelles

parts sociales préférentielles au total, d’une valeur nominale d’une couronne suédoise (1 SEK) chacune.

<i>Souscription et paiement

Les un million quatre-vingt mille (1.080.000) nouvelles parts sociales préférentielles d’une valeur nominale d’une cou-

ronne suédoise (1 SEK) chacune, ensemble avec une prime d'émission totale de un milliard sept cent millions neuf cent
vingt mille couronnes suédoises (1.700.920.000 SEK) ont été souscrites comme suit:

Browne Holding Guernsey Limited, prénommée, a souscrit à:
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie A;
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie B;
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie C;
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie D;
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie E;
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie F;
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie G;
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie H; et
- cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie I.
Ces nouvelles parts sociales sont libérées par un apport en numéraire d’un montant total de un milliard sept cent deux

millions couronnes suédoises (1.702.000.000 SEK) (les «Apports en Numéraire»).

La preuve des Apports en Numéraire susmentionnés a été rapportée au notaire instrumentaire.
Les  Apports  en  Numéraire  pour  un  montant  total  de  un  milliard  sept  cent  deux  millions  couronnes  suédoises

(1.702.000.000 SEK) dont:

- un million quatre-vingt mille couronnes suédoises (1.080.000 SEK) seront attribuées au capital social de la Société;

et

175038

L

U X E M B O U R G

- un milliard sept cent millions neuf cent vingt mille couronnes suédoises (1.700.920.000 SEK) seront attribuées au

compte de prime d’émission attaché aux parts sociales préférentielles.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des Statuts de la Société

dans son intégralité pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Capital social.
6.1 Le capital social de la Société est fixé à un million deux cent mille couronnes suédoises (1.200.000 SEK) représenté

par un million deux cent mille (1.200.000) parts sociales d’une valeur nominale d’une couronne suédoise (1 SEK) chacune,
entièrement libéré et divisé en:

(i) cent vingt mille (120.000) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»);
(ii) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie A (les “Parts Sociales de Catégorie A”);
(iii) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie B (les “Parts Sociales de Catégorie B”);
(iv) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie C (les “Parts Sociales de Catégorie C”);
(v) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie D (les “Parts Sociales de Catégorie D”);
(vi) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie E (les “Parts Sociales de Catégorie E”);
(vii) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie F (les “Parts Sociales de Catégorie F”);
(viii) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie G (les “Parts Sociales de Catégorie G”);
(ix) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie H (les “Parts Sociales de Catégorie H”); et
(x) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie I (les “Parts Sociales de Catégorie I”).
Les Parts Sociales sont uniquement sous forme nominative.
Les Parts Sociales de la Catégorie A à la Catégorie I sont ci-après dénommées les “Parts Sociales Préférentielles”. Les

Parts Sociales Ordinaires et/ou les Parts Sociales Préférentielles sont dénommées ci-après comme les “Parts Sociales” et
“Part Sociale” doit être interprété en conséquence.

Les détenteurs de Parts Sociales sont dénommés ensemble, les “Associés” et individuellement un “Associé”.
Chaque catégorie de Parts Sociales aura les mêmes droits, sauf dispositions contraires dans les présents Statuts. Chaque

Part Sociale donne droit à un (1) vote à l’assemblée générale de(des) l’Associé(s).

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution du (des) Associés(s) adoptée selon les

modalités requises pour la modification des Statuts.

Le capital social de la Société peut être réduit par l’annulation d’une ou plusieurs catégories entières de Parts Sociales

Préférentielles par le rachat et l’annulation de toutes les Parts Sociales émises dans cette (ces) catégorie(s).

Dans le cas où la Société procède à une réduction de capital par le rachat d’une catégorie de Parts Sociales Préféren-

tielles, un avis énonçant la date du rachat et de l’annulation ainsi que le Montant d'Annulation doit être donné par ou
pour le compte de la Société au moins sept (7) jours avant la date du rachat et de l’annulation à (aux) l’Associé(s) à
l’adresse de (des) l’Associé(s) qui aura été notifiée à la Société, sous réserve toutefois que ni l’omission de donner un tel
avis, ni un quelconque défaut de celui-ci n'affecte la validité de la procédure pour le rachat et l’annulation.

Une réduction de capital par le rachat d'une catégorie de Parts Sociales Préférentielles ne peut être faite que pendant

les Périodes de Catégorie respectives.

La période pour les Parts Sociales de Catégorie A est la période commençant à la date de constitution de la Société

et se terminant au plus tard le 31 décembre 2014 (la “Période de Catégorie A”).

La période pour les Parts Sociales de Catégorie B est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie

A et se terminant au plus tard le 31 décembre 2015 (la “Période de Catégorie B”).

La période pour les Parts Sociales de Catégorie C est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie

B et se terminant au plus tard le 31 décembre 2016 (la “Période de Catégorie C”).

La période pour les Parts Sociales de Catégorie D est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie

C et se terminant au plus tard le 31 décembre 2017 (la “Période de Catégorie D”).

La période pour les Parts Sociales de Catégorie E est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie

D et se terminant au plus tard le 31 décembre 2018 (la “ Période de Catégorie E”).

La période pour les Parts Sociales de Catégorie F est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie

E et se terminant au plus tard le 31 décembre 2019 (la “Période de Catégorie F”).

La période pour les Parts Sociales de Catégorie G est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie

F et se terminant au plus tard le 31 décembre 2020 (la “Période de Catégorie G”).

La période pour les Parts Sociales de Catégorie H est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie

G et se terminant au plus tard le 31 décembre 2021 (la “Période de Catégorie H”).

La période pour les Parts Sociales de Catégorie I est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie

H et se terminant au plus tard le 31 décembre 2022 (la “Période de Catégorie I”).

175039

L

U X E M B O U R G

Dans le cas où une catégorie de Parts Sociales Préférentielles n'a pas été rachetée et annulée pendant la Période de

Catégorie concernée, le rachat et l’annulation de cette (ces) catégorie(s) de Parts Sociales Préférentielles peut/peuvent
être fait(s) pendant une nouvelle période (la “Nouvelle Période”) qui débutera à la date suivant la dernière Période de
Catégorie (ou, le cas échéant, la date après la fin de la Nouvelle Période immédiatement précédente d’une autre catégorie)
et se terminera pas plus tard qu’un an après la date de début de ladite Nouvelle Période. La première Nouvelle Période
débutera le jour suivant la Période de Catégorie I et les catégories de Parts Sociales Préférentielles non rachetées et non
annulées pendant leur Période de Catégorie respective viendront dans l’ordre de la catégorie A à la catégorie I (dans la
mesure où elles n'ont pas été rachetées et annulées antérieurement).

Pour éviter tout doute, dans le cas où un rachat et une annulation d'une catégorie de Parts Sociales Préférentielles

doit avoir lieu avant le dernier jour de sa Période de Catégorie respective (ou le cas échéant, la Nouvelle Période), la
Période de Catégorie suivante (ou le cas échéant, la Nouvelle Période) doit commencer le jour après le rachat et l’an-
nulation  de  cette  catégorie  de  Parts  Sociales  Préférentielles  et  continuera  pour  se  terminer  au  jour  tel  que  défini
initialement dans les Statuts ci-dessus.

Au moment du rachat et de l’annulation de la (des) catégorie(s) entière(s) concernée(s), le Montant d'Annulation

deviendra exigible et payable par la Société à(aux) l’Associé(s) au prorata de leur participation dans cette (ces) catégorie
(s). Pour éviter tout doute, la Société peut s'acquitter de son obligation de paiement, en espèces, en nature ou par voie
de compensation.

Le Montant d’Annulation mentionné à l’alinéa ci-dessus, à retenir, sera déterminé par le Gérant Unique ou en cas de

pluralité de gérants, le Conseil de Gérance (tels que définis ci-après) à sa raisonnable discrétion et dans le meilleur intérêt
social de la Société.

Pour éviter tout doute, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut choisir à sa

seule discrétion d’inclure ou d’exclure dans sa détermination du Montant d’Annulation tout ou partie des réserves libre-
ment distribuables attachées aux Parts Sociales Préférentielles.

Pour les besoins de ces Statuts, les termes en majuscule ci-dessous ont la signification suivante:
- “Montant Disponible” signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés),

augmenté de (i) toutes réserves librement distribuables attachées aux Parts Sociales Préférentielles et (ii) le cas échéant,
du montant de la réduction de capital et de la réduction de réserve légale relatives aux catégories des Parts Sociales
Préférentielles devant être annulées, celui-ci réduit par (i) toutes pertes (y compris les pertes reportées) exprimées
comme étant positives et (ii) toutes sommes à affecter à la(aux) réserve(s) en vertu des exigences de la Loi ou des Statuts,
chaque fois tel que figurant dans les Comptes Intérimaires concernés (pour éviter tout doute, sans double comptage),
(iii) tous dividendes auxquels a(ont) droit le(les) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires et (iv) tout Droit au Bénéfice
de telle sorte que:

MD = (BN+B+RC) - (P+RL+DO+DB)
Sachant que:
MD = Montant Disponible.
BN = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés).
B = toute réserve librement distribuable attachée aux Parts Sociales Préférentielles.
RC = le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale en rapport avec la catégorie de Parts

Sociales Préférentielles devant être annulée.

P = pertes (y compris les pertes reportées), exprimées comme étant positives.
RL = toutes sommes devant être allouées dans une (des) réserve(s) conformément à la Loi et aux Statuts.
DO = tous dividendes auxquels a(ont) droit le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires conformément aux Statuts.
DB = Droit au Bénéfice.
Le Montant Disponible doit être indiqué dans les Comptes Intérimaires (tels que définis ci-dessous) de la Période de

Catégorie correspondante et sera évalué par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance
de la Société, de bonne foi et en prenant en compte la possibilité de la Société de continuer ses activités.

- “Liquidités Disponibles” désigne (i) toutes les espèces détenues par la Société (sauf les dépôts à terme en espèces

avec une échéance supérieure à six (6) mois), (ii) tous les instruments du marché monétaire immédiatement négociables,
obligations et billets et toute créance qui, de l’avis du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de
Gérance, seront versés à la Société à court terme, moins les endettements ou autres dettes de la Société payables dans
moins de six (6) mois déterminées sur base des Comptes Intérimaires relatifs à la Période de Catégorie concernée (ou
Nouvelle Période, le cas échéant) et (iii) tous les actifs tels que les actions, titres ou valeurs mobilières de toute sorte
détenus par la Société.

- “Montant d’Annulation” désigne un montant n’excédant pas les Liquidités Disponibles en rapport avec la Période de

Catégorie concernée (ou la Nouvelle Période, le cas échéant) à condition que le Montant d’Annulation ne soit pas su-
périeur aux Liquidités Disponibles relatives à la Période de Catégorie concernée (ou à la Nouvelle Période).

175040

L

U X E M B O U R G

- “Période de Catégorie” désigne chacune des périodes suivantes: Période de Catégorie A, Période de Catégorie B,

Période de Catégorie C, Période de Catégorie D, Période de Catégorie E, Période de Catégorie F, Période de Catégorie
G, Période de Catégorie H et Période de Catégorie I.

- “Comptes Intérimaires” signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires.
- “Date des Comptes Intérimaires” signifie la date au plus tôt trente (30) jours, mais au plus tard dix (10) jours avant

la date de rachat et d’annulation de la catégorie des Parts Sociales Préférentielles concernée.

- “Droit au Bénéfice” signifie les dividendes préférentiels des Parts Sociales Préférentielles.
6.2 En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime d’émission

payée pour toute Part Sociale sera versée. Ainsi, tout montant de prime d’émission versé à la Société pour toutes Parts
Sociales Préférentielles sera alloué à un compte de prime d’émission attaché à ces Parts Sociales Préférentielles. De même,
tout montant de prime d’émission versé à la Société pour toutes Parts Sociales Ordinaires sera alloué à un compte de
prime d’émission attaché à ces Parts Sociales Ordinaires.

6.3 La prime d’émission sera distribuée sur décision du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil

de Gérance. Le montant de la prime d’émission attachée aux Parts Sociales Préférentielles sera distribué exclusivement
aux détenteurs des Parts Sociales Préférentielles. Le montant de la prime d’émission attachée aux Parts Sociales Ordinaires
sera distribué exclusivement aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires.

6.4 Sauf disposition contraire des Statuts, les Parts Sociales confèrent les mêmes droits.»

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide d’insérer un nouvel article 16.3 dans les Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

« 16.3. Les dividendes déclarés peuvent être payés dans toute devise déterminée par le Gérant Unique ou, le cas

échéant, par le Conseil de Gérance et peuvent être payés aux lieux et heures tel que déterminés par le Gérant Unique
ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance. Le Gérant Unique, ou le cas échéant le Conseil de Gérance peut recourir à
une détermination finale du taux de change applicable à la devise utilisée pour convertir les fonds de dividende dans la
devise de paiement. Un dividende déclaré mais impayé sur une Part Sociale pendant une durée de cinq (5) ans ne pourra
plus être réclamé par le détenteur de cette Part Sociale, sera perdu pour le détenteur de cette Part Sociale et reviendra
à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur des dividendes déclarés et non réclamés qui sont détenus par la Société pour
le compte de détenteurs de Parts Sociales.

Dans le cas d’une déclaration de dividendes, ces dividendes devront être alloués et payés dans l’ordre suivant:
16.3.1 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires aura(auront) droit à un dividende égal à 0,01% de la valeur

nominale des Parts Sociales Ordinaires;

16.3.2 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie A aura(auront) droit à un dividende égal à 0,20% de la valeur

nominale des Parts Sociales de Catégorie A;

16.3.3 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie B aura(auront) droit à un dividende égal à 0,25% de la valeur

nominale des Parts Sociales de Catégorie B;

16.3.4 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie C aura(auront) droit à un dividende égal à 0,30% de la valeur

nominale des Parts Sociales de Catégorie C;

16.3.5 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie D aura(auront) droit à un dividende égal à 0,35% de la valeur

nominale des parts sociales de Catégorie D;

16.3.6 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie E aura(auront) droit à un dividende égal à 0,40% de la valeur

nominale des Parts Sociales de Catégorie E;

16.3.7 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie F aura(auront) droit à un dividende égal à 0,45% de la valeur

nominale des Parts Sociales de Catégorie F;

16.3.8 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie G aura(auront) droit à un dividende égal à 0,50% de la valeur

nominale des Parts Sociales de Catégorie G;

16.3.9 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie H aura(auront) droit à un dividende égal à 0,55% de la valeur

nominale des Parts Sociales de Catégorie H;

16.3.10 le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de catégorie I aura(auront) droit à un dividende égal à 0,60% de la valeur

nominale des Parts Sociales de Catégorie I;

16.3.11 le solde sera alloué au(x) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles en vertu d’une décision devant être

prise par l’assemblée générale des Associés.”

<i>Sixième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 17.4 des Statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« 17.4. Le surplus après paiement des charges, dettes, dépenses qui résultent de la liquidation sera utilisé pour rem-

bourser l’apport fait par les Associés sur les Parts Sociales de la Société. Le surplus final sera distribué aux Associés
conformément aux et afin d’atteindre sur une base totale le même résultat économique que celui atteint par les règles
de distribution établies à l’article 16.3 des présents Statuts.»

175041

L

U X E M B O U R G

<i>Septième résolution

L’associé unique décide que du compte de prime d’émission attaché aux parts sociales préférentielles d’un montant

de un milliard sept cents millions neuf cent vingt mille couronnes suédoises (1.700.920.000 SEK), la somme de cent vingt
mille couronnes suédoises (120.000 SEK) sera attribuée à la réserve légale de la Société. Après une telle allocation à la
réserve légale de la Société, le montant du compte de prime d’émission attaché aux parts sociales préférentielles sera
égal à un milliard sept cents millions huit cent mille couronnes suédoises (1.700.800.000 SEK).

<i>Dépenses

Les frais, coûts, dépenses, rémunérations et charges de quelque forme que ce soit incombant à la Société en raison

du présent acte s’élèvent approximativement à sept mille Euros.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même partie comparante, en cas de divergence
entre le texte français et anglais, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, qui est connu du notaire ins-

trumentaire par son nom, prénom, état civil et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec nous, le
notaire, le présent acte.

Signé: Cisse, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 octobre 2014. Relation: EAC/2014/13887. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014172636/508.
(140197947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

First Street A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 191.539.

STATUTEN

Im Jahr zweitausendundvierzehn, am dreiundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Léonie GRETHEN, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

First Street Topco 1 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, Rue

Beck,  L-1222  Luxemburg,  im  Registrierungsprozess  beim  Handelsregister  von  Luxemburg,  vertreten  durch  ihre  Ge-
schäftsführer,

hier vertreten durch Frau Laurence Heinen, Angestellte, geschäftsansässig in 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg,

aufgrund einer privatrechtlich erteilten Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 23. Oktober 2014.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Vertreterin der Erschienenen und dem unterzeichneten

Notar, dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene, den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-

schaft  mit  beschränkter  Haftung,  unter  der  Bezeichnung  First  Street  A  S.à  r.l.,  die  sie  hiermit  gründet,  wie  folgt  zu
beurkunden

I. Rechtsform, Bezeichnung, Dauer, eingetragener Geschäftssitz

Art. 1. Rechtsform und Bezeichnung. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-

ponsabilité  limitée)  unter  der  Bezeichnung  First  Street  A  S.à  r.l.,  gemäß  dem  Gesetz  vom  10.  August  1915  über
Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (nachstehend das „Gesetz“) sowie der vorliegenden Satzung
(nachstehend die „Satzung“).

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 3. Sitz der Gesellschaft Gesellschaftssitz.
3.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

175042

L

U X E M B O U R G

3.2. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder des Geschäftsfüh-

rerrats verlegt werden.

3.3. Durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch Beschluss einer außerordentlichen Generalver-

sammlung, vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse zur Änderung der Satzung, kann der Sitz der
Gesellschaft an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

3.4. Zweigniederlassungen oder sonstige Geschäftsstellen der Gesellschaft können durch Beschluss des alleinigen Ge-

schäftsführers oder der Geschäftsführerrats im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

II. Gesellschaftszweck

Art. 4. Gesellschaftszweck.
4.1. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften in jeglicher

Weise, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf sonstige Art und Weise sowie die Übertragung durch Veräußerung,
Tausch oder anderweitig von Aktien, Obligationen, Schuldverschreibungen, Anleihen und anderen Wertpapieren sowie
der Besitz, die Verwaltung und die Entwicklung des Portfolios. Die Gesellschaft kann außerdem Anteile an Kommandit-
gesellschaften halten.

4.2. Der Zweck der Gesellschaft beinhaltet insbesondere den Erwerb, den Besitz, die Entwicklung, die Veräußerung,

die Verwaltung und/oder die Vermietung von unbeweglichem Eigentum im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland
sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesem unbeweglichen Eigentum, einschließlich der direkte oder indirekte
Besitz von Aktienkapital luxemburgischer oder ausländischer Gesellschaften, deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwic-
klung, die Veräußerung, die Verwaltung und/oder die Vermietung von unbeweglichem Eigentum ist.

4.3. Die Gesellschaft kann hierzu insbesondere:
- Geldmittel in jeglicher Form aufnehmen oder Bankkreditlinien abschließen und Geldmittel durch, einschließlich, aber

nicht beschränkt auf, die Ausgabe von Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheindarlehen, Garantien und anderen
Schuldinstrumenten und Schuldtiteln, wandelbar oder nicht, oder den Gebrauch von derivativen Finanzinstrumenten oder
anderweitig, mit Ausnahme von öffentlichen Kaufangeboten, aufbringen;

- jegliche Art von Kreditderivatverträgen eingehen, wie z.B., jedoch nicht beschränkt auf, Swapverträge gemäß welcher

die Gesellschaft eine Kreditbesicherung für eine Swapgegenpartei stellen oder von ihr erhalten kann;

- zugunsten ihrer Tochtergesellschaften oder Gesellschaften in denen die Gesellschaft eine direkte oder indirekte

Beteiligung hat, oder jeglicher anderen Gesellschaft welche direkt oder indirekt durch den (die) Gesellschafter kontrolliert
werden (nachstehend „Tochtergesellschaften“): (i) jegliche Art von Unterstützung gewähren, Geldmittel vorschießen,
leihen, einzahlen oder Schuldverschreibungen welche von einer Luxemburgischen oder ausländischen Tochtergesellschaft
ausgegeben worden sind, mit oder ohne Sicherheit, zeichnen oder erwerben; (ii) jegliche Sicherheit, Verpfändung oder
andere Art der Sicherheit beibringen, sei es durch persönliche Bürgschaft oder Hypothek oder durch eine teilweise oder
vollständige Belastung der Gesellschaft oder ihres (gegenwärtigen oder zukünftigen) Vermögens oder durch jegliche Art
und Weise, zur Erfüllung von Verträgen und ihrer Verpflichtungen sowie der der Tochtergesellschaften, im Rahmen der
geltenden Gesetze; und

- Verträge abschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Personenvereinigungsverträge, Übernahmeverträge,

Marketingverträge,  Verwaltungsverträge,  Beraterverträge  und  andere  Dienstleistungsverträge,  Veräußerungsverträge,
Zins- oder Währungstauschvereinbarungen oder andere derivative Finanzvereinbarungen welche im Rahmen des Ge-
sellschaftszwecks sind;

wobei die Gesellschaft keine Geschäfte abwickeln darf, welche eine Geschäftstätigkeit darstellt oder wodurch die

Gesellschaft Tätigkeiten abwickeln würde, welche als reglementierte Tätigkeit des Finanzsektors angesehen würde.

4.4. Die Gesellschaft kann außerdem als Komplementär oder Kommanditär mit unbeschränkter oder beschränkter

Haftung für sämtliche Schulden und Verpflichtungen von Kommanditgesellschaft oder ähnlichen Unternehmensformen
einstehen.

4.5. Die Gesellschaft kann jegliche kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, die sie für die

Erfüllung oder Entwicklung ihrer Zwecke als sachdienlich betrachtet.

I. Stammkapital und Anteile

Art. 5. Stammkapital.
5.1.  Das  Stammkapital  der  Gesellschaft  ist  auf  zwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR  12.500,-)  festgesetzt,  geteilt  in

einhundert (100) vollständig eingezahlte Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

5.2. Das Stammkapital kann durch Beschluss des alleingien Gesellschafters oder durch Beschluss der Gesellschafter-

versammlung  jederzeit  erhöht  oder  reduziert  werden;  Gesellschafterbeschlüsse  dieser  Art  sind  in  der  Weise  zu
verabschieden, die für Beschlüsse über Änderungen der Satzung erforderlich ist.

5.3. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen des geltenden Gesetzes zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1. Anteile werden ausschließlich als Namensanteile ausgegeben und werden, gemäß dem Gesetz, in einem Gesell-

schafterregister eingetragen. Das Eigentum der Anteile wird durch die Eintragung im Gesellschafterregister bestätigt.

175043

L

U X E M B O U R G

6.2. Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Anteil an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft

eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.

6.3. Die Gesellschaft kann aus mehreren Gesellschaftern bestehen. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt

vom Tode, der Insolvenz oder des Bankrottes des alleinigen Gesellschafters oder irgendeines Gesellschafters.

6.4. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und

die Gewinne der Gesellschaft.

6.5. Anteile sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen sind durch notarielle oder private Ur-

kunden zu protokollieren. Gegenüber der Gesellschaft oder Dritten sind Übertragungen erst dann bestandskräftig, wenn
sie der Gesellschaft angezeigt oder von ihr gemäß den Bestimmungen des Art. 1690 des Code Civil (Bürgerliches Ge-
setzbuch) von Luxemburg angenommen worden sind.

6.6. Geschäftsanteile dürfen unter Lebenden nicht an andere Personen als an Gesellschafter übertragen werden, es sei

denn, die Gesellschafterversammlung stimmt einem derartigen Vorgang mit mindestens einer Dreiviertelmehrheit des
Stammkapitals der Gesellschaft zu.

6.7. Im Todesfall unterliegt die Übertragung der Anteile von verstorbenen Gesellschaftern an Nicht-Gesellschafter,

der  vorherigen  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  mit  einer  Dreiviertelmehrheit  des  Stammkapitals.  Diese
Genehmigung ist allerdings nicht erforderlich, wenn die Geschäftsanteile an die Eltern, die Nachkommen oder den über-
lebenden Ehepartner eines verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

II. Geschäftsführung

Art. 7. Geschäftsführung.
7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführer(n) geleitet, welcher/welche vom alleinigen Ge-

sellschafter oder der Gesellschafterversammlung bestellt wird/werden. Die Gesellschafterversammlung legt auch dessen/
deren Amtszeit fest. Ein Geschäftsführer muss nicht unbedingt Gesellschafter sein.

7.2. Ein Geschäftsführer kann jederzeit auch ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss des alleinigen Gesell-

schafters oder der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

Art. 8. Beschlüsse der Geschäftsführer.
8.1. Wurden mehrere Geschäftsführer bestellt, bilden sie zusammen den Geschäftsführerrat.
8.2. Der Geschäftsführerrat tritt so oft zusammen, wie es die Angelegenheiten der Gesellschaft es erfordern oder auf

Einberufung eines Geschäftsführers an dem Ort, wie es die Ladung vorsieht. Alle Sitzungen des Geschäftsführerrats finden
im Großherzogtum Luxemburg statt.

8.3. Der Geschäftsführerrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Er kann außerdem einen Schriftführer

bestellen,  der  nicht  unbedingt  Geschäftsführer  sein  muss  und  der  für  die  Führung  der  Protokolle  der  Sitzungen  des
Geschäftsführerrats verantwortlich ist. Der Vorsitzende hält den Vorsitz sämtlicher Sitzungen des Geschäftsführerrats,
und im Falle seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat, durch Mehrheit der Stimmen, einen anderen Geschäfts-
führer als Vorsitzenden pro tempore bestellen.

8.4. Jede Sitzung muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem vorgesehenen Datum schriftlich gegenüber

jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle der Dringlichkeit, wobei die Art und Umstände der Dringlichkeit
aufgeführt werden müssen.

8.5. Wenn alle Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass die Tagesordnung ihnen

bekannt ist, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Es kann auf die Einberufung durch eine schriftliche Einverständ-
niserklärung jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats verzichtet werden. Diese Einverständniserklärung wird in Urschrift,
per Fax oder Email (ohne elektronische Unterschrift) oder über ein anderes Kommunikationsmittel abgegeben. Wird
eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten, die vorher in einem Beschluss des
Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

8.6. Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail (ohne elektronische Un-

terschrift) einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.

8.7.  Jeder  Geschäftsführer  kann  an  einer  Sitzung  per  Telefonkonferenz,  Videokonferenz  oder  durch  jedes  andere

ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, unter der Bedingung, dass die an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführer
sich miteinander verständigen können. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des Geschäftsführerrates per Telefon-
oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel teilnimmt, gilt als persönlich erschienen.

8.8. Beschlüsse können nur gefasst werden und der Geschäftsführerrat ist nur dann handlungsfähig, wenn mindestens

die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

8.9. Die Beschlüsse jeder Sitzung des Geschäftsführerrats werden entweder vom Vorsitzenden oder von zwei Ge-

schäftsführern  unterzeichnet.  Kopien  oder  Auszüge  dieser  Beschlüsse,  welche  bei  Gerichtsverfahren  oder  sonstigen
Anlässen vorgelegt werden können, sind vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

175044

L

U X E M B O U R G

8.10. Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch auf schriftlichem Wege wirksam gefasst werden wenn sie von

allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet werden. Derartige Unterschriften können auf einer oder mehreren
Ausführungen in Urschrift oder als Kopie per Fax, Email oder durch ähnliche Kommunikationsmittel erscheinen.

Art. 9. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers/des Geschäftsführerrats.
9.1. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch vorliegende Satzung der Gesell-

schafterversammlung vorbehalten sind, können durch den alleinigen Geschäftsführer / den Geschäftsführerrat getroffen
werden. Der alleinige Geschäftsführer/ der Geschäftsführerrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und
Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes auszuüben.

9.2. Der alleinige Geschäftsführer / der Geschäftsführerrat kann einer oder mehreren Personen, welche nicht unbedingt

Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen, seine Befugnis zur Ausführung der täglichen Geschäfte der Gesellschaft
übertragen.

9.3. Ferner kann der alleinige Verwalter/ der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und Son-

dervollmachten über einen begrenzten Zeitraum für Einzelgeschäfte an Dritte erteilen.

Art. 10. Vertretung. Unter allen Umständen ist die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen

Geschäftsführers, oder durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers oder der Unterschrift der, gemäß Artikel
9.2 und 9.3 mit der Zeichnungsbefugnis ausgestatteten Person, gebunden.

Art. 11. Haftung der Geschäftsführer.  Die  Geschäftsführer  haften  nicht  persönlich  für  im  Rahmen  ihrer  Funktion

ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten, vorausgesetzt, die Verbindlichkeit entspricht
dem Gesetz und der Satzung.

III. Eigentum der Anteile

Art. 12. Stimmrechte.
12.1. Jeder Anteil verleiht seinem Eigentümer eine Stimme.
12.2. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile an Gesellschafterversamm-

lungen teilnehmen.

Art. 13. Befugnisse.
13.1. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ist mit sämtlichen Vollmachten und Befugnissen

ausgestattet, die gemäß dem Gesetz oder vorliegender Satzung an die Gesellschafterversammlung übertragen wurden.

13.2. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann/können beschließen, dass die Abschlüsse

und Tätigkeiten der Gesellschaft unter Aufsicht eines oder mehrerer zugelassener Wirtschaftsprüfer erstellt werden,
welcher/welche nicht unbedingt Gesellschafter sein muss/müssen. Soweit die Gesellschaft mehr als 25 (fünfundzwanzig)
Gesellschafter zählt, sind ein oder mehrere zugelassene Wirtschaftsprüferprüfer zu bestellen. Honorar und Laufzeit des
Mandats für jene Wirtschaftsprüfer werden von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung fest-
gelegt.

Art. 14. Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters.
14.1. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden entweder schriftlich gefasst oder in einem Protokoll nie-

dergelegt.

14.2. Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter werden entweder schriftlich abgefasst oder

in  einem  Protokoll  schriftlich  niedergelegt,  mit  Ausnahme  der  Verträge  die  sich  auf  übliche  Geschäftstätigkeiten  der
Gesellschaft beziehen, die unter üblichen Marktbedingungen abgeschlossen werden.

Art. 15. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.
15.1. Gemeinschaftliche Beschlüsse der Gesellschafter können entweder im Verlauf einer Gesellschafterversammlung

oder schriftlich gefasst werden, soweit die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter zählt. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den genauen Wortlaut der jeweils zu verabschiedenden Beschlüsse oder Entscheidungen
und gibt seine Stimme schriftlich ab. Die jeweiligen Unterschriften der Gesellschafter können auf einer oder auf mehreren
Ausfertigungen im Original oder in Form von Kopien per Fax, Email oder anderer Kommunikationsmittel erscheinen.

15.2. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann gültig, wenn sie von der Mehrheit der Gesellschafter

angenommen werden, welche mehr als die Hälfte des Stammkapitals hält. Änderungen des Gesellschaftsvertrags bedürfen
allerdings der Zustimmung einer Dreiviertelmehrheit des Stammkapitals.

VI. Geschäftsjahr, Jahresabschlüsse, Ergebniszuweisungen

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines

jeden Jahres.

Art. 17. Jahresabschlüsse. Zum Ende eines jeweiligen Geschäftsjahres werden die Abschlussunterlagen der Gesellschaft

erstellt; in diesem Zusammenhang müssen der alleinige Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat eine Bestandsauf-
nahme vornehmen, in welcher der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft festgelegt wird.

175045

L

U X E M B O U R G

Die Bestandsaufnahme und die Abschlussunterlagen stehen jedem Gesellschafter am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht-
nahme zur Verfügung.

Art. 18. Gewinnverteilung.
18.1. Der Nettogewinn der Gesellschaft entspricht dem in den Jahresabschlussunterlagen ausgewiesenen Bruttogewinn

abzüglich Gemeinkosten, Abschreibungen und Aufwendungen.

18.2. In jedem Jahr ist ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft solange einer

gesetzlichen Rücklage zuzuweisen, solange die Rücklage sich auf zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft
beläuft. Sobald die gesetzliche Rücklage unter diese 10%-Schwelle fällt, wird die jährliche Rücklage wieder zwingend bis
zu dem Zeitpunkt an dem eine gesetzliche Rücklage von 10% erreicht worden ist.

18.3. Der dann verbleibende Betrag des Nettogewinns kann gemäß Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der

Gesellschafterversammlung im Verhältnis  zu  den  jeweils  gehaltenen Anteilen  an  den/die  Gesellschafter  ausgeschüttet
werden.

18.4. Zwischendividenden können, in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Gesetztes an den/die Gesellschafter

ausschüttet werden.

VII. Auflösung, Liquidation

Art. 19. Auflösung - Liquidation.
19.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ist die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren vorzuneh-

men, welcher/welche nicht notwendigerweise Gesellschafter sein muss/müssen und durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung zu bestellen ist/sind, wobei die Gesellschafterversammlung auch dessen/deren Befugnisse und Honorare
festlegt. Soweit keine anderweitigen Regelungen getroffen werden, stehen den Liquidatoren die weitestgehenden Befu-
gnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu.

19.2. Die Liquidationserlöse können im Verhältnis zu den jeweils gehaltenen Anteilen an der Gesellschaft an den/die

Gesellschafter ausgeschüttet werden.

VIII. Allgemeine Bestimmungen

Art. 20. Für sämtliche Angelegenheiten, die in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelt sind, gilt das Gesetz.

Art. 21. Diese Satzung wurde auf Englisch aufgesetzt und von einer deutschen Fassung gefolgt. Im Falle von Unstim-

migkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, gilt die englische Fassung.

<i>Übergangsbestimmungen

Abweichend von Artikel 16 der Satzung, beginnt das erste Geschäftsjahr am Tag der Gründung der Gesellschaft und

endet am 31. Dezember 2014

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Satzung der Gesellschaft ist somit von der erschienenen Partei erstellt worden, und die erschienene Partei hat die

folgenden Geschäftsanteile gezeichnet und vollständig eingezahlt:

Zeichner

Anzahl von

Geschäftsanteilen

Insgesamt

Zeichnungspreis

(EUR)

Zahlung

(EUR)

First Street Topco 1 S.à r.l., vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

12.500,-

12.500,-

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

12.500,-

12.500,-

Der unterzeichnende Notar hat den Nachweis der Zahlung des gesamten Zeichnungspreises erhalten.

<i>Ausgaben, Wertfeststellung

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Belastungen jeglicher Art, die infolge dieser Gründung von der Gesellschaft zu

übernehmen sind, werden auf ca. tausend ein hundert Euro (EUR 1.100,-) geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters

Der Alleinige Gesellschafter hat umgehend die folgenden Beschlüsse verabschiedet:
1. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt und werden für einen unbefristeten

Zeitraum Mitglieder des Geschäftsführungsrats der Gesellschaft:

- Herr Arwed Fischer, geboren in Kemnath (D) am 2. November 1952, geschäftsansässig in Fuggerstraße 26, D-86150

Augsburg; und

- Dr. Bernhard Engelbrecht, geboren in München (D) am 21. Dezember 1967, geschäftsansässig in 25a, Boulevard

Royal, L-2449 Luxemburg.

175046

L

U X E M B O U R G

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde

auf Wunsch der vorgenannten Vertreterin der erschienenen Partei in deutscher Sprache, gefolgt von einer englischen
Fassung,  erstellt  wurde.  Auf  Wunsch  derselben  Vertreterin  soll  im  Falle  von  Unvereinbarkeiten  bzw.  Abweichungen
zwischen dem deutschen und dem englischen Text die deutsche Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER URKUNDE aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Vertreterin der Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

It follows the English translation

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of October.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

First Street Topco 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and

existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, Rue Beck, L-1222 Lux-
embourg and in course of registration with the Luxembourg Trade and Companies Registry, represented by its managers,

hereby duly represented by Mrs Laurence Heinen, employee, residing professionally at 35, Avenue Monterey, L-2163

Luxembourg pursuant to a proxy given under private seal in Luxembourg on 23 October 2014.

Said proxy, after being initialed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to

and registered with the present deed.

The appearing party has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a private limited

liability company under the name of First Street A S.à r.l. which is hereby established as follows:

IV. Form, Name, Duration, Registered Office

Art. 1. Form and Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the

name of First Street A S.à r.l. which shall be governed by the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(the “Company Law”), as well as by these articles of incorporation (hereafter the “Articles”).

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 3. Registered Office.
3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
3.2. It may be transferred within the municipality by decision of the sole manager or the board of managers, as the

case may be.

3.3. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the sole shareholder

or the general meeting of the shareholders, as the case may be, which shall be adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.

3.4. Branches or other offices of the Company may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

V. Purpose of the Company

Art. 4. Purpose.
4.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, devel-
opment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

4.2. The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial

enterprises.

4.2. The purpose of the Company includes in particular the acquisition, holding, development, sale, management and/

or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating
to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having
as principal object the acquisition, development, sale, management and/or lease of immovable properties.

4.3. The Company may in particular:
- borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited

to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, convertible
or not, or the use of financial derivatives or otherwise, except by way of a public offer;

- enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the

Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;

- in favor of its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, or any company directly or

indirectly controlled by the shareholder(s) of the Company (hereafter referred to as the “Affiliated Company”): (i) grant

175047

L

U X E M B O U R G

any assistance, advance, lend, deposit money or give credit or subscribe to or purchase any debt instrument issued by
any Luxembourg or foreign Affiliated Company, with or without security; (ii) enter into any guarantee, pledge or any
other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking,
property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations
of the Company and of any Affiliated Company, within the limits of any applicable legal provision; and

- enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing

agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services,
selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in relation
to its purpose;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be carrying on a

trade or to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

4.4. The Company may further act as a general or limited partner with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar corporate structures.

4.5. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-

plishment of its purpose.

III. Capital and Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1. The Company's subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented

by one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, fully paid-in.

5.2. The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision

of the general meeting of the shareholders, as the case may be, adopted in the manner required for the amendment of
the Articles.

5.3. The Company may redeem its own shares, within the limits set forth by the Company Law.

Art. 6. Shares.
6.1. All shares are in registered form and recorded in a shareholders' register in accordance with the Company Law.

The ownership of shares is established by registration in said register.

6.2. The Company will recognize only one holder per share. Co-owners shall appoint a sole person to represent them

towards the Company.

6.3. The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder shall

not lead to the dissolution, liquidation or similar termination of the Company.

6.4. Each share entitles its holder to partake in the Company’s assets and profits prorata to the number of outstanding

shares.

6.5. Shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares must be recorded by a notarial or private

deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company
or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Luxembourg civil Code.

6.6.  Shares  may  not  be  transferred  inter  vivos  to  non-shareholders  unless  a  general  meeting  of  the  shareholders

representing at least three-quarters of the Company’s share capital shall have agreed thereto.

6.7. In the event of death, the transfer of the shares of the deceased shareholders to non-shareholders is subject to

the prior approval of the general meeting of shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval
is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

IV. Management

Art. 7. Management.
7.1. The Company is managed by one or several managers appointed by the sole shareholder or the general meeting

of shareholders, as the case may be, which sets the term of its/their office. A manager does not need to be a shareholder.

7.2. A manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or the

general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 8. Decisions of the managers.
8.1. If several managers are appointed, they shall form a board of managers.
8.2. The board of managers shall meet as often as the Company’s so requires or upon request of any manager, at the

place indicated in the convening notice. All the meetings of the board of managers shall take place in the Grand Duchy
of Luxembourg.

8.3. The board of managers shall choose among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does

not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, in his/her/its absence, the board of managers shall,
at the majority of their votes, appoint another manager as chairman pro tempore.

175048

L

U X E M B O U R G

8.4. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to managers twenty-four (24) hours at least

in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the circumstances
of the emergency shall be mentioned in the convening notice.

8.5. No convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed of the agenda of the meeting. The notice may
be waived by the written consent of each member of the board of managers, such consent being given in original, fax or
electronic mail (without electronic signature) or any other communication means. No convening notice shall be required
for a meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

8.6. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager of the Company

as his proxy in writing, by fax or electronic mail (without electronic signature) or any other similar means of communi-
cation.

8.7. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference or other

communication means allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

8.8. The board of managers can deliberate or act only if at least a majority of the managers is present or represented

at the meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

8.9. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed either by the chairman of the board of

managers or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or two managers.

8.10. Written resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held by the board of managers. Such signatures may appear on a single or several counterpart
(s) in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.

Art. 9. Powers of the manager(s).
9.1. All powers not expressly reserved by the Company Law or the Articles to the general meeting of shareholders

fall within the competences of the sole manager or the board of managers, as the case may be. The sole manager or the
board of managers, as the case may be, shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company's purpose.

9.2. The sole manager or the board of managers, as the case may be, is authorized to delegate the daily management

of the Company to one or several persons, who do not need to be managers.

9.3. Special and limited powers may be delegated by the sole manager or the board of managers, as the case may be,

for determined matters and within a limited period of time to one or several persons, who do not need to be managers.

Art. 10. Representation. The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or by

the signature of any manager acting individually or the signature of any person to whom a signatory power shall be
delegated in accordance with article 9.2. and 9.3. of these Articles.

Art. 11. Manager’s liability. A manager assumes, by reason of his mandate, no personal liability in relation to any

commitment validly made by him in the name of the Company, provided such commitment complies with the Company
Law and the Articles.

V. Shareholding

Art. 12. Voting Rights.
12.1. Each share entitles its holder to one vote.
12.2. Each shareholder may participate in the general meeting of the shareholders irrespective of the number of shares

he owns.

Art. 13. Powers.
13.1. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, assumes all the powers con-

ferred to the general meeting of shareholders by the Company Law or these Articles.

13.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, may decide that the financial

statements and operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, who do not need
to be shareholders. They must appoint one or several statutory auditors if there is more than 25 (twenty-five) share-
holders in the Company. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall fix their
remuneration and term of their mandate.

Art. 14. Decisions of the sole shareholder.
14.1. Decisions of the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes.
14.2. Contracts entered into between the Company and the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or

recorded in minutes, except if such contracts relate to usual business operations of the Company entered into normal
market conditions.

175049

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Decisions of the general meeting of shareholders.
15.1. Collective decisions of the shareholders may be taken either by holding a general meeting of shareholders or by

written resolutions, if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25). In such event, each
shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his
vote in writing. Each shareholder’s signature may appear on a single or several counterpart(s), in original or copy delivered
by fax, electronic mail or any other communication means.

15.2. The decisions of the general meeting of shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by a

majority of shareholders owning more than half of the share capital. However, an amendment to the Articles requires
the approval of a majority of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

VI. Financial year, annual accounts, allocation of profits

Art. 16. Financial year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day

of December of each year.

Art. 17. Annual accounts. Each year, with reference to the end of the Company’s financial year, the Company’s accounts

are drawn up, and the sole manager or the board of managers, as the case may be, shall prepare an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities. The inventory and the accounts shall be available for inspection by each
shareholder at the Company's registered office.

Art. 18. Allocation of profits.
18.1. The net profit of the Company is equal to the gross profit as stated in the annual accounts less the general

expenses, amortization and expenses.

18.2. Each year, an amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory

reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital. Whenever the statutory reserve
falls below this ten per cent threshold, the yearly allocation shall become compulsory again until this ten per cent statutory
reserve has been restored.

18.3. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding

in the Company by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

18.4. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions set forth by the Company Law.

VII. Dissolution, Liquidation

Art. 19. Dissolution - Liquidation.
19.1. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or several liquidators who

do not need to be shareholders, appointed by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders,
as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the
most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

19.2. The liquidation proceeds may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in

the Company.

VIII. General Provisions

Art. 20. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Company Law.

Art. 21. These Articles have been drawn up in English followed by a French version. In the event of discrepancy between

the English and the French version, the English version shall prevail.

<i>Transitory provisions

By exception to Article 16 of these Articles, the first accounting year shall start on the day of incorporation of the

Company and end on 31 December 2014.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party

has subscribed and fully paid up the following shares:

Subscriber

Number

of

shares

Aggregate

subscription

price (EUR)

Payment

(EUR)

First Street Topco 1 S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

12,500.-

12,500.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

12,500.-

12,500.-

Evidence of the payment of the total subscription price has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).

175050

L

U X E M B O U R G

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has immediately taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company and shall be members of the Board of Managers

of the Company for an undetermined period of time:

- Mr. Arwed Fischer, born in Kemnath (Germany) on 2 November 1952, residing professionally in Fuggerstraße 26,

D-86150 Augsburg; and

- Dr. Bernhard Engelbrecht, born in Munich (Germany) on 21 December 1967, residing professionally in 25a, Boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in German followed by an English version. On request of the same
proxyholder and in case of divergences between the German and the English text, the German version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party’s proxyholder, known to the notary by name, first name, civil

status and residence, the appearing party’s proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

Gezeichnet: Heinen, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49732. Reçu soixante-quinze (75.-)

euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxemburg, den 5. November 2014.

Référence de publication: 2014171924/485.
(140196902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Magnetar Intermediate Solar Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.742,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 187.361.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of October.
Before US Maître BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Magnetar Solar Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg,
and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 187.327 (hereafter the “Appearing
Company”), here represented by Mrs. Peggy Simon, private employee, with professional address at 9 Rabatt, L-6475
Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the Appearing Company and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

I. The Appearing Company is the current sole shareholder of the private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) established in Luxembourg under the name of “Magnetar Intermediate Solar Luxembourg S.à r.l.” (he-
reafter the “Company”), having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 187.361, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, Maître Henri Beck, dated May 23 

rd

 , 2014, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations

number 2059, dated August 5 

th

 , 2014, and whose articles have been lastly amended pursuant to a deed dated June 11

th

 , 2014, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number 2221, dated August 21 

st

 , 2014.

II. The Company’s share capital is set at ten thousand seven hundred and forty-two British Pounds (GBP 10,742.-)

represented by ten thousand seven hundred and forty-two (10,742) shares with a nominal value of one British Pound
(GBP 1.-) each, all of which are fully paid up.

III. The Appearing Company requested the public notary to enact the following:
Whereas, through the above-mentioned deed dated June 11 

th

 , 2014, registered in Echternach, on the 13 

th

 of June

2014, ECH/2014/1121, deposited with the Luxembourg Trade and Companies' Register on the 18 

th

 of June 2014, refe-

rence L140100821, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number 2221, dated August 21

st

 , 2014 (hereafter the “Deed”), the share capital of the Company has been converted from US Dollar (USD) into British

Pound (GBP) with effect as of the execution date of such Deed, so that the Company’s initial share capital of eighteen

175051

L

U X E M B O U R G

thousand US Dollars (USD 18,000.-) was replaced by a share capital of ten thousand, seven hundred and forty-two British
Pounds (GBP 10,742.-), being split as follows:

- Ten thousand six hundred and thirty-five (10,635) Ordinary Shares with a nominal value of one British Pound (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up; and

- One hundred and seven (107) Class A Shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each, all subscribed

and fully paid up.

Whereas, the Appearing Company wishes to rectify the effective date of the Deed so as to make it retrospective as

of May 23 

rd

 , 2014, i.e., as of the Company’s incorporation date.

IV. In accordance with the above, the Appearing Company resolved to rectify the article 6 of the Company’s articles

of incorporation with retrospective effect as of May 23 

rd

 , 2014 and to give it henceforth the following wording as of

May 23 

rd

 , 2014:

“ Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at ten thousand seven hundred and forty-two British Pounds (GBP

10,742.-) represented by ten thousand seven hundred and forty-two (10,742) shares with a nominal value of one British
Pound (GBP 1.-), which are divided into:

- Ten thousand six hundred and thirty-five (10,635) Ordinary Shares with a nominal value of one British Pound (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up; and

- One hundred and seven (107) Class A Shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each, subscribed

and fully paid up.

The terms defined in this Article 6, wherever appearing in the Articles shall have the meaning set forth below:
- “Ordinary Shares” means Ordinary Shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each in the share

capital of the Company.

- “Ordinary Shareholder” means any Shareholder of the Company, which holds at any time Ordinary Shares of the

Company.

- “Class A Shares” means Class A Shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each in the share capital

of the Company.

- “Class A Shareholder” means any Shareholder of the Company, which holds at any time Class A Shares of the

Company.

- “Shareholders” means all the shareholders of the Company, i.e., shareholders holding at any time Ordinary Shares

and/or Class A Shares.

- “Portfolio A” means the reference to an assigned investment.
All the shares can be issued with or without a share premium, subject to legal requirements and the provisions of the

present Articles. Except otherwise provided, any amount of share premium which has been or shall be paid in addition
to the nominal or par value, as the case may be, of the Ordinary Shares shall remain attached to the Ordinary Shares and
shall be allocated to a special reserve to be designated as the Ordinary Shares Premium Account. This Ordinary Shares
Premium Account shall be used to provide for the payment of the Ordinary Shares to which such account is attached
and which the Company may redeem, to offset any net realised losses, to make distributions to the holder(s) of such
Ordinary Shares or to allocate funds to the legal reserve.

Except otherwise provided, any amount of share premium which has been or shall be paid in addition to the nominal

or par value, as the case may be, of any share belonging to the Class A Shares shall remain attached to the Class A Shares
and shall be allocated to a special reserve to be designated as the Class A Shares Premium Account. This Class A Shares
Premium Account shall be used to provide for the payment of the Class A Shares to which such account is attached and
which the Company may redeem, to offset any net realised losses, to make distributions to the holder(s) of such Class
A Shares or to allocate funds to the legal reserve.”

V. The Appearing Company resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the rectification

related to the retrospective share capital conversion as of May 23 

rd

 , 2014.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above Appearing

Company, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same Appearing Company and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the Appearing Company, who is known to the notary by her

Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L’an deux mille quatorze, le vingt-neuf octobre.

175052

L

U X E M B O U R G

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Magnetar Solar Luxembourg S.à r.l, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enre-
gistrée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  du  Luxembourg  sous  le  numéro  B  187.327  (ci-après  la
«Comparante»), représentée par Mme Peggy Simon, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 9 Rabatt,
L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la Comparante et le notaire instru-

mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

I. La Comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de «Magnetar Intermediate Solar Luxembourg S.à r.l.» (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg section B, sous le numéro 187.361, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 23 mai 2014,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2059, en date du 5 août 2014, et dont les statuts ont
été modifiés dernièrement par un acte en date du 11 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2221, en date du 21 août 2014.

II. Le capital social de la Société est fixé à dix mille sept cent quarante-deux Livres Sterling (10.742,- GBP) représenté

par dix mille sept cent quarante-deux (10.742) parts sociales ayant une valeur nominale d’une Livre Sterling (1,- GBP)
chacune, et étant toutes entièrement libérées.

III. La Comparante a requis le notaire d’acter ce qui suit:
Attendu que, par le biais de l’acte susmentionné daté du 11 juin 2014, enregistré à Echternach, le 13 juin 2014, ECH/

2014/1121, déposé auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 18 juin 2014, référence
L140100821, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2221, en date du 21 août 2014 (ci-
après l’»Acte»), le capital social de la Société a été converti de Dollars américains (USD) en Livres Sterling (GBP) avec
effet à la date de signature de l’Acte, de sorte que le capital social initial de la Société d’un montant de dix-huit mille
Dollars américains (18.000,- USD) a été remplacé par un capital social de dix mille sept cent quarante-deux Livres Sterling
(10.742,- GBP), étant divisé comme suit:

- Dix mille six cent trente-cinq (10.635) Parts Sociales Ordinaires avec une valeur nominale d’une Livre Sterling (1,-

GBP) chacune, et étant toutes entièrement libérées; et

- Cent sept (107) Parts Sociales de Classe A avec une valeur nominale d’une Livre Sterling (1,- GBP) chacune, et étant

toutes entièrement libérées.

Attendu que, la Comparante souhaite rectifier la date effective de l’Acte pour lui donner un effet rétroactif au 23 mai

2014, c’est-à-dire avec effet à la date de constitution de la Société.

IV. Suite à ce qui précède, la Comparante a décidé de rectifier l’article 6 des statuts de la Société avec un effet rétroactif

au 23 mai 2014 et de lui donner la teneur suivante avec effet rétroactif au 23 mai 2014:

« Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à dix mille sept cent quarante-deux Livres Sterling (10.742 GBP)

représenté par dix mille sept cent quarante-deux (10.742) parts sociales avec une valeur nominale d’une Livre Sterling
(1,- GBP), et divisé en:

- Dix mille six cent trente-cinq (10.635) Parts Sociales Ordinaires avec une valeur nominale d’une Livre Sterling (1,-

GBP) chacune, entièrement souscrites et libérées; et

- Cent sept (107) Parts Sociales de Classe A avec une valeur nominale d’une Livre Sterling (1,- GBP) chacune, entiè-

rement souscrites et libérées.

Les notions définies dans cet Article 6 et figurant dans les Statuts ont la signification suivante:
- «Parts Sociales Ordinaires» désigne les Parts Sociales Ordinaires avec une valeur nominale d’une Livre Sterling (1,-

GBP) chacune dans le capital social de la Société.

- «Associé Ordinaire» signifie tout Associé de la Société qui détient des Parts Sociales Ordinaires de la Société.
- «Parts Sociales de Classe A» désigne les Parts Sociales de Classe A avec une valeur nominale d’une Livre Sterling (1,-

GBP) chacune dans le capital social de la Société.

- «Associé de Classe A» signifie tout Associé de la Société qui détient des Parts Sociales de Classe A de la Société.
- «Associés» signifie tous les associés, c’est-à-dire les associés détenant en tout temps des Parts Sociales Ordinaires

et/ou des Parts Sociales de Classe A.

- «Portefeuille A» désigne la référence à un investissement correspondant.
Toutes les parts sociales peuvent être émises avec ou sans prime d’émission, conformément aux dispositions légales

et statutaires. Sauf disposition contraire, tout montant de prime d’émission qui a été ou doit être payé en complément
de la valeur nominale ou de la valeur au pair, selon le cas, des Parts Sociales Ordinaires, doit rester attaché aux Parts
Sociales Ordinaires et doit être alloué à une réserve spéciale désignée comme le Compte de Prime d’Emission des Parts
Sociales Ordinaires. Ce compte peut être utilisé pour effectuer le remboursement des Parts Sociales Ordinaires aux-

175053

L

U X E M B O U R G

quelles ce compte se rattache et que la Société peut racheter, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer
des distributions aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Sauf disposition contraire, tout montant de prime d’émission qui a été ou doit être payé en complément de la valeur

nominale ou de la valeur au pair, selon le cas, d’une part sociale appartenant aux Parts Sociales de Classe A, doit rester
attaché aux Parts Sociales de Classe A et doit être alloué à une réserve spéciale désignée comme le Compte de Prime
d’Emission des Parts Sociales de Classe A. Ce compte peut être utilisé pour effectuer le remboursement des Parts Sociales
de Classe A auxquelles ce compte se rattache et que la Société peut racheter, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux détenteurs de Parts Sociales de Classe A, ou pour affecter des fonds à la réserve
légale.»

V. La Comparante a décidé de modifier le registre des associés de la Société de façon à refléter la rectification relative

à la conversion rétroactive du capital social au 23 mai 2014.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la société comparante

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même société comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la

version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des

présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la Comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 31 octobre 2014. Relation: ECH/2014/2070. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 04 novembre 2014.

Référence de publication: 2014170536/172.
(140194670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

Panattoni Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 162.001.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-four October.
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary public, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PG Europe S.à r.l, a limited liability company existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at, 203

route d'Esch, L 1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company register under the number 184
024,

here represented by Mrs Catherine DELSEMME, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the proxy-holder and the notary, will remain annexed to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, is the sole shareholder of Panattoni Germany S.à r.l. (hereinafter

the «Company»), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 162.001, having its registered
office at L-1471 Luxembourg, 203, Route d'Esch, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing
in  Junglinster  on  22  June  2011,  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  number  2180  of
September 16t, 2011 and amended from time to time.

The sole shareholder representing the entire share capital takes the following resolutions:

<i>First Resolution

The sole shareholder resolves to amend article 13 of the Company's articles of incorporation, which shall now read

as follows:

“ Art. 13. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The

Company will be bound in all circumstance by the signature of the sole manager.

175054

L

U X E M B O U R G

In case of several managers, the Company will be managed by a board of managers composed of managers A and

managers B who need not necessarily be shareholders.

The Company will be bound by the joint signatures of either:
- at least one Manager A and one Manager B
- or two Managers B.
The sole manager or of the board of managers may, grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument to one or more persons.

The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason ("cause légiti-

me").”

<i>Second Resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Panattoni Luxembourg Directorship S.à r.l, and Mr. Robert

Dobrzycki, with effect as from the date of the present resolution and the sole shareholder resolves to grant full discharge
for their mandates.

<i>Third Resolution

The sole shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited period:

<i>Manager A:

- Mr Edward Francis Lyons III, chief operating officer, born in San Francisco (USA), on 7 

th

 March 1972, residing at

Top Floor, 42 Gayton Road, NW3 1TU London, United Kingdom.

<i>Managers B:

- Mr Mark J Connor, financial consultant, born 13 

th

 August 1966 in New-York (USA), residing at 200, Central Park

South - Suite 10 P- NY 10015- New York - USA; and

- Mrs Catherine Delsemme, employee, born on 16 

th

 January 1979, in Verviers (Belgium), professionally residing at

203, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the proxy-holder, known to the notary by

his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-duché de Luxembourg.

A comparu:

PG Europe S.à r l, une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant selon le Droit du Luxembourg,

ayant son siège sociale 203 route d'Esch, L 1471 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B184.024

ici représentée par Madame Catherine DELSEMME, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, signée ne varietur par la mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, est l'associée unique de Panattoni Germany S.à.r.l. (ci-après la

«Société»), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon le droit luxembourgeois, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.001, ayant son siège social au Route d'Esch, 203,
L-1471 Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en
date du 22 Juin 2011, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2180 du 16 Septembre
2011.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 13 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante

175055

L

U X E M B O U R G

« Art. 13. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
La Société sera liée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique ou de tout membre du conseil de

gérance.

En cas de pluralité de gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, dont les membres peuvent être

associés ou non. Le conseil de gérance sera composé de Gérants A et de de Gérants B.

La Société sera liée en toutes circonstances par la signature conjointe soit:
- d'au moins un Gérant A et un Gérant B ou
- deux Gérants B
Le gérant unique ou le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique

ou sous seing privé.

Les gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.»

<i>Deuxième Résolution

L'associé unique accepte la démission de Panattoni Luxembourg Directorship S.à r.l et Mr. Robert Dobrzycki, en tant

que gérants de la société, avec effet à la date de la présente résolution et leur donne décharge pour leur mandat.

<i>Troisième Résolution

L'associée unique décide de nommer les personnes suivantes comme gérants de la société pour une durée indéter-

minée:

<i>Gérant A

- Monsieur Edward Francis Lyons III, chief operating officer, né à San Francisco (USA), le 7 mars 1972, demeurant à

Top Floor, 42

Gayton Road, NW3 1TU London, United Kingdom.

<i>Gérants B

- Monsieur Mark J Connor, financial consultant, né le 13 août 1966 à New-York (USA) demeurant à 200, Central Park

South - Suite 10 P- NY 10015 - New York - USA; et

- Madame Catherine Delsemme, employée, née le 16 janvier 1979, à Verviers (Belgique), demeurant professionnelle-

ment à 203, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées

approximativement à mille cents euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-

parante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même personne
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, le présent acte notarié a été acté à Luxembourg, au jour indiqué au début du présent document.
Le document ayant été lu et traduit dans une langue connue du mandataire, connue du notaire par son surnom, ses

nom, prénom, état civil et demeure, il a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: Catherine DELSEMME, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2014. Relation GRE/2014/4207. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014170596/121.
(140194888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

Waldtec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 5, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 60.731.

EXTRAIT

Montbrun Révision S.à r.l. a démissionné avec effet immédiat de sa fonction de commissaire aux comptes.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174223/11.
(140199199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

175056


Document Outline

Art d'Eau Lux S.à r.l.

ASA Corporation s.à r.l.

Awadent Lux S.A.

B &amp; B Consulting S.à r.l.

BCF I Global S.à r.l.

Benat Services S.à r.l.

BE Sophia Lux I

BE Sophia Lux II

Brimag A.G.

Browne Holding S.à r.l.

Calilux S.à r.l.

Climate Change Investment I S.A. SICAR

Digihold S.à r.l.

DSM Capital Partners Funds

Fiduciaire Générale de Marnach S.à r.l.

First Street A S.à r.l.

Funckenhaus S.à r.l.

Green European Venture Capital S.A.

Grove Second Unitholder S.à r.l.

Gyrfalcon Capital S.à r.l.

Halcyon European Holdings S.à r.l.

Heraldic LuxCo S.à r.l.

Knight Estate Management S.A.

La Couronne S.A.

Lady Holding S.A.

Langevin Siding S.à r.l.

L'Arancino S.à r.l.

Liberty Properties S.à r.l.

Librairie Diderich

LSP International Holdings S.à r.l.

Lubami Private S.A. SPF

Luciano Barbera Holdings S.à r.l.

Luxembourg Cargo Agency (LCA)

Luxflower SA

Magnetar Intermediate Solar Luxembourg S.à r.l.

Malibu Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Methanex Luxembourg S.à r.l.

Mezzanine Finance S.A.

Minimoyz S.à r.l.

Norbert Boler G.m.b.H.

Oliver Holdings S.A.

Panattoni Germany S.à r.l.

Phiolla S.A.

Phoenix Corporate S.A

Placomar S.à r.l.

Socosme S.A.

Union Financière Immobilière Luxembourgeoise

Waldtec S.A.