logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3407

15 novembre 2014

SOMMAIRE

Ampacet Europe Holding S.à r.l.  . . . . . . . .

163492

Artec Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163529

Assaloca SICAV-SIF, SCA  . . . . . . . . . . . . . .

163492

CBG Alternative Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163491

CBRE Global Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163491

CEES Invest Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163532

CEF (W) SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163492

CEP II Nelson SCSp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163533

CEREP Ashley S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163492

Chevrotine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163493

Chevrotine S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163493

CITIC CWEI Renewables S.C.A.  . . . . . . . .

163493

Compagnie Finance Ponte Carlo S.A.  . . . .

163494

Compagnie Financière et Commerciale du

Parc SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163494

Consulting & Co. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163494

Coppart Holding S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . .

163494

Coprez Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163495

CWEI (Europe) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163495

CWEI (Luxembourg) Energy S.à r.l.  . . . . .

163495

CWEI (Luxembourg) Investment Manage-

ment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163496

CWEI (Luxembourg) Power S.à r.l. . . . . . .

163496

D.A.S. Luxemburg Allgemeine Rechts-

schutz-Versicherung S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

163496

Data Genpar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163495

Data Genpar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163497

DCC Euro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163498

DCC Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163490

DCC Funding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163496

Deep Sea Minerals Investment Limited  . .

163497

Demeter Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . .

163493

Destiny Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163493

Deutsche Oel & Gas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

163497

DIF Infra 3 Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .

163494

DISBOLUX (Distribution de Boissons Lu-

xembourg) Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163495

Divisional Funding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

163498

Dundeal (International) 22 S.à r.l.  . . . . . . .

163498

Dundee Realty Acquisitions SCS  . . . . . . . .

163498

Entreprise de Construction G. THOMAS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163497

Global Gate Delta (Lux) 3 . . . . . . . . . . . . . . .

163519

Group George Forrest S.A.  . . . . . . . . . . . . .

163534

Johnson Controls Luxembourg Solutions

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163490

KÖHL Aktiengesellschaft  . . . . . . . . . . . . . . .

163499

Lion Systems S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163515

Partinverd S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163536

Pasteur Hair & Style s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

163536

Precisé S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163536

Prestige Euro-Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . .

163499

Sigma Capital Investments S.A.  . . . . . . . . .

163499

Sopinor Constructions S.A.  . . . . . . . . . . . . .

163490

T.G.D. Théatre Grand-Ducal  . . . . . . . . . . . .

163527

T.S. aerospace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163491

Unicorp Seeds S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163516

163489

L

U X E M B O U R G

Johnson Controls Luxembourg Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 170.591.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 1 

er

 octobre 2014 que:

- Mr. Jérôme D. Okarma a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 1 

er

octobre 2014; et

- Mr. Brian Cadwallader, né le 18 février 1959 à Ohio, Etats-Unis, résidant professionnellement au 5757 N. Green Bay

Avenue, 53209, Glendale, WI, Etats-Unis, a été nommée gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 1 

er

 octobre

2014 et pour une durée indéterminée.

En conséquence de ce qui précède et à compter du 1 

er

 octobre 2014, le conseil de gérance de la Société est composé

des membres suivants:

- Mr. Bruce McDonald, gérant de catégorie A;
- Mr. Brian Cadwallader, gérant de catégorie A;
- Mr. Andrew O'Shea, gérant de catégorie B; et
- Ms. Ingrid Cernicchi, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2014.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014162463/25.
(140184425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Sopinor Constructions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Schifflange, 70, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 150.004.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2014.

Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2014162831/12.
(140185241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

DCC Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.957.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 121.910.

EXTRAIT

La société prend acte de la nouvelle adresse de DCC Treasury Services Limited Luxembourg Branch, représentée par

DCC Treasury Services Limited, associée unique de la Société, à DCC House, Leopardstown Road, Foxrock, Dublin 18,
Irlande.

La société prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Gerard Whyte, gérant de la Société, à DCC House, Leo-

pardstown Road, Foxrock, Dublin 18, Irlande.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Référence de publication: 2014163134/17.
(140185555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

163490

L

U X E M B O U R G

T.S. aerospace, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5481 Wormeldange, 109, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 183.143.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2014.

Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2014162848/12.
(140184864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

CBRE Global Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 122.785.675,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 150.693.

Il est à noter que l'adresse de Madame Becky H. Younger, gérante de type A de la Société, a changé; sa nouvelle adresse

est la suivante:

16941 Bedford Lane, Huntington Beach, Californie 92649, Etats-Unis d'Amérique.

Le 20 octobre 2014.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014163102/14.
(140185521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

CBG Alternative Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 79.966.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «CBG

ALTERNATIVE SICAV», reçu par Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Lu-
xembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché
de Luxembourg), en date du 2 octobre 2014, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 octobre 2014. Relation: EAC/
2014/13688.

- que la société «CBG ALTERNATIVE SICAV» (la «Société»), société d’investissement à capital variable, établie et

ayant son siège social au 28-32, Place de la Gare, L-1916 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 79966,

constituée suivant acte notarié en date du 16 janvier 2001, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

(le «Mémorial») numéro 131 du 20 février 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 9
août 2004, tel que publié au Mémorial , numéro 88 du 1 

er

 février 2005,

se trouve à partir de la date du 2 octobre 2014 définitivement liquidée, l’assemblée générale extraordinaire prémen-

tionnée faisant suite à celle du 6 octobre 2009 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise
en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915.
concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront archivés pour une période d’au moins dix ans chez

Société Générale Securities Services Luxembourg, ayant son siège social au 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 21 octobre 2014.

Référence de publication: 2014163101/28.
(140186014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

163491

L

U X E M B O U R G

CEF (W) SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 5, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 103.686.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 3 septembre 2014 que le mandat de

Deloitte Audit, en sa qualité de réviseur d'entreprises de la Société, a été reconduit avec effet immédiat et jusqu'à l'as-
semblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
CEF (W) S.A.

Référence de publication: 2014163106/14.
(140186121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Assaloca SICAV-SIF, SCA, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 163.712.

Le bilan audité au 31 décembre 2013 tel qu'approuvé lors de l’assemblée générale tenue en date du 20 octobre 2014

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le fonds
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014162989/14.
(140186001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Ampacet Europe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 586.092,00.

Siège social: L-3451 Dudelange, Z.I. Riedgen.

R.C.S. Luxembourg B 165.277.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 30 septembre 2014 que:
1. Monsieur Robert DE FALCO a démissionné avec effet au 30 septembre 2014 en tant que gérant de catégorie B de

la Société;

2. Monsieur Yves CARETTE, né le 3 novembre 1954 à Uccle, Belgique, résidant professionnellement au 208 Soundview

Avenue, Mamaroneck, NY 10543, Etats-Unis, est nommé avec effet au 30 septembre 2014 gérant de catégorie B de la
Société pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014162981/16.
(140185719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

CEREP Ashley S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 130.424.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Le présent document remplace celui déposé sous le numéro L140060477
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014163107/10.
(140185833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

163492

L

U X E M B O U R G

Chevrotine S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 58.381.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 août 2014.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.
Monsieur Jean-Marie LEGENDRE et les sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. sont réélus Adminis-

trateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric HERREMANS est réélu Commissaire aux Comptes pour une
nouvelle période de 6 ans.

<i>Pour la société
CHEVROTINE S.A., SPF

Référence de publication: 2014163108/14.
(140185660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Chevrotine S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 58.381.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014163109/10.
(140185661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

CITIC CWEI Renewables S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 178.748.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil de Gérance du 20 octobre 2014 que le siège de la société est transféré de son

adresse actuelle au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 21/10/2014.

Référence de publication: 2014163110/12.
(140186311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Demeter Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 83.440.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014163140/9.
(140185578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Destiny Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 77.236.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014163143/9.
(140185982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

163493

L

U X E M B O U R G

Compagnie Finance Ponte Carlo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 54.516.

Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCE PONTE CARLO S.A. (EN LIQUIDATION)
Robert REGGIORI
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2014163112/12.
(140186019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Compagnie Financière et Commerciale du Parc SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 45.257.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 20 octobre 2014

Est nommé président du conseil d'administration, la durée de son mandat sera fonction de celle de son mandat d'ad-

ministrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit
le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles:

- M. Benoît de Froidmont, demeurant au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014163113/13.
(140185620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Consulting &amp; Co. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 139.664.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014163114/10.
(140185992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Coppart Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 76.740.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014163115/10.
(140185234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

DIF Infra 3 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 168.503.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014163147/9.
(140186026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

163494

L

U X E M B O U R G

Coprez Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 131.698.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRIVATE INVESTMENT TRUST SARL
Signature

Référence de publication: 2014163116/11.
(140186213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

CWEI (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 164.928.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration du 20 octobre 2014 que le siège de la société est transféré de

son adresse actuelle au 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 21/10/2014.

Référence de publication: 2014163117/12.
(140186272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

CWEI (Luxembourg) Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 180.307.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil de gérance du 20 octobre 2014 que le siège de la société est transféré de son

adresse actuelle au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Référence de publication: 2014163118/12.
(140186259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Data Genpar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 169.852.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014163123/10.
(140186083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

DISBOLUX (Distribution de Boissons Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 12, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 104.095.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014163149/9.
(140186161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

163495

L

U X E M B O U R G

CWEI (Luxembourg) Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 178.710.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil de gérance du 20 octobre 2014 que le siège de la société est transféré de son

adresse actuelle au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Référence de publication: 2014163119/12.
(140186232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

CWEI (Luxembourg) Power S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue de Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 180.321.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil de gérance du 20 octobre 2014 que le siège de la société est transféré de son

adresse actuelle au 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 21/10/2014.

Référence de publication: 2014163120/12.
(140186300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

D.A.S. Luxemburg Allgemeine Rechtsschutz-Versicherung S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 9, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 41.395.

La liste de signatures autorisées a fait l'objet d'un dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher.

Jacques CASTEL
<i>Notaire

Référence de publication: 2014163121/13.
(140186473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

DCC Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 37.712.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 121.909.

EXTRAIT

La société prend acte de la nouvelle adresse de DCC Financial Services Ireland Limited Luxembourg Branch, repré-

sentée par DCC Financial Services Ireland Limited, associée unique de la Société, à DCC House, Leopardstown Road,
Foxrock, Dublin 18, Irlande.

La société prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Gerard Whyte, gérant de la Société, à DCC House, Leo-

pardstown Road, Foxrock, Dublin 18, Irlande.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Référence de publication: 2014163136/17.
(140185556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

163496

L

U X E M B O U R G

Data Genpar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 169.852.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014163124/10.
(140186084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Deep Sea Minerals Investment Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 169.135.

EXTRAIT

Par résolution écrite de l'associé unique en date du 7 août 2014, l'associé unique a décidé d'adopter les résolutions

suivantes:

1. La démission de Monsieur Philip Mun Ho Tai de son mandat de gérant de catégorie A a été acceptée par l'associé

unique.

2. Monsieur Wen Hua Li, né le 20 septembre 1986 à Guangdong, Chine, avec adresse au Fiat B, 9 

th

 Floor, Tower 1,

Xin Fu Li, Luo Wo District, 7518000 Shenzen, Chine, a été nommé en tant que gérant de catégorie A de la société avec
effet immédiat et pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2014163125/20.
(140185541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Deutsche Oel &amp; Gas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 179.408.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 29. August 2014

Paul DECKER
<i>Der Notar

Référence de publication: 2014163127/12.
(140185654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Entreprise de Construction G. THOMAS, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.000,00.

Siège social: L-8352 Dahlem, 12, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 12.334.

Le siège social de l'associé unique, ASFERIS S.A., est désormais sis au:
2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Référence de publication: 2014163155/12.
(140185586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

163497

L

U X E M B O U R G

Divisional Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.654.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 183.978.

EXTRAIT

La société prend acte de la nouvelle adresse de DCC Plc, associée unique de la Société, à DCC House, Leopardstown

Road, Foxrock, Dublin 18, Irlande.

La société prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Gerard Whyte, gérant de la Société, à DCC House, Leo-

pardstown Road, Foxrock, Dublin 18, Irlande.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Référence de publication: 2014163129/16.
(140186333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Dundeal (International) 22 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 9A, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 177.948.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Dundeal (International) 22 S.à r.l.
Dream Global Advisors Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2014163130/11.
(140185564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Dundee Realty Acquisitions SCS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 166.586.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Dundee Realty Acquisitions SCS
Dream Global Advisors Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2014163131/11.
(140185559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

DCC Euro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.512.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 166.087.

EXTRAIT

La société prend acte de la nouvelle adresse de Sercom Solutions Property Limited, associée unique de la Société, à

DCC House, Leopardstown Road, Foxrock, Dublin 18, Irlande.

La société prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Gerard Whyte, gérant de la Société, à DCC House, Leo-

pardstown Road, Foxrock, Dublin 18, Irlande.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Référence de publication: 2014163133/16.
(140185557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

163498

L

U X E M B O U R G

Sigma Capital Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 90.335.

EXTRAIT

Les résolutions de l'associé unique ont été prises en date 2 octobre 2014:
1. Acceptation de la démission avec effet immédiat de BMT Management Ltd. du poste d'administrateur de la société;
2. Nomination au poste d'administrateur de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée de Madame

Nina Petrova Daneva, née le 25 avril 1941, avec résidence à Bigla St, Apt. 15, Stolichna obshina, Sofia, Bulgarie.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Référence de publication: 2014164345/14.
(140187102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Prestige Euro-Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 55.263.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014164274/9.
(140186745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

KÖHL Aktiengesellschaft, Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 17, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 43.668.

En date du 12 novembre 2014

KÖHL Aktiengesellschaft S.A.

Entwurf eines Ausgliederungsplans

entsprechend Sektion XVbis (insbesondere Artikel 308bis-3) des Gesetzes über

Handelsgesellschaften vom 15. August 1915 (in der heutigen abgeänderten Fassung).

Loyens &amp; Loeff Sàrl
18-20, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

AUSGLIEDERUNGSPLAN

Die Köhl Aktiengesellschaft S.A. ist eine luxemburgische Aktiengesellschaft (Société anonyme) mit Gesellschaftssitz in

17, Am Scheerleck, L-6868 Wecker, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister in Abteilung B unter
der Nummer 43.668 (die Gesellschaft), gegründet durch notarielle Urkunde vor der Notarin Christine Doerner mit
Amtssitz in Bettemburg am 1. April 1993, veröffentlicht im Amtsblatt Mémorial C, Recueil des sociétés et associations,
Nummer 323 vom 8. Juli 1993. Die Satzung der Köhl Aktiengesellschaft S.A. wurde zuletzt geändert auf Grund notarieller
Urkunde vor dem Notar Jean Seckler mit Amtssitz in Junglinster vom 20. Dezember 2004, veröffentlicht im Amtsblatt
Mémorial C, Recueil des sociétés et associations Nummer 274 vom 26. März 2005.

Der Verwaltungsrat der Köhl Aktiengesellschaft S.A. (der Verwaltungsrat) hat in seiner Sitzung vom 12/11/2014 fol-

genden Ausgliederungsplan angenommen, welcher den Aktionären der Köhl Aktiengesellschaft S.A. (die Aktionäre) im
Rahmen der Abhaltung einer außerordentlichen Aktionärsversammlung zur Zustimmung vorgelegt wird.

1. Übertragung der Teilbetriebe in zwei neue Gesellschaften. Es wird beabsichtigt, die bestehenden Teilbetriebe (bran-

che d'activités) namentlich, [Elektromaschinenbau] und [Elektrotechnik], der Köhl Aktiengesellschaft S.A. (die Ursprungs-
gesellschaft) in zwei neu zu gründende Gesellschaften, die Köhl Antriebstechnik S.à r.l. und die Köhl S.à r.l. (die neuen
Gesellschaften), gemäß den Artikeln 308bis-1, 308bis-2 und 308bis-3 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-
delsgesellschaften  in  seiner  aktuellen  Fassung  (das  HandelsGG)  auszugliedern.  Die  neuen  Gesellschaften  sollen  ihren
Gesellschaftssitz in 17, Am Scheerleck, L-6868 Wecker Großherzogtum Luxemburg haben. Die Ursprungsgesellschaft
wird hierbei weder abgewickelt noch liquidiert. Die Ursprungsgesellschaft erhält als Gegenleistung für die Einbringung
der Teilbetriebe alle Geschäftsanteile an den im Wege der Ausgliederung entstehenden neuen Gesellschaften (die Aus-
gliederung).  Die  Ausgliederung  erfolgt,  gemäß  der  in  letztgenannten  Artikeln  vorgesehenen  Option,  im  Einklang  mit

163499

L

U X E M B O U R G

Artikeln 285 bis 308, ausgeschlossen Artikel 303, des HandelsGG. Die Ausgliederung hat zum Ziel dass die Köhl Aktien-
gesellschaft  S.A.  in  Zukunft  eine  reine  Besitzgesellschaft  sein  soll  die  hauptsächlich  Holdingfunktionen  ausüben  wird
während die neu zu gründenden Gesellschaften die Aktivitäten Elektromaschinenbau und Elektrotechnik als separate
Tochtergesellschaften ausüben werden. Von dieser Restrukturierung erhofft sich der Verwaltungsrat der Köhl S.A. eine
bessere Kontrolle und erhöhte Effizienz der beiden ausgegliederten Geschäftszweige.

Das Kapital der Ursprungsgesellschaft beträgt eine Millionen zwei hundert tausend Euro (1.200.000,- EUR), aufgeteilt

in zwölf tausend (12.000) Aktien zu je ein hundert Euro (100,- EUR). Die zwei neuen Gesellschaften werden im Falle der:

- Köhl Antriebstechnik S.à. r.l. ein Gesellschaftskapital von hunderttausend Euro ([100.000,-] EUR), aufgeteilt in zehn-

tausend [(10.000)] Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils [zehn] [(10,-)] EUR und

-  Köhl  S.à.  r.l.  ein  Gesellschaftskapital  von  einer  Million  ([1.000.000,-]  EUR)  Euro,  aufgeteilt  in  hunderttausend

[(100.000)] Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils zehn [(10,-)] EUR aufweisen.

2. Durchführung der Ausgliederung.
2.1 Stichtag
Die Ausgliederung wird vorgenommen auf der Grundlage der Finanzsituation der Ursprungsgesellschaft zum 31. März

2014 (der Bilanzstichtag).

Aus buchhalterischer und steuerrechtlicher Sicht gilt die Ausgliederung als am 1. November 2014 durchgeführt (der

Ausgliederungsstichtag),

2.2 Umtauschverhältnis der Geschäftsanteile
Die neuen Gesellschaften werden an die Ursprungsgesellschaft folgende Geschäftsanteile ausgeben:

(a) Köhl Antriebstechnik S.à r.l. . . . . . . . . . (10.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils (10,-) EUR.
(b) Köhl S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (100.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils (10,-) EUR.

Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären vor, auf die Erstellung eines schriftlichen Berichts der Verwaltungsräte

nach Artikel 293 sowie auf die Erstellung eines Ausgliederungsberichts durch einen unabhängigen Gutachter nach Artikel
294 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das HandelsGG) gemäß
Artikel 296 des HandelsGG zu verzichten.

Daraus ergibt sich, dass nach der Ausgliederung die Ursprungsgesellschaft insgesamt (10.000) Geschäftsanteile an der

Köhl Antriebstechnik S.à r.l., und (100.000) Geschäftsanteile an der Köhl S.à r.l. halten wird.

Entsprechend den angefügten Satzungen gewähren die ausgebenden Geschäftsanteile an den neuen Gesellschaften der

Ursprungsgesellschaft Stimmrecht, Anteil an den ausgeschütteten Dividenden und Anteil an einem eventuellen Liquida-
tionserlös ab dem Tag der Gründung der neuen Gesellschaften.

Die von den neuen Gesellschaften ausgegebenen Geschäftsanteile sind in ein entsprechendes Register, das gemäß

Artikel 185 HandelsGG anzulegen ist, einzutragen.

2.3 Übertragung von Aktiva und Passiva auf die neuen Gesellschaften
Die neuen Gesellschaften übernehmen alle unten beschriebenen Aktiva und Passiva von der Ursprungsgesellschaft in

dem Zustand, in dem sie sich zum Ausgliederungsstichtag befinden.

Ein Recht auf Regress der neuen Gesellschaften gegen die Ursprungsgesellschaft ist ausgeschlossen.
Die Ursprungsgesellschaft garantiert lediglich den Bestand der übertragenen Forderungen, nicht aber die Liquidität der

Schuldner.

Die neuen Gesellschaften sind vom Ausgliederungsstichtag an die alleinigen Schuldner für sämtliche zuvor gegenüber

der Ursprungsgesellschaft entstandene steuer-, abgaben- und gebührenrechtliche Forderungen, soweit diese jeweils auf
sie übergegangen sind, unabhängig von deren Fälligkeit. Eine Gesamtschuldnerhaftung der neuen Gesellschaften für Alt-
verbindlichkeiten der Ursprungsgesellschaft besteht nur bis zur Höhe des den neuen Gesellschaften jeweils zugewiesenen
Reinvermögens.

Die neuen Gesellschaften werden ab dem Ausgliederungsstichtag für alle auf sie im Einzelnen übergegangenen Rechte

und Verpflichtungen haften und die Ausführung und Abwicklung der auf sie jeweils übergegangenen Verträge, Forderungen
und Rechte ordnungs- und vertragsgemäß sicherstellen.

Die Übertragung von Rechten und Forderungen von der Ursprungsgesellschaft an die neuen Gesellschaften hat zur

Folge, dass letztere im Umfang der an sie vorgenommenen Übertragung vollständig in alle Rechte, Sicherheiten, Rechts-
positionen und Verpflichtungen der Ursprungsgesellschaft gegenüber Dritten eintreten. Eine Novation findet in diesen
Fällen  nicht  statt.  Die  Rechte  zum  Schutz  der  Gläubiger  gegen  die  Ursprungsgesellschaft  bleiben  von  diesem  Absatz
unberührt.

Die neuen Gesellschaften verzichten auf eine allfällige Rückgängigmachung der in diesem Ausgliederungsplan vorgese-

henen Übertragung der Aktiva und Passiva.

Die neuen Gesellschaften werden alles Erforderliche veranlassen, um die Übertragung der Aktiva und Passiva von der

Ursprungsgesellschaft auf die neuen Gesellschaften zu ermöglichen und zu vollziehen.

2.4 Keine Aktionäre mit Sonderrechten oder Inhaber anderer Wertpapiere als Aktien

163500

L

U X E M B O U R G

Weder in der Ursprungsgesellschaft noch in den neuen Gesellschaften sind Aktionärssonderrechte bzw., Gesellschaf-

tersonderrechte oder andere Wertpapiere als Aktien bzw. Geschäftsanteile ausgegeben bzw. vorgesehen.

2.5 Keine Vorteilsgewährunq
Anlässlich der Ausgliederung wird weder einem Mitglied des Verwaltungsrat noch dem Kommissar noch einem Sach-

verständigen oder Wirtschaftsprüfer ein Vorteil gewährt.

2.6 Vermögensaufteilung
2.6.1 Aufstellung der Aktiva und Passiva der Ursprungsgesellschaft zum Bilanzstichtag
Die Ausgliederung erfolgt auf Basis der Bilanz der Ursprungsgesellschaft zum 31. März 2014 wie hier beschrieben und

sie näher dem Anhang 1. des vorliegenden Ausgliederungsplans hervorgeht:

AKTIVA

BUCHUNGSWERT

ZUM

BILANZSTICHTAG

(euros)

Buchungsposten

Buchungsbetrag

Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43,109,529.06

Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,730,213.78

Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175,736.37

Summe sämtlicher Aktiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57,015,479.21

Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,221,062.06

Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,065,253.91

Nicht nachrangige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29,729,163.24

Summe sämtlicher Passiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57,015,479.21

2.6.2 Einbringung des Teilbetriebs Elektromaschinenbau der Ursprungsgesellschaft in die Köhl Antriebstechnik S.à r.l.
Die Ursprungsgesellschaft überträgt den von ihr unterhaltenen Teilbetrieb Elektromaschinenbau auf die Köhl An-

triebstechnik S.à r.l. mit allen Aktiva und Passiva. Die Ausgliederung erfolgt auf Basis der folgenden Ausgliederungsbilanz
und wie sie näher dem Anhang 2. des vorliegenden Ausgliederungsplans hervorgeht:

AKTIVA

BUCHUNGSWERT

ZUM

BILANZSTICHTAG

Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203,654.73

Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,321,157.39

Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,563.00

Summe sämtlicher Aktiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,531,375.12

PASSIVA

BUCHUNGSWERT

ZUM

BILANZSTICHTAG

Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,000.00

Nicht nachrangige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,431,375.12

Summe sämtlicher Passiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,531,375.12

2.6.3 Einbringung des Teilbetriebs [Elektrotechnik] der Ursprungsgesellschaft in die Köhl S.à r.l.
Die Ursprungsgesellschaft überträgt den von ihr unterhaltenen Teilbetrieb Elektrotechnik auf die Köhl S.à r.l. mit allen

Aktiva und Passiva. Die Ausgliederung erfolgt auf Basis der folgenden Ausgliederungsbilanz und wie sie näher dem Anhang
3. des vorliegenden Ausgliederungsplans hervorgeht:

AKTIVA

BUCHUNGSWERT

ZUM

BILANZSTICHTAG

Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,083,786.70

Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,283,262.10

Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164,953.37

Summe sämtlicher Aktiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,532,002.17

PASSIVA

BUCHUNGSWERT

ZUM

BILANZSTICHTAG

Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000,000.00

Nicht nachrangige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,532,002.17

163501

L

U X E M B O U R G

Summe sämtlicher Passiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,532,002.17

2.6.5 Unberücksichtigte Aktiva und Passiva zum Ausgliederungsstichtag
Für sämtliche unter 2.6 ff. beschrieben Aktiva und Passiva gilt, dass die Übertragung im Wege der Ausgliederung alle

Wirtschaftsgüter, Gegenstände materiellen und immateriellen Rechte, Verbindlichkeiten, Rechtsbeziehungen erfasst, die
dem jeweiligen Teilbetrieb dienen oder zu dienen bestimmt sind oder sonst den Teilbetrieb betreffen oder ihm wirt-
schaftlich zuzurechnen sind, unabhängig davon, ob die Vermögensposition bilanzierungsfähig ist oder nicht. Die Übertra-
gung erfolgt auch unabhängig davon, ob der Vermögensgegenstand unter 2.7 ff. aufgeführt ist.

Sollten die zu übertragenden Rechtspositionen des Aktiv- oder Passivvermögens bis zum Wirksamwerden der Aus-

gliederung im regelmäßigen Geschäftsgang veräußert worden sein, so werden die an ihrer Stelle getretenen Surrogate
übertragen. Übertragen werden auch die bis zum Wirksamwerden der Ausgliederung erworbenen Gegenstände des
Aktiv- oder Passivvermögens, soweit sie zum übertragenden Teilbetrieb gehören.

In Zweifelsfällen, die auch durch Auslegung dieses Vertrages nicht zu klären sind, gilt, dass Vermögensgegenstände,

Verbindlichkeiten, Verträge und Rechtspositionen, die nach obigen Regeln nicht zugeordnet werden können, bei der
Ursprungsgesellschaft verbleiben. In diesen Fällen ist die Ursprungsgesellschaft berechtigt eine Zuordnung nach ihrem
Ermessen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Zugehörigkeit vorzunehmen.

Soweit bilanzierte und nicht bilanzierte Vermögensgegenstände und Schulden in die Rechtsbeziehungen, die den je-

weiligen Teilbetrieben wirtschaftlich zuzuordnen sind, nicht schon kraft Gesetzes von der Ursprungsgesellschaft auf die
jeweils neue Gesellschaft übergehen, wird die Ursprungsgesellschaft diese Vermögensgegenstände oder Schulden sowie
die Rechtsbeziehungen auf die entsprechenden Gesellschaften übertragen. Ist die Übertragung im Außenverhältnis nicht
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich oder unzweckmäßig, werden sich die beteiligten Gesellschaften im
Innenverhältnis so stellen, wie sie stehen würden, wenn die Übertragung der Vermögensgegenstände und Passiva bzw.
Rechtsbeziehungen auch im Außenverhältnis mit Wirkung zum Ausgliederungsstichtag erfolgt wäre. Wird die Ursprungs-
gesellschaft aus Verbindlichkeiten in Anspruch genommen, die der jeweils neuen Gesellschaft zuzuordnen sind, ist die
jeweilige neue Gesellschaft zur Freistellung verpflichtet oder hat einen Ausgleich zu leisten.

2.7 Berichtigung bei Registern, Markenerklärungen, Grundbuch
Soweit für die Übertragung von bestimmten Gegenständen die Zustimmung eines Dritten an einer öffentlich-rechtli-

chen  Genehmigung  oder  eine  Registrierung  erforderlich  ist,  werden  sich  die  Ursprungsgesellschaft  und  die  neuen
Gesellschaften bemühen, die Zustimmung Genehmigung oder Registrierung beizubringen. Falls dies nicht oder nur mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich sein würde, werden sich die Ursprungsgesellschaft und die neuen Gesell-
schaften im Innenverhältnis so stellen, als wäre die Übertragung der Gegenstände des ausgegliederten Vermögens mit
Wirkung zum Ausgliederungsstichtag erfolgt.

Die Ursprungsgesellschaft und die neuen Gesellschaften bewilligen und beantragen, nach Wirksamwerden der Aus-

gliederung die von der Ausgliederung betroffenen Markenregister entsprechend den Vorschriften dieser Urkunde zu
berichtigen.

Die Ursprungsgesellschaft und die neuen Gesellschaften bewilligen und beantragen, nach Wirksamwerden der Aus-

gliederung, das Grundbuch soweit notwendig zu berichtigen.

3. Entwürfe der Gründungsurkunden der neuen Gesellschaften.
ENTWURF GRÜNDUNGSURKUNDE DER Köhl Antriebstechnik S.à r.l.
Der Entwurf der Statuten der zu gründenden Köhl Antriebstechnik S.à r.l. befindet sich im Anhang 4. des vorliegenden

Ausgliederungsplans.

ENTWURF GRÜNDUNGSURKUNDE DER Köhl S.à r.l.
Der Entwurf der Statuten der zu gründenden Köhl S.à r.l. befindet sich im Anhang 5. des vorliegenden Ausgliede-

rungsplans.

4. Übergangsbestimmungen und sonstige Vereinbarungen. Allfällig erforderliche weitere, bislang nicht genannte Über-

gangsbestimmungen werden durch die Aktionäre bestimmt anlässlich der Annahme des Ausgliederungsplans, welche vor
einem luxemburgischen Notar mindestens einen Monat nach der Veröffentlichung dieses Ausgliederungsplans im Amts-
blatt Mémorial C, Recueil des sociétés et associations zu erfolgen hat.

Wecker, den 12. November 2014.

Wilfried Köhl / Edith Kohl / Mario Kohl / Dirk Hartmann
<i>Der Verwaltungsrat der Ursprungsgesellschaft

Anhang 1

KÖHL AG
17, Am Scheerleck
L-6868 Wecker

163502

L

U X E M B O U R G

<i>Bilanz

<i>Geschäftsjahr vom 1. April 2013 bis 31. März 2014

<i>(Vor- Ausgliederung)

AKTIVA

Geschäftsjahr

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

0.00

I. Nicht eingefordertes gezeichnetes Kapital

103

II. Eingefordertes, nicht eingezahltes gezeichnetes Kapital

105

B. Gründungskosten

107

C. Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

43,109,529.06

I. Immaterielle Anlagewerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

2,904,345.22

1 Forschungs- und Entwicklungskosten

113

2 Konzessionen, Patente, Lizenzen, Warenzeichen und vergleichbare Rechte und Werte
soweit sie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

2,904,345.22

a) entgeltlich erworben wurden und nicht unter C.I.3 auszuweisen sind . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

2,904,345.22

b) vom Unternehmen selbst erstellt wurden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
3 Geschäfts- oder Firmenwert, sofern er entgeltlich erworben wurde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4 Geleistete Anzahlungen und immaterielle Vermögensgegenstände in Entwicklung . . . . . . . . 123
II. Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

40,168,983.84

1 Grundstücke und Bauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

37,379,761.61

2 Technische Anlagen und Maschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

2,150,150.47

3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

639,071.76

4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

0.00

III. Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

36,200.00

1 Anteile an verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

36,200.00

2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

0.00

3 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

141

4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

143

5 Wertpapiere des Anlagevermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

0.00

6 Ausleihungen und Forderungen (Anlagevermögen)

147

7 Eigene Aktien oder eigene Anteile

149

D. Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

13,730,213.78

1. Vorräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

8,022,417.41

1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

155

2 Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

5,181,287.99

3 Fertige Erzeugnisse und Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

2,591,129.42

4 Bestand Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

250,000.00

II. Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

4,857,907.30

1 Forderungen, Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

3,432,118.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

3,432,118.00

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

169

2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

173

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

175

3 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht . . . . . . . . . 177

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

179

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

181

4 Sonstige Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

1,425,789.30

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

1,425,789.30

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

187

III. Wertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

0.00

1 Anteile an verbundenen Unternehmen und an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht

191

2 Eigene Aktien oder eigene Anteile

193

3 Sonstige Wertpapiere

195

163503

L

U X E M B O U R G

IV. Bank- und Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

849,889.07

E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

175,736.37

SUMME (AKTIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

57,015,479.21

PASSIVA

Geschäftsjahr

A. Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

20,221,062.06

I. Gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

1,200,000.00

II. Ausgabeagio und vergleichbare Agien

305

III. Neubewertungsrücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

14,350,000.00

IV. Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

1,920,000.00

1 Gesetzliche Rücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

120,000.00

2 Rücklage für eigene Aktien oder Anteile

313

3 Satzungsmässige Rücklagen

315

4 Sonstige Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

1,800,000.00

V. Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

2,091,356.13

VI. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

659,705.93

VII. Vorabdividenden

323

VIII. Investitionszulagen

325

IX. Sonderposten mit Rücklageanteil

327

B. Nachrangige Verbindlichkeiten

329

C. Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

7.065.253.91

1 Rückstellungen für Pensionen und vergleichbare Verpflichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

595,508.00

2 Steuerrückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

319,745.91

3 Sonstige Rückstellungen latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

6,150,000.00

D. Nicht nachrangige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

29,729,163.24

1 Anleihen

341

a) Wandelanleihen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

0.00

i) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

345

ii) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

347

b) nicht wandelbare Anleihen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

0.00

i) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

351

ii) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

353

2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

17,471,286.29

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

0.00

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

17,471,286.29

3 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, soweit diese nicht offen von den Vorräten abgesetzt
werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

363

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

365

4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

7,823,909.76

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

7,823,909.76

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

371

5 Durch Handelswechsel entstandene Verbindlichkeiten (Schuldwechsel) . . . . . . . . . . . . . . . . 373

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

375

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

377

6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

381

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

383

7 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

387

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

389

8 Verbindlichkeiten aus Steuern und im Rahmen der sozialen Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

2,027,440.65

a) aus Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

343,481.61

b) im Rahmen der sozialen Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

1,683,959.04

163504

L

U X E M B O U R G

9 Sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

2,406,526.54

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

2,406,526.54

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

0.00

E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

0.00

SUMME (PASSIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

57,015,479.21

Anhang 2.

Köhl Antriebstechnik S.à r.l.

<i>Bilanz

<i>Geschäftsjahr vom 1. April 2013 bis 31. März 2014

AKTIVA

Geschäftsjahr

Voriges

Geschäftsjahr

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital . . . . . . . . . . . . . . . 101

0.00 102

0.00

I. Nicht eingefordertes gezeichnetes Kapital

103

104

II. Eingefordertes, nicht eingezahltes gezeichnetes Kapital

105

106

B. Gründungskosten

107

108

C. Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

203,654.73 110

0.00

I. Immaterielle Anlagewerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

22,971.86 112

0.00

1 Forschungs- und Entwicklungskosten

113

114

2 Konzessionen, Patente, Lizenzen, Warenzeichen und
vergleichbare Rechte und Werte soweit sie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

22,971.86 116

0.00

a) entgeltlich erworben wurden und nicht unter C.I.3
auszuweisen sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

22,971.86 118

0.00

b) vom Unternehmen selbst erstellt wurden

119

120

3 Geschäfts- oder Firmenwert, sofern er entgeltlich erworben wurde

121

122

4 Geleistete Anzahlungen und immaterielle Vermögensgegenstände
in Entwicklung

123

124

II. Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

180,682.87 126

0.00

1 Grundstücke und Bauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

18,976.72 128

0.00

2 Technische Anlagen und Maschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

85,220.37 130

0.00

3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . . . . . . . . . . 131

76,485.78 132

0.00

4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

0.00 134

0.00

III. Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

0.00 136

0.00

1 Anteile an verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

0.00 138

0.00

2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

0.00 140

3 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 141

142

4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht

143

144

5 Wertpapiere des Anlagevermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

0.00 146

0.00

6 Ausleihungen und Forderungen (Anlagevermögen)

147

148

7 Eigene Aktien oder eigene Anteile

149

150

D. Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

1,321,157.39 152

0.00

I. Vorräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

476,588.18 154

0.00

1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

0.00 156

2 Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

0.00 158

0.00

3 Fertige Erzeugnisse und Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

476,588.18 160

0.00

4 Bestand Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

0.00 162

II. Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

835,183.99 164

0.00

1 Forderungen, Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

805,978.01 166

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

805,978.01 168

0.00

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

169

170

2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

0.00 172

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

173

174

163505

L

U X E M B O U R G

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

175

176

3 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

0.00 178

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

179

180

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

181

182

4 Sonstige Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

29,205.98 184

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

29,205.98 186

0.00

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

187

188

III. Wertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

0.00 190

0.00

1 Anteile an verbundenen Unternehmen und an Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht

191

192

2 Eigene Aktien oder eigene Anteile

193

194

3 Sonstige Wertpapiere

195

196

IV. Bank- und Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand . . . . . . 197

9,385.22 198

0.00

E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

6,563.00 200

0.00

SUMME (AKTIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

1,531,375.12 202

0.00

PASSIVA

Geschäftsjahr

Voriges

Geschäftsjahr

A. Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

100,000.00 302

0.00

I. Gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

100,000.00 304

0.00

II. Ausgabeagio und vergleichbare Agien

305

306

III. Neubewertungsrücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

0.00 308

IV. Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

0.00 310

0.00

1 Gesetzliche Rücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

0.00 312

0.00

2 Rücklage für eigene Aktien oder Anteile

313

314

3 Satzungsmässige Rücklagen

315

316

4 Sonstige Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

0.00 318

0.00

V. Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

0.00 320

0.00

VI. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

0.00 322

0.00

VII. Vorabdividenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

0.00 324

0.00

VIII. Investitionszulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

0.00 326

0.00

IX. Sonderposten mit Rücklageanteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

0.00 328

0.00

B. Nachrangige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

0.00 330

0.00

C. Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

0.00 332

0.00

1 Rückstellungen für Pensionen und vergleichbare Verpflichtungen . . . . 333

0.00 334

0.00

2 Steuerrückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

0.00 336

0.00

3 Sonstige Rückstellungen latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

0.00 338

0.00

D. Nicht nachrangige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

1,431,375.12 340

0.00

1 Anleihen

341

342

a) Wandelanleihen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

0.00 344

0.00

i) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

345

346

ii) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

0.00 348

b) nicht wandelbare Anleihen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

0.00 350

0.00

i) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

351

352

ii) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

353

354

2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

0.00 356

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

0.00 358

0.00

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

0.00 360

0.00

3 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, soweit diese nicht offen von
der Vorräten abgesetzt werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

0.00 362

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

363

364

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

365

366

4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . 367

284,774.66 368

0.00

163506

L

U X E M B O U R G

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

284,774.66 370

0.00

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

371

372

5 Durch Handelswechsel entstandene Verbindlichkeiten
(Schuldwechsel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

0.00 374

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

375

376

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

377

378

6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . 379

96,103.20 380

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

96,103.20 382

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

384

384

7 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

0.00 386

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

387

388

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

389

390

8 Verbindlichkeiten aus Steuern und im Rahmen der sozialen
Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

300,497.26 392

0.00

a) aus Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

300,497.26 394

0.00

b) im Rahmen der sozialen Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

0.00 396

0.00

9 Sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

750,000.00 398

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

750,000.00 400

0.00

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

0.00 402

0.00

E. Rechnungsabgrenzungsposten

403

0.00 404

0.00

SUMME (PASSIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

1,531,375.12 406

0.00

Anhang 3.

Köhl S.à r.l.

<i>Bilanz

<i>Geschäftsjahr vom 1. April 2013 bis 31. März 2014

AKTIVA

Geschäftsjahr

Voriges

Geschäftsjahr

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital . . . . . . . . . . . . . . . 101

0.00 102

0.00

I. Nicht eingefordertes gezeichnetes Kapital

103

104

II. Eingefordertes, nicht eingezahltes gezeichnetes Kapital

105

106

B. Gründungskosten

107

108

C. Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

4,083,786.70 110

0.00

1. Immaterielle Anlagewerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

2,881,217.05 112

0.00

1 Forschungs- und Entwicklungskosten

113

114

2 Konzessionen, Patente, Lizenzen, Warenzeichen und vergleichbare
Rechte und Werte soweit sie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

2,881,217.05

116

0,00

a) entgeltlich erworben wurden und nicht unter C.I.3 auszuweisen
sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

2,881,217.05

118

0.00

b) vom Unternehmen selbst erstellt wurden

119

120

3 Geschäfts- oder Firmenwert, sofern er entgeltlich erworben wurde

121

122

4 Geleistete Anzahlungen und immaterielle Vermögensgegenstände in
Entwicklung

123

124

II. Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

1,201,369.65 126

0.00

1 Grundstücke und Bauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

65,531.99 128

0.00

2 Technische Anlagen und Maschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

608,455.39 130

0.00

3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . . . . . . . . . . 131

527,382.27 132

0.00

4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

0.00 134

0.00

III. Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

1.200.00 136

0.00

1 Anteile an verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

1,200.00 138

0.00

2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

0.00 140

3 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 141

142

163507

L

U X E M B O U R G

4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht

143

144

5 Wertpapiere des Anlagevermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

0.00 146

0.00

6 Ausleihungen und Forderungen (Anlagevermögen)

147

148

7 Eigene Aktien oder eigene Anteile

149

150

D. Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

11,283,262.10 152

0.00

1. Vorräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

7,295,829.23 154

0.00

1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

0.00 156

2 Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

5,181,287.99 158

0.00

3 Fertige Erzeugnisse und Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

2,114,541.24 160

0.00

4 Bestand Gebäude

161

0.00 162

II. Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

3,174,966.37 164

0.00

1 Forderungen Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

2,760.079.62 166

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

2,760,079.62 168

0.00

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

169

170

2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

0.00 172

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

173

174

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

175

176

3 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

0.00 178

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

179

180

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

181

182

4 Sonstige Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

414,886.75 184

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

414,886.75 186

0.00

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

187

188

III. Wertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

0.00 190

0.00

1 Anteile an verbundenen Unternehmen und an Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191

192

2 Eigene Aktien oder eigene Anteile

193

194

3 Sonstige Wertpapiere

195

196

IV. Bank- und Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand . . . . . . 197

812,466.50 198

0.00

E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

164,953.37 200

0.00

SUMME (AKTIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

15,532,002.17 202

0.00

PASSIVA

Geschäftsjahr

Voriges

Geschäftsjahr

A. Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

1,000,000.00 302

0.00

I. Gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

1,000,000.00 304

0.00

II. Ausgabeagio und vergleichbare Agien

305

306

III. Neubewertungsrücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

0.00 308

IV. Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

0.00 310

0.00

1 Gesetzliche Rücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

0.00 312

0.00

2 Rücklage für eigene Aktien oder Anteile

313

314

3 Satzungsmässige Rücklagen

315

316

4 Sonstige Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

0.00 318

0.00

V. Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

0.00 320

0.00

VI. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

0.00 322

0.00

VII. Vorabdividenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

0.00 324

0.00

VIII. Investitionszulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

0.00 326

0.00

IX. Sonderposten mit Rücklageanteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

0.00 328

0.00

B. Nachrangige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

0.00 330

0.00

C. Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

0.00 332

0.00

1 Rückstellungen für Pensionen und vergleichbare Verpflichtungen . . . . 333

0.00 334

0.00

2 Steuerrückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

0.00 336

0.00

3 Sonstige Rückstellungen latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

0.00 338

0.00

163508

L

U X E M B O U R G

D. Nicht nachrangige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

14,532,002.17 340

0.00

1 Anleihen

341

342

0.00

a) Wandelanleihen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

0.00 344

0.00

i) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

346

ii) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

0.00 348

b) nicht wandelbare Anleihen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

0.00 350

0.00

i) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

352

ii) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

354

2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

69,740.91 356

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

69,740.91 358

0.00

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

0.00 360

0.00

3 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,
soweit diese nicht offen von der Vorräten abgesetzt werden . . . . . . . . . 361

0.00 362

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

363

364

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

366

4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . 367

7,392,902.86 368

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

7,392,902.86 370

0.00

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

371

372

5 Durch Handelswechsel entstandene Verbindlichkeiten
(Schuldwechsel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

0,00 374

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

375

376

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

377

378

6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . 379

4,025,795.70 380

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

4,025,795.70 382

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

383

384

7 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

0.00 386

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

387

388

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

390

8 Verbindlichkeiten aus Steuern und im Rahmen
der sozialen Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

1,628,313.57 392

0.00

a) aus Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

1,628,313.57 394

0.00

b) im Rahmen der sozialen Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

0.00 396

0.00

9 Sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

1,415,249.13 398

0.00

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

1,415,249.13 400

0.00

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

0.00 402

0.00

E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

0.00 404

0.00

SUMME (PASSIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

15,532,002.17 406

0.00

Anhang 4.

Köhl Antriebstechnik S.à.r.l.

Im Jahre zweitausend***, den
Vor dem unterzeichnenden Notar, mit dem Amtssitze zu.

Sind erschienen:

1. KÖHL AKTIENGESELLSCHAFT, eine nach luxemburgischen Recht errichtete Aktiengesellschaft (société anonyme)

mit Gesellschaftssitz in L-6868, Wecker, 17, am Scheerleck, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister
von Luxemburg unter der Registernummer B 43.668, mit einem Stammkapital von einer Million zweihunderttausend Euro
(EUR 1.200.000),

vertreten durch Herrn Wilfried Köhl, wohnhaft in 15, Um Kecker, 5489 Ehnen, Luxemburg und
Herrn Dirk Hartmann, wohnhaft am Röderbusch-Ring 28 in 54329 Konz, Deutschland

Diese erscheinende Partei, vertreten wie vorher genannt, ersucht den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer

von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorbenannte Erschienene errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeich-

nung „Köhl Antriebstechnik S.à.r.l.“.

163509

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker, der Gemeinde Biwer.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Er darf durch Verwaltungsratbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Biwer verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Projektierung, sowie der Verkauf, die elektrische, mechanische

und sonstige Instandhaltung, die Reparatur und die Installation von Motoren, Maschinen und Anlagen aller Art, Umfor-
mern, Industriepumpen, Ventilatoren, Getrieben und Generatoren, die Konzeption und die Herstellung von Sondermo-
toren,  -maschinen  und  -anlagen,  Dreh-,  Fräsarbeiten,  Auftragsschweissen  sowie  sonstige  mechanischen  Arbeiten,  die
Projektierung, die Errichtung, das Betreiben, die Betriebsführung und die Wartung und Instandhaltung von Windkraft-
und  kompletten  Windparkanlagen.  Die  Gesellschaft  ist  berechtigt,  andere  Erzeugnisse  gleicher  oder  ähnlicher  Art
herzustellen, zu erwerben oder zu vertreiben, überhaupt alles zu tun, was dem Gesellschaftszweck dienlich und förderlich
ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen  und  alle  Maßnahmen  zu  treffen  welche  mit  dem  Gegenstand  der  Gesellschaft  mittelbar  oder  unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen
errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder
denselben fördern kann, ausüben.

Zweck der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, deren

Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder auf
andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen, Immobilien sowie Grundstücken und
anderen Wertpapieren oder Effekten aller Art sowie der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapier und
Immobilienbestands.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller

Gesellschaften beteiligen und kann finanzielle Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder auf sonstige Weise
geben an verbundene Unternehmen oder Unternehmen derselben Gruppe. Die Gesellschaft kann auch Zweigstellen in
Luxemburg oder im Ausland begründen. Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen gegen flüssige oder
fixe Vermögenswerte von verbundenen oder nicht verbundenen Unternehmen, und kann Schuldinstrumente ausgeben.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art finanzieller, bewe-

glicher  und  unbeweglicher,  kommerzieller  und  industrieller  Operationen  tätigen,  welche  sie  zur  Verwirklichung  und
Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März eines jeden Jahres.

Art. 6.  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  einhunderttausend  Euro  (EUR  100.000,-)  und  ist  eingeteilt  in  eintausend

(10.000) Geschäftsanteile zu je zehn Euro (EUR 10,-)

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen

und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Le-

benden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindes-

tens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen, vorausgesetzt sie hat dazu genügend verteilbare Rücklagen

oder wenn der Rückkauf von einer Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft herrührt.

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden

von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Ums-

tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt werden, stellen sie die Geschäftsführung dar.
Die Geschäftsführung kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für sie und in ihrem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Die Gesellschafter können die Geschäftsführer durch einen einstimmigen Beschluss jederzeit, mit oder ohne Grund

abberufen.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung

ihres Mandates verantwortlich.

163510

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die,
in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum

Buchwert an den Nachfolger auszuzahlen.

Art. 12. Am 31. März eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den

Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestim-

mungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) die Geschäftsführung erstellt einen Zwischenabschluss;
(ii) der Zwischenabschluss zeigt, dass genügend Gewinne und andere Rücklagen (einschließlich Emissionsagios) zur

Ausschüttung zur Verfügung stehen; wohlwissentlich, dass der auszuschüttende Betrag die realisierten Gewinne seit Ende
des letzten Geschäftsjahres für das die Abschlüsse approbiert wurden, sofern vorhanden, nicht übersteigen darf, erhöht
um die Gewinnvorträge und verteilbare Rücklagen und abzüglich der Verlustvorträge und Summen, die der gesetzlichen
Rücklage zugeteilt werden müssen;

(iii) die Hauptversammlung muss einstimmig die Entscheidung, Zwischendividenden auszuschütten, innerhalb von zwei

(2) Monaten vom Zeitpunkt des Zwischenabschlusses an treffen;

(iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind angesichts der Aktiva der Gesellschaft nicht bedroht; und
wenn die ausgezahlten Zwischendividenden die verteilbaren Gewinne am Ende des Geschäftsjahres übersteigen, müs-

sen die Gesellschafter den Überschuss der Gesellschaft zurückerstatten.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern

ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Vorübergehende Bestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am 1. April 2014 und endet am 31. März 2015.

Köhl S.à.r.l.

Im Jahre zweitausend***, den
Vor dem unterzeichnenden Notar***, mit dem Amtssitze zu ***.

Sind erschienen:

1. KÖHL AKTIENGESELLSCHAFT, eine nach luxemburgischen Recht errichtete Aktiengesellschaft (société anonyme)

mit Gesellschaftssitz in L-6868, Wecker, 17, am Scheerleck, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister
von Luxemburg unter der Registernummer B 43.668, mit einem Stammkapital von einer Million zweihunderttausend Euro
(EUR 1.200.000),

vertreten durch vertreten durch Herrn Wilfried Köhl, wohnhaft in 15, Um Kecker, 5489 Ehnen, Luxemburg und
Herrn Dirk Hartmann, wohnhaft am Röderbusch-Ring 28 in 54329 Konz, Deutschland

Diese erscheinende Partei, vertreten wie vorher genannt, ersucht den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer

von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorbenannte Erschienene errichtet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeich-

nung „Köhl S.à.r.l.“.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker, der Gemeinde Biwer.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Er darf durch Verwaltungsratbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Biwer verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Projektierung, Herstellung und Verkauf von mechanischen und

elektrischen Bauteilen, Installationsverteilern, Steuerungsanlagen, Nieder- und Mittelspannungsschaltanlgen sowie deren

163511

L

U X E M B O U R G

Aufstellung, Inbetriebnahme, Installation, Wartung und Reparatur, die Konstruktion und Fertigung von Sondermaschinen
und Anlangen, die Erbringung von Ingenieurleistungen, die Erstellung von Software sowie die Ausführung von Installa-
tionsarbeiten jeglicher Art.

Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Erzeugnisse gleicher oder ähnlicher Art herzustellen, zu erwerben oder zu

vertreiben, überhaupt alles zu tun, was dem Gesellschaftszweck dienlich und förderlich ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen  und  alle  Maßnahmen  zu  treffen  welche  mit  dem  Gegenstand  der  Gesellschaft  mittelbar  oder  unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen
errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder
denselben fördern kann, ausüben.

Zweck der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, deren

Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder auf
andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen, Immobilien sowie Grundstücken und
anderen Wertpapieren oder Effekten aller Art sowie der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapier und
Immobilienbestands.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller

Gesellschaften beteiligen und kann finanzielle Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder auf sonstige Weise
geben an verbundene Unternehmen oder Unternehmen derselben Gruppe. Die Gesellschaft kann auch Zweigstellen in
Luxemburg oder im Ausland begründen. Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen gegen flüssige oder
fixe Vermögenswerte von verbundenen oder nicht verbundenen Unternehmen, und kann Schuldinstrumente ausgeben.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art finanzieller, bewe-

glicher  und  unbeweglicher,  kommerzieller  und  industrieller  Operationen  tätigen,  welche  sie  zur  Verwirklichung  und
Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März eines jeden Jahres.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million Euro (EUR 1.000.000,-) und ist eingeteilt in zehntausend (100.000)

Geschäftsanteile, zu je zehn Euro (EUR 10,-).

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen

und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Le-

benden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindes-

tens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen, vorausgesetzt sie hat dazu genügend verteilbare Rücklagen

oder wenn der Rückkauf von einer Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft herrührt.

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden

von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Ums-

tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt werden, stellen sie die Geschäftsführung dar.
Die Geschäftsführung kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für sie und in ihrem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Die Gesellschafter können die Geschäftsführer durch einen einstimmigen Beschluss jederzeit, mit oder ohne Grund

abberufen.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung

ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die,
in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum

Buchwert an den Nachfolger auszuzahlen.

163512

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Am 31. März eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den

Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestim-

mungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) die Geschäftsführung erstellt einen Zwischenabschluss;
(ii) der Zwischenabschluss zeigt, dass genügend Gewinne und andere Rücklagen (einschließlich Emissionsagios) zur

Ausschüttung zur Verfügung stehen; wohlwissentlich, dass der auszuschüttende Betrag die realisierten Gewinne seit Ende
des letzten Geschäftsjahres für das die Abschlüsse approbiert wurden, sofern vorhanden, nicht übersteigen darf, erhöht
um die Gewinnvorträge und verteilbare Rücklagen und abzüglich der Verlustvorträge und Summen, die der gesetzlichen
Rücklage zugeteilt werden müssen;

(iii) die Hauptversammlung muss einstimmig die Entscheidung, Zwischendividenden auszuschütten, innerhalb von zwei

(2) Monaten vom Zeitpunkt des Zwischenabschlusses an treffen;

(iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind angesichts der Aktiva der Gesellschaft nicht bedroht; und
(v) wenn die ausgezahlten Zwischendividenden die verteilbaren Gewinne am Ende des Geschäftsjahres übersteigen,

müssen die Gesellschafter den Überschuss der Gesellschaft zurückerstatten.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern

ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Vorübergehende Bestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am 1. April 2014 und endet am 31. März 2015.

Anhang 4.

Köhl Antriebstechnik S.à.r.l.

Im Jahre zweitausend***, den
Vor dem unterzeichnenden Notar, mit dem Amtssitze zu.

Sind erschienen:

1. KÖHL AKTIENGESELLSCHAFT, eine nach luxemburgischen Recht errichtete Aktiengesellschaft (société anonyme)

mit Gesellschaftssitz in L-6868, Wecker, 17, am Scheerleck, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister
von Luxemburg unter der Registernummer B 43.668, mit einem Stammkapital von einer Million zweihunderttausend Euro
(EUR 1.200.000),

vertreten durch Herrn Wilfried Köhl, wohnhaft in 15, Um Kecker, 5489 Ehnen, Luxemburg und
Herrn Dirk Hartmann wohnhaft am Röderbusch-Ring 28 in 54329 Konz, Deutschland

Diese erscheinende Partei, vertreten wie vorher genannt, ersucht den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer

von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorbenannte Erschienene errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeich-

nung „Köhl Antriebstechnik S.à.r.l.“.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker, der Gemeinde Biwer.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Er darf durch Verwaltungsratbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Biwer verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Projektierung, sowie der Verkauf, die elektrische, mechanische

und sonstige Instandhaltung, die Reparatur und die Installation von Motoren, Maschinen und Anlagen aller Art, Umfor-
mern, Industriepumpen, Ventilatoren, Getrieben und Generatoren, die Konzeption und die Herstellung von Sondermo-
toren,  -maschinen  und  -anlagen,  Dreh-,  Fräsarbeiten,  Auftragsschweissen  sowie  sonstige  mechanischen  Arbeiten,  die
Projektierung, die Errichtung, das Betreiben, die Betriebsführung und die Wartung und Instandhaltung von Windkraft-
und  kompletten  Windparkanlagen.  Die  Gesellschaft  ist  berechtigt,  andere  Erzeugnisse  gleicher  oder  ähnlicher  Art
herzustellen, zu erwerben oder zu vertreiben, überhaupt alles zu tun, was dem Gesellschaftszweck dienlich und förderlich
ist.

163513

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen  und  alle  Maßnahmen  zu  treffen  welche  mit  dem  Gegenstand  der  Gesellschaft  mittelbar  oder  unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen
errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder
denselben fördern kann, ausüben.

Zweck der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, deren

Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder auf
andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen, Immobilien sowie Grundstücken und
anderen Wertpapieren oder Effekten aller Art sowie der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapier und
Immobilienbestands.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller

Gesellschaften beteiligen und kann finanzielle Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder auf sonstige Weise
geben an verbundene Unternehmen oder Unternehmen derselben Gruppe. Die Gesellschaft kann auch Zweigstellen in
Luxemburg oder im Ausland begründen. Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen gegen flüssige oder
fixe Vermögenswerte von verbundenen oder nicht verbundenen Unternehmen, und kann Schuldinstrumente ausgeben.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art finanzieller, bewe-

glicher  und  unbeweglicher,  kommerzieller  und  industrieller  Operationen  tätigen,  welche  sie  zur  Verwirklichung  und
Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März eines jeden Jahres.

Art. 6.  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  einhunderttausend  Euro  (EUR  100.000,-)  und  ist  eingeteilt  in  eintausend

(10.000) Geschäftsanteile zu je zehn Euro (EUR 10,-)

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen

und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Le-

benden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindes-

tens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen, vorausgesetzt sie hat dazu genügend verteilbare Rücklagen

oder wenn der Rückkauf von einer Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft herrührt.

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden

von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Ums-

tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt werden, stellen sie die Geschäftsführung dar.
Die Geschäftsführung kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für sie und in ihrem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Die Gesellschafter können die Geschäftsführer durch einen einstimmigen Beschluss jederzeit, mit oder ohne Grund

abberufen.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung

ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die,
in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum

Buchwert an den Nachfolger auszuzahlen.

Art. 12. Am 31. März eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den

Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

163514

L

U X E M B O U R G

- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestim-

mungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) die Geschäftsführung erstellt einen Zwischenabschluss;
(ii) der Zwischenabschluss zeigt, dass genügend Gewinne und andere Rücklagen (einschließlich Emissionsagios) zur

Ausschüttung zur Verfügung stehen; wohlwissentlich, dass der auszuschüttende Betrag die realisierten Gewinne seit Ende
des letzten Geschäftsjahres für das die Abschlüsse approbiert wurden, sofern vorhanden, nicht übersteigen darf, erhöht
um die Gewinnvorträge und verteilbare Rücklagen und abzüglich der Verlustvorträge und Summen, die der gesetzlichen
Rücklage zugeteilt werden müssen;

(iii) die Hauptversammlung muss einstimmig die Entscheidung, Zwischendividenden auszuschütten, innerhalb von zwei

(2) Monaten vom Zeitpunkt des Zwischenabschlusses an treffen;

(iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind angesichts der Aktiva der Gesellschaft nicht bedroht; und
wenn die ausgezahlten Zwischendividenden die verteilbaren Gewinne am Ende des Geschäftsjahres übersteigen, müs-

sen die Gesellschafter den Überschuss der Gesellschaft zurückerstatten.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern

ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Vorübergehende Bestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am 1. April 2014 und endet am 31. März 2015.
Référence de publication: 2014176251/877.
(140201267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Lion Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Strassen, 32, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 135.827.

Im Jahre zweitausendvierzehn, den fünften November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jacques CASTEL, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Sind die Aktionäre der luxemburgischen Aktiengesellschaft LION SYSTEMS S.A., mit Sitz in L-3895 Foetz, rue du

Commerce, ecostart 2, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 135.827, zu
einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den damals zu Grevenmacher residierenden

Notar Joseph GLODEN, am 29. Januar 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
498 vom 27. Februar 2008; die Satzungen wurden abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten
Notar Joseph GLODEN, am 04. August 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
2096 vom 29. August 2008.

Die Versammlung wird um 14.40 Uhr eröffnet unter dem Vorsitz von Dame Gaby REIFF, berufsansässig in Greven-

macher.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Dame Diane LOLAICO, berufsansässig in Grevenmacher.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Marc SCHMIZ, berufsansässig zu Strassen.
Nachdem das Versammlungsbüro zusammengesetzt ist, erklärt der Vorsitzende und bittet den amtierenden Notar zu

beurkunden:

I. Die Tagesordnung lautet:
1. Sitzverlegung von L-3895 Foetz, rue du Commerce, ecostart 2, nach L-8069 Strassen, 32, rue de l'Industrie.
2. Artikel 4, Absatz eins der Satzungen der Gesellschaft „LION SYSTEMS S.A.“, wie folgt abzuändern:
„ Art. 4. (Absatz eins). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen.“
II. Die Aktionäre sind unter Angabe des Namens, Vornamens, sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer

Anwesenheitsliste verzeichnet und die Aktionäre haben sich auf dieser Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung anwesend

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über die vorstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschließen.

163515

L

U X E M B O U R G

Sodann haben die Aktionäre, nachdem über die vorstehende Tagesordnung verhandelt worden ist, einstimmig folgende

Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft „LION SYSTEMS S.A.“, von L-3895 Foetz, rue du

Commerce, ecostart 2, nach L-8069 Strassen, 32, rue de l'Industrie, zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge der obigen Sitzverlegung erklärt die Gesellschafterversammlung Artikel vier, Absatz eins der Satzungen der

Gesellschaft „LION SYSTEMS S.A.“, wie folgt abzuändern:

„ Art. 4. (Absatz eins). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen.“

<i>Kosten

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen um 14.50 Uhr.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und  nach  Vorlesung  an  den  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichen  Vornamen,  Stand  und  Wohnort  bekannten

Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. REIFF, D. LOLAICO, M. SCHMIZ, J. CASTEL.
Enregistré à Grevenmacher, le 06 novembre 2014. Relation: GRE/2014/4359. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister, sowie

zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 10. November 2014.

J. CASTEL
<i>Der Notar

Référence de publication: 2014173850/56.
(140198488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Unicorp Seeds S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 147.872.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of September,
Before us, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Unicorp Seeds S.A., a Luxembourg public

limited liability company (société anonyme), having its registered office at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand-
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under registration number
B147.872 and having a share capital of EUR 31,000.- (the Company). The Company was incorporated pursuant to a deed
of Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri HELLINCKX on 30 July
2009,  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  (the  Memorial)  under  number  1836  on  23
September 2009. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since then.

THERE APPEARED:

The sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder) as described in the attendance list,
here represented by Mrs Claudia ROUCKERT, employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that thirty-one thousand (31,000) shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, and representing the entirety

of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and
may deliberate upon the items of the agenda, hereinafter reproduced;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;

163516

L

U X E M B O U R G

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of eighty thousand euro (EUR 80,000.-) in order to bring

the share capital of the Company from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by
thirty-one thousand (31,000) fully paid up shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each to one
hundred eleven thousand euro (EUR 111,000.-) by way of the issuance of eighty thousand (80,000) additional shares of
the Company, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, in registered form;

3. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 2 above by way of a contribution in cash;
4. Amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company;
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any director of the Company and Daniel Kaiser to proceed, in the name and on behalf of the Company,
to the above changes; and

6. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Sole Shareholder waives the

convening notice, the Sole Shareholder considering itself as duly convened and declaring itself to have perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eighty thousand euro

(EUR 80,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of thirty-one thousand euro
(EUR 31,000.-) represented by thirty-one thousand (31,000) shares in registered form, having a par value of one euro
(EUR 1.-) each to one hundred and eleven thousand euro (EUR 111,000.-) by way of the issuance of eighty thousand
(80,000) additional shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, in registered form.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital

increase as follows:

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to subscribe for eighty thousand (80,000) addi-

tional shares and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of eighty thousand euro (EUR
80,000.-), it being understood that eighty thousand euro (80,000.-) shall be allocated to the share capital account of the
Company.

The amount of eighty thousand euro (EUR 80,000) is at the Company’s disposal and evidence of such amount has been

given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend paragraph one of article 5.1

of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The share capital is set at one hundred and eleven thousand euro (EUR 111,000.-), represented by one hundred

and eleven thousand (111,000) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed
and fully paid-up.”

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes with power and authority given to any director of the Company and Daniel Kaiser to proceed, on behalf of the
Company, to the registration of the above changes.

There being no further business, the Meeting is terminated.

<i>Attestation

The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26

of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German
text, the English version shall be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on the day

indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the person appearing, it signed together with the notary the present original deed.

163517

L

U X E M B O U R G

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahr zweitausendvierzehn, am dreißigsten September,
Vor Maître Francis KESSELER, Notar, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,
fand eine außerordentliche Generalversammlung (die Versammlung) des Alleinaktionärs von Unicorp Seeds S.A., einer

luxemburgischen Aktiengesellschaft (société anonyme), mit Sitz in 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 147.872 und mit
einem Stammkapital von EUR 31.000,- (die Gesellschaft) statt. Die Gesellschaft wurde gemäß einer Urkunde des Notars
Maître Carlo WERSANDT, Notar, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, als Vertreter von Maître Henri HELLINCKX am 30.
Juli 2009 gegründet, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das Memorial) unter der Nummer
1836 vom 23. September 2009. Die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist seitdem nicht geändert worden.

IST ERSCHIENEN:

Der Alleinaktionär der Gesellschaft (der Alleinaktionär), wie in der Anwesenheitsliste dargestellt,
hier vertreten durch Frau Claudia ROUCKERT, Privatbeamtin, mit Geschäftsadresse in Esch-sur-Alzette, Großher-

zogtum Luxemburg, kraft privatschriftlicher Vollmacht.

Besagte Vollmacht, welche von dem Vollmachtsinhaber, handelnd für die erschienene Partei, und dem unterzeichn-

enden Notar "ne varietur" unterzeichnet wurde, bleibt der vorliegenden Urkunde zu Registrierungszwecken beigefügt.

Die erschienene Partei, vertreten wie hier oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht folgendes zu

beurkunden:

I. dass einunddreißigtausend (31.000) Aktien, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), das gesamte Aktien-

kapital der Gesellschaft darstellend, ordnungsmäßig bei dieser Versammlung vertreten sind, die folglich ordnungsgemäß
zusammengekommen ist und über die im Folgenden wiedergegebenen Punkte der Tagesordnung beraten darf;

II. dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
1. Verzicht auf die Einberufungsbekanntmachung;
2.  Erhöhung  des  Stammkapitals  der  Gesellschaft  um  einen  Betrag  von  achtzigtausend  Euro  (EUR  80,000),  um  das

Stammkapital der Gesellschaft von seiner gegenwärtigen Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31,000.-), eingeteilt
in einunddreißigtausend (31,000) vollständig eingezahlte Aktien in registrierter Form mit einem Nennwert von je einem
Euro (EUR 1), auf einhundertelftausend Euro (EUR 111,000) mittels Ausgabe von achtzigtausend (80,000) zusätzlichen
Aktien in registrierter Form der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu erhöhen;

3. Zeichnung und Zahlung der im vorstehenden Tagesordnungspunkt 2 angegebenen Kapitalerhöhung mittels einer

Bareinlage;

4. Änderung von Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft;
5. Änderung des Aktionärsregisters der Gesellschaft zwecks Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen, unter

Befugnis- und Vollmachtserteilung an jedes Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft und Herrn Daniel Kaiser, die
vorstehenden Änderungen für und im Namen der Gesellschaft einzutragen;

6. Verschiedenes.
III. dass die Versammlung die nachstehenden Beschlüsse gefasst hat:

<i>Erster Beschluss

Da das gesamte Stammkapital der Gesellschaft auf der Versammlung vertreten ist, verzichtet der Alleinaktionär auf

das Einberufungsschreiben; der Alleinaktionär, sieht sich als ordnungsgemäß einberufen an und erklärt die Tagesordnung
perfekt zu kennen, welche ihm im Voraus mitgeteilt wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Der  Alleinaktionär  beschließt  das  Stammkapital  der  Gesellschaft  um  einen  Betrag  von  achtzigtausend  Euro  (EUR

80,000) zu erhöhen, um das Stammkapital der Gesellschaft von seiner gegenwärtigen Höhe von einunddreißigtausend
Euro (EUR 31,000), eingeteilt in einunddreißigtausend (31,000) Aktien in registrierter Form mit einem Nennwert von je
einem Euro (EUR 1) in, auf einhundertelftausend Euro (EUR 111,000) mittels Ausgabe von achtzigtausend (80,000) zu-
sätzlichen Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) in registrierter Form anzuheben.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleinaktionär beschließt die folgende Zeichnung und volle Zahlung der Kapitalerhöhung anzunehmen und wie

folgt einzutragen:

<i>Zeichnung - Zahlung

Der  Alleinaktionär,  vertreten  wie  eingangs  erwähnt,  erklärt  hiermit  achtzigtausend  (80,000)  zusätzliche  Aktien  zu

zeichnen und zahlt diese mittels Bareinzahlung im Gesamtbetrag von achtzigtausend Euro (EUR 80,000) in voller Höhe
ein, wobei die gesamten achtzigtausend Euro (EUR 80,000) dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen werden.

163518

L

U X E M B O U R G

Der Betrag von achtzigtausend Euro (EUR 80,000) steht zur Verfügung der Gesellschaft und ein Nachweis des Betrags

wurde dem unterzeichneten Notar ausgehändigt.

<i>Vierter Beschluss

Infolge der Fassung der vorgehenden Beschlüsse beschließt der Alleinaktionär den ersten Absatz des Artikels 5.1 der

Satzung zu ändern, so dass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ 5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertelftausend Euro (EUR 111,000), eingeteilt in einhundertelftausend

(111,000) Aktien in registrierter Form mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1) je Aktie, alle vollgezeichnet und voll
eingezahlt.“

<i>Fünfter Beschluss

Der Alleinaktionär beschließt im Aktienregister der Gesellschaft zwecks Berücksichtigung der vorstehenden Ände-

rungen, unter Befugnis- und Vollmachtserteilung an jedes Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft und Herrn Daniel
Kaiser die vorstehenden Änderungen für und im Namen der Gesellschaft vorzunehmen.

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte ausstehen, wird die Versammlung beendet.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der

erschienenen Partei in englischer Sprache abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung und dass im Falle von Wi-
dersprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen Wortlaut die englische Fassung maßgebend ist.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg, an dem eingangs

angegebenen Datum erstellt wurde.

Nach Verlesung des Dokuments an die erschienene Partei, hat diese zusammen mit dem Notar, die vorliegende Ori-

ginalurkunde unterzeichnet.

Signé: Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 03 octobre 2014. Relation: EAC/2014/13338. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014160562/163.
(140182098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

Global Gate Delta (Lux) 3, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 190.990.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of September,
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Global Gate Delta (Lux), a société à responsabilité limitée duly incorporated under the Laws of Luxembourg, having

its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, under registration process with the Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, incorporated toay by the undersigned notary,

duly represented by Mr Geoffrey AREND, private employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal dated 26 September 2014.
This proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for

the purpose of registration.

The appearing person, acting in the above capacity, has requested the notary to draw up the articles of incorporation

of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which is established as follows:

Art. 1. Form. A société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the "Company") governed by the

law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and by these articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation"), is hereby established by the founding shareholder.

163519

L

U X E M B O U R G

The Company may at any time have one or several shareholders, as a result of the transfer of shares or the issue of

new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.

Art. 2. Corporate name. The Company will exist under the corporate name of "Global Gate Delta (Lux) 3".

Art. 3. Corporate objects. The purposes for which the Company is formed are all operations or transactions pertaining

directly or indirectly to the taking of participating interests in any companies or enterprises in whatever form, as well as
the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities, financial instruments, bonds, treasury bills, equity participation, stocks and patents
of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of
contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and
patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The Company may also enter into the following transactions (it being understood that the Company will not enter

into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as regulated activity of
the financial sector):

- to grant every assistance and any financial support, whether by way of loans, advances or otherwise to its direct and

indirect subsidiaries affiliates and/or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, and/or
entities belonging to its Group, the Group being referred to as the group of companies which includes the direct and
indirect shareholders of the Company as well as their direct and indirect subsidiaries;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present and future) or by all or any such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its direct and indirect subsidiaries, affiliates
and/or entities belonging to its Group, within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg laws.

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by

any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

The Company may invest in real estate that is exclusively used for investment purposes and not for the own use of

the Company.

In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever, which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the

shareholders, as the case may be.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the

managers.

The managers may establish subsidiaries and branches in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500.00) represented by twelve

thousand and five hundred (12,500) shares of a par value of one Euro (EUR 1.00) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the shareholder(s).

The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities

in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use
of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance
of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

All shares will have equal rights.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 7. Changes to the capital. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the

law regarding commercial companies.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets

of the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder,
the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the sole

shareholder or of the shareholders, as the case may be.

163520

L

U X E M B O U R G

The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever

reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the
sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares. Shares are freely transferable among shareholders. The share transfer inter vivos to non

shareholders is subject to the consent of at least seventy-five per cent (75%) of the Company's capital. In case of death
of a shareholder, the share transfer to non shareholders is subject to the consent of no less than seventy-five per cent
(75%) of the votes of the surviving shareholders. In any event the remaining shareholders have a preemption right which
has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non shareholder.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Managers. The Company is managed by one or more manager(s), who need not to be shareholders, appointed

by decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for an unlimited period years.

Managers are eligible for reelection. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the

sole shareholder or of the shareholders at a single majority. Each manager may as well resign.

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their

tenure and the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.
If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers composed of category A and

category B managers and articles 14, 15 and 16 shall apply.

Art. 14. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to

attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.

The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need

not be members of the board of managers.

Art. 15. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by any manager. The meetings

are held at the place, the day and the hour specified in the notice.

The board of managers may only proceed to business if a majority of its members is present or represented and only

if, at least, one manager of category A and one manager of category B are present or represented.

Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to

vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or e-mail.

Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting and only if,

at least, one manager of category A and one manager of category B vote in favour of the decisions.

A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board,

shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.

In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority

of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.

At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall

be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.

In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference

calls.

Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

Art. 16. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by,

at least, one manager of category A and one manager of category B or in circular resolutions as provided in the preceding
paragraph. Any power of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.

The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.

Art. 17. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is/are vested with the

broadest powers to perform all acts of management and disposal in the Company's interest. All powers not expressly
reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.

163521

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Delegation of powers. The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general

meeting of shareholders, as the case may be, entrust the daily management of the company to one of its members

The managers may further delegate specific powers to any managers or other officers.
The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.
If more than one manager is appointed, any delegation of powers has to be decided by at least one manager of category

A and one manager of category B.

Art. 19. Representation of the Company. The Company shall be bound towards third parties, in case of a sole manager,

by the sole signature of the sole manager or, in case of plurality of managers, by (i) the joint signatures of one manager
of category A and one manager of category B, (ii) the sole signature of the manager to whom the daily management of
the Company has been delegated, within the scope of the daily management, and (iii) the sole signature or the joint
signatures of any persons to whom such signatory powers have been delegated by the managers, within the limits of such
powers.

Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting

a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.

Art. 21. Liability of the managers. No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation

in relation to the commitments taken on behalf of the Company. A manager is only liable for the performance of his
duties.

Art. 22. Decisions of the shareholders.
1. If the Company has only one shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of

shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915 are not applicable in such a situation.

2. If the Company has more than one shareholder, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting

or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted
which has been sent by the manager(s) to the shareholders.

In the latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,

within fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

If the Company has more than one shareholder, no decision may validly be taken, unless it is approved by shareholders

representing together at least one half of the corporate capital. All amendments to the Articles of Incorporation have to
be approved by a majority of shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.

Art. 23. Minutes. The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented

in writing, recorded in a register and kept by the manager(s) at the registered office of the Company. The powers-of-
attorney are attached to the minutes.

Art. 24. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty first day of December

of each year.

Art. 25. Financial statements - Statutory auditor. Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed,

the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in
accordance with the law. The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to
the shareholders, as the case may be, for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company

pursuant to article 198 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Should the Company have more than twenty-five shareholders, or otherwise as required by law, the general meeting

of shareholders shall appoint a statutory auditor as provided in article 200 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended. In all other cases, the general meeting of shareholders is free to appoint a statutory auditor or
an external auditor at its discretion.

Art. 26. Allocation of profits. Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this

allocation is no longer mandatory when and as long as the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,

as the case may be. The manager(s) may decide on the declaration and payment of interim dividends.

Art. 27. Dissolution - liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation

will be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders or not, appointed by the sole shareholder
or by the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 28. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in ac-

cordance with applicable laws.

163522

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and payment

All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash by

Global Gate Delta (Lux), previously named.

The amount of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500.00) is thus as from now being made available to

the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Statement

The  undersigned  notary  states  that  the  conditions  provided  for  by  Article  183  of  the  law  of  10  August  1915  on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory provision

The first financial year starts on this date and ends on 31 December 2014.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The founding shareholder, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to adopt the following

resolutions as sole shareholder of the Company pursuant to article 200-2 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended:

I. Resolved to set at two (2) the number of managers and further resolved to appoint the following as managers for

an unlimited period:

- Mr Rudy SAYEGH, Chief Executive Officer, with professional address in 9 

th

 Floor, Atomium Tower, Georges Haimari

Street, Achrafieh, Beirut, Lebanon, as manager of category A,

- Mr Richard HAWEL, company director, with professional address in 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg, as manager

of category B.

The managers will be entrusted with the powers set forth in article 17 of the Articles of Incorporation and the Company

is bound towards third parties by the joint signatures of at least, one manager of category A and one manager of Category
B.

II. The registered office of the Company shall be set at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Whereof, the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed

is worded in English followed by a French version; and that in case of any differences between the English text and the
French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, that person signed this original deed together with, the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Global Gate Delta (Lux), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue

Adolphe, L-1116 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, constituée aujourd'hui par le notaire soussigné,

dûment représentée par Monsieur Geoffrey AREND, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 26 septembre 2014.
Cette procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de

formalisation.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'il est constituée comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par le comparant ci-avant une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission

de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de "Global Gate Delta (Lux) 3".

163523

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes opérations ou transactions permettant directement ou indirectement la

prise de participations dans toute société ou entreprise de quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et
brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes (étant entendu qu'elle n'entrera dans aucune opé-

ration qui aurait pour conséquence de l'engager dans une activité considérée comme une activité réglementée du secteur
financier):

- apporter toute assistance ou soutien financier, que ce soit sous forme de prêts, d'avances ou autrement à ses filiales

directes et indirectes, aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel,
aux sociétés liées ou entités appartenant à son Groupe, c'est-à-dire au groupe de sociétés comprenant les associés directs
et indirects de la Société ainsi que de leurs filiales directes ou indirectes;

- accorder toute garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de ses filiales directes et indirectes, des sociétés dans
lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou encore des sociétés liées ou entités
appartenant à son Groupe dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt
de la Société;

La Société pourra investir dans des opérations immobilières uniquement à des fins d'investissement et non par pour

l'utilisation personnelle de la société.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution des associés, selon le

cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d'une décision des gérants.
Les gérants pourront établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,00), représenté par douze

mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur d'un Euro (EUR 1.00) chacune.

Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute part sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés, selon le cas.

La Société pourra, sans limite aucune, accepter tout apport de fonds propres ou toute autre contribution sans émission

de Parts Sociales ou autres titres en contrepartie de l'apport, et pourra créditer ces apports sur un ou plusieurs comptes.
Les décisions quant à l'utilisation de ces comptes devront être prises par l'(les) Associé(s) et seront régies par la Loi de
1915 et les présents statuts. Afin d'éviter toute équivoque, chacune de ces décisions pourra, sans caractère obligatoire,
allouer tout montant apporté à l'apporteur.

Toutes les parts sociales donnent droit à des droits égaux.
La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues

par l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal

dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société
comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des
associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou

de la collectivité des associés, selon le cas.

163524

L

U X E M B O U R G

Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons

que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les
actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l'actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l'exercice de leurs
droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée des associés,
suivant le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun désigné parmi eux ou en dehors d'eux.

Art. 10. Cession de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être

cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement

similaire affectant l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés

par une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée indéterminée.

Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés

pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).

L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d'un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé de gérants de catégorie A et de

gérants de catégorie B et les articles 14, 15 et 16 trouveront à s'appliquer.

Art. 14. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses

fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.

Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance peuvent être convoquées par chaque

gérant. Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnés dans la convocation.

Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité des gérants est présente ou représentée et qu'au moins un

gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B sont présents ou représentés.

Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et

voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion cette majorité devant

obligatoirement comporter le vote d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer

le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.

En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des

autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.

A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans

lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.

Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors

d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 16. Procès verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des

procès verbaux signés par au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B, ou dans des résolutions
circulaires comme prévu à l'alinéa qui précède. Les procurations resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et
extraits de ces procès verbaux seront signés par le président.

Ces procès verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.

163525

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Pouvoirs. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les

plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.

Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut, avec l'autorisation préalable de l'associé unique ou de

l'assemblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.

Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
Si plus d'un gérant est nommé, toute décision de délégation de pouvoirs doit être prise par au moins un gérant de

catégorie A et un gérant de catégorie B.

Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée, en cas de gérant unique, par la seule

signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par (i) la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et
d'un gérant de catégorie B, (ii) par la signature individuelle du gérant auquel la gestion journalière a été déléguée et, (iii)
par la signature individuelle ou conjointe à toute personne à qui les pouvoirs de signature ont été délégués par le conseil
de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Événements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire

affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.

Art. 21. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.

Art. 22. Décisions de l'associé ou des associés.
1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés. Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

2. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale ou, s'il y a moins

de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux
associés.

Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

En cas de pluralité d'associés, aucune décision n'est valablement prise si elle n'est pas approuvée par des associés

représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée
par une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.

Art. 23. Procès-verbaux. Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront do-

cumentées par écrit et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procurations
y seront annexées.

Art. 24. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance. Chaque année, le dernier jour de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et

le gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément
à la loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des
associés.

Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents comptables,

conformément à l'article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l'assemblée générale des associés

doit nommer un commissaire aux comptes comme prévu à l'article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l'assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion de
nommer un commissaire aux comptes ou un réviseur d'entreprises.

Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la

constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. Les gérant

(s) pourra (pourront) procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 27. Dissolution. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que

ce soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé
unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 28. Dispositions générales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux

dispositions légales en vigueur.

163526

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et paiement

Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire par Global

Gate Delta (Lux), prénommée.

La somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,00) se trouve partant dès maintenant à la disposition de la

Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2014.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes comme

associé unique de la Société conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée:

I. Décide de fixer à deux (2), le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer comme gérants pour une durée

indéterminée:

- Monsieur Rudy SAYEGH, Président Directeur Général, demeurant professionnellement au 9 

th

 Floor, Atomium

Tower, Georges Haimari Street, Achrafieh, Beyrouth, Liban, comme gérant de catégorie A,

- Monsieur Richard HAWEL, directeur de société, demeurant professionnellement au 8, rue Yolande, L-2761 Luxem-

bourg, comme gérant de catégorie B.

Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l'article 17 des statuts de la Société et la société est valablement

engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

II. Le siège social de la société est fixé au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: G. AREND, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 octobre 2014. Relation: EAC/2014/13294. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014160817/437.
(140182672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

T.G.D. Théatre Grand-Ducal, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4951 Bascharage, 56, cité Charles de Gaulles.

R.C.S. Luxembourg F 10.122.

STATUTS

Chapitre I 

er

 - Dénomination, siège, objet, durée

Art. 1 

er

 .  L'association est dénommée Théatre Grand-Ducal, association sans but lucratif selon la loi du 21 avril

1928,sur les associations et les fondations sans Dut lucratif.

Art. 1a. Son siège social est Théâtre Grand-Ducal 56,Cité Charles de Gaulle L-4951 Bascharage

Art. 2. L'association a pour buts: De développer et de promouvoir le théâtre ainsi que toutes autres activités culturelles

b) d'établir des relations entre ses membres et ceux d'associations luxembourgeoises et étrangères poursuivant un but
analogue, d'établir un contact avec d'autres pays ainsi que de présenter le Grand Duché au delà de ses frontières.

Art. 2a. L'association est constituée pour une durée indéterminée.

163527

L

U X E M B O U R G

Chapitre II - Des membres

Art. 3. L'association se compose de membres actifs.

Art. 3a. Le nombre minimum de membres est trois.

Art. 4. Conditions pour être membre actif:
a) être admis en tant que membre actif par vote du conseil d'administration
b) avoir payé la cotisation annuelle.

Art. 5. Les membres peuvent se retirer de l'association moyennant une simple déclaration écrite. La qualité de membre

se perd encore:

a) par non-paiement de la cotisation
b) par l'exclusion prononcée par l'assemblée générale et à majorité des deux tiers des voix pour violation des statuts

ou pour autre motif grave.

Art. 5a. Le membre démissionnaire et le membre exclu n'a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le

remboursement des cotisations.

Chapitre III - Des assemblées générales

Art. 6. Le corps délibérant de l'association est l'assemblée générale.
Elle se compose de la totalité des membres actifs de l'association.
Le conseil d'administration, dénommé ci-après comité directeur a la possibilité de faire appel à la collaboration de

personnes extérieures à l'association et dont la participation est jugée indispensable pour la réalisation d'un spectacle.

Ces collaborateurs n'ont aucun droit de vote à l'assemblée générale.

Art. 7. Seules les décisions de l'assemblée générale engagent l'association.

Art. 8. L'assemblée générale décide à la majorité simple des membres actifs présents, sauf pour la modification des

présents statuts.

Art. 9. Tout vote par procuration est exclu.

Art. 10. En cas de parité des voix, la proposition en discussion est soumise à un scrutin dans le quel, en cas de parité

des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 11. La présence du président, accompagné d'au moins un membre du conseil d'administration, est nécessaire à la

validité des délibérations de l'assemblée générale.

Art. 12. Il y a vote secret si dix pour cent des membres actifs présents le demandent

Art. 13. L'assemblée générale se réunit une fois pas an. En cas de nécessité, une assemblée générale extraordinaire

peut être convoquée par le conseil d'administration.

Art. 14. Pour chaque assemblée générale, tout membre actif doit recevoir une convocation écrite.

Art. 15. Le président dirige les débats de l'assemblée générale.

Art. 16. Toute proposition présentée par un membre actif, par écrit et au moins trois jours avant la date de l'assemblée

générale, est mise à l'ordre du jour.

Art. 17. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées par le secrétaire dans un registre qu'il tient à la dispo-

sition de tous les membres.

Art. 18. Tout membre désigné par l'assemblée générale ou par le président, en accord avec le conseil d'administration,

représente officiellement l'association dans tous les domaines où cela est nécessaire.

Art. 19. Le conseil d'administration est responsable du bon fonctionnement de l'association et est chargé de l'exécution

de toutes les décisions prises par l'assemblée générale.

Art. 20. Tout membre du conseil d'administration est responsable de l'exécution qui lui incombe suivant les articles

21 à 24 des présents statuts.

Chapitre IV - Du conseil d'administration

Art. 21a. Le conseil d'administration se réunit au besoin des affaires et au moins deux fois par semestre de l'année en

cours.

Art. 21b. Le conseil d'administration, organe exécutif, se compose d'au moins trois membres actifs, dont:
1. un président
2. un secrétaire

163528

L

U X E M B O U R G

3. un trésorier.

Art. 22. Le président préside le conseil d'administration et veille à la coordination et à l'efficacité des travaux de celui-

ci. Il représente officiellement l'association dans tous les domaines utiles.

Art. 23. Le secrétaire est responsable des archives de l'association. Il doit informer tous les membres des activités de

l'association.

Art. 24. Le trésorier est responsable de la bonne tenue des comptes. A chaque réunion de l'assemblée générale, il

résume la situation financière de l'association.

Chapitre V

Lors de chaque assemblée, le conseil d'administration fait un rapport détaillé sur les activités de l'association.
Le trésorier présente un rapport détaillé sur la gestion financière de l'association.

Art. 26. Les membres du conseil d'administration seront élus à la majorité simple des voix et au vote secret au cours

de la réunion de l'assemblée générale. Ils seront élus pour la période d'un an. Ils entrent en fonction immédiatement après
leur élection. Chaque membre actif dispose d'autant de voix qu'il y a de membres du conseil d'administration à élire.

Art. 27. Les membres du conseil d'administration sortants sont rééligibles pour une nouvelle période de deux ans.

Chapitre VI - De la cotisation

Art. 28. L'association perçoit, une fois par an, une cotisation. Tout changement de cette cotisation doit être approuvé

par le conseil d'administration. Le montant est fixé: à 15.- € euros pour les membres actifs.

Chapitre VII - Divers

Art. 29. Toute proposition de modification des statuts doit indiquer exactement les modifications à apporter au texte.

Pour entrer en vigueur, elle doit avoir été votée à l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers. Lors du vote, dix
pour cent des membres actifs doivent être présents.

Art. 30. Les membres de l'association ne peuvent recevoir de rétribution pour un travail exécuté que si le conseil

d'administration le décide par deux tiers des voix.

Art. 31. La dissolution de l'association ne peut être décidée que par un vote à la majorité des deux tiers à une réunion

de l'assemblée générale où au moins deux tiers des membres sont présents. En cas de dissolution, la caisse de l'association
revient à une association, société ou à un autre groupement ayant les mêmes buts que TGD, A.s.b.l. Ce groupement sera
désigné par un vote à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration sortants.

Bascharage, le 1 

er

 octobre 2014.

Jean Noesen / Melanie Noesen / Claude Humbert
<i>Le président / La secrétaire / Le Trésorier

Référence de publication: 2014161179/94.
(140183535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

Artec Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 154.428.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of September,
Before Me Roger ARRENSDORFF, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- Mr. KLIMOV Andrey Vladimirovich, entrepreneur, born on January 17, 1976 in Novosibirsk (Russia), residing at

119331, Prospekt Vernadskogo, 25-1-40, Moscow, Russia;

- Mr. GUSEV Gleb Alexandrovich, entrepreneur, born on November 21, 1978 in Novosibirsk (Russia), residing at 28,

rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;

- Mr. YUKHIN Artem Leonidovich, entrepreneur, born on December 21, 1975 in Moscow (Russia), residing at 41,

Burgaass, L-5425 Gostinen;

- Mr. SUKHOVEY Sergey Vladimirovich, entrepreneur, born on October 8, 1976 in Moscow (Russia), residing at 2,

rue Jean Arp, L-8166 Bridel;

- Mr. VALUKENKO Andrey Pavlovich, entrepreneur, born on November 1, 1961 in Moscow (Russia), residing at 20,

Burgaass, L-5425 Gostinen; and

- Mr. GRAYVER Leonard, lawyer, born on September 30, 1974 in Moscow (Russia), residing at 16 Cypress way, Rolling

Hills Est, CA 90274, USA,

163529

L

U X E M B O U R G

Mr. Klimov Andrey Vladimirovich, Mr. Gusev Gleb Alexandrovich, Mr. Yukhin Artem Leonidovich, Mr. Valukenko

Andrey Pavlovich and Mr. Grayver Leonard are represented by Mr. Sukhovey Sergey Vladimirovich, residing at 2, rue
Jean Arp, Bridel, L-8166 Luxembourg, by a virtue of five proxies given under private seal.

Such proxies after having been signed ne varuetur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties, shall

remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing parties are the shareholders of ARTEC EUROPE S.à r.l., established under the laws of Luxembourg,

having its registered address at 2, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, having its share capital of EUR 12.500, and
registered by the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 154.428 (hereinafter, the “Company”),
and incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary then residing in Luxembourg, on 14 July 2010,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1768 of 30 August 2010, and whose articles
have been amended for the last time by a deed received by Camille Mines residing in Capellen, on 23 December 2010,
published in the said Mémorial C, number 648 of 6 April 2011.

The agenda of the meeting is as follows:
1. Waiver the convening notices;
2. Amendment of the Company’s Articles of Association.
The appearing parties represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, all Shareholders waive the

requirement for convening notices considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to revise some articles of the Articles of Association of the Company, which shall henceforth

have the following wording:

Article 3 (Purpose) shall be worded as follows:

“ Art. 3. Purpose.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition and holding of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in

any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and
financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the
creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition,
development and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin
whatsoever.

3.2. An additional purpose of the Company is (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as

well as the transfer by sale, exchange or otherwise of hardware, intellectual and industrial property rights of any kind
(such as patents, trademarks, copyrights), including in particular on software and source codes, and of domain names,
and hardware (ii) the granting licenses on such intellectual and industrial property rights, including in particular on software
and source codes, and on such domain names, and collecting royalties (iii) the holding, the management and the deve-
lopment of such intellectual and industrial property rights, including software, source codes and hardware, and of such
domain names, and (iv) the investing in the acquisition and management of hardware, trademarks and/or other intellectual
property rights of any nature and origin whatsoever.

3.3. The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

3.4. The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

3.5. The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities, whether in the

Grand Duchy of Luxembourg or abroad, which it considers useful for the accomplishment of these purposes.”

Article 17 (Financial year) shall be worded as follows:

“ Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 .”

There being no further items of agenda, the Meeting is closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

deed are estimated at approximately one thousand sixty (EUR 1,060.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

163530

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary, who knows and understands English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who are known to the notary by his/her surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-six septembre,
Par-devant Me Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

- M. KLIMOV Andrey Vladimirovich, entrepreneur, né le 17 janvier 1976 à Novossibirsk (Russie), résidant au n° 119331,

Pro spekt Vernadskogo, 25-1-40, à Moscou en Russie;

- M. GUSEV Gleb Alexandrovich, entrepreneur, né le 21 novembre 1978 à Novossibirsk (Russie), résidant au 28, rue

Jean-Pierre Brasseur, à L-1258 Luxembourg;

- M. YUKHIN Artem Leonidovich, entrepreneur, né le 21 décembre 1975 à Moscou (Russie), résidant au 41, Burgaass,

à L-5425 Gostingen;

- M. SUKHOVEY Sergey Vladimirovich, entrepreneur, né le 8 octobre 1976 à Moscou (Russie), résidant au 2, rue Jean

Arp, à L-8166 Bridel;

- M. VALUKENKO Andrey Pavlovich, entrepreneur, né le 1 

er

 novembre 1961 à Moscou (Russie), résidant au 20,

Burgaass à L-5425 Gostingen; et

- M. GRAYVER Leonard, juriste, né le 30 septembre 1974 à Moscou (Russie), résidant au 16 Cypress way, Rolling Hills

Estates, CA 90274 aux États-Unis,

M. Klimov Andrey Vladimirovich, M. Gusev Gleb Alexandrovich, M. Yukhin Artem Leonidovich, M. Valukenko Andrey

Pavlovich et Mr. Grayver Leonard sont représentés par M. Sukhovey Sergey Vladimirovich, résidant au 2, rue Jean Arp,
à L-8166 Bridel, en vertu de cinq procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des comparants,

resteront jointes au présent acte pour être conservées avec ledit acte par les autorités chargées de l’enregistrement.

Les comparants sont les associés de la société ARTEC EUROPE S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant

son siège social au 2, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, d'un capital social de 12.500,- EUR et enregistrée auprès du
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 154.428 (ci-après «la Société»), constituée le
14 juillet 2010 sur acte de Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1768 du 30 août 2010, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un
acte du notaire Camille Mines, résidant à Capellen, le 23 décembre 2010 et publié audit Mémorial C, numéro 648 du 6
avril 2011.

L’ordre du jour de l’Assemblée générale est le suivant:
1. Dispense des convocations à l’assemblée;
2. Modification des statuts de la Société.
Les comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont demandé au notaire soussigné d’enregistrer ce qui suit:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, tous les Associés renoncent à l’exigence sta-

tutaire fixée en matière de convocation, se considèrent dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été préalablement communiqué.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier certains articles des Statuts de la Société, qui seront désormais libellés comme suit:
L'article 3 (Objet social) sera libellé comme suit:

« Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise et la détention de participations, au Luxembourg ou à l’étranger, dans toutes

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion de ces participations. La Société peut no-
tamment acquérir par voie de souscription, d’achat et d’échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs mobilières, obligations, obligations non garanties, certificats de dépôt et autres instruments de créance et, plus
généralement, toutes valeurs et tous instruments financiers émis par toute entité faisant appel à l’épargne publique ou
non, y compris les sociétés en nom collectif. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou
autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou de toute origine.

3.2 La Société a pour objet complémentaire (i) l’acquisition par voie d’achat, d’inscription ou de toute autre façon ainsi

que la cession par voie de vente, d’échange ou de toute autre façon de droits de propriété sur le matériel, intellectuelle

163531

L

U X E M B O U R G

et industrielle de tout type (brevets, marques de commerce, droits d’auteur), y compris en particulier sur les logiciels et
les codes sources, les noms de domaine et le matériel, (ii) l’octroi de licences sur ces droits de propriété intellectuelle
et industrielle, y compris en particulier sur les logiciels et les codes sources et lesdits noms de domaine et la collecte des
redevances, (iii) la détention, la gestion et le développement desdits droits de propriété intellectuelle et industrielle, y
compris sur des logiciels, codes sources, matériels et noms de domaine et (iv) l’investissement dans l’acquisition et la
gestion de matériel, marques de commerce et/ou autres droits de propriété intellectuelle de toute nature et de toute
origine.

3.3 La Société peut en outre garantir, octroyer des sûretés, accorder des prêts ou assister autrement les sociétés dans

lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie
du même groupe de sociétés que la Société.

3.4 La Société peut, sauf par appel public à l’épargne, lever des fonds notamment par voie d’emprunt sous quelque

forme que ce soit ou en émettant tous types d’effets, valeurs mobilières ou instruments de créance, obligations et obli-
gations non garanties et peut généralement émettre des valeurs mobilières de toute nature.

3.5.  La  Société  peut  effectuer  toutes  activités  commerciales,  industrielles,  financières  ou  en  matière  de  propriété

intellectuelle, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, qu'elle juge utiles pour la réalisation de ces objectifs.»

L'article 17 (Exercice social) sera libellé comme suit:

« Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.»

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée est levée.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait du présent acte sont

estimés à environ mille soixante (1.060,-) euros.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît et comprend l’anglais, déclare qu'à la requête des comparants susnommés, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la demande de ces mêmes personnes, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Ce document ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et lieu de résidence, ladite

personne ayant signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: SUKHOVEY, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 octobre 2014. Relation: LAC / 2014 / 46189. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 15 octobre 2014.

Référence de publication: 2014160648/165.
(140182636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

CEES Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 165.454.

Im Jahre zweitausendvierzehn,
den achten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jacques CASTEL, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft «Lampe Alternative Investments S.A., SICAV-FIS», (früher: CEE Sidefund I S.A., SICAV-FIS),

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable
- fonds d'investissement spécialisé), mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler, eingetragen im Handelsre-
gister Luxemburg unter der Nummer B 160.571,

hier vertreten durch:
- Herrn Alain NATI, beruflich wohnhaft zu L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler, handelnd in seiner Eigenschaft

als Verwaltungsratsmitglied, und

- Herrn Cornelius BECHTEL, beruflich wohnhaft zu L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler, handelnd in seiner

Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied,

163532

L

U X E M B O U R G

beide handelnd auf Grund eines Beschlusses, welcher in der Gründungsversammlung der Gesellschaft am 21. April

2011 gefasst wurde, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 1607 vom 19.
Juli 2011 sowie in Übereinstimmung von Artikel 19.3 der Gesellschaftsstatuten,

beide vorgenannten hier selbst vertreten durch Saskia SANDER, beruflich wohnhaft zu L-6776 Grevenmacher, 15, rue

de Flaxweiler,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben zu Grevenmacher, am 22. September 2014,
welche Vollmacht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welche Komparentin, hier vertreten wie vorgangs erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht um Folgendes zu

beurkunden:

Die Aktiengesellschaft “Lampe Alternative Investments S.A., SICAV-FIS, (früher: CEE Sidefund I S.A., SICAV-FIS)“ ist

die einzige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „CEES INVEST SARL“, mit Sitz zu L-5365 Muns-
bach, 18-20, rue Gabriel Lippmmann, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 165.454,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean-Joseph WAGNER aus Sassenheim am 6. Dezember

2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 257 vom 31. Januar 2012,
welche Statuten zum letzten Mal abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean-Paul MEYERS
aus  Rambrouch  am  11.  Dezember  2013,  veröffentlicht  im  Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et  Associations,
Nummer 105 vom 13. Januar 2014.

Die alleinige Gesellschafterin ersucht den amtierenden Notar um ihre gefassten Beschlüsse wie folgt zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Sie beschließt den Gesellschaftssitz von Munsbach nach Grevenmacher, mit Rückwirkung vom 22. September 2014,

zu verlegen und dementsprechend Artikel 2, Absatz 1 der Statuten abzuändern wie folgt:

“ Art. 2. Gesellschaftssitz, Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.“.

<i>Zweiter Beschluss.

Sie beschließt die Adresse der Gesellschaft in L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler festzulegen.
Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler, Datum wie eingangs erwähnt,

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort
bekannte Komparentin, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. Sander, J. Castel.
Enregistré à Grevenmacher, le 09 octobre 2014. Relation: GRE/2014/3961. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

<i>Der Einnehmer

 (gezeichnet): Schlink.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister so-

wie zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Grevenmacher, den 14. Oktober 2014.

J. Castel
<i>Der Notar

Référence de publication: 2014160719/57.
(140182605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

CEP II Nelson SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 191.033.

STATUTS

<i>Extrait

I/ La Société, CEP III Nelson SCSp, une société en commandite spéciale, a été constituée par acte sous seing prive

signe en date du 1 

er

 octobre 2014 pour une durée illimitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

II/ Il résulte du contrat social que l'objet social de la Société s'inscrit comme suit:
La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous

quelque forme que ce soit dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger,

163533

L

U X E M B O U R G

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété Intellectuelle de toute origine, et participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise.

La Société peut, dans ce même contexte, acquérir, céder et investir dans des prêts, actions, émissions de parts sociales,

obligations, titres, notes, avances, parts, mandats et autres sûretés.

Elle peut également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre

manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de
cession, d'échange ou autrement. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés
ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés
auquel appartient la Société (notamment par exemple, ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou im-

mobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directe-
ment ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut emprunter sous toute forme que ce soit y compris par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par

voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, con-
vertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La
Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.

III/ Il résulte du contrat social que la société suivante a été nommée en tant qu'associé commandité assurant les pouvoirs

de gérance de la Société pour une durée illimitée:

- CEP III Nelson GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, ayant son siège sociale au

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191012.

Son pouvoir est inscrit comme suit:
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son associé commandité représenté par ses

signataires dûment autorisés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, 17 octobre 2014.

Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2014161344/51.
(140184212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2014.

Group George Forrest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 46.803.

L'an deux mille quatorze, le premier jour du mois d’octobre.
Par  devant  Maître  Joseph  Elvinger,  notaire  de  résidence  à  15,  côte  d’Eich,  L-1450  Luxembourg,  Grand-Duché  de

Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

- Groupe Forrest Luxembourg S.à r.l.-S.P.F, société de droit luxembourgeois enregistrée au registre de commerce et

des sociétés sous le numéro B 158753 avec adresse du siège social au 11, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof, Grand-
Duché du Luxembourg;

- Monsieur Pierre Albert Pairoux, né le 1 

er

 novembre 1933 à Vilvorde (Belgique), résidant au 21, rue des Trois Héros,

B-1370 Jodoigne, Belgique;

- Groupe Forrest International S.A., société anonyme enregistrée sous le numéro 0833.585.336 avec adresse du siège

social au 9, Avenue Pasteur à B-1000 Wavre, Belgique.

(désignés ensemble comme les «Associés»).
Ici dûment représentés par Mme Flora Gibert, résidant professionnellement au 15, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seings privés.

163534

L

U X E M B O U R G

Lesdites procurations, paraphées «ne varietur» par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et le notaire

instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- Les parties comparantes détiennent 26,830 actions de GROUP GEORGE FORREST S.A., une société anonyme de

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 22, rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro B 46803, constituée
suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 février 1994, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C numéro 221, le 6 juin 1994.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence

à Mondorf-les-Bains, en date du 22 novembre 2013, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 18 le 3 janvier 2014
(les “Statuts”) (la «Société»).

II.- Que les 26.830 actions, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que

l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont les Associés reconnaissent avoir
été dûment préalablement informé.

III.- L’ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1) Renonciation des Associés aux formalités de convocation à la présente assemblée générale;
2) Transfert du siège social de la société du 22, rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg au 11, rue de l'Industrie,

L-8399 Windhof;

3) Modification de l'article 2 des statuts concernant le siège social de la société.
4) Nomination de l'administrateur de catégorie B
Suite à l'approbation de ce qui précède par les Associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

L'entièreté du capital social étant représentée, l'assemblée générale renonce aux formalités de convocation, les As-

sociés représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du
jour préalablement communiqué.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 22, rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg au

11, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof.

<i>Troisième résolution:

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le siège de la société est établi à Windhof.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière»

<i>Quatrième résolution:

L'assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur de catégorie B Madame Muriel Bourgeois avec adresse

professionnelle au 11, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof. La durée du mandat est déterminée et durera jusqu’à l'assemblée
générale qui se tiendra en 2018.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec cet acte, ont été estimés à environ mille euros (EUR 1.000,-).

Aucun autre point n’ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

163535

L

U X E M B O U R G

Dont acte fait et passé à Luxembourg, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire des comparantes, elles ont signé avec nous, notaire, l'original

du présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 2 octobre 2014. Relation: LAC/2014/45879. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-)

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014160847/81.
(140182961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

Precisé S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, Z. I. Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 96.222.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUDWIG CONSULT S.A.R.L.
<i>EXPERTS COMPTABLES - FIDUCIAIRE
31, OP DER HECKMILL - L-6783 GREVENMACHER
Signature

Référence de publication: 2014164273/13.
(140186339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Partinverd S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.700.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 98.360.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2014 que:
1. Le transfert du siège social du 412F Route d'Esch, L - 2086 Luxembourg au 45, avenue de la Liberté, L-1931 Lu-

xembourg, est approuvé;

2. Les démissions de Messieurs Jean-Robert BARTOLINI et Thierry JACOB de leur mandat de gérant de catégorie B

de la société sont acceptées;

3. Les nominations de Mr Stéphane ALLART, expert-comptable, né le 19 février 1981 à Uccle (Belgique), résidant

professionnellement au 45 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, et de Mr Pierre MESTDAGH, employé privé, né le
21 novembre 1961 à Etterbeek (Belgique), résidant professionnellement au 45 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
comme gérants de catégorie B, sont acceptées.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg.

Référence de publication: 2014164260/21.
(140187235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Pasteur Hair &amp; Style s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 34, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 146.656.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014164262/9.
(140186392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

163536


Document Outline

Ampacet Europe Holding S.à r.l.

Artec Europe S.à r.l.

Assaloca SICAV-SIF, SCA

CBG Alternative Sicav

CBRE Global Holdings

CEES Invest Sàrl

CEF (W) SA

CEP II Nelson SCSp

CEREP Ashley S.à r.l.

Chevrotine S.A.

Chevrotine S.A., SPF

CITIC CWEI Renewables S.C.A.

Compagnie Finance Ponte Carlo S.A.

Compagnie Financière et Commerciale du Parc SA

Consulting &amp; Co. S.A.

Coppart Holding S.A. SPF

Coprez Partners S.A.

CWEI (Europe) S.A.

CWEI (Luxembourg) Energy S.à r.l.

CWEI (Luxembourg) Investment Management S.à r.l.

CWEI (Luxembourg) Power S.à r.l.

D.A.S. Luxemburg Allgemeine Rechtsschutz-Versicherung S.A.

Data Genpar S.à r.l.

Data Genpar S.à r.l.

DCC Euro S.à r.l.

DCC Finance S.à r.l.

DCC Funding S.à r.l.

Deep Sea Minerals Investment Limited

Demeter Luxembourg S.A.

Destiny Invest S.A.

Deutsche Oel &amp; Gas S.A.

DIF Infra 3 Luxembourg S.à r.l.

DISBOLUX (Distribution de Boissons Luxembourg) Sàrl

Divisional Funding S.à r.l.

Dundeal (International) 22 S.à r.l.

Dundee Realty Acquisitions SCS

Entreprise de Construction G. THOMAS

Global Gate Delta (Lux) 3

Group George Forrest S.A.

Johnson Controls Luxembourg Solutions S.à r.l.

KÖHL Aktiengesellschaft

Lion Systems S.A.

Partinverd S.à r.l.

Pasteur Hair &amp; Style s.à r.l.

Precisé S.à.r.l.

Prestige Euro-Trading S.A.

Sigma Capital Investments S.A.

Sopinor Constructions S.A.

T.G.D. Théatre Grand-Ducal

T.S. aerospace

Unicorp Seeds S.A.