This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2608
26 septembre 2014
SOMMAIRE
ABI CEE Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
125161
Aerium Erlangen Holdings S.à r.l. . . . . . . .
125181
AFP (Germany) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
125160
Albatros Son Holding BV & Cie. . . . . . . . . .
125161
Almacantar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125161
Al-Tat Doner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125183
Benelom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125166
BF Immo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125166
BIM S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125170
Boing Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125166
Cadanor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125170
Cambaceres France Holdings AREII (Lu-
xembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125159
Can Benelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125160
Capoffice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125170
CASHMERE Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125170
Compagnie Maritime Monégasque Inter-
national II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125167
Corpus Sireo Investment Residential No.
14 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125168
CORPUS SIREO Investment Residential
No. 21 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125169
CORPUS SIREO Investment Residential
No. 23 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125167
Croq'Chalet Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125168
Darwin International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
125165
DB Equity S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125167
DB Valoren S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125143
Débardage et Exploitation Forestiers . . . .
125167
Delphea S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125168
Développement & Rénovation Sàrl . . . . . .
125159
Dewey S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125165
Dexris Terminus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125168
Diorama Investments Sicar, S.A. . . . . . . . .
125143
DL Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125169
DMD S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125143
Double Eagle Capt Company . . . . . . . . . . . .
125169
Dupuis Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
125184
Dyonas S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125159
E.B. Trans S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125184
Electro Sud S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125172
EnergyMixx Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
125160
European Assist S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125169
E.V.A.F. Luxembourg (Highstreet) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125184
GMT Spanext S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125171
Goba Cardinal S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125181
Gottschol Alcuilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
125171
Heisdorf Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .
125160
Hypo Pfandbrief Bank International S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125171
Insurance Participations Company . . . . . .
125162
Jazz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125162
KKR Retail Partners (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125165
Lear East European Operations . . . . . . . . .
125155
Le Grand Chêne S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125165
LOGOS IT Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
125138
London Transit Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
125164
Scandium Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
125173
Sirius Group Holdings (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125163
St. Georges Investment S.A. - SPF . . . . . . .
125161
Taché Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
125142
Umicore International . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125162
Vatoa Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125163
Vazon Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
125163
WD Nonntal S.C.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125164
YELLOW T International S.A. . . . . . . . . . .
125164
125137
L
U X E M B O U R G
LOGOS IT Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 65.954.
L'an deux mille quatorze, le onze septembre.
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
S’est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois “LOGOS IT
SERVICES S.A.”, avec siège social à L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thionville, Résidence des Jardins, constituée
originairement sous la forme d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant la dénomination “LO-
GOS Inc S.à r.l.” suivant acte reçu par le notaire Paul BETTINGEN, de résidence à Niederanven, en date du 15 juillet
1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 797 du 30 octobre 1998, dont les
statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Carlo WERSANDT,
de résidence à Luxembourg, en date du 6 novembre 2013, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 71 du 8 janvier 2014, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B
et le 65.954.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lionel CAPIAUX, employé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxem-
bourg, 15, boulevard Roosevelt,
qui désigne comme secrétaire Madame Oana ARON, employée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxem-
bourg, 15, boulevard Roosevelt.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michael DUCHENE, employé, demeurant professionnellement à
L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Ladite liste de présence ainsi que les procurations
resteront, après avoir été signés “ ne varietur ” par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, annexés au
présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
1. Refonte de l’objet social et modification subséquente de l’article 4 qui sera désormais lu comme suit:
« Art. 4. La société a pour objet toutes prestations informatiques ainsi que toutes activités connexes et annexes.
La société exerce également l’activité d'opérateur des systèmes informatiques primaires du secteur financier et d'opé-
rateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication selon les articles 29-3 et 29-4 de la loi
du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée.
Elle peut aussi faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se
rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.»
2. Modification du premier paragraphe de l’article 6 des statuts qui prendra à compter de ce jour la teneur suivante:
« Art. 6. paragraphe 1. Les actions de la société sont exclusivement nominatives.»
3. Modification de l’article 12 des statuts qui sera lu comme suit:
« Art. 12. Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs, relatifs à la gestion journalière des affaires de la
société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à au moins deux directeurs en charge de la gestion
journalière, agréés par la CSSF, administrateurs ou non, qui porteront le titre de “directeurs-délégués à la gestion jour-
nalière».
Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être ad-
ministrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.»
4. Refonte de l’article 14 des statuts ayant trait à la signature sociale:
« Art. 14. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux
administrateurs, soit par la signature individuelle de l’un des directeurs-délégués à la gestion journalière, sans préjudice
des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d'administration en vertu de l’article 12 des statuts.»
5. Modification de l’article 15 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
125138
L
U X E M B O U R G
« Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) qui justifie(nt) d'une expérience
professionnelle adéquate, nommé(s) par le conseil d'administration, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que
la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six ans. Le conseil d'administration de la société peut révoquer le(s)
réviseur(s) d'entreprises agréé(s) à tout moment.
Le(s) réviseur(s) d'entreprises agréé(s) est (sont) rééligibles.»
6. Insertion dans les statuts, outre la référence à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
la référence à la loi du 5 avril 1993, relative au secteur financier, telle que modifiée, et modification subséquente des
articles 11 paragraphe 2 et 23.
7. Suppression de l’expression «administrateur unique» dans les statuts et son remplacement par l’expression «conseil
d’administration».
8. Modification subséquente des articles des statuts concernés et refonte complète des statuts.
9. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de refondre l’objet social et de modifier par conséquence l’article 4 qui sera désormais
lu comme suit:
« Art. 4. La société a pour objet toutes prestations informatiques ainsi que toutes activités connexes et annexes.
La société exerce également l’activité d'opérateur des systèmes informatiques primaires du secteur financier et d'opé-
rateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication selon les articles 29-3 et 29-4 de la loi
du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée.
Elle peut aussi faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se
rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article 6 des statuts qui prendra à compter de ce
jour la teneur suivante:
« Art. 6. paragraphe 1. Les actions de la société sont exclusivement nominatives.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts comme suit:
« Art. 12. Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs, relatifs à la gestion journalière des affaires de la
société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à au moins deux directeurs en charge de la gestion
journalière, agréés par la CSSF, administrateurs ou non, qui porteront le titre de «directeurs-délégués à la gestion jour-
nalière.»
Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être ad-
ministrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de refondre l’article 14 des statuts ayant trait à la signature sociale qui sera lu comme
suit:
« Art. 14. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux
administrateurs, soit par la signature individuelle de l’un des directeurs-délégués à la gestion journalière, sans préjudice
des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d'administration en vertu de l’article 12 des statuts.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 15 des statuts qui prendra dorénavant la teneur suivante:
« Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) qui justifie(nt) d'une expérience
professionnelle adéquate nommé(s) par le conseil d'administration, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que
la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six ans. Le conseil d'administration de la société peut révoquer le(s)
réviseur(s) d'entreprises agréé(s) à tout moment.
Le(s) réviseur(s) d'entreprises agréé(s) est (sont) rééligibles.»
125139
L
U X E M B O U R G
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’insérer également dans les statuts, outre la référence à la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée, la référence à la loi du 5 avril 1993, relative au secteur financier, telle que
modifiée.
En conséquence de la résolution qui précède, les articles 11 paragraphe 2 et 23 sont modifiés comme suit:
« Art. 11. paragraphe 2. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée, la loi du 5 avril 1993, relative au secteur financier telle que modifiée, ou encore
par les statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.»
« Art. 23. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que loi du 5 avril 1993, relative
au secteur financier telle que modifiée, trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents
statuts.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer toute référence dans les statuts à l’expression «administrateur unique» et
de la remplacer par l’expression «conseil d’administration».
<i>Huitième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de refondre intégralement les statuts qui
prendront à compter de ce jour la teneur suivante:
«Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. II existe une société anonyme sous la dénomination de «LOGOS IT Services S.A.».
Art. 2. Le siège de la société est établi à Alzingen.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une
résolution de l’actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l’assemblée générale
des actionnaires.
Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout,
selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l’étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes prestations informatiques ainsi que toutes activités connexes et annexes.
La société exerce également l’activité d'opérateur des systèmes informatiques primaires du secteur financier et d'opé-
rateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication selon les articles 29-3 et 29-4 de la loi
du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée.
Elle peut aussi faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se
rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent soixante-dix mille euros (370.000,- EUR), représenté par mille deux cent
quarante (1.240) actions, chacune sans désignation de valeur nominale.
Art. 6. Les actions de la société sont exclusivement nominatives.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs.
Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire pat action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés
jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.
Administration - Surveillance
Art. 8. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours
révocables par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration.
En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent
désigné à cet effet.
125140
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration, Sauf le cas d'urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-
blement représentés.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement; représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.
Art. 10. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans
un registre spécial et signé par au moins un des administrateurs.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par deux
administrateurs.
Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition
et d'administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée, la loi du 5 avril 1993, relative au secteur financier telle que modifiée, ou encore par les statuts de la
société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.
Art. 12. Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs, relatifs à la gestion journalière des affaires de la
société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à au moins deux directeurs en charge de la gestion
journalière, agréés par la CSSF, administrateurs ou non, qui porteront le titre de “directeurs-délégués à la gestion jour-
nalière».
Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être ad-
ministrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 13. Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 14. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux
administrateurs, soit par la signature individuelle de l’un des directeurs-délégués à la gestion journalière, sans préjudice
des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d'administration en vertu de l’article 12 des statuts.
Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) qui justifie(nt) d'une expérience
professionnelle adéquate nommé(s) par le conseil d'administration, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que
la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six ans. Le conseil d'administration de la société peut révoquer le(s)
réviseur(s) d'entreprises agréé(s) à tout moment.
Le(s) réviseur(s) d'entreprises agréé(s) est (sont) rééligibles.
Assemblées
Art. 16. S'il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais
prévus par la loi.
Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation,
le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou le(s) commis-
saire(s) aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant dix pourcent (10%) du
capital social.
Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.
125141
L
U X E M B O U R G
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des Bénéfices
Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 21. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pourcent (5%) au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pourcent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 22. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale ou par l’actionnaire unique qui déterminera leurs pouvoirs et
leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 23. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que loi du 5 avril 1993, relative
au secteur financier telle que modifiée, trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents
statuts».
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les
membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: L. CAPIAUX, O. ARON, M. DUCHENE, E. SCHLESSER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 septembre 2014. Relation: LAC/2014/42833. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2014.
Référence de publication: 2014147515/244.
(140167923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.
Taché Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1527 Luxembourg, 52, rue du Maréchal Foch.
R.C.S. Luxembourg B 87.621.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2014.
Taché Investments S.A.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Director Ai>
Référence de publication: 2014110041/15.
(140131145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
125142
L
U X E M B O U R G
DMD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.
R.C.S. Luxembourg B 72.049.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106552/9.
(140127249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
DB Valoren S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 111.379.
Die Bilanz zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DB Valoren S.à r.l.
Référence de publication: 2014106509/10.
(140127234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Diorama Investments Sicar, S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Ca-
pital à Risque.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 190.311.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the twelfth day of September.
Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mr Dimitrios DASKALOPOULOS, born in Athens on 18
th
January 1957, residing professionally in 89, Amaroussiou-
Halandriou Street, GR-15233 Halandri, Greece
here represented by Mrs Marie-José FERNANDES, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
on 9
th
September 2014.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be registered therewith.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a société anonyme par qualifying as a société d’investissement en capital à risque (SICAR) and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
Art. 1. Name. There exists among the subscriber and all those who may become holders of Shares, a company in the
form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement en capital à risque" (“Sicar”) with multiple com-
partments under the name of "Diorama Investments Sicar, S.A." (the “Company”).
The Company shall be governed by the law of 15 June 2004 relating to the Société d’investissement en capital à risque
(SICAR) as amended.
For the purpose of the law of July 12, 2013 on Alternative Investment Fund Managers (“AIFM Law”), the Company is
an "externally managed AIF" with DECA INVESTMENTS S.A. AIFM as its external alternative investment fund manager.
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
However, the Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of the Shareholders subject
to the quorum and majority requirements for the amendment of these Articles after approval of the Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
Art. 3. Purpose. The purpose of the Company is the investment of the funds available to it in risk capital within the
widest meaning permitted under article one of the law of 15 June 2004 concerning the société d’investissement en capital
à risque, as amended. The Company may also invest the funds available to it in any other assets permitted by law and
consistent with its purpose. Furthermore, the Company may take any measures and carry out any transactions which it
may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the fullest extent permitted under the law of 15
June 2004 concerning the société d’investissement en capital à risque as may be amended from time to time (the “2004
Law”).
125143
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy
of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board
of Directors (the "Board" or the "Directors").
In the event that the Board determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent
that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Com-
pany which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 5. Capital. The capital of the Company shall be represented by fully paid-up registered Shares of no par value and
shall at any time be equal to the total net assets of the various Sub-Funds of the Company pursuant to Article 21 hereof.
The minimum capital shall be as provided by law, i.e., one million euro (€ 1.000.000.-). The minimum capital of the
Company must be achieved within 12 months after the date on which the Company has been authorized as a Sicar under
Luxembourg law.
For consolidation purposes, the base currency of the Company is the Euro (EUR).
The initial capital of the Company was thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into thirty one (31) fully paid
up Shares of no par value.
The Share capital of the Company will be equal, at any time, to its net assets.
Art. 6. Sub-Funds. The Board of Directors of the Company may, at any time, establish several portfolios of assets, each
constituting a sub-fund (hereinafter referred to as a “Sub-Fund”), a “compartiment” within the meaning of Article 3 of
the Luxembourg Law dated 15 June 2004 concerning the société d’investissement en capital à risque as may be amended
from time to time.
The Board of Directors shall attribute specific investment objectives and policies and denomination to each Sub-Fund.
The board of directors of the Company may, at any time, within each Sub-Fund, issue different Classes of Shares
(hereinafter referred to as a “Class” or “Classes”) which may differ in, inter alia, their issue price, sales charge structure,
reference currency, minimum investment requirements and management fees, in the attribution of the Company's per-
formance applying to them or type of target investors.
Art. 7. Issue and Transfer of Shares. Shares are exclusively restricted to Institutional Investors, Professional Investors
or Well-informed Investors within the meaning of article 2 of the law of 15 June 2004 concerning the société d’investis-
sement en capital à risque (the "Eligible Investors").
The Directors may decide to issue Shares with non-voting rights in conformity with the applicable articles of the Law
of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time. The Shares that carry non-voting rights will
have the right to participate preferentially to the benefits of the Company as defined in the Company’s prospectus. The
Shares carrying voting rights will participate equally to the decision of the Company independently of their value. The
voting right must be exercised in compliance with Luxembourg law and the Articles.
The Directors may decide to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities or other assets,
provided that such securities or others assets comply with the investment policy of the Company and with the conditions
set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to receive a report from the auditor on the valuation which
shall be available for inspection. Any cost incurred with a contribution in kind shall be borne by the relevant Shareholders.
The Directors may decide to issue Shares in registered form only. If a registered Shareholder desires that more than
one Share certificate be issued for his Shares, customary costs may be charged to him.
No charge may be made on the issue of a certificate for the balance of a shareholding following a transfer or redemption
of Shares. Share certificates shall be signed by two Directors or by a Director and an official duly authorized by the Board
for such purpose. Signatures of the Directors may either be manual or printed or by facsimile. The signature of the
authorized official shall be manual. The Company may issue temporary Share certificates in such form as the Board may
from time to time determine.
After the initial offering period, Shares may be issued at any time at the discretion of the Board and shall be issued
only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the price, being the Net Asset Value per Share, as
set forth in Article 21 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of definitive Share certificates or,
subject as aforesaid, a confirmation of his shareholding.
All issued registered Shares shall be inscribed in the Register, which shall be kept by the Company or by one person
designated therefore by the Company and the Register shall contain the name of each holder of registered Shares, his
residence or domicile and the number of Shares held by him (and in the case of joint holders the first named joint holder's
address only). Every transfer of a registered Share shall be entered in the Register upon payment of such customary fee
as shall have been approved by the Directors.
Payments of dividends, if any, will be made to Shareholders, in respect of registered Shares, at their addresses in the
register of Shareholders (the "Register") or to such other address given to the Directors in writing.
125144
L
U X E M B O U R G
Shares can only be transferred to investors fulfilling the eligibility requirements of well-informed investors as set-out
in article 2 of 2004 Law, but shall otherwise be free from any restriction on the right of transfer and from any lien in
favour of the Company. A transfer of Shares will entail the transfer of the obligations attached thereto.
Transfer of registered Shares shall be effected by delivering the Certificate or Certificates, if any, to the Company
along with such other instruments of transfer satisfactory to the Company or by a written declaration of transfer entered
in the Register, dated and signed by the transferor and by the transferee, or by persons holding suitable powers of attorney
to act therefore.
Every registered Shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements
from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders.
In the event that a Shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered in the Register and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company or
such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to
the Company by such Shareholder. The Shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register by
means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the
Company from time to time.
Fractions of registered Shares may be issued, if the Board so decides, up to three decimal places. Fractions of Shares
will not entitle to vote but shall, to the extent the Company shall so determine, entitle to a corresponding fraction of a
dividend or liquidation proceeds.
Art. 8. Redemption of Shares. The Company is a closed-end Sicar. Consequently, Shares in the Company shall not be
redeemable at the request of a Shareholder.
The Company may redeem Shares of any Sub-Fund whenever the Board considers this to be in the best interests of
the Company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by law and these
Articles. In particular, Shares may, at the option of the board of directors, be redeemed on a pro rata basis as between
existing Shareholders of the concerned Sub-Fund, in order to distribute to the Shareholders upon the disposal of an
investment asset by the Company the net proceeds of such investment, notwithstanding any other distribution.
The Company may offer to redeem up to a specified maximum number of Shares of each Sub-Fund to the extent that
Shareholders voluntarily tender Shares for redemption. In any such case the Shares tendered for redemption by Share-
holders will be redeemed by the Company to the maximum extent possible without exceeding the number of Shares the
Company has offered to redeem and any reductions in Shares redeemed below the total number of Shares tendered will
be pro rata to the number of Shares tendered by Shareholders. The redemption price shall be the Net Asset Value per
Share determined in accordance with the provisions of Article 21 as at the Valuation Day specified by the Board in its
discretion, less an amount equal to any duties and charges which will be incurred upon the disposal of the Company's
investments as at the date of redemption in order to fund such a redemption.
The redemption price per Share shall be paid within a period as determined by the Board which shall normally not
exceed fourteen business days from the relevant Valuation Day, provided that the Company has received the Share
certificates (if any) or such other evidence of title or ownership satisfactory to it Payment of redemption monies is
normally made in euro, or in such other currency as the Board may determine.
Payment of redemptions proceeds may be delayed if there are any specific statutory provisions such as foreign exchange
restrictions or any circumstances beyond the Company's control which make it impossible or impracticable to realise an
Investment or to repatriate any sale proceeds or to transfer the redemption proceeds to the country where the re-
demption was requested.
All redeemed Shares shall be cancelled.
The Company may redeem all outstanding Shares of any Sub-Fund at any time in the following circumstances:
(i) if any law is passed which renders it illegal, or in the reasonable opinion of the Directors, impracticable or inadvisable
to continue the Company or the Sub-Fund; or
(ii) if in the reasonable opinion of the Directors, there is any material adverse change in the tax treatment of the
Company or the Sub-Fund; or
(iii) if in the opinion of the Directors there is a change in the markets in which the Sub-Fund or the Company invests
which causes the Directors to believe after consultation with the Investment Manager that there is no longer any rea-
sonable profit potential for the Shareholder.
The Company may redeem all outstanding Shares on the Termination Date. Subject to Shareholders prior approval,
the Company may make distributions in specie to Shareholders provided that an independent valuation of assets to be
so distributed is obtained from the auditors of the Company.
In the above cases the Company will be liquidated in accordance with article 27 hereof.
Art. 9. Loss or destruction of Share certificates. If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that
his Share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate Share certificate may be
issued under such conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance company but without restriction
125145
L
U X E M B O U R G
thereto, as the Company may determine. At the issuance of the new Share certificate, on which it shall be recorded that
it is a duplicate, the original Share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.
The Company may, at its choice, charge the Shareholder any exceptional reasonable out of pocket expenses incurred
in issuing a duplicate or a new Share certificate in substitution for one mislaid, mutilated or destroyed.
Art. 10. Limitation to the ownership of Shares. The Company may restrict or prevent the direct and indirect ownership
of Shares in the Company by any natural person, firm, partnership or legal entity (such natural persons, firms, partnerships
or legal entities to be determined by the Board of Directors and herein referred to as “Prohibited Persons” or individually
to as a “Prohibited Person”) if, in the sole opinion of the Company, such holding may be detrimental to the interests of
the existing Shareholders or of the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg
or foreign, if as a result thereof the Company may become subject to taxation in a country other than the Grand Duchy
of Luxembourg or exposed to tax disadvantages, fines or penalties that it would not have otherwise incurred, or if it may
otherwise be detrimental to the Company or its existing Shareholders. The terms “Prohibited Person” and “Prohibited
Persons” as used herein include, among others, any non Eligible Investor as well as, if applicable, any “United States
Person” (as defined hereafter).
For such purposes, the Company may, at its discretion and without liability:
a) decline to issue any Shares or to register any transfer of Shares if such issue or transfer may result in the ownership
of the Shares by a person who is not authorized to hold Shares in the Company;
b) at any time require any person whose name is entered in the register of Shareholders to furnish it with any infor-
mation, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial
ownership of such Shareholder's Share rests or will rest in a person who is precluded from holding Shares in the Company;
c) proceed with the compulsory redemption of all the Shares if it appears that a person who is not authorized to hold
Shares in the Company, either alone or together with other persons, is the owner of Shares in the Company, or proceed
with the compulsory redemption of all or a part of the Shares, if it appears to the Company that one or several person
(s) own(s) Shares in the Company in a manner that may be detrimental to the Company or its existing Shareholders. In
such case, the following procedure shall be applied:
1. The Company shall serve a notice (the "purchase notice") upon the Shareholder holding such Shares or appearing
in the register of Shareholders as the owner of the Shares to be purchased, specifying the Shares to be purchased as
aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.
Any such notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a pre-paid envelope addressed to such
Shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company.
Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such Shareholder shall cease to
be the owner of the Shares specified in such notice and, in the case of registered Shares, his name shall be removed from
the register of Shareholders.
2. The purchase price at which each Share is to be purchased ("the purchase price") shall be that payable for redemption
under Article 8 hereof.
3. Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such Shares in euro or in such other
currency as the Board may determine and will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in
Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) upon the final determination of the purchase price fol-
lowing surrender of the Share certificate or certificates (if any) specified in such notice. Upon service of the purchase
notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such Shares or any of them, nor any claim against
the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such
bank following surrender of Share certificates, if any, or other provision of evidence of title or ownership satisfactory to
the Company as aforesaid. Any funds receivable by a Shareholder under this paragraph, but not collected within a period
of five years from the date specified in the purchase notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the Company.
The Directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorise
such action on behalf of the Company.
4. The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of the Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided in such case
the said powers were exercised by the Company in good faith.
Whenever used in these Articles, the term "US Person" means any citizen or resident of the United States, any
corporation, partnership or other entity created or organized in or under the laws of the United States, or any person
falling within the definition of the term "US Person" under Regulation S promulgated under the United States Securities
Act of 1933, as amended from time to time.
US Person as used herein does not include any subscriber to Shares of the Company issued in connection with the
incorporation of the Company whilst such subscriber holds such Shares or any securities dealer who acquires Shares
with a view to their distribution in connection with an issue of Shares by the Company.
Art. 11. Annual General Meeting. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Lu-
xembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be
125146
L
U X E M B O U R G
specified in the notice of meeting, at 10 a.m. on the 30
th
of June each year. If such day is not a business day in Luxembourg,
the annual general meeting shall be held on the preceding business day in Luxembourg. However, the first annual general
meeting of Shareholders can be held at another date, specified in the transitional provisions hereafter, in order to be held
within eighteen months following the Company’s incorporation, in accordance with article 70 of the Luxembourg law of
August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.
The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional
circumstances so require.
Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 12. Functioning of Shareholders’ meetings. Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein
or in the Prospectus, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority vote of
those present and voting. Only Shares carrying voting rights are entitled to participate equally to the decisions indepen-
dently of their value subject to the limitations imposed by these Articles. Fractions of Shares do not give their holders
any voting right. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in
writing or by cable, telegram, or fax message.
A corporation may execute a proxy under the hand of a duly authorised officer.
The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any
meeting of Shareholders.
Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of
the Company. Its resolutions shall be binding upon all Shareholders of the Company.
The general meeting of Shareholders shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Company.
The requirements relating to general meeting (as described below), unless otherwise provided herein, are those out-
lined in the Luxembourg law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.
In accordance with the Luxembourg law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended, any
resolution of the general meeting of Shareholders of the Company, affecting the rights of the holders of Shares of any
Sub-Fund, Class or type vis-à-vis the rights of the holders of Shares of any other Sub-Fund or Sub-Funds, Class or Classes,
type or types shall be subject to a resolution of the general meeting of Shareholders of such Sub-Fund or Sub-Funds, Class
or Classes, type or types. The resolutions, in order to be valid, must be adopted in compliance with the quorum and
majority requirements referred to in article 12 hereof, with respect to each Sub-Fund, each Class or each type concerned.
Shareholders shall meet upon call by the Board pursuant to a written notice setting forth the agenda and sent at least
eight (8) days prior to the meeting to each registered Shareholder at the Shareholder's address in the register of Share-
holders. The giving of such notice to registered Shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall be
prepared by the Board except in the instance where the meeting is called on the written demand of the Shareholders in
which instance the Board may prepare a supplementary agenda.
If all Shares are in registered form and if no publications are made, notices to Shareholders may be mailed by registered
mail only.
To the extent required by law, the notice shall be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the Board may decide.
If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
The business transacted at any meeting of the Shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
The chairman of the Board will preside over all general meetings of the Shareholders. In his absence, the general
meeting of the Shareholders shall appoint any other person as chairman pro tempore of the general meeting by vote of
the majority of the Shareholders present or represented at such meeting.
Art. 13. General meetings in a Sub-Fund or in a Class of Shares. The Shareholders of the Class or Classes issued in
respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to
such Sub-Fund.
In addition, the Shareholders of any Class of Shares may hold, at any time, general meetings for any matters which are
specific to such Class.
The provisions of article 12 hereof shall apply, mutatis mutandis, to such general meetings. As an exception to these
provisions, the Board may decide that any general meeting of a Class of Shares will require a quorum of 75% (seventy-
five percent) of the Shares issued to be present or represented at the general meeting of this Class of Shares and any
decision will be passed at a majority of 75% (seventy-five percent) of the Shares present or represented.
Art. 14. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board composed of not less than three (3) members;
members of the Board need not be Shareholders of the Company.
125147
L
U X E M B O U R G
The Directors shall be elected by the Shareholders at their annual general meeting and until their successors are
elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed with or without cause and/or replaced at any
time by resolution adopted by the Shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may meet and may elect, by majority vote, subject to the prior approval of the CSSF, a Director to fill such vacancy until
the next meeting of Shareholders.
Art. 15. Meetings and Deliberations of the Board of Directors. The Board may choose from among its members a
chairman, and one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders. The Board shall meet upon
call by the chairman or by any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.
If a chairman is appointed, he shall preside at all meetings of Shareholders and at the Board. Failing a chairman or in
his absence the Shareholders or the Board may appoint any person as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours in advance
of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. Notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, or telefax
of each Director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a
schedule previously adopted by resolution of the Board.
Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telefax or any other electronic
mean another Director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing or by cable, telefax message or any
other electronic mean.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their
individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.
The Board can deliberate or act validly only if at least two Directors are present or represented at a meeting of the
Board, which may be by way of a conference telephone call. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the
Directors present or represented at such meeting or participating therein by telephone. The chairman of the meeting
shall have a casting vote in case of parity of vote.
Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms which may be signed
on one or more counterparts by all the Directors, which may be by way of a telefax or other electronic mean confirmed
in writing.
The Board from time to time may appoint the officers of the Company, including an administrative manager, a secretary,
and an assistant administrative manager, or other officers considered necessary for the operation and management of the
Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be Directors or Share-
holders of the Company.
The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given to them
by the Board.
The Board may delegate under its own responsibility, its powers to conduct the daily management and affairs of the
Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to physical persons or
corporate entities which need not be members of the Board. The Board may also delegate any of its powers, authorities
and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board
or not) as it thinks fit.
The board has wide powers to conduct business and affairs of the SICAR within the scope for which it was established,
save for any powers expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of the Shareholders.
Art. 16. Minutes. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the person who presided such meeting
or by the secretary.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman, or by the secretary, or by two directors.
Art. 17. Powers of the Board of Directors. The Board is vested with the broadest powers to manage the business
affairs of the Company, to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not
expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of Shareholders are in the competence of
the Board.
The Board shall, without limiting the generality of the foregoing, have the power to determine the corporate and
investment policy for investments, subject to such investment restrictions as may be imposed by law or by regulation or
as may be determined by the Board.
Art. 18. Conflict of Interest. In the event that any member of the Company or the Investment Manager is a party and/
or has an interest opposite with that of the Company in a company or a transaction which is subject to the approval of
the Company, such potential conflict of interest or interest opposite to the Company is to be fully disclosed to the
Company by that member and cause a record of his statement to be included in the minutes of the meetings of the
125148
L
U X E M B O U R G
Company. This member if manager/director shall not deliberate nor vote upon any such transaction. Such abstention
from voting shall not be counted. This situation will be reported to the Company’s Shareholders by any means determined
by the Board of Directors.
The term "interest opposite to the Company", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship
with or interest in any matter, position or transaction involving such company or entity as may from time to time be
determined by the Board of Directors on its discretion.
Art. 19. Engagement of the Company vis-à-vis third persons. The Company will be bound by the joint signatures of
any two Directors or by the joint or single signature(s) of any Director or officer to whom authority has been delegated
by the Board.
Art. 20. Auditor. The general meeting of Shareholders shall appoint a "réviseur d'entreprises agréé" who shall carry
out the duties prescribed by Article 27 of the 2004 Law.
Art. 21. Net Asset Value. The Net Asset Value per Share in each Sub-Fund shall be expressed in euro and shall be
determined as of any Valuation Day as defined in the Prospectus by dividing the Net Assets of the Sub-Fund, being the
value of the assets less the liabilities, on any such Valuation Day, by the number of Shares then outstanding in the Sub-
Fund, in accordance with the Valuation Rules set forth below.
The Net Asset Value per Share of each Sub-Fund may be rounded up or down to one thousand as the Directors shall
determine. If since the time of determination of the Net Asset Value there has been a material change in the quotations
in the markets on which a substantial portion of the investments of the Sub-Fund are dealt in or quoted, the Company
may, in order to safeguard the interests of the Shareholders and the Sub-Fund, cancel the first valuation and carry out a
second valuation.
The valuation of the Net Asset Value per Share of each Sub-Fund shall be made in the following manner:
I. The assets of the Company shall include:
1. all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2. all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3. all bonds, time notes, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other
securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company
may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-
rights, or by similar practices);
4. all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information
thereon is reasonably available to the Company;
5. all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount of such asset;
6. the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing Shares of the Company,
insofar as the same have not been written off;
7. all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
8. all instruments to enable the Company to hedge its currency risk.
The value of such assets shall be determined by the Board as follows:
(i) All Investments quoted, listed, traded or dealt in on any market shall be valued by reference to the latest available
quoted trade price (or, in the absence of any trades, at the latest available bid price) prevailing as at the close of business
on such market on the Valuation Day as of which such calculation is to be made or prevailing at such other time as the
Directors may determine, provided that:
(a) if the Investment is normally listed, quoted or dealt in on more than one market, the relevant market shall be the
market which the Directors determine provides the fair value for the Investment;
(b) if no closing price is available or if the last closing price is unrepresentative in the opinion of the Directors the
Investment shall be valued at such value as shall be certified by a competent person, firm or corporation which, in the
opinion of the Directors, provides a satisfactory market in any part of the world in such Investments or by a stockbroker
or other professional person approved for the purpose by the Custodian or such value as the Directors, in consultation
with the Investment Manager, with the approval of the Custodian, considers in the circumstances to be fair;
(c) for the purposes of ascertaining market dealing prices the Directors shall be entitled to use and to rely upon
recognised systems of valuation dissemination approved by the Directors.
(ii) Notwithstanding the provisions of paragraph (i) above, all calculations based on the value of Investments traded or
dealt in on any over-the-counter market (OTC Market) which is the principal OTC Market therefor shall be made by
reference to the latest available bid price quoted thereon provided always that if the Directors in their discretion consider
that the prices prevailing on an OTC Market other than the principal OTC Market for any such Investment provide in
all circumstances fairer criteria of value in relation to any such Investment, they may adopt such prices;
(iii) In the event that any Investment is not listed or dealt on a regulated market, stock exchange or other regulated
markets or if, in the opinion of the Company, the latest available price does not truly reflect the fair market value of the
125149
L
U X E M B O U R G
relevant securities, the value of such securities will be defined by the Company based on the fair value price determined
prudently and in good faith by the Board of Directors or by Independent Valuator(s) if specifically provided for in each
Sub-Fund relevant Appendix. The probable net fair value price for Investments (including permits, sales and purchase
agreements and valuation of operating SPVs), un-listed securities or securities not negotiated on a regulated market shall
normally be determined according to the "International Private Equity and Venture Capital Guidelines" established by
EVCA (European Venture Capital Association), and/or in accordance with the methods and principles applied by Inde-
pendent Valuator(s) as agreed from time to time by the Board of Directors;
(iv) Cash deposits and similar Investments will be valued at their face value with interest accrued to the close of business
in the jurisdiction in which the deposit account and/or Investments are held on the Valuation Day as of which such
calculation is to be made, unless the Directors in their sole discretion consider it appropriate to make any adjustment to
reflect the fair value thereof;
(v) Derivative instruments other than derivative instruments valued in accordance with paragraphs (i) and (ii) above
shall be valued at such price as the Directors in good faith, and in consultation with the Investment Manager, consider
represents the fair value of the derivative instrument; Forward currency contracts shall be valued by reference to their
contractual price taking into account any gains or losses incurred in respect of such contracts; Contracts on derivative
instruments will only be concluded for hedging purposes on forward exchanges and on interest changes
(vi) Investments in Collective Investment Schemes (if any, and subject to the fact that the Company’s prospectus be
updated accordingly) shall be valued on the basis of the last known Net Asset Value of such units or shares on the Valuation
Day as of which the valuation is made;
(vii) Notwithstanding the provisions of paragraphs (i) and (ii) above hereof, in determining the value of any Investment
the Directors may, with the approval of the Custodian, permit on a consistent basis a method of valuation other than
that contained in paragraphs (i) and (ii) above to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value
of an Investment;
(viii) If any Investment is realised or contracted to be realised at a known value, the net proceeds of such realisation
shall be taken into account in lieu of any other method of determining the value of the Investment concerned, and if any
Investment is acquired or contracted to be acquired at a known value for a consideration payable out of the assets of the
Company, such Investment shall be included among the assets of the Company and valued in accordance with the foregoing
provisions in lieu of the cost of acquisition.
In calculating the Net Asset Value, all liabilities of the Company including fees due and such contingency provisions and
allowances as the Directors consider appropriate in respect of the costs and expenses payable by the Company, will be
deducted. There will, however, be included in the valuation any interest, dividend or debts accrued, received or receivable
as at the relevant Valuation Date.
The value of all assets and liabilities not expressed in EUROS will be converted into EUROS at the spot rate of exchange
prevailing in Luxembourg on the relevant Valuation Day. If such quotations are not available, the rate of exchange will be
determined in good faith by or under procedures established by the Board.
The Board in its discretion may permit some other method of valuation to be used, if it considers that such valuation
better reflects the fair value of any asset of the Company on a consistent basis.
All Valuation Rules and determinations shall be interpreted and made in accordance with Luxembourg law and Inter-
national Accounting Standards.
The reasonableness of the determination by the Company of the fair value of the Investments will be subject to annual
examination by the auditor as part of the annual audit of the Company's financial statements and upon which they will
express their independent opinion.
In the absence of negligence, wilful default, fraud or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value
taken on a consistent basis by the Board or by any bank, company or other organisation which the Board may appoint
for the purpose of calculating the Net Asset Value or by the auditor in examining the reasonableness of any such valuation,
shall be final and binding on the Company and present, past or future Shareholders.
II. The liabilities of the Company shall include:
1. all loans, bills and accounts payable;
2. all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
3. all accrued or payable expenses (including administrative expenses, advisory and investment management fees,
including performance fees, and corporate agent's fees);
4. all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid distributions declared by the Company;
5. an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Company, and other reserves (if any) authorised and approved by the Board of Directors, as well as
such amount (if any) as the Board of Directors may consider to be appropriate allowance in respect of any contingent
liabilities of the Company;
6. all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with Luxembourg law
and International Accounting Standards. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account
125150
L
U X E M B O U R G
all expenses payable by the Company which shall comprise, without limitation formation expenses, fees payable to its
Investment Manager including performance related fees, fees and expenses payable to its accountants, the custodian and
its correspondents, domiciliary, corporate registrar and transfer agents, any placing or structuring agent and permanent
representatives in places of registration, as well as any other agent employed by the Company, the remuneration of the
Directors and their reasonable out-of-pocket expenses, (including insurance coverage and reasonable travelling costs in
connection with Board meetings), fees and expenses for legal and auditing services (including due diligence expenses
relating to potential investments), any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the
Company with any Governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other
country, reporting and publishing expenses, including the cost of preparing printing, advertising and distributing prospec-
tuses, explanatory memoranda, periodic reports and registration statements, the cost of printing certificates, and the
costs of any reports to Shareholders, expenses incurred in determining the Net Asset Value, the cost of convening and
holding Shareholders' and Directors' meetings, all taxes, duties, governmental and similar charges, and all other operating
expenses, including the cost of buying and selling assets, the cost of publishing the issue and redemption prices (if any),
interest, bank charges, currency conversion costs, brokerage, postage, telephone and telex. The Company may accrue
administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount rateably for yearly or
other periods.
As between the Shareholders, each Sub-Fund shall be treated as a separate legal entity.
With regard to third parties, the Company shall constitute a single legal entity, however, by derogation from Article
2093 of the Luxembourg Civil Code, the assets of a particular Sub-Fund are only applicable to the debts, engagements
and obligations of that Sub-Fund. The assets, commitments, charges and expenses which cannot be allocated to one
specific Sub-Fund will be charged to the different Sub-Funds proportionally to their respective net assets and pro rata
temporis, if appropriate due to the amounts considered.
III. For the purpose of this article:
1. Shares of the Company to be redeemed under Article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the time specified by the Board on the Valuation Day on which such valuation is made, and from
such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
2. Shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the Board on
the Valuation Day on which such valuation is made, and from such time and until received by the Company the price
therefor shall be deemed to be a debt due to the Company;
3. All investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the currency in which the Net
Asset Value is calculated shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the
date and time for determination of Net Asset Value of Shares; and
4. Where on any Valuation Day the Company has contracted to:
- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset, shall be shown as a liability of the Company
and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;
- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company
and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;
- provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation
Day, then its value shall be estimated by the Company.
Art. 22. Suspension of the Net Asset Value. The Company may suspend the determination of the Net Asset Value of
the Shares of any Sub-Fund, and may suspend the issue and redemption (if any) of the Shares during:
i) during any period when any of the principal stock exchanges or other recognised markets on which a substantial
portion of the investments of the Company is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary holidays, or during
which dealings therein are restricted or suspended, provided that such restriction or suspension affects the valuation of
the investments of the Company quoted thereon;
ii) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency (as political, military, economic or
monetary events) in the opinion of the Directors as a result of which disposal or valuation of assets owned by the Company
would be impracticable;
iii) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the investments or the current price or value on any stock exchange or other market in respect of the assets;
iv) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of Shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or
payments due on redemption of Shares cannot, in the opinion of the Directors, be effected at normal rates of exchange;
v) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to such Sub-Fund
cannot promptly or accurately be ascertained or is suspended;
vi) upon the publication of a notice convening a general meeting of Shareholders for the purpose of winding-up the
Company, or a decision of the Board of Directors to close a Sub-Fund;
125151
L
U X E M B O U R G
vii) during any other circumstance or circumstances where a failure to do so might result in the Company or its
Shareholders incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or any other detriment which
the Company or its Shareholders might so otherwise have suffered.
The Directors shall suspend the issue and redemption (if any) of Shares of any Sub-Fund forthwith upon the occurrence
of an event causing it to enter into liquidation.
Investors who have made an application for subscription or who have applied for redemptions shall be notified of any
such suspension of their request and will be promptly notified of the termination of such suspension.
Art. 23. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January in each year and
shall terminate on the last day of December in the same year. The accounts of the Company shall be expressed in euro.
A copy of the annual accounts, including the audited balance sheet and profit and loss account and the Directors' report
will be sent to registered Shareholders are issued, further published not less than 15 calendar days prior to each annual
general meeting of Shareholders.
Art. 24. Distribution policy. The general meeting of Shareholders shall, upon the proposal of the Board, determine
how the annual profits shall be disposed of. Dividends, if any, will be declared on the number of Shares outstanding at
the dividend record date, as that date is determined by the Board in the case of an interim dividend or by the general
meeting of Shareholders of the Company in the case of the final dividend, and will be paid to the holders of such Shares
within two months of such declaration.
The Board may declare and pay an interim dividend in accordance with all applicable laws. The Shareholders may
authorize the Board to declare distributions.
The net assets of the Company may be distributed, subject to the minimum capital of the Company as defined under
Article 5 hereof being maintained.
Art. 25. Termination of a Sub-Fund or Class of Shares. The Board of Directors may decide subject to the conditions
set forth in the following paragraph to terminate any Sub-Fund or Class of Shares in taking due account of the interests
of the Shareholders. In such case, the Board of Directors may offer the Shareholders of such Sub-Fund the conversion
of their Shares into Shares of another Sub-Fund, under the terms fixed by the Board of Directors, or the redemption of
their Shares for cash at the net asset value per Share (including all estimated expenses and costs relating to the termination)
determined on the Valuation Day.
In the event that for any reason the value of the net assets in any Sub-Fund has decreased to an amount equal to Euros
5,000,000.00 (five millions euros) or if a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund would have
material adverse consequences on the investments of that Sub-Fund, the Board of Directors may decide (i) to compulsorily
redeem all the Shares of the relevant Classes issued in such Sub-Fund at the Net Asset Value per Share, taking into account
actual realisation prices of investments and realisation expenses and calculated on the valuation day at which such decision
shall take effect or (ii) to offer to the Shareholders of the relevant Class in such Sub-Fund the conversion (if not prohibited)
of their Shares into Shares of another Sub-Fund.
The Company shall serve a notice to the Shareholders of the relevant Class of Shares prior to the effective date of
the compulsory redemption, which will indicate the reasons for and the procedure of the redemption operations. Re-
gistered Shareholders will be notified in writing. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to maintain equal
treatment between the Shareholders, the Shareholders of the Class concerned may continue to request redemption or
conversion of their Shares free of charge, taking into account actual realisation prices of investments and realisation
expenses and prior to the date effective for the compulsory redemption.
Notwithstanding the powers conferred on the Board of Directors by the preceding paragraph hereof, the general
meeting of Shareholders of any one or all Classes of Shares issued may, upon proposal of the Board of Directors, redeem
all the Shares of the relevant Classes and refund to the Shareholders the net asset value of their Shares, taking into account
actual realisation prices of investments and realisation expenses and calculated on the valuation day at which such decision
shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of Shareholders that shall decide by
resolution taken by simple majority of those present or represented.
Assets which may not be distributed to their owners upon the implementation of the redemption will be deposited
with the Custodian of the Company for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited
with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.
All redeemed Shares will be cancelled in the books of the Company.
Art. 26. Merger and Division of Sub-Funds or Classes of Shares. Under the same circumstances as provided in the
Article 25, and subject to prior approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier, the Board of Directors
may decide to merge any Sub-Fund with one or more other Sub-Funds or merge any Sub-Fund into other collective
investment undertakings governed by Luxembourg law or reorganise the Shares of a Sub-Fund into two or more Classes
or combine two or more Classes of Shares into a single Class providing in each case it is in the interests of Shareholders
of the relevant Sub-Funds.
Prior notice will be given to Shareholders of the Sub-Fund being merged.
125152
L
U X E M B O U R G
Publication of the decision will be made as described above including details of the merger and will be made at least
one calendar month prior to the merger taking effect during which time Shareholders of the Sub-Fund or Classes of
Shares to be merged may request redemption of their Shares free of charge.
The Directors may also decide upon the reorganisation of any Sub-Fund by means of a division into two or more
separate Sub-Funds. Such decision will be published in the same manner as described above and, in addition, the publication
will contain information in relation to the two or more separate Sub-Funds resulting from the reorganisation. Such
publication will be made at least one month before the date on which the reorganisation becomes effective in order to
enable Shareholders to request redemption or conversion of their Shares, free of charge, before the reorganisation
becomes effective. The Company’s prospectus will be updated accordingly.
Any request for subscription shall be suspended as from the moment of the announcement of the termination, the
merger, the division or the transfer of the relevant Sub-Fund.
Art. 27. Dissolution and liquidation of the Company. In the event of dissolution of the Company, liquidation subject
to the prior approval of the CSSF, shall be carried out by one or several liquidators who may be physical persons or legal
entities and shall be approved the financial authority, named by the meeting of Shareholders effecting such dissolution
and which shall determine their powers and their compensation, pursuant to the 2004 Law. The net proceeds of liquidation
shall be distributed by the liquidators to the holders of Shares in proportion of their holding of Shares. The liquidator
may at the request of any Shareholder make distributions in specie provided that an independent valuation of the assets
to be so distributed is obtained.
Whenever the capital falls below the minimum capital as provided by the Luxembourg law dated 15 June 2004, as may
be amended from time to time, the Board of Directors has to submit the question of the dissolution of the Company to
the shareholders in a general meeting which shall deliberate without that a quorum shall be required and which shall
decide on simple majority of the votes of the shares represented at the meeting.
Art. 28. Expenses borne by the Company. The Company shall bear, without limitation, its initial incorporation costs,
including the costs of drawing up and printing the prospectus, notary public fees, management fees, the filing costs with
administrative and stock exchange authorities, the costs of printing the certificates and any other costs pertaining to the
establishment and launching of the Company.
The costs will be amortised on a period not exceeding the five first accounting years.
The Company bears all its running costs as foreseen in Article 21 hereof.
Art. 29. Amendment of the Articles of Incorporation. Subject to the prior approval of the CSSF, these Articles of
Incorporation may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and majority
requirements provided by the law on commercial companies of 10 August 1915 (the “1915 Law”) unless otherwise
provided by these Articles.
Art. 30. Amendment of the Company’s legal status. Subject to the prior approval of the CSSF, any decision to be taken
in relation to the submission of the Company’s legal status to another law as the 2004 Law, will require, in order to be
valid, the unanimously consent of the Company’s Shareholders.
Art. 31. Applicable law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies and the 2004
Law.
<i>Subscription and paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
Name of Subscriber
Number of
subscribed
Shares
Subscribed
capital
Mr Dimitrios DASKALOPOULOS», prenamed
31 EUR 31,000
Upon incorporation, the Shares were fully paid-up, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on December 31
st
, 2014.
The first general annual meeting of Shareholders shall be held on 30 June 2015.
However, in order to be held within eighteen months following the Company’s incorporation, in accordance with
article 70 of the Luxembourg law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended, the first annual
general meeting of Shareholders will be held on 30
th
June 2015.
The first annual report of the Company will be dated December 31
st
, 2014.
125153
L
U X E M B O U R G
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the
Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately three thousand euro.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entire subscribed
capital and considering himself as duly convoked, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having
first verified that it was regularly constituted, the meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The registered office of the Company shall be at 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The number of directors of the Company is set at five (5), and the following persons are appointed as directors for a
period ending immediately after the annual general meeting of Shareholders to be held the first time on 30
th
June 2015
to resolve upon the approval of the accounts as of 31 December 2014:
- Mr. Dimitrios Daskalopoulos, born in Athens (Greece) the 18
th
January 1957, residing professionally 89, Amaroussiou
- Halandriou Street, GR - 15233 Halandri, Greece
- Mrs. Nicole Krafft - Pollefort born in Arlon (Belgium) the 11
th
October 1946, residing 115, Rue des Espagnols B-6700
Arlon, Belgium,
- Mr. Nikolaos Nanopoulos, born in Alexandria (Egypt) the 2
nd
November 1952, residing professionally 8 Fragoklissias
Street, GR - 15122 Maroussi, Greece,
Mr. Nicolas Muller, born in Thionville (France) the 19
th
May 1975, residing professionally 65, rue d’Eich, L-1461
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Mr. Jean-Marie Bondioli, born in Villerupt (France) the 17
th
June 1959, residing 28, domaine Schmiseleck, L-3373
Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The independent auditor for the Company shall be PricewaterhouseCoopers Société Coopérative. 400, route d’Esch,
B.P. 1443, L-1014 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg.
The term of office of the auditor shall be for one year and shall be renewed by the annual general meeting of Share-
holders approving the accounts as of December 31
st
, 2014.
The auditor shall remain in office until the close of the first accounting year.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, said persons signed together with the notary the present deed.
Signé: M.-J. FERNANDES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 septembre 2014. Relation: LAC/2014/42689. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Référence de publication: 2014146648/653.
(140166980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
125154
L
U X E M B O U R G
Lear East European Operations, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.499.400,00.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 100.647.
In the year two thousand fourteen, on the fifteenth day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Lear East European Operations, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue du Laboratoire, L-1911
Luxembourg, with a share capital of four million four hundred ninety-nine thousand four hundred euro (EUR 4,499,400)
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 100.647,
here represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, lawyer, with professional address at 3, rue Goethe, L-1637 Lu-
xembourg, by virtue of a power of attorney granted by the board of managers of Lear East European Operations on
September 15, 2014,
2. Lear West European Operations, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue du Laboratoire,
L-1911 Luxembourg, with a share capital of one hundred eighty million forty thousand United States Dollars (USD
180,040,000) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 102.878,
here represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, with professional address at 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,
by virtue of a power of attorney granted by the board of managers of Lear West European Operations on September
15, 2014.
The board of managers of Lear East European Operations and Lear West European Operations decide to approve
the following merger proposal:
I. The merging companies: Name - Legal form - Registered Office
Lear East European Operations, defined as the Recipient Company, is a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 100.647, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxem-
bourg, dated April 7, 2004 and published in Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) number 679
dated July 2, 2004, whose articles have been amended several times and a last time pursuant to a notarial deed of Maître
Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated December 17, 2013 and published in Mémorial C number 1120
dated May 3, 2014.
The Recipient Company has a share capital of four million four hundred ninety-nine thousand four hundred euro (EUR
4,499,400), represented by forty-four thousand nine hundred ninety-four (44,994) shares with a nominal value of one
hundred euro (EUR 100) each.
Lear West European Operations, defined as the Absorbed Company, is a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 102.878, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxem-
bourg, dated August 2, 2004 and published in Mémorial C number 1159 dated November 16, 2004, whose articles have
been amended several times and a last time pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, dated December 14, 2007 and published in Mémorial C number 384 dated February 14, 2008.
The Absorbed Company has a share capital of one hundred eighty million forty thousand United States Dollars (USD
180,040,000), represented by one million eight hundred thousand four hundred (1,800,400) shares with a nominal value
of one hundred United States Dollars (USD 100) each.
The Recipient Company and the Absorbed Company are collectively referred as the merging companies (the Merging
Companies).
II. Merger
The board of managers of each of the Merging Companies has approved the merger of the Merging Companies (the
Merger), by way of a merger by absorption without liquidation of the Absorbed Company by the Recipient Company,
whereby the Recipient Company shall acquire all the assets and liabilities of the Absorbed Company pursuant to articles
257 et seq. of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law) and this merger proposal (the
Merger Proposal).
In accordance with article 274 of the Law, upon the Merger, all the assets and liabilities of the Absorbed Company
shall be automatically transferred by operation of the Law to the Recipient Company and the Absorbed Company shall
cease to exist.
125155
L
U X E M B O U R G
In accordance with article 265 (3) of the Law, the board of manager of each of the Merging Companies does not have
to draw up a detailed written report explaining the Merger Proposal and setting out the legal and economic grounds of
the Merger. The sole shareholder of each of the Companies, who acknowledges these articles, expressly renounced to
be provided with the reports of the board of managers of the respective merging companies.
In addition, according to article 266 (5) of the Law, the Merger Proposal does not need to be the subject of a written
report drawn up for each of the Merging Companies by one or more réviseurs d’entreprises agréés. The sole shareholder
of each of the Merging Companies, who acknowledges these articles, expressly renounced to be provided with the reports
of the réviseur d’entreprise agréé.
III. Share exchange ratio
Lear (Luxembourg), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg,
with a share capital of one hundred eighty-six million one hundred fifteen thousand eight hundred United States Dollars
(USD 186,115,800) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 98070, is the
sole shareholder of both Merging Companies (the Sole Shareholder).
Since there is a common Sole Shareholder, the contribution of the net assets and liabilities of the Absorbed Company
to the Recipient Company shall not entail any other remuneration than the increase of the net asset value of the Recipient
Company. No new shares shall be issued in the Recipient Company and hence a share exchange ratio is not applicable.
IV. Denomination change of the Recipient Company
The Recipient Company shall as of the Effective Date (as defined hereafter under Section X.) be denominated “Lear
East European Operations S.à r.l.”.
Article 4 of the articles of association of the Recipient Company will be amended accordingly so as to take the deno-
mination change into consideration.
V. Effective date of the Merger - Effectiveness from an accounting point of view
From an accounting point of view, the operations of the Absorbed Company shall be treated as having been carried
out on behalf of the Recipient Company as from January 1, 2014.
VI. Special shareholders rights
No special rights are conferred by the Recipient Company to holders of shares with special rights. Neither the Recipient
Company nor the Absorbed Company have issued securities other than shares.
VII. Advantages
No special advantage will be granted to the managers and auditors of the Merging Companies in connection with or
as a result of the Merger.
VIII. Employees
No change to the employment conditions of the Merging Companies’ employees, if any, as a result of the Merger has
been foreseen and, in accordance with the Law, the rights and obligations of the Absorbed Company under the respective
employment agreements to which they are a party will be automatically transferred to the Recipient Company, if appli-
cable.
IX. Passing of all assets and rights and liabilities of the Absorbed Company; cancellation of the shares in the Absorbed
Company, and dissolution without liquidation of the Absorbed Company
As a result of the Merger, all the assets and liabilities belonging to the Absorbed Company (known or unknown) as of
the date of the meetings of shareholders approving the Merger will pass under universal title to the Recipient Company
in accordance with, and subject to, article 274 of the Law. The shares held by the Recipient Company in the Absorbed
Company will be cancelled and the Absorbed Company shall cease to exist.
X. Information regarding the Merger
In accordance with the Law, this Merger Proposal shall be published in the Mémorial C at least one month before the
date of the holding of the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Absorbed Company, resolving
upon the Merger (the Effective Date).
At the registered offices of each of the Merging Companies, the following documents will be available for review by
the Merging Companies' shareholders no later than one month before the Merger:
- Merger Proposal of the respective Merging Companies;
- Annual accounts and management reports for the Merging Companies for the last three (3) accounting years; and
- Interim accounts of the Merging Companies as of August 30, 2014.
<i>Fees and dutiesi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately seven thousand Euros (7,000.- EUR).
In accordance with article 271 of the law of 10 August 1915, the undersigned notary certifies the legality of the present
Merger Project.
125156
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same persons and in
case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first names, civil
status and residence, the said persons signed together with Me, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le quinzième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Lear East European Operations, une société à responsabilité limitée établie et existante selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, avec un capital social de
quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cents euros (EUR 4.499.400) et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.647,
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 3, rue Goethe, L-1637 Lu-
xembourg, en vertu d’une procuration donnée par le conseil de gérance de Lear East European Operations le 15
septembre 2014.
2. Lear West European Operations, une société à responsabilité limitée établie et existante selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, avec un capital social de cent
quatre-vingts millions quarante mille dollars américains (USD 180.040.000) et immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.878,
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 3, rue Goethe, L-1637 Lu-
xembourg, en vertu d’une procuration donnée par le conseil de gérance de Lear West European Operations le 15
septembre 2014.
Les conseils de gérance de Lear East European Operations et Lear West European Operations ont décidé d’approuver
le projet de fusion suivant:
I. Les sociétés participant à la fusion: Dénomination - Forme juridique - Siège social
Lear East European Operations, également définie comme la Société Absorbante, est une société à responsabilité
limitée établie et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 9, rue du Laboratoire,
L-1911 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.647,
constituée par acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 7 avril 2004 et publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) numéro 679 le 2 juillet 2004, dont les statuts ont été modifiés
plusieurs fois et pour la dernière fois par acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, le 17
décembre 2013 et publié au Mémorial C numéro 1120 le 3 mai 2014.
La Société Absorbante a un capital social de quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cents euros
(EUR 4.499.400) représenté par quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (44.994) parts sociales d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
Lear West European Operations, également définie comme la Société Absorbée, est une société à responsabilité
limitée établie et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 9, rue du Laboratoire,
L-1911 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.878,
constituée par acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 2 août 2004 et publié au Mémorial
C numéro 1159 le 16 novembre 2004, dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par acte
notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 14 décembre 2007 et publié au Mémorial C numéro
384 le 14 février 2008.
La Société Absorbée a un capital social de cent quatre-vingts millions quarante mille dollars américains (USD
180.040.000) représenté par un million huit cent mille quatre cents (1.800.400) parts sociales d’une valeur nominale de
cent dollars américains (USD 100) chacune.
La Société Absorbante et la Société Absorbée sont désignées collectivement comme les sociétés fusionnantes (les
Sociétés Fusionnantes).
II. Fusion
Le conseil de gérance de chacune des Sociétés Fusionnantes a approuvé la fusion des Sociétés Fusionnantes (la Fusion),
par voie de fusion par absorption sans liquidation de la Société Absorbée par la Société Absorbante, par laquelle la Société
Absorbante acquerra tous les actifs et passifs de la Société Absorbée conformément aux articles 257 et sv. de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi) et le présent projet de fusion (le Projet de Fusion).
Conformément à l’article 274 de la Loi, dès la Fusion, tous les actifs et passifs de la Société Absorbée seront automa-
tiquement transférés par effet de la Loi à la Société Absorbante et la Société Absorbé cessera d’exister.
Conformément à l’article 265 (3) de la Loi, le conseil de gérance de chacune des Sociétés Fusionnantes ne doit pas
dresser un rapport écrit détaillé expliquant le Projet de Fusion et fixant les motifs juridiques et économiques de la Fusion.
125157
L
U X E M B O U R G
L’associé unique de chacune des Sociétés Fusionnantes, qui prend connaissance de ces articles, a renoncé expressément
à ce que les rapports des conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes respectives lui soit transmis.
Par ailleurs, conformément à l’article 266 (5) de la Loi, le Projet de Fusion ne doit pas faire l’objet d’un rapport écrit
rédigé pour chacune des Sociétés Fusionnantes par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés. L’associé unique de
chacune des Sociétés Fusionnantes, qui prend connaissance de ces articles, a renoncé expressément à ce que les rapports
du réviseur d’entreprise agréé lui soit transmis.
III. Rapport d’échange
Lear (Luxembourg), une société à responsabilité limitée (société à responsabilité limitée) établie et existante selon les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, avec un capital
social de cent quatre-vingt-six millions cent quinze mille huit cents dollars américains (USD 186.115.800) et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98070, est l’unique actionnaire des deux
Sociétés Fusionnantes (l’Associé Unique).
Dès lors qu'il y a un Actionnaire Unique commun, la contribution des actifs et passifs nets de la Société Absorbée à la
Société Absorbante ne comportera aucune autre rémunération que l’augmentation de la valeur de l’actif net de la Société
Absorbante. Aucunes nouvelles actions ne seront émises dans la Société Absorbante et par conséquent un rapport
d’échange des parts n'est pas applicable.
IV. Changement de dénomination de la Société Absorbante
La Société Absorbante sera à la Date de Réalisation (telle que définie ci-après dans la section X.) dénommée, "Lear
East European Operations S.à r.l. ".
L'article 4 des statuts de la Société Absorbante sera modifié en conséquence afin de prendre le changement de dé-
nomination en considération.
V. Date effective de la Fusion - Effectivité au point de vue comptable
D’un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée devront être traitées comme ayant été réalisées
au nom de la Société Absorbante à compter du 1
er
janvier 2014.
VI. Droits spéciaux des associés
Aucun droit spécial ne sera conféré par la Société Absorbante aux détenteurs de parts sociales dotées de droits
spéciaux. Ni la Société Absorbante, ni la Société Absorbée n'ont émis de titres autres que des parts sociales.
VII. Avantages
Aucun avantage spécial ne sera accordé aux membres des conseils de gérance et auditeurs des Sociétés Fusionnantes
en relation avec la Fusion ou suite à celle-ci.
VIII. Employés
Aucun changement des conditions de travail des employés des Sociétés Fusionnantes résultant de la Fusion n'a été
prévu et, conformément à la Loi, les droits et obligations de la Société Absorbée découlant des contrats de travail
respectifs auxquels elle est partie seront automatiquement transférés à la Société Absorbante, le cas échéant.
IX. Transmission de tous les actifs, droits et passifs de la Société Absorbée; annulation des parts sociales de la Société
Absorbée, et dissolution sans liquidation de la Société Absorbée.
Suite à la Fusion, tous les actifs et passifs appartenant à la Société Absorbée (connus ou inconnus) seront transmis, par
transfert universel, à dater des réunions des associés approuvant la Fusion, à la Société Absorbante conformément à et
sous réserve de l’article 274 de la Loi. Les parts sociales détenues par la Société Absorbante dans la Société Absorbée
seront annulées et la Société Absorbée cessera d'exister.
X. Informations concernant la Fusion
Conformément à la Loi, ce Projet de Fusion sera publié au Mémorial C au moins un mois avant la tenue de l’assemblée
générale extraordinaire de l’associé unique de la Société Absorbée, approuvant la Fusion (la Date de Réalisation).
Au siège social de chacune des Sociétés Fusionnantes, les documents suivants pourront être consultés par les associés
des Sociétés Fusionnantes au plus tard un mois avant la Fusion:
- Projet de Fusion des Sociétés Fusionnantes respectives;
- Comptes annuels et rapports de gestion de la Sociétés Fusionnantes pour les trois (3) derniers exercices comptables;
et
- Comptes intérimaires des Sociétés Fusionnantes à compter du 30 août 2014.
<i>Frais et droitsi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont estimés à sept mille Euros (7.000.- EUR).
Conformément à l’article 271 de la loi du 10 août 1915, le notaire soussigné certifie la légalité du présent Projet de
Fusion.
Dont Acte,
125158
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une 11/11 traduction française; sur demande des mêmes personnes et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Après lecture faite au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec
Nous, notaire, le présent acte original.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 septembre 2014. Relation: LAC/2014/43660. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2014.
Référence de publication: 2014147492/239.
(140168428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.
Développement & Rénovation Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 125.170.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014106518/10.
(140128071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Dyonas S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 151.179.
Le Bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014106536/10.
(140126992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Cambaceres France Holdings AREII (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 155.173.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 22 juillet 2014i>
1. Monsieur Pietro LONGO a démissionné de son mandat de gérant B.
2. Monsieur Douwe TERPSTRA, administrateur de sociétés, né à Leeuwarden (Pays-Bas), le 31 octobre 1958, de-
meurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une
durée indéterminée.
3. Monsieur Tobias STEMMLER, administrateur de sociétés, né à Neunkirchen/Saar (Allemagne), le 18 juillet 1983,
demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une
durée indéterminée.
Veuillez noter que adresse professionnelle de Monsieur Hugo FROMENT gérant de catégorie B, se situe désormais
au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AIMCo Re Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à.r.l
Référence de publication: 2014117711/21.
(140134901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
125159
L
U X E M B O U R G
EnergyMixx Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.
R.C.S. Luxembourg B 84.062.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106551/9.
(140127243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Can Benelux, Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach, 151, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 115.013.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2014106451/10.
(140127292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Heisdorf Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 116.711.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 octobre 2014i> à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2014
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014144550/795/15.
AFP (Germany) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.958.
EXTRAIT
Transfert de parts sociales:
Il résulte du contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 24 juillet 2014 sous seing privé, que 96 (quatre-
vingt-seize) parts sociales ordinaires de la Société détenues par Ares European Real Estate Fund IV, L.P., ont été transférées
à AFP Germany Holdings SARL, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 43, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro
B188849, laquelle détient désormais 96 (quatre-vingt-seize) parts sociales ordinaires de la Société représentant 96% de
son capital
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 Juillet 2014.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2014113014/20.
(140133925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
125160
L
U X E M B O U R G
ABI CEE Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 157.381.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014113005/9.
(140132953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
Almacantar, Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 149.157.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014113027/9.
(140133549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
St. Georges Investment S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 34.251.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme ST. GEORGES INVESTMENT S.A.-SPF sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>3 octobre 2014i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30.06.2014.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014144558/750/16.
Albatros Son Holding BV & Cie., Société en nom collectif.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 87.104.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des associés tenue en date du 24 juin 2014i>
<i>3 i>
<i>èmei>
<i> Résolution:i>
Sont réélus membres du conseil de gérance:
- Monsieur Gregorius Hendricus VAN CRANENBROEK, demeurant au 32, Bosch, NL-6021 AP Budel, Pays-Bas, Gé-
rant;
- Monsieur Jan VERHULST, demeurant au 129, Venbergsmolen, NL-5612 DX Eindhoven, Pays-Bas, Gérant.
Leur mandat est valable jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre
2014.
L'Assemblée décide aussi de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé de ERNST & YOUNG S.A., ayant
son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach. Son mandat est valable jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Albatros Son Holding BV & Cie., S.e.n.c.
Référence de publication: 2014113022/20.
(140133347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
125161
L
U X E M B O U R G
Insurance Participations Company, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 13.756.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme INSURANCE PARTICIPATIONS COMPANY S.A. sont priés d'as-
sister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>3 octobre 2014i> à 15.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2013.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014144555/750/17.
Jazz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 54.401.
<i>Extrait des principales résolutions adoptées en date du 10 juillet 2014 lors de l'assemblée générale ordinaire des associési>
Les mandats des gérants en place sont renouvelés et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des associés statuant
sur les comptes clos au 31 décembre 2014, devant se tenir en 2015.
Ces gérants sont:
- Monsieur Marc Giorgetti
- Monsieur Michel Ducros
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour Jazz S.à r.l.
i>Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014114103/18.
(140133945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
Umicore International, Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 5, rue Bommel.
R.C.S. Luxembourg B 103.343.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 14 mai 2014i>
1. La société anonyme H.R.T. Révision S.A. a démissionné de son mandat de réviseur d’entreprises agréé.
2. La société coopérative PricewaterhouseCoopers, R.C.S. Luxembourg B65477, avec siège social à L-1471 Luxem-
bourg, 400, route d'Esch, a été nommée comme réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de 2018.
Veuillez prendre note que l'adresse professionnelle de M. Johan DEJANS, de Mme Virginie DOHOGNE, administra-
teurs, et de Mme Valérie PECHON, administrateur et administrateur-délégué, se situe désormais à L-2453 Luxembourg,
6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 29 Juillet 2014.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour UMICORE INTERNATIONAL
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014115691/19.
(140134635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
125162
L
U X E M B O U R G
Sirius Group Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 134.493.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2014.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014114615/14.
(140133778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
Vatoa Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 32.468.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 30 juin 2014i>
Le siège a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Luxembourg, 6,
rue Eugène Ruppert.
Veuillez noter que les adresses professionnelles de Mme Katia CAMBON, présidente du conseil d'administration, Mme
Virginie GUILLAUME et M. Franck BETH, administrateurs, se situent désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène
Ruppert.
Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TAMANA HOLDING S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014114603/17.
(140134168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
Vazon Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 136.666.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2014i>
<i>Conseil d'Administrationi>
Suite à cette décision le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2020 est com-
posé comme suit:
- LORIÉ Arnaud, demeurant à 17 Ha'tamar, Ra'anana 43571 Israël
- LORIÉ Roland, demeurant à 17 Ha'tamar, Ra'anana 43571 Israël
- MANGEN Fons, demeurant à 147 rue de Warken, L-9088 Ettelbruck
<i>Commissaire aux Comptesi>
L'assemblée générale a décidé de ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de M. Maqua Dominique
et a décidé de nommer en son remplacement pour une durée de six ans la société RAMLUX S.A., 9b bd Prince Henri,
L-1724 Luxembourg.
Suite à cette décision, le Commissaire aux Comptes en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020 est
RAMLUX S.A., 9b bd Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Fons MANGEN
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2014114604/23.
(140133444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
125163
L
U X E M B O U R G
WD Nonntal S.C.A, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 117.660.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg:
Le siège social de WD S.à r.l. en sa qualité de gérant et associé commandité est désormais la suivante: 412F, route
d'Esch, L-1030 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 Juillet 2014.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014114619/14.
(140134276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
London Transit Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 163.533.
Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Monsieur Frank PLETSCH, Monsieur Gérard BIRCHEN, et Monsieur
Mark GORHOLT, gérants de classe B, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Veuillez également prendre note que le siège social de l'associée Hub Investments S.à r.l. est désormais au L-2453
Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 29 juillet 2014.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour London Transit Holdings S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014117443/15.
(140134557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
YELLOW T International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5212 Sandweiler, 7, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 57.498.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2014 que:
1) Les mandats des administrateurs actuels prennent fin à l'issue de la présente assemblée générale annuelle.
L'assemblée générale nomme à nouveau les administrateurs sortants pour une nouvelle période de six ans jusqu'à
l'issue de la réunion de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020.
Le nouveau Conseil d'Administration se compose de:
- Monsieur Patrick GINDT, demeurant 7, rue des Champs à L-5212 SANDWEILER, Administrateur-Délégué
- Monsieur Gabriel DELLANDREA, demeurant 12, rue des anciens fours à chaux à F-57925 DISTROFF, Administrateur
Technique
- Madame Berthe BECKER, demeurant 7, rue des Champs à L-5212 SANDWEILER, Administrateur
- Madame Laurence MILLARD, demeurant 21, rue de la Fauvette à F-57100 THIONVILLE, Administrateur.
2) Le mandat du commissaire aux comptes actuel prend fin à l'issue de la présente assemblée générale annuelle.
L'assemblée générale nomme à nouveau comme commissaire aux comptes ”FIDUCIAIRE ENSCH-STREFF (FIDES)
S.A.”, ayant siège social au 55, Ceinture des Rosiers à L-2446 HOWALD pour une nouvelle période de six ans jusqu'à
l'issue de la réunion de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020.
Pour extrait conforme et sincère
Patrick GINDT
<i>Administrateur-Déléguéi>
Référence de publication: 2014114632/25.
(140133311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
125164
L
U X E M B O U R G
Dewey S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.332.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014106497/10.
(140127038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
KKR Retail Partners (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 176.285.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014117428/10.
(140135386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
Darwin International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 122.481.
Nous déclarons par la présente la dénonciation avec effet au 1
er
janvier 2014 du siège fixé au 6 rue Henri M. Schnadt,
L-2530 Luxembourg, de la société DARWIN INTERNATIONAL S.à r.l., inscrite sous numéro du RCS Luxembourg B
122 481.
Référence de publication: 2014106506/10.
(140127676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Le Grand Chêne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 123.649.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 28 juillet 2014i>
1. Mme Ingrid CERNICCHI a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Mme Virginie DECONINCK, administrateur de sociétés, née à Rocourt (Belgique), le 11 octobre 1976, demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale statutaire de 2018.
3. Le siège de la société a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453
Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
1. L'adresse professionnelle de M. Hans DE GRAAF, administrateur et président du conseil d' administration, est
désormais L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert
2. L'adresse professionnelle de Mme Laurence BIVER, administrateur, est désormais L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène
Ruppert
3. Le siège social de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., commissaire, est désormais L-2453 Lu-
xembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 29 Juillet 2014.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Le Grand Chêne S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014117434/24.
(140135141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
125165
L
U X E M B O U R G
Boing Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 187.901.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2014.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014109167/12.
(140130937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
BF Immo, Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 25, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 93.625.
<i>Extrait de résolutioni>
L'assemblée générale du 30 juin 2014, prend acte de la démission de Mademoiselle Emilie FRANCOIS et décide de
coopter au poste d'administrateur jusqu'en 2018, Monsieur Ludovic ABRAS, employé, né le 26 octobre 1981 à B-Namur,
demeurant à 6, rue de l'Etoile à B-5330 Sart Bernard.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2014.
BF IMMO
Société Anonyme
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2014109176/16.
(140131307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Benelom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 650.000,00.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 131.844.
Le gérant déclare que les 6.500 parts composant le capital de la Société et détenues intégralement par la société
anonyme de droit français HF COMPANY, ayant son siège social à F-37310 Tauxigny (France), Node Park Touraine,
immatriculée au Registre du commerce des sociétés de TOURS, sous le numéro 405.250.119 représentée par Monsieur
Yves Bouget président du conseil d'administration, demeurant à F-37540 St Cyr sur Loire (France), 9 rue du Coq, ont
été transférées en totalité, à la société anonyme de droit français SMART HOME INTERNATIONAL, ayant son siège
social à F-75116 Paris (France), rue Cimarosa, 3, immatriculée au Registre du commerce des sociétés de PARIS, sous le
numéro 802.074.245 représentée par Monsieur Alexandre Chaverot, président du conseil d'administration, demeurant
à F-60300 Charmant (France), 5 rue Sainte-Beuve.
Le gérant acte également la démission de la société anonyme de droit français HF COMPANY, ayant son siège social
à F-37310 Tauxigny (France), Node Park Touraine, immatriculée au Registre du commerce des sociétés de TOURS, sous
le numéro 405.250.119 représentée par Monsieur Yves Bouget président du conseil d'administration, demeurant à
F-37540 St Cyr sur Loire (France) 9 rue du Coq, ainsi que la société anonyme de droit français METRONIC, ayant son
siège social à F-37310 Tauxigny (France), Ld Bois Joli immatriculée au Registre du commerce des sociétés de TOURS,
sous le numéro 392.295.780 représentée par Monsieur Nicolas Razafinjato, président du conseil d'administration de-
meurant à F-37540 St Cyr sur Loire (France), 10 rue de Mondoux.
Windhof, le 15 mai 2014.
Philippe Capocci
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2014109163/26.
(140130908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
125166
L
U X E M B O U R G
DB Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 111.380.
Die Bilanz zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DB Equity S.à r.l.
Référence de publication: 2014106508/10.
(140127233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Débardage et Exploitation Forestiers, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6155 Stuppicht, Maison 2.
R.C.S. Luxembourg B 37.424.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014106512/10.
(140128029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Compagnie Maritime Monégasque International II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 39.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 180.771.
Suite à une erreur typographique le numéro d'immatriculation de la COMPAGNIE MARITIME MONEGASQUE, sise
au 74 Boulevard d'Italie, MC-98000 Monaco est le
11S05532
et non le 09S05042.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Référence de publication: 2014110335/14.
(140132843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
CORPUS SIREO Investment Residential No. 23 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 131.935.
AUSZUG
Am 23. Juli 2014 hat CORPUS SIREO Investment Residential GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach
deutschem Recht, mit dem Gesellschaftssitz in 186, Aachener Straße, D-50931 Köln, Deutschland und eingetragen beim
Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 66701, der Teilhaber von 1.150.000 Gesellschaftsanteilen
der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils einem Euro Cent (EUR 0,01), seinen Firmennamen und Gesellschaftssitz
durch konstitutive Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Offenbach am Main dahingehend geändert, dass
er ab diesem Zeitpunkt unter dem Namen CORPUS SIREO Asset Management Commercial GmbH firmiert, den Ge-
sellschaftssitz in 64, Jahnstraße, D-63150 Heusenstamm, Deutschland hat und beim Handelsregister des Amtsgerichts
Offenbach am Main unter der Nummer HRB 47851 eingetragen ist.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, der 25. Juli 2014.
<i>Für die Gesellschafti>
Référence de publication: 2014110342/20.
(140132506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
125167
L
U X E M B O U R G
Delphea S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.
R.C.S. Luxembourg B 73.288.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014106517/10.
(140127867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Dexris Terminus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 158.676.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106519/10.
(140127980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Croq'Chalet Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 51.638.
EXTRAIT
Il découle du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2014 la décision suivante:
- d'accepter, à compter du 25 juillet 2014, la cession de 130 parts sociales détenues par Monsieur PETREMENT Pierre,
domicilié 8a, rue du Fort à F-57330 ENTRANGE, à Monsieur PETREMENT Alain, demeurant 13, rue du Stade à F-57330
ENTRANGE, pour le prix convenu entre parties.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Foetz, le 25 juillet 2014.
MORBIN Nathalie.
Référence de publication: 2014110348/14.
(140132367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Corpus Sireo Investment Residential No. 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 130.419.
AUSZUG
Am 23. Juli 2014 hat CORPUS SIREO Investment Residential GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach
deutschem Recht, mit dem Gesellschaftssitz in 186, Aachener Straße, D-50931 Köln, Deutschland und eingetragen beim
Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 66701, der Teilhaber von 1.150.000 Gesellschaftsanteilen
der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils einem Euro Cent (EUR 0,01), seinen Firmennamen und Gesellschaftssitz
durch konstitutive Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Offenbach am Main dahingehend geändert, dass
er ab diesem Zeitpunkt unter dem Namen CORPUS SIREO Asset Management Commercial GmbH firmiert, den Ge-
sellschaftssitz in 64, Jahnstraße, D-63150 Heusenstamm, Deutschland hat und beim Handelsregister des Amtsgerichts
Offenbach am Main unter der Nummer HRB 47851 eingetragen ist.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, der 25. Juli 2014.
<i>Für die Gesellschafti>
Référence de publication: 2014110339/20.
(140132508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
125168
L
U X E M B O U R G
Double Eagle Capt Company, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 98.560.
Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
.
Signature.
Référence de publication: 2014106530/10.
(140126984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
DL Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 156.686.
Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 21/07/2014.
Référence de publication: 2014106528/10.
(140127399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
European Assist S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 53, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 56.103.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Anonyme EUROPEAN ASSIST tenue en date du 2 juini>
<i>2014 en son siège sociali>
L'Assemblée prend acte que Monsieur Benoît SONVEAU, domicilié professionnellement 53, Gruuss-Strooss, L-9991
Weiswampach démissionne de sa fonction d'administrateur.
Un nouvel administrateur est nommé, qui accepte: Anne VANDEGAART, domiciliée rue Pierre Lecharlier 52/5, B-4430
Ans. Son mandat est de durée déterminée et prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
Signature.
Référence de publication: 2014109358/14.
(140131565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
CORPUS SIREO Investment Residential No. 21 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 131.918.
AUSZUG
Am 23. Juli 2014 hat CORPUS SIREO Investment Residential GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach
deutschem Recht, mit dem Gesellschaftssitz in 186, Aachener Straße, D-50931 Köln, Deutschland und eingetragen beim
Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 66701, der Teilhaber von 1.150.000 Gesellschaftsanteilen
der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils einem Euro Cent (EUR 0,01), seinen Firmennamen und Gesellschaftssitz
durch konstitutive Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Offenbach am Main dahingehend geändert, dass
er ab diesem Zeitpunkt unter dem Namen CORPUS SIREO Asset Management Commercial GmbH firmiert, den Ge-
sellschaftssitz in 64, Jahnstraße, D-63150 Heusenstamm, Deutschland hat und beim Handelsregister des Amtsgerichts
Offenbach am Main unter der Nummer HRB 47851 eingetragen ist.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, der 25. Juli 2014.
<i>Für die Gesellschafti>
Référence de publication: 2014110340/20.
(140132507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
125169
L
U X E M B O U R G
BIM S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.
R.C.S. Luxembourg B 158.410.
Der Jahresabschluss auf den 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014108220/9.
(140129414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.
Capoffice S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 80.883.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014108247/9.
(140130317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.
Cadanor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 46.106.
Monsieur DI BENEDETTO Michel né le 16/09/1969 à Mont Saint Martin en France, avec adresse professionnelle au 3,
Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommé en tant que représentant permanent de la société FMS SERVICES S.A.,
en remplacement de Monsieur Dominique MOINIL avec effet au 22 juillet 2014
<i>Pour la société
i>CADANOR S.A.
Référence de publication: 2014108299/12.
(140129578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.
CASHMERE Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 42.640.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2014i>
L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:
- Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Lux Konzern S.à.r.l., ayant son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, dont le représentant
permanent est Monsieur Peter VAN OPSTAL, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg;
- Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, dont le
représentant permanent est Monsieur Christian KNAUFF, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Mon-
terey à L-2163 Luxembourg.
Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
L’Assemblée renouvelle également le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège
social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes
de l'exercice 2014.
Luxembourg, le 26 juin 2014.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014108307/24.
(140129746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.
125170
L
U X E M B O U R G
GMT Spanext S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 120.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 107.627.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GMT Spanext S.à r.l.
Mandatairei>
Référence de publication: 2014109452/11.
(140131488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Hypo Pfandbrief Bank International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 71.104.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, daß sich die Adresse von Herrn Dr. Matthias Achilles, Verwaltungsratsmitglied und
täglicher Geschäftsführer der Gesellschaft ab sofort geändert hat und wie folgt lautet:
Clara-Schumann Straße 10
61440 Oberursel
Deutschland
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24. Juli 2014.
In Vertretung von Hypo Pfandbrief Bank International S.A.
Max Kremer
Référence de publication: 2014109487/16.
(140130668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Gottschol Alcuilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler.
R.C.S. Luxembourg B 92.809.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 18. Juni 2014i>
Die Jahreshauptversammlung beschließt:
- das Mandat der im Amt befindlichen Verwaltungsratsmitglieder, für die Dauer von sechs Jahren, bis zur Generalver-
sammlung des Jahres 2020 zu verlängern, und zwar:
* Herr Ralph GOTTSCHOL, Gesellschaftsverwalter, mit beruflicher Anschrift in L-9779 ESELBORN, Z.I. Eselborn-
Lentzweiler, 18, Op der Sang, Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates;
* Frau Gabriele GOTTSCHOL-BAASNER, Betriebswirtin, mit beruflicher Anschrift in L-9779 ESELBORN, Z.I. Esel-
born-Lentzweiler, 18, Op der Sang, Verwaltungsratsmitglied.
- das Mandat des jetzigen Wirtschaftsprüfers, „ Fiduciaire Internationale S.A. ", mit Gesellschaftssitz in L-1470 Luxem-
bourg, route d'Esch 7, eingetragen im Handels-und Firmenregister Luxemburg, unter der Nummer B 34.813, vertreten
durch Herrn Alain KOHNEN, zu verlängern und sie mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014, zu
beauftragen.
Die Jahreshauptversammlung nimmt Kenntnis davon, dass die berufliche Adresse von Herrn Ralph GOTTSCHOL und
Frau Gabriele GOTTSCHOL-BAASNER wie folgt lautet, und fortan in allen offiziellen Dokumenten aufgeführt wird:
L-9779 ESELBORN, Z.I. Eselborn-Lentzweiler, 18, Op der Sang.
Diese Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, den 23. Juli 2014.
<i>Für GOTTSCHOL ALCUILUX S.A.
i>FIDUNORD S.à r.l.
Référence de publication: 2014109455/27.
(140131678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
125171
L
U X E M B O U R G
Electro Sud S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4734 Pétange, 2, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 185.316.
L'an deux mil quatorze, le vingt-huit mai et vingt-cinq juin
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange,
ONT COMPARU:
1. La société anonyme Rainier Invest S.A., avec son siège social à L-1213 Luxembourg, 2, rue Caroline Baldauff-Ro-
thermel, constitué en date du 11 décembre 2008 suivant acte reçu par Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence
à Differdange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B143.653, publié au Mé-
morial C en date du 13 janvier 2009, numéro 74, page 3.545;
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Paul DUARTE, demeurant professionnellement à L-4873
Lamadelaine, 84, avenue de la Gare;
2. Monsieur Paulo VIDAL, né le 18 février 1967 à Aveiro (Portugal), demeurant à L-3249 Bettembourg, 2, rue de la
Libération
agissant en leur qualité d'actionnaires de la société ELECTRO SUD S.A., établie et ayant son siège social à L-4734
PETANGE, 2 Avenue de la Gare,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 février 2014,
en voie de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 185.316.
S'est ainsi réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société anonyme.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul DUARTE.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Thibault DAXHELET
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paulo VIDAL.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentaire, restera ci-annexée pour être
enregistrée avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées
à la présent assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Changement de l'objet social et par conséquent modification de l'article 4 des statuts;
3. Divers.
Sur ce, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de modifier l'objet social conformément au nouveau texte de l'article 4 et par conséquent
décide de changer l'article 4 des statuts afin de lui conférer dorénavant la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'une société d'électricité générale, effectuant notamment des travaux
d'installations électriques, des contrôles d'accès domotique, de câblage informatique, de transformations, de réparations,
d'entretien, y compris l'achat et la vente en gros et en détail de tous produits y relatifs.
La société pourra également exercer l'activité d'installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité.
La société a également pour objet l'achat, la vente, l'échange, la gestion d'immeubles et la promotion immobilière.
Pour réaliser ce but, elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières,
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, ou de
nature à en faciliter la réalisation et l'extension.
La société pourra accorder des hypothèques ou garanties, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour
d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes. Elle pourra également s'inté-
resser par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de constitution, de participation, de crédits, d'achats d'actions, parts,
obligations ou toute autre à toutes autres sociétés ou entreprises similaires susceptibles de favoriser directement ou
indirectement le développement de ses affaires.
125172
L
U X E M B O U R G
La Société donnera en autre en location à l'intérieur du groupe les installations techniques, machines et matériel roulant
dont elle dispose et fera de la mise à disposition de personnel.
La société peut, au Luxembourg et à l'étranger, créer des succursales, participer à d'autres entreprises et conclure
tous contrats propres à développer son but».
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
La partie comparante signataire des présentes, déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a
été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les
fonds/biens/droite servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre
(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des
actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes avec indication que Monsieur Jean-Paul DUARTE
a signé le présent acte en date du 28 mai 2014 et Monsieur Paulo VIDAL en date du 25 juin 2014.
Le notaire instrumentant a encore rendu la partie comparante attentive au fait que l'exercice de certaines activités
peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social respectivement
d'autres autorisations administratives particulières, et qu'il y a lieu de se renseigner en ce sens auprès des autorités
administratives compétentes avant d'exercer l'activité de la société dont question.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signés: T. DAXHELET, J-P. DUARTE, P. VIDAL, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 9 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9481. Reçu soixante-quinze euros 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME
PETANGE, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106574/80.
(140127450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Scandium Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 188.890.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of the month of July.
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/Europe 7Q S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having
a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés in Luxembourg under number B 180.323,
represented by Mr Patrick Santer, master at laws, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated
on 17 July 2014, which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company Scandium Investment S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is
hereby established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Scandium Investment
S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders the-
reafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
125173
L
U X E M B O U R G
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participa-
tions and assets.
The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from
the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate
enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock
lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and
instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of
indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/
or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary
in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent,
security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan
acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993
on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent
(75%) of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers
to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to
the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
125174
L
U X E M B O U R G
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
125175
L
U X E M B O U R G
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2014.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (EUR)
BRE/Europe 7Q S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (EUR 1,400).
125176
L
U X E M B O U R G
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BRE/Management 7 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 180.304,
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the
English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences
between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am siebzehnten Tag des Monats Juli,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Lu-
xemburg,
ist erschienen,
BRE/Europe 7Q S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen
Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 12.500) beträgt, und eingetragen ist im Registre de commerce et des sociétés in Luxembourg unter der Nummer
B 180.323,
hier vertreten durch Herrn Patrick Santer, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 17ten Juli 2014, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der
Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-
satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Scandium Investment S.à r.l." wie
folgt zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Scandium Investment S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die
gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen
die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die
Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures,
Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und
unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren
Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicher-
heiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobilienge-
schäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher
Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des
125177
L
U X E M B O U R G
Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der
Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern
würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zu-
künftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-
bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünf-
hundert Euros (EUR 12.500), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig Euros (EUR 25).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesell-
schaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz
nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer
die keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können.
125178
L
U X E M B O U R G
Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden.
Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten
durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzel-
nen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die
Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsfüh-
rung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“oder
„Verfahren“finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“und
„Ausgaben“beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei
Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben,
Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
125179
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung
der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befrie-
digung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse
können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden
Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit
Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert
werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaf-
tern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. De-
zember 2014 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten
sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
eingezahlt und gezeichnet:
125180
L
U X E M B O U R G
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(EUR)
BRE/Europe 7Q S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kostenschätzungi>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr vierzehnhundert Euro (EUR 1,400) geschätzt.
<i>Ausserordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 7 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der
Nummer B 180.304.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-
nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: P. SANTER, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 21 juillet 2014. Relation: RED/2014/1592. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels - und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, den 25. Juli 2014.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2014109934/453.
(140131956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Goba Cardinal S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Aerium Erlangen Holdings S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Luxembourg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 152.889.
In the year two thousand fourteen, on the tenth day of July.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
LDV MANAGEMENT AERIUM 2 S.C.A., a partnership limited by share (société en commandite par actions) incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6A, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, registered with the Luxembourg Companies Trade and Companies Register of under number B 98912,
(the “Sole Shareholder”),
here represented by Mr. Frédéric Lahaye, with professional address at 6A Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, by
virtue of a proxy, given under private seal.
The said proxy, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party declares to be the current sole shareholder of Aerium Erlangen Holdings S.à r.l, a société à
responsabilité limitée, with registered office at L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, incorporated by deed of Maître
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on April 28, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on May 20, 2010, under the number C 1056 (hereinafter referred to as the “Company”).
125181
L
U X E M B O U R G
The Sole Shareholder requests the notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder DECIDES to change the name of the Company into GOBA CARDINAL S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder DECIDES to amend the second paragraph of
article 1 of the articles of association of the Company which shall therefore be read as follows:
“The Company exists under the name of "GOBA CARDINAL S.à r.l.”
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, the said proxyholder signed together
with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil quatorze, le dix juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
LDV MANAGEMENT AERIUM 2 S.C.A., une société en commandite par actions.
constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 98912, (l'“Associé Unique”),
Ici représentée par Monsieur Frédéric Lahaye, demeurant professionnellement au 6A Route de Trèves, L-2633 Sen-
ningerberg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant déclare être l'associé unique actuel de Aerium Erlangen Holdings S.à r.l, une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, constituée par un acte de Maître Paul Bettingen, notaire de rési-
dence à Niederanven, le 28 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 28 avril 2010 numéro
C 1056 (ci-après dénommée «la Société»).
L'Associé Unique a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de changer la dénomination sociale de la Société en GOBA CARDINAL S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution précédente, l'Associé Unique DECIDE de modifier le deuxième alinéa de l'article 1 des statuts de
la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«La Société adopte la dénomination GOBA CARDINAL S.à r.l.».
Le notaire instrumentant, qui a connaissance de la langue anglaise, constate qu'à la requête des parties comparantes,
le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le
notaire le présent acte.
Signé: F. LAHAYE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 juillet 2014. Relation: LAC/2014/32910. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106286/70.
(140128047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
125182
L
U X E M B O U R G
Al-Tat Doner, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8372 Hobscheid, 16A, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 188.767.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le huit juillet.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
- Monsieur Murat YILDIRIM, commerçant, né à Palu (Turquie) le 1
er
avril 1982, demeurant au F-57185 Vitry-sur-
Orne, 66, rue du Docteur Maurin,
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il
déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de "AL-TAT DONER".
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Hobscheid.
Art. 3. La société a pour objet l'achat, le stockage, la vente en gros ou en détail de tous produits alimentaires, prestations
de services et fournitures connexes et faire l'entremise ou le courtage de tous ces produits.
La société pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le déve-
loppement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-€), représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (125,- €) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat, leur rémunération (s'il en est) et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication
de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été intégralement souscrites par l'associé unique, Monsieur Murat YILDIRIM, susdit.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à sept cent cinquante euros (750,- €).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-8372 Hobscheid, 16A, Grand-Rue.
- Le nombre des gérants est fixé à trois (3).
- Est nommé gérant technique, pour une durée illimitée:
* Monsieur Sahit YILDIRIM, commerçant, né le 29 septembre 1991 à Saint-Avold (France), demeurant à F-57185 Vitry-
sur-Orne (France), 66, rue du Docteur Maurin,
- Sont nommés gérants administratifs, pour une durée illimitée:
* Monsieur Firat YILDIRIM, commerçant, né le 20 novembre 1985 à Palu (Turquie), demeurant à L-4710 Pétange, 122,
rue d'Athus,
125183
L
U X E M B O U R G
* Monsieur Murat YILDIRIM, commerçant, né à Palu (Turquie) le 1
er
avril 1982, demeurant au F-57185 Vitry-sur-
Orne, 66, rue du Docteur Maurin.
La société est engagée par la signature conjointe du gérant technique avec un gérant administratif.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et
demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: YILDIRIM, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 juillet 2014. Relation: LAC / 2014 / 32663. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106333/66.
(140127567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
E.B. Trans S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7-9, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 38.281.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106538/10.
(140128025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
E.V.A.F. Luxembourg (Highstreet) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 136.822.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014106540/10.
(140127776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Dupuis Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 3A, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 177.987.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Stonehage Corporate Services Luxembourg S.A.
3A, Val Ste Croix
L-1371 Luxembourg
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014106501/14.
(140127490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
125184
ABI CEE Holdings S.à r.l.
Aerium Erlangen Holdings S.à r.l.
AFP (Germany) S.à r.l.
Albatros Son Holding BV & Cie.
Almacantar
Al-Tat Doner
Benelom S.à r.l.
BF Immo
BIM S. à r. l.
Boing Group S.à r.l.
Cadanor S.A.
Cambaceres France Holdings AREII (Luxembourg) S.à r.l.
Can Benelux
Capoffice S.A.
CASHMERE Spf S.A.
Compagnie Maritime Monégasque International II S.à r.l.
Corpus Sireo Investment Residential No. 14 S.à r.l.
CORPUS SIREO Investment Residential No. 21 S.à r.l.
CORPUS SIREO Investment Residential No. 23 S.à r.l.
Croq'Chalet Sàrl
Darwin International S.à r.l.
DB Equity S.à r.l.
DB Valoren S.à r.l.
Débardage et Exploitation Forestiers
Delphea S.à r.l.
Développement & Rénovation Sàrl
Dewey S.A.
Dexris Terminus S.A.
Diorama Investments Sicar, S.A.
DL Investments S.A.
DMD S.A.
Double Eagle Capt Company
Dupuis Investment S.à r.l.
Dyonas S.à.r.l.
E.B. Trans S.A.
Electro Sud S.A.
EnergyMixx Europe S.A.
European Assist S.A.
E.V.A.F. Luxembourg (Highstreet) S.à r.l.
GMT Spanext S.à r.l.
Goba Cardinal S.à r.l.
Gottschol Alcuilux S.A.
Heisdorf Participations S.A.
Hypo Pfandbrief Bank International S.A.
Insurance Participations Company
Jazz S.à r.l.
KKR Retail Partners (Luxembourg) S.à r.l.
Lear East European Operations
Le Grand Chêne S.A.
LOGOS IT Services S.A.
London Transit Holdings S.à r.l.
Scandium Investment S.à r.l.
Sirius Group Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
St. Georges Investment S.A. - SPF
Taché Investments S.A.
Umicore International
Vatoa Holding S.A.
Vazon Investments S.A.
WD Nonntal S.C.A
YELLOW T International S.A.