This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2453
11 septembre 2014
SOMMAIRE
Almacantar Kingsway S. à r.l. . . . . . . . . . . .
117717
Cambodia-Laos Development Fund
S.C.A., SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117734
CORPUS SIREO Investment Residential
No. 21 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117710
Digital Services XXIV (GP) S.à r.l. . . . . . . .
117724
Dix-huit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117705
Dix-huit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117704
EcoSol - Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117711
Edmund Propco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
117720
Educastream Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
117709
Euromax IV MBS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117709
Euro-Trading S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117708
Gripinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117735
Merou S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117701
MFS Meridian Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117698
Miele s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117701
Monumenta Invest I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117698
Mothership S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117698
Motola S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117699
Motola S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117699
Mouwannes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117699
Moxfleisch Finanz Beteiligungs Gesell-
schaft AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117700
NameDrive EU s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117700
Nectar Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117705
Nectar Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117704
Nectar Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . .
117706
Nectar Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . .
117706
Nexus Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117699
NinaLi S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117704
Njord Wind S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117704
NM Coiffure S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117702
NM Coiffure S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117703
Nordica Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117707
Noura S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117703
NREP Transactions Holding 6 S.à r.l. . . . .
117707
N.V. Getronics Belgium S.A. . . . . . . . . . . . .
117702
N.V. Getronics Belgium S.A. . . . . . . . . . . . .
117702
OCM KSH Devco Holdings S.à r.l. . . . . . . .
117700
OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117708
OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117709
OCM Luxembourg Mezz II S.à r.l. . . . . . . .
117703
Octavian S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117704
Open Mind Investments S.C.A. SICAR . . .
117707
Openvise Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117705
OW Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
117706
Paragem Assets S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
117705
Parsnip S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117699
Patrilar Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117706
Pecana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117709
Petrolog Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
117703
P&Pm S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117701
PrivAccess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117700
Softgreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117708
Spittelmarkt S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117707
Spunken S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117708
SurveyMonkey Europe Sarl . . . . . . . . . . . . .
117706
Talgo MGT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117701
Talys Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117723
Tasal 3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117698
Textile Aaronsons S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
117719
That's It A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117702
Twister Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117698
ZapFi International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
117714
117697
L
U X E M B O U R G
Mothership S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 155.085.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014096266/10.
(140114665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Monumenta Invest I, Société Anonyme,
(anc. Tasal 3 S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 167.539.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2013 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2014096264/11.
(140115003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
MFS Meridian Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 39.346.
Faisant suite à l'assemblée générale ordinaire du 16 Juin 2014, sont re- nommés gérants jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2015:
Madame Lina M. MEDEIROS
Monsieur Mark N. POLEBAUM
Madame Robin A. STELMACH
Mr. Mitchell C. Freestone
Mr. David M. Mace Jr
Est renommé réviseur d'entreprise jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015:
Ernst & Young S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 Juin 2014.
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2014096252/19.
(140114982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Twister Investment, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 121.216.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 9 juillet 2014i>
Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxem-
bourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 9 juillet 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Twister Investment
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014098771/14.
(140116793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.
117698
L
U X E M B O U R G
Motola S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4671 Oberkorn, 98, avenue du Parc des Sports.
R.C.S. Luxembourg B 156.786.
Les comptes annuels au 11 avril 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014096268/10.
(140115058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Motola S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4671 Oberkorn, 98, avenue du Parc des Sports.
R.C.S. Luxembourg B 156.786.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014096269/10.
(140115059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Mouwannes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3501 Dudelange, 38, rue Aloyse Kayser.
R.C.S. Luxembourg B 69.810.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2014096270/11.
(140114526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Nexus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 132.313.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 31 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 31 janvier 2014.
Référence de publication: 2014096282/11.
(140114855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Parsnip S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 172.782.
Il est pris acte de la modification de l'adresse de l'associé unique de la société comme indiqué ci-dessous:
- Monsieur Denery Fenouil, né le 04/02/1971 à Nice en France, demeurant au 15 crane grove, Londres, N7 8LD,
Royaume Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2014.
Référence de publication: 2014096355/12.
(140113816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
117699
L
U X E M B O U R G
NameDrive EU s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 157.524.
Il est porté à la connaissance des tiers que Monsieur François Herpoel, Gérant de la société, habite désormais au 10
rue des Bruyères, B-6791 Athus.
Référence de publication: 2014096278/9.
(140114584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Moxfleisch Finanz Beteiligungs Gesellschaft AG, Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 65.418.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04/07/2014.
Signature.
Référence de publication: 2014096271/10.
(140114016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
PrivAccess, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 166.550.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 27 juin 2014i>
L'Assemblée General décide à l'unanimité de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route
d'Esch, L-1014 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (RCS Luxembourg B 65477) au poste de Réviseur d'Entre-
prises Agréé pour une période arrivant à échéance à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2014.
Extrait
FIDUPAR
Signatures
Référence de publication: 2014097448/15.
(140115939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
OCM KSH Devco Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 186.300.
<i>Extrait du contrat de cession de parts socialesi>
En date du 7 avril 2014, l'associé unique de la société, OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., une société à responsabilité
limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Lu-
xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B159343, a cédé la
totalité des parts sociales qu'il détenait dans la société, soit cinq cents (500) parts sociales, à la société OCM Luxembourg
Unicity Top Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B181517.
En conséquence de cette cession de parts sociales, OCM Luxembourg Unicity Top Holdings S.à r.l., précitée, est
désormais associé unique de la société et détient cinq cents (500) parts sociales dans la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2014096312/20.
(140114481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
117700
L
U X E M B O U R G
Miele s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 20, rue Christophe Plantin.
R.C.S. Luxembourg B 15.429.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014097376/9.
(140116076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
P&Pm S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 95.537.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07/07/2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014097412/12.
(140115115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Merou S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5865 Alzingen, 2, rue de Roeser.
R.C.S. Luxembourg E 5.122.
Les statuts coordonnés au 01/07/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 08/07/2014.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014097375/12.
(140116023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Talgo MGT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 171.938.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenu au siège social le 15 juillet 2014i>
L'assemblée des actionnaires, après avoir lu les lettres de démission de Monsieur Patrick HALLER, Monsieur Martin
RUTLEDGE et Madame Christine PICCO, comme administrateurs de la société, a résolu d'accepter leur démission.
L'assemblée a décidé de nommer comme nouveaux administrateurs de la société, ayant la même échéance que leur
prédécesseur:
- Monsieur Thomas Dewé, né le 14 Janvier 1977 à Rocourt (Belgique), résident professionnellement au 20 Rue de la
Poste, L-2346 Luxembourg;
- Madame Hélène Mercier, née le 1
er
Février 1972 à Mont Saint Martin (France), résident professionnellement au 20
Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
- Madame Manuela D'Amore, née le 4 Mars 1972 à Rome (Italie), résident professionnellement au 20 Rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg.
L'assemblée a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social du 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 20 Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014102657/21.
(140123667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.
117701
L
U X E M B O U R G
NM Coiffure S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 35.309.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014096294/9.
(140113840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
N.V. Getronics Belgium S.A., Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2529 Luxembourg, 15, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 50.820.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 13 juin 2014.
Référence de publication: 2014096276/10.
(140114102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
N.V. Getronics Belgium S.A., Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2529 Luxembourg, 15, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 50.820.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 13 juin 2014.
Référence de publication: 2014096277/10.
(140114103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
That's It A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 95.618.
EXTRAIT
Monsieur André HARPES, né le 17.03.1960 à Luxembourg, demeurant à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, a
été renommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019, avec droit de signature individuelle.
Madame Nina MEYER, née le 23.11.1984 à Ettelbruck, demeurant à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, a été
nommée administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019, avec droit de signature individuelle, en
remplacement de Madame Carine BITTLER.
La société à responsabilité limitée MAMA.LU S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, Place
du Théâtre, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B147396, représentée par Monsieur
Jean-Pierre VERNIER, né le 02.10.1952 à Nantes, demeurant à L-2210 Luxembourg, 84, boulevard Napoléon I
er
, a été
renommée administrateur et administrateur-délégué, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019, avec droit de
signature individuelle.
La société anonyme COMPTABILUX S.A., établie et ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre,
immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 87204, représentée par Monsieur Yves SCHMIT,
a été renommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014102667/25.
(140123792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.
117702
L
U X E M B O U R G
NM Coiffure S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 35.309.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014096295/9.
(140113854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Noura S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 32, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 140.768.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2014096302/11.
(140114527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
OCM Luxembourg Mezz II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 140.812.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de la Société prises le 10 juin 2014i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé de nommer Mme Figen EREN, née le 10 février 1978 à
Besançon (France) ayant sa résidence professionnelle au 26A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg comme Gérant de la
société avec effet au 10 juin 2014
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OCM Luxembourg Mezz II Sàrl
Référence de publication: 2014096317/13.
(140113883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Petrolog Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.
R.C.S. Luxembourg B 95.386.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2013.i>
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 avril 2013 que:
Les mandats d'administrateur de Madame Corinne Andres et de Monsieur Marc Scherrer sont renouvelés jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.
Le mandat de commissaire aux comptes de la société FIDAL Gestion & Conseils S.à r.l. est renouvelé jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en 2019.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Olivier Merconato n'est pas renouvelé.
L'assemblée générale nomme au poste d'administrateur Monsieur Christophe Fender, né le 10/07/1965 à Strasbourg
en France, demeurant professionnellement au 2, Rue Benjamin Franklin L-1540 Luxembourg et ce, avec effet immédiat
et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18/06/2014.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014096371/21.
(140114765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
117703
L
U X E M B O U R G
Octavian S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 72.551.
Les comptes annuels au 30 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014096318/9.
(140114580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
NinaLi S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9115 Schieren, 1, rue de l'Abattoir.
R.C.S. Luxembourg B 165.672.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014096284/10.
(140114602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Njord Wind S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 212.300,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 130.710.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2014096285/10.
(140114619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Nectar Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 60.796.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014096288/10.
(140114158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Dix-huit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 209, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 176.397.
 qui de droit:
Le sous signé, Roni Moshiashvili, en sa capacité de Gérant de la société, prend acte du transfert des parts sociales
survenu entre:
1- Mr. Meir TETROASHVILI, demeurant à: 40, Hagedoornlaan. B- 2180 Anvers; dénommé ci-après le Cédant
2- Mme. Malkit MOSHIASHVILI, demeurant à: 13, Nerviërstraat. B-2018 Anvers; ci-après dénommée la Cessionnaire
Le cédant cède sous seing privé ses 50 parts sociales nominatives, à la valeur nominale à la cessionnaire, qui accepte,
valeur reçue, pour acquit.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2014.
Signature.
Référence de publication: 2014098872/15.
(140117873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.
117704
L
U X E M B O U R G
Nectar Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 60.796.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014096289/10.
(140114163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Openvise Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 166.276.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2013 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2014096325/11.
(140114119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Paragem Assets S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 179.253.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 20 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 20 janvier 2014.
Référence de publication: 2014096332/11.
(140114853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Dix-huit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 209, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 176.397.
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 juin 2014i>
L'an deux mille quatorze, le treize juin, à onze heures trente, les associés se sont réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire, sur convocation du Gérant de la société.
Sont présents:
- Mr. Meir Tetroashvili représentant 50 parts sociales de € 125,-
- Mr. Rahamim Moshiashvili représentant 50 parts sociales de €125,-
<i>Première Résolutioni>
Sur proposition du président, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'accepter la démission de Mr. Meir TE-
TROASHVILI, domicilié: 40, Hagedoornlaan a B-2180 Ekeren, de la fonction de Gérant de la société.
<i>Deuxième Résolutioni>
Sur proposition du président, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'accepter la nomination de Mr. Roni Mos-
hiashvili, domicilié.26, Charlottalei, à B-2018 Anvers à la fonction de Gérant de la société, qui accepte.
Mr. Rahamim Moshiashvili / Mr. Meir Tetroashvili / Mr. Roni Moshiashvili
<i>Associé / Associé / -i>
Référence de publication: 2014098871/22.
(140117873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.
117705
L
U X E M B O U R G
OW Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: JPY 1.801.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 177.580.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014096329/9.
(140114971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Nectar Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 60.796.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014096290/10.
(140114170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Nectar Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 60.796.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014096291/10.
(140114180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Patrilar Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 43.240.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PATRILAR Sàrl
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014096360/11.
(140113804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
SurveyMonkey Europe Sarl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 167.062.
En date du 09 juin 2014, le Conseil de Gérance a décidé de changer le siège social de la Société du 1, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SurveyMonkey Europe Sarl
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Agent Administratifi>
Référence de publication: 2014099421/14.
(140118244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.
117706
L
U X E M B O U R G
Nordica Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 150.541.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014096300/10.
(140114904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
NREP Transactions Holding 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 134.153.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 Juillet 2014.
Référence de publication: 2014096303/10.
(140114542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Open Mind Investments S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société
d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 144.283.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014096307/10.
(140113718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Spittelmarkt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 150.567.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société tenue en date du 30 juin 2014:
1. Clôture de la liquidation de la Société avec effet au 30 juin 2014;
2. Décharge au liquidateur, la société FIDES (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg et immatriculé sous le numéro B 41469;
3. Décharge au Commissaire à la liquidation, la société EQ Audit S.à.r.l., ayant son siège social au 2, rue Joseph Hackin,
L-1746 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 124782;
4. Les livres et les documents sociaux de la Société seront conservés à l'adresse suivante pendant une période de cinq
(5) ans à compter de la publication de la clôture de la liquidation de la Société au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, C: au 18-20, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2014.
<i>Pour la Société
i>FIDES (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014101603/24.
(140120522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
117707
L
U X E M B O U R G
OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.699.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2014.
Référence de publication: 2014096314/10.
(140114428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Spunken S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 151.284.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 30 juin 2014i>
L'assemblée décide de renouveler le mandat de la société Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, aux fonctions de réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'assemblée générale annuelle approu-
vant les comptes annuels au 31 décembre 2014.
Pour extrait conforme
Spunken S.A.
Référence de publication: 2014101604/13.
(140120564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Euro-Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 30.537.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par un jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI
e
section, siégeant en matière
commerciale a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée EURO-
TRADING S.à r.l., ayant eu son siège social à L-1013 LUXEMBOURG, Zone Industrielle de Sandweiler, de fait inconnue
à cette adresse.
Les frais sont mis à charge de la masse.
Pour extrait conforme
Me Pierre FELTGEN
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2014099908/15.
(140119582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.
Softgreen, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 178.035.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 13 mai 2014i>
1. la démission de FISCOGES avec siège social à L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen est acceptée;
2. Mme Isabelle Schul, employée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, est
nommée nouvel Administrateur en remplacement de FISCOGES. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale
Statutaire de 2018;
Luxembourg, le 13 mai 2014.
Pour extrait sincère et conforme
SOFTGREEN
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2014101597/16.
(140120196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
117708
L
U X E M B O U R G
Educastream Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 148.408.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014099893/9.
(140118826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.
OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.699.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2014.
Référence de publication: 2014096315/10.
(140114429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Euromax IV MBS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 110.721.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 8 juillet 2014i>
Le Conseil d'Administration de la Société décide de renouveler le mandat de Ernst & Young, ayant son siège social au
7, rue Gabriel Lippmann L - 5365 Munsbach, enregistrée sous le numéro B 47771 au Registre de Commerce et des
Sociétés du Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société et ce pour l'audit des comptes se clôturant le 31
décembre 2014.
A Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2014099910/16.
(140119437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.
Pecana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 47.903.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenue en date du 30 mai 2014i>
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 30 mai 2014 que:
- Le siège social de la société est transféré du 42-44 avenue de la gare L-1610 Luxembourg au 50, rue Charles Martel,
L-2134 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2014.
- Les administrateurs M. Claude ZIMMER, M. Hendrik H.J. KEMMERLING et M. Rob SONNENSCHEIN sont domiciliés
professionnellement au 50, rue Charles Martel 1
er
étage, L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1
er
juin 2014.
- L'administrateur LuxGlobal Management S.à r.l, société enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg sous le numéro B159.893 est transféré au 50, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au
1
er
juin 2014. Représentant permanent M. Hendrik H.J. KEMMERLING domicilié professionnellement au 50, rue Charles
Martel, 1
er
étage L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1
er
juin 2014.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014098596/19.
(140117486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.
117709
L
U X E M B O U R G
CORPUS SIREO Investment Residential No. 21 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 131.918.
Im Jahre zweitausendvierzehn, am dreißigsten Tag des Monats Juni.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Léonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
1) CORPUS SIREO Investment Residential Holding GmbH & Co. KG, eine nach deutschem Recht bestehende Kom-
manditgesellschaft mit Gesellschaftssitz in 186, Aachener Straße, D-50931 Köln, Deutschland und im Handelsregister des
Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRA 26442 eingetragen durch den Gesellschafter 2 in seiner Eigenschaft als
Komplementär handelnd (hiernach "Gesellschafter 1")
und
2) CORPUS SIREO Investment Residential GmbH, eine nach deutschem Recht bestehende Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung mit Gesellschaftssitz in 186, Aachener Straße, D-50931 Köln, Deutschland und im Handelsregister des
Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 66701 eingetragen (hiernach "Gesellschafter 2" und gemeinsam mit dem
Gesellschafter 1 als die "Gesellschafter" bezeichnet).
Die Gesellschafter werden infolge privatschriftlicher Vollmachten durch Herrn Peter F. Bonert, Rechtsanwalt, mit
professioneller Anschrift in 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, vertreten.
Die besagten Vollmachten werden, nachdem sie durch den Bevollmächtigten und die Notarin paraphiert und gegen-
gezeichnet worden sind, dieser Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.
Die erschienenen Parteien erklären hiermit, dass sie die alleinigen Gesellschafter von CORPUS SIREO Investment
Residential No. 21 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (Société à respon-
sabilité limitée) mit Gesellschaftssitz in 4a, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingetragen im Luxemburger Handelsre-
gister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 131.918 (die "Gesellschaft"), sind und das gesamte
Gesellschaftskapital der Gesellschaft halten. Die Gesellschaft wurde am 16. August 2007 durch notarielle Urkunde der
Notarin Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet, was im Luxem-
burger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Associations et des Sociétés) Nummer 2402 vom 24. Oktober 2007
veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 30. Dezember 2013 durch notarielle Urkunde der-
selben Notarin verändert und im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Associations et des Sociétés) Nummer
1064 am 25. April 2014 veröffentlicht.
Die ordnungsgemäß vertretenen Parteien erklären, von den zu beschließenden Punkten entsprechend der Tagesord-
nung Kenntnis zu haben.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnungi>
1) Neueinteilung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals durch Abänderung und Reduzierung des Nennwerts eines
Gesellschaftsanteils von derzeit fünf Hundert Euro (EUR 500,-) auf einen Euro Cent (EUR 0,01), mit der Folge, dass das
Gesellschaftskapital, das derzeit aus fünfundzwanzig (25) Gesellschaftsanteilen besteht, auf eine Million zweihundertfünf-
zigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro Cent (EUR 0,01) aufgeteilt wird und
dass daraufhin der Gesellschafter 1 eine Million einhundertfünfzigtausend (1.150.000) Gesellschaftsanteile und der Ge-
sellschafter 2 ein hunderttausend (100.000) Gesellschaftsanteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem Euro
Cent (EUR 0,01) hält;
2) Änderung der Satzung der Gesellschaft, um den unter Punkt 1 verabschiedeten Beschluss darin widerzuspiegeln;
3) Verschiedenes.
Die wirksam vertretenen Parteien haben die unterzeichnende Notarin gebeten, folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen, das ausgegebene Gesellschaftskapital neu einzuteilen, indem der Nennwert eines Ge-
sellschaftsanteils von derzeit fünfhundert Euro (EUR 500,-) auf einen Nennwert eines Gesellschaftsanteils von einem Euro
Cent (EUR 0,01) abgeändert und reduziert wird, mit der Folge, dass das Gesellschaftskapital, das derzeit aus fünfundz-
wanzig (25) Gesellschaftsanteilen besteht, auf eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteile mit
einem Nennwert von je einem Euro Cent (EUR 0,01) aufgeteilt wird und dass daraufhin der Gesellschafter 1 eine Million
einhundertfünfzigtausend (1.150.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro Cent (EUR 0,01) und
der Gesellschafter 2 einhunderttausend (100.000) Gesellschaftsanteile hält.
117710
L
U X E M B O U R G
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen, die Satzung der Gesellschaft zu ändern, um den ersten Beschluss dieser Urkunde darin
widerzuspiegeln.
Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft hat demzufolge folgenden Wortlaut:
" 5.1. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist in eine Million
zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro Cent (EUR 0,01)
aufgeteilt."
<i>Ausgabeni>
Die Kosten, Ausgaben, Gebühren oder Lasten, die in irgendeiner Form der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde
erwachsen, werden auf eintausend Euro (EUR 1.000,-) veranschlagt.
Worüber die gegenwärtige notarielle Urkunde am eingangs erwähnten Datum in Luxemburg aufgenommen wurde.
Nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an den erschienenen Vertreter, der der Notarin von seinem Vor-
namen, Nachnamen, Familienstand und seiner professionellen Adresse her bekannt ist, hat dieselbe Person zusammen
mit der beurkundenden Notarin, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Bonert, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 juillet 2014. Relation: LAC/2014/30548. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole FRISING.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 10. Juli 2014.
Référence de publication: 2014099824/76.
(140119927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.
EcoSol - Sanem, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4477 Belvaux, 60, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg F 9.990.
Cette version corrigée remplace la 1
ère
version déposée le 11/06/2014 sous le No L140095306
Entre les soussignés, membres associés et fondateurs, à Belvaux, le 5 juin 2014:
Nom
Prénom
Profession
Domicile
Nationalité
Asselborn-Bintz
Simone
Éducatrice diplômée
20 rue Sigefroi/
L-4407 Belvaux
Luxembourgeoise
Cecchetti
Myriam
Institutrice
5 rue de Limpach
L-4986 Sanem
Luxembourgeoise
Cozzi
Tamara
Assistante sociale
21 rue du Stade
L-4488 Belvaux
Luxembourgeoise
De Rocco
Magali
Travailleuse sociale
49 rue Basse/
L-3813 Schifflange
Luxembourgeoise
Goerend
Nathalie
Employée communale
1 rue Aloyse Meyer
L-4407 Belvaux
Luxembourgeoise
Morgenthaler
Nathalie
Politologue
15 rue Aloyse Meyer
L-4407 Belvaux
Luxembourgeoise
Olmo
Serge
Educateur gradué
45 rue Charles de Gaulle/
L- 4459 Soleuvre
Luxembourgeoise
Phillips
Catherine
Juriste
3 rue de l'Ecole/
L-8358 Goeblange
Luxembourgeoise
Piscitelli
Jos
Fonctionnaire d'état
42 rue G.D. Charlotte
L-4430 Belvaux
Luxembourgeoise
Rod
Gilles
Psychologue
27 rue du Cimetière
L-1338 Luxembourg
Luxembourgeoise
Sander
Beate
Educatrice diplômée
4 rue Léon Weirich
L-4348 Esch-sur-Alzette
Luxembourgeoise
Speck-Braun
Patricia
Agente commerciale
50 cité op Gewaennchen/
L- 4383 Ehlerange
Luxembourgeoise
Steffen
Josy
Retraité
5, Place de l'Indépendance
L-4418 Soleuvre
Luxembourgeoise
117711
L
U X E M B O U R G
est crée par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle
a été modifiée et les présents statuts.
STATUTS
Art. 1
er
. Dénomination, siège et durée. L'association prend la dénomination «EcoSol - Sanem» a.s.b.l. (Economie
Solidaire et sociale - Commune de Sanem)
Son siège est établi dans la Commune de Sanem.
Le siège pourra être transféré à l'intérieur du territoire de la Commune de Sanem par simple décision du Conseil
d'administration et dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'Assemblée gé-
nérale statuant en matière de modification des statuts.
L'association est créée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet. L'association a pour objet de réaliser, promouvoir, développer et soutenir la promotion d'une économie
sociale et solidaire qui se base essentiellement sur un développement de synergies entre les différents acteurs socio-
économiques sur le plan local et régional dans une approche sociale, écologique et économique.
Les axes principaux de son action concernent la lutte contre l'exclusion sociale par la création et le maintien d'emplois
ainsi que le développement de nouveaux secteurs d'activité sur le plan local et régional qui pourra prendre les formes
suivantes (énumération non prioritaire et non exhaustive):
- mise en place et opération d'une épicerie solidaire,
- organisation d'une guidance socio-éducative vers des aides et prises en charge sociales,
- favorisation d'une approche communautaire et participative,
- soutenir des partenariats avec des organismes actifs dans la promotion d'activités sociales, écologiques et économi-
ques
- formations théoriques et/ou pratiques, stages (au sens large).
L'association se réserve le droit d'administrer et de gérer, y compris d'acquérir, de louer et de vendre tous biens
meubles et immeubles nécessaires à ces fins. Elle pourra également organiser des activités culturelles à destination et/ou
au profit de son public-cible.
Pour réaliser ces actions, l'association procédera à la recherche de subventionnement public et de sponsoring privé
et aux signatures de contrats et conventions ad hoc.
L'association poursuit son activité dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse mais n'excluant
aucun partenariat tant avec les pouvoirs publics qu'avec des organismes privés du secteur de l'économie sociale et solidaire
comme du secteur économique non protégé.
De manière générale, l'association engage sa responsabilité sociale par le respect des standards de bonne gouvernance
démocratique et s'emploie à former à des activités favorisant un développement sociétal sur plan local et régional.
Art. 3. Membres. L'association se compose de membres associés qui sont nommés «membres actifs» et de membres
donateurs auxquels elle délivre des cartes de membres différentes.
Le paiement de la cotisation donne droit à une carte de membre démontrant l'affiliation à l'association pour une année
de calendrier. Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l'Assemblée générale et ne peut dépasser 100 euros.
3.1 Les membres actifs
Peut devenir membre actif toute personne physique ou morale qui désire participer aux activités de l'association et
qui justifie des liens avec l'association, qui s'est particulièrement distinguée dans le domaine de la lutte contre l'exclusion
sociale du pays et qui paie chaque année la cotisation annuelle.
Pour devenir membre actif, le candidat doit adresser une demande motivée au Conseil d'administration laquelle devra
être appuyée par deux membres actifs. L'admission d'un membre actif est formalisée par une décision du Conseil d'ad-
ministration statuant à la majorité des voix et, en cas de demande, au scrutin secret.
En cas de refus par le Conseil d'administration, un recours est possible devant la prochaine Assemblée générale.
Seuls les membres actifs ont le droit de vote à l'Assemblée générale.
Seuls les membres actifs peuvent être élus au Conseil d'administration.
Les membres du personnel de l'association ne sont pas éligibles en tant que membres actifs.
3.2 Les membres donateurs
Peut devenir membre donateur toute personne physique ou morale désirant apporter un soutien financier à l'asso-
ciation en payant chaque année la cotisation annuelle. Le paiement de la cotisation donne uniquement droit à une carte
de membre démontrant l'affiliation à l'association pour une année de calendrier. La carte de membre donateur ne confère
aucun droit de propriété au niveau de l'association ni droit de vote à l'assemblée générale.
Le non-paiement de la cotisation annuelle met fin à l'affiliation à l'association de la personne physique ou morale
concernée pour l'année en question.
117712
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Démission ou exclusion de membres actifs. Tout membre actif est libre de se retirer de l'association à tout
moment en adressant sa démission écrite au Conseil d'administration.
Est démissionnaire de plein droit tout membre actif qui n'a pas acquitté sa cotisation annuelle avant la tenue de
l'Assemblée générale.
Le Conseil d'administration peut prononcer l'exclusion d'un membre actif qui d'une manière quelconque porte atteinte
aux intérêts et/ou à la finalité sociale ou aux objets de l'association.
La mesure d'exclusion ne pourra être appliquée sans que l'intéressé ait été informé de la mesure envisagée à son
encontre et des motifs la justifiant et, s'il en exprime le souhait, ait eu l'occasion de fournir des explications.
Les membres associés démissionnaires ou exclus ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'association et n'ont
aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.
Art. 5. L'Assemblée générale. L'Assemblée générale se compose de tous les membres actifs et se réunit ordinairement
chaque année avant la fin du mois de juin sur convocation du Conseil d'administration par lettre ordinaire au moins huit
(8) jours avant la date de la réunion de l'Assemblée. La convocation doit indiquer l'ordre du jour proposé.
Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un
cinquième des membres actifs le demande par écrit au Conseil d'administration.
L'Assemblée générale prend ses décisions à la simple majorité des membres actifs présents ou représentés. Chaque
membre actif dispose d'un vote et peut se faire représenter par procuration écrite à l'Assemblée générale par un autre
membre actif.
L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration, ou par un membre dûment mandaté
à cet effet.
L'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur une modification des statuts que si l'objet de la modification
est spécialement indiqué dans la convocation et si l'Assemblée réunit les deux tiers des membres actifs. Une telle modi-
fication peut seulement être adoptée à la majorité des deux tiers des voix.
Si le quorum nécessaire de deux tiers des membres associés n'est pas atteint lors d'une première assemblée, une
seconde Assemblée générale peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres actifs
présents; mais, dans ce cas la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.
Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, soit sur sa disso-
lution, les règles suivantes s'appliquent:
- La seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres actifs est présente
ou représentée,
- la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est adoptée à la majorité des trois quarts
des voix des membres actifs présents ou représentés,
- si, dans la seconde assemblée les deux tiers des membres actifs ne sont pas présents ou représentés, la décision
devra être que par le tribunal civil.
Sont de la compétence exclusive de l'Assemblée générale:
- Les modifications des statuts;
- La nomination et la révocation des administrateurs et réviseurs de caisse;
- L'approbation des budgets et des comptes;
- La dissolution volontaire de l'association.
Les décisions et résolutions de l'Assemblée générale sont inscrites dans un registre spécial qui est tenu au siège de
l'association. Tous les membres et les tiers peuvent consulter ce registre sur demande.
Art. 6. Le Conseil d'administration. L'association est gérée par un Conseil d'administration qui est élu à la majorité
simple des membres actifs présents ou représentés à l'Assemblée générale.
Le Conseil d'administration se compose de 5 membres au minimum et 13 membres au maximum.
Les administrateurs sont élus pour une durée de 2 ans par l'assemblée générale et désigneront parmi eux les mandats
respectifs du Président, de deux Vice-présidents, du Secrétaire et du Trésorier.
Les mandats des administrateurs sont révocables. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont
un caractère bénévole et les administrateurs renoncent à toute rémunération.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
L'association sera valablement engagée par la signature conjointe du Président - ou à défaut d'un Vice-président - et
d'un membre du Conseil d'administration dûment mandaté à cet effet.
Le Conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extra-
judiciaires.
Le Conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur l'initiative du Président ou du Secrétaire qui
proposent l'ordre du jour. Le Conseil d'administration ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents
ou représentés. Aucun administrateur ne peut porter plus d'une procuration à une réunion du conseil d'administration.
117713
L
U X E M B O U R G
Le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité absolue. En cas de partage des voix, celle du Président
ou de son remplaçant est prépondérante.
Les décisions du Conseil d'administration sont notées sous forme de procès-verbaux et sont inscrites dans un registre
spécial.
Art. 7. Comptes annuels et commissaire aux comptes. La vérification de l'état des recettes et des dépenses de l'as-
sociation devra être faite par au moins un commissaire aux comptes élu à cet effet par l'Assemblée générale, pour une
durée de 2 ans. Le(s) commissaire(s) sortants sont rééligibles.
Le Conseil d'administration soumet annuellement à l'Assemblée générale les comptes annuels de l'exercice écoulé,
ainsi qu'un budget prévisionnel sur l'exercice à venir.
L'Assemblée générale votera sur l'approbation des comptes, sur la décharge à donner aux administrateurs après avoir
entendu les rapports du Conseil d'administration et du/des commissaire(s) aux comptes et/ou d'un réviseur d'entreprise
compétent, étranger à l'association nommé à cet effet.
Art. 8. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier et prend fin le 31 décembre.
Art. 9. Dissolution. En cas de dissolution de l'association, l'actif net est affecté à une autre association sans but lucratif
reconnue d'utilité publique ou à une fondation poursuivant une activité analogue.
Art. 10. Dispositions générales. Le Conseil d'administration complète les listes des membres chaque année par l'indi-
cation des modifications qui se sont produites et ce endéans un mois à partir de la clôture de l'année sociale.
Pour toutes matières non-réglées par les présents statuts, il est fait référence à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les
associations et les fondations sans but lucratif.
Référence de publication: 2014103056/165.
(140121603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
ZapFi International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7432 Gosseldange, 79, route de Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 163.788.
In the year two thousand fourteen, on the 2
th
of July,
Before us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of “ZapFi International S.A.”, a société anonyme (joint stock
company) duly formed and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office
at L-7432 Gosseldange, 79, route de Mersch (Grand-Duchy of Luxembourg), registered at the Luxembourg Register of
Trade and Companies under the number B 163 788, incorporated on October 5
th
, 2011 before Maître Blanche Moutrier,
notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), deed published in the Mémorial C Recueil Spécial des
Sociétés et Associations number 2830 of November 19
th
, 2011, modified on December 12
th
, 2011 before the under-
signed Notary Maître Blanche Moutrier, deed published in the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations
number 162 of January 19
th
, 2012 and modified on April 25
th
, 2013 before the undersigned Notary Maître Blanche
MOUTRIER, deed published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1465 from June 20
th
, 2013 (hereafter the “Company”).
The General Meeting was presided by Mr Charles Duro, attorney-at-law, with professional address at 03, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
The chairman appointed as secretary Mrs Karine Mastinu, attorney-at-law, with professional address at 03, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
The General Meeting elected as scrutineer Mr Lionel Bonifazzi, attorney-at-law, with professional address at 03, rue
de la Chapelle L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
The chairman requested the notary to act that:
I. The shareholders present or represented, the proxyholders of the shareholders and the number of shares held by
each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders present, by the proxyholders of the shareholders
represented and by the members of the bureau and the undersigned Notary. That attendance list and the proxies of the
shareholders represented shall remain attached to the present deed in order to be registered with it.
II. The whole share capital of the Company being present or represented at the current meeting, the convening notices
could be waived, the shareholders present or represented consider being validly convened and acknowledge being suffi-
ciently informed on the agenda of which the shareholders expressly state having been duly informed beforehand.
III. The agenda of the General Meeting was the following:
117714
L
U X E M B O U R G
<i>Agendai>
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of 2.000.000,-eur so as to raise it from its
current amount of 4.725.000,-eur to an amount of 6.725.000,-eur by issuance of 2.000.000 new shares with a nominal
value of 1,-eur per share, having the same rights and obligations than the existing shares, by a contribution in cash;
2. Subscription by ZapHolding S.A., a Luxembourg société anonyme (joint stock company) with registered office at
79, route de Mersch, L-7432 Gosseldange (Grand-Duchy of Luxembourg) of the 2.000.000 new shares of the Company
and payment up to one fourth for an amount of 500.000,-eur by a contribution in cash;
3. Amendment of article 6 paragraph 1 of the by-laws of the Company so as to reflect the decisions taken;
4. Miscellaneous.
After discussion and deliberation of the foregoing, the General Meeting passed the following resolutions by unanimous
decisions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolved to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of 2.000.000,-
eur so as to raise it from its current amount of 4.725.000,-eur to an amount of 6.725.000,-eur by issuance of 2.000.000
new shares with a nominal value of 1,-eur per share, having the same rights and obligations than the existing shares, by a
contribution in cash.
<i>Second resolutioni>
The 2.000.000 new shares of the Company with a nominal value of 1-eur per share have been entirely subscribed and
partially paid-up up to one fourth for an amount of 500.000,-eur by ZapHolding S.A. a Luxembourg société anonyme
(joint stock company) with registered office at 79, route de Mersch, L-7432 Gosseldange (Grand-Duchy of Luxembourg)
in its capacity as sole shareholder by a contribution in cash.
Evidence of such contribution has been given to the undersigned notary by a bank certificate, so that the amount of
500.000,-eur is as of now available to the Company.
Said bank certificate will remain attached to the present deed.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the General Meeting resolved to amend article 6 paragraph 1 of the
by-laws of the Company which will now be read as follows:
“ Art. 6. Share Capital. The share capital of the Company is fixed at 6.725.000,-eur represented by 6.725.000 shares
with a nominal value of 1,-eur each and such rights and obligations as set out in the Articles.”
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting further resolved to entitle Mr Charles Duro prenamed in his capacity as member of the board
of directors of the Company to proceed individually in the name of the shareholders and on behalf of the Company with
the inscriptions or formalities necessary or deemed useful in order to inscribe in the register of the shareholders of the
Company the new representation of the share capital of the Company resulting from the above taken resolutions.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at 2,900,- Eur.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.
French version
L'an deux mille quatorze, le deux juillet.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «ZapFi International S.A.», une société anonyme dûment
constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social situé à L-7432 Gosseldange,
79, route de Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 163 788, constituée le 5 octobre 2011 par devant Maître Blanche Moutrier, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
117715
L
U X E M B O U R G
Associations, numéro 2830 du 19 novembre 2011, modifié le 12 décembre 2011 par devant le Notaire soussigné Maître
Blanche Moutrier, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 162 du 19 janvier
2012, et modifié le 25 avril 2013 par devant le Notaire soussigné Maître Blanche Moutrier, acte publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1465 du 20 juin 2013 (ci-après «la Société»).
L'Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat, demeurant professionnellement
à L-1325 Luxembourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
Le Président désigne comme secrétaire Maître Karine Mastinu, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Lu-
xembourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
L'Assemblée Générale choisit comme scrutateur Maître Lionel Bonifazzi, avocat, demeurant professionnellement à
L1325 Luxembourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
Le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions
possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les manda-
taires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises
avec lui aux formalités d'enregistrement.
II. L'intégralité du capital social de la Société étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. La présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:
<i>Agendai>
1. Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de 2.000.000,-eur pour le porter
de son montant actuel de 4.725.000,-eur au montant 6.725.000,-eur par l'émission de 2.000.000 nouvelles actions d'une
valeur nominale de 1,-eur par action ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, par un apport en
numéraire;
2. Souscription par ZapHolding S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 79, route
de Mersch, L-7432 Gosseldange (Grand-Duché de Luxembourg) des 2.000.000 nouvelles actions de la Société et libération
à concurrence d'un quart pour un montant de 500.000,-eur par un apport en numéraire;
3. Modification de l'article 6 alinéa 1 des statuts de la Société afin de refléter les décisions prises;
4. Divers.
Après avoir approuvé l'agenda et délibéré, l'Assemblée Générale a pris les décisions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale a décidé d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de
2.000.000,-eur pour le porter de son montant actuel de 4.725.000,-eur au montant 6.725.000,-eur par l'émission de
2.000.000 nouvelles actions d'une valeur nominale de 1,-eur par action, ayant les mêmes droits et obligations que les
actions existantes, par un apport en numéraire.
<i>Deuxième résolutioni>
Les 2.000.000 nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale de 1,-eur par action ont été entièrement souscrites
et partiellement libérées à concurrence d'un quart pour un montant de 500.000,-eur par ZapHolding S.A., une société
anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 79, route de Mersch, L-7432 Gosseldange (Grand-Duché de
Luxembourg) en qualité d'actionnaire unique par un apport en numéraire.
La preuve de la contribution a été donnée au notaire par un certificat de blocage des fonds, de sorte que le montant
de 500.000,-eur est à présent à la disposition de la Société.
Ledit certificat restera attaché au présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 6 alinéa 1 des statuts de la Société a été modifié et a dorénavant la teneur
suivante:
« Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est de 6.725.000,-eur représenté par 6.725.000 actions, d'une
valeur nominale de 1,-eur chacune et les droits et obligations prévus par les Statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale a décidé de donner pouvoir à Maître Charles Duro prénommé en sa qualité de membre du
conseil d'administration de la Société de procéder individuellement au nom des actionnaires et pour le compte de la
Société aux inscriptions et formalités nécessaires ou considérées comme utiles pour l'inscription dans le registre des
117716
L
U X E M B O U R G
actionnaires de la Société de la nouvelle représentation du capital social de la Société résultante des décisions ci-avant
prises.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges qui seront supportées par la Société comme résultat du présent acte sont
estimés à 2.900.- Eur.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire,
Signé: DURO, MASTINU, BONIFAZZI, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10/07/2014. Relation: EAC/2014/9558. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2014.
Référence de publication: 2014101767/156.
(140121164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Almacantar Kingsway S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 101.386.
In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of the month of June;
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED
Almacantar, a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Register of commerce and companies under number B 149.157 and having its registered
office at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg,
here represented by Maître Oliver MALLWITZ, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of Almacantar Kingsway S.à r.l., a société à responsabilité limitée incor-
porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
commerce and companies under number B 101.386 and having its registered office at 8-10, avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg (the "Company").
II. The Company was incorporated under the name “Kingsway Investment S.A.” pursuant to a deed of Me Léon Thomas
known as Tom Metzler, then notary residing in Luxembourg-Bonnevoie (Grand Duchy of Luxembourg), dated 21 June
2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 850 of 18 August 2004. The articles of
association of the Company were amended a last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 25 July 2014,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2317 of 18 September 2012.
III. The Company's share capital is currently set at thirteen million British Pounds (GBP 13,000,000.-), represented by
thirteen million shares (13,000,000) shares of one British Pound (GBP 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid-up.
IV. The agenda of the meeting is as follows:
1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of seven million nine hundred fifty thousand British
Pounds (GBP 7,950,000.-) so as to bring it from thirteen million British Pounds (GBP 13,000,000.-) to five million fifty
thousand British Pounds (GBP 5,050,000.-) by the cancellation of seven million nine hundred fifty thousand (7,950,000)
shares of the Company, each with a par value of one British Pound (GBP 1.-).
2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company to reflect the preceding agenda
item.
3. Miscellaneous.
The sole shareholder then passed the following resolutions:
117717
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of seven million nine hundred
fifty thousand British Pounds (GBP 7,950,000.-) so as to bring it from thirteen million British Pounds (GBP 13,000,000.-)
to five million fifty thousand British Pounds (GBP 5,050,000.-) by the cancellation of seven million nine hundred fifty
thousand (7,950,000) shares of the Company, each with a par value of one British Pound (GBP 1.-).
The sole shareholder further resolves to authorize the board of managers of the Company to take all steps required
to record the capital reduction in the shareholders register and in the accounts of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended
and shall henceforth read as follows:
“ Art. 6. The share capital is fixed at five million fifty thousand British Pounds (GBP 5,050,000.-), represented by five
million fifty thousand (5,050,000) shares of one British Pound (GBP 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid-up.”
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 1,550.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg);
A COMPARU
Almacantar S.A., société anonyme, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 149.157, ayant son siège social à 8-10,
avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg,
représentée par Maître Oliver MALLWITZ, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que la comparante est l’actionnaire unique de «Almacantar Kingsway S.àr.l.», une société à responsabilité limitée,
constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.386 et ayant leur siège social à 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
(la «Société»).
II. Que la Société a été constituée sous la dénomination de «Kingsway Investment S.A.» suivant un acte notarié de
Maître Léon Thomas connu sous le nom de Tom Metzler, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-
Duché de Luxembourg), en date du 21 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
850 du 18 août 2004. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentaire en date du
25 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2317 du 18 septembre 2012.
III. Que le capital de la Société est actuellement treize million de Livres Sterling (GBP 13.000.000,-), représenté par
treize million de parts sociales, chacune d’une valeur nominale de cent Livres Sterling (GBP 100,-), toutes entièrement
souscrites et libérées.
IV. Que l’ordre du jour est le suivant:
1. Réduction du capital de la Société d’un montant de sept million neuf cent cinquante mille Livres Sterling (GBP
7.950.000,-) afin de ramener le capital de treize million de Livres Sterling (GBP 13.000.000,-) à cinq million cinquante mille
Livres Sterling (GBP 5.050.000,-) et annulation afférente de sept million neuf cent cinquante mille (7.950.000) parts sociales
de la Société, chacune d'une valeur nominale d’une Livre Sterling (GBP 1,-).
2. Modification afférente de l’article 6 des statuts de la Société pour refléter le point précédent de l’ordre du jour.
3. Divers.
117718
L
U X E M B O U R G
L’actionnaire unique a ensuite pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’actionnaire unique décide de réduire le capital de la Société d’un montant de sept million neuf cent cinquante mille
Livres Sterling (GBP 7.950.000,-) afin de ramener le capital de treize million de Livres Sterling (GBP 13.000.000,-) à cinq
million cinquante mille Livres Sterling (GBP 5.050.000,-) et annulation afférente de sept million neuf cent cinquante mille
(7.950.000) parts sociales de la Société, chacune d'une valeur nominale d’une Livre Sterling (GBP 1,-).
L’actionnaire unique décide encore d’autoriser le conseil de gérance de la Société à faire toutes les démarches requises
afin de refléter la réduction de capital dans le registre aux actionnaires et dans les comptes de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Sur base de la résolution précédente, l’article 6 des statuts de la Société sera modifié pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à cinq million cinquante mille Livres Sterling (GBP 5.050.000,-) représenté par cinq
million cinquante mille (5.050.000) parts sociales d'une valeur nominale d’une Livre Sterling (GBP 1,-), chacune entière-
ment souscrite et entièrement libérée.»
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme d’EUR 1.550,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais et le français, déclare, à la demande de la comparante, que
le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante, et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, agissant comme indiqué ci-avant, connu du notaire par ses noms,
prénoms usuels, états et demeures, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Oliver MALLWITZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 juin 2014. Relation GRE/2014/2549. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014099595/117.
(140118957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.
Textile Aaronsons S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-222 Luxembourg, 2, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 183.131.
EXTRAIT
Il résulte d'un acte de constitution pour la société UNITED TEXTILE S.à r.l., avec siège sociale à L -2227 Luxembourg,
2 avenue de la Porte Neuve, RCS Luxembourg B183196 reçu en date du 18 décembre 2013 par Maître Paul Bettingen,
notaire de résidence à Niederanven, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 décembre 2013, relation: LAC/
2013/58706 que les vingt deux millions quatre cent soixante mil quatre cent quarante-quatre (22460444) parts sociales
de la société TEXTILE AARONSONS S.à r.l., avec siège sociale à L-2227 Luxembourg, 2, avenue de la Porte Neuve, RCS
Luxembourg B183131, sont désormais détenues comme suit:
1. BEN SOUSSAN Serge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale
2. BENSOUSSAN Jean-Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale
3. BEN SOUSSAN Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale
4. UNITED TEXTILE SARL,
avec siège sociale à
L-2227 Luxembourg,
2 avenue de la Porte Neuve,
RCS Luxembourg B183196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22460441 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 26 juin 2014.
Référence de publication: 2014102635/24.
(140122566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.
117719
L
U X E M B O U R G
Edmund Propco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 176.021.
In the year two thousand and fourteen, on the fourth day of July,
before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Edmund Propco S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), organised and existing under the laws of Luxembourg, having its re-
gistered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 176.021 (the Company).
The Company was incorporated on March 11, 2013 pursuant to a deed enacted by the undersigned notary, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1164, page 55841, dated May 16, 2013. The articles of
association of the Company (the Articles) have not been amended since the incorporation of the Company.
THERE APPEARED:
Plymouth Sound (UK) Holdings LP, a limited partnership existing under the laws of the United Kingdom, with registered
office at Swatton Barn, Badbury, Swindon, Wiltshire, SN4 0EU, United Kingdom, registered with the Registrar of Com-
panies for England and Wales under number LP15450 (the Sole Shareholder);
hereby represented by Mr Max MAYER, employee, professionally residing in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that:
I. The twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company, with a nominal value of one pound sterling (GBP
1) each, representing the entire share capital of the Company of an amount of twelve thousand five hundred pound sterling
(GBP 12,500) are duly represented at the present Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items on the agenda hereinafter reproduced.
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of convening notice;
2. amendment to the corporate object of the Company and subsequent amendment to article 3 of the Articles which
will henceforth read as follows:
“ Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. The Company may invest in real estate
whatever the acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of security.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.”
3. miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
117720
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices requi-
rement, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend the corporate object of the Company and to subsequently amend article 3 of the
Articles which will henceforth read as follows:
“ Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. The Company may invest in real estate
whatever the acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of security.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.”
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 900.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, such proxyholder signed together with
the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois de juillet,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Edmund Propco S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, organisée et existante selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176.021 (la Société).
La Société a été constituée le 11 mars 2013 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, sous le numéro 1164, page 55841, en date du 16 mai 2013. Les statuts de la Société (les
Statuts) n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
A COMPARU:
Plymouth Sound (UK) Holdings LP, une limited partnership organisée et existante selon les lois du Royaume-Uni, ayant
son siège social au Swatton Barn, Badbury, Swindon, Wiltshire, SN4 0EU, Royaume-Uni et immatriculée auprès du Re-
gistrar of Companies for England and Wales sous le numéro LP15450 (l'Associé Unique);
117721
L
U X E M B O U R G
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, avec adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
L’Associé Unique a prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d’une livre sterling (GBP
1) chacune, qui représentent la totalité du capital social de la Société d’un montant de douze mille cinq cents livres sterling
(GBP 12.500) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et
peut délibérer sur les points qui sont à l'ordre du jour reproduits ci-après.
II. L’ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. modification de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article 3 des Statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
« Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit. La Société peut également investir dans l'immobilier quelles qu'en soient les modalités d'acquisition, notamment
mais sans que ce soit limitatif, l'acquisition par la vente ou l'exercice de sûretés.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs
d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.
3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-
actions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se
rapportent à la réalisation de son objet social.»
3. divers.
Sur ce, la partie comparante, représentée par son mandataire, a prié le notaire instrumentant d’acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'As-
socié Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l'objet social de la Société et, subséquemment, l'article 3 des Statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
« Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations.
La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres,
actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en
général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la
création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans
l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou
117722
L
U X E M B O U R G
origine que ce soit. La Société peut également investir dans l'immobilier quelles qu'en soient les modalités d'acquisition,
notamment mais sans que ce soit limitatif, l'acquisition par la vente ou l'exercice de sûretés.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs
d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.
3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-
actions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se
rapportent à la réalisation de son objet social.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est estimé à environ 900,- EUR.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par le présent acte qu'à la requête de la partie
comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version
anglaise et française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, rédigé et passé à Junglinster, à la date indiquée en tête du présent acte.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec le notaire le présent acte
original.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 09 juillet 2014. Relation GRE/2014/2778. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014099877/196.
(140119141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.
Talys Financière S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 143.547.
EXTRAIT
Il résulte de la décision du conseil d'administration tenu en date du 23 mai 2014 que le siège de la société est transféré
du 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg à compter du 1
er
juin
2014.
Les administrateurs mentionnés ci-dessous résident professionnellement au 50, rue Charles Martel 1
er
étage L-2134
Luxembourg:
- Claude ZIMMER
- Hendrik H.J. KEMMERLING
- Rob SONNENSCHEIN
L'administrateur Luxglobal Management S.à r.l., réside professionnellement au 50, Rue Charles Martel L-2134 Luxem-
bourg.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014099480/21.
(140118074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.
117723
L
U X E M B O U R G
Digital Services XXIV (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.496.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of June.
Before us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Digital Services XXIV S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,
the registration of which with the Luxembourg Trade and Companies' Register is pending,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, residing in Luxembourg,, by virtue of a
proxy, given in Berlin, Germany, on 18. June 2014, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 18. June 2014.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Digital Services XXIV (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any
Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
117724
L
U X E M B O U R G
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
117725
L
U X E M B O U R G
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
117726
L
U X E M B O U R G
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
117727
L
U X E M B O U R G
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2014.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XXIV S.à r.l., afo-
rementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand Euros (EUR
1,000.-).
<i>Resolution of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035
Strassen, Luxembourg.
117728
L
U X E M B O U R G
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausendvierzehn, am achtzehnten Juni.
Vor uns, Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Digital Services XXIV S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groß-
herzogtum Luxemburg, deren Eintragung im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister noch aussteht,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer
Vollmacht ausgestellt in Berlin, Deutschland, am 18. Juni 2014 und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 18.
Juni 2014.
Besagte Vollmacht, welche vom Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne vari-
etur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Digital Services XXIV (GP) S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen
und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vorneh-
men, sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen, und die
ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
117729
L
U X E M B O U R G
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) bestehend aus
zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehepartner/in oder
jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und
übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die
„Gesellschafterversammlung“in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusam-
menhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Allein-
gesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich
innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
117730
L
U X E M B O U R G
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welche in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-
sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger
Geschäftsführer“nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.
117731
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, EMail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den) oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift
mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren
Vertreter) oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen
eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
117732
L
U X E M B O U R G
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen
oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflö-
sung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2014.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
117733
L
U X E M B O U R G
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden von Digital Services XXIV S.à r.l., vorbenannt,
zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf eintausend Euro (EUR 1.000) geschätzt.
<i>Beschlüsse des alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstraße
20, D-10117 Berlin.
Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welcher dem Notar mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.
Signé: L. AGUERRE ENRÍQUEZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juin 2014. LAC/2014/28986. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 11 juillet 2014.
Référence de publication: 2014099845/577.
(140120107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.
Cambodia-Laos Development Fund S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 149.077.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle de la Société du 3 juin 2014:i>
- La société KPMG Luxembourg, ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé en tant
que réviseur d'entreprise agréé de la Société;
- Le mandat de KPMG prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2015, statuant
sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014.
Luxembourg, le 4 juin 2013.
Référence de publication: 2014100842/14.
(140120699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
117734
L
U X E M B O U R G
Gripinvest, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 188.430.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the second of July.
Before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
GRIPFIN, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxem-
bourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, having its registered office at 37C, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
here represented by Me Astrid Wagner, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on July 2, 2014.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which he wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
“GRIPINVEST” (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
117735
L
U X E M B O U R G
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by
the surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
117736
L
U X E M B O U R G
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers composed of at least one (1) class A manager and one (1) class B manager. Any reference made
hereinafter to the “manager(s)” shall be construed as a reference to any and each of the class A manager(s) and the class
B manager(s), depending of the context and as applicable.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office. The general meeting of shareholders may decide to appoint one or several class A managers
and one or several class B managers.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager irrespective of the
class to which he/she belongs, as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means
of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but
not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to partici-
pation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, including one (1)
class A manager and one (1) class B manager are present or represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, including at
least one (1) class A manager and one (1) class B manager. The chairman, if any, shall not have a casting vote.
117737
L
U X E M B O U R G
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by one (1) class A manager and one (1) class B manager. Copies
or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by one (1) class A manager and one (1) class B manager.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of one (1) class A manager
and one (1) class B manager, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory
power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first (1
st
) of January of each year and
shall end on the thirty-first (31
st
) of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
117738
L
U X E M B O U R G
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2014.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by GRIPFIN, aforementioned, repre-
sented as above, for the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred
euro (EUR 1,300.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, have passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 37C, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) Mr Manuel Roumain, born in Haute-Ajoie, Switzerland, on 21 August 1965, professionally residing at 9, Chemin de
Monthoux, 1291 Commugny, Switzerland, as class A manager of the Company;
(ii) Ms Véronique Marty, born in Nancy (France) on 30 March 1977, having her professional address at 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, as class B manager of the Company; and
(iii) Ms Laetitia Antoine, born in Woippy (France) on 30 March 1973, having her professional address at 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, as class B manager of the Company.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same proxyholder
and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède.
L'an deux mille quatorze, le deux juillet.
Par devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
117739
L
U X E M B O U R G
GRIPFIN, une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
pas encore immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, ayant son siège social à 37C, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
dûment représentée par Me Astrid Wagner, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à le 2 juillet 2014.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée
qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «GRIPINVEST» (ci-après
la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi
que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière
des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non
garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-
nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
117740
L
U X E M B O U R G
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé
pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent
être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs
à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle
cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé
sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des
survivants. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux
ascendants, descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l'associé décédé.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par
les présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de
décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter
expressément formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant
et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une
assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convo-
cations [aux assemblées générales] correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée
générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou
publication préalable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social.
Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consente-
ment unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un
conseil de gérance composé au moins d'un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B. Toute référence
faite ci-après au(x) «gérant(s)» doit être lue comme une référence à chacun de et tout gérant de catégorie A et gérant
de catégorie B, en fonction du contexte et le cas échéant.
117741
L
U X E M B O U R G
13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue
comme une référence au «gérant unique».
13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre
toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération
et la durée de son (leur) mandat. Une assemblée générale des associés peut décider de nommer un ou plusieurs gérants
de catégorie A et un ou plusieurs gérants de catégorie B.
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif,
par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Vacance d'un poste de gérant.
15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la
démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne
pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des
associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.
15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est
comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.
Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues
au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24)
heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs
d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit
de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel
document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un
conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de
gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.
16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et
approuvées par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance.
17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son
absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote
à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.
17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant,
quelque soit sa catégorie, comme son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen
de communication, une copie du mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs,
mais non l'intégralité des membres du conseil de gérance.
17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par
tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement
sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être
tenue au siège social de la Société.
17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres, y inclus
un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B, sont présents ou représentés à une réunion du conseil de
gérance.
17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil
de gérance avec la voix d'au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B. Le président du conseil
de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.
17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer
117742
L
U X E M B O U R G
son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces dé-
cisions sera la date de la dernière signature.
Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant,
ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par un (1) gérant de catégorie A et
un (1) gérant de catégorie B. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre
seront, le cas échéant, signés par le président ou par un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B.
18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront
signés par le gérant unique.
Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par
la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe d'un (1) gérant de catégorie
A et d'un (1) gérant de catégorie B, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à
laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délé-
gation.
E. Audit et surveillance
Art. 20. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société
seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et dé-
termine la durée de leurs fonctions.
20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des
associés.
20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier (1
er
) janvier de chaque année et se
termine le trente et un (31) décembre de la même année.
Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de
l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.
22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des
bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans
la Société.
Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés
conformément à la Loi et aux présents statuts.
117743
L
U X E M B O U R G
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui
fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du
nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites par GRIPFIN, susmentionnée, représentée
comme indiqué ci-dessus.
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que
le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a
été justifié au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est entièrement affecté au capital social.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
<i>Résolutions des associési>
Les associés fondateurs, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de
convocation, ont adopté les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 37C, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérant pour une durée illimitée:
(i) Monsieur Manuel Roumain, né à Haute-Ajoie le 21 août 1965, résidant professionnellement à 9, Chemin de Mon-
thoux, 1291 Commugny, Suisse, en tant que gérant de catégorie A;
(ii) Madame Véronique Marty, née à Nancy (France) le 30 mars 1977, résidant professionnellement à 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B; et
(iii) Madame Laetitia Antoine, née à Woippy (France) le 30 mars 1973, résidant professionnellement à 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B;
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du mandataire de la comparante que le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du même mandataire et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,
ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Wagner, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 4 juillet 2014. REM/2014/1454. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 10 juillet 2014.
Référence de publication: 2014099174/528.
(140118466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
117744
Almacantar Kingsway S. à r.l.
Cambodia-Laos Development Fund S.C.A., SICAV-SIF
CORPUS SIREO Investment Residential No. 21 S.à r.l.
Digital Services XXIV (GP) S.à r.l.
Dix-huit S.à r.l.
Dix-huit S.à r.l.
EcoSol - Sanem
Edmund Propco S.à r.l.
Educastream Europe S.à r.l.
Euromax IV MBS S.A.
Euro-Trading S.à r.l.
Gripinvest
Merou S.C.I.
MFS Meridian Funds
Miele s.à r.l.
Monumenta Invest I
Mothership S.à r.l.
Motola S.à r.l.
Motola S.à r.l.
Mouwannes S.à r.l.
Moxfleisch Finanz Beteiligungs Gesellschaft AG
NameDrive EU s.à r.l.
Nectar Holding S.A.
Nectar Holding S.A.
Nectar Holding S.A., SPF
Nectar Holding S.A., SPF
Nexus Holdings S.à r.l.
NinaLi S.à.r.l.
Njord Wind S.à r.l.
NM Coiffure S.A.
NM Coiffure S.A.
Nordica Group S.A.
Noura S.A.
NREP Transactions Holding 6 S.à r.l.
N.V. Getronics Belgium S.A.
N.V. Getronics Belgium S.A.
OCM KSH Devco Holdings S.à r.l.
OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings S.à r.l.
OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings S.à r.l.
OCM Luxembourg Mezz II S.à r.l.
Octavian S.à.r.l.
Open Mind Investments S.C.A. SICAR
Openvise Immo S.A.
OW Investments S.à r.l.
Paragem Assets S.à r.l.
Parsnip S.à r.l.
Patrilar Sàrl
Pecana S.A.
Petrolog Investments S.A.
P&Pm S.A.
PrivAccess
Softgreen
Spittelmarkt S.à r.l.
Spunken S.A.
SurveyMonkey Europe Sarl
Talgo MGT S.A.
Talys Financière S.A.
Tasal 3 S.A.
Textile Aaronsons S.à r.l.
That's It A.G.
Twister Investment
ZapFi International S.A.