This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1976
29 juillet 2014
SOMMAIRE
Algebris Npl Partnership Gp, S.à r.l. . . . . .
94831
Fairfield 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94811
Generas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94848
Global Terminal Limited S.à r.l. . . . . . . . . .
94802
Green Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94803
Hanscan Technology S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
94803
Iberian Minerals Financing S.A. . . . . . . . . . .
94802
Ikano S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94804
Il Limoncello S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94804
Immo Penfret S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94805
INI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94805
International Diamonds & Gems S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94805
International Medical Technology Holding
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94806
International Property Management . . . . .
94806
Interocean Shipping and Investments Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94806
Invenergy Wind Europe II S.à r.l. . . . . . . . .
94802
Invenergy Wind Europe II S.à r.l. . . . . . . . .
94804
Invista European RE Roth PropCo S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94803
Invista European RE Solingen PropCo S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94804
IP Crossroads S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94805
IP Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94807
IPN Unternehmensberatung S.A. . . . . . . . .
94805
Ipsen Ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94804
Irrus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94808
Iumi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94806
IVAX International GmbH Lux SCS . . . . .
94807
Ivefi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94807
Jabcab (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94808
Jaggard S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94806
J.A.P. Rent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94809
J.M.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94809
JPP Polymere S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94803
Juno Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94808
KC Esther S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94810
Kensington Square S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
94810
Kingswood S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94807
Kotak Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94809
Krisian S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94807
La Française AM Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94808
Lamp International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
94810
Langley CoInvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
94810
Larochette RCG Re SCA . . . . . . . . . . . . . . .
94810
Liane Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
94808
LuxOr Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94809
Lux Pillar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94802
Universal Air Charter . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94811
Xylem IP Management S.à r.l. . . . . . . . . . . .
94837
94801
L
U X E M B O U R G
Global Terminal Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 30.000,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 174.231.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014073776/10.
(140086767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Invenergy Wind Europe II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 111.311.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg en date du 10 juillet 2013 sous la référence L130115611.
Ce dépôt est à remplacer par dépôt suivant:
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Invenergy Wind Europe II S.à r.l.
Mandatairei>
Référence de publication: 2014073829/15.
(140086420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Iberian Minerals Financing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 160.222.
EXTRAIT
Suite à un déménagement,
- Monsieur Mark Irwin, administrateur de catégorie A de la société susmentionnée, né le 28 octobre 1964 à Castle-
dawson (United Kingdom), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 3 Western Esplanade, Brighton,
BN41 1WE, United Kingdom.
- Monsieur Pierre Lorinet, administrateur de catégorie A de la société susmentionnée, né le 08 février 1972 à Chambery
(France), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 10 Collyer Quay #28-00, Ocean Financial Centre,
Singapore 049315.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2014073823/19.
(140087294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Lux Pillar, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 181.640.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073908/9.
(140086472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94802
L
U X E M B O U R G
Green Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1272 Luxembourg, 23, rue de Bourgogne.
R.C.S. Luxembourg B 50.579.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073805/9.
(140086675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Hanscan Technology S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 131.267.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 Avril 2014i>
L'Assemblée Générale accepte, avec effet immédiat, la démission d'un administrateur, à savoir:
- Monsieur Marc THEISEN, administrateur, né le 05 Novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié profes-
sionnellement au 291 route d'Arlon L-1150 Luxembourg
L'Assemblée Générale accepte, avec effet immédiat, de nommer un gérant, à savoir:
- Monsieur Hendrik H. J. (Rob) KEMMERLING, gérant, né le 22 Mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié profes-
sionnellement au 42- 44 avenue de la gare L-1610 Luxembourg
Pour une durée indéterminée
- Monsieur Claude ZIMMER, gérant, est domicilié professionnellement au 42-44 avenue de la gare L-1610 Luxembourg
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014073807/18.
(140087276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Invista European RE Roth PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9.330.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 119.646.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014073838/10.
(140086926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
JPP Polymere S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9437 Steinfort, 66, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 169.813.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société du 6 janvier 2014i>
Il résulte des dites résolutions:
1. Acceptation de la démission du mandat d'administrateur de Madame Françoise Gravé.
2. L'actionnaire unique de la Société a décidé de nommer, avec effet au 1
er
janvier 2014 et jusqu'à l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2018, Monsieur Alain Donvil, demeurant professionnellement au 39, route d'Arlon, L-8410
Steinfort, en tant que nouvel Administrateur de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014073879/17.
(140086527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94803
L
U X E M B O U R G
Invenergy Wind Europe II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 111.311.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg en date du 10 mai 2012 sous la référence L120075952.
Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Invenergy Wind Europe II S.à r.l.
Mandatairei>
Référence de publication: 2014073830/15.
(140086421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Invista European RE Solingen PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 112.741.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014073839/10.
(140086928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Ikano S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R.C.S. Luxembourg B 87.842.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073847/9.
(140087344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Il Limoncello S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3222 Bettembourg, 7, route de Dudelange.
R.C.S. Luxembourg B 90.455.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073848/9.
(140086511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Ipsen Ré, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 113.939.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société IPSEN RE
i>AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2014073864/11.
(140086721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94804
L
U X E M B O U R G
Immo Penfret S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 92.956.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2013.
GERARD Rachel.
Référence de publication: 2014073851/10.
(140086615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
INI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 147.884.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68594 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073852/10.
(140087018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
International Diamonds & Gems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 4, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 51.625.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073853/9.
(140086992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
IP Crossroads S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 175.934.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 octobre 2013i>
<i>Résolutionsi>
L'Assemblée Générale décide de nommer Mr Hans Seeuws - né le 13 avril 1978 à Antwerpen (B) demeurant à B 2530
Boechout, Vremdesesteenweg 44, en tant qu'administrateur.
L'Assemblée Générale décide de nommer Mr Jan Jansen, né le 18 mai 1968 à Mol (B), demeurant à B-3000, Leuven,
De Vier Vaantjes, 37, en tant qu'administrateur.
Les mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes annuels de l'exercice
2018.
Référence de publication: 2014073860/15.
(140087125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
IPN Unternehmensberatung S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5440 Remerschen, 34, Waïstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 105.033.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remerschen, den. 26.05.2014.
Référence de publication: 2014073862/10.
(140087242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94805
L
U X E M B O U R G
International Medical Technology Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 179.254.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014073854/10.
(140086952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
International Property Management, Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 174.566.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073855/9.
(140086586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Interocean Shipping and Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 62.245.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073856/9.
(140086792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Iumi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1409 Luxembourg, 22, rue Edmond Dune.
R.C.S. Luxembourg B 142.266.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2014073868/11.
(140086335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Jaggard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 45.557.
EXTRAIT
Il résulte d'une cession d'actions effectuée en date du 27 mars 2013 que:
- Monsieur Joaquin PUIG ALEMANY a cédé 8.922 parts sociales qu'il détenait dans la société JAGGARD S.A.R.L. à
Monsieur Jorge PUIG HERRERA demeurant 38B C/Ballester, 08023 Barcelone, Espagne.
Suite à ce transfert les parts sociales de la société JAGGARD S.A.R.L. sont désormais détenues comme suit:
Joaquin PUIG ALEMANY: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.317.019 parts sociales
Jorge PUIG HERRERA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.922 parts sociales
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2014073878/15.
(140087236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94806
L
U X E M B O U R G
IP Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 6.419.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073861/9.
(140087215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
IVAX International GmbH Lux SCS, Société en Commandite simple.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 152.057.
<i>Rectificatif au dépôt n° L 140012345 effectué en date du 21 janvier 2014i>
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073869/11.
(140087063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Ivefi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 111.894.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2014.
Référence de publication: 2014073870/10.
(140086788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Kingswood S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R.C.S. Luxembourg B 123.026.
Par résolution signée en date du 12 mai 2014, l'associé unique a pris la décision suivante:
- Nomination de Gaëlle Violette, avec adresse professionnelle au 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, au
mandat de Gérant B, avec effet au 1
er
juillet 2014 et pour une durée indéterminée
- Acceptation de la démission de Sharon Taylor, avec adresse professionnelle au 7a, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, de son mandat de Gérant B, avec effet au 30 juin 2014
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014073884/15.
(140087238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Krisian S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 79.848.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073885/9.
(140087113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94807
L
U X E M B O U R G
Jabcab (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 155.045.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073877/9.
(140087366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Juno Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint Esprit.
R.C.S. Luxembourg B 133.592.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012, ainsi que les documents et informations qui s’y rapportent, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014073876/11.
(140086947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Liane Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 151.553.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société du 19 mai 2014i>
Le 19 mai 2014, l'associé unique de Liane Properties S. à r.l. a pris les résolutions suivantes:
- D'accepter la démission de Mme Christelle Ferry en qualité de Gérant de la Société avec effet au 12 mai 2014;
- De nommer Mme Séverine Canova, ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société avec effet au 12 mai 2014 et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Xavier De Cillia
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014073904/15.
(140087347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Irrus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R.C.S. Luxembourg B 117.113.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073866/9.
(140087195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
La Française AM Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 66.785.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 22 mai 2014.
Référence de publication: 2014073912/10.
(140086564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94808
L
U X E M B O U R G
J.M.C., Société Civile.
Siège social: L-4991 Sanem, 198, rue de Niederkorn.
R.C.S. Luxembourg E 1.835.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue en date du 22 mai 2014
que:
- le mandat de gérant de Monsieur Joao MONTEIRO DO CARMO a été révoqué avec effet immédiat,
- qu'a été nommé en son remplacement, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Monsieur Manuel
MONTEIRO DO CARMO ACURCIO, retraité, demeurant à L-5222 SANDWEILER, 18, An der Kettenbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
<i>Pour la Société
i>Me David YURTMAN
<i>Avocat à la Couri>
Référence de publication: 2014073874/18.
(140087320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
J.A.P. Rent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 33, rue d'Audun-le-Tiche.
R.C.S. Luxembourg B 118.520.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073873/9.
(140087172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
LuxOr Services, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.750,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 155.893.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.
L'adresse de Monsieur Ronald W. DE KONING, gérant de la Société, a changé avec effet au 3 janvier 2014 et se trouve
désormais au:
- 59, Korteraarseweg, 2461 GH Ter Aar, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2014.
LuxOr Services
Signature
Référence de publication: 2014073911/17.
(140086938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Kotak Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 131.576.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014073893/10.
(140086870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94809
L
U X E M B O U R G
Langley CoInvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 178.374.
Ce document rectifie celui annexé au dépôt L140035469 du 26 février 2014.
Les statuts coordonnés au 24 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014073896/12.
(140086832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Kensington Square S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 147.944.
M. Denis Van den Bulke, domiciliataire de la société Kensington Square S.à.r.l., immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B147944 (la «Société») dénonce avec effet au 8 mai 2014 le siège de la Société 35, avenue
Monterey L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
M. Denis Van den Bulke.
Référence de publication: 2014073883/11.
(140086617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
KC Esther S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 174.450.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014073892/10.
(140087101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Lamp International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 137.565.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014073895/10.
(140087193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Larochette RCG Re SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.
R.C.S. Luxembourg B 28.687.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société LAROCHETTE RCG RE S.C.A.
i>Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2014073898/11.
(140087286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94810
L
U X E M B O U R G
Universal Air Charter, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 34.700,00.
Siège social: L-8156 Bridel, 31, rue Lucien Wercollier.
R.C.S. Luxembourg B 16.694.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2014074274/11.
(140087057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Fairfield 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 185.390.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of April.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Fairfield L.P., a limited partnership registered under the laws of Guernsey with registration number 2042, having its
registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QL (“Fairfield L.P.”),
here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of Fairfield 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 185390, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, on 5 March 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(hereafter the "Company"). The articles of association of the Company have not been amended since.
The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to enact that the agenda
of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Decrease of the nominal value of the existing shares to five cents (EUR 0.05) and creation of nine (9) different classes
of shares to be named A1 shares, A2 shares, A3 shares, A4 shares, B1 shares, B2 shares, B3 shares, B4 shares and C
shares and conversion of the existing two hundred fifty thousand (250,000) shares with a nominal value of five cents (EUR
0.05) each, into (i) sixty-two thousand five hundred (62,500) Class A1 shares, (ii) sixty-two thousand five hundred (62,500)
Class A2 shares, (iii) sixty-two thousand five hundred (62,500) Class A3 shares, (iv) sixty-two thousand five hundred
(62,500) Class A4 shares, all having a nominal value of five cents (EUR 0.05) each;
2. Acceptance of Mr. Barend Franciscus Johannes van den Hoek, Mr. Andrew Michael Copson, S&L Casey Superan-
nuation Fund and Fairfield 2014 Employee Benefit Trust as new shareholders of the Company;
3. Increase of the share capital by an amount of sixty-five thousand five hundred thirty-two euro (EUR 65,532) up to
seventy-eight thousand thirty-two euro (EUR 78,032) through the issuance of (i) two hundred seventy-seven thousand
three hundred forty-three (277,343) Class A1 shares, (ii) two hundred seventy-seven thousand three hundred forty-three
(277,343) Class A2 shares, (iii) two hundred seventy-seven thousand three hundred forty-three (277,343) Class A3 shares,
(iv) two hundred seventy-seven thousand three hundred forty-three (277,343) Class A4 shares, (v) twenty-five thousand
sixty-seven (25,067) Class B1 shares, (vi) twenty-five thousand sixty-seven (25,067) Class B2 shares, (vii) twenty-five
thousand sixty-seven (25,067) Class B3 shares, (viii) twenty-five thousand sixty-seven (25,067) Class B4 shares and (ix)
one hundred one thousand (101,000) Class C shares, all having a nominal value of five cents (EUR 0.05) each;
4. Reduction of the share capital of the Company by an amount of twelve thousand euro (EUR 12,500) in order to
reduce it from its present amount of seventy-eight thousand thirty-two euro (EUR 78,032) to sixty-five thousand five
hundred thirty-two euro (EUR 65,532) by cancellation of (i) sixty-two thousand five hundred (62,500) Class A1 shares,
(ii) sixty-two thousand five hundred (62,500) Class A2 shares, (iii) sixty-two thousand five hundred (62,500) Class A3
shares, (iv) sixty-two thousand five hundred (62,500) Class A4 shares, all having a nominal value of five cents (EUR 0.05)
each all held by Fairfield L.P..
94811
L
U X E M B O U R G
5. Decision to fully restate the articles of association of the Company;
6. Miscellaneous.
Such appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Fairfield L.P. resolves:
(i) to decrease the nominal value of the existing shares from one euro (EUR 1) to five cents (EUR 0.05) so that the
share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) shall henceforth be represented by two hundred fifty
thousand (250,000) shares with a nominal value of five cents (EUR 0.05) each. All of the two hundred fifty thousand
(250,000) shares are held by Fairfield L.P.;
(ii) to create the following new classes of shares to be denominated as follows: A1 shares, A2 shares, A3 shares, A4
shares, B1 shares, B2 shares, B3 shares, B4 shares, C shares, having a nominal value of five cents (EUR 0.05) each;
(iii) to convert the existing two hundred fifty thousand (250,000) shares with a nominal value of five cents (EUR 0.05)
each, into (i) sixty-two thousand five hundred (62,500) Class A1 shares, (ii) sixty-two thousand five hundred (62,500)
Class A2 shares, (iii) sixty-two thousand five hundred (62,500) Class A3 shares, (iv) sixty-two thousand five hundred
(62,500) Class A4 shares, all having a nominal value of five cents (EUR 0.05) each.
<i>Second resolutioni>
Fairfield L.P. accepts (i) Mr. Barend Franciscus Johannes van den Hoek, born on 27 December 1957 in Zierikzee (the
Netherlands), residing at 4 Boyd Close, Mooroolbark, Victoria, 3138, Australia, (ii) Mr. Andrew Michael Copson, born
21 October 1963 in Aldershot (United Kingdom), residing at 6 Westport Manor, Gastons Road, Malmesbury, SN16 0FE,
United Kingdom, (iii) S&L Casey Superannuation Fund, a company existing under the laws of Australia, registered with
Australia Business Register, having its registered office at 2/322 Cotham Road, Kew Victoria 3101, Australia and (iv)
Fairfield 2014 Employee Benefit Trust, a trust incorporated under the laws of Jersey and constituted by a trust instrument
dated 23 April 2014 between Appleby Trust (Jersey) Limited incorporated and registered in Jersey with company number
21755 whose registered office is at 13-14 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1BD (as trustee) and Fairfield Bidco Limited
(as settlor) as new shareholders of the Company.
<i>Third resolutioni>
Fairfield L.P. resolves to increase the Company's share capital by an amount of sixty-five thousand five hundred thirty-
two euro (EUR 65,532) up to seventy-eight thousand thirty-two euro (EUR 78,032) through the issuance of (i) two
hundred seventy-seven thousand three hundred forty-three (277,343) Class A1 shares, (ii) two hundred seventy-seven
thousand three hundred forty-three (277,343) Class A2 shares, (iii) two hundred seventy-seven thousand three hundred
forty-three (277,343) Class A3 shares, (iv) two hundred seventy-seven thousand three hundred forty-three (277,343)
Class A4 shares, (v) twenty-five thousand sixty-seven (25,067) Class B1 shares, (vi) twenty-five thousand sixty-seven
(25,067) Class B2 shares, (vii) twenty-five thousand sixty-seven (25,067) Class B3 shares, (viii) twenty-five thousand sixty-
seven (25,067) Class B4 shares and (ix) one hundred one thousand (101,000) Class C shares, all having a nominal value
of five cents (EUR 0.05) each.
(i) two hundred seventy-six thousand eight hundred eighty (276,880) Class A1 shares, (ii) two hundred seventy-six
thousand eight hundred eighty (276,880) Class A2 shares, (iii) two hundred seventy-six thousand eight hundred eighty
(276,880) Class A3 shares, (iv) two hundred seventy-six thousand eight hundred eighty (276,880) Class A4 shares have
been entirely subscribed by Fairfield L.P. for a price of one million one hundred seven thousand five hundred twenty euro
(EUR 1,107,520), here represented by Ikrame Dabaj, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy and have been fully
paid up by a contribution in cash.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of one million one hundred seven thousand five hundred twenty euro (EUR 1,107,520) consists
of fifty-five thousand three hundred seventy-six euro (EUR 55,376) for the share capital and one million fifty-two thousand
one hundred forty-four euro (EUR 1,052,144) for the share premium.
(i) one hundred seventy-one (171) Class A1 shares, (ii) one hundred seventy-one (171) Class A2 shares, (iii) one
hundred seventy-one (171) Class A3 shares, (iv) one hundred seventy-one (171) Class A4 shares, (v) eight hundred thirty-
nine (839) Class B1 shares, (vi) eight hundred thirty-nine (839) Class B2 shares, (vii) eight hundred thirty-nine (839) Class
B3 shares and (viii) eight hundred thirty-nine (839) Class B4 shares have been entirely subscribed by Mr. Barend Franciscus
Johannes van den Hoek for a price of four thousand forty euro (EUR 4,040), here represented by Ikrame Dabaj, residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy, and have been fully paid up by a contribution in cash.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of four thousand forty euro (EUR 4,040) consists of two hundred two euro (EUR 202) for the
share capital and three thousand eight hundred thirty-eight euro (EUR 3,838) for the share premium.
(i) one hundred thirty-two (132) Class A1 shares, (ii) one hundred thirty-two (132) Class A2 shares, (iii) one hundred
thirty-two (132) Class A3 shares, (iv) one hundred thirty-two (132) Class A4 shares, (v) one thousand three hundred
eighteen (1,318) Class B1 shares, (vi) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B2 shares, (vii) one thousand
94812
L
U X E M B O U R G
three hundred eighteen (1,318) Class B3 shares and (viii) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B4 shares
have been entirely subscribed by Mr. Andrew Michael Copson for a price of five thousand eight hundred euro (EUR
5,800), here represented by Ikrame Dabaj, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, and have been fully paid up by
a contribution in cash.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of five thousand eight hundred euro (EUR 5,800) consists of two hundred ninety euro (EUR
290) for the share capital and five thousand five hundred ten euro (EUR 5,510) for the share premium.
(i) one hundred sixty (160) Class A1 shares, (ii) one hundred sixty (160) Class A2 shares, (iii) one hundred sixty (160)
Class A3 shares, (iv) one hundred sixty (160) Class A4 shares, (v) seven hundred nineteen (719) Class B1 shares, (vi)
seven hundred nineteen (719) Class B2 shares, (vii) seven hundred nineteen (719) Class B3 shares and (viii) seven hundred
nineteen (719) Class B4 shares have been entirely subscribed by S&L Casey Superannuation Fund for a price of three
thousand five hundred sixteen euro (EUR 3,516), here represented by Ikrame Dabaj, residing in Luxembourg, by virtue
of a proxy, and have been fully paid up by a contribution in cash.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of three thousand five hundred sixteen euro (EUR 3,516) consists of one hundred seventy-five
euro and eighty cents (EUR 175.80) for the share capital and three thousand three hundred forty euro and twenty cents
(EUR 3,340.20) for the share premium.
(i) twenty-two thousand one hundred ninety-one (22,191) Class B1 shares, (ii) twenty-two thousand one hundred
ninety-one (22,191) Class B2 shares, (iii) twenty-two thousand one hundred ninety-one (22,191) Class B3 shares, (iv)
twenty-two thousand one hundred ninety-one (22,191) Class B4 shares and (v) one hundred one thousand (101,000)
Class C shares have been entirely subscribed by Fairfield 2014 Employee Benefit Trust for a price of ninety-three thousand
eight hundred fourteen euro (EUR 93,814), here represented by Ikrame Dabaj, residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, and have been fully paid up by a contribution in cash.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of ninety-three thousand eight hundred fourteen euro (EUR 93,814) consists of nine thousand
four hundred eighty-eight euro and twenty cents (EUR 9,488.20) for the share capital and eighty-four thousand three
hundred twenty-five euro and eighty cents (EUR 84,325.80) for the share premium.
Mr. Barend Franciscus Johannes van den Hoek, aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,;
Mr. Andrew Michael Copson, aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy;
S&L Casey Superannuation Fund; here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue
of a proxy; and
Fairfield 2014 Employee Benefit Trust, aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy.
join the general meeting of shareholders of the Company and resolve together with Fairfield L.P. on the subsequent
items of the agenda.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of twelve
thousand euro (EUR 12,500) in order to reduce it from its present amount of seventy-eight thousand thirty-two euro
(EUR 78,032) to sixty-five thousand five hundred thirty-two euro (EUR 65,532) by cancellation of (i) sixty-two thousand
five hundred (62,500) Class A1 shares, (ii) sixty-two thousand five hundred (62,500) Class A2 shares, (iii) sixty-two
thousand five hundred (62,500) Class A3 shares, (iv) sixty-two thousand five hundred (62,500) Class A4 shares, all having
a nominal value of five cents (EUR 0.05) each, all held by Fairfield L.P.. As a consequence of the cancellation of such shares,
Fairfield L.P. shall receive an amount corresponding to the nominal value of the shares cancelled. The other shareholders
in the Company have waived their right to participate in the share capital decrease.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the general meeting of shareholders resolve to fully restate the Company's
articles of association which shall henceforth read as follows:
“A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Fairfield 1 S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
94813
L
U X E M B O U R G
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at sixty-five thousand five hundred thirty-two euro (EUR 65,532), consisting of
the following shares:
(i) two hundred seventy-seven thousand three hundred and forty-three (277,343) class A1 shares with a nominal value
of five cents (EUR 0.05) each (the “Class A1 Shares”);
(ii) two hundred seventy-seven thousand three hundred and forty-three (277,343) class A2 shares with a nominal value
of five cents (EUR 0.05) each (the “Class A2 Shares”);
(iii) two hundred seventy-seven thousand three hundred and forty-three (277,343) class A3 shares with a nominal
value of five cents (EUR 0.05) each (the “Class A3 Shares”);
(iv) two hundred seventy-seven thousand three hundred and forty-three (277,343) class A4 shares with a nominal
value of five cents (EUR 0.05) each (the “Class A4 Shares” and, together with the Class A1 Shares, the Class A2 Shares
and the Class A3 Shares the "Class A Shares" and the holders thereof are referred to collectively as "A Shareholders");
(v) twenty-five thousand sixty-seven (25,067) class B1 shares with a nominal value of five cents (EUR 0.05) each (the
“Class B1 Shares”);
(vi) twenty-five thousand sixty-seven (25,067) class B2 shares with a nominal value of five cents (EUR 0.05) each (the
“Class B2 Shares”);
(vii) twenty-five thousand sixty-seven (25,067) class B3 shares with a nominal value of five cents (EUR 0.05) each (the
“Class B3 Shares”);
(viii) twenty-five thousand sixty-seven (25,067) class B4 shares with a nominal value of five cents (EUR 0.05) each (the
“Class B4 Shares” and, together with the Class B1 Shares, the Class B2 Shares and the Class B3 Shares the "Class B
Shares" and the holders thereof are referred to collectively as "B Shareholders"); and
(ix) one hundred one thousand (101,000) class C shares with a nominal value of five cents (EUR 0.05) each (the “Class
C Shares” and the holders thereof are referred to collectively as "C Shareholders").
5.2 All the shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these articles of association,
the holders of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter.
5.3. Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a
resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.
5.4. Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder. In case of plurality
of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in
94814
L
U X E M B O U R G
the Company's share capital. The board of managers shall determine the period of time during which such preferential
subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a
registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, the general meeting
of shareholders, called to resolve upon an increase of the Company's share capital, may limit or suppress the preferential
subscription right of the existing shareholder. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment
of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into nine (9) classes of shares, each of them having the same nominal value.
6.2 Classes of shares
(1) The class A1 Shares
(a) All Class A1 Shares shall be identical in all respects. All Class A1 Shares shall share rateably in the payment of
dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to
such Class A1 Shares. All Class A1 Shares purchased or otherwise acquired by the Company shall be retired with the
effect that the issued number of Class A1 Shares is reduced.
(b) Each Class A1 Shares will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the
right to vote.
(2) The Class A2 Shares
(a) All Class A2 Shares shall be identical in all respects. All Class A2 Shares shall share rateably in the payment of
dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to
such Class A2 Shares. All Class A2 Shares purchased or otherwise acquired by the Company shall be retired with the
effect that the issued number of Class A2 Shares is reduced.
(b) Each Class A2 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the
right to vote.
(3) The Class A3 Shares
(a) All Class A3 Shares shall be identical in all respects. All Class A3 Shares shall share rateably in the payment of
dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to
such Class A3 Shares. All Class A3 Shares purchased or otherwise acquired by the Company shall be retired with the
effect that the issued number of Class A3 Shares is reduced.
(b) Each Class A3 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the
right to vote.
(4) The Class A4 Shares
(a) All Class A4 Shares shall be identical in all respects. All Class A4 Shares shall share rateably in the payment of
dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to
such Class A4 Shares. All Class A4 Shares purchased or otherwise acquired by the Company shall be retired with the
effect that the issued number of Class A3 Shares is reduced.
(b) Each Class A4 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the
right to vote.
(5) The Class B1 Shares
(a) All Class B1 Shares shall be identical in all respects. All Class B1 Shares shall share rateably in the payment of
dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to
such Class B1 Shares. All Class B1 Shares purchased or otherwise acquired by the Company shall be retired with the
effect that the issued number of Class B1 Shares is reduced.
(b) Each Class B1 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the
right to vote.
(6) The Class B2 Shares
(a) All Class B2 Shares shall be identical in all respects. All Class B2 Shares shall share rateably in the payment of
dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to
such Class B2 Shares. All Class B2 Shares purchased or otherwise acquired by the Company shall be retired with the
effect that the issued number of Class B2 Shares is reduced.
(b) Each Class B2 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the
right to vote.
(7) The Class B3 Shares
(a) All Class B3 Shares shall be identical in all respects. All Class B3 Shares shall share rateably in the payment of
dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to
such Class B3 Shares. All Class B3 Shares purchased or otherwise acquired by the Company shall be retired with the
effect that the issued number of Class B3 Shares is reduced.
94815
L
U X E M B O U R G
(b) Each Class B3 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the
right to vote.
(8) The Class B4 Shares
(a) All Class B4 Shares shall be identical in all respects. All Class B4 Shares shall share rateably in the payment of
dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to
such Class B4 Shares. All Class B4 Shares purchased or otherwise acquired by the Company shall be retired with the
effect that the issued number of Class B3 Shares is reduced.
(b) Each Class B4 Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the
right to vote.(8) The Class C Shares
(a) All Class C Shares shall be identical in all respects. All Class C Shares shall share rateably in the payment of dividends
and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Class
C Shares. All Class C shares purchased or otherwise acquired by the Company shall be retired with the effect that the
issued number of Class C Shares is reduced.
(b) Each Class C Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the
right to vote.
6.3 The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by law, repurchase or redeem its
own shares.
6.4 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association.
6.5 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation
of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class
(es). [In the case of repurchases and cancellations of classes of shares such cancellations and repurchases of shares shall
be made in the reverse alphabetical order (starting with Cass A4 Shares and Class B4 Shares).
6.6 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares, in the
order provided for in article 6.5, such class of shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the board
of managers) and the holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive from the Company
an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class held by them and cancelled.
6.7 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of
shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.
6.8 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers on the basis of the
relevant interim accounts of the Company as of a date not earlier than eight (8) days before the date of the repurchase
and cancellation of the relevant class of shares. The Total Cancellation Amount for each of the classes of Class A Shares
and Class B Shares shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class
unless otherwise resolved by the board of managers provided however that the Total Cancellation Amount shall never
be higher than such Available Amount.
6.9 The Available Amount shall be the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits
and share premium) to the extent the shareholder of the relevant class of shares would have been entitled to dividend
distributions according to article 22 of these articles of association and in accordance with the provisions of any share-
holders' agreement which may be entered into from time to time between, amongst others, all of the shareholders of
the Company, increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share
capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses
(included carried forward losses), (ii) any sums to be placed into undistributable reserve(s) pursuant to the requirements
of law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts and (iii) any accrued and unpaid dividends
to the extent those have not already reduced the NP (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR + LD). Whereby: AA=Available Amount; NP= net profits (including carried forward profits
and share premium); P= any freely distributable reserves; CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve
reduction relating to the Class of Shares to be cancelled; L= losses (including carried forward losses); LR = any sums to
be placed into undistributable reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles; LD = any accrued and
unpaid dividends to the extent those have not already reduced the NP.
6.10 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will
become due and payable by the Company.
6.11 Fractional shares may be issued up to three decimal places and shall carry rights in proportion to the fraction of
a share they represent but shall carry no voting rights except to the extent their number is so that they represent a whole
share.
6.12 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise
provided by law.
6.13 Subject to the provisions of article 22 of these articles of association, a shareholder's right in the Company's
assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/her/it in the Company's share capital.
94816
L
U X E M B O U R G
6.14 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as
the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.
6.15 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed
shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.
6.16 The Company's shares are in registered form.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognize only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
94817
L
U X E M B O U R G
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers. The Company may have several classes of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting, provided that such conference-calls or video conferences shall be
initiated from Luxembourg and that no manager who is physically present in the United Kingdom at the time of the
meeting may participate in such meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers, including, if several classes of managers have been appointed, at least
one (1) manager of each class of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, including, if
several classes of managers have been appointed, the affirmative vote of at least one (1) manager of each class of managers.
The chairman, if any, shall not have a casting vote.
94818
L
U X E M B O U R G
17.7 The board of managers may not pass resolutions by circular means in writing, by facsimile, electronic mail or any
other similar means of communication.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or (ii) if the Company has several managers, by the joint signature of one (1) class A manager
and one (1) class B manager, or (iii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory
power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges
and provisions represents the net annual profit of the Company.
22.2 From the Company's annual net profits, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid to the shareholders in the following
order of priority:
- first, each Class C Share shall be entitled each year to an annual preferential dividend in an amount equal to the
nominal value of the Class C Share multiplied by the LIBOR rate applicable on the 31 December of each year (the “Class
C Share Preferred Return”). The Class C Share Preferred Return is cumulative and recoverable, which means that the
holders of the Class C Shares shall, during posterior financial years, recover the Class C Share Preferred Return that they
could not receive during the foregoing financial years during which there was no realized nor distributed profit. The
recovery of the Class C Share Preferred Return is not limited in time. The Class C Shares shall not be entitled to any
further profits in the Company in addition to the Class C Share Preferred Return nor will such Class C Share Preferred
Return be, at any time, allocated to any Class A Shares and/or Class B Shares; and
- second, an amount equal to zero point sixty percent (0.60%) of the nominal value of each share shall be distributed
to all holders of Class A4 Shares and Class B4 Shares, then an amount equal to zero point fifty-five percent (0.55%) of
the nominal value of each share shall be distributed to all holders of Class A3 Shares and Class B3 Shares; then an amount
94819
L
U X E M B O U R G
equal to zero point fifty (0.50%) of the nominal value of each share shall be distributed to all holders of Class A2 Shares
and Class B2 Shares and then an amount equal to zero point forty-five (0.45%) of the nominal value of each share shall
be distributed to all holders of Class A1 Shares and Class B1 Shares;
- third, any remaining amount out of the annual net profits made by the Company after allocation of the Class C Share
Preferred Return shall be allocated to the holders of the last sub-class of Class A Shares and Class B Shares on a prorata
basis in the reverse alphabetical order (i.e. first Class A4 Shares and Class B4 shares, then if there are no longer Class
A4 Shares and Class B4 shares, the Class A3 shares and Class B3 Shares in existence, the Class A2 Shares and the Class
B2 Shares and in such continuation until only Class A1 shares and Class B1 Shares are in existence.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities (the “Surplus”) shall be
distributed among the shareholders in the following order of priority:
- first, to the C Shareholders in an amount equal to the unpaid Class C Share Preferred Return, if any; and
- any remaining Surplus amount after payment of any unpaid Class C Share Preferred Return shall be allocated to the
A Shareholders and B Shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with the present deed are estimated at approximately EUR 3,500.-.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, known to the notary by name, first
name and residence, the said proxyholders of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq avril.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Fairfield L.P., une limited partnership constituée et existant selon les lois de Guernsey, immatriculée sous le numéro
2042, ayant son siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QL («Fairfield
L.P.»),
ici représentée par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de Fairfield 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée
et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
94820
L
U X E M B O U R G
bourg sous le numéro B 185390, constituée selon acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 5 mars 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.
La partie comparante représentant l'intégralité du capital social a requis le notaire soussigné d'acter que l'ordre du
jour de l'assemblée sera le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Réduction de la valeur nominale des parts sociales existantes à cinq cents (EUR 0,05) et création de neuf (9) caté-
gories différentes de parts sociales qui seront désignées parts sociales de catégorie A1, parts sociales de catégorie A2,
parts sociales de catégorie A3, parts sociales de catégorie A4, parts sociales de catégorie B1, parts sociales de catégorie
B2, parts sociales de catégorie B3, parts sociales de catégorie B4 et parts sociales de catégorie C et conversion des deux
cent cinquante mille parts sociales existantes d'une valeur nominale de cinq cents (EUR 0,05) chacune en soixante-deux
mille cinq cents (62.500) parts sociales de Catégorie A1, soixante-deux mille cinq cents (62.500) parts sociales de Caté-
gorie A2, soixante-deux mille cinq cents (62.500) parts sociales de Catégorie A3, soixante-deux mille cinq cents (62.500)
parts sociales de Catégorie A4, d'une valeur de 5 cents (EUR 0,05) chacune;
2. Agrément de M. Barend Franciscus Johannes van den Hoek, M. Andrew Michael Copson, S&L Casey Superannuation
Fund et Fairfield 2014 Employee Benefit Trust en qualité de nouveaux associés de la Société;
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de soixante-cinq mille cinq cent trente-deux euros (EUR
65.532) jusqu'à un montant de soixante-dix-huit mille trente-deux euros (EUR 78,032) par l'émission de (i) deux cent
soixante-dix-sept mille trois cent quarante-trois (277,343) parts sociales de Catégorie A1, (ii) deux cent soixante-dix-
sept mille trois cent quarante-trois (277,343) parts sociales de Catégorie A2, (iii) deux cent soixante-dix-sept mille trois
cent quarante-trois (277,343) parts sociales de Catégorie A3 et (iv) deux cent soixante-dix-sept mille trois cent quarante-
trois (277,343) parts sociales de Catégorie A4, (v) vingt-cinq mille soixante-sept (25.067) parts sociales de Catégorie B1,
(vi) vingt-cinq mille soixante-sept (25.067) parts sociales de Catégorie B2, (vii) vingt-cinq mille soixante-sept (25.067)
parts sociales de Catégorie B3, (viii) vingt-cinq mille soixante-sept (25.067) parts sociales de Catégorie B4 et (ix) cent un
mille (101.000) parts sociales de Catégorie C, toutes d'une valeur nominale unitaire de cinq cents (EUR 0,05) chacune;
4. Réduction du capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) pour le
ramener de son montant actuel de soixante-dix-huit mille trente-deux Euros (EUR 78.032,-) à soixante-cinq mille cinq
cent trente-deux Euros (EUR 65.532,-) par l'annulation de (i) soixante-deux mille cinq cents (62.500) parts sociales de
Catégorie A1, (ii) soixante-deux mille cinq cents (62.500) parts sociales de Catégorie A2, (iii) soixante-deux mille cinq
cents (62.500) parts sociales de Catégorie A3, (iv) soixante-deux mille cinq cents (62.500) parts sociales de Catégorie
A4, ayant toutes une valeur nominale de cinq cents (EUR 0,05) chacune, toutes détenues par Fairfield L.P.
5. Décision de refondre complètement les statuts de la Société;
6. Divers.
Ladite partie comparante représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Fairfield L.P. décide:
(i) de réduire la valeur nominale des parts sociales existantes d'un euro (EUR 1) à cinq cents (EUR 0,05) afin que le
capital social d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500) soit désormais représenté par deux cent
cinquante mille (250,000) parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents (EUR 0,05) chacune. L'intégralité des deux
cent cinquante mille (250,000) parts sociales est détenue par Fairfield L.P.;
(ii) de créer les nouvelles catégories de parts sociales suivantes qui seront désignées comme suit: parts sociales de
catégorie A1, parts sociales de catégorie A2, parts sociales de catégorie A3, parts sociales de catégorie A4, parts sociales
de catégorie B1, parts sociales de catégorie B2, parts sociales de catégorie B3, parts sociales de catégorie B4 et parts
sociales de catégorie C, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune;
(iii) de convertir les deux cent cinquante mille (250,000) parts sociales existantes d'une valeur nominale de cinq cents
(EUR 0,05) chacune en (i) soixante-deux mille cinq cents (62.500) parts sociales de Catégorie A1, (ii) soixante-deux mille
cinq cents (62.500) parts sociales de Catégorie A2, (iii) soixante-deux mille cinq cents (62.500) parts sociales de Catégorie
A3 et (iv) soixante-deux mille cinq cents (62.500) parts sociales de Catégorie A4, d'une valeur nominale de cinq cents
(EUR 0,05) chacune;
<i>Deuxième résolutioni>
Fairfield L.P. approuve (i) M. Barend Franciscus Johannes van den Hoek, né le 27 décembre 1957 à Zierikzee (Pays-
Bas), demeurant au 4 Boyd Close, Mooroolbark, Victoria, 3138, Australie, (ii) M. Andrew Michael Copson, né le 21
octobre 1963 à Aldershot (Royaume-Uni), residant au 6 Westport Manor, Gastons Road, Malmesbury, SN16 0FE, Roy-
aume-Uni, (iii) S&L Casey Superannuation Fund, une société existant selon la loi australienne, immatriculée au Australia
Business Register, dont le siège social est sis à 2/322 Cotham Road, Kew Victoria 3101, Australie (iv) Fairfield 2014
Employee Benefit Trust, un trust constitué selon les lois de Jersey par voie d'un acte fiduciaire en date du 23 avril 2014
entre Appleby Trust (Jersey) Limited, constituée et immatriculée à Jersey sous le numéro 21755 dont le siège social est
94821
L
U X E M B O U R G
13-14 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1BD (en qualité de trustee) and Fairfield Bidco Limited (en qualité de constituant),
en qualité de nouveaux associés de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
Fairfield L.P. décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de soixante-cinq mille cinq cent trente-
deux euros (EUR 65.532) jusqu'à soixante-dix-huit mille trente-deux euros (EUR 78.032) par l'émission de (i) deux cent
soixante-dix-sept mille trois cent quarante-trois (277,343) parts sociales de Catégorie A1, (ii) deux cent soixante-dix-
sept mille trois cent quarante-trois (277,343) parts sociales de Catégorie A2, (iii) deux cent soixante-dix-sept mille trois
cent quarante-trois (277,343) parts sociales de Catégorie A3 et (iv) deux cent soixante-dix-sept mille trois cent quarante-
trois (277,343) parts sociales de Catégorie A4, (v) vingt-cinq mille soixante-sept (25.067) parts sociales de Catégorie B1,
(vi) vingt-cinq mille soixante-sept (25.067) parts sociales de Catégorie B2, (vii) vingt-cinq mille soixante-sept (25.067)
parts sociales de Catégorie B3, (viii) vingt-cinq mille soixante-sept (25.067) parts sociales de Catégorie B4 et (ix) cent un
mille (101.000) parts sociales de Catégorie C, toutes d'une valeur nominale unitaire de cinq cents (EUR 0,05) chacune.
Toutes ces parts sociales ont été entièrement souscrites pour un prix d'un million cent sept mille cinq cent vingt euros
(EUR 1.107.520) par Fairfield L.P., ici représentée par Ikrame Dabaj, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
et ont été intégralement libérées par un apport en numéraire.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant d'un million cent sept mille cinq cent vingt euros (EUR 1.107.520) consiste en cinquante-
cinq mille trois cent soixante-seize euros (EUR 55.376) pour le capital social et un million cinquante-deux mille cent
quarante-quatre euros (EUR 1.052.144) pour la prime d'émission.
(i) cent soixante et onze (171) parts sociales de Catégorie A1, (ii) cent soixante et onze (171) parts sociales de
Catégorie A2, (iii) cent soixante et onze (171) parts sociales de Catégorie A3, (iv) cent soixante et onze (171) parts
sociales de Catégorie A4, (v) huit cent trente-neuf (839) parts sociales de Catégorie B1, (vi) huit cent trente-neuf (839)
parts sociales de Catégorie B2, (vii) huit cent trente-neuf (839) parts sociales de Catégorie B3 et (viii) huit cent trente-
neuf (839) parts sociales de Catégorie B4 ont été entièrement souscrites par M. Barend Franciscus Johannes van den
Hoek pour un prix de quatre mille quarante euros (EUR 4,040), ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration et ont été intégralement libérées par un apport en numéraire.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de quatre mille quarante euros (EUR 4,040) consiste en deux cent deux euros (EUR 202)
pour le capital social et trois mille huit cent trente-huit euros (EUR 3.838) pour la prime d'émission.
(i) cent trente-deux (132) parts sociales de Catégorie A1, (ii) cent trente-deux (132) parts sociales de Catégorie A2,
(iii) cent trente-deux (132) parts sociales de Catégorie A3, (iv) cent trente-deux (132) parts sociales de Catégorie A4,
(v) mille trois cent dix-huit (1.318) parts sociales de Catégorie B1, (vi) mille trois cent dix-huit (1.318) parts sociales de
Catégorie B2, (vii) mille trois cent dix-huit (1.318) parts sociales de Catégorie B3 et (viii) mille trois cent dix-huit (1.318)
parts sociales de Catégorie B4 ont été entièrement souscrites par M. Andrew Michael Copson pour un prix de cinq mille
huit cents euros (EUR 5,800), ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration et ont
été intégralement libérées par un apport en numéraire.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de cinq mille huit cents euros (EUR 5,800) consiste en deux cent quatre-vingt-dix euros
(EUR 290) pour le capital social et cinq mille cinq cent dix euros (EUR 5,510) pour la prime d'émission.
(i) cent soixante (160) parts sociales de Catégorie A1, (ii) cent soixante (160) parts sociales de Catégorie A2, (iii) cent
soixante (160) parts sociales de Catégorie A3, (iv) cent soixante (160) parts sociales de Catégorie A4, (v) sept cent dix-
neuf (719) parts sociales de Catégorie B1, (vi) sept cent dix-neuf (719) parts sociales de Catégorie B2, (vii) sept cent dix-
neuf (719) parts sociales de Catégorie B3 et (viii) sept cent dix-neuf (719) parts sociales de Catégorie B4 ont été
entièrement souscrites par S&L Casey Superannuation Fund pour un prix de trois mille cinq cent seize euros (EUR 3,516),
ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration et ont été intégralement libérées
par un apport en numéraire.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de trois mille cinq cent seize euros (EUR 3,516) consiste en cent soixante-quinze euros
et quatre-vingt-dix cents (EUR 175,80) pour le capital social et trois mille trois cent quarante euros et vingt cents (EUR
3.340,20) pour la prime d'émission.
(i) vingt-deux mille cent quatre-vingt-onze (22,191) parts sociales de Catégorie A1, (ii) vingt-deux mille cent quatre-
vingt-onze (22,191) parts sociales de Catégorie A2, (iii) vingt-deux mille cent quatre-vingt-onze (22,191) parts sociales
de Catégorie A3, (iv) vingt-deux mille cent quatre-vingt-onze (22,191) parts sociales de Catégorie A4 et (v) cent un mille
(101,000) parts sociales de Catégorie C ont été entièrement souscrites par Fairfield 2014 Employee Benefit Trust pour
un prix de quatre-vingt-treize mille huit cent quatorze euros (EUR 93,814), ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant à
Luxembourg, en vertu d'une procuration et ont été intégralement libérées par un apport en numéraire.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
94822
L
U X E M B O U R G
L'apport global d'un montant de quatre-vingt-treize mille huit cent quatorze euros (EUR 93,814) consiste en neuf mille
quatre cent quatre-vingt-huit euros et vingt cents (EUR 9,488.20) pour le capital social et quatre-vingt-quatre mille trois
cent vingt-cinq euros et quatre-vingts cents (EUR 84,325.80) pour la prime d'émission.
M. Barend Franciscus Johannes van den Hoek, susmentionné, ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant profession-
nellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration,
M. Andrew Michael Copson, susmentionné, ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration,
S&L Casey Superannuation Fund susmentionné, ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration,
Fairfield 2014 Employee Benefit Trust, susmentionnée, ici représentée par susmentionné, ici représenté par Ikrame
Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration,
rejoignent l'assemblée générale des associés de la Société et décident conjointement avec l'associé unique sur les points
suivants figurant à l'ordre du jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des associés décide de réduire le capital social d'un montant de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500) afin de le réduire de son montant actuel de soixante-dix-huit mille trente-deux euros (EUR 78.032) à
soixante-cinq mille cinq cent trente-deux euros (EUR 65.532) par annulation de (i) soixante-deux mille cinq cents (62.500)
parts sociales de Catégorie A1, (ii) soixante-deux mille cinq cents (62.500) parts sociales de Catégorie A2, (iii) soixante-
deux mille cinq cents (62.500) parts sociales de Catégorie A3, (iv) soixante-deux mille cinq cents (62.500) parts sociales
de Catégorie A4, d'une valeur nominale de cinq cents (EUR 0.05) chacune, toutes détenues par Fairfield L.P.. En consé-
quence de l'annulation de ces parts sociales, Fairfield L.P. recevra un montant correspondant à la valeur nominale des
parts sociales annulées. Les autres associés de la Société ont renoncé à leur droit de participer à la réduction de capital.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale des associés décide de refondre complètement
les statuts de la Société qui seront désormais rédigés comme suit:
«A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Fairfield 1 S.à r.l.» (ci-
après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
«Loi»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi
que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière
les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non
garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-
nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
94823
L
U X E M B O U R G
l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à soixante-cinq mille cinq cent trente-deux euros (EUR 65.532), représenté
par les parts sociales suivantes:
- (i) deux cent soixante-dix-sept mille trois cent quarante-trois (277.343) parts sociales de catégorie A1 ayant une
valeur nominale de cinq cents (EUR 0.05) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie A1»);
- (ii) deux cent soixante-dix-sept mille trois cent quarante-trois (277.343) parts sociales de catégorie A2 ayant une
valeur nominale de cinq cents (EUR 0.05) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie A2»);
- (iii) deux cent soixante-dix-sept mille trois cent quarante-trois (277.343) parts sociales de catégorie A3 ayant une
valeur nominale de cinq cents (EUR 0.05) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie A3»);
- (iv) deux cent soixante-dix-sept mille trois cent quarante-trois (277.343) parts sociales de catégorie A4 ayant une
valeur nominale de cinq cents (EUR 0.05) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie A4» et avec les Parts Sociales de
Catégorie A2, les Parts Sociales de Catégorie A3, les «Parts Sociales de Catégorie A» et les détenteurs de Parts Sociales
de Catégorie A sont référencés comme les «Associés A»);
- (v) vingt-cinq mille soixante-sept (25.067) parts sociales de catégorie B1 ayant une valeur nominale de cinq cents
(EUR 0.05) chacune (les «Parts sociales de Catégorie B1»);
- (vi) vingt-cinq mille soixante-sept (25.067) parts sociales de catégorie B2 ayant une valeur nominale de cinq cents
(EUR 0.05) chacune (les «Parts sociales de Catégorie B2»);
- (vii) vingt-cinq mille soixante-sept (25.067) parts sociales de catégorie B3 ayant une valeur nominale de cinq cents
(EUR 0.05) chacune (les «Parts sociales de Catégorie B3»);
- (viii) vingt-cinq mille soixante-sept (25.067) parts sociales de catégorie B4 ayant une valeur nominale de cinq cents
(EUR 0.05) chacune (les «Parts sociales de Catégorie B4» et avec les Parts sociales de Catégorie B2, les Parts sociales de
Catégorie B3, les «Parts sociales de Catégorie B» et les détenteurs de Parts sociales de Catégorie A sont référencés
comme les «Associés B»);
- (ix) cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie C ayant une valeur nominale de cinq cents (EUR 0.05) chacune
(les «Parts sociales de Catégorie C» et les détenteurs de Parts sociales de Catégorie C sont référencés comme les
«Associés C»).
5.2 Toutes les parts sociales doivent voter ensemble et, sauf exceptions prévues par la loi ou dans les présents statuts,
les détenteurs de parts sociales de différentes catégories ne peuvent voter séparément sur tout point.
5.3 Dans les conditions prévues par la loi, le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision
de l'assemblée générale des associés de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents
statuts.
5.4 Toutes parts sociales payées en numéraire doivent être offerte par préférence aux associés existants. En cas de
pluralité d'associés, ces parts sociales seront offertes aux associés en proportion du nombre de parts sociales qu'ils
détiennent dans le capital social de la Société. Le conseil de gérance déterminera la période au cours de laquelle le droit
préférentiel de souscription peut être exercé. Cette période ne peut pas être inférieure à trente (30) jours à compter
de la date d'envoi d'une lettre recommandée au(x) associé(s) les informant de l'ouverture de la souscription. Cependant,
l'assemblée générale des associés, appelée à voter sur l'augmentation du capital social de la Société, peut limiter ou
supprimer le droit préférentiel de souscription de l'associé existant. Une telle résolution doit être adoptée selon les
modalités requises pour la modification des présents statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en neuf (9) catégories de parts sociales ayant chacune la même valeur
nominale.
6.2 Les catégories de parts sociales
(1) Les Parts Sociales de Catégorie A1
(a) Les Parts Sociales de Catégorie A1 doivent être totalement identiques, dans tous les aspects. Les Parts Sociales de
Catégorie A1 doivent partager équitablement le paiement de dividendes and toutes distribution d'actifs autres que des
dividendes qui sont alloués d'une manière globale à ces Parts Sociales de Catégorie A1. Toutes les Parts Sociales de
Catégorie A1 achetées ou autrement acquises par la Société doivent être annulées de manière à ce que le nombre de
Part Sociales de Catégorie A1 émise soit réduit.
(b) Chaque Part Sociale de Catégorie A1 donne droit à une voix à son détenteur sur tout sujet sur lesquels les associés
ont le droit de voter.
(2) Les Parts Sociales de Catégorie A2
94824
L
U X E M B O U R G
(a) Les Parts Sociales de Catégorie A2 doivent être totalement identiques, dans tous les aspects. Les Parts Sociales de
Catégorie A2 doivent partager équitablement le paiement de dividendes and toutes distribution d'actifs autres que des
dividendes qui sont alloués d'une manière globale à ces Parts Sociales de Catégorie A2. Toutes les Parts Sociales de
Catégorie A2 achetées ou autrement acquises par la Société doivent être annulées de manière à ce que le nombre de
Part Sociales de Catégorie A2 émise soit réduit.
(b) Chaque Part Sociale de Catégorie A2 donne droit à une voix à son détenteur sur tout sujet sur lesquels les associés
ont le droit de voter.
(3) Les Parts Sociales de Catégorie A3
(a) Les Parts Sociales de Catégorie A3 doivent être totalement identiques, dans tous les aspects. Les Parts Sociales de
Catégorie A3 doivent partager équitablement le paiement de dividendes and toutes distribution d'actifs autres que des
dividendes qui sont alloués d'une manière globale à ces Parts Sociales de Catégorie A3. Toutes les Parts Sociales de
Catégorie A3 achetées ou autrement acquises par la Société doivent être annulées de manière à ce que le nombre de
Part Sociales de Catégorie A3 émise soit réduit.
(b) Chaque Part Sociale de Catégorie A3 donne droit à une voix à son détenteur sur tout sujet sur lesquels les associés
ont le droit de voter.
(2) Les Parts Sociales de Catégorie A4
(a) Les Parts Sociales de Catégorie A4 doivent être totalement identiques, dans tous les aspects. Les Parts Sociales de
Catégorie A4 doivent partager équitablement le paiement de dividendes and toutes distribution d'actifs autres que des
dividendes qui sont alloués d'une manière globale à ces Parts Sociales de Catégorie A4. Toutes les Parts Sociales de
Catégorie A4 achetées ou autrement acquises par la Société doivent être annulées de manière à ce que le nombre de
Part Sociales de Catégorie A4 émise soit réduit.
(b) Chaque Part Sociale de Catégorie A4 donne droit à une voix à son détenteur sur tout sujet sur lesquels les associés
ont le droit de voter.
(5) Les Parts Sociales de Catégorie B1
(a) Les Parts Sociales de Catégorie B1 doivent être totalement identiques, dans tous les aspects. Les Parts Sociales de
Catégorie B1 doivent partager équitablement le paiement de dividendes and toutes distribution d'actifs autres que des
dividendes qui sont alloués d'une manière globale à ces Parts Sociales de Catégorie B1. Toutes les Parts Sociales de
Catégorie B1 achetées ou autrement acquises par la Société doivent être annulées de manière à ce que le nombre de
Part Sociales de Catégorie B1 émise soit réduit.
(b) Chaque Part Sociale de Catégorie B1 donne droit à une voix à son détenteur sur tout sujet sur lesquels les associés
ont le droit de voter.
(6) Les Parts Sociales de Catégorie B2
(a) Les Parts Sociales de Catégorie B2 doivent être totalement identiques, dans tous les aspects. Les Parts Sociales de
Catégorie B2 doivent partager équitablement le paiement de dividendes and toutes distribution d'actifs autres que des
dividendes qui sont alloués d'une manière globale à ces Parts Sociales de Catégorie B2. Toutes les Parts Sociales de
Catégorie B2 achetées ou autrement acquises par la Société doivent être annulées de manière à ce que le nombre de
Part Sociales de Catégorie B2 émise soit réduit.
(b) Chaque Part Sociale de Catégorie B2 donne droit à une voix à son détenteur sur tout sujet sur lesquels les associés
ont le droit de voter.
(7) Les Parts Sociales de Catégorie B3
(a) Les Parts Sociales de Catégorie B3 doivent être totalement identiques, dans tous les aspects. Les Parts Sociales de
Catégorie B3 doivent partager équitablement le paiement de dividendes and toutes distribution d'actifs autres que des
dividendes qui sont alloués d'une manière globale à ces Parts Sociales de Catégorie B3. Toutes les Parts Sociales de
Catégorie B3 achetées ou autrement acquises par la Société doivent être annulées de manière à ce que le nombre de
Part Sociales de Catégorie B3 émise soit réduit.
(b) Chaque Part Sociale de Catégorie B3 donne droit à une voix à son détenteur sur tout sujet sur lesquels les associés
ont le droit de voter.
(8) Les Parts Sociales de Catégorie B4
(a) Les Parts Sociales de Catégorie B4 doivent être totalement identiques, dans tous les aspects. Les Parts Sociales de
Catégorie B4 doivent partager équitablement le paiement de dividendes and toutes distribution d'actifs autres que des
dividendes qui sont alloués d'une manière globale à ces Parts Sociales de Catégorie B4. Toutes les Parts Sociales de
Catégorie B4 achetées ou autrement acquises par la Société doivent être annulées de manière à ce que le nombre de
Part Sociales de Catégorie B4 émise soit réduit.
(b) Chaque Part Sociale de Catégorie B4 donne droit à une voix à son détenteur sur tout sujet sur lesquels les associés
ont le droit de voter.
(9) Les Parts Sociales de Catégorie C
(a) Les Parts Sociales de Catégorie C doivent être totalement identiques, dans tous les aspects. Les Parts Sociales de
Catégorie C doivent partager équitablement le paiement de dividendes and toutes distribution d'actifs autres que des
94825
L
U X E M B O U R G
dividendes qui sont alloués d'une manière globale à ces Parts Sociales de Catégorie C. Toutes les Parts Sociales de
Catégorie C achetées ou autrement acquises par la Société doivent être annulées de manière à ce que le nombre de Part
Sociales de Catégorie C émise soit réduit.
(b) Chaque Part Sociale de Catégorie C donne droit à une voix à son détenteur sur tout sujet sur lesquels les associés
ont le droit de voter.
6.3 La Société peut, dans les conditions prévues par la loi, racheter ou annuler ses propres parts sociales.
6.4 Le capital de la Société peut être réduit ou augmenté par une résolution des associés adoptée selon les modalités
requises pour la modification des présents statuts.
6.5 Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales, notamment par l'annulation d'une
ou plusieurs catégories entière de parts sociales par le rachat ou l'annulation de toutes les parts sociales émises dans
cette catégorie. Dans l'hypothèse de rachat ou d'annulation de catégorie de parts sociales, le rachat et l'annulation de
parts sociales doit se faire dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par les Parts Sociales de Catégorie A4 et
les Parts Sociales de Catégorie B4).
6.6 Dans l'hypothèse d'une réduction de capital par le rachat et l'annulation de catégorie de parts sociales, dans l'ordre
prévu par l'article 6.5, cette catégorie de part sociales donne le droit aux détenteurs de ces parts sociales, au prorata du
nombre de parts détenues dans cette catégorie, au Montant Disponible (dans la limite du Montant Total de l'Annulation
tel que défini par le conseil de gérance) et les détenteurs de parts sociales des parts détenues et rachetées doivent recevoir
de la société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale qu'ils détiennent dans
chaque catégorie et qui sont annulées.
6.7 La Valeur d'Annulation par Part Sociale est calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de
parts sociales émises dans la catégorie de parts sociales qui est rachetée et annulée.
6.8 Le Montant Total d'Annulation est un montant déterminé par le conseil de gérance sur la base des comptes
intérimaires émise par la Société à une date qui ne peut être inférieure à huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation
de la catégorie d'action concernée. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Parts Sociales de Catégorie A et
des Parts Sociales de Catégorie B doit être égal au Montant Disponible pour chaque catégorie au moment de l'annulation
de la catégorie concernée, sauf décision contraire par le conseil de gérance en tenant compte cependant que le Montant
Total d'Annulation ne peut jamais être supérieur au Montant Disponible.
6.9 Le Montant Disponible correspond au montant total des bénéfices nets de la Société (comprenant les bénéfices
reportés et la prime d'émission) dans la mesure où l'associé de la catégorie de parts sociales concerné aurait eu le droit
de bénéficier d'un dividende distribuable en fonction des dispositions de l'article 22 des présents statuts et dans le respect
des dispositions de tout pacte d'associés existants pouvant être conclus de temps à autres entre tous les associés de la
Société, augmenté (i) de toutes réserves librement distribuables et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction du
capital social et de la réserve légale relatif à la catégorie de parts sociales devant être annulée mais réduit par (i) toutes
pertes (ainsi que toutes pertes reportées), (ii) toutes sommes placées dans des réserves non distribuables en fonction
des dispositions de la loi ou des présents Statuts, à chaque fois tel qu'indiqué dans les Comptes Intérimaires et (iii) tous
dividendes acquis mais non payés seulement si ceux-ci n'ont pas réduit la NP (sans, pour éviter toute confusion, qu'il y
ait une double comptabilisation) afin que AA = (NP+P+CR) - (L+LR+LD). Dans ce cas: AA = Montant Disponible; NP =
bénéfices nets (comprenant les bénéfices reportés et la prime d'émission); P = toutes réserves librement distribuables;
CR = montant de la réduction du capital social et de la réserve légale relatif à la catégorie de parts sociales devant être
annulée; L = toutes pertes (ainsi que toutes pertes reportées); LR = toutes sommes placées dans des réserves non
distribuables en fonction des dispositions de la loi ou des présents Statuts; LD = ous dividendes acquis mais non payés
seulement si ceux-ci n'ont pas réduit la NP.
6.10 Lors du rachat et de l'annulation de parts sociales d'une certaine catégorie, la Valeur d'Annulation par Part Sociale
sera due et devra être payée par la Société.
6.11 Des fractions de parts sociales peuvent être émises jusqu'à trois décimales et ces fractions de parts sociales ont
des droits qui sont proportionnels à la fraction de la part sociale qu'elles représentent mais ne peuvent pas détenir de
droit de vote, sauf si le nombre qu'elles représentent est un nombre entier.
6.12 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.13 Sous réserve des dispositions de l'article 22 de ces présents statuts, le droit d'un associé aux actifs et aux bénéfices
de la Société doit être proportionnel au nombre de parts sociales détenues par lui dans le capital social de la Société.
6.14 Le décès, l'incapacité légale, la dissolution, la liquidation, la faillite ou tout autre événement similaire à l'associé
unique, le cas échéant, ou à tout autre associé n'entraînera pas la dissolution de la Société.
6.15 La Société peut racheter ou annuler ses propres parts sociales à la condition que le rachat ou l'annulation des
parts sociales soit immédiatement suivi par leur annulation et que le capital social soit réduit de manière concordante.
6.16 Les parts sociales de la Société ont la forme nominative.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé
pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent
être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
94826
L
U X E M B O U R G
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs
à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle
cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées à un nouvel associé
sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital
social. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux as-
cendants, descendants ou au conjoint survivant.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par
les présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de
décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter
expressément formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant
et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une
assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation. D'autres assemblées
générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations aux assemblées générales
correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux
formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il ne détient de parts.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première réunion ou consultation écrite, les
associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée avec le même ordre du jour et
les décisions sont valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consente-
ment unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un
conseil de gérance.
13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue
comme une référence au «gérant unique».
13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre
toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
94827
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération
et la durée de son (leur) mandat.
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif,
par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Vacance d'un poste de gérant.
15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la
démission ou pour tout autre motif, cette vacance pourra être pourvue de manière temporaire et pour une période ne
pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des
associés qui devra procéder à la nomination d'un nouveau gérant, conformément aux dispositions légales applicables.
15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance devra
être pourvue sans délai par l'assemblée générale des associés.
Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues
au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
16.2 La convocation par écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donnée aux gérants au minimum vingt-
quatre (24) heures avant l'heure fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une telle
urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document
signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de
gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance,
communiquée à tous les membres du conseil de gérance.
16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants sont présents ou représentés
à un conseil de gérance et renoncent aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées
par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance.
17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son
absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote
à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.
17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des
membres du conseil de gérance.
17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par
tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement
sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion, en tenant compte qu'une telle téléconférence
ou vidéoconférence doit être initialisée de Luxembourg afin qu'aucun gérant qui serait physiquement présent en Grande-
Bretagne au moment de la réunion ne puisse participer à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être
tenue au siège social de la Société.
17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est
présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance en ce compris le vote d'au moins un (1) gérant de chaque
catégorie lorsqu'il existe différentes catégories de gérants.
17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil
de gérance en ce compris le vote d'au moins un gérant de chaque catégorie lorsqu'il existe différentes catégories de
gérants. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.
17.7 Le conseil de gérance ne peut pas prendre des décisions par voie circulaire par écrit, par télécopie, courrier
électronique ou par tout autre moyen de communication.
Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant,
ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président
ou par deux (2) gérants.
94828
L
U X E M B O U R G
18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront
signés par le gérant unique.
Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par
la signature du gérant unique, ou, (ii) si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe d'un (1) gérant de catégorie
A et d'un (1) gérant de catégorie B, ou (iii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à
laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délé-
gation.
E. Audit et Surveillance
Art. 20. Commissaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société
seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et dé-
termine la durée de leurs fonctions.
20.2 Le commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des
associés.
20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine
le trente et un décembre de la même année.
Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de
l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
22.2 Le montant disponible sur le compte de résultat, après déduction des dépenses, des coûts, des amortissements,
des charges et des provisions représente le bénéfice annuel net de la Société.
22.3 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.
22.4 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
22.5 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
22.6 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des
bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
22.7 Dans l'hypothèse où il existe un bénéfice, ce bénéfice peut être alloué et payé aux associés dans les conditions
de priorité suivantes:
- premièrement, chaque Part Sociale de Catégorie C aura droit chaque année à un dividende annuel préférentiel
correspondant à un montant équivalent à la valeur nominale de chaque Part Sociale de Catégorie C multiplié par le taux
LIBOR applicable au 31 décembre de chaque année (le «Rendement Privilégié de Catégorie C»). Le Rendement Privilégié
de Catégorie C est cumulatif et recouvrable, ce qui signifie que les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C ont le
droit au Rendement Privilégié de Catégorie C des exercices sociaux antérieurs au cours desquels ils n'y auraient pas eu
le droit du fait de l'absence de bénéfices ou de l'absence de distribution de bénéfices. Ce droit au recouvrement du
Rendement Privilégié de Catégorie C n'est pas limité dans le temps. Les Parts Sociales de Catégorie C n'ont pas le droit
à d'autres bénéfices dans la Société en plus de ce Rendement Privilégié de Catégorie C et ce Rendement Privilégié de
Catégorie C ne peut, à aucun moment, être alloué aux Parts Sociales de Catégorie A et/ou aux Parts Sociales de Catégorie
B;
- deuxièmement, un montant égal à zéro point six pourcent (0.60%) de la valeur nominale de chaque part sociale peut
être distribué à tous les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A4 et de Parts Sociales de Catégories B4, ensuite un
montant de zéro point cinquante-cinq pourcent (0.55%) de la valeur nominale de chaque part sociale peut être distribué
à tous les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A3 et de Parts Sociales de Catégories B3; ensuite un montant égal
à zéro point cinq pourcent (0.50%) de la valeur nominale de chaque part sociale peut être distribué à tous les détenteurs
de Parts Sociales de Catégorie A2 et de Parts Sociales de Catégories B2; un montant égal à zéro point forty-five pourcent
94829
L
U X E M B O U R G
(0.45%) de la valeur nominale de chaque part sociale peut être distribué à tous les détenteurs de Parts Sociales de
Catégorie A1 et de Parts Sociales de Catégories B1;
- troisièmement, tout montant restant des bénéfices nets de la Société après l'attribution du Rendement Privilégié de
Catégorie C doit être distribué aux détenteurs des dernières sous-catégories de Parts Sociales de Catégorie A et de
Parts Sociales de Catégorie B sur une base de prorata dans l'ordre alphabétique inversé (c'est-à-dire premièrement les
Parts Sociales de Catégorie A4 et les Parts Sociales de Catégorie B4, et une fois qu'il n'y a plus de Parts Sociales de
Catégorie A4 et de Parts Sociales de Catégorie B4, les Parts Sociales de Catégorie A3 et les Parts Sociales de Catégorie
B3, dans cet ordre de continuité jusqu'aux Parts Sociales de Catégorie A1 et aux Parts Sociales de Catégorie B1 qui sont
en existence).
Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base de comptes intérimaires
préparés par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués. Le
montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être
affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés sous
réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui
fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et l'acquittement du passif de la Société.
24.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation de l'actif et de l'acquittement du passif (l'«Excédent») sera distribué
entre les associés dans l'ordre de priorité suivant:
- premièrement les Associés C dans un montant équivalent au montant non payé du Rendement Privilégié de Catégorie
C le cas échéant; et
- tout montant restant de l'Excédant après paiement de ce Rendement Privilégié de Catégorie C doit être alloué aux
Associés A et aux Associés B en fonction du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.
H. Disposition finale - loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.»
<i>Dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges de toute nature qui incombe à la Société ou qui est mis à sa
charge en raison de cet acte est évalué à environ EUR 3.500,-.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de ladite partie comparante et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu aux mandataires de la partie comparante connus du notaire instrumentant par nom, prénom et
résidence, lesdits mandataires de la partie comparante ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: I. DABAJ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mai 2014. Relation: LAC/2014/20464. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2014.
Référence de publication: 2014081551/1101.
(140096258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.
94830
L
U X E M B O U R G
Algebris Npl Partnership Gp, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 188.836.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the sixteenth day of July.
Before, Maître Henri Hellinckx, notary professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Algebris Investments (UK) LLP, a limited liability partnership incorporated under the laws of England and Wales, having
its registered office at 7 Clifford Street, London, W1S 2FT, England, registered with the Companies House under number
OC319392,
here represented by Lisa Klemann, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of
a proxy given by private seal.
Said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration
authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
1. Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of
"Algebris NPL Partnership GP, S.à r.l." (the Company).
2. Art. 2. Corporate object.
2.1 The Company may act as general partner of, and take general partner interests, in any Luxembourg limited part-
nership (formed either as common limited partnerships (sociétés en commandite simple), as special limited partnerships
(sociétés en commandite spéciale) or as corporate partnerships limited by shares (société en commandite par action)).
2.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purpose.
3. Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
4. Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a
resolution of the board of managers of the Company.
4.3 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
5. Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand and five hundred euro
(EUR 12,500) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares having a nominal value of one euro (EUR
1) each.
6. Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by a decision of the general meeting of the shareholders in accordance with article 15 of these articles of
association.
7. Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
8. Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is
admitted per share. Joint co-owners have to appoint a single representative towards the Company.
9. Art. 9. Transfer of shares.
9.1 In case the Company has only one shareholder, the shares held by the sole shareholder are freely transferable.
9.2 In case the Company has several shareholders, any transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised
by the general meeting of shareholders who represent at least three-quarters of the share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among shareholders.
9.3 Any transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
9.4 The requirements of articles 189 and 190 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(the 1915 Act) will apply to the transfer of shares.
94831
L
U X E M B O U R G
10. Art. 10. Redemption of shares.
10.1 The Company shall have the power to acquire shares of its own share capital, provided that the Company has
sufficient distributable reserves and funds to that effect.
10.2 The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue
of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting
of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association of
the Company shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.
11. Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of
civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
12. Art. 12. Management.
12.1 The Company is managed by at least three managers forming a board of managers. The managers need not to be
shareholders. The managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders,
adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
12.2 The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace any
of the managers.
12.3 In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name and on behalf of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects provided
that the terms of this article 12 have been complied with.
12.4 All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the power of the board of managers.
12.5 The Company shall be bound by the joint signature of any two managers.
12.6 Any two manager may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The delegating
managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation
and any other relevant conditions of his agency.
12.7 The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented
at a meeting of the board of managers.
12.8 A chairman pro tempore may be appointed by the board of managers for each meeting of the board of managers.
The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed.
The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers
present or represented at the board meeting.
12.9 In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all
managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set
for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by the
chairman or any two managers jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if
they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
12.10 A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic
mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by
conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the
meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference
or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such
meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board
of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the
managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain
attached to the minutes of the relevant meeting.
12.11 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which
case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every
manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers
held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
13. Art. 13. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company.
14. Art. 14. General meetings of the shareholder(s).
14.1 An annual general meeting of the shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such
other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.
14.2 Other general meetings of the shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
94832
L
U X E M B O U R G
14.3 As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
15. Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority.
15.1 The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.
15.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions regardless of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital of
the Company.
15.3 However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the 1915 Act.
16. Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.
17. Art. 17. Financial statements.
17.1 Each year as at the end of the financial year, the Company's balance sheet and the profit and loss statement are
established under the responsibility of the board of managers.
17.2 Each shareholder may inspect the balance sheet and the profit and loss statement at the Company's registered
office.
18. Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s)
on a pro rata basis in proportion to his (their) share holding in the Company. The board of managers may decide to pay
interim dividends.
19. Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders(s) or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine his (their) powers and remu-
neration.
20. Art. 20. Auditor. In accordance with article 200 of the 1915 Act, the Company needs only to be audited by a
statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever
the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies
register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
21. Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the 1915 Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes to twelve thousand
and five hundred (12,500) shares representing the total share capital of the Company.
All these shares have been fully paid-up by Algebris Investments (UK) LLP, prenamed, by payment in cash, so that the
amount of twelve thousand and five hundred EUR (EUR 12,500) paid by Algebris Investments (UK) LLP is from now on
at the free disposal of the Company, proof of which has been duly given to the officiating notary.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2015.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company
has herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers of the Company is set at three (3);
2. the meeting appoints as members of the board of managers of the Company for an unlimited period of time:
- Massimo Paolo Gentili, Managing Partner, born on 10 July 1963 in Milan, Italy, whose professional address is at 11,
rue Beatrix Bourbon, L-1225 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
94833
L
U X E M B O U R G
- Keith Burman, Independent Director, born on 6 March 1970 in Cape Town, South Africa, whose professional address
is at 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Alexander Lasagna, Chief Operating Officer, born on 21 August 1968 in La Spezia, Italy, whose professional address
is at 7 Clifford Street, London, W1S 2FT.
3. the registered office of the Company is established at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le seize juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Algebris Investments (UK) LLP, une société constituée en vertu des lois de l’Angleterre et de Wales, ayant son siège
social à 7 Clifford Street, London, W1S 2FT, Angleterre, inscrite au Companies House, sous le numéro OC319392,
ici représentée par Lisa Klemann, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter
ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée constituée par le présent acte.
1. Art. 1
er
. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Algebris NPL Partnership
GP, S.à r.l." (ci-après, la Société).
2. Art. 2. Objet social.
2.1 La Société peut agir en tant qu'associé commandité de, et prendre des intérêts d'associé commandité dans, toute
société en commandite (sous forme soit de sociétés en commandite simple, soit de sociétés en commandite spéciale, soit
de sociétés en commandite par actions.
2.2 La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l’accomplissement et le développement de son objet.
3. Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4. Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée
générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l’intérieur de la commune par une décision du conseil de
gérance de la Société.
4.3 La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du Grand-Duché de Luxembourg ainsi
qu'à l’étranger.
5. Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500)
représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.
6. Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de
l’associé unique sinon de l’assemblée des associés, conformément à l’article 15 des présents statuts.
7. Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des
parts existantes, de l’actif social ainsi que des bénéfices.
8. Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu'un
seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter
auprès de la Société par une seule et même personne.
9. Art. 9. Transfert de parts sociales.
9.1 Lorsque la Société a un associé unique, toutes les cessions des parts sociales détenues par l’associé unique sont
libres.
94834
L
U X E M B O U R G
9.2 En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée
par l’assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
9.3 La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux associés survivants.
9.4 Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la Loi de 1915) doivent être respectées en ce qui concerne le transfert de parts sociales.
10. Art. 10. Rachat de parts sociales.
10.1 La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves
distribuables ou des fonds suffisants.
10.2 L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne
pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée
générale de l’associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts
de la Société en vertu de l’article 15 des présents statuts sont d'application.
11. Art. 11. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture
de l’associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.
12. Art. 12. Gérance.
12.1 La Société est gérée par au moins trois gérants qui formeront un conseil de gérance. Les gérants n'ont pas besoin
d'être associés. Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l’assemblée générale des associés, par une résolution
adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
12.2 L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et
remplacer n'importe lequel des gérants.
12.3 Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société
en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société
et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.
12.4 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du conseil de gérance.
12.5 La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants quelconques.
12.6 Deux gérants quelconques pourront déléguer leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs
mandataires ad hoc. Les gérants qui déléguent détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le
mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce
mandat.
12.7 Les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le
conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou
représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
12.8 Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion
du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance
pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des
gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.
12.9 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel
(e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du
conseil de gérance pourra être convoquée par le président ou deux gérants conjointement. On pourra passer outre cette
convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de
l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une
heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
12.10 Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre
gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence télé-
phonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui
prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance
par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait
référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance,
si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
12.11 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par
voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une
réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
94835
L
U X E M B O U R G
13. Art. 13. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation per-
sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
14. Art. 14. Assemblées générale des associés.
14.1 Une assemblée générale annuelle de l’associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à
tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l’assemblée.
14.2 D'autres assemblées générales de l’associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
14.3 Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l’associé unique ou des associés
pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypo-
thèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque
associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
15. Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité.
15.1 L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
15.2 En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre
de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
15.3 Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l’accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
16. Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
17. Art. 17. Comptes annuels.
17.1 Chaque année à la fin de l’année sociale, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
17.2 Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
18. Art. 18. Distribution des bénéfices, réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,
déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du
capital social. L'assemblée générale décide de l’affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.
19. Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
20. Art. 20. Commissaire aux comptes - Reviseur d'entreprises. Conformément à l’article 200 de la Loi de 1915, la
Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un
réviseur d'entreprises doit être nommé si l’exemption prévue à l’article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas appli-
cable.
21. Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés
s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de cette Société ayant ainsi été établis, la partie comparante déclare qu'elle souscrive douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales représentant la totalité du capital social de la Société.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en numéraire par la société Algebris Investments
(UK) LLP, prénommée, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) payée par la société Algebris
Investments (UK) LLP est désormais à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au notaire instru-
mentant.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.200.-.
94836
L
U X E M B O U R G
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution, l’unique associé représentant la totalité du capital souscrit a pris les résolutions
suivantes:
1. les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois (3).
2. L’assemblée nomme en tant que membres du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée:
- Massimo Paolo Gentili, Associé gérant, né le 10 juillet 1963 à Milan, Italie, dont l’adresse professionnelle est à 11, rue
Beatrix Bourbon, L-1225 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Keith Burman, Directeur Indépendant, né le 6 mai 1970 au Cap, Afrique du Sud dont l’adresse professionnelle est à
24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Alexander Lasagna, Chief operating Officer, né le 21 août 1968 à La Spezia, Italie, dont l’adresse professionnelle est
à 7 Clifford Street, Londres, W1S 2FT.
3. le siège social de la société est établi à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante,
le présent acte est établi en anglais, suivi d'une traduction française. A la requête de cette même partie comparante, et
en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaut.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, qui sont connues du notaire par leurs prénoms,
noms, états et demeures, lesdites parties comparantes ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. KLEMANN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juillet 2014. Relation: LAC/2014/33677. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2014.
Référence de publication: 2014107302/350.
(140129144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.
Xylem IP Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1259 Senningerberg, 11, Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 180.077.
Die Geschäftsführer der
Xylem Technologies Austria GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht mit dem
Sitz in Stockerau, Österreich, und der Geschäftsanschrift Ernst Vogel-Straße 2, 2000 Stockerau, Österreich, eingetragen
im Firmenbuch des Landesgerichts Korneuburg zu FN 59353i („Übertragende Gesellschaft“);
und der
Xylem IP Management S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Großherzogtums Lu-
xemburg mit Gesellschaftssitz in 11, Breedewues, L-1259 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im
Handelsregister Luxemburg unter Handelsregisternummer B 180077 („Übernehmende Gesellschaft“, gemeinsam mit der
Übertragenden Gesellschaft, die „Gesellschaften“)
vereinbaren hiermit den folgenden Verschmelzungsplan:
<i>Präambeli>
(A) Das Stammkapital der Übertragenden Gesellschaft im Nominale von EUR 2.107.512,20 wird zur Gänze von der
Übernehmenden Gesellschaft gehalten. Diese ist daher Alleingesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft..
(B) Die Xylem-Gruppe hat beschlossen, die in der Übertragenden Gesellschaft gebündelten, auf die österreichischen
Konzerngesellschaften entfallenden Immaterialgüterrechte auf die Übernehmende Gesellschaft zu übertragen.
(C) Es ist daher beabsichtigt, die Übertragende Gesellschaft grenzüberschreitend auf die Übernehmende Gesellschaft
zu verschmelzen. Nach Durchführung der Verschmelzung werden sämtliche IP-Rechte bei der Übernehmenden Gesell-
schaft zusammengefasst sein und von dieser verwaltet werden.
Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien Folgendes:
1. Definitionen und Hinweise.
1.1 Begriffsbestimmungen
Sämtliche Begriffsbestimmungen in diesem Vertrag haben die ihnen nachstehend bzw. an den entsprechenden Stellen
im Vertrag beigelegte Bedeutung:
94837
L
U X E M B O U R G
„AktG“
bezeichnet das österreichische Aktiengesetz.
„EU-VerschG“
bezeichnet das österreichische Gesetz über die grenzüberschreitende Verschmelzung von
Kapitalgesellschaften in der Europäischen Union (EU-Verschmelzungsgesetz).
„GmbHG“
bezeichnet das österreichische GmbH-Gesetz.
„1915 Gesetz“
bezeichnet das Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 betreffend Gesellschaften.
2. Rechtsform, Firma und Sitz der Gesellschaften. Die Xylem Technologies Austria GmbH (Übertragende Gesellschaft)
ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht mit dem Sitz in Stockerau, Österreich, und
der Geschäftsanschrift in Ernst Vogel-Straße 2, 2000 Stockerau, Österreich. Die Übertragende Gesellschaft ist im Fir-
menbuch des Landesgerichts Korneuburg zu FN 59353i eingetragen.
Xylem IP Management S.à r.l. (Übernehmende Gesellschaft) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Gesellschaftssitz in 11, Breedewues, L-1259 Senningerberg, Großherzogtum
Luxemburg, Die Übernehmende Gesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter Handelsregisternummer B180077
eingetragen.
Keine der Gesellschaften hat einen Aufsichtsrat.
Keine der Gesellschaften befindet sich in Liquidation, wurde für insolvent erklärt oder ihr ein Zahlungsaufschub ge-
währt.
3. Übertragung von vermögenswerten Mittels grenzüberschreitender Verschmelzung. Die Gesellschaften vereinbaren
hiermit eine grenzüberschreitende Verschmelzung, als deren Ergebnis die Übertragende Gesellschaft auf die Überneh-
mende Gesellschaft auf Grundlage dieses Verschmelzungsplans sowie nach Maßgabe der anwendbaren gesetzlichen
Bestimmungen durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes, einschließlich aller Rechte und Pflichten, im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge verschmolzen wird.
Mit Wirksamkeit der Verschmelzung durch deren Eintragung im Luxemburger Handelsregister gehen sämtliche Ver-
mögenswerte, Rechte, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der Übertragenden Gesellschaft im Wege der Gesam-
trechtsnachfolge auf die Übernehmende Gesellschaft über. Die Übertragende Gesellschaft erlischt ohne Abwicklung
(Liquidation).
Die übertragenen Vermögenswerte (einschließlich aller Rechte, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten), insbesondere
die Immaterialgüterrechte, haben einen positiven Verkehrswert.
Die Gesellschaften bestätigen und vereinbaren, dass die Übernehmende Gesellschaft aus Anlass dieser grenzübers-
chreitenden Verschmelzung alle Vermögenswerte, Rechte, Verbindlichkeiten und (allfällige) Verpflichtungen übernimmt,
einschließlich Rechte aus Verträgen und laufenden und wiederkehrenden Verpflichtungen. Die Übernehmende Gesell-
schaft ist daher berechtigt, sämtliche entsprechenden Rechte in ihrem eigenen Namen auszuüben und durchzusetzen, und
kann daher alle Registrierungen und Eintragungen jeder Art bei Gerichten und Behörden beantragen, sofern solche Rechte
mit Wirksamkeit der Verschmelzung nicht ohnehin im Wege der Gesamtrechtsnachfolge übertragen werden.
4. Nominalkapital und Beteiligungsstruktur. Ausgabe neuer Gesellschaftsanteile der Übernehmenden Gesellschaft. Das
Stammkapital der Übertragenden Gesellschaft beträgt EUR 2.107.512,20. Das Stammkapital der Übernehmenden Ge-
sellschaft beträgt EUR 12.500,00.
Sämtliche Anteile der Übernehmenden Gesellschaft und der Übertragenden Gesellschaft sind zur Gänze einbezahlt.
Sie sind weder mit Fruchtgenuss- noch mit Pfandrechten belastet.
Die Übernehmende Gesellschaft hält sämtliche Anteile an der Übertragenden Gesellschaft. Somit werden keine Anteile
an der Übernehmenden Gesellschaft eingezogen oder ausgegeben, und die Bestimmungen gemäß § 5 Abs 3 EU-VerschG
und Art. 278 und folgende des 1915 Gesetzes sind auf die beabsichtigte Verschmelzung anwendbar.
Der Verschmelzungsplan enthält daher keine Angaben über (i) das Umtauschverhältnis von Gesellschaftsanteilen oder
die Höhe barer Zuzahlungen im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Verschmelzung (§ 5 Abs 2 Z 2 EU-
VerschG), (ii) Einzelheiten hinsichtlich der Gewährung von Anteilen an der Übernehmenden Gesellschaft (§ 5 Abs 2 Z 3
EU-VerschG) oder (iii) den Zeitpunkt, ab dem solche Anteile ihren Inhabern das Recht auf eine Beteiligung am Gewinn
gewähren sowie allfällige Besonderheiten, die Auswirkungen auf dieses Recht haben (§ 5 Abs 2 Z 5 EUVerschG).
Da die Übernehmende Gesellschaft Alleingesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft ist, können ebenfalls Anga-
ben zur Barabfindung, die einem widersprechenden Gesellschafter für die Hingabe seiner Anteile angeboten wird, entfallen
(§ 5 Abs 4 EU-VerschG).
Die Anteile an der Übertragenden Gesellschaft gehen infolge der grenzüberschreitenden Verschmelzung gemäß ös-
terreichischem Recht unter.
5. Relevante Bilanzen, Stichtag, Firmenwert und ausschüttungsfähige Rücklagen. Das Geschäftsjahr der Übertragenden
Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr und endet sohin am 31. Dezember. Der letzte genehmigte Jahresabschluss der
Übertragenden Gesellschaft wurde zum 31. Dezember 2013 erstellt und wird von der Gesellschafterversammlung der
Übertragenden Gesellschaft vor Fassung des Verschmelzungsbeschlusses genehmigt werden.
94838
L
U X E M B O U R G
Das Geschäftsjahr der Übernehmenden Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr und endet somit am 31. Dezember.
Der letzte genehmigte Jahresabschluss der Übernehmenden Gesellschaft wurde zum 31. Dezember 2013 erstellt und von
der Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft am 15. Juli 2014 genehmigt.
Die grenzüberschreitende Verschmelzung erfolgt auf Basis des (geprüften) Jahresabschlusses der Übertragenden Ge-
sellschaft zum 31. Dezember 2013 als unternehmensrechtliche Schlussbilanz, aus welcher die übertragenen Vermögens-
gegenstände und Verbindlichkeiten der Übertragenden Gesellschaft sowie die jeweiligen Bewertungen hervorgehen. Die
in der Schlussbilanz enthaltenen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind zu Buchwerten bewertet. Die Über-
nehmende Gesellschaft wird diese Bewertung fortführen.
Der Verschmelzungsstichtag gemäß § 5 Abs 2 Z 6 EU-VerschG ist der 31. Dezember 2013 (24:00 Uhr MEZ) („Stichtag“).
Ab dem 1. Januar 2014 (00:00 Uhr MEZ) gelten alle Handlungen der Übertragenden Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt
der Rechnungslegung und des Ertragssteuerrechts als für Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft vorgenommen und
sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sowie sämtliche sonstigen Rechte und Verpflichtungen der
Übertragenden Gesellschaft als auf die Übernehmende Gesellschaft übergegangen.
Der erste Jahresabschluss der Übernehmenden Gesellschaft nach erfolgter grenzüberschreitender Verschmelzung
wird sich somit auf das Geschäftsjahr beziehen, das mit 1. Januar 2014 (0.00 Uhr) begonnen hat.
Die grenzüberschreitende Verschmelzung wird für Zwecke der Rechnungslegung und des Ertragssteuerrechts mit
Wirksamkeit zum Stichtag durchgeführt. Ab dem Stichtag werden die Finanzdaten der Übertragenden Gesellschaft im
Jahresabschluss der Übernehmenden Gesellschaft ausgewiesen.
Aus Perspektive der Rechnungslegung hat die grenzüberschreitende Verschmelzung keine Auswirkungen auf den Fir-
menwert und die ausschüttungsfähigen Rücklagen der Übernehmenden Gesellschaft.
Die Jahresabschlüsse der Übertragenden Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2011, 2012 und 2013 sowie der Jahre-
sabschluss der Übernehmenden Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 werden ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieses Verschmelzungsplans oder seines Entwurfs bei der Übertragenden Gesellschaft (Ernst Vogel-Straße 2, 2000 Stoc-
kerau, Österreich) und der Übernehmenden Gesellschaft (11, Breedewues, L-1259 Senningerberg, Großherzogtum
Luxemburg) zur Einsicht aufliegen. Der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss der Übertra-
genden Gesellschaft zum Geschäftsjahr 2013 liegt noch nicht vor und wird der Firmenbuchanmeldung der beabsichtigten
Verschmelzung als Anlage beigeschlossen werden. Die Übernehmende Gesellschaft wurde zum 10.09.2013 gegründet,
weshalb nur der Jahresabschluss der Übernehmenden Gesellschaft zum 31.12.2013 besteht und offengelegt werden kann.
6. Mögliche Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer.
6.1. Mögliche Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer
Gegenwärtig beschäftigt die Übernehmende Gesellschaft fünf Teilzeitmitarbeiter. Die Übertragende Gesellschaft hat
(aus arbeitsrechtlicher Sicht) keine Arbeitnehmer. Die Gesellschaften verfügen über keinen Betriebsrat.
Die Durchführung der grenzüberschreitenden Verschmelzung hat keine Auswirkungen auf die Arbeitnehmer der
Übernehmenden Gesellschaft. Sie werden weiterhin und zu denselben Bedingungen bei der Übernehmenden Gesellschaft
beschäftigt sein. Insbesondere wird die grenzüberschreitende Verschmelzung nicht zum Abbau von Arbeitnehmern der
Übernehmenden Gesellschaft führen. Sämtliche Mitarbeiter wurden ordnungsgemäß über die grenzüberschreitende
Verschmelzung informiert.
Darüber hinaus führt die grenzüberschreitende Verschmelzung an sich zu keiner Änderung der vor dem Zeitpunkt
der Verschmelzung bei der Übernehmenden Gesellschaft bestehenden betrieblichen Struktur.
Die sozialen Aspekte der grenzüberschreitenden Verschmelzung, ebenso wie ihre rechtlichen und wirtschaftlichen
Aspekte, werden in einem gemeinsamen Verschmelzungsbericht der Gesellschaften nach österreichischem und luxem-
burgischem Recht näher erläutert werden.
6.2. Verfahren zur Regelung der Beteiligung von Arbeitnehmern
Da bei keiner der Gesellschaften die Arbeitnehmer und/oder deren Vertretungsorgane und/oder deren Vertreter
berechtigt sind, Mitglieder der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrats zu wählen oder zu bestellen, oder die Bestellung
von Mitgliedern der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrats zu empfehlen oder abzulehnen, sind die Verfahren zur
Regelung der Beteiligung von Arbeitnehmern an grenzüberschreitenden Verschmelzungen auf die gegenständliche gren-
züberschreitende Verschmelzung nicht anwendbar.
7. Mögliche Folgen der Verschmelzung für die Gläubiger.
7.1. Österreich
Der vorliegende Verschmelzungsvorgang verwirklicht einen sogenannten kapitalherabsetzenden Effekt, da das gebun-
dene Kapital (bestehend aus Stammkapital und gebundenen Rücklagen) der Übertragenden Gesellschaft (EUR
2.107.512,20) jenes der Übernehmenden Gesellschaft, wie es nach der Verschmelzung besteht (EUR 12.500,00), übers-
teigt.
Gläubigern der Übertragenden Gesellschaft, die sich binnen zwei Monaten nach dem Tag, an dem der Verschmel-
zungsplan bekannt gemacht worden ist, schriftlich zu diesem Zweck melden, können nach Maßgabe der nachstehenden
Eckpunkte Befriedigung oder Sicherstellung ihrer Forderungen verlangen (Gläubigerschutz ex ante).
94839
L
U X E M B O U R G
Anspruchsberechtigt sind alle Gläubiger, deren Forderungen gegenüber der Xylem Technologies Austria GmbH bis
zum Ende der Zweimonatsfrist entstanden sind / entstehen.
Ob die Forderung auf Vertrag oder Gesetz beruht, ist unerheblich. Sicherzustellen sind aber nur schuldrechtliche
Ansprüche, nicht dingliche Rechte.
Sicherstellungsfähig sind nur Forderungen, die bereits (dem Grunde nach) entstanden sind, für die jedoch noch nicht
Befriedigung verlangt werden kann. Dies betrifft etwa noch nicht fällige oder aufschiebend bedingte Forderungen. Für
fällige und unbedingte Forderungen kann nur Befriedigung verlangt werden. Ein zusätzlicher Sicherstellungsanspruch bes-
teht nicht und zwar auch dann nicht, wenn die Befriedigung verweigert oder die Forderung bestritten wird.
Die Gläubiger der Übertragenden Gesellschaft müssen ihre Forderungen dem Grunde und der Höhe nach zum Zwecke
der Sicherheitsleistung innerhalb von zwei Monaten bei der Übertragenden Gesellschaft anmelden. Die Meldung hat
schriftlich zu erfolgen und muss der Übertragenden Gesellschaft innerhalb dieser Frist zugehen. Eine Absendung am letzten
Tag dieser Frist genügt nicht. Eine Klageerhebung ist nicht erforderlich. Der Ablauf der Frist nimmt dem Gläubiger zwar
den Sicherstellungsanspruch, der Anspruch auf die Forderung selbst bleibt aber unberührt.
Einer Glaubhaftmachung oder Bescheinigung der Gesellschaftsgläubiger, dass durch die grenzüberschreitende Versch-
melzung die Erfüllung ihrer Forderung gegenüber der Übertragenden Gesellschaft gefährdet wird, bedarf es nicht.
Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht jedoch solchen Gläubigern nicht zu, die im Fall des Insolvenzverfah-
rens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichteten und
behördlich überwachten Deckungsmasse haben.
Darüber hinaus ist Gläubigern der übertragenden Xylem Technologies Austria GmbH, die sich binnen sechs Monaten
nach der Veröffentlichung der Eintragung der Verschmelzung (Löschung der Übertragenden Gesellschaft) schriftlich zu
diesem Zweck melden, für ihre bis zu diesem Datum entstehenden Forderungen Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht
Befriedigung verlangen können (Gläubigerschutz ex post).
Anspruchsberechtigt sind alle Gläubiger, deren Forderungen gegenüber der Xylem Technologies Austria GmbH bis
zur Offenlegung der Eintragung der Löschung der Übertragenden Gesellschaft im Firmenbuch des Landesgerichts Kor-
neuburg dem Grunde nach entstanden sind.
Maßgeblich ist nicht die Eintragung im Firmenbuch sondern die Offenlegung in der Ediktsdatei, die gemäß § 10 Unter-
nehmensgesetzbuch (UGB) vom Gericht veranlasst wird.
Der Anspruch auf Sicherheitsleistung besteht nur für Gläubiger, die sich binnen der Präklusivfrist von sechs Monaten
nach Veröffentlichung der Eintragung der Verschmelzung (Löschung der Übertragenden Gesellschaft) bei der Überneh-
menden Gesellschaft (Adresse: 11, Breedewues, L-1259 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg) melden.
Dieses Recht auf Sicherstellung steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Versch-
melzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird Betreffend die übrigen Grundsätze ist auch im Zusammenhang mit
dem Gläubigerschutz ex post auf die zum Gläubigerschutz ex ante dargestellten Eckpunkte zu verweisen.
7.2. Luxemburg
Gläubigern der Übernehmenden Gesellschaft, die sich innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag, ab dem die Beschlüsse
der Gesellschafterversammlung, die über die Zustimmung zur Verschmelzung beschließt, veröffentlicht wurden, zu diesem
Zweck melden, ist gemäß Artikel 268 des 1915 Gesetzes für ihre bis dahin entstandenen Forderungen Sicherheit zu leisten.
Die Meldung hat beim Präsidenten des für Handelssachen zuständigen Luxemburger Bezirksgerichts zu erfolgen.
Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die
Erfüllung ihrer Forderungen gegenüber der Übernehmenden Gesellschaft gefährdet wird und die Übernehmende Gesell-
schaft keine angemessene Sicherstellung angeboten hat.
Die Auswirkungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die Gläubiger der verschmelzungsbeteiligten Ge-
sellschaften werden in einem gemeinsamen Verschmelzungsbericht der Gesellschaften nach österreichischem und
luxemburgischem Recht näher erläutert. Ausführliche Informationen erhalten die Gläubiger darüber hinaus in den Büro-
räumlichkeiten der Übertragenden Gesellschaft (Adresse: Ernst Vogel-Straße 2, 2000 Stockerau, Österreich) und der
Übernehmenden Gesellschaft (Adresse: 11, Breedewues, L-1259 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg).
8. Geschäftsführung, Aufsichtsrat. Keine der Gesellschaften hat einen Aufsichtsrat. Die Geschäftsführung der Über-
nehmenden Gesellschaft hat beschlossen, dem gegenständlichen Verschmelzungsplan seine Genehmigung zu erteilen.
Es ist nicht geplant, die Zusammensetzung der Geschäftsführung der Übernehmenden Gesellschaft im Zusammenhang
mit der grenzüberschreitenden Verschmelzung zu ändern.
Im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Verschmelzung werden den Geschäftsführern der Gesellschaften
oder anderen den Gesellschaften nahe stehenden Personen (zB Aufsichts- oder Kontrollorgane, Abschlusssprüfer) kei-
nerlei Begünstigungen oder besondere Vorteile im Sinne von § 5 Abs 2 Z 8 EU-VerschG gewährt.
9. Besondere Rechte und Genehmigungen, besondere Vorteile. Es gibt keine Personen, denen als Gesellschafter oder
in einer anderen Eigenschaft (z.B. als Inhaber von Wertpapieren) gegenüber den Gesellschaften Sonderrechte nach
Maßgabe von § 5 Abs 2 Z 7 EU-VerschG zustehen.
Demgemäß werden (auch im Rahmen der grenzüberschreitenden Verschmelzung) keine (Sonder-)Rechte im Sinne von
§ 5 Abs 2 Z 7 EU-VerschG gewährt und keine Maßnahmen im Sinne dieser Bestimmung ergriffen.
94840
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschaftsverträge der Gesellschaften normieren betreffend die grenzüberschreitende Verschmelzung keine
Genehmigungsvorbehalte seitens der Gesellschafterversammlungen der Gesellschaften.
10. Gesellschaftsvertrag. Der Gesellschaftsvertrag der Übernehmenden Gesellschaft in der aktuellen Fassung ist als
Beilage 1 beigeschlossen.
Nach erfolgter Verschmelzung wird keine Änderung des Gesellschaftsvertrags der Übernehmenden Gesellschaft er-
folgen.
11. Formalitäten und Ablauf. Nach Aufstellung des Verschmelzungsplans sowie seiner Veröffentlichung wird die Ge-
neralversammlung der Übertragenden Gesellschaft über die grenzüberschreitende Verschmelzung und die Genehmigung
des Verschmelzungsplans beschließen. Anschließend (frühestens zwei Monate nach Veröffentlichung der Einreichung des
Verschmelzungsplans zum Firmenbuch oder seiner Veröffentlichung in der Ediktsdatei) ist die beabsichtigte Verschmel-
zung beim Firmenbuch des Landesgerichts Korneuburg anzumelden und die Ausstellung der Rechtmäßigkeitsbescheini-
gung über die ordnungsgemäße Erledigung aller der grenzüberschreitenden Verschmelzung vorangehenden Rechtshand-
lungen und Formalitäten in Österreich zu beantragen.
Nach Ausstellung der Rechtmäßigkeitsbescheinigung wird der von der Übernehmenden Gesellschaft bestellte luxem-
burgische Notar die Rechtmäßigkeit der grenzüberschreitenden Verschmelzung prüfen und eine Verschmelzungsbestä-
tigung ausstellen. Nach erfolgter Bestätigung durch den Luxemburger Notar wird der Verschmelzungsbeschluss durch
den Notar beim Luxemburger Handelsregister hinterlegt und im Mémorial veröffentlicht. Die grenzüberschreitende
Verschmelzung wird mit der Veröffentlichung des Gesellschafterbeschlusses im Mémorial aus Sicht österreichischen und
luxemburgischen Rechts rechtswirksam. Nach Rechtswirksamkeit der Verschmelzung wird das Luxemburger Handels-
register das Landesgericht Korneuburg davon in Kenntnis setzen.
Nach Vollzug der Verschmelzung in Luxemburg wird die Übernehmende Gesellschaft die Durchführung der Versch-
melzung sowie die Löschung der Übertragenden Gesellschaft zum Firmenbuch des Landesgerichts Korneuburg anmelden.
Die nähere Erläuterung des vorliegenden Verschmelzungsplans sowie der rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen
Aspekte der grenzüberschreitenden Verschmelzung in Österreich und Luxemburg erfolgt in einem Verschmelzungsbe-
richt gemäß § 6 EU-VerschG. Dieser Verschmelzungsbericht wird in den Büroräumlichkeiten (i) der Übertragenden
Gesellschaft, Ernst Vogel-Straße 2, 2000 Stockerau, Österreich, sowie (ii) der Übernehmenden Gesellschaft, 11, Bree-
dewues, L-1259 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, zur Einsichtnahme aufliegen.
12. Vollmacht. Die Gesellschaften bevollmächtigen (i) Herrn Dr. Nikolaus Adensamer, Rechtsanwalt, geboren am 29.
Januar 1976, und (ii) Kerschbaum Partner Rechtsanwälte GmbH, FN 273656k, jeweils einzelvertretungsbefugt, sämtliche
Änderungen zu diesem Verschmelzungsplan, einschließlich solcher in Notariatsaktsform oder sonstiger notarieller Form,
durchzuführen und alle Dokumente, Protokolle, Erklärungen und Abänderungen auch in notarieller Form zu unterzeich-
nen sowie alle Handlungen auch gegenüber österreichischen Behörden, Gerichten und öffentlichen Registern, die sie im
Zusammenhang mit der Übertragung des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft
für erforderlich erachten, insbesondere, aber nicht beschränkt darauf, im Zusammenhang mit dem Erhalt der Rechtmäßig-
keitsbescheinigung und der Eintragung der beabsichtigten und der Durchführung der grenzüberschreitenden Verschmel-
zung einschließlich der Löschung der Übertragenden Gesellschaft im österreichischen Firmenbuch oder in einem anderen
öffentlichen Register in Österreich.
Die Bevollmächtigten sind berechtigt, die Bevollmächtigung (ganz oder teilweise) an Dritte zu übertragen. Sie sind
weiters zu Doppel- oder Mehrfachvertretungen berechtigt.
13. Allgemeine Bestimmungen. Alle Kosten, Steuern und Gebühren, die im Zusammenhang mit der Unterzeichnung
und Durchführung dieses Verschmelzungsplans entstehen, werden von der Übernehmenden Gesellschaft getragen.
Sollte eine Bestimmung dieses Verschmelzungsplans ganz oder teilweise ungültig oder undurchführbar sein oder wer-
den, berührt dies nicht die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen. In diesem Fall verpflichten
sich die Gesellschaften, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine gültige oder durchführbare Bes-
timmung zu ersetzen, die in ihrem wesentlichen Gehalt der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst
nahe kommt. Das Gleiche gilt analog für etwaige Lücken in diesem Verschmelzungsplan.
Alle Anlagen zu diesem Verschmelzungsplan sind seine integrierten Bestandteile. Sofern sich aus dem Kontext des
Verschmelzungsplans nichts Gegenteiliges ergibt, sind alle Verweise auf den Verschmelzungsplan auch als Verweise auf
seine Anlagen auszulegen.
Dieser Verschmelzungsplan wurde im Hinblick auf die Einhaltung der Erfordernisse für grenzüberschreitende Versch-
melzungen sowohl nach österreichischem als auch nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg erstellt.
Dieser Verschmelzungsplan wird in Form eines Notariatsakts in einem Original errichtet, das von dem beurkundenden
österreichischen Notar aufbewahrt wird. Die Gesellschaften und deren Geschäftsführer, Rechtsnachfolger sowie der-
zeitige und künftige Gesellschafter sind berechtigt, auf eigene Kosten beglaubigte Abschriften dieser Urkunde von dem
diesen Notariatsakt errichtenden Notar zu erhalten.
94841
L
U X E M B O U R G
Stockerau, den 24. Juli 2014.
<i>Für Xylem Technologies Austria GmbH
i>Mag. Konstantin Kolonja
<i>Geschäftsführeri>
Senningerberg, den 24. Juli 2014.
<i>Für Xylem IP Management S.à r.l.
i>Pascale Wagner und Danielle Kolbach
<i>Geschäftsführeri>
Gesellschaftsvertrag der übernehmenden Gesellschaft
Chapter I. Name - Duration - Object - Registered office
Art. 1. Name and Duration. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under
Luxembourg law by the name of Xylem IP Management S.à r.l. (hereafter the Company).
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly
to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control
and development of those participations.
The Company may apply for, register, purchase or by other mean, acquire, and protect, allocate, extend and renew,
whether in Luxembourg or elsewhere any patents, licences, trade marks, or any other intellectual property and intangible
rights. It may further sell, improve, manage, develop, exchange, license, share or otherwise enhance the patents, licences,
trade marks, or any other intellectual property and intangible rights.
The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they
may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees.
The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favors the realization of
its objects.
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the municipality of Niederanven.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and
abroad.
Chapter II. Corporate capital.
Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
represented by five hundred (500) ordinary shares having a par value of twenty five Euro (EUR 25.-) per share.
The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,
by decision of the shareholders' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.
Art. 5. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 6. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-share-
holders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the
shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is
required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the law
on commercial companies dated 10
th
August 1915, as amended (the Law), to acquire shares in its own capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.
94842
L
U X E M B O U R G
Chapter III. Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorized signatories
Art. 8. Management. The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they
constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause)
revoke and replace the manager(s).
The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment
of each of the managers.
Art. 9. Meeting of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the
board.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which
will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days' written notice
of board meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means
of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other
suitable telecommunication means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present
at the meeting.
Meetings of the board of managers can be held by way of a telephone or video conference. Any and all managers may
participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to be identified, to hear each other and to be able to
speak up in the course of such meeting. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting without that it is required that two managers attend in person to such meeting. All
meetings held by way of telephone or video conference are deemed to be held at the registered office of the Company.
The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or repre-
sented.
Decisions of the board of managers are taken by an absolute majority of the votes cast.
The board of managers may in all instances take resolutions in writing. Resolutions signed by all managers shall be valid
and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.
Art. 10. Representation - Authorized signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with
the Company's objects and further provided the terms of this Article 10 shall be complied with.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of share-
holders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of
managers. In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in
case of plurality of managers, by the joint signatures of any two managers. The shareholders may appoint from among
the members of the board of managers one or several general managers who may be granted the powers to bind the
Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/their powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)' responsibilities
and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/
their agency.
Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as
such commitment is in compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions
of the Law.
The Company may indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
94843
L
U X E M B O U R G
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Chapter IV. Secretary
Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s)
of the Company (the Secretary).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the
board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required. He
shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the
tasks so delegated.
The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be
produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.
Chapter V. General Meetings of Shareholders
Art. 13. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered
office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within six
months after the close of the financial year.
Art. 14. Shareholders' voting rights. Each shareholder may participate in general shareholders' meetings irrespective
of the number of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at share-
holders' meetings.
Art. 15. Quorum - Majority. Resolutions at shareholders' meetings are only validly taken in so far as they are adopted
by a majority of shareholders' owning more than half of the Company's share capital.
However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be
carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by
all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and
shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.
The sole shareholder exercises the powers of the general meeting.
The decisions of the sole shareholder which are taken in the scope of the above paragraph are recorded in minutes
or drawn-up in writing.
Any reference to shareholders' meeting shall mutatis mutandis refer to a resolution passed in writing in the above
form.
Chapter VI. Financial year - Financial statement - Profit sharing
Art. 16. Financial year. The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of
the same year.
Art. 17. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the
board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 18. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts
at the Company's registered office.
Art. 19. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The
general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim divi-
dends.
Chapter VII. Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause
the dissolution of the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of these
Articles of Association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.
94844
L
U X E M B O U R G
Art. 21. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and re-
muneration.
Chapter VIII. Audit
Art. 22. Statutory Auditor - External Auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be
audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever
the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.
Chapter IX. Governing law
Art. 23. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no
specific provision is made in these Articles of Association.
The present deed is worded in English, followed by a German version. In case of discrepancies between the English
and the German text, the English version will be prevailing.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausend und dreizehn, am zehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
„Xylem Water Solutions Manufacturing AB“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung schwedischen Rechts, mit
Geschäftssitz in 361 80 Emmaboda, Schweden, einem Stammkapital von SEK 50,000,000 und beim schwedischen Ge-
schäftsregister (Bolagsverket) unter Nummer 556010-9422 eingetragen
hier vertreten durch Danielle Kolbach, Anwalt, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Emaboda
am 26. August 2013.
Die Vollmacht, wird der vorliegenden Urkunde, nach der Unterzeichnung „ne varietur“ durch die Erschienene und
den unterzeichneten Notar, als Anlage beigeheftet um bei den Registerbehörden zusammen mit der Urkunde eingetragen
zu werden.
Die Erschienene hat in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung der hiermit
gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt aufzusetzen:
Kapitel I. Name - Dauer - Gegenstand - Sitz
Art. 1. Name und Dauer. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) nach luxemburgischen Recht mit der Bezeichnung Xylem IP Management S.à r.l. (nachfolgend die Gesellschaft).
Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft. Gegenstand der Gesellschaft ist die Vornahme aller unmittelbar oder mittelbar
mit dem Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Form in Zusammenhang stehender Geschäfte, sowie die
Verwaltung, die Kontrolle und die Förderung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann in Luxemburg oder anderswo Patente, Lizenzen, Marken und alle anderen geistigen Eigentümer
und immaterielle Vermögenswerte beantragen, anmelden, kaufen oder unter welcher Form auch immer erwerben,
schützen, zuteilen oder verlängern. Deswieten kann die Gesellschaft die Patente, Lizenzen, Marken und alle anderen
geistigen Eigentümer und immaterielle Vermögenswerte verkaufen, veräußern, verbessern, verwalten, entwickeln und
erweitern, austauschen, Lizenzen erteilen, aufteilen oder anders verbessern.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel in Immobilien anlegen; sie kann sie zur Bildung, Verwaltung, Förderung und Veräu-
ßerung ihrer Vermögenswerte in der jeweils bestehenden Zusammensetzung benutzen und insbesondere, jedoch nicht
ausschließlich, in ihren Wertpapierbestand beliebigen Ursprungs anlegen, um sich an der Gründung, Entwicklung und
Beherrschung von Unternehmen zu beteiligen und im Wege von Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Optionen Wert-
papiere und Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, diese durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder unter einer
anderen Form zu veräußern, Lizenzen zur Verwertung von Rechten des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren,
sowie Unternehmen, an denen die Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, sowie Konzernen oder zu deren
Vorteil Unterstützung -einschließlich finanzieller Unterstützung, Darlehen, Vorauszahlungen oder Garantien -zu gewäh-
ren.
Die Gesellschaft kann jede gewerbliche oder wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die der Erreichung des Gesellschafts-
zwecks direkt oder indirekt dient.
Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Niederanven. Der Sitz kann durch Beschluss
der außerordentlichen Generalversammlung ihres Gesellschafters oder -bei mehreren Gesellschaftern -durch Gesell-
schafterbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
94845
L
U X E M B O U R G
Kapitel II. Gesellschaftskapital
Art. 4. Stammkapital. Das Stammkapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500.-) und ist in fünfhundert
(500) ordentliche Geschäftsanteile im Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25.-) eingeteilt.
Das gezeichnete Stammkapital kann durch Beschluß des alleinigen Gesellschafters beziehungsweise durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Beschlussfassung geändert
werden.
Art. 5. Gewinnbeteiligung. Jeder Geschäftsanteil berechtigt nach dem direkten Verhältnis der bestehenden Geschäfts-
anteile zu einem Bruchteil am Gesellschaftsvermögen und -gewinn.
Art. 6. Übertragung von Geschäftsanteilen. Im Falle eines Alleingesellschafters sind die Anteile frei an Dritte, die keine
Gesellschafter sind, übertragbar.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Dritte der
Genehmigung der Generalversammlung, Gesellschafter, die drei Viertel des eingezahlten Kapitals vertreten. Es bedarf
keiner solchen Genehmigung für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern.
Die Genehmigung einer Übertragung im Todesfall bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln des Gesell-
schaftskapitals, welches von den Überlebenden gehalten wird.
Art. 7. Rückkauf von Geschäftsanteilen. Die Gesellschaft ist befugt, vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen
des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das Gesetz) Anteile an
ihrem eigenen Kapital zu erwerben.
Der Erwerb und die Veräußerung von im Stammkapital der Gesellschaft befindlichen Geschäftsanteilen bedürfen eines
Beschlusses, dessen Form und Bedingungen von der Gesellschafterversammlung festzulegen sind.
Kapitel III. Geschäftsführung - Geschäftsführersitzungen - Vertretung - Vertretungsvollmachten
Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern bilden diese die Geschäftsführung. Der/Die Geschäftsführer muß/müssen nicht Gesell-
schafter sein. Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterver-
sammlung ist berechtigt; zu jeder Zeit und ad nutum (ohne Grund) den Rücktritt eines Geschäftsführers zu fordern und
ihn zu ersetzen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Vergütung der Geschäftsführer, sowie die Dauer und Bedingungen für
ihre Bestellung.
Art. 9. Versammlungen - Geschäftsführerversammlungen. Die Geschäftsführerversammlungen können von jedem Ge-
schäftsführer einberufen werden.
Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Geschäftsführerversammlung einberufen. Außer in Dringlichkeitsfällen,
die in der Einberufungsmitteilung zu spezifizieren sind, oder außer bei vorheriger Genehmigung aller Geschäftsführer soll
der Einberufung eine mindestens achttägige Einberufungsfrist vorhergehen.
Die Versammlung kann ordnungsgemäß abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß
vertreten sind.
Die Versammlungen finden an dem Ort, an dem Tage und zu der Zeit statt, die in der Einberufung festgelegt sind.
Die Geschäftsführer können mittels schriftlicher Genehmigung, mittels Telefax oder in der jeweils geeigneten Kom-
munikationsform auf die Einberufung verzichten. Eine separate Einberufung ist nicht nötig, wenn Zeit und Ort der
Versammlungen im Rahmen eines zuvor durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Terminplans festgelegt wurden.
Jeder Geschäftsführer kann sich auf den Geschäftsführerversammlungen durch einen schriftlich, mittels Telefax oder
anderer geeigneter Kommunikationsmittel von ihm ernannten Bevollmächtigten vertreten lassen.
Ein Geschäftsführer kann mehrere seiner Kollegen vertreten; es müssen jedoch wenigstens zwei Geschäftsführer an
einer Versammlung teilnehmen.
Versammlungen der Geschäftsführer können mittels Telefon - oder Videokonferenz abgehalten werden. Die Ge-
schäftsführer können mittels Konferenzschaltung, Videoschaltung oder jeglicher Kommunikationsmittel, die es allen
Teilnehmern erlaubt ausgewiesen zu werden, mitzuhören und mitzusprechen, an einer Geschäftsführerversammlung teil-
nehmen. Die Teilnahme an einer Versammlung mittels der vorgenannten Instrumente ist einer persönlichen Teilnahme
gleichzustellen, ohne dass es nötig wäre dass zwei Geschäftsführer sich versammeln. Die Versammlungen welche mittels
Telefon - oder Videokonferenz abgehalten werden sind einer Versammlung am Geschäftssitz gleichgestellt.
Die Geschäftsführung ist nur ordnungsgemäß beratungs-und beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder an-
wesend oder vertreten ist.
Die Geschäftsführungsbeschlüsse bedürfen der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Die Geschäftsführer können immer schriftliche Beschlüsse fassen Beschlüsse welche von allen Geschäftsführern un-
terzeichnet sind haben die gleiche Rechtskraft wie Beschlüsse im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen und
abgehaltenen Versammlung. Solche Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder mehreren Kopien ein und
desselben Beschlusses erscheinen und erhalten Beweiskraft mit Brief, Telefax oder Telex.
94846
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Vertretung - Zeichnungsberechtigung. In Geschäften mit Dritten ist/sind der/die Geschäftsführer jederzeit
dazu ermächtigt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte zu tätigen, welche im Einklang mit dem Ge-
sellschaftszweck und den Bestimmungen von Artikel 10 der Satzung liegen.
Alle durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung nicht ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen
Rechte fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder -bei mehreren Geschäftsführern -der Geschäfts-
führung. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, ist der vorhandene Geschäftsführer alleine zur Vertretung der Gesellschaft
berechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch jeweils zwei Geschäftsführer gemein-
schaftlich vertreten. Die Gesellschafter können aus der Geschäftsführung einen oder mehrere (Generalgeschäftsführer)
Hauptgeschäftsführer ernennen, welche(r) Alleinvertretungsbefugnis hat/haben, vorausgesetzt jedoch, sie überschreiten
die der Geschäftsführung übertragenen Befugnisse nicht.
Der Geschäftsführer oder -bei mehreren Geschäftsführern -die Geschäftsführung kann seine Befugnisse für die Vor-
nahme bestimmter Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Vertreter weiterdelegieren.
Der Geschäftsführer oder -bei mehreren Geschäftsführern -die Geschäftsführung bestimmt die Verantwortungen und
(falls zutreffend) die Vergütung seines/seiner Vertreter, die Dauer ihrer Vertretung sowie alle sonstigen etwaigen Bedin-
gungen in Zusammenhang mit ihrer Beauftragung.
Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer haften aufgrund ihrer Position nicht persönlich für im
Namen der Gesellschaft eingegangene Verpflichtungen, solange diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit der Satzung
der Gesellschaft und den geltenden Bestimmungen des Gesetzes stehen.
Die Gesellschaft kann den Geschäftsführern und leitenden Angestellten sowie deren Erben, Testamentsvollstreckern
und Nachlassverwaltern Freistellung zusichern von den Kosten, die diesen in vernünftigem Rahmen in Zusammenhang
mit Klagen, Prozessen oder Verfahren entstehen, in die sie aufgrund der Tatsache als Prozesspartei verwickelt wurden,
dass sie Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder - auf eigenes Verlangen - einer anderen Ge-
sellschaft waren, an der die Gesellschaft beteiligt oder deren Gläubiger sie ist, und gegen die sie keinen Schadenersatz-
anspruch geltend machen können; diese Freistellung gilt nicht, wenn sie im Rahmen dieser Klagen, Prozesse und Verfahren
der groben Fahrlässigkeit oder schweren Pflichtverletzung für schuldig befunden wurden. Im Falle eines Vergleiches erfolgt
eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, welche von dem Vergleich abgedeckt werden, und
insofern als der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, daß die zu entschädigende Person keine Pflichtver-
letzung begangen hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere etwaige rechtliche Ansprüche nicht aus.
Kapitel IV. Schriftführer
Art. 12. Bestellung eines Schriftführers. Die Gesellschafterversammlung kann durch einfachen Beschluß einen Schrift-
führer der Gesellschaft (der Schriftführer) ernennen.
Der Schriftführer, der nicht Geschäftsführer sein muß, fungiert als Protokollführer in den Geschäftsführerversamm-
lungen und, sofern durchführbar, in den Gesellschafterversammlungen; er führt die Akten und Protokolle der Geschäfts-
führer und der Gesellschafterversammlungen und die von ihnen durchgeführten Transaktionen in einem speziell zu diesem
Zweck geführten Buch; er übernimmt dieselben Aufgaben für alle eventuell von der Geschäftsführung beauftragten Aus-
schüsse. Der Schriftführer kann seine Befugnisse auf eine oder mehrere Person/en delegieren, sofern er für diese
delegierten Aufgaben verantwortlich bleibt.
Der Schriftführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft Zertifikate und Auszüge auszustellen, die der Vorlage bei
Gericht beziehungsweise Dritten zur Vorlage als amtliche Unterlagen dienen.
Kapitel V. Gesellschafterversammlung
Art. 13. Jahresgeneralversammlung und außerordentliche Gesellschafterversammlung. Die Jahresgeneralversammlung
findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des jeweils vorhergehenden Geschäftsjahres am Sitz der
Gesellschaft oder jedem anderen, in der Einberufungsmitteilung genannten Ort in Luxemburg statt.
Art. 14. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter hat das Recht, an der Gesellschafterversammlung teil-
zunehmen, unabhängig davon, wie viele Anteile er besitzt.
Die Stimmrechte der Gesellschafter bestimmen sich nach der Zahl der von ihnen gehaltenen Anteile.
Jeder Gesellschafter kann sich auf der Gesellschafterversammlung durch einen bevollmächtigten Vertreter, der kein
Gesellschafter sein muß, vertreten lassen.
Art. 15. Quorum - Mehrheit. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann ordnungsgemäß, wenn sie von
einer Mehrheit von Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, angenommen werden.
Beschlüsse, die Satzungsänderungen oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft zu Gegenstand haben, können
nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern angenommen werden, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals besitzt.
Anstatt auf einer Gesellschafterversammlung können Beschlüsse auch schriftlich von allen Gesellschaftern angenom-
men werden. In diesem Fall wird jedem Gesellschafter ein Entwurf des Beschlusses übermittelt, welchen er unterzeichnet.
Die Beschlussfassung durch Unterzeichnung einer oder mehrerer Zweitausfertigungen hat die gleiche Rechtskraft wie die
auf einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse.
94847
L
U X E M B O U R G
Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.
Die in Anwendung des vorstehenden Absatzes gefassten Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden protokolliert
oder als Bericht abgefasst oder schriftlich niedergeschrieben.
Alle Verweise auf Gesellschafterversammlungen beziehen sich mutatis mutandis auf einen in der vorstehend beschrie-
benen Form schriftlich gefassten Beschluss.
Kapitel VI. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverwendung
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des
gleichen Jahres.
Art. 17. Jahresabschluss. Die Bücher werden jährlich abgeschlossen, und der Geschäftsführer oder -bei mehreren
Geschäftsführern -die Geschäftsführung erstellt die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung.
Art. 18. Einsicht in die Unterlagen. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, am Sitz der Gesellschaft Einsicht in die oben
genannte Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung zu nehmen.
Art. 19. Gewinnverwendung. Vom ausgeschütteten Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen
Rücklage zurückzulegen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht.
Die Verteilung des Restbetrags erfolgt nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile. Die Gesellschafterversammlung kann
nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung einer oder mehrerer Zwischendividende/n
beschließen.
Kapitel VII. Auflösung - Liquidation
Art. 20. Auflösung. Zahlungsunfähigkeit, Bankrott und andere Verfahren gegen einen Geschäftsführer sind keine Grün-
de für die Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschafter müssen der Auflösung und Liquidation sowie den darauf
anwendbaren Bedingungen nach Maßgabe von Artikel 15 der vorliegenden Satzung zustimmen.
Art. 21. Liquidation. Die Liquidation erfolgt bei Auflösung der Gesellschaft durch einen oder mehrere Liquidator/en,
die keine Gesellschafter sein müssen und von den Gesellschaftern ernannt werden, die auch ihre Befugnisse und Bezüge
festlegen.
Kapitel VIII. Abschlussprüfung
Art. 22. Wirtschaftsprüfer - Abschlussprüfer. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes muss die Gesellschaft nur in den Fällen
von einem Abschlussprüfer geprüft werden, wenn die Anzahl der Gesellschafter 25 überschreitet. Ein externer Ab-
schlussprüfer muss beauftragt werden, wenn die Befreiungen unter Artikel 256 und Artikel 215 des Gesetzes keine
Anwendung finden.
Kapitel IX. Anwendbares Recht
Art. 23. Bezugnahme auf die gesetzlichen Bestimmungen. In allen im Rahmen der vorliegenden Satzung nicht aus-
drücklich geregelten Angelegenheiten wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.
Die Urkunde wurde in englischer Sprache aufgesetzt, gefolgt von der deutschen Sprache, und bei Abweichungen zwi-
schen dem englischen und dem deutschen Text ist die englische Fassung maßgebend ist.
Référence de publication: 2014110107/615.
(140132045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Generas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 27.046.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration de la Société du 14 avril 2014i>
<i>Première résolutioni>
Confirmation du mandat de Monsieur Marc AUGIER en tant que Président du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration confirme le mandat de Monsieur Marc AUGIER comme Président du Conseil d'Adminis-
tration. Monsieur Marc AUGIER accepte ce mandat pendant la durée de son mandat d'Administrateur qui vient à échéance
à l'issue de l'Assemblée Générale de 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
GENERAS S.A.
Référence de publication: 2014074721/16.
(140088152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
94848
Algebris Npl Partnership Gp, S.à r.l.
Fairfield 1 S.à r.l.
Generas S.A.
Global Terminal Limited S.à r.l.
Green Company S.A.
Hanscan Technology S.à r.l.
Iberian Minerals Financing S.A.
Ikano S.A.
Il Limoncello S.à r.l.
Immo Penfret S.A.
INI S.A.
International Diamonds & Gems S.à r.l.
International Medical Technology Holding S.à r.l.
International Property Management
Interocean Shipping and Investments Sàrl
Invenergy Wind Europe II S.à r.l.
Invenergy Wind Europe II S.à r.l.
Invista European RE Roth PropCo S.à r.l.
Invista European RE Solingen PropCo S.à r.l.
IP Crossroads S.A.
IP Luxembourg S.à r.l.
IPN Unternehmensberatung S.A.
Ipsen Ré
Irrus S.à r.l.
Iumi S.A.
IVAX International GmbH Lux SCS
Ivefi S.A.
Jabcab (Lux)
Jaggard S.à r.l.
J.A.P. Rent S.à r.l.
J.M.C.
JPP Polymere S.A.
Juno Properties S.à r.l.
KC Esther S.à r.l.
Kensington Square S.à.r.l.
Kingswood S.à r.l.
Kotak Funds
Krisian S.A.
La Française AM Fund
Lamp International S.à r.l.
Langley CoInvest S.à r.l.
Larochette RCG Re SCA
Liane Properties S.à r.l.
LuxOr Services
Lux Pillar
Universal Air Charter
Xylem IP Management S.à r.l.