This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1977
29 juillet 2014
SOMMAIRE
Affinia Luxembourg Finance S.à r.l. . . . . . .
94863
Berbou International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
94859
Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l. . .
94864
Euro Trade International S.A. . . . . . . . . . . .
94895
Financière Prooftag S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
94856
Finexsto S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94850
Fiscobelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94851
Fivecom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94893
Foyer Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94858
Freetop Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94896
Galena Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
94852
Genel Alpay International Sàrl . . . . . . . . . .
94851
Generaltrade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94850
GERI Consult G.m.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94859
Gestlux Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .
94851
GLN Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94853
GLN Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94853
Global Management Consulting S.à.r.l. . . .
94853
Global Palaces Real Estate S.à r.l. . . . . . . . .
94852
Global PepsiCo Luxembourg Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94850
Goodman Flame Logistics (Lux) S.à r.l. . .
94896
GPN Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94854
Gracewell Investment N°6 S.à r.l. . . . . . . .
94850
Granada S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94857
Great Bio Energies S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
94858
Gries S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94851
Hanscan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94857
Haute Tension S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94854
Heaven Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94857
Helena Debtco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94854
HIB, Holding Invest Batiment S.A. . . . . . . .
94851
Hôtel Schumacher Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
94855
Hôtel Schumacher Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
94854
Hôtel Schumacher Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
94855
Hyosung Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
94852
Ibos II Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
94855
Icaria Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94854
Ikano Finance (Russia) S.A. . . . . . . . . . . . . .
94852
Immibel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94858
Immo Hesperange S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
94850
Innovation Arch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94852
Intermind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94863
Invenergy Wind Canada Operational S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94855
Invista European Real Estate Bel-Air Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94856
Invista European Real Estate Finance S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94856
Invista European Real Estate Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94855
Invista European RE Delta HoldCo S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94856
Invista European RE Pocking PropCo S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94856
ION Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
94853
IP Crossroads S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94859
Rye Acquisitions S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
94886
Sapori & Gusti S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94860
Sargos Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
94860
Schengen RCG Re SCA . . . . . . . . . . . . . . . . .
94861
Seema II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94861
Seema Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
94862
Seema Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
94862
Seema S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94861
Seema S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94863
Siegwerk Holding Luxembourg S.A. . . . . .
94861
Société Luxembourgeoise de Restauration
et d'Hôtellerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94860
Sofidra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94862
Sun Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94860
UPA - Union des Propriétaires d'Avions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94862
Woodford S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94859
94849
L
U X E M B O U R G
Finexsto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 174.418.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073757/9.
(140086394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Gracewell Investment N°6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 184.653.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014073780/10.
(140087280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Global PepsiCo Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 131.152.
Le Bilan consolidé au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
(conforme Art. 314 du loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Global PepsiCo Luxembourg Holdings S.à r.l.
Paul Galliver
<i>Manager Bi>
Référence de publication: 2014073774/14.
(140087266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Generaltrade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 71.736.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014073787/10.
(140087082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Immo Hesperange S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 169.259.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2014073825/11.
(140087149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94850
L
U X E M B O U R G
Fiscobelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 60.852.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 mai 2014i>
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de ce jour:
1. La nomination en temps qu'administrateur-délégué et administrateur de Monsieur Jean-Claude Buffin, comptable
agréé, domicilié professionnellement au 27, route de Luxembourg à L-4761 Pétange jusqu'à l'assemblée générale qui se
tiendra en l'année 2018.
2. Le mandat d'administrateur de Madame Isabelle Binamé n'est pas renouvelé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2014.
Abraham Aferwork / Simon Buffin
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014073758/17.
(140086868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Genel Alpay International Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.250,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 119.094.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073786/9.
(140086744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Gestlux Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 166.811.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GESTLUX MANAGEMENT S.A.i>
Référence de publication: 2014073793/10.
(140086455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Gries S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 50.173.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073806/9.
(140086695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
HIB, Holding Invest Batiment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 62, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 162.095.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073817/9.
(140086935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94851
L
U X E M B O U R G
Galena Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 160.522.
EXTRAIT
Suite à un déménagement,
- Monsieur Mark Irwin, gérant de catégorie A de la société susmentionnée, né le 28 octobre 1964 à Castledawson
(United Kingdom), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 3 Western Esplanade, Brighton, BN41
1WE, United Kingdom.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2014073771/17.
(140087296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Global Palaces Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 144.536.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2014073799/10.
(140087008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Hyosung Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7737 Colmar-Berg, 6, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 121.171.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073822/9.
(140086976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Innovation Arch, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 181.642.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073826/9.
(140086478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Ikano Finance (Russia) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R.C.S. Luxembourg B 106.009.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073845/9.
(140087249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94852
L
U X E M B O U R G
GLN Investment, Société Anonyme.
Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.
R.C.S. Luxembourg B 84.936.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014073795/10.
(140086886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
GLN Investment, Société Anonyme.
Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.
R.C.S. Luxembourg B 84.936.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire tenue en date du 26 mai 2014i>
1. Les mandats d'Administrateur de Madame Viviane GRAFFE, demeurant professionnellement au 1, rue des Coque-
licots, L-1356 Luxembourg, de Monsieur Bruno LAMBERT demeurant professionnellement au 1, rue des Coquelicots,
L-1356 Luxembourg et de Monsieur Paul GERVIS, demeurant professionnellement au 1, rue des Coquelicots, L-1356
Luxembourg, sont renouvelés pour une nouvelle période d'un an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2015.
2. Le mandat du Commissaire aux Comptes, FIN-CONTROLE SA, Société Anonyme de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg est renouvelé pour une nouvelle période
d'un an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.
Fait à Luxembourg, le 26 mai 2014.
<i>Pour GLN INVESTMENT
i>Signatures
Référence de publication: 2014073796/19.
(140086907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Global Management Consulting S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4551 Niederkorn, 28A, rue des Ecoles.
R.C.S. Luxembourg B 154.365.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2014i>
1) Acceptation de la démission du gérant Monsieur GILLIS Marc.
2) Nomination de Madame THYS Anne Marie, née le 30 janvier 1966 à Anderlecht (B), demeurant à B-1785 Merchtem,
5, Meerstraat comme nouveau gérant.
La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014073798/13.
(140086471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
ION Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 70.981.
Le bilan de la société au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014073857/12.
(140086979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94853
L
U X E M B O U R G
Haute Tension S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4599 Differdange, 2, rue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 89.754.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014073814/10.
(140086419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Helena Debtco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 123.707.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2014.
Référence de publication: 2014073808/10.
(140086899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Hôtel Schumacher Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6590 Weilerbach, 1, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 105.815.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014073819/10.
(140087322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
GPN Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 168.434.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014073803/10.
(140086400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Icaria Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 121.595.
Le Bilan consolidé au 31 décembre 2012 a été déposé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg (conforme Art. 314 du loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Icaria Invest S.à r.l.
Paul Galliver
<i>Manager Bi>
Référence de publication: 2014073842/14.
(140087395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94854
L
U X E M B O U R G
Hôtel Schumacher Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6590 Weilerbach, 1, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 105.815.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014073818/10.
(140087303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Hôtel Schumacher Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6590 Weilerbach, 1, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 105.815.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014073820/10.
(140087345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Invenergy Wind Canada Operational S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 164.866.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
en date du 9 juillet 2013 sous la référence L130114457.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Invenergy Wind Canada Operational S.à r.l.
Mandatairei>
Référence de publication: 2014073828/13.
(140086422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Invista European Real Estate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 24.756.074,36.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.463.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014073834/10.
(140086931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Ibos II Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 92.926.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014073841/11.
(140087314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94855
L
U X E M B O U R G
Invista European RE Pocking PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.870.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 120.455.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014073837/10.
(140086929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Invista European Real Estate Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.462.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014073833/10.
(140086930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Invista European RE Delta HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 733.685,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.965.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014073835/10.
(140086924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Invista European Real Estate Bel-Air Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.332.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 128.172.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014073832/10.
(140086927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Financière Prooftag S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 137.284.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2014073755/11.
(140086801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94856
L
U X E M B O U R G
Heaven Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 166.683.
Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2013, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HEAVEN SERVICES S.A.
i>Signatures
Administrateur / Administrateur
Référence de publication: 2014073815/13.
(140087073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Granada S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 98.258.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 15 mai 2014i>
L'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:
- L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats de:
* M. Thierry Grosjean, né le 3 août 1975 à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au L-3372 Leudelange,
15, rue Léon Laval;
* Mme Claudia Schweich, née le 1
er
Août 1979, à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-3372
Leudelange, 15, rue Léon Laval;
aux fonctions d'administrateurs.
* Kohnen & Associés S à.r.l., ayant son siège social 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée au
registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 114.190,
à la fonction de Commissaire aux Comptes.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se
clôturant le 31 Décembre 2013.
- L'Assemblée Générale accepte la démission de:
* Melle Radia Taddrart, née le 17 novembre 1985, à Epinal, (France), ayant son adresse professionnelle au L-1728
Luxembourg 14 rue du Marché aux Herbes;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 Mai 2014.
<i>Pour Granada S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014074731/28.
(140087458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Hanscan, Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 120.691.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 Avril 2014i>
L'Assemblée Générale accepte, avec effet immédiat, la démission d'un administrateur, à savoir:
- Monsieur Marc THEISEN, administrateur, né le 05 Novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié profes-
sionnellement au 291 route d'Arlon L-1150 Luxembourg
L'Assemblée Générale accepte, avec effet immédiat, de nommer un administrateur, à savoir:
- Monsieur Hendrik H. J. (Rob) KEMMERLING, administrateur, né le 22 Mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié
professionnellement au 42-44 avenue de la gare L-1610 Luxembourg
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.
L'Assemblée Générale accepte, avec effet immédiat, de renouveler deux administrateurs, à savoir:
94857
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, domicilié professionnellement au 42-44 avenue de la gare L-1610 Lu-
xembourg
- Monsieur Bruce Mark CURRIE, administrateur, domicilié professionnellement au St Peter Port CY1 4HL Forest Lane
Guernesey
Leurs mandats d'administrateur expireront lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2018.
L'Assemblée Générale accepte, avec effet immédiat, de renouveler le commissaire aux comptes, à savoir:
- La société ZIMMER & PARTNERS S.A. immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
sous le n° B151.507, domicilié au 3-7 rue Schiller L-2519 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2018.
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité en date du 25 Avril 2014, de nommer comme Président du Conseil
d'Administration, à savoir:
- Monsieur Claude ZIMMER, Président et administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié
professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014073812/31.
(140087135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Great Bio Energies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 113.888.
EXTRAIT
Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2014073804/12.
(140087122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Immibel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 128.555.
EXTRAIT
Le siège social de Société a été transféré le 16 mai 2014 de 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 21, Avenue
Monterey L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 Mai 2014.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2014073850/13.
(140087202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Foyer Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 33.850.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 mai 2014 que
- Monsieur André ELVINGER a été reconduit comme administrateur pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée
générale ordinaire de 2017,
- Monsieur Dominique LAVAL a été reconduit comme administrateur pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée
générale ordinaire de 2017,
- Monsieur François TESCH a été reconduit comme administrateur pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée
générale ordinaire de 2017,
94858
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Théo WORRÉ, demeurant à L-8154 Bridel, 1, Ferme de Klingelbour, a été reconduit comme administrateur
pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2017.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration du même jour que Messieurs André ELVINGER et François
TESCH ont été reconduits dans leurs fonctions de Président respectivement d'Administrateur-délégué pour la durée de
leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FOYER FINANCE S.A.
Référence de publication: 2014073763/21.
(140086900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
GERI Consult G.m.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 140.242.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23/05/2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014073788/12.
(140086454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
IP Crossroads S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 175.934.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 avril 2014i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 avril 2014 révoque la société ARIETIS CONSULTING S.A. immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 146781 de son poste de Commissaire aux
comptes et nomme en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire la société AUDIT & CONTROLS,
ayant son siège social 59 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174348.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes annuels de l'exercice 2018.
Référence de publication: 2014073859/14.
(140087125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Woodford S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 122.775.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014074306/10.
(140087191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Berbou International Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8373 Hobscheid, 33, rue du Neuort.
R.C.S. Luxembourg B 99.984.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014074475/9.
(140088399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
94859
L
U X E M B O U R G
Sargos Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 109.456.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société du 19 mai 2014i>
Le 19 mai 2014, l'associé unique de Sargos Properties S.à r.l. a pris les résolutions suivantes:
- D'accepter la démission de Mme Christelle Ferry en qualité de Gérant de la Société avec effet au 12 mai 2014;
- De nommer Mme Séverine Canova, ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société avec effet au 12 mai 2014 et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Xavier De Cillia
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014074162/15.
(140087315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Sun Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 164.806.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société du 19 mai 2014i>
Le 19 mai 2014, l'associé unique de Sun Properties S. à r.l. a pris les résolutions suivantes:
- D'accepter la démission de Mme Christelle Ferry en qualité de Gérant de la Société avec effet au 12 mai 2014;
- De nommer Mme Séverine Canova, ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société avec effet au 12 mai 2014 et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Xavier De Cillia
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014074191/15.
(140087278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Société Luxembourgeoise de Restauration et d'Hôtellerie, Société Anonyme.
Siège social: L-3321 Berchem, Aire de Berchem.
R.C.S. Luxembourg B 47.106.
Les comptes annuels au 30.09.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2014074219/12.
(140087391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Sapori & Gusti S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4761 Pétange, 23, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 118.900.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
EASIT SA
Signature
Référence de publication: 2014074200/12.
(140086909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94860
L
U X E M B O U R G
Seema S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: NOK 161.664.417,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 133.664.
Constituée par devant Me Paul Friders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 Décembre 2007, acte publié
au Mémorial C no 2955
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Seema S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Manager Ai>
Référence de publication: 2014074171/14.
(140086660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Siegwerk Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 66.882.
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 23 décembre 2013 que:
Ernst & Young, Société Anonyme, RCS numéro B47.771; demeurant au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach, a été réélu en tant que commissaire aux comptes de la société.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire devant approuver les comptes arrêtés au 31 décembre
2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014074210/14.
(140086816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Seema II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: NOK 8.000.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 134.977.
Constituée par devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 novembre 2007, acte
publié au Mémorial C no 255
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Seema II S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Manager Ai>
Référence de publication: 2014074167/14.
(140086663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Schengen RCG Re SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.
R.C.S. Luxembourg B 37.290.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société Schengen RCG RE SCA
i>Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2014074164/11.
(140087265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94861
L
U X E M B O U R G
Sofidra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 34-36, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 73.723.
Les statuts coordonnés au 4 février 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014074180/11.
(140086867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
UPA - Union des Propriétaires d'Avions, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2632 Findel, 2, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 11.085.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
A. Heiderscheid
<i>Présidenti>
Référence de publication: 2014074279/12.
(140087059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Seema Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: NOK 13.677.707,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 135.615.
Constituée par devant Me Paul Friders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 Décembre 2007, acte publié
au Mémorial C no 425
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Seema Management S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Manageri>
Référence de publication: 2014074169/14.
(140086658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Seema Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: NOK 13.677.707,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 135.615.
Constituée par devant Me Paul Friders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 Décembre 2007, acte publié
au Mémorial C no 425
<i>Rectificatif suite au dépôt L120206317 en date du 29 novembre 2012.i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Seema Management S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Manager Ai>
Référence de publication: 2014074170/15.
(140086659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
94862
L
U X E M B O U R G
Seema S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: NOK 161.664.417,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 133.664.
Constituée par devant Me Paul Friders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 Décembre 2007, acte publié
au Mémorial C no 2955
<i>Rectificatif suite au dépôt L120206316 en date du 29 novembre 2012.i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Seema S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Manager Ai>
Référence de publication: 2014074172/15.
(140086661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Affinia Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 161.119.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/05/2014.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014074377/11.
(140088127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Intermind, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 168.718.
<i>Extrait rectificatif du dépôt enregistré sous la référence L140086181 déposé le 23 mai 2014i>
Suite aux résolutions écrites de l'associé unique datée du 9 mai 2014, il est confirmé que:
- Monsieur Luc LEROI, né le 26 octobre 1965 à Rocourt (Belgique), avec adresse privée au 13a, rue de Clairefontaine,
L-8460 Eischen, a démissionné de son mandat de gérant avec effet à la date de la résolution de l'associé unique;
- Monsieur Matthijs BOGERS, né le 24 novembre 1966 à Amsterdam (Pays-Bas), résidant professionnellement au 11-1
Boulevard de la Foire, L-1528, a été nommé gérant avec effet à la date de la résolution de l'associé unique pour une durée
illimité;
- Monsieur Julien FRANCOIS, né le 18 juin 1976, à Messancy (Belgique), résidant professionnellement au 11-13 Bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été nommé gérant avec effet à la date de la résolution de l'associé unique pour
une durée illimitée;
- Le siège social a été transféré au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet à la date de la résolution
de l'associé unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Intermind S.à r.l.
Représentée par Julien FRANCOIS
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014074772/25.
(140088460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
94863
L
U X E M B O U R G
Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 184.675.
In the year two thousand and fourteen, on the sixth of June.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 177.038,
having its registered office at 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
being the holder of three thousand two hundred sixty-eight (3,268) Common Shares and becoming the holder of three
thousand two hundred sixty-eight (3,268) Series A1 Shares,
here represented by Ms Alix van der Wielen, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Luxembourg, on 6 June 2014, and
2. MKC Brillant Services GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,
registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 139778 B, having
its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
being the holder of eight thousand one hundred seventy (8,170) Common Shares and becoming the holder of eight
thousand one hundred seventy (8,170) Series A2 Shares,
here represented by Ms Alix van der Wielen, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Luxembourg, on 6 June 2014, and
3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 176.544,
having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and having a
share capital of thirty thousand euros (EUR 30,000),
being the holder of four hundred eight (408) Common Shares and becoming the holder of four hundred eight (408)
Series A3 Shares,
here represented by Ms Alix van der Wielen, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Luxembourg, on 6 June 2014, and
4. TEC Global Invest IX GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,
registered with Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg under number HRB 26061, having its registered office at
Wissollstrasse 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr,
being the holder of six hundred fifty-four (654) Common Shares and becoming the holder of six hundred fifty-four
(654) Series A4 Shares,
here represented by Ms Alix van der Wielen, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Luxembourg, on 6 June 2014.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are all of the shareholders, representing the entire share capital, of Emerging Markets Taxi
Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number B 184675, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 7 February 2014, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1066 on 26 April 2014. The articles of incorporation were
amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 15 May 2014, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing parties representing the entire share capital having waived any notice requirement, the general meeting
of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Decision to create five (5) classes of shares, referred to as the common shares (hereinafter the “Common Shares”),
the series A1 shares (hereinafter the “Series A1 Shares”), the series A2 shares (hereinafter the “Series A2 Shares”), the
series A3 shares (hereinafter the “Series A3 Shares”) and the series A4 shares (hereinafter the “Series A4 Shares”) and
to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each,
into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, without cancellation of shares.
2. Increase of the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand-five hundred euros (EUR
12,500) up to twenty-five thousand euros (EUR 25,000) through the issuance of three thousand two hundred sixty-eight
94864
L
U X E M B O U R G
(3,268) Series A1 Shares, eight thousand one hundred seventy (8,170) Series A2 Shares, four hundred eight (408) Series
A3 Shares and six hundred fifty-four (654) Series A4 Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
3. Subsequent amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company.
4. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
“A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name “Emerging
Markets Taxi Holding S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 con-
cerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The object of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000), represented by (i) twelve thousand
five hundred (12,500) common shares (the “Common Shares”), (ii) three thousand two hundred and sixty eight (3,268)
series A1 shares (the “Series A1 Shares”), (iii) eight thousand one hundred and seventy (8,170) series A2 shares (the
“Series A2 Shares”), (iv) four hundred eight (408) series A3 shares (the “Series A3 Shares”), and (iv) six hundred and fifty
four (654) series A4 shares (the “Series A4 Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
5.2 The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the
extent otherwise provided by these articles of association or by the Law.
5.3 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.4 Each of (i) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”), (ii) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (iii) Aismare Lux Holdings
S.à r.l. (“Aismare”) and (iv) TEC Global Invest IX GmbH (“TEC”; LIH, AIH, Aismare and TEC jointly the “Investors” and
each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital
increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a
94865
L
U X E M B O U R G
shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”)
and which has been approved by the Advisory Board (a “Third Party Investment”) -irrespective whether made by the
Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the
Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is
based on. Each of (i) LIH, (ii) AIH, (iii) Aismare and (iv) TEC shall inform the Company by binding declaration within three
(3) weeks after it has been notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) LIH, (ii) AIH, (iii) Aismare
and/or (iv) TEC intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.4. This
Article 5.4 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into Shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The Shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that Share until such representative has been appointed.
7.3 The Shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the Shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of
any shareholders’ agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of preemption,
tag-along rights, or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders. To the extent
that such shareholder approval has been granted, an additional consent to the transfer of Shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by an Investor to a company affiliated
to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (each an “Affiliate”);
7.4.2 in case of the transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares of one Investor to a company or entity
(x) which is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by
one or more direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Con-
trol” or “Controlled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing
the company or entity as managing shareholder, (b) holding the majority of Shares or (c) holding the majority of voting
rights by means of a contractual voting pool, or (y) in which the respective Investor or one or more shareholders of such
Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by a Shareholder to the Company and/or
any of the Investors pursuant to a call-option under a vesting scheme.
7.5 To the extent a sale, transfer, assignment or any other disposal of Shares requires no additional consent of the
shareholders’ meeting pursuant to Article 7.4.1 through Article 7.4.3 above, no duties to offer for sale apply, nor do any
rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any sale, transfer, assignment or other disposal of Shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification thereof to, or upon the acceptance thereof by the Company in accordance with Article
1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the Shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the Shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least fifty percent (50%) of all Shares in the Company, or a swap or a take-over of the
Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
another, or (ii) of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of Shares in the Company either to third
parties or other shareholders that would result in either more than fifty percent (50%) of the share capital or more than
fifty percent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one
or more related acquisitions, (each of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity
94866
L
U X E M B O U R G
Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) - subject to Articles 8.2, 8.4 and 8.5 below - will be distributed in accordance
with Article 8.3 to the shareholders pro rata to their Shares held at the time of the Liquidity Event.
8.2 On a first level (“First Level”) each holder of Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and of the Series
A4 Shares shall receive an amount equal to its total investment made in the company in order to acquire the respective
Shares held by it, consisting of the nominal amount of the Shares acquired and any share premium and/or other capital
contribution (account 115) paid by it to the Company.
8.3 After the payments on the First Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be allocated on a second
level (“Second Level”) to all shareholders pro rata corresponding to the respective Shares held at the time of the Liquidity
Event. Any amounts received by any shareholder on the First Level shall reduce the amount to be allocated to such
shareholder on the Second Level and shall be allocated subsequently pursuant to this Second Level provided that no
shareholder shall be obliged to repay any amount received on the First Level. The allocation at Second Level shall be
made until all Exit Proceeds have been distributed to the shareholders.
8.4 The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level applies to each of the respective Series A1 Shares,
Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares as long as on the respective Series A1 Shares, Series A2 Shares,
Series A3 Shares and Series A4 Shares the Investor has not yet received the full amount that is to be allocated to such
Investor according to the First Level.
8.5 Irrespective of whether or not the sale of Shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one
transaction or more transactions, no shareholder shall receive for the sale of all of its Shares (and shall repay any exceeding
amount to the other Shareholders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or proceeds
pro rata to the Shares sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such Shareholder on the First
Level from a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own Shares. The voting rights of any of its Shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings
is rejected for lack of assets;
9.2.2 the Share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such Share and
such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the Shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles of association together with
the declaration of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of Article 190 of the
Law and the Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the Shares in such case and undertakes to register
the transfer in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.
9.3 If the Share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one
person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).
Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed Shares. The effective
date is the date before the redemption resolution.
10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the Shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
94867
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Request of Assignment in Lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the Shares to a
person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the Share to the Company or to a person named by the Company.
11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of
association, for the Shares to be assigned is owed by the person acquiring the Shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders.
Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
12.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
12.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
13.2 The shareholders’ meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or
registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.
13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another share-
holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders’ resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.
Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds Shares.
14.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
94868
L
U X E M B O U R G
no quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 13.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous
consent.
Art. 16. Amendments of the Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the
approval of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.
Art. 17. Decisions Requiring Specific Majority.
17.1 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and require the prior consent of
the Advisory Board:
17.1.1 disposition of all the Company’s assets, of a significant part of the Company’s assets or all or significant part of
assets of any direct or indirect subsidiary of the Company (including, among others, transfer of any and all of the intellectual
property rights), if such disposition is made on arm`s length terms;
17.1.2 resolution with respect to the liquidation of the Company;
17.1.3 amendment of these articles of association (including this Article 17) including the resolution with respect to
the merger, separation and transformation of the Company;
17.1.4 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such
profits to new accounts; increase or reduction of reserves (including but not limited to share premium and assimilated
premium) as well as capital increase from company funds;
17.1.5 conclusion, amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning
of sections 291 et seqq. of the German Stock Corporation Act (AktG));
17.1.6 conclusion, termination or amendment of sub-participations of any kind including silent partnerships in the
Company;
17.1.7 approval of the annual budget for each following year;
17.1.8 transfer of industrial property rights or documented knowhow by the Company to a third party.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the consent of
all of the Investors.
17.2.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.2 acquisition of the Company’s own Shares, including redemption of Shares, with the exception of acquisitions in
accordance with Article 9.2 and transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association.
17.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares the special rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders’ who hold
all the issued shares of that class.
17.4 Any changes in the decision making process (including the competence of meetings of shareholders, Advisory
Board and any specific majority necessary for adoption of some of the decisions) of the Company to the unilateral
disadvantage of any of the Investors shall not be made without such Investor’s consent. For the avoidance of doubt any
decrease of the number of votes or change of the voting rights of shareholders or managers necessary for adoption of
any decision will bring the unilateral disadvantage of the Investors.
D. Board of managers and advisory board.
Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause, by a resolution
of the general meeting of shareholders.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
94869
L
U X E M B O U R G
Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
22.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board for legal transactions and measures of the Company
and its direct or indirect subsidiaries which are beyond the ordinary course of business of the Company, and - in any case
- for the legal transactions and measures of the Company and its direct or indirect subsidiaries specified below (no consent
is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance been approved by an
adopted budget with the consent of the shareholders’ meeting):
22.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of five hundred thousand euro
(EUR 500,000) each;
22.8.2 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other
transactions with derivative financial instruments;
22.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.4 conclusion, amendment or termination of company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the company pension scheme;
22.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than five hundred thousand euro (EUR 500,000) in the individual case;
22.8.6 passing on of industrial property rights or know-how by the Company to a third party;
94870
L
U X E M B O U R G
22.8.7 conclusion, termination or amendment of sub-participations of any kind including silent partnerships in the
Company 22.8.8 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals
as set forth in any shareholders’ agreement between the shareholders; and
22.8.9 conclusion, amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning
of articles 291 et seqq. of the German Stock Corporation Act (AktG)).
Resolutions regarding the introduction of an employee participation scheme require the consent of the Advisory Board.
22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also
required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.
22.10 The shareholders may by shareholders’ resolution or by virtue of shareholders’ agreement adopt rules of pro-
cedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.
Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company shall have an advisory board (the “Advisory Board”). It shall consist of five (5) voting members and
additional non-voting members (the “Observers”). The shareholders’ meeting may by way of unanimous shareholders’
resolution increase or decrease the number of members of the Advisory Board.
25.2 The shareholders’ meeting shall only adopt or amend the rules of procedure for the Advisory Board by way of a
unanimous shareholders’ resolution or by virtue of shareholders’ agreement.
25.3 Each of the Investors may nominate a non-voting Observer to the Advisory Board who shall be entitled to attend
the meetings of the Advisory Board and receive any preparatory documents, meeting notices and minutes of the Advisory
Board.
25.4 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s res-
pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
25.4.1 two (2) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder AIH in its sole discretion;
25.4.2 three (3) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder LIH in its sole discretion.
Each voting member of the Advisory Board shall have one (1) vote.
25.5 The Advisory Board shall be competent for the granting of consents to any transactions and measures of the
managers which the shareholders’ meeting has made subject to the consent of the Advisory Board either (i) in these
articles of association, (ii) in the rules of procedure of the managers, (iii) by way of shareholders’ resolution or (iv) in any
shareholders’ agreement.
25.6 The remuneration of the members of the Advisory Board, if any, shall be determined by shareholders of the
Company by way of a unanimous shareholders’ resolution.
25.7 In addition to the consent requirements provided for in Article 22.8 and Article 22.9, the Advisory Board has a
consultative function and will not interfere in the management of the Company.
25.8 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis 11 et seq. of the Law.
94871
L
U X E M B O U R G
E. Audit and supervision
Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with Article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
28.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of Shares they
hold in the Company.
Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.
29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.
31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.”
5. Undertaking to make a future contribution of shares of ECommerce Taxi Asia S.à r.l. to the Company.
94872
L
U X E M B O U R G
6. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires
the undersigned notary to enact, the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to create five (5) classes of shares, referred to as the common shares
(hereinafter the “Common Shares”), the series A1 shares (hereinafter the “Series A1 Shares”), the series A2 shares
(hereinafter the “Series A2 Shares”), the series A3 shares (hereinafter the “Series A3 Shares”) and the series A4 shares
(hereinafter the “Series A4 Shares”) and to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a
nominal value of one euro (EUR 1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, without cancellation
of shares.
<i>Second Resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to increase the Company’s share capital by an amount of twelve thousand
five hundred euros (EUR 12,500) so as to raise it from amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) up
to twenty-five thousand euros (EUR 25,000) through the issuance of three thousand two hundred sixty-eight (3,268)
Series A1 Shares, eight thousand one hundred seventy (8,170) Series A2 Shares, four hundred eight (408) Series A3 Shares
and six hundred fifty-four (654) Series A4 Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Subscriptioni>
The new Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares have been subscribed as follows:
1. three thousand two hundred sixty-eight (3,268) Series A1 Shares have been subscribed by Asia Internet Holding S.à
r.l., aforementioned, here represented as aforementioned, for the subscription price of twenty-six thousand seven hun-
dred five euros (EUR 26,705); and
2. eight thousand one hundred seventy (8,170) Series A2 Shares have been subscribed by MKC Brillant Services GmbH,
aforementioned, here represented as aforementioned, for the subscription price of thirteen thousand fifty-two euros and
forty-three cents (EUR 13,052.43); and
3. four hundred eight (408) Series A3 Shares have been subscribed by Aismare Lux Holdings S.à r.l., aforementioned,
here represented as aforementioned, for the subscription price of three thousand five hundred thirty-three euros (EUR
3,533); and
4. six hundred fifty-four (654) Series A4 Shares have been subscribed by TEC Global Invest IX GmbH, aforementioned,
here represented as aforementioned, for the subscription price of five thousand six hundred fiftyfour euros (EUR 5,654).
<i>Paymenti>
1. The three thousand two hundred sixty-eight (3,268) Series A1 Shares have been subscribed for a total subscription
price of twenty-six thousand seven hundred five euros (EUR 26,705.-) by Asia Internet Holding S.à r.l., aforementioned,
and have been fully paid-up through (i) a contribution in cash in the amount of three thousand two hundred sixty-eight
euros (EUR 3,268) and (ii) a contribution in kind consisting of:
(a) twelve thousand five hundred (12,500) common shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, of
ECommerce Taxi Eastern Europe S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 184.673, having
an aggregate value of at least twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500); and
(b) ten thousand nine hundred thirty-seven (10,937) common shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each,
of ECommerce Taxi Asia S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 7, avenue J.-P. Pescatore,
L-2324 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 180.251, having
an aggregate value of at least ten thousand nine hundred thirty-seven euros (EUR 10,937).
2. The eight thousand one hundred seventy (8,170) Series A2 Shares have been subscribed for a total subscription
price of thirteen thousand fiftytwo euros and forty-three cents (EUR 13,052.43) by MKC Brillant Services GmbH, afo-
rementioned, and have been fully paid-up through (i) a contribution in cash in the amount of eight thousand one hundred
seventy euros (EUR 8,170) and (ii) a contribution in kind consisting of a limited partnership interest of LIH Subholding
Nr. 1 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, a limited partnership incorporated and existing under the laws of Germany
with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg,
Germany, under no. HRA 46945 B, having an aggregate value of at least four thousand eight hundred eighty-two euros
and forty-three cents (EUR 4,882.43).
3. The four hundred eight (408) Series A3 Shares have been subscribed for a total subscription price of three thousand
five hundred thirty-three euros (EUR 3,533) by Aismare Lux Holdings S.à r.l., aforementioned, and have been fully paid-
up through (i) a contribution in cash in the amount of four hundred eight euros (EUR 408) and (ii) a contribution in kind
consisting of three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A shares, having a nominal value of one euro (EUR
1) each, of ECommerce Taxi Asia S.à r.l., aforementioned, having an aggregate value of at least three thousand one hundred
twenty-five euros (EUR 3,125).
94873
L
U X E M B O U R G
4. The six hundred fifty-four (654) Series A4 Shares have been subscribed for a total subscription price of five thousand
six hundred fifty-four euros (EUR 5,654) by TEC Global Invest IX GmbH, aforementioned, and have been fully paid-up
through (i) a contribution in cash in the amount of six hundred fifty-four euros (EUR 654) and (ii) a contribution in kind
consisting of five thousand (5,000) series A shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, of ECommerce Taxi
Eastern Europe S.à r.l., aforementioned, having an aggregate value of at least five thousand euros (EUR 5,000).
Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution have been produced to the undersigned
notary.
The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as now available to the Company as has been
proved to the undersigned notary.
The total contribution, in the amount of forty-eight thousand nine hundred forty-four euros and forty-three cents
(EUR 48,944.43), consists of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) allocated to the share capital and thirty-
six thousand four hundred forty-four euros and forty-three cents (EUR 36,444. 43) allocated to the share premium of
the Company.
<i>Third Resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article 5.1. of
the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The Company’s share capital is set at twenty-five thousand euros (EUR 25,000), represented by (i) twelve
thousand five hundred (12,500) common shares (the “Common Shares”), (ii) three thousand two hundred sixty-eight
(3,268) series A1 shares (the “Series A1 Shares”), (iii) eight thousand one hundred seventy (8,170) series A2 shares (the
“Series A2 Shares”), and (iv) four hundred eight (408) series A3 shares (the “Series A3 Shares”), and (v) six hundred fifty-
four (654) series A4 shares (the “Series A4 Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.”
<i>Fourth Resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders unanimously resolves to fully restate the
articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Fifth Resolutioni>
In light of the three thousand two hundred sixty-eight (3,268) Series A1 Shares issued in the first resolution above,
Asia Internet Holding S.à r.l. hereby undertakes to acquire and contribute to the Company one thousand five hundred
sixty-three (1,563) common shares of ECommerce Taxi Asia S.à r.l., aforementioned, on or after 1 October 2014.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at EUR 2,500.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am sechsten Juni.
vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 177.038, mit Sitz in 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg,
Inhaber von dreitausendzweihundertachtundsechzig (3.268) Stammanteilen und zukünftiger Inhaber von dreitausend-
zweihundertachtundsechzig (3.268) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, Maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
6. Juni, ausgestellt in Luxemburg, und
2. MKC Brillant Services GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 139778
B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
94874
L
U X E M B O U R G
Inhaber von achttausendeinhundertsiebzig (8.170) Stammanteilen und zukünftiger Inhaber von achttausendeinhun-
dertsiebzig (8.170) Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, Maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
6. Juni, ausgestellt in Luxemburg, und
3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von dreißigtausend Euro (EUR 30.000),
Inhaber von vierhundertacht (408) Stammanteilen und zukünftiger Inhaber von vierhundertacht (408) Anteilen der
Serie A3,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, Maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
6. Juni, ausgestellt in Luxemburg, und
4. TEC Global Invest IX GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg unter der Nummer HRB 26061, mit Sitz in Wissoll-
straße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr,
Inhaber von sechshundertvierundfünfzig (654) Stammanteilen und zukünftiger Inhaber von sechshundertvierundfünfzig
(654) Anteilen der Serie A4,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, Maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
6. Juni, ausgestellt in Luxemburg.
Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-
phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die besagten erschienenen Parteien sind alle Gesellschafter und vertreten das gesamte Gesellschaftskapital der Emer-
ging Markets Taxi Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée), mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Han-
dels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 184675, gegründet am 7. Februar 2014 gemäß einer Urkunde des
unterzeichnenden Notars, welche am 26. April 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1066
veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 15. Mai 2014 gemäß einer Urkunde des unter-
zeichnenden Notars geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht
wurde.
Da die erschienenen Parteien das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten ver-
zichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle
Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung von fünf (5) Klassen von Anteilen, welche als Stammanteile (die „Stammanteile“),
Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), Anteile der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“), Anteile der Serie A3
(die „Anteile der Serie A3“) und Anteile der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“) bezeichnet werden und bezüglich der
Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem No-
minalwert von je einem Euro (EUR 1) in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500) auf einen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) durch die Ausgabe von dreitausend-
zweihundertachtundsechzig (3.268) Anteilen der Serie A1, achttausendeinhundertsiebzig (8.170) Anteilen der Serie A2,
vierhundertacht (408) Anteilen der Serie A3 und sechshundertvierundfünfzig (654) Anteilen der Serie A4 mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
3. Dementsprechende Änderung des Artikels 5.1 der Satzung der Gesellschaft.
4. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
„Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l.“ (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Artikel.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
94875
L
U X E M B O U R G
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000), bestehend aus (i)
zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile”), (ii) dreitausendzweihundertachtundsechzig
(3.268) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), (iii) achttausendeinhundertsiebzig (8.170) Anteilen der Serie
A2 (die „Anteile der Serie A2“), (iv) vierhundertacht (408) Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“) und (v)
sechshundertvierundfünfzig (654) Anteilen der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“) mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1).
5.2 Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn,
es wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.3 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.4 Jede der Gesellschaften (i) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (ii) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (iii)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“) und (iv) TEC Global Invest IX GmbH („TEC“; LIH, AIH, Aismare und TEC
gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapital-
erhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es
sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Inves-
tition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren
Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitaler-
höhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften
(i) LIH, (ii) AIH, (iii) Aismare und (iv) TEC hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3)
Wochen nach Ankündigung der Investition eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) LIH, (ii)
AIH, (iii) Aismare und/oder (iv) TEC ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.4
ausüben möchte. Dieser Artikel 5.4 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend
anwendbar.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
94876
L
U X E M B O U R G
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-
venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich
Vorkaufsrechten, Bezugsrechten, Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung der Gesellschafter erteilt wurde, ist eine weitere
Einwilligung zur Übertragung von Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch
einen Investor an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG) (jeweils eine „Verbundene Gesellschaft“);
7.4.2 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen eines
Investors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, (x) welche/s direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen
oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“)
Kontrolliert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte
„Kontrolle“ oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft
bezeichnet, durch (a) die Leitung der Gesellschaft oder des Unternehmens durch einen geschäftsführenden Gesellschafter,
(b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche
Stimmvereinbarung, oder (y) in welcher/m der betreffende Investor oder ein oder mehrere Gesellschafter dieses Investors
eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch
einen Gesellschafter an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang
mit einer Vesting-Regelung.
7.5 Sofern ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen keiner weiteren
Zustimmung als der der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 7.4.1 bis 7.4.3 bedarf, gelten weder Verpflichtungen
zu Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer
Gesellschafter.
7.6 Ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der
Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft darüber in Kenntnis
gesetzt wurde oder diesem/dieser zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zugestimmt hat (wobei die Anteile des verstorbenen Ge-
sellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich,
wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen
Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines
Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Trans-
aktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der
Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde,
dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimm-
rechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer
verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätser-
eignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse“) - vorbehaltlich der Artikel 8.2, 8.4 und 8.5 - im Einklang mit
94877
L
U X E M B O U R G
Artikel 8.3 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer zum Zeitpunkt des Liquiditätsereignisses gehaltenen Anteile an die
Gesellschafter verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhält jeder Inhaber von Anteilen der Serie A1, Anteilen der Serie A2,
Anteilen der Serie A3 und Anteilen der Serie A4 einen seiner Gesamtinvestition in die Gesellschaft entsprechenden Betrag,
um die entsprechenden von ihm gehaltenen Anteile, bestehend aus dem Nominalbetrag der erworbenen Anteile und dem
Agio und/oder anderen Kapitaleinlagen (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem
Inhaber an die Gesellschaft gezahlt wurden, zu erwerben.
8.3 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse auf einer zweiten
Ebene („Zweite Ebene”) an alle Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer jeweiligen zum Zeitpunkt des
Liquiditätsereignisses gehaltenen Anteile verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten Ebene erhaltenen
Beträge mindern den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf der Zweiten Ebene und werden anschließend
entsprechend dieser Zweiten Ebene zugeteilt, mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung eines auf der
Ersten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der Zweiten Ebene erfolgt solange, bis alle Exiterlöse
an die Gesellschafter verteilt wurden.
8.4 Die bevorzugte Zuteilung der Exiterlöse auf der Ersten Ebene gilt für jeden der jeweiligen Anteile der Serie A1,
Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und Anteile der Serie A4 solange, wie der Investor den Gesamtbetrag für die
jeweiligen Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und Anteile der Serie A4, welcher diesem
Investor gemäß der Ersten Ebene zuzuteilen ist, noch nicht erhalten hat.
8.5 Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines Liquiditätsereignisses oder danach in einer oder
mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu
erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an
der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen und
gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten Ebene aus einem
späteren Verkauf zugeteilt wurde. Sämtliche mit der hierin festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können
nur einmal ausgeübt werden.
Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
94878
L
U X E M B O U R G
betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.
11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.
Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche
in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
13.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei der Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
94879
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-
treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.
Art. 17. Beschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die vor-
herige Zustimmung des Beirats:
17.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens, eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens
oder des gesamten oder eines beträchtlichen Anteils des Vermögens direkter oder indirekter Tochtergesellschaften der
Gesellschaft (einschließlich, unter anderem, der Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder der Gesamtheit
der Rechte des geistigen Eigentums), sofern eine solche Veräußerung marktüblichen Bedingungen unterliegt:
17.1.2 Beschluss hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;
17.1.3 Änderung dieser Satzung (Artikel 17 inbegriffen), einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Verschmelzung,
Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft;
17.1.4 Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag sol-
cher Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven (einschließlich, aber nicht beschränkt auf
das Agio und andere Kapitalreserven), sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln;
17.1.5 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Ak-
tiengesetzes (AktG));
17.1.6 Abschluss, Beendigung oder Änderung von Unterbeteiligungen jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen
an der Gesellschaft;
17.1.7 Genehmigung des Jahresplans für jedes folgende Jahr;
17.1.8 Übertragung von gewerblichen Schutzrechten oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft an
Dritte.
17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die Zu-
stimmung aller Investoren:
17.2.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.2 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, einschließlich des Rückkaufs von Anteilen, mit Ausnahme der Erwerbe
gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.
17.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
17.4 Änderungen im Beschlussfassungsprozess der Gesellschaft (einschließlich der Zuständigkeit der Gesellschafter-
versammlungen, der Sitzungen des Beirats und jeder notwendigen spezifischen Mehrheit zur Annahme einiger Beschlüsse)
zum einseitigen Nachteil eines Investors sind nicht ohne Zustimmung dieses Investors vorzunehmen. Zur Klarstellung
wird darauf hingewiesen, dass ein einseitiger Nachteil der Investoren bei einer Herabsetzung der Stimmanzahl oder bei
einer Änderung der Stimmrechte von Gesellschaftern oder Geschäftsführern besteht, die zur Annahme eines Beschlusses
erforderlich sind.
D. Rat der Geschäftsführer und Beirat
Art. 18. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
94880
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
ihre Amtszeit festlegt.
19.2 Die Geschäftsführer können durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung jederzeit und ohne Grund
ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem
Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.
20.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
21.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, EMail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.
22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
94881
L
U X E M B O U R G
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für Rechtsgeschäfte und Maßnahmen der Gesellschaft
und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, die außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs der Gesell-
schaft liegen und - in jedem Fall - für die untenstehenden Rechtsgeschäfte und Maßnahmen der Gesellschaft und deren
direkten oder indirekten Tochtergesellschaften (eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn solche Rechtsgeschäfte
und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung genehmigt wurden):
22.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Betrag von fünfhunderttau-
send Euro (EUR 500.000) überschreiten;
22.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-
aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
22.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-
cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
22.8.5 Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streit-
wert von über fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) im Einzelfall;
22.8.6 Weitergabe von gewerblichen Schutzrechten oder Know-how von der Gesellschaft an Dritte;
22.8.7 Abschluss, Beendigung oder Änderung von Unterbeteiligungen jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen
an der Gesellschaft;
22.8.8 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen,
wie in Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern dargelegt; und
22.8.9 Abschluss von, Änderungen an und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deut-
schen Aktiengesetzes (AktG)).
Beschlüsse bezüglich der Einführung eines Mitarbeiter-Beteiligungsmodells bedürfen der Zustimmung des Beirats.
22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-
lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss oder eine Gesellschaftervereinbarung eine Ge-
schäftsordnung für die Geschäftsführer beschließen.
22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers, oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
94882
L
U X E M B O U R G
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.
Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat (der „Beirat“). Dieser besteht aus fünf (5) stimmberechtigten Mitgliedern und
zusätzlichen nichtstimmberechtigten Mitgliedern (die „Beobachter“). Die Gesellschafterversammlung kann durch einen
einstimmigen Gesellschafterbeschluss die Anzahl der Mitglieder des Beirats erhöhen oder herabsetzen.
25.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einen einstimmigen Gesell-
schafterbeschluss oder eine Gesellschaftervereinbarung genehmigen oder verändern.
25.3 Jeder Investor kann einen nicht-stimmberechtigten Beobachter des Beirats ernennen, der zur Teilnahme an Sitz-
ungen des Beirats berechtigt ist und alle vorbereitenden Dokumente, Einladungen zu Sitzungen und Protokolle des Beirats
erhält.
25.4 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter jedes
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
25.4.1 zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter AIH nach eigenem Ermessen
ernannt;
25.4.2 drei (1) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter LIH nach eigenem Ermessen
ernannt.
Jedes stimmberechtigte Mitglied des Beirats hat eine (1) Stimme.
25.5 Der Beirat ist für die Erteilung von Zustimmungen zu Transkationen und Maßnahmen der Geschäftsführer zu-
ständig, welche die Gesellschafterversammlung vorbehaltlich der Zustimmung des Beirats (i) in dieser Satzung, (ii) in der
Geschäftsordnung für die Geschäftsführer, (iii) durch einen Gesellschafterbeschluss oder (iv) in einer Gesellschafterver-
einbarung, vorgenommen hat.
25.6 Die Vergütung der Mitglieder des Beirats wird, sofern vorgesehen, von den Gesellschaftern der Gesellschaft durch
einstimmigen Gesellschafterbeschluss festgelegt.
25.7 Neben den Zustimmungserfordernissen gemäß Artikel 22.8 und Artikel 22.9 hat der Beirat eine beratende Funk-
tion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.
25.8 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und prüfung der Gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer (commissaire(s)) beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
28.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-
mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
94883
L
U X E M B O U R G
28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-
stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen
an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.
Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt
und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls
erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene
Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht
ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den
Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen
den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“
5. Verpflichtung zur zukünftigen Einbringung von Anteilen der ECommerce Taxi Asia S.à r.l. in die Gesellschaft.
6. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse und ersucht den unterzeichnenden Notar, diese zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, fünf (5) Klassen von Anteilen zu schaffen, welche als Stammanteile (die
„Stammanteile“), Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), Anteile der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“),
Anteile der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“) und Anteile der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“) bezeichnet werden
und die bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) ohne
Einziehung von Anteilen in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile umzuwandeln.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) auf einen
Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) durch die Ausgabe von dreitausendzweihundertachtundsechzig
(3.268) Anteilen der Serie A1, achttausendeinhundertsiebzig (8.170) Anteilen der Serie A2, vierhundertacht (408) Anteilen
der Serie A3 und sechshundertvierundfünfzig (654) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die neuen Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und Anteile der Serie A4 wurden wie folgt
gezeichnet:
1. dreitausendzweihundertachtundsechzig (3.268) Anteile der Serie A1 wurden von Asia Internet Holding S.à r.l.,
vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, zu einem Zeichnungspreis von sechsundzwanzigtausendsiebenhundertfünf
Euro (EUR 26.705) gezeichnet; und
94884
L
U X E M B O U R G
2. achttausendeinhundertsiebzig (8.170) Anteile der Serie A2 wurden von MKC Brillant Services GmbH, vorbenannt,
hier vertreten wie vorerwähnt,zu einem Zeichnungspreis von dreizehntausendzweiundfünfzig Euro und dreiundvierzig
Cent (EUR 13.052,43) gezeichnet; und
3. vierhundertacht (408) Anteile der Serie A3 wurden von Aismare Lux Holdings S.à r.l., vorbenannt, hier vertreten
wie vorerwähnt, zu einem Zeichnungspreis von dreitausendfünfhundertdreiunddreißig Euro (EUR 3.533) gezeichnet; und
4. sechshundertvierundfünfzig (654) Anteile der Serie A4 wurden von TEC Global Invest IX GmbH, vorbenannt, hier
vertreten wie vorerwähnt, zu einem Zeichnungspreis von fünftausendsechshundertvierundfünfzig Euro (EUR 5.654) ge-
zeichnet.
<i>Zahlungi>
1. Die dreitausendzweihundertachtundsechzig (3.268) Anteile der Serie A1 wurden von Asia Internet Holding S.à r.l.,
vorbenannt, zu einem Gesamtzeichnungspreis von sechsundzwanzigtausendsiebenhundertfünf Euro (EUR 26.705) ge-
zeichnet und vollständig eingezahlt durch (i) eine Bareinlage in Höhe von dreitausendzweihundertachtundsechzig Euro
(EUR 3.268) und (ii) eine Sacheinlage bestehend aus:
(a) zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), der ECom-
merce Taxi Eastern Europe S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz
in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer
B 184.673, mit einem Gesamtwert von mindestens zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500); und
(b) zehntausendneunhundertsiebenunddreißig (10.937) Stammanteilen, mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1), der ECommerce Taxi Asia S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit Sitz in 7, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
unter der Nummer B 180.251, mit einem Gesamtwert von mindestens zehntausendneunhundertsiebenunddreißig Euro
(EUR 10.937).
2. Die achttausendeinhundertsiebzig (8.170) Anteile der Serie A2 wurden von MKC Brillant Services GmbH, vorbe-
nannt, zu einem Gesamtzeichnungspreis von dreizehntausendzweiundfünfzig Euro und dreiundvierzig Cent (EUR
13.052,43) gezeichnet und vollständig eingezahlt durch (i) eine Bareinlage in Höhe von achttausendeinhundertsiebzig Euro
(EUR 8.170) und (ii) eine Sacheinlage bestehend aus einem Kommanditanteil der LIH Subholding Nr. 1 UG (haftungsbe-
schränkt) & Co. KG, einer Kommanditgesellschaft gegründet und bestehend nach deutschem Recht, mit satzungsmäßigem
Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der
Nummer HRA 46945 B, mit einem Gesamtwert von mindestens viertausendachthundertzweiundachtzig Euro und drei-
undvierzig Cent (EUR 4.882,43).
3. Die vierhundertacht (408) Anteile der Serie A3 wurden von Aismare Lux Holdings S.à r.l., vorbenannt, zu einem
Gesamtzeichnungspreis von dreitausendfünfhundertdreiunddreißig Euro (EUR 3.533) gezeichnet und vollständig einge-
zahlt durch (i) eine Bareinlage in Höhe von vierhundertacht Euro (EUR 408) und (ii) eine Sacheinlage bestehend aus
dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1),
der ECommerce Taxi Asia S.à r.l., vorbenannt, mit einem Gesamtwert von mindestens dreitausendeinhundertfünfund-
zwanzig Euro (EUR 3.125).
4. Die sechshundertvierundfünfzig (654) Anteile der Serie A4 wurden von TEC Global Invest IX GmbH, vorbenannt,
zu einem Gesamtzeichnungspreis von fünftausendsechshundertvierundfünfzig Euro (EUR 5.654) gezeichnet und vollständig
eingezahlt durch (i) eine Bareinlage in Höhe von sechshundertvierundfünfzig Euro (EUR 654) und (ii) eine Sacheinlage
bestehend aus fünftausend (5.000) Anteilen der Serie A, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), der ECom-
merce Taxi Eastern Europe S.à r.l., vorbenannt, mit einem Gesamtwert von mindestens fünftausend Euro (EUR 5.000).
Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar
erbracht.
Die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von achtundvierzigtausendneunhundertvierundvierzig Euro und dreiundvierzig Cent
(48.944,43) besteht aus zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), die dem Gesellschaftskapital zugeführt werden und
aus sechsunddreißigtausendvierhundertvierundvierzig Euro und dreiundvierzig Cent (EUR 36.444,43), die dem Agio der
Gesellschaft zugeführt werden.
<i>Dritter Beschlussi>
Infolge des vorstehenden Beschlusses beschließt die Gesellschafterversammlung, Artikel fünf Punkt eins (5.1) der Sat-
zung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ 5.1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000), bestehend aus (i)
zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile”), (ii) dreitausendzweihundertachtundsechzig
(3.268) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), (iii) achttausendeinhundertsiebzig (8.170) Anteilen der Serie
A2 (die „Anteile der Serie A2“), (iv) vierhundertacht (408) Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“) und (v)
sechshundertvierundfünfzig (654) Anteilen der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“) mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1).“
94885
L
U X E M B O U R G
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der
Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Fünfter Beschlussi>
Angesichts der im ersten Beschluss ausgegebenen dreitausendzweihundertachtundsechzig (3.268) Anteile der Serie
A1 verpflichtet sich Asia Internet Holding S.à r.l. hiermit dazu, eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Stammanteile
der ECommerce Taxi Asia S.à r.l., vorbenannt, am oder nach dem 1. Oktober 2014 zu erwerben und in die Gesellschaft
einzubringen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden
Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 2.500,- geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.
Gezeichnet: A. VAN DER WIELEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 juin 2014. Relation: LAC/2014/27837. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 15. Juli 2014.
Référence de publication: 2014102069/1269.
(140122962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.
Rye Acquisitions S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 187.270.
STATUTES
In the year two thousand fourteen, on the twenty-fourth day of April.
Before, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Kildare Holdings Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited company, being registrered with the Luxembourg
Trade and Companies Registrar under number B182789, having its registered address at 65, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, represented by Louis Paletta, acting in his capacity as A manager of Kildare Holdings
Luxembourg S.àr.l., signing together with Mr Davy Toussaint, acting in his capacity as B manager of Kildare Holdings
Luxembourg S.àr.l.;
here represented by Ms Carole Gonner, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of at-
torney, given in Westlake, Texas, United States of America and in Luxembourg on 24 April 2014;
Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Rye
Acquisitions S.àr.l. "(the Company).
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly
to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration,
management, control and development of those participations.
The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from
time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable,
and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition,
development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option,
94886
L
U X E M B O U R G
securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to
develop them. The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The
Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or
affiliated companies.
The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the
obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which
form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or
all its assets.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or
indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are
directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at USD 20,000 (twenty thousand United States
dollars), represented by 20,000 (twenty thousand) shares having a nominal value of USD 1 (One United States dollar)
each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company
to an end.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. Each manager may be assigned either an
A or a B signatory power. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager
(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting
of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
94887
L
U X E M B O U R G
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two managers, and in case A and B managers have been appointed, by the joint signatures of a
manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power.
The manager, or in case of plurality of managers, any two managers, and in case A and B managers have been appointed,
a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power jointly may sub-delegate their powers for
specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager
managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation
and any other relevant conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers
attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
94888
L
U X E M B O U R G
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established
and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
Kildare Holdings Luxembourg S.àr.l., prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 (twenty thousand) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 (twenty thousand) shares
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of USD 20,000 (twenty thousand US dollars)
is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2014.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,400 (one thousand four hundred euro).
<i>Valuationi>
The share capital is valued at EUR 14,468 (fourteen thousand four hundred sixty-eight euro).
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholders representing the entire subscribed capital of the Company have
herewith adopted the following resolutions:
- the number of managers is set at 4 (four). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period
of time:
<i>As A managers:i>
- Louis Paletta, Chief Operating Officer, Kildare Partners US, LLC, whose private address is: 122 Post Oak Place,
Westlake, TX;
- Emer Finnan, Senior Managing Director, Kildare Acquisitions Ireland, Ltd., with private address in Innisfallen, 24
Sandymount Avenue, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland;
<i>As B managers:i>
- Davy Toussaint, whose professional address is 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; and
- Nicola Foley, team manager, whose professional address is 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. the registered office is established at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
94889
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof, We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove
mentioned.
The document having been read to the proxyholder(s) of the appearing party, the proxyholder(s) of the appearing
party signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Kildare Holdings Luxembourg S.àr.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B182789, avec siège social au 65, Bd Grande-
Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, représentée par Louis Paletta agissant en capacité de gérant A de Kildare
Holdings Luxembourg S.àr.l., signant conjointement avec M. Davy Toussaint, agissant en capacité de gérant B de Kildare
Holdings Luxembourg S.àr.l.
ici représentée par Maître Carole Gonner, avocate, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée à Westlake, Texas, Etats-Unis et au Luxembourg, le 24 avril 2014;
Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter
ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.
Art. 1
er
. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Rye Acquisitions S.àr.l." (ci-
après, la Société).
Art. 2. Objet social. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme
que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils
seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles,
mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour
participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie
d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des droits intellectuels, pour en disposer par voie
de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut octroyer des licences et des droits
intellectuels de toute origine.
La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme
nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts
et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.
La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société
faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité
à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties.
Elle peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur toute ou partie de ses avoirs.
En plus, la Société peut acquérir et céder des propriétés immobilières, pour son propre compte, à la fois au Grand-
Duché de Luxembourg et à l'étranger et elle peut effectuer toutes les opérations en relation avec des propriétés
immobilières, y inclus la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères
qui ont comme objet principal l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et la location de propriétés
immobilières.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
94890
L
U X E M B O U R G
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale
extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de
gérance.
La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 20.000 USD (vingt mille dollars des Etats-
Unis d’Amérique) et est représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1 (un dollar des
Etats-Unis d’Amérique) chacune.
Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de
l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.
Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des
parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.
Art. 9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
Loi de 1915) doivent être respectées.
Art. 10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose
à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en
vertu de l'article 15 des statuts sont d'application.
Art. 11. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de
l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.
Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. A chaque gérant peut être attribué soit un pouvoir
de signature A, soit un pouvoir de signature B. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance.
Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée
générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer
le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société
en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous
réserve du respect des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature conjointe de deux gérants quelconques et, en présence de gérants A et B, par la signature conjointe d'un
gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant ou, en présence de gérants A et B, un gérant ayant un
pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement, pourront déléguer leurs compétences
pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants,
les gérants qui délèguent détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré),
la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du
conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance
pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des
gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.
94891
L
U X E M B O U R G
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par tout gérant. On pourra passer outre cette
convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de
l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une
heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant
comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,
visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent
part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par
conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait
référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance,
si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion
du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. Assemblées générale des associés. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se
tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convo-
cation à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le
conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 18. Distribution des bénéfices, réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,
déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du
capital social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le gérant unique ou,
en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Commissaire aux comptes - réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société
doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur
d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
94892
L
U X E M B O U R G
Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en
réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par:
Kildare Holdings Luxembourg S.àr.l., susmentionnée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 parts sociales
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de 20.000 USD (vingt
mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentaire.
<i>Dispositions Transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31décembre 2014.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.400 (mille quatre cents
euros).
<i>Evaluation du capital sociali>
Le capital social est évalué à EUR 14.468 (quatorze mille quatre cent soixante-huit euros).
<i>Assemblée Générale Constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés représentant la totalité du capital souscrit
ont pris les résolutions suivantes:
1. les membres du conseil de gérance sont au nombre de 4 (quatre). Sont nommés pour une durée indéterminée:
<i>En tant que gérants A:i>
- Louis Paletta, Chief Operating Officer, Kildare Partners US, LLC, dont l'adresse privée est: 122 Post Oak Place,
Westlake, TX 76262, Etats-Unis d’Amérique;
- Emer Finnan, Senior Managing Director, Kildare Acquisitions Ireland, Ltd, dont l'adresse privée est à Innisfallen, 24
Sandymount Avenue, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande
<i>En tant que gérants B:i>
- Davy Toussaint, dont l'adresse professionnelle est au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; et
- Nicola Foley, team manager, dont l'adresse professionnelle est au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. le siège social de la société est établi au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: C. Gonner et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 avril 2014. LAC/2014/19859. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signée): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Référence de publication: 2014075044/400.
(140088339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Fivecom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 69.638.
L'an deux mille quatorze,
le treize mai.
94893
L
U X E M B O U R G
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires Assemblée») de la société «FIVECOM S.A.» (la «Société»), une
société anonyme, établie et ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 28 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 531 du 10 juillet 1999.
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 69
638.
Les statuts de la Société furent modifiés tout dernièrement par acte dressé par le notaire soussigné, en date du 1
er
décembre 2004, lequel acte de modification des statuts fut régulièrement publié au Mémorial, en date du 16 avril 2005,
sous le numéro 341 et page 16337.
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alessandro DI ROBERTO, employé privé, avec adresse
professionnelle à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à
Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Emanuela MORANDI, employée privée, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'Assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Le Président expose et l'Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Présentation et approbation du bilan au 31 décembre 2013;
2) Affectation du résultat au 31 décembre 2013;
3) Décharge pleine et entière à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur
mandat relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013;
4) Délibération conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle qu'elle a
été modifiée);
5) Présentation et approbation du bilan intérimaire et du compte de pertes et profits au 06 mai 2014;
6) Dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation;
7) Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs;
8) Nomination d'un Commissaire-Vérificateur à la liquidation.
B) Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social actuellement fixé à CINQUANTE MILLE EUROS
(50'000.- EUR) est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets
portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée prend acte de la lecture et de la présentation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire
aux Comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2013.
De même l'Assemblée APPROUVE sans restriction ni réserve le bilan de la Société arrêté au 31 décembre 2013.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE de reporter les pertes de l'année 2013.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE d'accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de
la Société, pour l'accomplissement de leur mandat relativement à l'exercice clos le 31 décembre 2013.
94894
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE d'approuver sans restriction ni réserve le bilan intérimaire et du compte des pertes et profits
de la Société au 06 mai 2014.
<i>Cinquième résolutioni>
Conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée, l'Assemblée prend acte qu'à l'heure actuelle les pertes de la Société dépassent cinquante pour cent (50%)
en l'occurrence soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société et DECIDE de procéder à la dissolution
immédiate de la Société «FIVECOM S.A.».
L'Assemblée DECIDE de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
Compte tenu de tout ce qui précède, l'Assemblée DECIDE de nommer Monsieur Arsène KRONSHAGEN, avocat, né
à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 1955, avec adresse professionnelle au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg,
aux fonctions de seul liquidateur (le «Liquidateur») de la Société.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE d'investir le Liquidateur des pouvoirs suivants:
- le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, telles que modifiées.
- le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée
Générale des Associés dans les cas où elle est requise.
- le Liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.
<i>Huitième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE de nommer la société:
«LG Management S.à r.l.», une société à responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois établie et ayant son
siège social au 7, rue Portland, L-4281 Esch-sur-Alzette (RCS Luxembourg, section B numéro 156 639),
aux fonctions de Commissaire-Vérificateur à la liquidation de la Société.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ces
derniers ont signé avec Nous le notaire soussigné le présent acte.
Signé: A. DI ROBERTO, B. D. KLAPP, E. MORANDI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 mai 2014. Relation: EAC/2014/6777. Reçu douze Euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2014074679/95.
(140087640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Euro Trade International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 69.157.
Im Jahre zweitausendvierzehn, den dreiundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Versammelte sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, der Aktiengesellschaft “Euro Trade In-
ternational S.A.”, mit Sitz in L-5619 Mondorf-Les-Bains, 20, Rue John Grun, eingetragen im Handels- und Gesellschafts-
register von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 69.157, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar
Christine Doerner, mit Amtssitz in Bettemburg, am 8. März 1999, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations Nummer 450 vom 15. June 1999.
Den Vorsitz der Versammlung führt, Dame Géraldine Nucera, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in L-2740 Luxemburg
welcher zur Schriftführerin Dame Virginie Pierru, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in L-2740 Luxemburg, ernennt.
Die Versammlung bestellt als Stimmenzähler Herr Olivier Differdange, Geschäftsführer, beruflich wohnhaft in L-1420
Luxemburg.
94895
L
U X E M B O U R G
Gegenwärtigem Protokoll liegt die Präsenzliste der Aktien bei; welche Liste von dem Vertreter des alleinigen Aktionärs,
sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.
Da sämtliche Aktien der Gesellschaft vertreten sind, erübrigte sich eine Einberufung; somit ist gegenwärtige Ver-
sammlung rechtsgültig zusammengetreten.
Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg und Änderung von Artikel 2
der Satzung.
2. Verschiedenes.
Die Versammlung, nach vorheriger Beratung nahm, einstimmig folgenden Beschluss:
<i>Einziger Beschlussi>
Der Gesellschaftssitz wird nach L-1420 Luxemburg, 5, avenue Gaston Diderich verlegt, und somit wird die erste Satz
von Artikel 2 wie folgt abgeändert:
„ Art. 2. (Erster Satz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg“
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde gegenwärtige Versammlung abgeschlossen.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt 790.- Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der
Gesellschaft.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: G.NUCERA, O.DIFFERDANGE, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 avril 2014. Relation: LAC/2014/18956. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Référence de publication: 2014074625/44.
(140088431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Goodman Flame Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 175.734.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 26. Mai 2014.
Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notari>
Référence de publication: 2014074699/14.
(140087894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Freetop Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 148.515.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014074684/10.
(140088281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
94896
Affinia Luxembourg Finance S.à r.l.
Berbou International Sàrl
Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l.
Euro Trade International S.A.
Financière Prooftag S.A.
Finexsto S.à r.l.
Fiscobelux S.A.
Fivecom S.A.
Foyer Finance S.A.
Freetop Invest S.A.
Galena Investments S.à r.l.
Genel Alpay International Sàrl
Generaltrade S.A.
GERI Consult G.m.H.
Gestlux Management S.A.
GLN Investment
GLN Investment
Global Management Consulting S.à.r.l.
Global Palaces Real Estate S.à r.l.
Global PepsiCo Luxembourg Holdings S.à r.l.
Goodman Flame Logistics (Lux) S.à r.l.
GPN Capital S.A.
Gracewell Investment N°6 S.à r.l.
Granada S.A.
Great Bio Energies S.à r.l.
Gries S.A.
Hanscan
Haute Tension S.à r.l.
Heaven Services S.A.
Helena Debtco S.à r.l.
HIB, Holding Invest Batiment S.A.
Hôtel Schumacher Sàrl
Hôtel Schumacher Sàrl
Hôtel Schumacher Sàrl
Hyosung Luxembourg S.A.
Ibos II Luxembourg S.A.
Icaria Invest S.à r.l.
Ikano Finance (Russia) S.A.
Immibel S.A.
Immo Hesperange S.à r.l.
Innovation Arch
Intermind
Invenergy Wind Canada Operational S.à r.l.
Invista European Real Estate Bel-Air Holdings S.à r.l.
Invista European Real Estate Finance S.à r.l.
Invista European Real Estate Holdings S.à r.l.
Invista European RE Delta HoldCo S.à r.l.
Invista European RE Pocking PropCo S.à r.l.
ION Investments S.à r.l.
IP Crossroads S.A.
Rye Acquisitions S.àr.l.
Sapori & Gusti S.à.r.l.
Sargos Properties S.à r.l.
Schengen RCG Re SCA
Seema II S.à r.l.
Seema Management S.à r.l.
Seema Management S.à r.l.
Seema S.à r.l.
Seema S.à r.l.
Siegwerk Holding Luxembourg S.A.
Société Luxembourgeoise de Restauration et d'Hôtellerie
Sofidra S.A.
Sun Properties S.à r.l.
UPA - Union des Propriétaires d'Avions
Woodford S.à r.l.