logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1789

10 juillet 2014

SOMMAIRE

Amcoll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85832

AMP Capital Strategic Infrastructure

Trust of Europe (EUR) SICAV-SIF . . . . . .

85835

Anglo American Finland Holdings 1  . . . . .

85829

Anglo American Finland Holdings 2  . . . . .

85829

ARAM Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85836

Armat Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85832

Avatar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85833

Barentz Ravago Chemical Specialist S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85845

Bau Cap Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85852

Chamelle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85828

Clemency RCG Re SCA  . . . . . . . . . . . . . . . .

85853

Countryside Real Luxury Estate S.à r.l. . . .

85837

Delta Shipping & Chartering S.A. . . . . . . . .

85827

Dontas Law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85828

EEM World S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85826

EuroAmerica AM SICAV  . . . . . . . . . . . . . . .

85859

Financière Ervacace Holding Company

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85831

F.T.A. Satellite Communication Technolo-

gies Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85828

GFA - HAIG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85833

Guliver Demografie Sicherheit  . . . . . . . . . .

85832

Hahn FCP-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85831

Hydro-Get Enviromental Investment S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85839

Immobilière Saint Marcel S.A.  . . . . . . . . . .

85829

Impect SCSp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85834

KSK LB Exklusiv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85832

KSS Holdings S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85872

Larochette RCG Re SCA  . . . . . . . . . . . . . . .

85853

LUX Global Real Estate FCP-SIF  . . . . . . . .

85830

Mac Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85858

Midilux Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85828

Mokaline S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85839

Montigny S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85826

Plexus Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

85832

Polyver Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85849

Premium Portfolio SICAV  . . . . . . . . . . . . . .

85833

Premium Portfolio SICAV  . . . . . . . . . . . . . .

85834

ProLogis European Finance XI S.àr.l.  . . . .

85827

Promotrust S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85842

Ravago Chemicals S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

85845

Schengen RCG Re SCA  . . . . . . . . . . . . . . . . .

85853

SecureValue E.E.I.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85831

Sevchukmorneftegaz Holding SARL  . . . . .

85830

Stabilus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85826

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav  . . . . . . .

85833

Swiss Rock (Lux) Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85834

Tudor Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

85827

Tulipan SCSp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85835

Vianden RCG Re SCA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85853

Werte & Sicherheit Nr. 1  . . . . . . . . . . . . . . .

85831

Wiltz RCG Re SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85853

85825

L

U X E M B O U R G

EEM World S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue 1900.

R.C.S. Luxembourg B 166.088.

Les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>31 juillet 2014 à 14.30 heures en l'étude de Me Joëlle Baden sise à L - 2018 Luxembourg, 17, rue des

Bains, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à L - 8041 Strassen, 65, rue des Romains;
2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts;
3. Nomination d'administrateurs.
Les formalités à accomplir pour l'accès à l'assemblée générale sont visées à l'article 9 des statuts.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014096689/16.

Montigny S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 43.632.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>28 juillet 2014 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 avril 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Notification du report de l'approbation des comptes annuels au 30 avril 2014
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014097789/795/16.

Stabilus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 151.589.

En date du 5 mai 2014, le conseil de surveillance de la Société a nommé les personnes suivantes comme membres du

directoire de la Société:

(a) Dietmar Siemssen, ayant comme adresse professionnelle le 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, a été

nommé Directeur Général pour un mandat de 4 (quatre) ans jusqu'au 5 mai 2018 (inclus);

(b) Mark Wilhelms, ayant comme adresse professionnelle le 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, a été

nommé Directeur Financier pour un mandat de 3 (trois) ans jusqu'au 5 mai 2017 (inclus);

(c) Bernd-Dietrich Bockamp, ayant comme adresse professionnelle le 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,

a été nommé membre du directoire pour un mandat de 1 (un) an jusqu'au 5 mai 2015; (inclus) et

(d) Andreas Schröder, ayant comme adresse professionnelle le 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, a été

nommé membre du directoire pour un mandat de 1 (un) an jusqu'au 5 mai 2015 (inclus).

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Stabilus S.A.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2014064516/21.
(140075022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.

85826

L

U X E M B O U R G

Delta Shipping &amp; Chartering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 172.225.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Delta Shipping &amp; Chartering S.A. welche am <i>28. Juli 2014 um 12.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit

der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

<i>Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2014092516/17.

Tudor Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 147.042.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Tudor Investments S.A., welche am <i>28. Juli 2014 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nach-

folgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

<i>Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Mandatsverlängerungen
6. Verschiedenes

<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2014091718/18.

ProLogis European Finance XI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.139.750,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.210.

<i>Extrait de la traduction des résolutions prises par les associés de la Société du 07 Mai 2014

Il a été décidé:
- La démission de Mr Gareth Alan Gregory avec effet au 07 mai 2014 en tant que gérant de la Société a été acceptée.
- Mr Peter Cassells, né le 25 juin 1965 (Dublin, Irlande), résidant professionnellement au 34-38, Avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg a été nommé gérant de la Société avec effet au 07 mai 2014.

Le nouveau gérant a été nommé pour un mandat d'une durée indéterminée.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus afin d'agir au nom de la Société en toutes circonstances et pourront

individuellement engager valablement la Société par leur seule signature.

Luxembourg, le 08 mai 2014.

Gerrit Jan Meerkerk
<i>Gérant

Référence de publication: 2014065248/19.
(140076145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.

85827

L

U X E M B O U R G

F.T.A. Satellite Communication Technologies Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 38.420.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014064160/9.
(140074858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.

Dontas Law, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 177.648.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2014.

Référence de publication: 2014064120/10.
(140074904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.

Chamelle S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 65.069.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 11 août 2014 à 16.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 26 juin 2014 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 6 de l'ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014092515/696/15.

Midilux Holdings S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 6.749.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juillet 2014 à 11.00 heures au siège social.
Cette assemblée est le report de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2014, dont l'ordre du jour est le suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Nomination d'un nouveau réviseur d'entreprises agréé en remplacement d'AbaCab S.à r.l., démissionnaire, avec

mission à partir des comptes au 31 décembre 2013.

2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels

de l'exercice 2013.

3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2013 et au Réviseur d'entre-

prises agréé pour l'exercice de son mandat se rapportant au bilan clôturé au 31 décembre 2013.

5. Ré-élections statutaires des Administrateurs pour un nouveau terme d'un an.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014090724/20.

85828

L

U X E M B O U R G

Anglo American Finland Holdings 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 163.185.

Le bilan consolidé de la société Anglo American plc au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2014.

Référence de publication: 2014063905/11.
(140075312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.

Anglo American Finland Holdings 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 163.186.

Le bilan consolidé de la société Anglo American plc au 31 décembre 2013, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2014.

Référence de publication: 2014063907/11.
(140075310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.

Immobilière Saint Marcel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 99.814.

Messieurs, Mesdames, Chers actionnaires, nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le <i>mercredi

<i>28 juillet 2014 , à 10.00 heures, au siège social, en

ASSEMBLEE GENERALE

tenue extraordinairement à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Après lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de

l'exercice clos des années 2009, 2010, 2011 et 2012 :

Résolution 1:
Approbation par les actionnaires des comptes rectifiés clôturés au 31.12.2009 et affectation du résultat de l'exercice

2009.

Résolution 2:
Approbation par les actionnaires des comptes rectifiés clôturés au 31.12.2010 et affectation du résultat de l'exercice

2010.

Résolution 3:
Approbation par les actionnaires des comptes rectifiés clôturés au 31.12.2011 et affectation du résultat de l'exercice

2011.

Résolution 4:
Approbation par les actionnaires des comptes rectifiés clôturés au 31.12.2012 et affectation du résultat de l'exercice

2012.

Résolution 5:
Approbation par les actionnaires de procéder à un prélèvement sur le bénéfice reporté de l'année 2010 et d'affecter

ce montant à la réserve prévue par la loi du 19.08.1915.

Résolution 6:
Approbation par les actionnaires des acomptes distribués sur dividendes aux résultats reportés en les déduisant des

résultats disponibles et distribuables après constitution des réserves.

Approbation par les actionnaires de distribution d'un complément de dividendes sur les résultats disponibles après

déduction des réserves légales et acomptes sur les dividendes déjà distribués.

Présentation du détail du compte de résultat et des résultats disponibles après affectations aux réserves et après

distribution des dividendes.

85829

L

U X E M B O U R G

Résolution 7:
Les actionnaires réunies donnent pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l'exercice de leur mandat pour et pendant les exercices 2009, 2010, 2011 et 2012.

Résolution 8: Examen de la situation des mandats
Approbations par les actionnaires des démissions des anciens administrateurs et nomination de nouveaux adminis-

trateurs pour un nouveau mandat de 6 ans allant jusqu'à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2020, à
savoir:

1. Monsieur Jean-Louis BONET-MAURY, retraité, demeurant à F-76810 GREUVILLE, 130 rue de la Grande Mare,
2. Monsieur Olivier BONET-MAURY SCHALLER, administrateur, demeurant à F-76740 Saint Aubin sur Mer, Villa "Les

Hêtres", 33, rue de l'Isolette,

3. Madame Nicole BONET-MAURY, retraitée, demeurant à F-76740 Saint Aubin sur Mer, Villa "Les Hêtres", 33, rue

de l'Isolette.

Résolution 9:
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes par les actionnaires, à savoir la société DANA SERVICES Sàrl.
Résolution 10:
Nomination de nouveaux gérants de la SCI 83, BOULEVARD SAINT MARCEL, soit les personnes suivantes:
1. Monsieur Jean-Louis BONET-MAURY, retraité, demeurant à F-76810 GREUVILLE, 130, rue de la Grande Mare,
2. Madame Nicole BONET-MAURY, retraitée, demeurant à F-76740 Saint Aubin sur Mer, Villa "Les Hêtres", 33, rue

de l'Isolette.

Résolution 11:
Questions diverses.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014095395/57.

LUX Global Real Estate FCP-SIF, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion de LUX Global Real Estate FCP-SIF a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.

Référence de publication: 2014096187/9.
(140114303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Sevchukmorneftegaz Holding SARL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 185.306.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication des statuts dans le Mémorial C n° 1200 du 12 mai 2014, page 57583,

version anglaise, la répartition des parts pour Rosneft Shareholder:

au lieu de:
"(...)
Rosneft Shareholder:
ten thousand (10,000) Ordinary Shares; and
one hundred (100) Class A Preferred Shares.
(...)",
lire:
" (...)
Rosneft Shareholder:
twenty thousand (20,000) Ordinary Shares; and
two hundred (200) Class A Preferred Shares.
(...)".
Référence de publication: 2014097773/21.

85830

L

U X E M B O U R G

Hahn FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion de HAHN FCP-FIS a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.

Référence de publication: 2014096186/8.
(140114302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Werte &amp; Sicherheit Nr. 1, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion coordonné au 26 mai 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, mai 2014.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014071473/10.
(140083401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2014.

Financière Ervacace Holding Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 28.180.

<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2013

Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 décembre que:
-  le  mandat  des  administrateurs  actuellement  en  place,  à  savoir  Monsieur  Max  GALOWICH,  Monsieur  Jean-Paul

FRANK et Monsieur Georges GREDT est reconduit pour une nouvelle période de six ans,

- le mandat du commissaire aux comptes LUX-AUDIT S.A. est reconduit pour une nouvelle période de six ans.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

qui se tiendra en 2019.

Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, a

été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur de la société qui prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2019.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Référence de publication: 2014065003/19.
(140076058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.

SecureValue E.E.I.G., Groupement Européen d'Intérêt Economique.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg D 96.

PROJET DE TRANSFERT

Il résulte des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du GEIE qui s'est tenue le 8 avril 2014

que le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale des membres du GEIE de transférer le siège
social du GEIE de son adresse actuelle située au 7, avenue J.P. Pescatore L-2324 Luxembourg à 3 Burlington Gardens,
London W1S 3EP (le "Transfert").

De par le fait que le Transfert a une dimension transfrontalière, il se doit de respecter les conditions indiquées à l'article

14 du Réglement (CEE) No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt
économique selon les termes duquel le conseil d'administration du GEIE doit préparer un projet de transfert et le faire
publier au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Publication"). Le conseil de gérance du GEIE pourra
proposer le Transfert à l'assemblée générale des membres du GEIE après une période de deux mois suivant la Publication.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SecureValue E.E.I.G.

Référence de publication: 2014075849/19.
(140089265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.

85831

L

U X E M B O U R G

KSK LB Exklusiv, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de KSK LB Exklusiv a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.

Référence de publication: 2014096188/8.
(140114304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Guliver Demografie Sicherheit, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Guliver Demografie Sicherheit a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.

Référence de publication: 2014096189/9.
(140114305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Amcoll, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 159.244.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2014.

Référence de publication: 2014063900/10.
(140075319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.

Armat Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 176.840.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08.05.2014.

Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2014063919/12.
(140074985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.

Plexus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 186.603.

Il résulte d'une des décisions prises en date du 18 juin 2014 par le conseil de gérance de la Société, de transférer avec

effet  immédiat  à  la  date  de  ladite  résolution,  la  Société  de  son  siège  social  actuel  vers  son  nouveau  siège  social  qui
dorénavant sera dans les bureaux de la société Ogier Fiduciary Services (Luxembourg) S.àr.l. sise au 2-4 rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro
B 167609.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg le 7 juillet 2014.

Référence de publication: 2014097438/15.
(140115319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

85832

L

U X E M B O U R G

GFA - HAIG, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Verwaltungsreglement, welches am 18. Juni 2014 in Kraft trat. Das Verwaltungsreglement wurde

beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg einregistriert und hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 18. Juni 2014.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2014086187/11.
(140102488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

Avatar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 150.546.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2014.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014063930/12.
(140075082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.

Premium Portfolio SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 137.056.

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds

Premium Portfolio SICAV - Türkische Lira Anleihen

(WKN: A0Q5Z4 / ISIN: LU0376358049)

Hiermit werden die Aktionäre darüber informiert, dass der vorgenannte Teilfonds mit Wirkung zum 30. Juni 2014

liquidiert wurde. Der Liquidationserlös wurde mit Liquidationsabschluss ausgezahlt. Alle Aktionäre wurden erreicht, es
erfolgt keine Zahlung an die Caisse de Consignation. Die Auflösung des Teilfonds erfolgte ebenfalls zu diesem Datum.

Luxembourg, im Juli 2014
Référence de publication: 2014097787/755/13.

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 137.055.

<i>Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss im Umlaufverfahren vom 13. Mai 2014

Der Verwaltungsrat der Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav (die „Gesellschaft“) nimmt zur Kenntnis, dass Herr Stefan

Klass als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 31. März 2014 von seinem Mandat zurücktritt.

Der Verwaltungsrat beschließt, Herrn Lobsang Gangshontsang, Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Rock Asset

Management AG, beruflich ansässig in Rigistrasse 60, CH-8006 Zürich, Schweiz, mit Wirkung zum 1. Juli 2014 zum Mitglied
des Verwaltungsrates der Gesellschaft zu kooptieren.

Die Kooptation von Herrn Lobsang Gangshontsang als Verwaltungsratsmitglied unterliegt der Zustimmung der nächs-

ten ordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre (24. September 2014).

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav
<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2014096477/18.
(140114301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

85833

L

U X E M B O U R G

Premium Portfolio SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 137.056.

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds

Premium Portfolio SICAV - Südafrikanischer Rand Anleihen

(WKN: A0Q5Z5 / ISIN: LU0376358395)

Hiermit werden die Aktionäre darüber informiert, dass der vorgenannte Teilfonds mit Wirkung zum 30. Juni 2014

liquidiert wurde. Der Liquidationserlös wurde mit Liquidationsabschluss ausgezahlt. Alle Aktionäre wurden erreicht, es
erfolgt keine Zahlung an die Caisse de Consignation. Die Auflösung des Teilfonds erfolgte ebenfalls zu diesem Datum.

Luxembourg, im Juli 2014
Référence de publication: 2014097788/755/13.

Swiss Rock (Lux) Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 135.671.

<i>Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss im Umlaufverfahren vom 13. Mai 2014

Der Verwaltungsrat der Swiss Rock (Lux) Sicav (die „Gesellschaft“) nimmt zur Kenntnis, dass Herr Stefan Klass als

Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 31. März 2014 von seinem Mandat zurücktritt.

Der Verwaltungsrat beschließt, Herrn Lobsang Gangshontsang, Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Rock Asset

Management AG, beruflich ansässig in Rigistrasse 60, CH-8006 Zürich, Schweiz, mit Wirkung zum 1. Juli 2014 zum Mitglied
des Verwaltungsrates der Gesellschaft zu kooptieren.

Die Kooptation von Herrn Lobsang Gangshontsang als Verwaltungsratsmitglied unterliegt der Zustimmung der nächs-

ten ordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre (15. Oktober 2014).

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Swiss Rock (Lux) Sicav
<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2014096478/18.
(140114300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Impect SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldrigen.

R.C.S. Luxembourg B 187.934.

EXTRAIT

1. Date de constitution. La société a été constituée en date du 18 juin 2014.

2. Forme juridique. Société en commandite spéciale.

3. Dénomination sociale. La dénomination de la société est Impet SCSp.

4. Siège social. Le siège social de la société est établi au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.

5. Objet social.
1. L'objet de la société est l'acquisition et la détention de participations dans des sociétés luxembourgeoises et/ou

étrangères ainsi que l'administration, le développement et la gestion de ces participations.

2. La société pourra fournir tout support financier aux sociétés faisant partie du même groupe que la société, tel que

l'octroi de prêts et de garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

3. La société pourra également utiliser ses fonds et actifs aux fins d'investissement immobilier et, à condition que ces

investissements soient accessoires ou liés à l'acquisition, à la détention, à l'administration, au développement et à la gestion
de la société faisant partie du même groupe que la société, elle pourra investir dans des droits de propriété intellectuelle
ou autres actifs mobiliers ou immobiliers de toute nature ou forme.

4. La société pourra emprunter sous toute forme et pourra procéder à l'émission privée d'obligations, billets ou autres

instruments de dette.

5. La société pourra de manière générale faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle

estimera utile à la réalisation et au développement de son objet social.

6. Durée. La société est établie pour une durée illimitée.

85834

L

U X E M B O U R G

7. Associé commandité. Impet Investment sp. Z o.o., société à responsabilité limitée de droit polonais ayant son siège

social à ul. Dabrowskiego, 2, PL-41-800 Zabrze, Pologne et immatriculée au National Court Register sous le numéro KRS
0000512333.

8. Gérants.

<i>a) Gérant de classe A:

i) Mr. Bartlomiej Tarnowka, né le 10/11/1979 à Poznan (Pologne), et demeurant à Ul. Wolnosci 524c/3, 41-806 Zabrze

(Pologne),

ii) Mrs. Agnieszka Magdalena Tarnowka, née le 31/10/1986 à Zabrze (Pologne), demeurant à Ul. Szczecinska 60, 41-814

Zabrze (Pologne),

<i>b) Gérants de classe B:

i) M. Raphaël BENAYOUN, né le 06/08/1984 à Marseille (France) et demeurant professionnellement au 23, rue Al-

dringen à L-1118 Luxembourg.

ii) M. Philippe AFLALO, né le 18/12/1970 à Fès (Maroc) et demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen à

L-1118 Luxembourg.

9. Pouvoir de signature des gérants. La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique

et en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux gérants y compris, le cas échéant, au moins un gérant
de chaque classe (y compris par voie de représentation).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2014.

Référence de publication: 2014087764/45.
(140104145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2014.

AMP Capital Strategic Infrastructure Trust of Europe (EUR) SICAV-SIF, Société en Commandite par

Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 138.814.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014063901/10.
(140074344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.

Tulipan SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldrigen.

R.C.S. Luxembourg B 187.931.

EXTRAIT

1. Date de constitution. La société a été constituée en date du 18 juin 2014.

2. Forme juridique. Société en commandite spéciale.

3. Dénomination sociale. La dénomination de la société est Tulipan SCSp.

4. Siège social. Le siège social de la société est établi au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.

5. Objet social.
1. L'objet de la société est l'acquisition et la détention de participations dans des sociétés luxembourgeoises et/ou

étrangères ainsi que l'administration, le développement et la gestion de ces participations.

2. La société pourra fournir tout support financier aux sociétés faisant partie du même groupe que la société, tel que

l'octroi de prêts et de garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

3. La société pourra également utiliser ses fonds et actifs aux fins d'investissement immobilier et, à condition que ces

investissements soient accessoires ou liés à l'acquisition, à la détention, à l'administration, au développement et à la gestion
de la société faisant partie du même groupe que la société, elle pourra investir dans des droits de propriété intellectuelle
ou autres actifs mobiliers ou immobiliers de toute nature ou forme.

4. La société pourra emprunter sous toute forme et pourra procéder à l'émission privée d'obligations, billets ou autres

instruments de dette.

5. La société pourra de manière générale faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle

estimera utile à la réalisation et au développement de son objet social.

85835

L

U X E M B O U R G

6. Durée. La société est établie pour une durée illimitée.

7. Associé commandité. Kumar Investment sp. Z o.o., société à responsabilité limitée de droit polonais ayant son siège

social à ul. Dabrowskiego, 2, PL-41-800 Zabrze, Pologne et immatriculée au National Court Register sous le numéro KRS
0000512340.

8. Gérants.

<i>a) Gérant de classe A:

i) Mr. Michal Krzysztof Nowrotek, né le 16/08/1976 à Bytom (Pologne), et demeurant à Henryka Wieniawskiego 15,

41-807 Zabrze (Pologne),

ii) Mr. Henryk Jan Rupik, né le 27/01/1956 à Bytom (Pologne), et demeurant à Wroclawska 42 m 21, 40-217 Katowice

(Pologne),

<i>b) Gérants de classe B:

i) M. Raphaël BENAYOUN, né le 06/08/1984 à Marseille (France) et demeurant professionnellement au 23, rue Al-

dringen à L-1118 Luxembourg.

ii) M. Philippe AFLALO, né le 18/12/1970 à Fès (Maroc) et demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen à

L-1118 Luxembourg.

9. Pouvoir de signature des gérants. La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique

et en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux gérants y compris, le cas échéant, au moins un gérant
de chaque classe (y compris par voie de représentation).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2014.

Référence de publication: 2014088114/45.
(140104075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2014.

ARAM Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 148.872.

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois «ARAM Holding

S.A.», avec siège social à L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville, constituée suivant acte reçu par notaire instrumentant,
en date du 20 octobre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2231 du 14 novembre
2009, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 148.872.

L’assemblée est présidée par Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne WILK, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Lu-

xembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L’assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Marc FUNCK, employé privé, et Madame Sabine LEMOYE, employée

privée, tous deux demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que la société a un capital social de soixante-douze millions cent soixante-douze mille euros (EUR 72.172.000,00),

représenté par soixante-douze mille cent soixante-douze (72.172) actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR
1.000,00) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

II.- Que conformément à l’article 67-1 paragraphe 1 et de l’article 70 de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés

commerciales, telle que modifiée (ci-après la «loi»), les actionnaires ont été convoqués par le biais d’avis de convocation
comportant l’ordre du jour de la présente assemblée, deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant la
tenue de la présente assemblée.

III.- Que lesdits avis de convocations ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro

1443 du 5 juin 2014 et au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1533 du 14 juin 2014.

IV.- Que lesdits avis de convocations ont été publiés au Lëtzebuerger Journal le 5 juin 2014 et le 14 juin 2014.
V.- Qu’une copie desdits avis de convocation a été déposée auprès des membres du bureau de la présente assemblée.
VI.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Ladite liste de présence ainsi que les procurations
resteront, après avoir été signés «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, annexés au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

85836

L

U X E M B O U R G

VII.- Qu’il ressort de ladite liste de présence que sur les soixante-douze mille cent soixante-douze (72.172) actions

représentant l’entièreté du capital social, seules cinquante-quatre mille cent vingt-neuf actions (54.129) sont présentes
ou représentées à la présente assemblée.

VIII. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l’ordre du

jour conçu comme suit:

1. Transfert du siège social de L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville, à L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roo-

sevelt.

2. Modification subséquente de l’article 2 des statuts.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité des voix

présentes ou représentées les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville, à L-2450 Lu-

xembourg, 17, boulevard Roosevelt.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 2 des statuts sera désormais lu comme suit:

« Art. 2. Siège social. La Société a son siège social établi à Luxembourg.
Il peut être transféré à tout autre endroit de la localité de Luxembourg par une décision de l’Administrateur unique

ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où l’Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration, estimerait

que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale
au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son
siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connais-
sance des tiers par l’Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration ou
par toute société ou personne à qui l’Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Ad-
ministration a confié la gestion journalière de la Société».

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. KIRSCH, A. WILK, M. FUNCK, S. LEMOYE, E. SCHLESSER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 juin 2014. Relation: LAC/2014/29145. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Référence de publication: 2014094526/75.
(140113232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2014.

Countryside Real Luxury Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 188.273.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, den fünfundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile SCHLESSER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame.

Ist erschienen:

Frau Stefanie MONNIER, selbstständige Beraterin, geboren am 31. Mai 1964 in Thun (Schweiz), wohnhaft in CH-3011

Bern (Schweiz), 2, Spitalgasse (nachfolgend die „Komparentin“).

Diese Komparentin ersucht den amtierenden Notar, die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter

Haftung zu beurkunden wie folgt:

85837

L

U X E M B O U R G

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht gegründet, die dem

nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie der diesbezüglichen Gesetzgebung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Ankauf und Verkauf von Immobilien zum Eigennutzen, sowie die Beratung und

administrative Dienstleistungen im Immobilienbereich generell und spezifisch Beratungen jeder Art betreffend strategische
Koordination, Organisation und Einrichtung von Wohn- und Geschäftsräumen, sowie Dienstleistungen im Import/Export-
Geschäft.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jede Maßnahme treffen und Handlungen vornehmen, die sie für die Erfüllung und

die Entwicklung ihres Geschäftszwecks für erforderlich erachtet.

Die Gesellschaft kann zudem jegliche kaufmännische und industrielle Geschäfte in sämtlichen Sektoren vornehmen,

die ihr zur Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks nützlich erscheinen.

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen "COUNTRYSIDE REAL LUXURY ESTATE S.à r.l.".

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Großherzog-

tums verlegt werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) und ist in einhundert (100)

Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,00) eingeteilt.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bedingungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Gesellschaftsanteile sind frei übertragbar, solange die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter besteht.
Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder

an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und welche

von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.
Die Gesellschaft verpflichtet sich, den Geschäftsführer in Bezug auf sämtliche Verluste, Schäden oder Ausgaben auf-

grund einer Klage oder eines Prozesses schadlos zu halten, durch die oder den er in seiner ehemaligen oder derzeitigen
Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft belangt werden könnte, außer er wird infolge einer solchen Klage oder
in einem solchen Prozess endgültig wegen schwerer Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher schlechter Verwaltung verurteilt.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung

ihres Mandats verantwortlich.

Art. 14. Solange die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter besteht, hat dieser alle Befugnisse, die das Gesetz der

Gesellschafterversammlung gibt.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen, sind die Beschlüsse der

Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
darstellen, angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind nur dann rechtswirk-
sam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausendvierzehn.

Art. 16. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und die Geschäfts-

führung erstellt den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn

dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung.

85838

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-

schafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche nicht Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaf-
terversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, sind die gesetzlichen Bestimmungen anwendbar.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Diese einhundert (100) Geschäftsanteile wurden von der alleinigen Gesellschafterin, Frau Stefanie MONNIER, vorge-

nannt, gezeichnet.

Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausend-

fünfhundert Euro (EUR 12.500,00) zur freien Verfügung steht, was die Gesellschafterin anerkennt.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf eintausendsechshundert Euro (EUR 1.600,00) geschätzt.

<i>Beschlussfassung durch die alleinige Gesellschafterin

Anschließend an die Gründung hat die Gesellschafterin sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusam-

mengefunden, zu welcher sie sich als gehörig einberufen betrachtet, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
2. Zur Geschäftsführerin wird auf unbestimmte Dauer ernannt:
Frau Stefanie MONNIER, vorgenannt.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin rechtsgültig verpflichtet.
3. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2450 Luxemburg, 17, boulevard Roosevelt.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die Komparentin, hat dieser die gegenwärtige Urkunde

mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. MONNIER, E. SCHLESSER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 juin 2014. Relation: LAC/2014/29900. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur ff. (signé): Tom BENNING.

Für gleichlautende Abschrift erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Juli 2014.

Référence de publication: 2014095730/95.
(140113697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Mokaline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 84.569.

Hydro-Get Enviromental Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 55.986.

PROJET COMMUN DE FUSION PAR ABSORPTION

Le conseil de gérance de:
(i) Mokaline S.à.r.l, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, rue Aldringen,

L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le matricule B 84569 (ci-après "Société Absorbante"),

Le conseil d'administration de:
(ii) Hydro-Get Enviromental Investment S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,

rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le matricule B 55986 (ci-après "Société Absorbée")

ont décidé d'établir le présent Projet Commun de Fusion conformément aux dispositions de l’article 261 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et de présenter le Projet Commun de Fusion à
leur actionnaire pour approbation.

85839

L

U X E M B O U R G

Le conseil de gérance et le conseil d'administration des sociétés susnommées proposent, aux termes du présent projet

de fusion, de réaliser une fusion par absorption qui impliquera le transfert de l’ensemble du patrimoine actif et passif de
la société absorbée à la société absorbante, conformément aux dispositions de l’article 274 de la Loi commerciale.

1. Date à partir de laquelle la fusion sera effective. Conformément à l’article 272 de la Loi, la fusion prendra effet entre

les sociétés lorsque seront intervenues les décisions concordantes à prendre au sein de chacune des sociétés, c'est-dire
à la date de tenue des assemblées générales des actionnaires de chacune des sociétés approuvant le Projet Commun de
Fusion. («date de prise d'effet») La fusion sera effective d'un point de vue comptable rétroactivement au 30 avril 2014.

La Fusion prendra effet envers les tiers après la publication du procès-verbal des assemblées générales des sociétés

qui fusionnent conformément aux articles 9 et 273(1) de la Loi.

2. Contexte de la fusion. Ces deux sociétés qui fusionnent, appartenant à 100% au même et unique actionnaire, ont

considéré comme approprié d'un point de vue économique et financier de se réorganiser de façon à fonctionner sous
forme d'une seule et unique société: la société Mokaline S.à.r.l étant amenée à absorber la société Hydro-Get Enviromental
Investment S.A.. Une fois la fusion opérée, des économies seront réalisées au niveau de la structure.

3. Présentation des Sociétés. Mokaline S.à.r.l, est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant

son siège social sis à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 84.569 et constituée en date du 31 octobre 2001 suivant acte notarié publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n° 410 en date du 14 mars 2002.

Les statuts ont été modifiés en date du 18 janvier 2005 suivant acte notarié publié au Mémorial C. Recueil des Sociétés

et Associations N° 465 du 19 mai 2005.

Objet social
La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Capital social
Le capital social souscrit de Mokaline S.à.r.l s'élève à EUR 31.000 représenté par 1.000 parts sociales avec une valeur

nominale de EUR 31,00 entièrement libérées.

Exercice social

L'exercice social de Mokaline S.à.r.l commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année.

Hydro-Get Enviromental Investment S.A., est une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social sis

à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le matricule
B 55.986 et constituée en date du 8 août 1996 suivant acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations n°567 en date du 5 novembre 1996.

Objet social
La société a pour objet au Luxembourg ou à l’étranger de prendre des participations directement et/ou indirectement,

par tout moyen et sous quelque forme que ce soit dans des sociétés créées ou à créer; de développer les échanges
internationaux par des activités de contacts, de relations publiques, de représentation et d'assistance dans les domaines
commerciaux, industriels et financiers; l’achat, la vente, l’achat pour revendre, la promotion, la commercialisation, l’ex-
ploitation, la mise en valeur et la location des biens mobiliers et immobiliers de toute nature et généralement toutes
opérations mobilières, immobilières, commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à l’objet
de la société ou susceptibles d'en assurer le développement.

Capital social
Le capital social de Hydro-Get Enviromental Investment S.A. avant la fusion s'élève à EUR 30.986,69 représenté par

1.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Exercice social

L'exercice social de Hydro-Get Enviromental Investment S.A commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine

le 31 décembre de la même année.

4. Critères d'évaluation et rapports d'échange. Mokaline S.àr.l., est détenue à 100 % par M. Menahem Eytan.

85840

L

U X E M B O U R G

Sur base de la situation comptable intérimaire au 30 avril 2014 (en annexe 1 du présent projet), la société absorbante

présente un actif net négatif. Il a été décidé de réaliser l’apport à la valeur de 1,00 EUR.

Hydro-Get Enviromental Investment S.A., est détenue à 100 % par M. Menahem Eytan.
Sur base de la situation comptable intérimaire au 30 avril 2014 (en annexe 2 du présent projet), la société absorbée

présente un actif net positif de EUR 5.185.416,33.

Sachant que le capital de Mokaline S.à.r.l. est composé de 1.000 parts sociales la valeur d'une part sociale ressort à

EUR 0,001.

Sachant que le capital de Hydro-Get Enviromental Investment S.A. est composé de 1.000 actions la valeur d'une action

ressort à EUR 5.185,42.

Détermination du rapport d'échange: Compte tenu de ces valorisations le rapport d'échange s'établit à 5.185.420

(5.142,42/0,001), soit une (1) action de la société absorbée pour 5.185.420 parts sociales de la société absorbante.

Rémunération - Augmentation de capital: Compte tenu de ce rapport d'échange et du fait que les deux sociétés sont

détenues par le même et unique actionnaire aucune rémunération de l’actif net apporté n'est due. Par conséquent, aucune
augmentation de capital n'est à réaliser.

Par l’effet de la fusion, la société absorbée sera dissoute et toutes les actions qu'elle a émises seront annulées au jour

de la tenue de l’assemblée générale qui se tiendra devant notaire.

5. Effets de la fusion. Repris, ci-après, les effets de la fusion tel que détaillées à l’article 274 de la loi:
(i) La société absorbée transférera tous ses droits et obligations à la société absorbante, et cessera d'exister consé-

cutivement à une dissolution sans procédure de liquidation et ses actions annulées;

(ii) La société absorbante paiera, à compter de la date de prise d'effet, tous les impôts, cotisations, droits, taxes qui

seront ou pourront devenir exigibles en relation avec la possession des actifs qui ont été apportés;

(iii) Les droits et créances afférents aux actifs de la société absorbée seront transférés à a société absorbante avec

tous les titres, soit réels (in rem) soit personnels, y attachés. La Société Absorbante sera donc subrogée, sans novation,
à tous les droits, qu'ils soient réels (in rem) ou personnels, de la société Absorbée à l’égard de tous ses actifs et contre
tous ses débiteurs sans exception aucune;

(iv) La société absorbante paiera toutes les dettes de quelque nature que ce soit de la société absorbée;
(v) Les mandats des membres du conseil d'administration de la société absorbée prendront fin à la date de prise d'effet

de la fusion. Pleine décharge sera accordée aux membres du conseil d'administration de la société absorbée pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs;

(vi) Les mandats des membres du conseil de gérance de la société absorbante ne seront pas affectés par la fusion;
(vii) Les livres et documents de la société absorbée seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société

absorbante;

6. Droits et avantages particuliers. Aucun avantage spécial n'est attribué ni aux membres du conseil d'administration

et de gérance ni au commissaire des sociétés qui fusionnent.

7. Droits d'information des actionnaires. Le Projet Commun de Fusion, les comptes annuels ainsi que les rapports de

gestion des trois derniers exercices des sociétés, les situations comptables intérimaires, les rapports des organes d'ad-
ministration peuvent être contrôlés par les actionnaires au siège social des sociétés conformément à l’article 267 de la
Loi.

8. Détails de Mokaline S.à.r.l. suite à la Procédure de Fusion.

Capital social: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

31.000,00

Prime de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5.185.416,33
Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -5.414.148,32
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

358.396,78

Conseil de gérance.
- Marie-Laure AFLALO, résidant professionnellement au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg;
- Joëlle MAMANE, résidant professionnellement au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg;
- Menahem EYTAN, résidant à Genève, Suisse
Siège social: 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
Exercice social: du 1 

er

 janvier au 31 décembre.

Approuvé par le conseil de gérance de la société Mokaline S.à.r.l. lors de sa réunion du 03/06/2014.
Approuvé par le conseil d'administration de la société Hydro-Get Enviromental Investment S.A. lors de sa réunion du

03/06/2014.

Signatures.

Référence de publication: 2014080111/130.
(140094542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

85841

L

U X E M B O U R G

Promotrust S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 187.097.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, den achtundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz zu Niederanven.

Sind erschienen:

1) FOKO S.A., mit Sitz in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, noch nicht eingetragen im Handels-

und  Firmenregister  Luxemburg,  hier  vertreten  durch  seinen  delegierten  Verwaltungsratsmitglied  Herr  Paul  KOCH,
Immobilienhändler, beruflich wohnhaft in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, alleinzeichnungsberech-
tigt.

2) EUROFERTIGBAU A.G., mit Sitz in L-5550 Remich, 22, rue de Macher, eingetragen im Handels- und Firmenregister

Luxemburg unter der Nummer B 86.311, hier vertreten durch seinen geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Herr
Heiko Benno LAUX, Diplom Bau Ingenieur, mit beruflicher Anschrift in L-5550 Remich, 22, rue de Macher, alleinzeich-
nungsberechtigt.

Vorbenannte Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, ersuchen den unterzeichnenden Notar, die Satzungen einer

von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung:
"PROMOTRUST S.A.".
Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Gesellschafter haben. Solange die Gesellschaft nur einen Gesell-

schafter hat, kann diese durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, welcher nicht der einzige Gesellschafter zu
sein braucht.

Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs, die Liquidation oder der Bankrott des einzigen Gesellschafters

lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen,

Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede

andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses

Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  und  bis  zur  völligen  Wiederherstellung  normaler  Verhältnisse  ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräußerung, die Vermietung, die Verwaltung und die Ver-

wertung von, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, gelegenen Immobilien.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in einhundert (100)

Aktien mit einem Nominalwert von dreihundertzehn Euro (EUR 310,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

85842

L

U X E M B O U R G

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Wenn die Gesellschaft durch einen einzigen Gesellschafter gegründet wurde oder wenn durch Generalver-

sammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, kann die Gesellschaft durch einen
einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einziger Verwalter“ genannt wird, bis zur nächsten ordentlichen Generalver-
sammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus

mindestens  drei  Mitgliedern  besteht,  die  keine  Aktionäre  sein  müssen.  In  diesem  Fall  muss  die  Generalversammlung
zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter beziehungsweise die
Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalver-
sammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter (wenn die

Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat) solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat.

Wenn eine juristische Person Verwalter der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher

die juristische Person gemäss Artikel 51bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie
dies abgeändert wurde, vertritt.

Der/die Verwalter werden durch die Generalversammlung ernannt. Die Gesellschafter bestimmen ebenfalls die Anzahl

der Verwalter, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandats.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund, frei, so können

die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Generalver-
sammlung der Aktionäre besetzen. Falls kein Verwalter verfügbar ist, wird durch den Prüfungskommissar schnell eine
Generalversammlung einberufen, um einen neuen Verwalter zu ernennen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter hat die weitestgehenden Befugnisse alle Verwal-

tungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.

Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz, der Generalversammlung vor-

behalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters zu.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Wenn kein Vorsitzender vorhanden

ist, kann der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwalter anvertraut werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

Vollmacht zwischen Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, fernschrift-
lich, telegraphisch oder per Telefax geben

In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch

oder per Telefax abgeben

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist

die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entscheidend.

Die Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden haben die gleiche Ausführungskraft wie diejenigen,

die durch den Verwaltungsrat gefasst werden und werden in Protokollen festgehalten, welche durch den einzigen Ver-
walter unterschrieben werden und wovon Kopien und Auszüge angefertigt werden können.

Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Ver-

tretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte, übertragen.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter kann ausserdem jedwelcher Person, die nicht Verwalter

sein muss, jedwelche Spezialvollmacht erteilen sowie Vertreter und Angestellte ernennen und abberufen und ihren Lohn
festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift vom Vorsitzenden des Verwal-

tungsrates, oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, in der täglichen Geschäfts-
führung durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwalters, beziehungsweise durch die Unterschrift des einzigen
Verwalters oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten han-
delnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

85843

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Für den Fall, dass es nur einen Gesellschafter (einziger Gesellschafter) gibt, übt dieser im Laufe der ordnungs-

gemäss abgehaltenen Generalversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem Gesetz vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften der Generalversammlung obliegen.

Die Generalversammlungen werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Sie sind nicht nötig, wenn alle

Gesellschafter bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären vorab von der Tagesordnung
Kenntnis genommen zu haben.

Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass nur die Aktionäre zur Generalversammlung zugelassen werden, die fünf Ka-

lendertage vor dem festgelegten Datum ihre Aktien hinterlegt haben. Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines
Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.

Jede Aktie gibt anrecht auf eine Stimme.

Art. 14. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden,

wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu

tätigen oder zu ratifizieren.

Art. 15. Die Generalversammlung bestimmt über Verwendung und die Zuteilung der Gewinne.
Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt Zwischendividenden auszuschütten gemäss

den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar

am ersten Montag des Monates Juni um 17.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Vorübergehende Bestimmungen

- Die erste ordentliche Generalversammlung der Gesellschafter findet im Jahre 2015 statt.
- Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2014.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-).

<i>Kapitalzeichnung

Die einhundert (100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1.- FOKO S.A., vorbenannt, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- EUROFERTIGBAU A.G. vorbenannt, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe

von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf vier, diejenige der Kommissare wird festgelegt auf einen.
2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralver-

sammlung des Jahres 2019.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Paul KOCH, vorbenannt;
- Herr Heiko Benno LAUX, vorbenannt;
- Herr Christoph Gisbert LAUX, Maurermeister, Dipl. Betriebswirt, geboren am 5. September 1975 in Losheim (D),

mit beruflicher Anschrift in L-5550 Remich, 22, rue de Macher;

- Herr John FORETTE, Frühpensionär, geboren am 18. Februar 1957 in Luxemburg, wohnhaft in L-5753 Frisange, 13,

parc Lésigny;

4.- Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird ernannt:

85844

L

U X E M B O U R G

- Herr Paul KOCH, vorbenannt;
5.- Zum Kommissar wird ernannt:
ACCURATE SA, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-5752 Frisange, 6A, rue de Luxembourg, eingetragen im Handels-

und Firmenregister Luxembourg unter der Nummer B 69.862.

6.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:
L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.

<i>Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten

Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchliche Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Paul Koch, Heiko Benno Laux, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 8 mai 2014. LAC/2014/21402. Reçu 75,- €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

Für gleichlautende Kopie ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 16. Mai 2014.

Référence de publication: 2014071641/182.
(140083842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2014.

Ravago Chemicals S.A., Société Anonyme,

(anc. BRCS S.A., Barentz Ravago Chemical Specialist S.A.).

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 91.789.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty third day of May.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg.

Is held:

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of “Barentz Ravago Chemical Specialist S.A., in abbreviated form

BRCS S.A.”, a société anonyme, having its registered office at Luxembourg, 16, rue Notre-Dame, trade register Luxem-
bourg, section B number 91.789, incorporated by deed dated on 12 February 2003, published in the Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, number 316 of 25 March 2003; and whose Articles of Association have been amended
for the last time by deed enacted on the December 5 

th

 , 2013 published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés

et Associations, number 142 of 16 January 2014.

The meeting is presided by Mr. Benoît Parmentier, professionally residing at L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Ms. Flora Gibert, with professional address

in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the 1,000,000 (one million) shares, representing the whole capital of the

corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Change of the name of the Company, so that it will be named “Ravago Chemicals S.A.”. Subsequent amendment

of the first article of the articles of incorporation.

2.- Change of the date of the annual general meeting and subsequent amendment of the third paragraph of the article

8 to be read as follows:

85845

L

U X E M B O U R G

“The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg Law at the registered office of the Company

or at such other place as specified in the notice of the Meeting on the second Friday in the month of May at 2.00 p.m.”

3.- Amendment of the article 9 of the articles of incorporation which shall read as follows:
Art. 9. “The Company shall be managed by a board of directors composed of at least six (6) members, their number

being determined by the general meeting of shareholders. Directors need not to be shareholders of the Company.

The board of directors consists of Class A directors and Class B directors.
All Directors shall be elected by the general meeting of shareholders for a period of not exceeding six (6) years and

until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken
by the general meeting of shareholders. The directors shall be eligible for reappointment.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, removal, resignation or otherwise, an extraordinary

meeting of shareholders shall be entitled to designate a successor who shall serve as a director for the remainder of the
original term of the former director.”

4.- Amendment of the article 12 of the articles of incorporation which shall read as follows:
Art. 12. “Vis-à-vis third parties, barring special delegation by the board of directors, all acts not pertaining to the daily

management of the Company and representing a commitment for the Company, such as but not limited to the purchase
and sale of financial fixed assets, the granting of corporate guarantees, the incorporation of private or commercial com-
panies, and powers of attorney regarding such acts shall be validly signed by two Class A directors. Acts pertaining to the
daily management of the Corporation shall be validly signed by two directors.”

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution:

The meeting decides to change the name of the Company will be from now on “Ravago Chemicals S.A.”
The meetings decides to amend accordingly the first article as follows:

“ Art. 1. Form, Name. The Company is a public limited liability company (“société anonyme”) (hereafter the “Com-

pany”) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (hereafter the “Law”) and by the present articles of Incorporation (he-
reafter the “Articles”).

The Company exists under the name of “Ravago Chemicals S.A.”.”

<i>Second resolution:

The meeting decides to change the date of the annual general meeting and to amend subsequently the third paragraph

of the article 8 to be read as follows:

“The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg Law at the registered office of the Company

or at such other place as specified in the notice of the Meeting on the second Friday in the month of May at 2.00 p.m.”

<i>Third resolution:

The meeting decides to amend the article 9 of the articles of incorporation which shall read as follows:

Art. 9. “The Company shall be managed by a board of directors composed of at least six (6) members, their number

being determined by the general meeting of shareholders. Directors need not to be shareholders of the Company.

The board of directors consists of Class A directors and Class B directors.
All Directors shall be elected by the general meeting of shareholders for a period of not exceeding six (6) years and

until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken
by the general meeting of shareholders. The directors shall be eligible for reappointment.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, removal, resignation or otherwise, an extraordinary

meeting of shareholders shall be entitled to designate a successor who shall serve as a director for the remainder of the
original term of the former director.”

<i>Fourth resolution:

The meeting decides to amend the article 12 of the articles of incorporation which shall read as follows:

Art. 12. “Vis-à-vis third parties, barring special delegation by the board of directors, all acts not pertaining to the daily

management of the Company and representing a commitment for the Company, such as but not limited to the purchase
and sale of financial fixed assets, the granting of corporate guarantees, the incorporation of private or commercial com-
panies, and powers of attorney regarding such acts shall be validly signed by two Class A directors. Acts pertaining to the
daily management of the Corporation shall be validly signed by two directors.”

85846

L

U X E M B O U R G

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about one thousand Euros.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit:

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Barentz Ravago Chemical Specialist S.A.,

en abrégé BRCS S.A.», ayant son siège social à Luxembourg, 16, rue Notre-Dame, immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de Luxembourg section B numéro 91.789 constituée suivant acte reçu le 12 février 2003 publié au Mémorial
C numéro 316 du 25 mars 2003 dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 5 décembre
2013, publié au Mémorial C numéro 142 du 16 janvier 2014.

L'assemblée est présidée par Monsieur Benoît Parmentier, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora Gibert demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les un million (1.000.000) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la société qui s’appellera désormais «Ravago Chemicals S.A.». Modification

subséquente de l’article premier des statuts.

2.- Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires et modification subséquente du

troisième alinéa de l’article 8 des statuts:

«L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de mai à 14.00 heures.»

3.- Modification de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 9. «La Société est gérée par un Conseil d’Administration composé d’au moins six (6) membres, le nombre exact

étant déterminé par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n’ont pas besoin d’être actionnaires de la
société. Le Conseil d’Administration est composé d’Administrateurs de catégorie A et d’Administrateurs de catégorie B.

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans

et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par
décision de l’assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, une assemblée

générale extraordinaire des actionnaires devra être réunie pour désigner un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu’à extinction du mandat en cours.»

4.- Modification de l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 12. «Vis-à-vis des tiers, sauf délégation spéciale du Conseil d'Administration, tout acte ne concernant pas la gestion

quotidienne de la société et engageant la société, tel que mais non limité à l’achat et la vente d'actifs financiers immobilisés,
l’octroi de garanties, la constitution de sociétés civiles ou commerciales, et les procurations concernant de tels actes
seront valablement signées par deux administrateurs de classe A. Les actes concernant la gestion quotidienne de la société
seront valablement signés par deux administrateurs.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

85847

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution:

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en «Ravago Chemicals S.A.». L’assemblée décide de modifier

l’article premier des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  La société est une société anonyme (ci-après la «Société»), laquelle sera régie par

les lois du Grand-Duché du Luxembourg, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle
que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

La Société existe sous la dénomination de «Ravago Chemical S.A.».»

<i>Deuxième résolution:

L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires et de modifier le

troisième alinéa de l’article 8 des statuts comme suit:

«L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de mai à 14.00 heures.»

<i>Troisième résolution:

L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 9. «La Société est gérée par un Conseil d’Administration composé d’au moins six (6) membres, le nombre exact

étant déterminé par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n’ont pas besoin d’être actionnaires de la
société. Le Conseil d’Administration est composé d’Administrateurs de catégorie A et d’Administrateurs de catégorie B.

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans

et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par
décision de l’assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, une assemblée

générale extraordinaire des actionnaires devra être réunie pour désigner un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu’à extinction du mandat en cours.»

<i>Quatrième résolution:

L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 12. «Vis-à-vis des tiers, sauf délégation spéciale du Conseil d'Administration, tout acte ne concernant pas la gestion

quotidienne de la société et engageant la société, tel que mais non limité à l’achat et la vente d'actifs financiers immobilisés,
l’octroi de garanties, la constitution de sociétés civiles ou commerciales, et les procurations concernant de tels actes
seront valablement signées par deux administrateurs de classe A. Les actes concernant la gestion quotidienne de la société
seront valablement signés par deux administrateurs.»

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ
mille Euros.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d'ores et déjà

à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: B. PARMENTIER, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 26 mai 2014. Relation: LAC/2014/24133. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014076752/182.
(140090268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

85848

L

U X E M B O U R G

Polyver Group, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 652.900,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 182.629.

<i>Projet commun de fusion transfrontalière par absorption

Le présent projet commun de fusion transfrontalière aux sens de la Directive 2005/56/CE (ci-après le «Projet de

Fusion») a été convenu entre les organes d'administration des sociétés POLYVER GROUP et TWBC et rédigé en appli-
cation des articles 261 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que
modifiée (ci-après «LSC») et des articles R236-14 et suivants du Code de commerce français (ci-après «CC»).

1. Description des sociétés à fusionner.
A. La Société Absorbante
La société à responsabilité limitée POLYVER GROUP, ici aussi désignée la «Société Absorbante», ayant son siège social

au  2,  avenue  Charles  de  Gaulle,  L-1653  Luxembourg,  inscrite  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg, à la section B sous le numéro 182629, a été constituée le 16 décembre 2013 suivant un acte reçu par Maître
Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 183 du 21 janvier 2014.

Son capital social s'élève à 652.900 représenté par 65.290 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10 chacune,

toutes intégralement souscrites et libérées.

B. La Société Absorbée
La société à responsabilité limitée TWBC, ici aussi désignée la «Société Absorbée», ayant son siège social au 15, rue

du Parc, F-67205 Oberhausbergen, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le
numéro 442 987 558 et constituée le 320 juin 2002 suivant acte sous seing privé.

Son capital social s'élève à EUR 107.600 représenté par 10.760 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10 chacune,

toutes intégralement libérées et appartenant à la Société Absorbante, POLYVER GROUP, associée unique.

2. Modalités de la fusion. La fusion transfrontalière sera réalisée, conformément aux articles 257 de la LSC et L236-25

du CC, par absorption de la société TWBC par son associée unique, la société POLYVER GROUP, et selon la procédure
simplifiée prévue aux articles 278 et suivants de la LSC ainsi qu'à l'article L236-11 du CC.

En cas de procédure simplifiée, l'article 279 (2) de la LSC stipule qu'en cas de fusion transfrontalière, l'approbation de

la fusion par l'assemblée générale de la Société Absorbée n'est pas nécessaire, et l'article L236-11 du CC prévoit que
l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la fusion n'est pas nécessaire.
De plus, l'article 271 de la LSC mentionne que la décision de fusion doit être établie par acte notarié.

Ainsi, seule l'assemblée générale de la Société Absorbante sera tenue, devant notaire, un mois au moins après la

publication au Mémorial C du Projet de Fusion et après réception du certificat attestant du contrôle de légalité pour la
partie de la procédure incombant à la Société Absorbée.

Enfin, les documents mentionnés aux articles 267 (1) a), b), c) et d) de la LSC et R236-3 du CC seront déposés au

siège social de la Société Absorbante afin que tout «associé» puisse, un mois au moins avant la date de la réunion de
l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le Projet de Fusion, en prendre connaissance.

Une copie intégrale ou partielle de ces documents pourra être obtenue par tout «associé», sans frais et sur simple

demande.

3. Rapport d'échange. Etant donné que la Société Absorbante détient et détiendra au moment de la fusion l'entièreté

du capital et titres quelconques de la Société Absorbée, la fusion ne donnera pas lieu à l'émission de nouvelles parts
sociales, ce conformément à l'article 278 de la LSC et au point II.- 1°de l'article L236-3 du CC, ni même à la création
d'une prime de fusion.

Aucun nouvelle part sociale étant émise, il n'y a pas lieu de procéder à la détermination d'un rapport d'échange.
En ces circonstances et compte tenu des dispositions des articles 278 de la LSC et L236-11 du CC, les dispositions

légales concernant la rédaction du rapport d'experts figurant respectivement à l'article 266 de la LSC et à l'article L236-10
du CC sont sans objet.

Cependant, conformément aux dispositions des articles 265 de la LSC et L236-27 du CC, un rapport écrit, expliquant

et justifiant du point de vue juridique et économique le projet commun de fusion a été établi par l'organe d'administration
de chacune des sociétés participant à la fusion.

En outre, à défaut d'émission de nouvelles parts sociales, il n'y a pas lieu de fixer les modalités de leur remise ni

d'indiquer la date à partir de laquelle elles donneraient le droit de participer aux bénéfices.

4. Date des comptes utilisés pour définir les conditions de la fusion. Le Projet de Fusion est basé sur les bilans respectifs

de la Société Absorbée et de la Société Absorbante arrêtés au 30 avril 2014.

85849

L

U X E M B O U R G

5. Informations relatives au patrimoine actif et passif transféré à la Société Absorbante. La société TWBC transférera

à la société POLYVER GROUP par suite de la fusion transfrontalière, les éléments patrimoniaux suivants à leur valeur
comptable:

TWBC (Société Absorbée)

Valeurs

patrimoniales

au 30/04/2014

(en EUR)

ACTIF
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180.093

Actif circulant:
- Créances clients et comptes rattachés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000

- Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.776

- Disponibilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

471

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190.340

PASSIF
Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107.600

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.461

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.757

Bénéfice de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(806)

Dettes:
- Emprunts et dettes financières divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.619

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.211

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190.340

6. Date de prise d'effet sur le plan comptable et juridique. La date à partir de laquelle les opérations de la Société

Absorbée sont conventionnellement considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte
de la Société Absorbante est fixée au 1 

er

 mai 2014, et tous bénéfices ou pertes réalisés par la Société Absorbée après

cette date sont censés réalisés pour le compte de la Société Absorbante.

Du point de vue juridique, en application des articles 273ter de la LSC et L236-31 du CC, la fusion sera réalisée en

2014, à la date de publication de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante approuvant le Projet de
Fusion.

7. Conséquences de la fusion. La fusion par absorption entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par

l'article 274 de la LSC et par l'article L236-3 du CC. Ainsi, par l'effet de la fusion, la Société Absorbée sera dissoute, toutes
les parts représentant son capital social seront annulées et l'ensemble de son patrimoine actif et passif sera universellement
transmis à la Société Absorbante, laquelle assumera la totalité des dettes de la Société Absorbée et substituera la Société
Absorbée dans tous les droits existants à la date de prise d'effet de la fusion.

Il est signalé que le patrimoine de la Société Absorbée ne comprend pas d'immeubles.
Les mandats des organes de gestion de la Société Absorbée prendront fin à la date d'effet de la fusion. La décharge

sera proposée à l'assemblée générale d'approbation de la fusion par la Société Absorbante.

8. Droits assurés par la Société Absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres

que des parts sociales. Il n'existe pas d'associés ayant des droits spéciaux ni de détenteurs de titres autres que des parts
sociales au sein des sociétés fusionnantes.

9. Avantages particuliers en faveur des experts, des membres des organes d'administration, de surveillance ou de

contrôle des sociétés qui fusionnent. Dans la mesure où il n'est pas nécessaire, aux fins de la fusion en objet, d'établir un
rapport d'experts tel que mentionné à l'article 266 de la LSC et à l'article L236-10 du CC, il n'y a pas d'avantages proposés
en leur faveur.

De même, aucun avantage particulier n'est prévu en faveur des membres des organes d'administration, de surveillance

ou de contrôle des sociétés participant à la fusion.

10. Informations relatives aux procédures d'implication des travailleurs. La Société Absorbante et la Société Absorbée

n'ayant pas de travailleurs, il n'est pas nécessaire de fournir d'informations sur les procédures d'implication des travailleurs
dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière.

11. Effets probables de la fusion sur l'emploi. L'opération mentionnée dans le présent Projet de Fusion n'aura aucune

répercussion sur l'emploi.

12. Modalités d'exercice des droits des créanciers et adresse à laquelle peut être obtenue une information exhausti-

ve. Pour la Société Absorbante, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de publication de l'approbation de
la fusion ont droit, en vertu de l'article 268 de la LSC, dans les deux mois à compter de ladite publication, de demander

85850

L

U X E M B O U R G

au Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, en référé, la constitution
de sûretés pour les créances échues ou non échues, au cas où l'opération de fusion réduirait leurs garanties.

Des informations complémentaires et exhaustives peuvent être demandées gratuitement au siège social de la Société

Absorbante, au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en s'adressant à Mon-
sieur Philippe PONSARD -tel + 352.45.123.1.

Pour la Société Absorbée, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de publication au Bulletin officiel des

annonces civiles et commerciales de l'avis relatif au Projet de Fusion ont droit, en vertu de l'article L236-14 du CC, dans
les trente jours à compter de ladite publication, de former opposition au Projet de Fusion.

Des informations complémentaires et exhaustives peuvent être demandées gratuitement au siège social de la Société

Absorbée, au 15, rue du Parc, 67205 Oberhausbergen, France, en s'adressant à Madame Elisabeth CHRISTIAN - tel +
33.3.88.56.91.74.

13. Statuts de la Société Absorbante. Les statuts en vigueur de la Société Absorbante sont annexés dans leur intégralité,

en langue française uniquement, au Projet de Fusion pour en faire partie intégrante. Ces statuts ne subiront aucune
modification suite à et par effet de l'opération de fusion.

Annexe - Statuts de la Société Absorbante (version française)

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts

et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de POLYVER GROUP.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets, marques, modèles, ou autres droits de propriété
intellectuelle de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les
réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La société peut gérer, fournir et développer des produits IT et rendre tous services professionnels y relatifs.
La société a, en outre, pour objet l'achat, la gestion, la mise en valeur et la vente de tous biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 652.900 (six cent cinquante-deux mille neuf cents euros) représenté par 65.290

(soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que

dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par au moins deux gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants dont

obligatoirement une signature d'un gérant de catégorie A et une autre signature d'un gérant de catégorie B, ou par la
signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul gérant sera toutefois
suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

85851

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.»

Oberhausbergen, le 4 juillet 2014.

TWBC
Francis WERLING
<i>Le gérant unique

Luxembourg, le 3 juillet 2014.

POLYVER GROUP
<i>Pour le conseil de gérance
Philippe PONSARD

Référence de publication: 2014096381/194.
(140114928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Bau Cap Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 126.082.

<i>Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 2 mai 2014

En date du 2 mai 2014, l'associé unique de la Société a résolu de nommer Monsieur Philippe van den Avenne, né le 29

avril 1972 à Beloeil, Belgique avec adresse professionnelle au Atrium Business Center, 33, rue du Puits Romain, L-8070,
Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
Monsieur Felix Bauer
Monsieur Philippe van den Avenne
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2014.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014065587/18.
(140076282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2014.

85852

L

U X E M B O U R G

Vianden RCG Re SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 27.908.

Clemency RCG Re SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 42.294.

Wiltz RCG Re SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 46.306.

Larochette RCG Re SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 28.687.

Schengen RCG Re SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 37.290.

Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1. “RCG Re”, a limited liability company, organized and existing under the laws of Luxembourg, with registered office

at L-4243 Esch-sur-Alzette 97, rue Jean-Pierre Michels registered to the Trade Register in Luxembourg, section B numéro
165.667, acting as Unlimited Shareholder (gérant commandité) of the company, represented by Ms. Concetta ALIBRANDI,
Marketing Manager, residing professionally in Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given under
private seal on June 30 

th

 , 2014 in Esch-sur-Alzette and

2. “Ramius Entreprise Luxembourg Holdco S.à r.l.”, a limited liability company, organized and existing under the laws

of Luxembourg, with registered office at L-4243 Esch-sur-Alzette 97, rue Jean-Pierre Michels registered to the Trade
Register in Luxembourg, section B numéro 130705, being the Limited Shareholder (gérant commanditaire) of the com-
pany, represented by Mrs Valérie COQUILLE, Legal Manager, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given under private seal on June 30 

th

 , 2014 in Esch-sur-Alzette,

The said proxy, initialled “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as aforesaid, are the sole shareholders (the "Shareholders") of “Vianden RCG Re

S.C.A.”, a Luxembourg société en commandite par actions, having its registered office at L-

4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg

Register of Commerce and Companies under number B 27908, incorporated pursuant to a notarial deed drawn up on
April 20 

th

 , 1988 by Me Frank BADEN and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under

the number B 27.908. Its articles have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated July
11 

th

 , 1988, number 187.

The Shareholders, represented as aforesaid and representing the entire share capital, have requested the undersigned

notary to act the resolutions contained indo the agenda:

<i>Agenda:

1. Waiver of the convening notices.
2. Presentation of the merger plan of the Company.
3. Approval of the merger plan and decision to realise the merger with Clemency RCG Re SCA, Wiltz RCG Re SCA,

Larochette RCG Re SCA and Schengen RCG Re SCA further to article 259 of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial

companies (the “Law”) by the transfer, following the dissolution without liquidation, of any and all assets, liabilities, rights,
obligations and contracts of Clemency RCG Re SCA, Wiltz RCG Re SCA, Larochette RCG Re SCA and Schengen RCG
Re SCA to the Company (the "Merger").

4. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 8,779,109 (eight million seven hundred seventy-

nine thousand and one hundred and nine United States Dollars), in order to bring it from its current amount of USD
6,502,939 (six million five hundred two thousand nine hundred and thirty-nine United States Dollars to USD 15,282,048
(fifteen million two hundred eight-two thousand forty-eight United States Dollars) by the issue of 8,779,109 (eight million
seven hundred seventy-nine thousand and one hundred and nine) shares without nominal value to be subscribed by Ramius
Entreprise Luxembourg Holdco sàrl, limited liability companies, organized and existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at L-4243 Esch-sur-Alzette 97, rue Jean-Pierre Michels, with Trade Register number B130705,

85853

L

U X E M B O U R G

being the Limited shareholder of Clemency RCG Re SCA, Wiltz RCG Re SCA, Larochette RCG Re SCA and Schengen
RCG Re SCA, in consideration of the transfer of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of Clemency
RCG Re SCA, Wiltz RCG Re SCA, Larochette RCG Re SCA and Schengen RCG Re SCA to the Company, and those
new shares to be issued with a merger share premium of an amount of USD 19,661,215 (nineteen million six hundred
sixty-one thousand two hundred and fifteen United States Dollars).

5. Further to the Merger and the dissolution of Clemency RCG Re SCA, Wiltz RCG Re SCA, Larochette RCG Re

SCA and Schengen RCG Re SCA, cancellation of the shareholders registers of Clemency RCG Re SCA, Wiltz RCG Re
SCA, Larochette RCG Re SCA and Schengen RCG Re SCA and update of the shareholders register of the Company;

6. Amendment of the first paragraph of Article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the

above;

7. Acknowledgement of the effective date of the Merger from an accounting perspective; and
8. Miscellaneous.

<i>First resolution

The entire share capital of the Companies being represented, the Shareholders, represented as aforesaid, waive the

convening notices, consider themselves as duly convened and declare having full knowledge of the agenda which was
communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders declare that they have full knowledge of the merger plan (the "Merger Plan") in relation to the merger

of the Company with:

1) «Clemency RCG Re S.C.A.», société en commandite par actions, having its registered office at L-4243 Esch-sur-

Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed, drawn up
on December 21 

st

 , 1992 by Me Reginald Neuman and registered with the Luxembourg Register of Commerce and

Companies under the number B 42294. Its articles have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations dated January 27 

th

 , 1993, number 39. The subscribed capital of this Company is of USD 4,480,000 (four

million United States Dollars), fully paid-up.

2) «Wiltz RCG Re S.C.A.», a Luxembourg société en commandite par actions, having its registered office at L-4243

Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed,
drawn up on December 23 

rd

 , 1993 by Me Joseph Elvinger and registered with the Luxembourg Register of Commerce

and Companies under the number B 46306. Its articles have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations dated 6 April 1994, number 127. The subscribed capital of this Company is of USD 5,118,001 (five million
one hundred eighteen thousand and one United Sates Dollars), fully paid-up.

3) «Larochette RCG Re S.C.A.», a Luxembourg société en commandite par actions, having its registered office at

L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial
deed, drawn up on August 11, 1988 by Me Gérard LECUIT and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under the number B 28687. Its articles have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations dated November 16 

th

 , 1988, number 302. The subscribed capital of this Company is of USD 5,096,800

(five million ninety-six thousand eight hundred United Sates Dollars), fully paid-up.

4) «Schengen RCG Re S.C.A.» a Luxembourg société en commandite par actions, having its registered office at L -

4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial
deed, drawn up on June 25, 1991 by Me Joseph Kerschen and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under the number B 37290. Its articles have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations dated December 13 

th

 , 1991, number 461. The subscribed capital of this Company is of 5,064,320 USD

(five million sixty-four thousand three hundred twenty United states Dollars), fully paid-up.

("Clemency RCG Re SCA, Wiltz RCG Re SCA, Larochette RCG Re SCA and Schengen RCG Re SCA together forming

the "Absorbed Companies"), whereby the Company will absorb the Absorbed Companies (the "Merger").

The Shareholders note that the Merger Plan has been executed by the General Partner of the Company and the

General Partner of the Absorbed Companies on 26 

th

 May 2014 and has been published in the Mémorial dated May 30

th

 , 2014, number 1386, in accordance with article 262 (1) of the Law.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to approve the Merger Plan, as published, in all its provisions and in its entirety, without

exception and reserve.

The Shareholders further resolve to realise the Merger further to article 259 of the Law, by the transfer, following

the dissolution without liquidation, of all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Absorbed Companies
to the Company retroactive to June 30 

th

 , 2014.

85854

L

U X E M B O U R G

The Shareholders also resolve to approve the transfer of all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the

Absorbed Companies to the Company and the allotment and conditions of issue of new shares in accordance with the
exchange ratio as published in the Merger Plan.

The newly issued shares will be in registered form and their inscription in the shareholders' register of the Company

will occur on the day of the present deed.

<i>Fourth resolution

As a result of the Merger, the Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of

USD 8,779,109 (eight million seven hundred seventy-nine thousand and one hundred and nine United States Dollars)
through the issuance of additional 8,779,109 (eight million seven hundred seventy-nine thousand and one hundred and
nine) shares without nominal value and the payment of a merger share premium of an aggregate amount of 19,661,215
USD (nineteen million six hundred sixty-one thousand two hundred and fifteen United States Dollars), to be subscribed
by “Ramius Entreprise Luxembourg Holdco S.à r.l.”, prenamed, the Limited shareholder, acting in its capacity of Limited
shareholder  of  the  fourth  Absorbed  Companies  too,  in  consideration  for  the  transfer  of  all  assets,  liabilities,  rights,
obligations and contracts of the Absorbed Companies to the Company.

<i>Subscription and payment

“Ramius Entreprise Luxembourg Holdco S.à r.l.”, prenamed, the Limited shareholder and acting in its capacity of Limited

shareholder of the fourth (4) Absorbed Companies too, declare to subscribe the 8,779,109 (eight million seven hundred
seventy-nine thousand and one hundred and nine) shares without nominal value and a merger share premium of an
aggregate amount of USD 19,661,215.- (nineteen million six hundred sixty-one thousand two hundred and fifteen United
States Dollars) as a result of the Merger.

<i>Fifth resolution

Further to the Merger and the dissolution of the Absorbed Companies, the Shareholders resolve to cancel the shares

of the Absorbed Companies, cancel the shareholders registers of the Absorbed Companies and update of the share-
holders' register of the Company.

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve to amend the first paragraph of article 5 of the Articles accordingly, which shall now read

as follows:

Art. 5. The corporate capital is fixed at USD 15,282,048.- (fifteen million two hundred eight-two thousand forty-

eight United States Dollars) divided into 15,282,048 (fifteen million two hundred eight-two thousand forty-eight) shares
without nominal value, fully paid up."

<i>Seventh resolution

The Shareholders acknowledge that:
- from an accounting perspective, the Merger is effective retroactively from January 1 

st

 2014, as provided for in the

Merger Plan

- The Merger takes effect retroactive from as from June 30 

th

 , 2014.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately four thousand three hundred and sixty Euro (EUR 4,360.-).

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

WHEREOF, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by an French version, at the request of the same appearing
persons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille quatorze, le trois juillet.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. «RCG Re», une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social à L-4243 Esch-sur-Alzette

97, rue Jean-Pierre Michels, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro

85855

L

U X E M B O U R G

165.667, étant le gérant commandité des 5 (cinq) sociétés suivantes (le «GC»), représenté par Mademoiselle Concetta
ALIBRANDI, Marketing Manager, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé le 30 juin 2014 à Esch-sur-Alzette, et

2. «Ramius Entreprise Luxembourg Holdco S.à r.l.», une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son

siège social à L-4243 Esch-sur-Alzette 97, rue Jean-Pierre Michels, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B numéro 130705, étant le gérant commanditaire des 5 (cinq) sociétés suivantes, représentée par
Madame Valérie COQUILLE, Legal Manager, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé le 30 juin 2014 à Esch-sur-Alzette:

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées «ne varietur» par les mandataires et le notaire instrumentant,

resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Les comparantes, représentées comme ci-avant et représentant l'entièreté du capital social, sont les seuls et uniques

actionnaires («les Actionnaires") de «Vianden RCG Re S.C.A.», une société en commandite par actions ayant son siège
social à L-4243 Esch-sur-Alzette 97, rue Jean-Pierre Michels, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B numéro 27908, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire de résidence à
Luxembourg en date du 20 avril 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 187 du 11
juillet 1988.

Les Actionnaires, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions contenues

dans l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Présentation du projet de fusion de la Société.
3. Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion avec Clemency RCG Re SCA, Wiltz RCG Re SCA,

Larochette RCG Re SCA and Schengen RCG Re SCA, d'après l'article 259 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales (la "Loi") par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de tous les actifs, passifs, droits,
obligations et contrats de Clemency RCG Re SCA, Wiltz RCG Re SCA, Larochette RCG Re SCA and Schengen RCG
Re SCA à la Société (la "Fusion").

4. Augmentation du capital social de la Société par un montant de USD 8.779.109 (huit millions sept cent soixante-

dix-neuf mille cent neuf Dollars des Etats-Unis d'Amérique), afin de le porter de son montant actuel de six millions cinq
cent deux mille neuf cent trente-neuf dollars des Etats-Unis d'Amérique (6.502.939,- USD) à USD 15.282.048 (quinze
millions deux cent quatre-vingt-deux Dollars des Etats-Unis) par l'émission de 8.779.109 (huit millions sept cent soixante-
dix-neuf mille cent neuf) d'actions sans désignation de valeur nominale, étant souscrites par Ramius Entreprise Luxem-
bourg Holdco sàrl, "société à responsabilité limitée", constituée et existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège
social au L-4243 Esch-sur-Alzette 97, rue Jean-Pierre Michels, avec numéro de Registre de Commerce B130705, étant
l'actionnaire commanditaire de Clemency RCG Re SCA, Wiltz RCG Re SCA, Larochette RCG Re SCA et Schengen RCG
Re SCA, en considération du transfert de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats de Clemency RCG Re
SCA, Wiltz RCG Re SCA, Larochette RCG Re SCA et Schengen RCG Re SCA à la Société, et de telles nouvelles actions
à être émises avec une prime de fusion de USD 19.661.215 (dix-neuf millions six cent soixante et un mille deux cent
quinze Dollars des Etats-Unis).

5. Suite à la Fusion et à la dissolution de Clemency RCG Re SCA, Wiltz RCG Re SCA, Larochette RCG Re SCA et

Schengen RCG Re SCA, annulation des registres des actionnaires de Clemency RCG Re SCA, Wiltz RCG Re SCA,
Larochette RCG Re SCA et Schengen RCG Re SCA et mise à jour du registre des actionnaires de la Société;

6. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société afin d'y refléter ce qui précède;
7. Reconnaissance de la date effective de la Fusion d'un point de vue comptable; et
8. Divers.

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social des Sociétés étant représentée, les Actionnaires renoncent aux formalités de convocation,

se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été
communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaire déclarent qu'ils ont entière connaissance du projet de fusion (le "Projet de Fusion") en relation avec

la fusion de la Société avec:

1) «Clemency RCG Re S.C.A.», une société en commandite par actions, ayant son siège social à L-4243 Esch-sur-

Alzette 97, rue Jean-Pierre Michels immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B
numéro 42294, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg en date
du 21 décembre 1992 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 39 du 27 janvier 1993,

2) «Wiltz RCG Re S.C.A.», une société en commandite par actions, ayant son siège social à L-4243 Esch-sur-Alzette

97, rue Jean-Pierre Michels, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro

85856

L

U X E M B O U R G

46306, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 23 dé-
cembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 127 du 6 avril 1994,

3) «Larochette RCG Re S.C.A.», une société en commandite par actions, ayant son siège social à L-4243 Esch-sur-

Alzette 97, rue Jean-Pierre Michels, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B
numéro 28.687, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange en date du 11
août 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 302 du 16 novembre 1988,

4) «Schengen RCG Re S.C.A.», une société en commandite par actions, ayant son siège social à L-4243 Esch-sur-Alzette

97, rue Jean-Pierre Michels, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro
37290, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 25
juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 461 du 13 décembre 1991,

("Clemency RCG Re SCA, Wiltz RCG Re SCA, Larochette RCG Re SCA et Schengen RCG Re SCA ensembles formant

les "Sociétés Absorbées"), par lequel la Société absorbe les Sociétés Absorbées (la "Fusion").

Les Actionnaires notent que le Project de Fusion a été exécuté par les gérants de la Société et par les gérants des

Sociétés Absorbées respectives le 26 mai 2014 et a été publié au Mémorial en date du 30 mai 2014, numéro 1386,
conformément à l'article 262 (1) de la Loi.

<i>Troisième résolution

Les Actionnaires décident d'approuver le Projet de Fusion, tel que publié, dans toutes ses dispositions et en son

entièreté, sans exception ni réserve.

Les Actionnaires par la suite décident de réaliser la Fusion d'après l'article 259 de la Loi, par le transfert, suite à la

dissolution sans liquidation, de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats des Sociétés Absorbées à la Société
rétroactivement au 30 juin 2014.

Les Actionnaires décident aussi d'approuver le transfert de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats des

Sociétés Absorbées à la Société et l'attribution et les conditions de l'émission des nouvelles actions conformément au
ratio d'échange tel que publié dans le Projet de Fusion.

Les actions nouvellement émises seront en forme nominative et leur inscription dans le registre des actionnaires de

la Société se produira le jour du présent acte.

<i>Quatrième résolution

En tant que résultat de la Fusion, les Actionnaires décident d'augmenter le capital social de la Société par un montant

de USD 8.779.109,- (huit millions sept cent soixante-dix-neuf mille cent neuf Dollars des Etats-Unis d'Amérique, par
l'émission de 8.779.109 (huit millions sept cent soixante-dix-neuf mille cent neuf) actions additionnelles sans désignation
de valeur nominale souscrites par «Ramius Entreprise Luxembourg Holdco S.à r.l.), prénommée, actionnaire comman-
ditaire de la Société mais agissant également en sa qualité d'actionnaire commanditaire des quatre (4) Sociétés Absorbées,
en considération du transfert de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats des Sociétés Absorbées à la Société
et le paiement d'une prime de fusion d'un montant total de USD 19.661.215,- (dix-neuf millions six cent soixante et un
mille deux cent quinze Dollars des Etats-Unis).

<i>Souscription et paiement

«Ramius Entreprise Luxembourg Holdco S.à r.l.», prénommée, actionnaire commanditaire et agissant en sa capacité

d'actionnaires des quatre (4) Sociétés Absorbées, décident de souscrire aux 8.779.109 (huit millions sept cent soixante-
dix-neuf mille cent neuf) actions sans valeur nominale chacune et à une prime de fusion d'un montant total de USD
19.661.215,- (dix-neuf millions six cent soixante et un mille deux cent quinze Dollars des Etats-Unis) comme résultat de
la Fusion.

<i>Cinquième résolution

Suite à la Fusion et à la dissolution des Sociétés Absorbées, les Actionnaires décident d'annuler les actions des Sociétés

Absorbées, d'annuler les registres des actionnaires des Sociétés Absorbées et de mettre à jour le registre des actionnaires
de la Société.

<i>Sixième résolution

Les Actionnaires décident par conséquent de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts, de telle sorte

qu'il sera désormais lu comme suit:

Art. 5. Le capital social est fixé à USD 15.282.048,- (quinze millions deux cent quatre-vingt-deux mille quarante-huit

Dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 15.282.048 (quinze millions deux cent quatre-vingt-deux mille qua-
rante-huit) actions ayant sans valeur nominale, entièrement libérées."

<i>Septième résolution

Les Actionnaires reconnaissent que:

85857

L

U X E M B O U R G

- d'un point de vue comptable, la Fusion est effective rétroactivement à partir du 1 

er

 janvier 2014, tel que prévu dans

le Projet de Fusion

- et que l'effet de la fusion est rétroactif au 30 juin 2014.

<i>Frais

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société suite au

présent acte sont estimés approximativement à quatre mille trois cent soixante euros (EUR 4.360,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne prenant plus la parole, l'assemblée est close.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date mentionnée en en-tête des présentes.
Le Notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les Actionnaires l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la requête des Actionnaires,
en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Le présent document a été lu aux Actionnaires, représentés par leurs mandataires, connues du Notaire par ses nom,

prénom, état civil et domicile, celles-ci ont signé ensemble avec le Notaire le présent acte.

Signé: V. COQUILLE, C. ALIBRANDI, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 03.07.2014. Relation: LAC/2014/30992. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Carole FRISING.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03.07.2014.

Référence de publication: 2014095338/291.
(140113267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2014.

Mac Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 142.783.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2013 de la société MAC EUROPE S.A. ayant son siège social à L-9991

Weiswampach, 2, Am Hock, enregistrée au registre de commerce sous le numéro B 142.783 a pris les décisions suivantes:

<i>1 

<i>ère

<i> décision

L'assemblée générale décide de prolonger le mandat du l'administrateur/président, POSSOZ Raymond, demeurant à

B-7850 ENGHIEN, 139, chaussée de Brunehault, qui l'accepte. Son mandat durera jusqu'à l'assemblée générale qui se
tiendra dans l'année 2019.

L'assemblée générale décide de prolonger les mandats des administrateurs de Madame NIEUWBOURG Marie-Claire,

demeurant à B-7850 ENGHIEN, 139, chaussée de Brunehault, qui l'accepte, de Madame POSSOZ Marie-Christine, de-
meurant à B-1640 RHODE-SAINT-GENÈSE, 15, avenue de la Petite Jonction, qui l'accepte et de Madame POSSOZ Ann,
demeurant à B-7850 ENGHIEN, 363, chaussée de Bruxelles, qui l'accepte. Leurs mandats dureront jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra dans l'année 2019.

L'assemblée générale décide de prolonger le mandat du l'administrateur-délégué, POSSOZ Raymond, demeurant à

B-7850 ENGHIEN, 139, chaussée de Brunehault, qui l'accepte. Son mandat durera jusqu'à l'assemblée générale qui se
tiendra dans l'année 2019.

L'assemblée générale décide de prolonger le mandat du commissaire, Madame HANSEN Katrin, demeurant à B-4780

ST. VITH, Stechelsberg, Hünningen, 3, qui l'accepte. Son mandat durera jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra dans
l'année 2019.

Ces décisions ont été prises à l'unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Weiswampach, le 30 juin 2013.

Signature
<i>Un mandataire de la société

Référence de publication: 2014065156/30.
(140076256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.

85858

L

U X E M B O U R G

EuroAmerica AM SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 188.230.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the eleventh day of June.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

EuroAmerica S.A., a company incorporated under the law of Chile, having its registered office at Av. Apoquindo 3885

piso 21, Las Condes, Santiago, Chile, registered with the Registro de Comercio under number 24920,

represented by Me Laetitia Servais, Avocat à la cour, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated

9 April 2014.

The proxy given, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

This appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a société anonyme which it intends to incorporate in Luxembourg:

1. Denomination, Duration, Corporate object, Registered office

Art. 1. Denomination. There exists among the subscribers and all those who become owners of Shares hereafter

issued, a corporation in the form of a société anonyme, qualifying as a société d'investissement à capital variable with
multiple sub-funds under the name of "EuroAmerica AM SICAV" (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited period of time. The Company may be dissolved by a

resolution of the shareholders (the "Shareholders") adopted in the manner required for amendment of these articles of
incorporation (the "Articles of Incorporation").

Art. 3. Corporate object. The exclusive object of the Company is the collective investment of its assets in transferable

securities, money market instruments and other permissible assets such as referred to in the Luxembourg Law of 17
December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended (the "Law"), with the purpose of offering
various investment opportunities, spreading investment risk and offering its Shareholders the benefit of the management
of the Company’s assets.

The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and deve-

lopment of its object in the broadest sense within the framework of Part I of the Law.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, in the Grand Duchy of

Luxembourg. If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the board of di-
rectors (hereafter collegially referred to as the "Board of Directors" or the "Directors" or individually referred to as a
"Director") may decide to transfer the registered office of the Company to any other place in the Grand Duchy of
Luxembourg. Wholly owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad
by resolution of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economical, social or military deve-

lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
rarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall
have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg corporation.

2. Share capital, variations of the share capital, characteristics of the shares

Art. 5. Share capital. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall be at any

time equal to the total net assets of the Company, as defined in Article 11. The minimum capital of the Company shall
not be less than the amount prescribed by the Law.

For consolidation purposes, the reference currency of the Company is the United States Dollar (US Dollar).

Art. 6. Variations in share capital. The share capital may also be increased or decreased as a result of the issue by the

Company of new fully paid-up shares (each a "Share") or the repurchase by the Company of existing Shares from its
Shareholders.

Art. 7. Sub-Funds. The Board of Directors is authorised without limitation to issue fully paid Shares at any time in

accordance with Article 12 hereof without reserving to the existing Shareholders a preferential right to subscription of
the Shares to be issued.

85859

L

U X E M B O U R G

Shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different sub-funds corresponding to separate portfolios

of assets (each a "Sub-Fund") (which may, as the Board of Directors shall determine, be denominated in different cur-
rencies) and the proceeds of the issue of the Shares of each Sub-Fund shall be invested pursuant to Article 3 hereof in
transferable securities, money market instruments or other permitted assets corresponding to such geographical areas,
industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities and other permitted assets,
as the Board of Directors shall from time to time determine.

Each Sub-Fund is deemed to be a compartment within the meaning of the Law (in particular article 181 of the Law).
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not

expressed in US Dollar, be converted into US Dollar.

Art. 8. Classes of Shares. The Board of Directors may decide, at any time, to create within each Sub-Fund different

classes of Shares (each a "Class") which may differ, inter alia, in their charging structure, the minimum investment requi-
rements, the management fees or type of target investors, or correspond to a specific hedging or distribution policy, such
as giving right to regular dividend payments ("Distribution Shares") or giving no right to distributions ("Capitalisation
Shares"). Fractions of Shares may be issued under the conditions as set out in the Company's sales documents.

When the context so requires, references in these Articles of Incorporation to Sub-Fund(s) shall mean references to

Class(es) of Shares and vice-versa.

Art. 9. Form of the Shares. The Company may issue Shares of each Sub-Fund and of each Class of Shares in registered

form only.

Ownership of Shares is evidenced by entry in the register of Shareholders of the Company and is represented by

confirmation of ownership. The Company will not issue share certificates.

All issued Shares of the Company shall be inscribed in the register of Shareholders shall be kept at the registered office

of the Company. Such Share register shall set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the
number of Shares held by him, the Class of Share, the amounts paid for each such Share, the transfer of Shares and the
dates of such transfers. The Share register is conclusive evidence of ownership.

Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the subscription price, under

the conditions disclosed in the sales documents of the Company. The subscriber will, upon acceptance of the subscription
and receipt of the purchase price, receive title to the Shares purchased by him.

The transfer of a Share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of Shareholders,

such declaration of transfer, in a form acceptable to the Company, to be dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence
of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

Any Shareholder has to indicate to the Company an address to be maintained in the Share register. All notices and

announcements of the Company given to Shareholders shall be validly made at such address. Any Shareholder may, at
any moment, request in writing amendments to his address as maintained in the Share register. The Shareholder shall be
responsible for ensuring that its details, including its address, for the register of Shareholders are kept up to date and
shall bear any and all responsibility should any details be incorrect or invalid.

The Company will recognise only one holder in respect of each Share in the Company. In the event of joint ownership,

the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant Share or Shares until one person shall
have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company.

If a conversion or a payment made by any subscriber results in the issue of a Share fraction, such fraction shall be

entered into the register of Shareholders. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall
determine, be entitled to a corresponding fraction of the dividend.

Art. 10. Limitation to the ownership of Shares. The Board of Directors shall have power to impose or relax such

restrictions on any Sub-Fund or Class of Shares as it may think necessary for the purpose of ensuring that no Shares in
the Company or no Shares of any Sub-Fund in the Company are acquired or held by

(a) any person in breach of any laws or regulations of any country or governmental or regulatory authority if the

Company, any Shareholder or any other person (all as determined by the Directors) would suffer any pecuniary or other
disadvantage as a result of such breach) or (b) any person in circumstances which in the opinion of the Board of Directors
might result in the Company incurring any liability to taxation (including inter alia any liability that might derive from the
Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might
not otherwise have incurred or suffered, including a requirement to register under any securities or investment or other
laws or requirements of any country or authority.

More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm

or corporate body, and without limitation, by any "U.S. person", (as defined hereafter) and any person, firm or corporate
body targeted by FATCA.

For such purposes, the Company may, at its discretion and without liability:

85860

L

U X E M B O U R G

a) decline to issue any Share and to register any transfer of a Share, where it appears to it that such registration or

transfer would or might result in such Share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from
holding Shares in the Company; and/or

b) at any time require any person whose name is entered in the register of Shareholders to furnish it with any infor-

mation, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial
ownership of such Shareholder's Shares rests in a person who is precluded from holding Shares in the Company; and/or

c) where it appears to the Company that any person, who is precluded pursuant to this Article from holding Shares

in the Company, either alone or in conjunction with any other person, is a beneficial owner of Shares compulsorily
purchase from any such Shareholder all Shares held by such Shareholder.

In such cases enumerated under (a) to (c) above, the Company may compulsorily redeem from any such Shareholder

all Shares held by such Shareholder in the following manner:

1) The Company shall serve a notice (hereinafter referred to as the "Redemption Notice") upon the Shareholder

subject to compulsory repurchase; the Redemption Notice shall specify the Shares to be repurchased as aforesaid, the
Redemption Price (as defined here below) to be paid for such Shares and the place at which this price is payable. Any
such notice may be served upon such Shareholder by registered mail, addressed to such Shareholder at his last known
address or at his address as indicated in the Share register. Immediately after the close of business on the date specified
in the Redemption Notice, such Shareholder shall cease to be the owner of the Shares specified in the redemption notice,

2) The price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall be purchased (hereinafter referred to as

the "Redemption Price") shall be an amount based on the Net Asset Value per Share of the Class and the Sub-Fund to
which the Shares belong, determined in accordance with Article 11 hereof, as at the date of the Redemption Notice,

3) Subject to all applicable laws and regulations, payment of the Redemption Price will be made to the owner of such

Shares in the currency in which the Shares are denominated or in certain other currencies as may be determined from
time to time by the Board of Directors, and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere
(as specified in the Redemption Notice) for payment to such owner,

4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article 10 shall not be questioned or invalidated in

any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person at the date of any
Redemption Notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

The Company may also, at its discretion and without liability, decline to accept the vote of any person who is precluded

pursuant to this Article from holding Shares in the Company at any meeting of Shareholders of the Company.

Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" shall include a national or resident of the United States of

America or any of its states, territories, possessions or areas subject to its jurisdiction (the "United States") and any
partnership, corporation or other entity organised or created under the laws of the United States or any political sub-
division thereof. The Directors may clarify the term U.S. person in the Company's sales documents.

In addition to the foregoing, the Board of Directors may restrict the issue and transfer of Shares of a Class of Shares

or of a Sub-Fund to institutional investors within the meaning of the Article 174 of the Law ("Institutional Investor(s)").
The Board of Directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for Shares of a Class
of Shares or of a Sub-Fund reserved for Institutional Investors until such time as the Company has received sufficient
evidence that the applicant qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of Shares of a Class
of Shares or of a Sub-Fund reserved to Institutional Investors is not an Institutional Investor, the Board of Directors will
convert the relevant Shares into Shares of a Class of Shares or of a Sub-Fund which is not restricted to Institutional
Investors (provided that there exists such a Class of Shares or of a Sub-Fund with similar characteristics) or compulsorily
redeem the relevant Shares in accordance with the provisions set forth above in this Article. The Board of Directors will
refuse to give effect to any transfer of Shares and consequently refuse for any transfer of Shares to be entered into the
register of Shareholders in circumstances where such transfer would result in a situation where Shares of a Class of
Shares or of a Sub-Fund to Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an
Institutional Investor. In addition to any liability under applicable law, (i) each Shareholder who is precluded from holding
Shares in the Company who holds Shares of the Company or (ii) each Shareholder who does not qualify as an Institutional
Investor who holds Shares in a Class of Shares or of a Sub-Fund restricted to Institutional Investors or, shall hold harmless
and indemnify the Company, the Board of Directors, the other Shareholders of the relevant Class of Shares or of a Sub-
Fund and the Company’s agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding
circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading
or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Company
of its change of such status.

3. Net asset value, issue and repurchase of shares, suspension of the calculation of the net asset value

Art. 11. Net Asset Value. The Net Asset Value per Share of each Class of Shares in each Sub-Fund of the Company

shall be determined periodically by the Company, but in any case not less than twice a month or, subject to regulatory
approval, no less than once a month, as the Board of Directors may determine (every such day for determination of the
Net Asset Value being referred to herein as the "Valuation Day") on the basis of prices whose references are specified
in the Company's sales documents.

85861

L

U X E M B O U R G

The Net Asset Value per Share is expressed in the reference currency of each Sub-Fund/Class and, for each Class of

Shares for all Sub-Funds, is determined by dividing the value of the total assets (including accrued income) of each Sub-
Fund properly allocable to such Class of Shares less the total liabilities of such Sub-Fund properly allocable to such Class
of Shares by the total number of Shares of such Class outstanding on any Valuation Day. The Board of Directors may
also apply dilution adjustments or swing pricing techniques as disclosed in the Company's sales document.

If since the close of business, there has been a material change in the quotations on the markets on which a substantial

portion of the investments attributable to a particular Sub-Fund are dealt or quoted, the Company may, in order to
safeguard the interests of Shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.

The valuation of the Net Asset Value per Share of the different Classes of Shares shall be made in the following manner:
A) The assets of the Company shall be deemed to include:
(1) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
(2) all bills and demand notes and accounts due (including the price of securities sold but not collected);
(3) all securities, shares, bonds, units/shares in undertakings for collective investment, debentures, options or sub-

scription rights and any other investments and securities belonging to the Company;

(4) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind; the Company may however adjust the valuation

to check fluctuations of the market value of securities due to trading practices such a trading ex dividend or ex rights;

(5) all accrued interest on securities held by the Company except to the extent such interest is comprised in the

principal thereof;

(6)  the  preliminary  expenses  of  the  Company  insofar  as  the  same  have  not  been  written  off,  provided  that  such

preliminary expenses may be written off directly from the capital of the Company;

(7) all other permitted assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
i) shares or units in open-ended undertakings for collective investment, which do not have a price quotation on a

regulated market, will be valued at the actual net asset value for such shares or units as of the relevant Valuation Day,
failing which they shall be valued at the last available net asset value which is calculated prior to such Valuation Day. In
the case where events have occurred which have resulted in a material change in the net asset value of such shares or
units since the last net asset value was calculated, the value of such shares or units may be adjusted at their fair value in
order to reflect, in the reasonable opinion of the Board of Directors, such change;

ii) the value of securities (including a share or unit in a closed-ended undertaking for collective investment and in an

exchange traded fund) and/or financial derivative instruments which are listed and with a price quoted on any official stock
exchange or traded on any other organised market at the last available stock price. Where such securities or other assets
are quoted or dealt in or on more than one stock exchange or other organised markets, the Board of Directors shall
select the principal of such stock exchanges or markets for such purposes;

iii) shares or units in undertakings for collective investment the issue or redemption of which is restricted and in

respect of which a secondary market is maintained by dealers who, as principal market-makers, offer prices in response
to market conditions may be valued by the Board of Directors in line with such prices;

iv) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,

cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Board of Directors may consider appropriate in such case to reflect the true
value thereof;

v) the financial derivative instruments which are not listed on any official stock exchange or traded on any other

organised market will be valued in a reliable and verifiable manner on a daily basis and verified by a competent professional
appointed by the Company;

vi) swap contracts will be valued according to generally accepted valuation rules that can be verified by auditors. Asset

based swap contracts will be valued by reference to the market value of the underlying assets. Cash flow based swap
contracts will be valued by reference to the net present value of the underlying future cash flows;

vii) the value of any security or other asset which is dealt principally on a market made among professional dealers

and institutional investors shall be determined by reference to the last available price;

viii) any assets or liabilities in currencies other than the currency of the Classes of the Shares will be converted using

the relevant spot rate quoted by a bank or other responsible financial institution;

ix) in the event that any of the securities held in the Company portfolio on the relevant day are not listed on any stock

exchange or traded on any organised market or if with respect to securities listed on any stock exchange or traded on
any other organised market, the price as determined pursuant to sub-paragraph (ii) is not, in the opinion of the Board of
Directors, representative of the fair market value of the relevant securities, the value of such securities will be determined
prudently and in good faith based on the reasonably foreseeable sales price or any other appropriate valuation principles;

85862

L

U X E M B O U R G

x) in the event that the above mentioned calculation methods are inappropriate or misleading, the Board of Directors

may adopt to the extent such valuation principles are in the best interests of the Shareholders any other appropriate
valuation principles for the assets of the Company; and

xi) in circumstances where the interests of the Company or its Shareholders so justify (avoidance of market timing

practices, for example), the Board of Directors may take any appropriate measures, such as applying a fair value pricing
methodology to adjust the value of the Company's assets.

If after the Net Asset Value per Share has been calculated, there has been a material change in the quoted prices on

the markets on which a substantial portion of the investments of the Company attributable to a particular Sub-Fund is
dealt or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the Shareholders and the Company, cancel the
first valuation and carry out a second valuation. In the case of such a second valuation, all issues, conversions or redemp-
tions of Shares dealt with by the Sub-Fund for such a Valuation Day must be made in accordance with this second valuation.

B) The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(1) all loans, bills and accounts payable;
(2) all accrued or payable administrative expenses (including but not limited to management fee, depositary fee and

corporate agents' fee);

(3) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company where the date of valuation falls on the
record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;

(4) an appropriate provision for future taxes based on capital and income as at the date of the valuation and any other

reserves, authorised and approved by the Board of Directors; and

(5) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the

Company. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the
Company comprising (but not limited to) formation expenses, fees payable to the management company, if appointed,
the Directors, the investment managers and/or advisers, fees and expenses of the accountants, the custodian, the registrar
and transfer, corporate, domiciliary and administrative agent, the paying agents and permanent representatives in places
of registration, any other agent employed by the Company, fees for legal and/or auditing services, insurance premiums,
printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising and/or preparing and printing of the pros-
pectuses, explanatory memoranda, key investor information documents or registration statements, taxes or governmental
charges, all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage
commissions, postage, telephone, telegram, telex, telefax message and facsimile (or other similar means of communica-
tion), litgation and indemnification expenses. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular
or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal
proportions over any such period.

C) The Directors shall establish a pool of assets for each Sub-Fund in the following manner:
(1) the proceeds from the allotment and issue of each Class of Shares of such Sub-Fund shall be applied in the books

of the Company to the portfolio of assets established for that Sub-Fund, and the assets and liabilities and income and
expenditure attributable thereto shall be applied to such pool subject to the provisions of this Article;

(2) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company

to the same pool as the assets from which it was derived and on each re-evaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant pool;

(3) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in

connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool;

(4) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular

pool, such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the Net Asset Values of each pool; provided that
all liabilities, attributable to a pool shall be binding on that pool; and

(5) upon the record date for the determination of the person entitled to any dividend declared on any Class of Shares,

the Net Asset Value of such Class of Shares shall be reduced by the amount of such dividends.

D) For the purpose of valuation under this Article:
(1) Shares of the Company to be redeemed under Article 12 hereof shall be treated as existing and taken into account

until immediately after the time specified by the Directors on the Valuation Day on which such valuation is made, and,
from such time and until paid, the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

(2) Shares of the Company in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received

shall be deemed to be existing as from the close of business on the Valuation Day on which they have been allotted and
the price therefore, until received by the Company, shall be deemed a debt due to the Company;

(3) all investments, cash balances and other assets of any Sub-Fund expressed in currencies other than the currency

of denomination in which the Net Asset Value per Share of the relevant Sub-Fund is calculated shall be valued after taking
into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value
of the relevant Sub-Fund;

85863

L

U X E M B O U R G

(4) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company

on such Valuation Day, to the extent practicable; and

(5) the valuation referred to above shall reflect that the Company is charged with all expenses and fees in relation to

the performance under contract or otherwise by agents for management company services (if appointed), asset mana-
gement, custodial, domiciliary, registrar and transfer agency, audit, legal and other professional services and with the
expenses of financial reporting, notices and dividend payments to Shareholders and all other customary administration
services and fiscal charges, if any.

E) The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for one or more

Sub-Fund(s) (hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is applicable with regard to their
respective investment sectors to do so. Any such enlarged asset pool ("Enlarged Asset Pool") shall first be formed by
transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds.
Thereafter the Directors may from time to time make further transfers to the Enlarged Asset Pool. They may also transfer
assets from the Enlarged Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating
Fund concerned. Assets other than cash may be allocated to an Enlarged Asset Pool only where they are appropriate to
the investment sector of the Enlarged Asset Pool concerned.

The  assets  of  the  Enlarged  Asset  Pool  to  which  each  Participating  Fund  shall  be  entitled,  shall  be  determined  by

reference to the allocations and withdrawals made on behalf of the other Participating Funds.

Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Enlarged Asset

Pool will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective entitlements to the assets
in the Enlarged Asset Pool at the time or receipt.

Art. 12. Issue, redemption and conversion of Shares. The Board of Directors is authorised to issue further fully paid-

up Shares of each Class and of each Sub-Fund at any time at a price based on the Net Asset Value per Share for each
Class of Shares and for each Sub-Fund determined in accordance with Article 11 hereof, as of such Valuation Day as is
determined in accordance with such policy as the Board of Directors may from time to time determine. Such price may
be increased by applicable charges and/or dilution levy, as approved from time to time by the Board of Directors and
described in the Company's sales document. Such price may be rounded upwards or downwards as the Board of Directors
may resolve. During any initial offer period to be determined by the Board of Directors and disclosed to investors, the
issue price may also be based on an initial subscription price, increased by any dilution levy and/or applicable charges (if
any).

The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company or to any other duly

authorised person, the duty of accepting subscriptions and of receiving payment for such new Shares.

All new Share subscriptions shall, under pain of nullity, be entirely paid-up, and the Shares issued carry the same rights

as those Shares in existence on the date of the issuance. The subscription price shall be paid within a period as determined
by the Board of Directors and specified in the Company's sales documents.

The Company may reject any subscription in whole or in part, and the Directors may, at any time and from time to

time and in their absolute discretion without liability and without notice, discontinue the issue and sale of Shares of any
Class in any one or more Sub-Funds.

The subscription price (not including the sales commission or any other changes) may, upon approval of the Board of

Directors, and subject to all applicable laws and regulations, namely with respect to a special audit report confirming the
value of any assets contributed in kind (if legally required), be paid by contributing to the Company assets acceptable to
the Board of Directors consistent with the investment policy and investment restrictions of the Company. The costs for
such subscription in kind, in particular the costs of the special audit report, will be borne by the shareholder requesting
the subscription in kind or by a third party, but will not be borne by the Company unless the Board of Directors considers
that the subscription in kind is in the interests of the Company or made to protect the interests of the Company, in which
case such costs may be borne in all or in part by the Company.

Any Shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company provided that:
(i) the Company may determine the notice period required for lodging redemption requests. Applicable notice periods

(if any) will be disclosed in the sales documents of the Company;

(ii) in the case of a request for redemption of part of his Shares, the Company may, if compliance with such request

would result in a holding of Shares of any one Class or in any one Sub-Fund with an aggregate Net Asset Value of less
than such amount or number of Shares as the Board of Directors may determine from time to time and as described in
the sales documents, redeem all the remaining Shares held by such Shareholder;

(iii) the Company may limit the percentage of the net asset value of any Sub-Fund which may be redeemed (including

conversions) on a Valuation Day to a certain percentage as disclosed in the Company's sales documents of the Net Asset
Value of such Sub-Fund on a Valuation Day. Redemption or conversion requests exceeding the threshold determined by
the Board of Directors may be deferred as disclosed in the sales documents of the Company. Deferred redemption or
conversion requests will be dealt in priority to later requests. Unless otherwise provided for herein, in case of deferral
of redemption the relevant Shares shall be redeemed at a price based on the Net Asset Value per Share prevailing at the
date on which the redemption is effected, less any redemption charge in respect thereof and/or less any applicable dilution

85864

L

U X E M B O U R G

levy and/or less any contingent deferred charge and/or less any other charge as foreseen by the sales documents of the
Company.

The redemption proceeds shall be paid within the timeframe provided for in the sales documents of the Company and

shall be based on the price for the relevant Class of Shares of the relevant Sub-Fund as determined in accordance with
the provisions of Article 11 hereof, less any redemption charge in respect thereof and/or less any applicable dilution levy
and/or less any contingent deferred charge and/or less any other charge as foreseen by the sales documents of the
Company.

If in exceptional circumstances the liquidity of the portfolio of assets maintained in respect of the Class of Shares of a

given Sub-Fund being redeemed is not sufficient to enable the payment to be made within such a period, such payment
shall be made as soon as reasonably practicable thereafter but without interest.

Payment of redemption proceeds may be delayed if there are any specific statutory provisions such as foreign exchange

restrictions, or any circumstances beyond the Company's control which make it impossible to transfer the redemption
proceeds to the country where the redemption was requested.

With the consent of or upon request of the Shareholder(s) concerned, the Board of Directors may satisfy redemption

requests in whole or in part in kind by allocating to the redeeming Shareholders investments from the portfolio in value
equal to the Net Asset Value attributable to the Shares to be redeemed as described in the Company’s sales documents.
Such redemption will, if required by law or regulation, be subject to a special audit report by the approved statutory
auditor of the Company confirming the number, the denomination and the value of the assets which the Board of Directors
will have determined to be contributed in counterpart of the redeemed Shares. The costs for such redemptions in kind,
in particular the costs of the special audit report, will be borne by the Shareholder requesting the redemption in kind or
by a third party, but will not be borne by the Company unless the Board of Directors considers that the redemption in
kind is in the interests of the Company or made to protect the interests of the Company, in which case such costs may
be borne in all or in part by the Company. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined
on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of Shares in the relevant Sub-
Fund.

Shares of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.
Unless otherwise provided for in the sales documents of the Company, any Shareholder is entitled to request the

conversion of whole or part of his Shares, provided that the Board of Directors may, in the Company's sales documents:

a) set terms and conditions as to the right and frequency of conversion of Shares between Sub-Funds or between

Classes of Shares; and

b) subject conversions to the payment of such charges and commissions as it shall determine.
If as a result of any request for conversion, the aggregate Net Asset Value per Share of the Shares held by a Shareholder

in any Class of Shares would fall below such value as determined by the Board of Directors, then the Company may
decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such Shareholder’s holding of Shares
in such Class, as stated in the sales documents.

Such a conversion shall be effected on the basis of the Net Asset Value of the relevant Shares of the different Sub-

Funds or Classes of Shares, determined in accordance with the provisions of Article 11 hereof. The relevant number of
Shares may be rounded up or down to a certain number of decimal places as determined by the Board of Directors and
described in the sales documents.

Subscription, redemption and conversion requests shall be revocable under the conditions determined by the Board

of Directors and disclosed (if any) in the sales documents of the Company as well as in the event of suspension of the
Net Asset Value Calculation, as further detailed in Article 13 of these Articles of Incorporation.

Art. 13. Suspension of the calculation of the Net Asset Value and of the issue, the redemption and the conversion of

Shares. The Company may suspend the calculation of the Net Asset Value of one or more Sub-Funds and the issue,
redemption and conversion of any Classes of Shares in the following circumstances:

a) during any period when any market or stock exchange, which is the principal market or stock exchange on which

a material part of the investments of the relevant Sub-Fund for the time being are quoted, is closed (other than for ordinary
holidays), or during which dealings are substantially restricted or suspended;

b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal of investments

of the relevant Sub-Fund by the Company is not possible;

c) during any period when the determination of the net asset value per share of the underlying fund of funds or the

dealing of their shares/units in which a Sub-Fund is a materially invested is suspended or restricted;

d) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the

relevant Sub-Fund's investments or the current prices on any market or stock exchange;

e) during any period when remittance of monies which will or may be involved in the realisation of, or in the repayment

for any of the relevant Sub-Fund's investments is not possible;

85865

L

U X E M B O U R G

f) from the date on which the Board of Directors decides to liquidate or merge one or more Sub-Fund(s) or Class or

in the event of the publication of the convening notice to a general meeting of Shareholders at which a resolution to wind
up or merge the Company or one or more Sub-Fund(s) or Class is to be proposed;

g) during any period when in the opinion of the Directors of the Company there exist circumstances outside the

control of the Company where it would be impracticable or unfair towards the Shareholders to continue dealing in Shares
of any Sub-Fund of the Company; or

h)  during  any  other  circumstance  or  circumstances  where  a  failure  to  do  so  might  result  in  the  Company  or  its

shareholders incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or other detriment to which
the Company or its shareholders might not otherwise have suffered.

The Company may cease the issue, allocation, conversion and redemption of the Shares forthwith upon the occurrence

of an event causing it to enter into liquidation or upon the order of the Luxembourg supervisory authority.

The suspension of the calculation of the Net Asset Value of a Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the

Net Asset Value per Share, the issue, redemption and conversion of Shares of any other Sub-Fund which is not suspended.

To the extent legally or regulatory required or decided by the Company, Shareholders who have requested conversion

or redemption of their Shares will be promptly notified in writing of any such suspension and of the termination thereof.
The Board of Directors may also make public such suspension in such a manner as it deems appropriate.

Suspended subscription, redemption and conversion applications may be withdrawn by written notice provided that

the Company receives such notice before the suspension ends.

Suspended subscription, redemption and conversion applications shall be executed on the first Valuation Day following

the resumption of Net Asset Value calculation by the Company.

4. General shareholders’ meetings

Art. 14. General provisions. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company shall represent

the entire body of Shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all Shareholders of the Company
regardless of the Class of Shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating
to the operations of the Company.

Art. 15. Annual general Shareholders’ meeting. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance

with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may
be specified in the notice of the meeting, on the eleventh of June at 10.00 a.m. (Luxembourg time). If such day is not a
bank business day in Luxembourg, then the annual general meeting shall be held on the next following bank business day.

If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of

Shareholders may be held at another date, time or place than those set forth in the preceding paragraph, which date,
time and place are to be decided by the Board of Directors.

Other meetings of Shareholders or of holders of Shares of any specific Sub-Fund or Class may, where required or

appropriate, be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 16. General meetings of Shareholders of Classes of Shares. The Shareholders of any Sub-Fund or any Class of

Shares may hold or be convened to, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to
such Sub-Fund or Class of Shares.

Two or more Classes of Shares or Sub-Funds may be treated as a single Class or Sub-Fund if such Sub-Funds or Classes

would be affected in the same way by the proposals requiring the approval of holders of Shares relating to the separate
Sub-Funds or Classes.

Art. 17. Shareholders’ meetings. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the

meetings of Shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each whole Share, regardless of the Class and of the Sub-Fund to which it belongs, is entitled to one vote, subject to

the limitations imposed by these Articles of Incorporation. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by
appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex, telefax message, facsimile or any other
electronic means capable of evidencing such proxy. Fractions of Shares are not entitled to a vote.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly

convened will be passed by simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes in relation to Shares in
respect of which the Shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid
vote. A corporation may execute a proxy under the hand of a duly authorised officer.

If and to the extent permitted by the Board of Directors for a specific meeting of Shareholders, each Shareholder may

vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the address specified in the
convening notice. The Shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least (i)
the name, address or registered office of the relevant Shareholder, (ii) the total number of Shares held by the relevant
Shareholder and, if applicable, the number of Shares of each Class held by the relevant Shareholder, (iii) the place, date
and time of the general meeting, (iv) the agenda of the general meeting, (v) the proposal submitted for decision of the
general meeting, as well as (vi) for each proposal three boxes allowing the Shareholder to vote in favour, against or abstain

85866

L

U X E M B O U R G

from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box. Voting forms, which show neither a vote in
favour, nor against the resolution, nor an abstention shall be void. The Company will only take into account voting forms
received prior to the general meeting of Shareholders to which they relate.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take

part in any meeting of Shareholders.

Where there is more than one Class of Shares or Sub-Fund and the resolution of the general meeting is such as to

change the respective rights thereof, such resolution must, in order to be valid, be approved separately by Shareholders
of such Class of Shares or Sub-Fund in accordance with the quorum and majority requirements provided for by this
Article.

Art. 18. Notice to the general Shareholders' meetings. Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors

or upon the written request of Shareholders representing at least one tenth of the share capital of the Company. To the
extent required by law, the notice shall be published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg,
in a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the Board of Directors may decide.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of Shareholders

may provide that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined by reference to the
Shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the
right of a Shareholder to participate at a general meeting of Shareholders and to exercise the voting right attached to his
Shares will be determined by reference to the Shares held by this Shareholder as at the Record Date.

5. Management of the Company

Art. 19. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three

members who need not to be Shareholders of the Company.

Art. 20. Duration of the appointment of the Directors, renewal of the Board of Directors. The Directors shall be

elected by a general meeting of Shareholders for a period ending at the next annual general meeting and until their
successors are elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed with or without cause and/or
replaced or an additional director appointed at any time by resolution adopted by the general meeting of Shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors

may meet and may elect, by majority vote, a new Director to fill such vacancy on a provisional basis until the next general
meeting of Shareholders.

Art. 21. Committee of the Board of Directors. The Board of Directors shall choose from among its members a

chairman, and may chose from among its members one or more vice-chairmen. It may also chose a secretary, who need
not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the
Shareholders.

Art. 22. Meetings and deliberations of the Board of Directors. The Board of Directors shall meet upon call by the

chairman, or any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of Shareholders and the Board of Directors, but in his absence the Share-

holders or the Board of Directors may appoint another Director by a majority vote to preside at such meetings. For
general meetings of Shareholders and in the case no Director is present, any other person may be appointed as chairman.

The Board of Directors from time to time may appoint officers of the Company, including a general manager, any

assistant managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the
Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors. Officers need not be Directors
or Shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein, shall have the powers and
duties given to them by the Board of Directors.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least 24 hours in advance

of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram,
telex or facsimile transmission or any other electronic means capable of evidencing such waiver of each Director. Separate
notice shall not be required for meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Directors.

Any Director may act at any meetings of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy.

Directors may also cast their vote in writing or by cable, telegram, facsimile transmission or any other electronic means
capable of evidencing such vote.

Any  Director  may  attend  a  meeting  of  the  Board  of  Directors  using  teleconference  means,  provided  that  (i)  the

Director attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other, (iii) the transmission is performed on an on-going basis and (iv) the Directors can properly deliberate. The parti-
cipation in a meeting by such means shall constitute presence in person at the meeting and the meeting is deemed to be
held at the registered office of the Company.

85867

L

U X E M B O U R G

The Directors may only act duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company

by their individual signature, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least half of the Directors are present or represented

at a meeting of Directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at
such meeting. The chairman shall have a casting vote.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effective as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letters, cables, telegrams, telexes, facsimile transmission and other means capable of evidencing such
consent.

The Board of Directors may delegate, under its responsibility and supervision, its powers to conduct the daily mana-

gement and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose,
to natural persons or corporate entities which need not be members of the Board of Directors.

Art. 23. Minutes. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman, or in his

absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

such chairman, or by the secretary, or by two Directors.

Art. 24. Engagement of the Company vis-à-vis third persons. The Company shall be engaged by the signature of two

members of the Board of Directors or by the individual signature of any duly authorised officer of the Company or by
the individual signature of any other person to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 25. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors determines the general orientation of the mana-

gement and of the investment policy, as well as the guidelines to be followed in the management of the Company, always
in compliance with the principle of risk diversification. When any investment policies are determined and implemented,
the Board of Directors shall ensure compliance with the following provisions:

The Board of Directors may decide that investment of the Company be made (i) in transferable securities and money

market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law, (ii) in transferable securities and
money market instruments dealt in on another market in a Member State (as defined by the Law) which is regulated,
operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities and money market instruments
admitted to official listing on a stock exchange in Europe, Asia, Oceania (including Australia), the American continents
and Africa, or dealt in on another market in the countries referred to above, provided that such market is regulated,
operates regularly and is recognised and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities, and money
market instruments provided the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in
any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured
within one year of issue, as well as (v) in any other transferable securities, instruments or other assets within the res-
trictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed
in the sales documents of the Company.

The Board of Directors may decide to invest up to one hundred per cent of the total net assets of each Sub-Fund of

the Company in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any Member
State of the European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union, as acceptable by the
Luxembourg supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Company (including but not limited to
any member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development (“OECD”) Singapore, or any member
state of the G20), or public international bodies of which one or more of Member States of the European Union are
members, provided that in the cases where the Company decides to make use of this provision it must hold, on behalf
of the Sub-Fund concerned, securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account
for more than thirty per cent of such Sub-Fund's total net assets.

The Board of Directors may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments,

including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Law and / or over-the-
counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by Article 41 (1) of the Law, financial
indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment
objectives as disclosed in its sales documents.

The Board of Directors may decide that investments of a Sub-Fund to be made with the aim to replicate a certain

index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that it is
sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the market to which it refers and is published in an appro-
priate manner.

Investments of the Company may be made either directly or indirectly through wholly owned subsidiaries. When

investments of the Company are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on its behalf, carry on
only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is located, with regard to the
redemption of units at the request of Shareholders, Article 48 paragraphs (1) and (2) of the Law do not apply. Any
reference in these Articles to "investments" and "assets" shall mean, as appropriate, either investments made and assets
beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.

85868

L

U X E M B O U R G

The Company will not invest more than 10% of the net assets of any Sub-Fund in undertakings for collective investment

as defined in Article 41 (1) e) of the Law unless specifically foreseen in the sales documents of the Company for a Sub-
Fund.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, any Sub-Fund may, to the widest extent permitted

by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents,
invest in one or more Sub-Funds. The relevant legal provisions on the computation of the Net Asset Value will be applied
accordingly. In such case and subject to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, the voting
rights, if any, attaching to the Shares held by a Sub-Fund in another Sub-Fund are suspended for as long as they are held
by the Sub-Fund concerned. In addition and for as long as these Shares are held by a Sub-Fund, their value will not be
taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum
capital required by the Law.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may, at any time it deems

appropriate and to the largest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with
the provisions set forth in the sales documents of the Company, (i) create any Sub-Fund qualifying either as a feeder
UCITS or as a master UCITS, (ii) convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS Sub-Fund or (iii) change the master
UCITS of any of its feeder UCITS Sub-Funds.

The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more Sub-

Funds on a pooled basis, as described in Article 11, where it is appropriate with regard to their respective investment
sectors to do so.

In order to reduce operational and administrative charges while allowing a wider diversification of the investments,

the Board of Directors may decide that part or all of the assets of the Company will be co-managed with assets belonging
to other collective investment schemes or that part will be co-managed among themselves.

Art. 26. Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or
is a Director, associate, officer or employee of any such other company or firm.

Any Director or officer of the Company who serves as a Director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason his connection and/or relationship
with that other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
any such contract or other business.

In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction submitted

for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, that Director or officer shall make such a
conflict known to the Board of Directors and shall not consider or vote on any such transaction, and any such transaction
shall be reported to the next meeting of Shareholders.

The preceding paragraph does not apply where the decision of the Board of Directors or by the single Director relates

to current operations entered into under normal conditions.

The term "personal interest", as used above, shall not include any relationship with or interest in any matter, position

or transaction involving any entity promoting the Company or any subsidiary thereof, or any other company or entity as
may from time to time be determined by the Board of Directors at its discretion, provided that this personal interest is
not considered as a conflicting interest according to applicable laws and regulations.

Art. 27. Indemnification of the Directors. The Company shall indemnify any Director or officer, and his heirs, executors

and administrators, against expenses reasonable incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its
request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled
to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

6. Auditor

Art. 28. Auditor. The general meeting of Shareholders shall appoint an approved statutory auditor ("réviseur d'entre-

prises agréé") who shall carry out the duties prescribed by the Law and serve until its successor is elected.

7. Annual accounts

Art. 29. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January in each year and shall end on

31 December of the same year.

The accounts of the Company shall be expressed in US Dollars. Where there shall be different Sub-Funds as provided

for in Article 7 hereof, and if the accounts within such Sub-Funds are expressed in different currencies, such accounts
shall be converted into Euro and added together for the purpose of determination of the accounts of the Company.

85869

L

U X E M B O U R G

Art. 30. Distribution Policy. The Shareholders shall, upon proposal from the Directors and within the limits provided

by Luxembourg law, determine how the results of the Company shall be disposed of and other distributions shall be
effected and may from time to time declare, or authorise the Directors to declare distributions. Distributions may be
made out of investment income, capital gains or capital.

For  any  Sub-Fund  or  Class  of  Shares,  the  Directors  may  decide  to  pay  interim  dividends  in  compliance  with  the

conditions set forth by law. Distribution Shares confer in principle on their holders the right to receive dividends declared
on the portion of the net assets of the Company attributable to the relevant Class of Shares in accordance with the
provisions below. Accumulation Shares do not in principle confer on their holders the right to dividends. The portion of
the net assets of the Company attributable to accumulation Shares of the relevant Class of Shares in accordance with the
provisions below shall automatically increase the Net Asset Value of these Shares.

Dividends may further, in respect of any Class of Shares, include an allocation from an equalisation account which may

be maintained in respect of any such Class of Shares and which, in such event, will in respect of such Class of Shares, be
credited upon issue of Shares and debited upon redemption of Shares, in an amount calculated by reference to the accrued
income attributable to such Shares.

Dividends will normally be paid in the currency in which the relevant Class of Shares is expressed or, in exceptional

circumstances, in such other currency as selected by the Board of Directors and may be paid at such places and times as
may be determined by the Board of Directors. The Board of Directors may make a final determination of the rate of
exchange applicable to translate dividends into the currency of their payment.

The Board of Directors may decide that dividends be automatically reinvested for any Sub-Fund or Class of Shares

unless a Shareholder entitled to receive cash distribution elects to receive payment of such dividends. However, no
dividends will be paid if their amount is below an amount to be decided by the Board of Directors from time to time and
published in the sales documents of the Company. Such dividends will automatically be reinvested.

No distribution shall be made if as a result thereof the capital of the Company becomes less than the minimum required

by law.

Declared dividends not claimed within five years of the due date will lapse and revert to the relevant Sub-Fund or

Class. The Board of Directors has all powers and may take all measures necessary for the implement of this position. No
interest shall be paid on a dividend declared and held by the Company at the disposal of its beneficiary.

8. Dissolution and liquidation

Art. 31. Dissolution of the Company. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by

one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation cor-
responding to each Class of Shares shall be distributed by the liquidators to the holders of Shares of each Class of Shares
of each Sub-Fund in proportion of their holding of Shares in such Class of Shares of each Sub-Fund either in cash or, upon
the prior consent of the Shareholder, in kind. Any funds to which Shareholders are entitled upon the liquidation of the
Company and which are not claimed by those entitled thereto prior to the close of the liquidation process shall be
deposited for the benefit of the persons entitled thereto to the Caisse de Consignation in Luxembourg in accordance
with the Law. Amounts so deposited shall be forfeited in accordance with Luxembourg laws.

Art. 32. Termination, division and amalgamation of Sub-Funds. The Directors may decide at any moment the termi-

nation, division and/or amalgamation of any Sub-Fund. In the case of termination of a Sub-Fund, the Directors may offer
to the Shareholders of such Sub-Fund the conversion of their Class of Shares into Classes of Shares of another Sub-Fund,
under terms fixed by the Directors.

In the event that for any reason the value of the net assets in any Sub-Fund or of any Class of Shares within a Sub-

Fund has decreased to an amount determined by the Directors from time to time to be the minimum level for such Sub-
Fund or such Class of Shares to be operated in an economically efficient manner, or if a change in the economic or political
situation relating to the Sub-Fund concerned would have material adverse consequences on the investments of that Sub-
Fund, the Directors may decide to compulsorily redeem all the Shares of the relevant Classes issued in such Sub-Fund at
the Net Asset Value per Share, taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses and
calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect.

The Company shall serve a notice to the Shareholders of the relevant Class of Shares prior to the effective date of

the redemption, which will indicate the reasons for and the procedure of the redemption operations. Unless it is otherwise
decided in the interests of, or to maintain equal treatment between the Shareholders, the Shareholders of the Sub-Fund
concerned may continue to request redemption or conversion of their Shares free of charge, taking into account actual
realisation prices of investments and realisation expenses and prior to the date effective for the compulsory redemption.

Assets which may not be distributed to their owners upon the implementation of the redemption will be deposited

with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.

All redeemed Shares will be cancelled in the books of the Company.
Under the same circumstances provided for under this Article the Board of Directors may decide to reorganise a Sub-

Fund or Class by means of a division into two or more Sub-Funds or Classes.

85870

L

U X E M B O U R G

The Board of Directors may decide to consolidate a Class of any Sub-Fund. The Board of Directors may also submit

the question of the consolidation of a Class to a meeting of holders of such Class. Such meeting will resolve on the
consolidation with a simple majority of the votes cast.

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraphs, a general meeting of

Shareholders of any Sub-Fund (or Class as the case may be) may, upon proposal from the Board of Directors, (i) decide
that all Shares of such Sub-Fund shall be redeemed and the Net Asset Value of the Shares (taking into account actual
realisation prices of investments and realisation expenses) refunded to Shareholders, such Net Asset Value calculated as
of the Valuation Day at which such decision shall take effect, and/or (ii) decide upon the division of a Sub-Fund or the
division, consolidation or amalgamation of Classes of Shares in the same Sub-Fund. There shall be no quorum requirements
for such general meeting of Shareholders at which resolutions shall be adopted by simple majority of the votes cast if
such decision does not result in the liquidation of the Company. Liquidation proceeds not claimed by the Shareholders
at the close of the liquidation of a Sub-Fund will be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg. If not claimed
they shall be forfeited in accordance with Luxembourg Law.

Any merger of a Sub-Fund shall be decided by the Board of Directors unless the Board of Directors decides to submit

the decision for a merger to a meeting of Shareholders of the Sub-Fund concerned. No quorum is required for this
meeting and decisions are taken by the simple majority of the votes cast. In case of a merger of one or more Sub-Fund
(s) where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of Shareholders for which
no quorum is required and that may decide with a simple majority of votes cast. In addition, the provisions on mergers
of UCITS set forth in the Law and any implementing regulation (relating in particular to the notification to the Shareholders
concerned) shall apply.

Art. 33. Amendment of the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended from time to

time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and majority voting requirements provided by the laws of
Luxembourg.

Art. 34. General provisions. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the
"1915 Law") and the Law.

Art. 35. Transitional provisions.
1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2014.
2) The first annual general meeting shall be held in 2015.

<i>Subscription and payment

These Articles having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid-

up the following Shares:

Subscriber

Number

of Shares

Subscription

price per

Share

EuroAmerica S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

USD 100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 USD 50,000

All these Shares have been entirely paid up of by payments in cash, so that the sum of fifty thousand United States

Dollars (50,000 USD) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the

1915 Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the appearing party

as a result of its formation are estimated at approximately EUR 3.000,-.

<i>Extraordinary general meeting

The single Shareholder, representing the entire subscribed capital, has taken the following resolutions.

<i>First resolution

The following persons are appointed as Directors of the Company for a period ending with the next annual general

meeting:

1) Henry Comber Sigall, CEO, EuroAmerica S.A., professionally residing at Av. Apoquindo 3885 piso 21, Las Condes,

Santiago, Chile;

2) Luis Felipe Bosselin Morales, Managing Director, EuroAmerica S.A., professionally residing at Av. Apoquindo 3885

piso 21, Las Condes, Santiago, Chile; Av. Apoquindo 3885 piso 20, Santiago, Chile

85871

L

U X E M B O U R G

3) Sergio Rosenberg Aratangy, CEO, EuroAmerica Administradora General de Fonds S.A., professionally residing at

Av. Apoquindo 3885 piso 20, Santiago, Chile;

4) Jörg Henzler, non-executive board member, Luxembourg Investment Solutions S.A., Airport Center, 5, Heihenhaff,

L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second resolution

The registered office of the Company is fixed at 33A, Avenue J.F: Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Third resolution

The following is elected as approved statutory auditor (réviseur d’entrerpises agréé) for a period ending with the next

annual general meeting:

KPMG Audit S.à r.l., 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, this deed, including the articles of incorporation, is worded in English.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, first names, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, this original deed.

Signé: L. SERVAIS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 juin 2014. Relation: LAC/2014/27278. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2014.

Référence de publication: 2014093619/763.
(140112376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2014.

KSS Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.160.025,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 106.644.

<i>Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 1 mai 2014

En date du 1 mai 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
D'accepter la démission de:
- Madame Lizanne Guptill, en tant que gérant de classe A de la Société, avec effet au 1 mai 2014.
De nommer la personne suivante en tant que gérant de classe A de la Société:
- Monsieur Paul John Scarcello, Jr., né le 18 août 1970 dans le Michigan, Etats-Unis d'Amérique, résidant profession-

nellement à 7000 Nineteen Mile Road, Sterling Heights, MI 48314, Etats-Unis d'Amérique, avec effet au 1 mai 2014 et
pour une durée indéterminée.

Depuis le 1 mai 2014, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

<i>Gérants de classe A:

Monsieur Paul John Scarcello, Jr.
Monsieur Thomas Dono, Jr.

<i>Gérant de classe B:

Monsieur Philippe van den Avenne
L'adresse de Monsieur Philippe van den Avenne, gérant de classe B de la Société, a changé et est désormais la suivante:

Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 12 mai 2014.

Key Cayman LP

Référence de publication: 2014065912/27.
(140077116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

85872


Document Outline

Amcoll

AMP Capital Strategic Infrastructure Trust of Europe (EUR) SICAV-SIF

Anglo American Finland Holdings 1

Anglo American Finland Holdings 2

ARAM Holding S.A.

Armat Group S.A.

Avatar S.A.

Barentz Ravago Chemical Specialist S.A.

Bau Cap Sàrl

Chamelle S.A.

Clemency RCG Re SCA

Countryside Real Luxury Estate S.à r.l.

Delta Shipping &amp; Chartering S.A.

Dontas Law

EEM World S.A.

EuroAmerica AM SICAV

Financière Ervacace Holding Company S.A.

F.T.A. Satellite Communication Technologies Holding

GFA - HAIG

Guliver Demografie Sicherheit

Hahn FCP-FIS

Hydro-Get Enviromental Investment S.A.

Immobilière Saint Marcel S.A.

Impect SCSp

KSK LB Exklusiv

KSS Holdings S.à.r.l.

Larochette RCG Re SCA

LUX Global Real Estate FCP-SIF

Mac Europe S.A.

Midilux Holdings S.A.

Mokaline S.à r.l.

Montigny S.A., SPF

Plexus Investments S.à r.l.

Polyver Group

Premium Portfolio SICAV

Premium Portfolio SICAV

ProLogis European Finance XI S.àr.l.

Promotrust S.A.

Ravago Chemicals S.A.

Schengen RCG Re SCA

SecureValue E.E.I.G.

Sevchukmorneftegaz Holding SARL

Stabilus S.A.

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav

Swiss Rock (Lux) Sicav

Tudor Investments S.A.

Tulipan SCSp

Vianden RCG Re SCA

Werte &amp; Sicherheit Nr. 1

Wiltz RCG Re SCA