This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1303
21 mai 2014
SOMMAIRE
Alphabeta 3 International S.à r.l. . . . . . . . .
62515
American Golf Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
62538
Angel's Majorettes de la commune de Pé-
tange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62534
Antipodes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62525
Berlioz Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
62526
BRS Luxco Outdoor Sports Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62526
Bufab S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62527
Bulgarian Acquisition Company VI S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62538
Cartrust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62533
CGM Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62533
Charlottenburg Capital International S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62526
CHEERLEADERS ANGEL'S Club . . . . . . .
62534
Ecouter pour Mieux s'Entendre . . . . . . . . .
62539
Elix Holdings Management S.à r.l. . . . . . . .
62514
ESCO Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62498
ESCO Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62509
Euro-Druck S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62510
Floresan S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62510
Franklin Templeton International Services
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62511
Funding Loop (GP) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
62498
Gallileo Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
62544
Hunac (No. 1) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62509
I C T C S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62509
I Like Events S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62544
Image-In-Nation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62511
Inaer Bond MEP GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
62522
Intershipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62533
kolabutti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62534
Les Editions du Lion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
62514
Marthilor S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62512
Maxam Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
62514
NCR International 2 SNC . . . . . . . . . . . . . . .
62523
Nelson Luxembourg Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62529
Ollean Etudes Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
62525
Radiant Systems International 2 SNC . . . .
62523
Schrëtt fir Schrëtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62544
Signature Holding S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
62542
Société Immobilière de l'Ill S.A. . . . . . . . . .
62543
Spotify Technology S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
62539
SRDV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62543
Trinderley Investments S.A. . . . . . . . . . . . .
62530
XLS Air S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62535
62497
L
U X E M B O U R G
ESCO Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 37.091.
Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014041434/12.
(140048045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Funding Loop (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 185.339.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of February.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Funding Loop Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 180.880,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Berlin, Germany, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 27 January 2013.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Funding Loop (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any
Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
62498
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
62499
L
U X E M B O U R G
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
62500
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers.
In his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
of managers present or represented at any such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
62501
L
U X E M B O U R G
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
Transitional provisions
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2014.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Funding Loop Holding S.à r.l.,
aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
62502
L
U X E M B O U R G
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:
- Mr Alexander Kudlich, born in Bonn, Germany, on 05 February 1980, professionally residing at Johannisstrasse 20,
D-10117 Berlin; and
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035
Strassen, Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausendvierzehn, am siebten Februar.
Vor uns, Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Funding Loop Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 180.880,
hier vertreten durch Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 27. Januar 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland, und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Funding Loop (GP) S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen
und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.
62503
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für
eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
62504
L
U X E M B O U R G
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst
werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die
„Gesellschafterversammlung“in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-
ter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschaf-
terversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden,
wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen
finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt
werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentli-
chung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger
Geschäftsführer“nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüng-
liche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
62505
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich aufgrund der Einberufung durch einen der Geschäftsführer. Die
Sitzungen des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesell-
schaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Datum zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevoll-
mächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen oder
mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der
Gesellschaft abgehalten erachtet.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustim-
mung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlus-
ses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer
(falls vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Pro-
tokollführer oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Ge-
richtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäfts-
führer (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterver-
sammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und
Geschäftsführer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A
und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter).
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
62506
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unter-
schrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet; sofern die Gesellschafterver-
sammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und
Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1) Ge-
schäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) oder (ii) durch
die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis
durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer / Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer
Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
62507
L
U X E M B O U R G
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2014.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile wurden ordnungsgemäß von Funding Loop Holding S.à r.l., vorbenannt, zum
Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.500,-geschätzt.
<i>Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Alexander Kudlich, geboren am 5. Februar 1980 in Bonn, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20,
D-10117 Berlin; und
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Parteien, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche dem Notar mit
Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat die Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unter-
zeichnet.
Gezeichnet: A. VAN DER WIELEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 février 2014. Relation: LAC/2014/7273. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 13. März 2014.
Référence de publication: 2014040090/582.
(140046424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.
62508
L
U X E M B O U R G
I C T C S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 53.858.
Par décision du Conseil d'Administration tenu en date du 14 mars 2014, Monsieur Raphaël EBER, domicilié profes-
sionnellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement
de Madame Marie Laurence THILL, démissionnaire.
Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2018.
Luxembourg, le 21 mars 2014.
<i>Pour: I C T C S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2014041497/17.
(140047890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Hunac (No. 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R.C.S. Luxembourg B 157.396.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 06 mars 2014i>
L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Mohaymin Monem comme gérant A de la société à partir du
06 Mars 2014, avec une adresse professionnelle au State General Reserve Fund, Ministry of Finance, P.O. Box 188, P.C.
100, Waljat Street, Way N°9105, Muscat, Sultanat d'Oman.
Et nomme comme gérant A:
Monsieur Saif Al Abri, Portfolio Accountant Supervisor, né le 06 décembre 1988 à Matrah Sultanat d'Oman, avec une
adresse professionnelle au State General Reserve Fund, Ministry of Finance, P.O. Box 188, P.C. 100, Waljat Street, Way
N°9105, Muscat, Sultanat d'Oman.
Luxembourg, le 14 Mars 2014.
Signatures
<i>L'agent domicilitairei>
Référence de publication: 2014041486/18.
(140048239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
ESCO Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 37.091.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2014i>
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey
à L-2163 Luxembourg, représentée par son représentant permanent Monsieur Peter Van Opstal et de Lux Business
Management Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, représentée par son représentant
permanent Monsieur Christian Knauff, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant
son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2013.
Luxembourg, le 21 mars 2014.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014041435/19.
(140048046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62509
L
U X E M B O U R G
Floresan S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 173.314.
Constituée suivant acte reçu par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à L-Luxembourg en date du 29 novembre
2012, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n°155 du 19 janvier 2013.
Il est porté à la connaissance des tiers que la société ANELOX FINANCE LIMITED, domicilié 1, Poseidonos, Ledra
Business Centre, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus, détentrice de 100 parts sociales de la société FLORESAN S.à r.l., avec
siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a transféré ses parts sociales:
- à la société OSTASHKOV INDUSTRIAL LTD, domiciliée 2, Church Street, Clarendon House, Hamilton HM 11,
Bermudes.
En conséquence, cette dernière détient seule toutes les parts sociales composant le capital social de la société FLO-
RESAN S.à r.l.
Luxembourg, le 21 mars 2014.
<i>Pour la société FLORESAN S.à r.l.
i>Fiduciaire Fernand Faber
Référence de publication: 2014041442/19.
(140048353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Euro-Druck S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 7, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 163.115.
Im Jahre zwei tausend vierzehn.
Den vierzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg),
IST ERSCHIENEN:
Herr Sven STREIT, Kaufmann, wohnhaft in L-6673 Mertert, 8, Cité Pierre Frieden.
Welcher Komparent dem unterzeichneten Notar erklärte, dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung EURODRUCK S.à r.l. ist, mit Sitz in L-6440 Echternach, 56, rue de la Gare, eingetragen beim Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 163.115 (NIN 2011 2432 419).
Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 23.
August 2011, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2501 vom 17. Oktober 2011.
Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert
(100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125.-), alle zugeteilt Herrn Sven STREIT, vorgenannt.
Alsdann ersuchte der Komparent den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. April 2014 von Echternach nach
Wasserbillig zu verlegen und demgemäss den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern wie folgt:
„ Art. 3. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.“.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6630 Wasserbillig, 7, Grand-
Rue.
WORÜBER URKUNDE Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: S. STREIT, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 17 mars 2014. Relation: ECH/2014/535. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.
Echternach, den 21. März 2014.
Référence de publication: 2014041439/35.
(140047746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62510
L
U X E M B O U R G
Franklin Templeton International Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 8A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 36.979.
EXTRAIT
Les membres du Conseil de la Société ont pris acte de la démission de M. Wylie Tollette en sa qualité de gérant de la
Société avec effet au 14 mars 2014.
Par conséquent, tout pouvoir confié à M. Wylie Tollette en relation avec la gérance de la Société ainsi que la repré-
sentation de la Société en ce qui concerne cette gérance est retiré avec effet au 14 mars 2014.
En conséquence, le Conseil de la Société se compose actuellement de:
- M. Paul J. Brady, gérant, résidant 1-11 John Adam Street, The Adelphi Building, WC2N 6HT, London, Royaume-Uni;
- Mme Kathleen M. Davidson, gérant, résidant 5 Morrison Street, EH3 8BH, Edinburgh, Royaume-Uni;
- M. David Smart gérant, résidant 1-11 John Adam Street, The Adelphi Building, WC2N 6HT, London, Royaume-Uni;
- M. Alok Sethi, gérant, résidant 100 Fountain Parkway, Building 160, 2
nd
Floor, FL 33716 Saint Petersburg, Etats-Unis
d'Amérique;
- Mme Gwen Shaneyfelt, gérant, résidant One Franklin Parkway, CA 94403-1906, San Mateo, Etats-Unis d'Amérique
- M. Harold C. Nash, gérant, résidant 8A, rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg;
- M. William Lockwood, gérant, résidant 8A, rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg;
- Mme Denise Voss, gérant, résidant 8A, rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg;
Le Conseil a également pris connaissance d'une inexactitude dans l'adresse de M. Alok Sethi, gérant de la Société.
L'adresse professionnelle de M. Alok Sethi se trouve désormais comme suit:
100 Fountain Parkway, Building 160, 2
nd
Floor, FL 33716 Saint Petersburg, Etats-Unis d'Amérique;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
Référence de publication: 2014041444/27.
(140048294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Image-In-Nation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 180.526.
<i>Extrait sincère et conforme des résolutions de l'associé unique du 11 mars 2014.i>
Il résulte des résolutions que:
- La société a été transférée du 4, Rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg au 11-13,
Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg avec effet au 1
er
janvier 2014;
- M. Eddy Dôme a démissionné de son poste de commissaire aux comptes de la Société avec effet au 1
er
janvier 2014;
- La société EUROPEAN TRUST SERVICES (Luxembourg) S.à r.l., société de droit luxembourgeois, avec adresse au
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 33065 a été nommée en tant que commissaire aux comptes
de la Société avec effet au 1
er
janvier 2014 pour une période allant jusqu'à l'approbation des comptes de l'année 2017;
- M. Matthijs Bogers, né le 24 novembre 1966 à Amsterdam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 11-13, Boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, grand-duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 1
er
janvier 2014 pour une période allant jusqu'à l'approbation des comptes de l'année 2017;
- M. Eddy Dôme, né le 16 août 1965 à Waremme, Belgique, avec adresse professionnelle au 11-13, Boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, grand-duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 1
er
janvier 2014 pour une période allant jusqu'à l'approbation des comptes de l'année 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2014.
Image-In-Nation S.A.
Représenté par M. Eddy Dôme
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2014041500/27.
(140047973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62511
L
U X E M B O U R G
Marthilor S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.216.500,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 159.258.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth of January.
before us Me Edouard Delosch, notary, residing at Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
1) Marthilux S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
having a corporate capital of EUR 16,899,300.-, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 161.942
hereby represented by Ms Jennifer Ferrand, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
17 January 2014.
2) Thycarlux S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
having a corporate capital of EUR 14,280.-, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B-161.576
hereby represented by Ms Jennifer Ferrand, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
17 January 2014.
(the “Shareholders”).
The Shareholders are the shareholders of Marthilor S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a corporate capital of two million two hundred sixteen thousand five hundred
euro (EUR 2,216,500.-), incorporated on 18 February 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 25 May 2011 number 1107, and registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 159.258 (the “Company”). The articles of association of
the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary of 14 February 2012,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 17 April 2012 number 988.
The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To acknowledge the resignation of Mr Ian Kent as statutory manager of the Company with effect as of 29 January
2014.
2 To appoint Mrs Jennifer Ferrand as new statutory manager of the Company with effect as of 29 January 2014 and
for an unlimited period.
3 To amend article 9 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the above resolutions.
The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders acknowledged the resignation of Mr Ian Kent as statutory manager of the Company with effect as
of 29 January 2014.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to appoint Mrs Jennifer Ferrand as new statutory manager of the Company with effect as
of 29 January 2014 and for an unlimited period.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolved to amend the first and second paragraphs of article 9 of the articles of incorporation of
the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraphs will from now on read as follows:
“ Art. 9. Managers. The Company shall be managed by (i) Mirko Dietz, (ii) Stephan Illenberger, (iii) Jennifer Ferrand,
(iv) Thierry Denoyel and (v) Simon Barnes.
Mirko Dietz, Stephan Illenberger, Jennifer Ferrand, Thierry Denoyel and Simon Barnes are together referred herei-
nafter as the “Managers” or the “Board of Managers.”
62512
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand one hundred euro (EUR 1000.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf janvier,
Par-devant Nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:
1) Marthilux S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de
EUR 16.899.300,-, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
161.942;
représenté aux fins des présentes par Madame Jennifer Ferrand, employé privée, demeurant à Luxembourg, aux termes
d'une procuration donnée le 17 janvier 2014.
2) Thycarlux S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de
EUR 14.280,-, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
161.576;
représenté aux fins des présentes par Madame Jennifer Ferrand, employé privée, demeurant à Luxembourg, aux termes
d'une procuration donnée le 17 janvier 2014.
(les «Associés»)
Les Associés sont les associés de Marthilor S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, ayant un capital social de deux millions deux cent seize mille cinq cents euros (EUR 2.216.500,-), constituée
suivant acte du notaire soussigné en date du 18 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
du 25 mai 2011 sous le numéro 1107, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 159.258 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné
en date du 14 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 17 avril 2012 sous le numéro
988.
Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissants avoir été dûments et pleinement informés des
décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Démission de M. Ian Kent en tant que gérant statutaire de la Société avec effet au 29 janvier 2014.
2 Nomination de Mme. Jennifer Ferrand en tant que nouveau gérant statutaire de la Société avec effet au 29 janvier
2014 et pour une durée illimitée.
3 Modification de l'article 9 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus.
Les Associés ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés ont constaté la démission de M. Iant Kent en tant que gérant statutaire de la Société avec effet au 29
janvier 2014.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés ont décidé de nommer Mme. Jennifer Ferrand en tant que nouveau gérant statutaire de la Société avec
effet au 29 janvier 2014 et pour une durée illimitée.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés ont décidé de modifier les alinéas premier et deuxième de l'article 9 des statuts de la Société afin de
refléter les résolutions ci-dessus.
Lesdits alinéas seront dorénavant rédigés comme suit:
62513
L
U X E M B O U R G
" Art. 9. Gestion. La Société sera gérée par (i) Mirko Dietz, (ii) Stephan Illenberger, (iii) Jennifer Ferrand, (iv) Thierry
Denoyel et (v) Simon Barnes.
Mirko Dietz, Stephan Illenberger, Jennifer Ferrand, Thierry Denoyel et Simon Barnes ensemble sont nommés ci-après
les “Gérants” ou le “Conseil de Gérance”.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont
estimés à mille cent euros (EUR 1.100.-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: J. FERRAND, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 30 janvier 2014. Relation: DIE/2014/1385. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé) pd: RECKEN.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 17 mars 2014.
Référence de publication: 2014039570/125.
(140045133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.
Les Editions du Lion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Commerciale «Le 2000», rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 86.923.
Les Comptes Annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jacques Deltenre
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014041556/11.
(140047900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Maxam Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 159.757.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014041578/10.
(140047857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Elix Holdings Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.353.
Par résolutions signées en date du 13 mars 2014, l'associé unique a décidé de nommer Laura Spitoni, avec adresse
professionnelle au 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2014.
Référence de publication: 2014041415/13.
(140047842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62514
L
U X E M B O U R G
Alphabeta 3 International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 185.359.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the fourth day of March
Before Maître Martine Schaeffer, Civil Law Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg the under-
signed acting in replacement of Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, who will be keeping the original of this deed,
THERE APPEARED:
1. IK VII N°1 Limited Partnership
2. IK VII N°2 Limited Partnership
3. IK VII N°3 Limited Partnership
4. IK VII N°4 Limited Partnership
governed under the Law of England and Wales, all acting ultimately through IK VII Limited, a company incorporated
and existing under the Laws of Jersey, with registered office at Charles Bisson House 3
rd
Floor, 30-32 New Street, St.
Helier, Jersey, Channel Islands JE2 3RA,
The founders are here represented by Mrs. Catherine Dessoy, “avocat à la Cour”, residing at L-1461 Luxembourg,
31, rue d’Eich by virtue of a proxy given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a Société à responsabilité limitée (“the
Company”) which she declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a Société à responsabilité limitée, limited liability company, governed by the present
articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of 10 August 1915 on commercial companies
on "Sociétés à responsabilité limitée", as amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following
shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.
Art. 2. The Company’s name is "Alphabeta 3 International S.à r.l.".
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licenses, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, including authorising its subsidiaries to do
the same; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
62515
L
U X E M B O U R G
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8.
8.1 The Company's capital is set at EUR 12,500.-(twelve thousand and five hundred Euros), represented by 12,500
(twelve thousand and five hundred) shares of EUR 1.-(one Euro) each.
8.2. The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the sole shareholder or, as the case may
be, by decision of the shareholders’ meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the articles of
association.
8.3. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is further authorized and empowered to
issue convertible bonds or not, or assimilated instruments or bonds with subscription rights or to issue any debt financial
instruments convertible or not, into shares under the conditions to be set by the manager or, in case of plurality of
managers, the board of managers, provided however that, in case of convertible bonds or assimilated instruments, these
bonds or instruments are not be issued to the public and that upon conversion, article 189 of the law of 10 August 1915
on commercial companies, as amended, will be complied with.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of the
corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers either shareholders or not, appointed by the shareholders
with or without limitation of their period of office.
The manager(s) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority
of votes.
The powers and the remuneration of any managers possibly appointed to or in place of the first managers will be
determined in the act of nomination.
In the case of one sole manager, the sole signature of this manager shall bind the Company.
In case of plurality of managers, the Company will be bound by the joint-signature of any two managers.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, transmitted either by ordinary
mail, electronic mail, telefax, cable, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may represent more than
one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Meetings held by these means will
be deemed held at the registered office.
62516
L
U X E M B O U R G
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
Circular resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all of them in
person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall
have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings, duly convened. The date of such circular resolutions
shall be the date of the last signature
Shareholders decisions
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five (25).
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopy.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of
shareholders representing the three quarters of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of 10 August 1915 on Sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.
Art. 17. Each year, as of 31 December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of
the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary
of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Interim dividend
Art. 20. Notwithstanding the provisions of the article twenty, the general meeting of partners of the Company, by the
majority vote determined by the Law for payment of dividend, upon proposal of the board of managers or the sole
manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the
basis of a recent interim statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager itself (as the case
may be), and showing that sufficient reserves are available for distribution, it being understood that the amount to be
distributed may not exceed realized profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts
have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses
carried forward and any sums to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 21. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
62517
L
U X E M B O U R G
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 22. The laws here above mentioned in article 1
st
shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on 31 December 2014.
<i>Subscription / Paymenti>
Thereupon IK VII Limited, prenamed, acting on the above capacity, represented by Mrs. Catherine Dessoy by virtue
of the aforementioned proxy;
declared to subscribe in the name and on behalf of IK VII N° 1 to 4 Limited Partnership to the 12,500 (twelve thousand
five hundred) shares which will be allocated as follows, and to have them fully paid up by payment in cash:
Number
of shares
Shares
Nominal
(EUR)
IK VII N°1 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,789
3,789.-
IK VII N°2 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,768
2,768.-
IK VII N°3 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,157
3,157.-
IK VII N°4 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,786
2,786.-
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500 12,500.-
so that as from now on, the company has at its free and entire disposal the amount of twelve thousand and five hundred
Euros (EUR 12,500.-) as was certified to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand two hundred Euros (EUR
1,200.-).
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers for an undetermined duration of the Company:
- Mr. Andrew Townend, with professional address at Brettenham House, 5, Lancaster Place, London WC2E 7EN,
United Kingdom, born on the 31 December 1971 in Mirfield, United Kingdom;
- Mr. Shaun Johnston, with professional address at 30-32 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, born
on the 14 June 1965 in Birmingham, United Kingdom;
- Mrs. Sandrine Anton, with professional address at 35, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, born on the 21 June 1972
in Algrange, France;
- Mrs. Catherine Dessoy, with professional address at 31 rue d’Eich L-1461 Luxembourg, born on the 14 December
1963 in Namur, Belgium.
The Company shall be bound in accordance with article eleven of the By-Laws.
2) The Company shall have its registered office at L-2520 Luxembourg, 35, Allée Scheffer.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the undersigned notary has set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of
this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le quatre mars
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg soussignée, agissant en remplacement de
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, empêché, lequel aura la garde des présentes minutes,
ONT COMPARU:
1. IK VII N°1 Limited Partnership
62518
L
U X E M B O U R G
2. IK VII N°2 Limited Partnership
3. IK VII N°3 Limited Partnership
4. IK VII N°4 Limited Partnership
régis par le droit anglais, agissant tous in fine à travers IK VII Limited, une société constituée sous le droit de Jersey,
ayant son siège social à Charles Bisson House, 3
rd
Floor, 30-32 New Street, St. Helier, Jersey Channel Islands JE2 3RA.
Fondateurs ici représentés par Maître Catherine Dessoy, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue
d’Eich, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée (la "Société")
qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée.
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera "Alphabeta 3 International S.à r.l.".
Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie de parts sociales ou de titres
de toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales
ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou auxdites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier
direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière que
ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée, incluant des autorisations à ses filiales pour faire la
même chose; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités pré-décrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature
à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8.
8.1 Le capital social est fixé à EUR 12.500,-(douze mille cinq cents Euros), représenté par 12.500 (douze mille cinq
cents) parts sociales de EUR 1,-(un Euro) chacune.
62519
L
U X E M B O U R G
8.2 Le capital souscrit peut être modifié sur décision de l’associé unique ou, comme cela peut être le cas, par décision
de l’assemblée des associés statuant de la même manière que pour une modification des statuts.
8.3 Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance seront de plus autorisés et habilités à émettre
des obligations convertibles ou non, ou des instruments assimilés ou des obligations avec droits de souscription ou
d’émettre tous instruments financiers convertibles ou non, en parts sociales à des conditions établies par le gérant ou,
en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance, pour autant cependant que ces obligations ou instruments ne
soient pas émis au public et que, dans le cas d'obligations convertibles ou instruments assimilés, au moment de la con-
version, l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié, soit respecté.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l’agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans
limitation de leur mandat.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la société sera valablement engagée à l’égard des tiers par la seule signature d’un gérant
unique.
En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l’exécution de son mandat.
La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous
frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire/associée ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel
et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres
droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit, transmis par courrier
simple, courrier électronique, téléfax, câble, télégramme ou télex, un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut
représenter plus d’un de ses collègues.
Chaque gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou
par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes y prenant part, d’entendre chacune d’entres
elles. La participation aux réunions tenues par ces moyens de communication est équivalente à la participation en personne
à ces réunions. Les réunions tenues par ces moyens seront considérées comme tenues au siège social.
Le conseil de gérance peut valablement délibérer ou agir qu’autant qu’au moins une majorité des gérants est présente
ou représentée aux réunions du conseil de gérance. Les décisions doivent être prises à la majorité des votes des gérants
présents ou représentés.
Les résolutions circulaires du conseil de gérance peuvent être valablement prises si elles sont approuvées par écrit et
signées par tous les gérants en personne. Une telle approbation peut être exprimée sur un seul ou plusieurs documents
envoyés par fax ou par e-mail. Ces résolutions auront le même effet que les résolutions votées à un conseil de gérance
dûment convoqué. La date de telles résolutions circulaires sera celle de la dernière signature.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25
(vingt-cinq).
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément
formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
62520
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excédent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de
la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dividendes intérimaires
Art. 20. Nonobstant les dispositions de l’article 20, l’assemblée générale des associés de la Société, par le vote majo-
ritaire déterminé par la loi sur le paiement des dividendes, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (le
cas échéant) peut décider de payer des dividendes intérimaires avant la fin de l’exercice social en cours, sur base d'un
récent état intérimaire des comptes préparé par e conseil de gérance ou le gérant unique lui-même (le cas échéant), et
laissant apparaître que les fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer
ne saurait excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social pour lesquels les comptes annuels ont été
approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles et diminué
des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le
capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à
sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 22. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application
partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.
62521
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription / Libérationi>
Le capital a été souscrit de la manière suivante:
IK VII Limited, pré-nommée, agissant en sa qualité référencée ci-dessus, représentée par Maître Catherine Dessoy en
vertu de la procuration ci-dessus référencée,
a déclaré souscrire au nom et pour le compte de IK VII Limited Partnership N° 1 à 4, 12.500 (douze mille cinq cents)
parts sociales, qui sont libérées intégralement en numéraire et réparties comme suit:
Nombre
de parts
Capital
souscrit
(EUR)
IK VII N°1 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,789
3,789.-
IK VII N°2 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,768
2,768.-
IK VII N°3 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,157
3,157.-
IK VII N°4 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,786
2,786.-
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500 12.500,-
de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq
cents Euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.200,-(mille deux cents Euros).
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée
- Monsieur Andrew Townend, demeurant professionnellement Brettenham House, 5, Lancaster Place, London WC2E
7EN, Royaume Uni, né le 31décembre 1971 à Mirfield, Royaume Uni;
- Monsieur Shaun Johnston, avec adresse professionnelle au 30-32 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Iles Anglo
Normandes, né le 14 juin 1965 à Birmingham, Royaume Uni;
- Madame Sandrine Anton, avec adresse professionnelle au 35, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, née le 21 juin 1972
à Algrange, France;
- Madame Catherine Dessoy, avec adresse professionnelle au 31 rue d’Eich L-1461 Luxembourg, née le 14 décembre
1963 à Namur, Belgique.
La Société se trouvera engagée conformément à l’article 11 des statuts.
2) Le siège social de la Société est établi à L-2520 Luxembourg, 35, Allée Scheffer.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante
les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: C. DESSOY, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 10 mars 2014. Relation: LAC/2014/11186. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Référence de publication: 2014039898/419.
(140046687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.
Inaer Bond MEP GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 160.500.
Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014041502/10.
(140048008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62522
L
U X E M B O U R G
NCR International 2 SNC, Société en nom collectif,
(anc. Radiant Systems International 2 SNC).
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 135.071.
In the year two thousand and fourteen, on the tenth of March.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
1.- NCR International SNC, formerly known as Radiant Systems International SNC, a general corporate partnership
(société en nom collectif) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 135.072; and
2.- NCR International, Inc., a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware,
United States of America, having its principal address at 3097 Satellite Boulevard., Duluth, Georgia 30096, United States
of America, registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations, under the control number 0900968
(“NCR International, Inc.”), as universal successor in title of Radiant Systems International, Inc., a company incorporated
under the laws of the State of Georgia (United States of America), with registered office at 3925, Brookside Parkway,
Alpharetta, Georgia 30022-4429, United States of America, and registered with the Georgia State Secretary under number
K 801119 ("Radiant Systems International Inc."), which merged into NCR International, Inc. on 31 December 2013 at
11:10 p.m. Eastern Standard Time in accordance with Delaware and Georgia law, with NCR International, Inc. succeeding
to all of the assets, property and liabilities of Radiant Systems International, Inc., including without limitation, all of the
partnership interests of the Company previously held by Radiant Systems International Inc. as a result of said merger;
here represented by Mr Gianpiero SADDI, notary's clerk, having her professional address at 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of powers of attorney given under private seal.
The said powers of attorney, initialed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain
annexed to this deed for registration purposes.
Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the partners (the "Partners") holding all the issued partnership interests representing the
entire capital of Radiant Systems International 2 SNC, a general corporate partnership (société en nom collectif) incor-
porated and existing under Luxembourg laws, having its central administration in the Grand Duchy of Luxembourg and
its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 135071, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, dated 18 December 2007,
and whose articles of association have last been amended by a deed of the undersigned notary dated 20 March 2013 (the
"Partnership").
II. The Partnership's share capital is set at seventeen thousand five hundred euro (EUR 17,500.-) divided into seventeen
thousand five hundred (17,500) partnership interests with no par value, fully paid-up.
III. The appearing parties then adopted the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Partners resolved to change the name of the Partnership.
The Partnership shall henceforth bear the name of "NCR International 2 SNC".
<i>Second resolutioni>
The Partners resolved to amend the Partnership's articles of association to reflect the above resolution.
Consequently, Article 2 of the Partnership's articles of association is amended to read as follows:
" Art. 2. Name of the Partnership. The Partnership's name is "NCR International 2 SNC"."
<i>Third resolutioni>
For the sake of good order, the Partners noted that following the merger of Radiant Systems, Inc. into NCR Corpo-
ration, the latter became the universal successor in title of the first and replaced it as a partner of the Partnership and
that said substitution was formally approved by the Partners, by way resolutions adopted under private deed.
The Partners further resolved to confirm that following the merger mentioned above, NCR Corporation succeeded
to Radiant Systems, Inc. as manager of the Partnership and to approve said change, with effect as of the effective date of
said merger.
The partners further noted that following the merger of Radiant Systems International, Inc. into NCR International,
Inc. the name of Radiant Systems International SNC, the other partner and manager of the Company, was changed into
NCR International SNC.
62523
L
U X E M B O U R G
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Partnership as a
result of these resolutions are estimated at EUR 1200.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, this deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties it is stated
that in case of discrepancy between the English and the French versions, the English version will be prevailing.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy-holder signed this deed,
together with the notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix mars.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1.- NCR International SNC, anciennement dénommée Radiant Systems International SNC, une société en nom collectif
de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Lu-
xembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135072, et
2.- NCR International, Inc., une société constituée selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, dont
le siège social est sis au 3097 Satellite Boulevard, Duluth, Georgie 30096, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du
Secrétaire de l'Etat de Delaware sous le numéro 0900968 (“NCR International, Inc.”), intervenant en qualité de successeur
universel de Radiant Systems International, Inc., une société constituée selon le droit de l'Etat de Georgie, Etats-Unis
d'Amérique, dont le siège social est sis au 3925, Brookside Parkway, Alpharetta, Géorgie 30022-4429, Etats-Unis d'Amé-
rique et enregistrée auprès du Secrétaire de l'Etat de Géorgie sous le numéro K 801119 ("Radiant Systems International
Inc."), qui a été absorbée par NCR International, Inc. dans le cadre d'une fusion réalisée avec effet au 31 décembre 2013
à 11:10 p.m. Eastern Standard Time, conformément au droit de l'Etat de Géorgie et au droit de l'Etat de Delaware,
l'ensemble de l'actif, des obligations et du passif de Radiant Systems International, Inc. étant automatiquement transféré
à NCR International, Inc., en ce compris les parts d'intérêt de la Société détenues précédemment par Radiant Systems
International, Inc. par l'effet de cette fusion;
ici représentées par Mr Gianpiero SADDI, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être enregistrées avec elle.
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
de ce qui suit:
I. Les comparantes sont les associés (les "Associés") détenant toutes les parts d'intérêt représentant la totalité du
capital de Radiant Systems International 2 SNC, une société en nom collectif, ayant son administration centrale au Grand-
Duché de Luxembourg et dont le siège social est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, enregistrée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135071, constituée par un acte de Maître Henri
Hellinckx du 18 décembre 2007 et dont les statuts ont été modifiés dernièrement par un acte du notaire instrumentant
daté du 20 mars 2013 (la "Société").
II. Le capital de la Société s'élève à dix-sept mille cinq cents euros (17.500,- EUR), divisé en dix-sept mille cinq cents
(17.500) parts d'intérêts sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
III. Les comparantes ont ensuite adopté, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de modifier la dénomination de la Société.
La Société sera désormais dénommée "NCR International 2 SNC".
<i>Seconde résolutioni>
Suite aux résolutions adoptées ci-dessus, les Associés décident de modifier les statuts de la Société afin de de les
mettre en concordance avec les résolutions ci-dessus.
Par conséquent, l'article 2 des statuts de la Société est modifié pour se lire comme suit:
" Art. 2. Raison Sociale. La raison sociale de la Société est "NCR International 2 SNC"."
62524
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
A toutes fins utiles, les Associés notent que par suite de l'absorption de Radiant Systems, Inc. par NCR Corporation,.
cette dernière est a repris l’universalité du patrimoine de la première et a remplacé Radiant Systems, Inc. en qualité
d'associé de la Société et que cette substitution a été formellement approuvée par les Associés, par résolutions écrites
adoptées sous seing privé.
Les Associés décident de confirmer que par suite de la fusion dont question ci-avant, NCR Corporation a succédé à
Radiant Systems Inc. en qualité de gérant de la Société, avec effet à compter de la date des fusions en question.
Les Associés prennent également acte du fait que par suite de l’absorption de Radiant Systems International, Inc. par
NCR International, Inc., la dénomination de Radiant Systems International SNC, l’autre associé et gérant de la Société, a
été changée en NCR International SNC.
<i>Fraisi>
Les comparantes ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes résolutions à environ EUR 1200.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes
l’ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et de préciser qu'en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, le mandataire a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 mars 2014. Relation: LAC/2014/11828. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 19 mars 2014.
Référence de publication: 2014040325/135.
(140046151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.
Antipodes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 40.744.
Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2014041297/10.
(140048286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Ollean Etudes Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, rue de Turi.
R.C.S. Luxembourg B 88.582.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’HUART, alors notaire de résidence à Pétange, en
date du 11 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1462 du 09 octobre 2002 et dont les statuts ont été modifiés
suivant actes reçus par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette:
- en date du 24 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1230 du 21 novembre 2003
- en date du 11 juin 2004, publié au Mémorial C numéro 818 du 10 août 2004
- en date du 28 juillet 2004, publié au Mémorial C numéro 1014 du 12 octobre 2004
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014041647/15.
(140047799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62525
L
U X E M B O U R G
Berlioz Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 68.608.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique en date du 24 février 2014i>
L'actionnaire unique de la Société a décidé de:
- Nommer, avec effet au 1
er
janvier 2013, la société «FIDEWA- CLAR S.A.», 2 rue du Château d'Eau, L-3364 Leude-
lange, Luxembourg, au mandat de commissaire aux comptes, en remplacement de la société EURAUDIT S.à r.l., jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.
Pour extrait
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2014041322/14.
(140047708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Charlottenburg Capital International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 155.180.
- L'adresse de State Street Trustees (Jersey) Limited, associé unique de la Société, est désormais au Lime Grove House
Green Street St Helier Jersey JE1 2ST.
- Monsieur Ganash Lokanathen a démissionné de ses fonctions en tant que gérant de la Société avec effet au 1
er
mars
2013.
Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:
- M. Simon Barnes, gérant
- M. Jens Hoellermann, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2014041339/17.
(140048257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
BRS Luxco Outdoor Sports Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 200.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 178.984.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 19 mars 2014i>
1. Monsieur Vincent REGNAULT DE BOUTTEMONT a démissionné de son mandat de gérant de la catégorie B.
2. Madame Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat de gérante de la catégorie B.
3. Monsieur Tamas MARK, administrateur de sociétés, né à Budapest (Hongrie), le 8 juin 1981, demeurant profes-
sionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de la catégorie B pour une
durée indéterminée, avec effet au 1
er
mars 2014.
4. Madame Ingrid CERNICCHI, administrateur de sociétés, née à Metz (France), le 18 mai 1983, demeurant profes-
sionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérante de la catégorie B pour une
durée indéterminée, avec effet au 1
er
mars 2014.
5. Le siège social a été transféré du L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte au L-2453 Lu-
xembourg, 6, rue Eugène Ruppert avec effet au 1
er
mars 2014.
Luxembourg, le 19 mars 2014.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour BRS Luxco Outdoor Sports Holdings S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014041330/23.
(140047652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62526
L
U X E M B O U R G
Bufab S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 112.721.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh of February.
Before the undersigned Maître Marc Loesch, notary, residing at Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Bufab S.à r.l., a limited liability company, having its registered
office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR
32,500.-, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 112.721 and incor-
porated pursuant to a notarial deed dated 24 October 2005 published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations (the "Mémorial C") under number 517 dated 10 March 2006.
The Articles have been amended for the last time by notarial deed dated 16 July 2006 published in the Mémorial C,
number 1658 of 1 September 2006 (the "Company").
The meeting is opened at 6.25 p.m. by Mrs Monica Morsch, private employee, residing professionally in Luxembourg-
Findel, in the chair,
who appoints as secretary Mrs Laura Comino Suarez, private employee, residing professionally in Luxembourg-Findel.
The meeting elects as scrutineer Mrs Rebecca Ballmann, private employee, residing professionally in Luxembourg-
Findel.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholder present or represented and the number and class of shares held by him are shown on an attendance
list which is signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said
attendance list as well as the proxy ne varietur will be registered with this deed.
II. It appears from the attendance list, that the 250 Ordinary Shares and 400 Preferred Shares, representing the entirety
of the statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly. The sole shareholder
declares having been informed on the agenda of the meeting on beforehand and waived all convening requirements and
formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of
the meeting.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Approval of the redemption of all Class A Preferred Shares at a Cancellation Value per Share as determined by the
Board pursuant to the articles of the Company so as to proceed to the liquidation of an entire class of shares of the
Company, cancellation of 100 Class A Preferred Shares and consequential reduction of the issued share capital of the
Company.
2. Delegation of power.
3. Consequential amendment of article ten of the articles of association of the Company so as to delete all references
to Class A shares and to provide for the new issued share capital amount of the Company.
3. Miscellaneous.
After approval of the foregoing, the sole shareholder decides what follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder approved the repurchase by the Company of all Class A Preferred shares.
The sole shareholder thus resolved to cancel the one hundred (100) Class A Preferred shares and to consequentially
reduce the issued share capital of the Company by an amount of five thousand euro (EUR 5,000) so that the issued share
capital is consequentially to the present reduction set at twenty-seven thousand five hundred euro (EUR 27,500).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to confer all powers to any member of the board of managers in order to implement
the necessary bookkeeping amendments, to cancel the redeemed shares and to organize the payment of the redemption
price to the shareholder of the Company. In particular, the board of managers shall determine the portion of the re-
demption price in excess of the nominal value of the redeemed shares and the way to fund it.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend article 8 of the Articles of asso-
ciation of the Company so as to delete all references to Class A shares. Article 10 now shall be read as follows:
62527
L
U X E M B O U R G
" Art. 8. The Company's capital is set at twenty-seven thousand five hundred euro (EUR 27,500), represented by two
hundred fifty-two (250) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), one hundred (100) class B preferred shares (the "Class
B Preferred Shares"), one hundred (100) class C preferred shares (the "Class C Preferred Shares"), one hundred (100)
class D preferred shares (the "Class D Preferred Shares", and together with the Class B Preferred Shares, the Class C
Preferred Shares (the "Preferred Shares")), being a total of five hundred and fifty (550) shares of a nominal value EUR 50
(fifty euro) each. The share capital of the Company may be increased or reduced by decision of the extraordinary general
meeting of shareholders resolving at the majorities required for the amendment of the present articles."
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred euros (EUR 1,300.-).
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed at 6.35p.m..
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg-Findel, on the day mentioned at the beginning of
this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le vingt-sept février.
Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie
une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de Bufab S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant
son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital social
de EUR 32.500,-, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.721 et con-
stituée suivant acte notarié en date du 24 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
(le «Mémorial C»), numéro 517 du 10 mars 2006.
Les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 16 juillet 2006, publié au Mémorial C,
numéro 1658 du 1
er
septembre 2006 (la «Société»).
L'assemblée est ouverte à 18.25 heures sous la présidence de Madame Monica Morsch, employée privée, demeurant
professionnellement à Luxembourg-Findel,
qui désigne comme secrétaire Madame Laura Comino Suarez, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg-Findel.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Rebecca Ballmann, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg-Findel.
Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. L'associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette
liste et les procurations ne varietur, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l'acte.
II. Il ressort de la liste de présence que les deux cent cinquante parts sociales ordinaires (250) et quatre-cent (400)
parts sociales préférentielles représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre
du jour, dont les associés ont été préalablement informés. L'assemblée est dès lors constituée régulièrement et peut
délibérer et décider de l'ordre du jour cité ci-dessous.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Ordre du jouri>
1) Approbation du rachat de toutes les parts sociales préférentielles de Classe A à une Valeur d'Annulation par Action
déterminée par le Conseil de Gérance par application des statuts de la Société afin de procéder à la liquidation d'une
classe entière de parts sociales de la Société, à l'annulation de 100 parts sociales préférentielles de Classe A et à la
réduction du capital social de la Société.
2) Délégation de pouvoir
3) Modification de l'article huit des statuts de la Société de manière à éliminer toute référence aux parts sociales
préférentielles de Classe A et à mentionner le nouveau montant du capital social de la Société.
Après approbation de ce qui précède, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit:
62528
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'associé unique approuve le rachat par la Société de toutes les parts sociales préférentielles de Classe A.
L'associé unique décide ainsi d'annuler les cent (100) parts sociales préférentielles de Classe A et, par conséquent, de
réduire le capital social de la Société à concurrence de cinq mille euros (EUR 5,000) pour le ramener de son montant
actuel à vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 27,500).
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique octroie tous pouvoirs à chacun des membres du conseil de gérance pour procéder aux écritures
comptables qui s'imposent, pour annuler les parts rachetées et organiser le paiement du prix de rachat aux associés de
la Société. Plus particulièrement, le conseil de gérance devra déterminer la portion du prix de rachat excédant la valeur
nominale des parts rachetées et la manière de la financer.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, l'associé unique décide de modifier l'article 8 des statuts de la Société de
manière à éliminer toute référence aux parts sociales préférentielles de Classe A. L'article 8 aura désormais la teneur
suivante:
« Art. 8. Le capital de la Société est de vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 27,500), représenté par deux cent
cinquante parts sociales ordinaires (250) (les «Parts Sociales Ordinaires»), cent (100) parts sociales préférentielles de
classe B (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe B») cent (100) parts sociales préférentielles de classe C (les «Parts
Sociales Préférentielles de Classe C»), cent (100) parts sociales préférentielles de classe D (les «Parts Sociales Préféren-
tielles de Classe D»)),et ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles de Classe B, les Parts Sociales Préférentielles de
Classe C, les Parts Sociales Préférentielles de Classe D («les Parts Sociales Préférentielles» et ensemble avec les Parts
Sociales Ordinaires, les «parts sociales»)), étant un total de cinq cent cinquante (550) parts sociales d'une valeur nominale
de EUR 50.- (cinquante euros) chacune. Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par une décision de
l'assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité requise pour la modification de ces statuts.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à mille trois cents euros (EUR 1.300)
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée à 18.35 heures.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est
établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Findel, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Morsch, L. Comino Suarez, R. Ballmann, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 4 mars 2014. REM/2014/506. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 21 mars 2014.
Référence de publication: 2014041315/147.
(140048389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Nelson Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 110.293.
EXTRAIT
Conformément à la convention de cession de parts sociales conclue en date du 12 décembre 2013, entre la société
TURENDEA INVESTMENTS LIMITED (comme vendeur) et la société Red Mango Holdings Ltd (comme acheteur), les
1.200 parts sociales de la société Nelson Luxembourg Investments S.à r.l de EUR 25,- chacune, formant le capital de EUR
30.000,- sont réparties comme suit:
- Red Mango Holdings Ltd, société de droit Ile Maurice, ayant son siège social au Sir William Newton Street, Newton
Tower 19 etage, Port Louis (Ile Maurice): 1.200 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014041620/15.
(140047750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62529
L
U X E M B O U R G
Trinderley Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 176.579.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifty day of the month of February;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of “TRINDERLEY INVESTMENTS S.A.”, a public
limited company (“société anonyme”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having
its registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, registered with the Trade and Companies
Registry of Luxembourg, section B, under the number 176579, (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Me
Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, in replacement of the undersigned notary, on March 27, 2013, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1354 of June 7, 2013,
and whose articles of association (the “Articles”) haven' been amended since.
The Meeting is presided by Mrs. Alexia UHL, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling.
The Chairman appoints Mrs. Monique GOERES, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling, as secretary.
The Meeting elects Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling, as scrutineer.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Creation of two categories of directors and subsequent amendment of the binding signatories' power of the Com-
pany;
2. Amendment of the second paragraph of article 9 of the Articles;
3. Restructuring of the composition of the board of directors and fixation of the duration of their mandates;
4. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on
an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting decides:
- to create two categories of directors, namely the category A directors and the category B directors;
- to modify the binding signatories' power of the Company, so that article 13 of the by-laws will henceforth have the
following wording:
“ Art. 13. The Company will be bound (i) by the joint signature of any two (2) directors, (ii) by the individual signature
of the managing director, or (iii) by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated
by the board of directors.
However, if the shareholders have qualified the directors as category A directors or as category B directors, the
Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) category A director and one (1) category
B director.
In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be validly bound, in any cir-
cumstances and without restrictions, by the individual signature of the sole director.”
62530
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Meeting decides also to amend the second paragraph of article 9, in order to give t the following wording:
“ Art. 9. (second paragraph). However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of
the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that
there is more than one shareholders in the Company. In case of plurality of directors the general meeting may decide to
create two categories of directors (category A director and category B director).”
<i>Third resolutioni>
The Meeting decides:
- to correct the date of birth of Mr. Philippe DE PATOUL as follows: August 9, 1947;
- to accept the resignations of Mr. Michael MORRICE and of Mr. Laurent MULLER as directors of the Company and
to grant them, by special vote, full and entire discharge for the execution of their mandate; and
- to appoint Mr. Alain LE JEUNE, licencié en sciences économiques et financières, born in Wilrijk (Belgium), on May
19, 1959, residing professionally in L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
, as new director, his mandate will
expire at the general annual meeting in the year 2018.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting decides:
- to attribute the category A to the directors Mrs. Ana FLORES and Mr. Alain LE JEUNE;
- to attribute the category B to the directors Mr. Philippe DE PATOUL and Mr. Paul TORI.
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to
speak, the Chairman then adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand two
hundred and fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du mois de février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de “TRINDERLEY INVESTMENTS S.A.”, une
société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
176579, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg,
en remplacement du notaire instrumentant, le 27 mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1354 du 7 juin 2013,
et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifies depuis lors.
L'Assemblée est présidée par Madame Alexia UHL, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling.
La Présidente désigne Madame Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling, comme secrétaire.
L'Assemblée choisit Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling, comme scrutateur.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
62531
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jour:i>
1. Création de deux catégories d'administrateurs et modification subséquente des règles d'engagement de la Société;
2. Modification du deuxième paragraphe de l'article 9 des statuts;
3. Restructuration de la composition du conseil d'administration et fixation de la durée de leurs mandats;
4. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide:
- de créer deux catégories d'administrateurs, savoir les administrateurs de catégorie A et les administrateurs de ca-
tégorie B;
- de modifier les règles d'engagement de la Société, de sorte à ce que l'article 13 des statuts aura dorénavant la teneur
suivante:
“ Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature
individuelle de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils
pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Toutefois, si les actionnaires ont qualifié les administrateurs d'administrateurs de catégorie A ou d'administrateurs de
catégorie B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un (1) administrateur de catégorie A
et d'un (1) administrateur de catégorie B.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes
circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.”
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide également de modifier le deuxième alinéa de l'article 9 des statuts afin de lui donner la teneur
suivante:
“ Art. 9. (deuxième alinéa). Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une
assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de
l'existence de plus d'un actionnaire. En cas de pluralité d'administrateurs, l'assemblée générale peut décider de créer deux
catégories d'administrateurs (administrateur de catégorie A et administrateur de catégorie B).”
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée
- de corriger la date de naissance de Monsieur Philippe DE PATOUL comme suit: 9 août 1947,
- d'accepter les démissions de Monsieur Michael MORRICE et de Monsieur Laurent MULLER comme administrateurs
de la Société et de leur accorder, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat;
- de nommer Monsieur Alain LE JEUNE, licencié en sciences économiques et financières, né à Wilrijk (Belgique), le 19
mai 1959, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
, comme nouvel adminis-
trateur, son mandat expirera à l'assemblée générale annuelle de l'année 2018.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide:
- d'attribuer la catégorie A aux administrateurs Madame Ana FLORES et Monsieur Alain LE JEUNE;
- d'attribuer la catégorie B aux administrateurs Monsieur Philippe DE PATOUL et Monsieur Paul TORI.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.
62532
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille deux cent cinquante
euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. UHL, M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 04 mars 2014. LAC/2014/10036. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 18 mars 2014.
Référence de publication: 2014039820/177.
(140045903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.
Cartrust S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 125.189.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014041350/10.
(140048282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
CGM Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 125.046.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2014.
Référence de publication: 2014041356/10.
(140048264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Intershipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 66.764.
<i>Extrait des décisions de l'assemblée générale du 11 février 2014i>
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs pour une année, soit jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014.
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de délégué à la gestion journalière de Fabrice MAIRE, pour une
année, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014.
L'Assemblée Générale décide de renouveler le cabinet Compagnie Européenne de Révision sis 15, rue des Carrefours
L-8124 Bridel - RCSL no B-37039, en qualité de Réviseur d'entreprises pour une année, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014041518/16.
(140048203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62533
L
U X E M B O U R G
Angel's Majorettes de la commune de Pétange, Association sans but lucratif,
(anc. CHEERLEADERS ANGEL'S Club).
Siège social: Pétange,
R.C.S. Luxembourg F 9.622.
Ajout d'un article aux Statuts des Cheerleaders Angel's Pétange
Art. 24. Lors des son Assemblée Générale du 14 mars 2014, le comité a approuvé à l'unanimité le changement de
dénomination de l'A.S.B.L. Cheerleaders Angel's Pétange en Angel's Majorettes de la commune de Pétange. Donc con-
cernant les statuts de l'association à chaque fois où la dénomination Cheerleaders Angel's est présente il faudra lire à sa
place «Angel's majorettes de la commune de Pétange»
Lamadelaine, le 14 mars 2014.
Paolo Moretti / Etienne Brassinne / Paola Vivani Bourquel
<i>Le président / Le vice président / La Secrétairei>
Référence de publication: 2014041228/16.
(140046140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.
kolabutti, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6460 Echternach, 9, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 154.681.
Im Jahre zwei tausend vierzehn.
Den dreizehnten März.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
Herr Jürgen KLANKERT, Kaufmann, wohnhaft in D-54293 Trier, Auf der Bausch, 65.
Welcher Komparent erklärte, dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung kolabutti
ist, mit Sitz in L-9780 Wintger, 66B, route de Lullange, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
unter der Nummer B 154.681 (NIN 2010 2425 732).
Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Pierre PROBST, mit dem
Amtssitze in Ettelbruck, am 9. Juli 2010, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1991
vom 24. September 2010 und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar
Pierre PROBST, am 9. März 2012, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1051 vom
25. April 2012.
Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert
(100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125.-), alle zugeteilt Herrn Jürgen KLANKERT, vorgenannt.
Alsdann ersuchte der Komparent den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Wintger nach Echternach zu verlegen und dem-
gemäss den ersten Absatz von Artikel 4 der Statuten abzuändern wie folgt:
„ Art. 4. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6460 Echternach, 9, place du
Marché.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: J. KLANKERT, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 17 mars 2014. Relation: ECH/2014/529. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.
Echternach, den 20. März 2014.
Référence de publication: 2014041245/38.
(140047690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62534
L
U X E M B O U R G
XLS Air S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 185.411.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le douze mars.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
IMACORP BUSINESS CENTRE S.A., immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 46706, ayant son siège
social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper,
ici représentée par son administrateur délégué, Monsieur Philippe CHANTEREAU, expert-comptable, avec adresse
professionnelle à Luxembourg.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société
anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination - Forme. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «XLS AIR S.A.» (la
«Société»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d'Administration respectivement de l’administrateur unique, la société pourra établir
des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration
respectivement de l’administrateur unique à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être
transféré dans toute autre localité du Grand-Duché au moyen d’une résolution de l’actionnaire unique ou en cas de
pluralité d’actionnaires au moyen d’une résolution de l’assemblée générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 4. Objet. L’objet de la Société est de prendre ou de donner en location, acheter directement ou indirectement,
et d’exploiter des aéronefs ou hélicoptères ainsi que tout engin ou équipement, avec ou sans équipage, pour transport
public ou privé de passagers avec départ depuis et vers toutes les destinations du monde. En général, la Société pourra
développer toutes les activités de service et d’assistance dans le secteur du transport aérien.
La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toutes activités et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission
et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.
La société a encore pour objet l’administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne l’achat,
la vente et la gestion d'immeubles propres.
En général, elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant
directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) divisé en trois mille cent
(3.100) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune. La Société peut racheter ses propres actions
dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au
choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
62535
L
U X E M B O U R G
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 7. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement
constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Art. 8. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-
naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième
vendredi du mois de mai à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée
générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.
Art. 9. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans
les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout
actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par
visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des carac-
téristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de
façon continue.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 10. Composition du Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé
de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.
Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un
membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six
années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.
Art. 11. Réunions du Conseil d’administration. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un
vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du
conseil d’administration par visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces
moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont
les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance
est réputée se dérouler au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion. La voix du Président est prépondérante en cas de partage des
voix.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
62536
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de
passer tous actes d'administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à
la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 13. Représentation. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'administrateur
unique, par la seule signature de son administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la seule signature
de l’administrateur-délégué ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un administrateur.
Art. 14. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes
qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes
et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont
rééligibles.
Art. 15. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la
formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième du capital social.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au paiement d’acomptes sur dividendes en conformité avec les
conditions prévues par la loi.
Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs
liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 18. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux
dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
(1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.
(2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2015.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant déclare souscrire les 3.100 (3.100) actions comme suit:
- IMACORP BUSINESS CENTRE S.A., préqualifiée,
Trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
Total: Trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
Les actions ont été entièrement libérées par le comparant par des versements en espèces, de sorte que la somme de
EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été
donnée au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi
du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de EUR 1.200.-
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Le comparant préqualifié représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu’associé unique de la Société
a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. A été appelé aux fonctions d'administrateur unique:
62537
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Stéphane LEDERMANN, Consultant en entreprise, né le 20 août 1970 à Neuilly sur Seine (France), de-
meurant, rue du liseron 5, CH-1006 Lausanne (Suisse).
La durée du mandat de l’administrateur unique sera de six années et prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires
qui se tiendra en l’an 2019.
4. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société PYXIS S.A., avec siège social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75 177.
5. La durée du mandat du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en l’an 2019.
6. L'adresse de la Société est fixée à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent
acte.
Signé: P. CHANTEREAU et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 mars 2014. Relation: LAC/2014/12383. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 20 mars 2014.
Référence de publication: 2014041183/185.
(140047621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.
American Golf Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 252.846,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.524.
Par résolutions signées en date du 13 mars 2014, les associés ont décidé de nommer Laura Spitoni, avec adresse
professionnelle au 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2014.
Référence de publication: 2014041255/13.
(140047657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Bulgarian Acquisition Company VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 137.222.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 06 mars 2014i>
L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Warith Al-Kharusi comme gérant A de la société, avec
adresse professionnelle au State General Reserve Fund, Ministry of Finance, P.O. Box 188, P.C. 100, Waljat Street, Way
N°9105, Muscat, Sultanat d'Oman.
Et de nommer comme gérant A:
Madame Wafa Ahmed Mohamed Al-Amri, Directeur de société, née le 10 Juillet 1979 à Qurayat Sultanat d'Oman,
avec adresse professionnelle au State General Reserve Fund, Ministry of Finance, P.O. Box 188, P.C. 100, Waljat Street,
Way N°9105, Muscat, Sultanat d'Oman.
Luxembourg, le 14 Mars 2014.
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2014041317/18.
(140048238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62538
L
U X E M B O U R G
Spotify Technology S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 123.052.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2014.
Référence de publication: 2014041766/10.
(140048115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Ecouter pour Mieux s'Entendre, Fondation.
Siège social: L-1499 Luxembourg, 1, place de l'Europe.
R.C.S. Luxembourg G 200.
<i>Comptes annuels au 31 décembre 2013 et rapport du reviseur d'entreprises agréei>
<i>Sommairei>
Rapport du réviseur d'entreprises agréé
Comptes annuels
Bilan
Compte de profits et pertes
Annexe aux comptes annuels
Au Conseil d'Administration de la FONDATION EME «Ecouter pour Mieux s'Entendre»
1, place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
<i>Rapport du Réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels au 31 décembre 2013i>
Nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de la FONDATION EME «Ecouter pour Mieux s'Entendre»,
comprenant le bilan au 31 décembre 2013, ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date et
un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.
Responsabilité du Conseil d'Administration pour les comptes annuels
Le Conseil d'Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg ainsi que d'un contrôle interne qu'il juge nécessaire pour permettre l'établissement de comptes
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Responsabilité du Réviseur d'entreprises agréé
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives.
Responsabilité du Réviseur d'entreprises agréé (suite)
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants
et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d'entre-
prises agréé, de même que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le réviseur d'entreprises agréé prend
en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes
annuels afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Administration, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Opinion
A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la FONDA-
TION EME «Ecouter pour Mieux s'Entendre» au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette
date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes
annuels en vigueur au Luxembourg.
62539
L
U X E M B O U R G
Howald, le 7 mars 2014.
INTERAUDIT S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
Edward KOSTKA
<i>Bilan au 31 décembre 2013i>
<i>(exprimé en EUR)i>
ACTIF
2013
2012
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.213,37
-
ACTIF CIRCULANT
Créances
Créances résultant de ventes et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.800,00
1.212,00
Avoirs en banques, avoir en compte de chèques postaux, chèques et en caisse . . .
212.154,74 247.123,00
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220.168,11 248.335,00
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Dotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145.000,00 145.000,00
Excédent reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.960,26
58.729,00
Excédent de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(18.290,82)
3.231,26
188.669,44 206.960,26
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.127,50
2.127,50
DETTES
Dettes sur achats et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.1)
15.982,36
21.713,80
Dettes fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.2)
13.388,81
7.533,44
29.371,17
29.247,24
COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
10.000,00
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220.168,11 248.335,00
L'annexe fait partie intégrante des comptes annuels
<i>Comptes de profits et pertes pour l'exercice clos le 31 décembre 2013i>
<i>(exprimé en EUR)i>
CHARGES
2013
2012
Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) 139.033,58 106.712,71
Corrections de valeur sur frais d'établissement et
sur immobilisations corporelles et incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179,78
-
Intérêts et charges financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264,21
16,18
Excédent de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
3.231,26
TOTAL DES CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139.477,57 109.960,15
PRODUITS
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121.025,20 104.800,27
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161,55
5.159,88
Déficit de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.290,82
-
TOTAL DES PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139.477,57 109.960,15
Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2013
1. Généralités. La Fondation EME «Ecouter pour Mieux s'Entendre» (ci-après la «Fondation») a été constituée le 21
janvier 2009 par acte notarié et a pour objet de soutenir par la musique le développement de toutes personnes et en
particulier des personnes physiquement, psychiquement ou socialement défavorisées.
2. Principes et méthodes comptables.
2.1 Présentation des comptes annuels
La Fondation tient ses livres en Euros ('EUR') et les comptes annuels ont été établis en accord avec les principes
comptables généralement admis au Luxembourg, utilisant notamment les règles d'évaluation suivantes:
2.2 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont portées à l'actif du bilan à leur valeur d'acquisition diminuée des amortissements
calculés linéairement en fonction de la durée d'utilisation estimée des biens.
62540
L
U X E M B O U R G
2.3 Créances
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Des corrections de valeur sont enregistrées pour tenir compte des
risques spécifiques de non-recouvrement.
2.4 Dettes
Les dettes sont enregistrées à leur valeur de remboursement respective.
3. Dettes.
3.1 Dettes sur achats et prestations de services
La dette sur achats et prestations de services s'élève à EUR 15.982,36.
3.2 Dettes fiscales
Les dettes fiscales sont des impôts retenus à la source sur les cachets des artistes à hauteur d'EUR 5.355,50 (2012:
2.999,96) ainsi que de la TVA à payer à décharge des ces artistes à hauteur d'EUR 8.033,31 (2012: 4.533,48).
4. Charges. Le poste «Autres charges d'exploitation» comprend essentiellement des honoraires d'artistes et des par-
ticipations aux frais de production.
5. Personnel. La fondation n'employait pas de salariés pendant l'exercice.
6. Engagements hors bilan. La fondation n'a pas d'engagements hors bilan au 31.12.2013.
<i>Budget prévisionnel 2014i>
Désignation
Honoraires
Coûts
supplémentaires
Total
dépenses
Frais de production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 699,91
7 692,29 110 392,20
Concerts hôpitaux, maisons de soin février-décembre 2014 . . . . . . . . .
30 000,00
2 277,14
32 277,14
Schrassig Femmes (printemps 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,00
500,00
Concerts pour enfants février-décembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 000,00
7 000,00
Projet Djembé avec Daaflux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 000,00
4 000,00
Joy Caravan Echternach (janvier-mars 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 893,60
4 893,60
Joy Caravan Sud (octobre-décembre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 780,00
4 780,00
Ateliers de chant choral - CHEM + CHNP 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 200,00
3 200,00
Ateliers de chant choral - Foyers ALA 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 500,00
5 500,00
Rumbled (juin 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 000,00
3 887,80
17 887,80
Projet Rap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 700,00
4 700,00
Biller sangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 776,31
12 776,31
Tanzende Instrumente Lilian Genn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 000,00
1 527,35
11 527,35
Participation aux frais Institut St Joseph Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 350,00
1 350,00
Frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 063,46
0,00
25 063,46
Paiement TVA 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 533,48
4 533,48
Paiement ACD 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 999,96
2 999,96
Interaudit (Honoraires + TVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 180,69
2 180,69
Don en confiance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250,00
250,00
Frais dons CETREL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,00
30,00
Modification RCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,76
15,76
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
734,90
734,90
Notes de Frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,00
500,00
Achats 5
e
anniversaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429,99
Administration des Contributions Directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 355,35
5 355,35
Enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 033,33
8 033,33
Total 2014
127 763,37
7 692,29 135 455,66
Référence de publication: 2014040050/146.
(140046636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.
62541
L
U X E M B O U R G
Signature Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 135.437.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of February
before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.
There appeared:
Ingemar Wittström, born on 26
th
March 1948, in Lund, Sweden, residing at 41, via Rondonico, CH-6612 Ascona,
Switzerland (the `Sole Shareholder`),
duly represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette,
by virtue of a power of attorney, given under private seal.
Said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:
- the Sole Shareholder holds all the shares in Signature Holding S.àr.l., a limited liability company constituted and existing
under the laws of Luxembourg, having its registered address at 40 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 135.437, incorporated pursuant to a notarial deed
dated December 20
th
, 2007, published in the official gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
389 of February 14
th
, 2008 (the Company);
- the Company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12.500.-) represented by seventeen thousand
five hundred (500) corporate units with a par value of twenty five euros (EUR 25) each;
- the Sole Shareholder hereby resolves to proceed with the dissolution of the Company with effect as from today;
- the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the
known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the
assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company,
in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment
to itself;
- the Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation)
and to hear a report of an auditor to the liquidation;
- consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the
financial situation of the Company;
- the Sole Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for their mandates from the date of their
respective appointments up to the date of the present meeting; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date the date of the present
meeting at the registered office of the Company.
Whereof the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix février.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Ingemar Wittström, né le 26 mars 1948, in Lund, Suède, demeurant au 41, via Rondonico, CH-6612 Ascona, Suisse
(l'Associé Unique)
ici dûment représentée par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement à
Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.
62542
L
U X E M B O U R G
Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- l'Associé Unique détient toutes les parts sociales de Signature Holding S.àr.l., une société à responsabilité limité de
droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 135.437, constituée suivant acte notarié du 20 décembre 2007, publié au
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 389 du 14 février 2008 (la Société);
- le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune;
- par la présente l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- l'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;
- l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif
connu de la Société a été payé ou provisionné, qu’il est investi de tout l’actif et qu'il s'engage expressément à prendre à
sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce
jour avant tout paiement à sa personne;
- l'Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un
rapport du commissaire à la liquidation;
- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- la comparante a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;
- la comparante donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leur mandat à compter de la date de
leur nomination respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et
- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de
la présente assemblée au siège de la Société.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 février 2014. Relation: EAC/2014/2419. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2014041086/88.
(140046878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.
Société Immobilière de l'Ill S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 79, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 23.425.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE IMMOBILIERE DE L’ILL S.A.
Référence de publication: 2014041095/10.
(140047538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.
SRDV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 139.734.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014041110/10.
(140047076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.
62543
L
U X E M B O U R G
Gallileo Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.252.265,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 177.248.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 21 mars 2014.
Référence de publication: 2014041461/10.
(140048163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Schrëtt fir Schrëtt, Association sans but lucratif.
Siège social: L-7260 Bereldange, 34, rue A. Weis.
R.C.S. Luxembourg F 4.309.
<i>Rapport de l'assemblée générale ordinaire du jeudi 06 mars 2014 à 19h.i>
Il a été décidé à l'unanimité des membres présents que l'article 3 des statuts devait être modifié comme suit:
Art. 3. L'association a pour objet.
1. de promouvoir la pédagogie dite conductive développée par le médecin hongrois Andras Petö ainsi que toute
méthode se rapprochant de celle-ci et pouvant profiter à toute personne à besoins spécifiques.
2. d'initier et de soutenir tout projet scolaire, pédagogique, professionnel et rééducatif, mettant en pratique la pédagogie
conductive, au profit de toute personne à besoins spécifiques, enfants en bas âge, enfants en âge scolaire, adolescents et
adultes, ayant la capacité de bénéficier de ce système.
Laurence Borges-Klamerek
<i>La secrétairei>
Référence de publication: 2014041242/17.
(140047176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.
I Like Events S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 133, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 145.983.
EXTRAIT
Suite à une cession de parts sociales dûment approuvée par les associés et dûment signifiée à la société, le capital social
fixé à 12.500 EUR, représenté par 500 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, se repartit comme suit:
Madame Mireille Rahme Bley
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Monsieur Christopher Rahme
deux cent dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
MORGANA S.A.
cent-vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
IKM S.A.
cent-vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Total: cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2014.
I LIKE EVENTS SARL
Fiduciaire des P.M.E.
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2014041498/25.
(140048387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
62544
Alphabeta 3 International S.à r.l.
American Golf Holdings S.à r.l.
Angel's Majorettes de la commune de Pétange
Antipodes S.A.
Berlioz Investment S.A.
BRS Luxco Outdoor Sports Holdings S.à r.l.
Bufab S.à r.l.
Bulgarian Acquisition Company VI S.à r.l.
Cartrust S.A.
CGM Lux 1 S.à r.l.
Charlottenburg Capital International S.à r.l.
CHEERLEADERS ANGEL'S Club
Ecouter pour Mieux s'Entendre
Elix Holdings Management S.à r.l.
ESCO Spf S.A.
ESCO Spf S.A.
Euro-Druck S.à r.l.
Floresan S. à r.l.
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Funding Loop (GP) S.à r.l.
Gallileo Holding S.à r.l.
Hunac (No. 1) S.à r.l.
I C T C S.A.
I Like Events S. à r.l.
Image-In-Nation S.A.
Inaer Bond MEP GP S.à r.l.
Intershipping S.A.
kolabutti
Les Editions du Lion S.à r.l.
Marthilor S.à r.l
Maxam Holdings S.à r.l.
NCR International 2 SNC
Nelson Luxembourg Investments S.à r.l.
Ollean Etudes Luxembourg S.A.
Radiant Systems International 2 SNC
Schrëtt fir Schrëtt
Signature Holding S. à r.l.
Société Immobilière de l'Ill S.A.
Spotify Technology S.A.
SRDV S.A.
Trinderley Investments S.A.
XLS Air S.A.