This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1057
25 avril 2014
SOMMAIRE
Aaxxes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50728
Alba Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50726
Alder Consultancy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
50733
Al Mi'yar Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50728
Alpha Business Consulting S.A. . . . . . . . . . .
50725
Armadillo Lux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .
50720
Beaumonde S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50725
Bogey Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . .
50735
Bullball S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50724
Cabinet Immobilier Schmitt S.à r.l. . . . . . .
50724
Carehb S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50729
CHERRY Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
50735
Churchgate Capital Partners, S.à r.l. . . . . .
50725
CPPE Carbon Process & Plant Engineering
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50724
CPPE Carbon Process & Plant Engineering
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50711
DBI Private Equity Fund S.A. . . . . . . . . . . . .
50723
ECP Europe & North Africa Food & Beve-
rage Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50701
Ersel Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50723
European Paper Group s. à r.l. . . . . . . . . . .
50723
Hyridia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50736
KPI Retail Property 25 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
50698
Mois européen de la photographie . . . . . . .
50690
Oranje-Nassau Développement S.A., SI-
CAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50731
Prize Holdings 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
50731
Promo Kappa 94 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50726
Rockwell Collins International Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50726
Shurgard Holding Luxembourg . . . . . . . . . .
50727
Soficomex Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
50711
Soficomex Holding Spf S.A. . . . . . . . . . . . . .
50711
Sokaris Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50727
Spectrum Media S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
50727
Valindus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50732
Valindus S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50732
VeTC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50736
WCG SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50728
WCG SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50728
50689
L
U X E M B O U R G
Mois européen de la photographie, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 2, rue Alphonse Munchen.
R.C.S. Luxembourg F 9.847.
STATUTES
Between the undersigned, acting as founding members:
Kulturprojekte Berlin GmbH, with address at Klosterstraße 68, D-10179 Berlin,
duly represented by Mr. Moritz van Dülmen (Managing Director of Kulturprojekte Berlin GmbH);
Fotofo, o.z. / Central European House of Photography with address at Prepoštská 4, SK-814 99 Bratislava,
duly represented by Mr. Vaclav Macek (Director);
Association of Hungarian Photographers with address at Nagymezo street 20, H-1068 Budapest,
duly represented by Mr. Zsolt Szamódy (Chairman of the Associaton of Hungarian Photographers)
Photon Association, with address at Trg prekomorskih brigad I, SLO-1000 Ljubljana,
duly represented by Mr. Dejan Sluga (Director) and Mr. Miha Colner (Chief Executive Officer);
Café-Crème asbl, Luxembourg non profit association with address at 2, rue Alphonse Munchen, L-2172 Luxembourg,
duly represented by Mr. Pierre Stiwer & Mr. Paul di Felice (Directors);
Department for Cultural Affairs of the City of Vienna, with address at Friedrich-Schmidt-Platz 5, A-1082 Vienna,
duly represented by Mr. Bernhard Denscher (Head of the Department for Cultural Affairs of the City of Vienna);
is formed a non-profit association which will be governed by the law of 21
st
of April 1928 on non profit associations
and foundations in Luxembourg, as amended, and by the following statutes:
<i>Mission statement and historyi>
The European Month of Photography was initiated in 2004 by the Maison Européenne de la Photographie, Paris, and
its director Jean-Luc Monterosso as a joint venture between European capitals hosting a photography festival with the
aim to confront expertise in curatorial practice in photography and the intention to develop common projects, notably
exhibitions, including exchange of information about the local photographers and artists concerned with photography.
As founding members acted the Maison Européenne de la Photographie, Paris, the Cultural Departement of the City of
Berlin (Museumspädagogischer Dienst Berlin) and the Department for Cultural Affairs of the City of Vienna. Those three
members were subsequently joined by the Central European House of Photography, Bratislava, the Museum of Photo-
graphy, Moscow, the association Zone Attive working for the City of Rome and Café-Crème asbl for Luxembourg. Wheras
Moscow and Rome have left the network in the meantime, Photon Association, Ljubljana, and the Association of Hungarian
Photographers in Budapest have joined the network in 2012.
After 2004, representatives of these cities were meeting about three or four times a year to discuss common projects.
Four exhibitions about the aesthetics and technical challenges met by contemporary photographers and artists have been
organized each with a catalogue.
A website featuring the common projects and documents on past and ongoing projects was set up.
(www.europeanmonthofphotography.net).
In order to develop further international cooperation in the field of photography, but also to promote essentially
European emerging artists whose use of contemporary photography and image modification techniques sets them at the
forefront of significant developments in image production and diffusion, it is the wish of the founding members to unite
and build a European net. Therefore, beside the festivals in the participating cities, common curating and organisation of
projects shall have top priority.
I. Name - Seat - Purpose - Duration
Art. 1. Name. The name of the association is European Month of Photography or its equivalent in the language of a
charter member, mainly Europäischer Monat der Fotografie, Mois européen de la photographie... which can be abbreviated
to "EMop".
It is established in accordance with the law of April 21, 1928 on non-profit making associations and foundations and
shall be registered in the Grand Duchy of Luxembourg.
Seat. The seat of the association is established in the Grand-Duchy of Luxembourg. 2, rue Alphonse Munchen, L-2172
Luxembourg.
Art. 2. Purpose. The purpose of the Association is:
to bring together European museums, state or city institutions, government agencies, non-profit associations of cities
that manage a festival on photography or new media-art and are concerned with its preservation, dissemination and
promotion in order to share their experience and expertise;
50690
L
U X E M B O U R G
to organize and curate common exhibitions, workshops, colloquia, and to be editor of books and catalogues on pho-
tography and new media-art;
to set up and maintain a web presence on photography and the new media-art related to its achievements and goals;
to promote essentially emerging European artists or photographers of high artistic quality, or those of foreign countries
who have chosen to live and work in Europe, as well as curators, cultural professionals from the field of the visual arts
and new media;
to promote exchange of information on all topics related to the visual arts in general as far as they relate to photography
and the new media-arts in particular.
The Association has the power to take whatever action is legally permissible to promote, encourage and advance its
purpose.
Art. 3. Duration and dissolution procedures. The association is established for an indefinate period. It may be dissolved
at any time at a General Meeting where at least two thirds of the Full Members of the Association are present or
represented,
If that quorum is not reached, the General Meeting may be re-convened after having duly informed the remaining
charter members on the issue, fixed the agenda of the meeting and its date.
At such re-convened meeting resolutions may be adopted irrespective of the number of Full Members present or
represented. The resolution to dissolve the association must be approved by simple majority of the present or represented
Full Members.
The remaining funds will be distributed equally according to the respective contributions of the remaining partners.
Art. 4. Fees and financial resources / operating expenses / project budget. The association's resources shall derive
mainly from maintenance fees paid annually by the different charter members.
In addition, it may receive contributions, donations, subsidies and any other funds resulting directly or indirectly from
its activities, subject to approval by the Board.
The association's annual operating budget is based on the membership fees and is to be used to set up and maintain
the office and communication costs, the internet site and expenses related to the search for sponsors and subsidization.
The board decides on the amount and the date of payment.
The common project budget deals with exhibition costs that can be shared, the publishing of books and catalogues
(including virtual media), the organization of colloquia, the promotion of the event on the internet site.
It will be voted on separately following a general meeting of the charter members or its appointed delegates, which
shall rule on the project's appropriateness with regards to the association's objectives.
II. Membership
Art. 5. Full Member. The word Full Member refers to a city or its institution which is in charge of organizing and
managing a festival on photography and has signed the statutes.
Full Members must be museums, state or city institutions, government agencies, non-profit associations of cities that
manage a festival on photography and are concerned with its preservation, dissemination and promotion.
No foundation, institution or gallery can be a permanent member if their purpose is commercial.
The number of Full Members shall not be less than three.
A Full Member can transfer his voting right only to a person of his citie's institution who will represent him at the
board if this is notified to the other members in due time by letter.
The latter is appropriately commissioned and has to detain official decision-making power particularly regarding bud-
getary issues in relationship with the operational budget and the common projects.
Full Members and Associated Members pay an annual membership fee to be fixed and revised by the board periodically.
The amount is noted annually in an appendix.
No member city can abstain or refuse to contribute to the operational budget excepting if it wants to resign and leave
the association.
The fee to be paid by the Full Members is refixed annually by the Board and decided at a General Meeting by a 2/3d
majority.
Amount of the fee and payment date for the fiscal year to come is voted on by board members at the same occasion.
All payment are to be made prior to September 1
st
of the fiscal year.
No Member can take part in decision making if the fee is not paid.
It is expected that Full Members participate at least every four years in a common project. Failure to do so leads to
exclusion.
New members may be admitted by a 2/3 decision adopted at a General Meeting, according to the rules and goals of
the association.
50691
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Associated Members. An Associated Member shall be such a City's institution that did not sign the statutes but
has a regular presence at the board through a permanent representative. An Associated Member may attend meetings
of the Full Member and may be heard at such meetings. It is eligible to vote on the general budget in so far it annually
contributes to it and is committed to the projects of the association. The same applies to the common projects in so far
it has contributed to it. It cannot hold office and cannot claim to have the full rights of the Full Members nor is it liable
in case of any financial obligations or the association's wrong doings.
Art. 7. Temporary Associate. A Temporary Associate may be any person or business, government agency or non-
profit association or organisation engaged in the visual arts sector activities and/or with an interest in the purpose of the
Association in a city that has a festival dedicated to photography.
It is called Temporary Associate in so far as its involvement is limited in time in accordance with specific projects that
are common and of which it is participant.
A Temporary Associate may be invited to attend meetings of the Full Members and may be heard at such meetings.
It does have a voting right in relation to the project it is part of and financing.
Art. 8. Admittance of new members. Application in writing must be made by anyone wishing to be admitted as a new
member. The application for membership must state:
the name, nature and place of activity which can be located in any country of Europe;
that the applicant has read the Statutes of the Association and accepts and agrees to be bound thereby;
that the applicant qualifies under the Statutes of the Association;
that the applicant agrees to pay its dues.
The admittance of new members is recommended by the Board and decided by a 2/3d decision adopted at a General
Meeting.
Art. 9. Resignation of a Full member or an Associated Member. A Full Member or an Associated Member is free to
resign from the association at any time. A resignation must be notified by registered letter to the president of the Board.
The said letter forfeits any claim to the amount of subscription due or paid by the resigning member for the year in which
the resignation occurs.
Art. 10. Exclusion of a Full Member or an Associated Member. The exclusion of a Full Member or Associated Member
from the association may be decreed at a General Meeting at a two-thirds majority. The General Meeting shall decide by
secret ballot after having heard the Full Member or Associated Member whose exclusion is proposed or after the said
Full Member or Associated Member has been summoned by letter to explain his/her/its conduct.
Failure to observe the requirements of the present Statutes or of the internal rules and regulations of the Association
shall constitute grounds for exclusion.
Neither the resigning or excluded member shall have any entitlement to any part of the Association's assets, nor may
they claim any amount, request seals or an inventory and/or copies of accounts or other documents.
III. Working procedures
Art. 11. Members of the Board. Every Full Member or Associated Member appoints at least one but not more than
three representatives to the board.
Disrespective of the number of its representatives, every Full Member or Associated Member every has only one vote.
The board takes all decisions concerning the objectives and goals of the association;
decides on the curatorial aspects of the exhibitions, book or internet projects;
decides on the annual fee and the common projects and its financing.
Art. 12. Decision taking of the board / number of meetings / common prejects & financial contributions. One meeting
at least is to be held annually
The board can take decisions by simple majority and only if at least 50% + 1 Member (Full or Associated) are attending
At a general meeting, it should be ruled upon:
- the annual contribution and fee by all members;
- which projects are to be called common projects;
- the amount of the financial contribution of every member to the common project;
- how these sums are allocated to catalogue design, printing, translation and artist's fees, production costs etc;
- the payment schedule.
Art. 13. Fresidency / Vice-presidency / Financial officer (Secretary / Treasurer), Supervisor. The board elects a president
and vice president - each of a different city - who represents the association; Their mandate will extend over two years
starting with the date of their election.
The board may designate a member whose function is to be secretary / treasurer and in charge of the association's
accounting and financial ressources. He will be assisted by a supervisor.
50692
L
U X E M B O U R G
Their mandate will extend over two years starting with the date of their election. They will be of different cities.
They will be designated to establish, maintain and operate bank accounts in the name of the institution at any registered
bank.
They are duly mandated to sign any documents related to activities, they may collect and pay out money.
Signatory status will be assigned to or removed from them by the board at an annual general meeting.
They will also monitor the budget and report to the Board on this at the end of the year or at any time if this is
required.
They are in charge of year-end reporting and will present to the Board each year a proposed operating budget.
They will ask for clearance of their activities once a year during a general meeting where 2/3d majority is required for
clearance.
The annual report will be signed by one representative of every charter member.
Art. 14. Working teams. The board can appoint members to be part of work groups for missions that are limited in
time. They may be
in charge of demands for grants to the European commission;
in charge of daily accounting and the set up of the financial reporting;
in charge of the daily management of the internet site;
in charge of contributing information to the internet site, to the blogs, newsletter etc;
in charge of coordinating the publishing of catalogues, books and the translation of texts.
These groups have to report to the members of the board on a regular basis.
Art. 15. common projects. Common projects or EMoP projects are called common when shared and financed by at
least three members.
In the case of an exhibition it is expected:
- that the exhibition is hosted in the best possible location in the member's city;
- that the exhibition is of proper size and quality;
- that every member commits itself to furnishing a solid financial contribution that goes beyond the regular contribution
as fixed by the statutes (article 4 & 12) in order to set up the common exhibition on the local premises;
- the catalogue design and printing are entrusted to a business of repute and excellence;
- that a common communication strategy be chosen and that all partner cities unite in their advertising and web
presence;
- that the participating artists are invited to the opening;
- that the EMoP logo is in due size and clearly visible on any document, poster, flag etc;
- that EU funding or any other funding and sponsorship be used exclusively for the project and equally shared among
the participating member cities.
Any costs directly related to a charter member's exhibition such as renting a proper exhibition space, insurance costs,
local advertising, production costs which depend on each city's specific choices, are not part of the common budget.
Signatures and dates:
Full Members:
Le 22.10.13.
Kulturprojekte Berlin GmbH, Berlin
Mr. Moritz van Dülmen
<i>Managing Director of Kulturprojekte Berlin GmbHi>
Le 14.10.13.
Fotofo, o.z. / Central European House of Photography, Bratislava
Mr. Vaclav Macek
<i>Directori>
Le 8.10.13.
Association of Hungarian Photographers, Budapest
Mr. Zsolt Szamódy
<i>Chairman of the Associaton of Hungarian Photographersi>
Le 8.10.13.
Photon Association, Ljubljana
Mr. Dejan Sluga
<i>Directori>
50693
L
U X E M B O U R G
Le 9.10.13.
Café-Crème asbl, Luxembourg
Mr. Pierre Stiwer / Mr. Paul di Felice
<i>Directorsi>
Le 17.12.13.
Department for Cultural Affairs of the City of Vienna
Mr. Bernhard Denscher
<i>Head of the Department for Cultural Affairs of the City of Viennai>
SATZUNG
Von den folgenden Unterzeichneten in ihrer Eigenschaft als Gründungsmitglieder
- Kuiturprojekte Berlin GmbH, Klosterstraße 68, D-10179 Berlin, Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Herrn
Moritz van Dülmen (Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin GmbH);
- Fotofo, o.z. / Central European House of Photography, Prepoštská 4, SK-814 99 Bratislava, vertreten durch Herrn
Vaclav Macek (Direktor);
- Vereinigung Ungarischer Fotografen, Nagymezo street 20, H-1068 Budapest, vertreten durch Herrn Zsolt Szamody
(Vorsitzender der Vereinigung Ungarischer Fotografen);
- Photon Association, Trg prekomorskih brigad I, SLO-1000 Ljubljana, vertreten durch Herrn Dejan Sluga (Direktor)
und Herrn Miha Colner (leitender Geschäftsführer);
- Café-Crème asbl, Luxembourg non profit association, 2, rue Alphonse Munchen, L-2172 Luxembourg, vertreten
durch Herrn Pierre Stiwer & Herrn Paul di Felice (Direktoren);
- Kulturabteilung der Stadt Wien, Friedrich-Schmldt-Platz 5, A-1082 Wien, vertreten durch Herrn Bernhard Denscher
(Leiter der Kulturabteilung der Stadt Wien);
wird eine Non-Profit-Organisation gemäß dem Gesetz vom 21. April 1928 über Non-Profit-Organisationen und Stif-
tungen in Luxemburg, in geänderter Fassung, gegründet und zwar mit folgender Satzung:
<i>Mission Statement / Zielsetzungi>
Der Europäische Monat der Fotografie wurde 2004 vom Pariser Maison Européenne de la Photographie und seinem
Direktor Jean-Luc Monterosso als Joint Venture zwischen europäischen Fotometropolen ins Leben gerufen, um kurato-
rische Praxis und fotografische Projektentwicklung, vor allem im Ausstellungsbereich, zusammen zu bringen, gemeinsame
Projekte, vor allem aber Ausstellungen, zu realisieren und den Austausch von Informationen über ortsansässige Foto-
grafinnen und auch Künstlerinnen zu fördern, die mit dem Medium der Fotografie arbeiten. Vollmitglieder sind das Maison
Européene de la Photographie, Paris, die Kulturabteilung der Stadt Berlin und die Kulturabteilung der Stadt Wien. An
diese drei Mitglieder haben sich das Zentraleuropäische Haus der Fotografie in Bratislava, das Museum der Fotografie in
Moskau, Zone Attive im Auftrag der Stadt Rom und Café-Crème asbl, Luxemburg, angeschlossen. Während Moskau und
Rom in der Zwischenzeit aus dem Netzwerk ausgetreten sind, haben sich 2012 Photon Association, Ljubljana, und die
Vereinigung Ungarischer Fotografinnen in Budapest angeschlossen.
Seit 2004 treffen sich die Repräsentanten dieser Städte drei oder vier Mal im Jahr, um gemeinsame Projekte zu be-
sprechen. Organisiert wurden vier, von Katalogen begleitete Ausstellungen zu ästhetischen und technischen Fragen, mit
denen sich zeitgenössische Fotografinnen und Künstlerinnen auseinandersetzen.
Eine eigene Internetplattform mit Informationen über gemeinsame Projekte und Dokumentationen über frühere und
aktuelle Projekte wurde eingerichtet (www.europeanmonthofphotography.net).
Um eine internationale Zusammenarbeit im Bereich der Fotografie voranzutreiben und junge, vielversprechende eu-
ropäische Künstlerinnen zu fördern, die durch ihre Verwendung von zeitgenössischer Fotografie und neuen Bildbearbei-
tungstechniken einen maßgeblichen Beitrag zur Herstellung und Verbreitung von Bildern leisten, wollen sich die
Vollmitglieder zusammenschließen und ein europäisches Netzwerk aufbauen. Deshalb sollen neben den Festivals in den
Partnerstädten gemeinsame Betreuung und Durchführung von Projekten an erster Stelle stehen.
I. Name - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Name. Die Organisation trägt den Namen „European Month of Photography“ oder den entsprechenden Namen
in der jeweiligen Sprache des Vollmitglieds. Auf Deutsch lautet er „Europäischer Monat der Fotografie“, auf Französisch
„Mois Européen de la Photographie“ abgekürzt „EMoP“.
Die Gründung erfolgt gemäß dem Gesetz vom 21. April 1928 über Non-Profit-Organisationen und Stiftungen in Lu-
xemburg. Die Eintragung ins Vereinsregister soll im Großherzogtum Luxemburg erfolgen.
Sitz. Der Sitz der Organisation befindet sich im Großherzogtum Luxemburg. 2, rue Alphonse Munchen, L-2172 Lu-
xembourg.
Art. 2. Ziel und Zweck. Das Ziel der Organisation ist
50694
L
U X E M B O U R G
- die Vernetzung von europäischen Museen, staatlichen oder städtischen Institutionen, staatlichen Agenturen, Non-
Profit-Organisationen von Städten, die ein Fotofestival oder ein Festival über neue Medienkunst durchführen und die
Aufrechterhaltung, Verbreitung und Förderung dieses Festivals als ihre Aufgabe betrachten, um so ihr Wissen und ihre
Erfahrung teilen zu können;
- gemeinsame Ausstellungen, Workshops und Kolloquien zu organisieren und kuratieren, neue Bücher und Kataloge
über Fotografie und neue Medienkunst publiziert werden sollen;
- das Einrichten und Verwalten einer Internetseite über Fotografie und neue Medienkunst, die ähnliche Ziele verfolgt;
- die Förderung von jungen, europäischen Nachwuchskünstlerinnen oder Fotografinnen mit großem künstlerischen
Potential, ebenso von ausländischen Künstierinnen, die sich entschieden haben, in Europa zu leben und zu arbeiten, sowie
von Kuratorinnen und Kulturschaffenden aus dem Bereich der bildenden Kunst und neuen Medien;
- die Intensivierung des Informationsaustausches in Hinblick auf Themen der bildenden Kunst, soweit sie sich mit
Fotografie und neuer Medienkunst befassen.
Die Organisation ist befugt, alle gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr helfen, dieses Ziel zu erreichen, zu
unterstützen und fördern.
Art. 3. Dauer und Auflösyngsprozeduren. Die Organisation wird auf unbefristete Zeit gegründet.
Sie kann jederzeit auf einer Hauptversammlung aufgelöst werden, bei der mindestens zwei Drittel der Vollmitglieder
oder deren Vertreterinnen anwesend sein müssen. Wird diese Voraussetzung nicht erfüllt, kann die Hauptversammlung
neu anberaumt werden, nachdem die übrigen Vollmitglieder ordnungsgemäß informiert und Tagesordnung und Datum
der Versammlung neu festgelegt wurden.
Auf einer solchen neu anberaumten Versammlung können, unabhängig von der Zahl der anwesenden oder vertretenen
Vollmitglieder, Beschlüsse gefasst werden. Die Entscheidung, die Organisation aufzulösen, muss von der einfachen Mehr-
heit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst werden.
Die restlichen (Finanz-) Mittel werden gleichmäßig gemäß den jeweiligen Beiträgen der verbliebenen Partner verteilt.
Art. 4. Beiträge und finanzielle Mittel/Aufwendungen/Projektgelder. Die finanziellen Mittel der Organisation bestehen
vor allem aus den Jahresbeiträgen der Mitglieder. Hinzukommen können Spenden, Schenkungen, Zuschüsse und andere
Gelder, die direkt oder indirekt aus den vom Vorstand genehmigten Aktivitäten der Organisation resultieren.
Das Jahresbudget der Organisation basiert auf den Mitgliederbeiträgen und soll zur Deckung von Verwaltungs-, Werbe-
und Fundraisingkosten sowie für die Betreuung der Internetseite verwendet werden.
Über Höhe und Datum der Zahlungen entscheidet der Vorstand.
Das Budget eines gemeinsamen Projekts enthält folgende Posten: Ausstellungskosten, die geteilt werden können, Her-
stellungskosten für Bücher und Kataloge (einschließlich der virtuellen Medien), Organisationskosten von Kolloquien,
Bewerbungskosten für Veranstaltungen auf der Internetseite. Es wird separat im Anschluss an eine Hauptversammlung
der Vollmitglieder oder deren Vertreterinnen beschlossen, auf der über die Übereinstimmung des Projekts mit der Ziel-
setzung der Organisation entschieden werden soll.
II. Mitgliedschaft
Art. 5. Vollmitglieder. Die Bezeichnung „Vollmitglied“ bezieht sich auf eine Stadt oder eine Institution dieser Stadt,
deren Aufgabe es ist, ein Fotofestival zu organisieren und durchzuführen, und die die Statuten unterzeichnet hat.
Vollmitglieder müssen Museen, staatliche oder städtische Institutionen, Staatsagenturen, Non-Profit Organisationen
von Städten sein, die ein Fotofestival durchführen und sich um die Erhaltung, die Medienpräsenz und die Förderung dieses
Festivals kümmern.
Stiftungen, Institutionen oder Galerien mit kommerziellen Interessen können keine ständigen Mitglieder sein.
Die Zahl der Vollmitglieder darf nicht weniger als drei betragen.
Ein Vollmitglied kann sein Stimmrecht nur dann auf eine Person der städtischen Institution übertragen, die es im
Vorstand vertritt, wenn die anderen Vollmitglieder rechtzeitig schriftlich davon unterrichtet werden.
Letzterer ist mit den entsprechenden Vollmachten ausgestattet und verfügt, vor allem, was das Vereinsvermögen und
gemeinsame Projekte betrifft, über uneingeschränkte Entscheidungsbefugnis.
Vollmitglieder zahlen einen Jahresbeitrag, der vom Vorstand periodisch festgesetzt und angepasst wird. Die Höhe des
Betrags wird jährlich in einem Appendix vermerkt.
Eine Partnerstadt muss nur dann keinen Beitrag zum Haushaltsbudget leisten, wenn sie ihre Mitgliedschaft aufgeben
oder aus der Organisation austreten will.
Die Höhe des Beitrags, den die Vollmitglieder aufbringen müssen, wird jedes Jahr vom Vorstand neu festgelegt und auf
der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen beschlossen.
Über Beitragshöhe und Fälligkeitsdatum für das folgende Geschäftsjahr wird von den Vorstandsmitgliedern in ein- und
derselben Sitzung abgestimmt. Alle Zahlungen müssen spätestens bis zum 1. September des Geschäftsjahres erfolgen.
Ein Vollmitglied, das seinen Beitrag nicht bezahlt hat, kann sich an der Entscheidungsfindung nicht beteiligen.
50695
L
U X E M B O U R G
Von den Vollmitgliedern wird erwartet, dass sie sich mindestens alle vier Jahre an einem gemeinsamen Projekt betei-
ligen. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, werden sie von der Organisation ausgeschlossen.
Neue Mitglieder können durch einen 2/3 Beschluss der Mitgliederversammlung aufgenommen werden, gemäß den
Regeln und Zielen der Organisation.
Art. 6. Assoziiertes Mitglied. Ein assoziiertes Mitglied soll eine städtische Institution sein, die die Satzung nicht unter-
zeichnet hat, aber über einen regulären Vertreter im Vorstand verfügt. Ein assoziiertes Mitglied kann die Mitgliederver-
sammlung besuchen und hierbei auch das Wort ergreifen. Es hat ein Stimmrecht in Haushaltsfragen, insofern es durch
seine Jahresbeiträge die Projekte der Organisation finanziell und ideell unterstützt. Dasselbe gilt auch für gemeinsam
kuratierte Projekte, die es mitfinanziert hat. Es ist aber nicht geschäftsführend und kann nicht dieselben Rechte wie die
Vollmitglieder für sich beanspruchen, noch haftet es bei finanzielle Verpflichtungen der Organisation oder deren Verfeh-
lungen.
Art. 7. Temporäres Mitglied. Temporäre Mitgliedschaft kann von allen im Bereich der bildenden Künste tätigen Per-
sonen, Unternehmen, Staatsagenturen, Non-Profit-Organisationen oder Stiftungen erworben werden, die sich für die
Ziele der Organisation und deren Aktivitäten in einer Stadt mit einem Fotofestival interessieren.
Temporär ist diese Mitgliedschaft, weil sie von der Dauer der gemeinsamen Projekte abhängen.
Ein temporäres Mitglied kann zu den Mitgliederversammlungen eingeladen und auch angehört werden.
Es hat ein Stimmrecht in Bezug auf das Projekt, an dem es teilnimmt und das es mitfinanziert.
Art. 8 Aufnahme neuer Mitglieder. Voraussetzung für die Aufnahme eines neuen Mitglieds ist ein schriftlicher Antrag.
Dieser Aufnahmeantrag muss folgende Angaben enthalten:
- Name, Art und Ort der Aktivität, die in jedem europäischen Land sein kann;
- Der Bewerber bestätigt die Kenntnisnahme der Satzung und erklärt, sich an deren Bestimmungen zu halten;
- Der Bewerber erfüllt die in der Satzung aufgeführten Voraussetzungen;
- Der Bewerber verpflichtet sich zur Leistung der Beiträge.
Die Aufnahme eines Bewerbers wird vom Vorstand empfohlen und durch einen 2/3 Beschluss auf einer Mitglieder-
versammlung entschieden.
Art. 9. Austritt eines Vollmitglieds oder eines assoziierten Mitglieds. Vollmitglieder oder assoziierte Mitglieder können
jederzeit ihre Mitgliedschaft kündigen. Die Kündigung erfolgt durch einen eingeschriebenen Brief an den Präsidenten des
Vorstands. Durch diesen Brief wird jeder Anspruch auf Beiträge hinfällig, die das ausscheidende Mitglied für das laufende
Jahr bezahlt hat oder noch schuldet.
Art. 10. Ausschluss eines Vollmitglieds oder eines assoziierten Mitglieds. Der Ausschluss eines Vollmitglieds oder eines
assoziierten Mitglieds aus der Organisation kann auf einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen
beschlossen werden. Die Mitgliederversammlung entscheidet in geheimer Abstimmung nach Anhörung des Vollmitglieds
oder assoziierten Mitglieds, dessen Ausschluss zur Diskussion steht, oder an das die Aufforderung erging, sein Verhalten
schriftlich zu erklären.
Nichtbeachtung der geltenden Satzung oder interner Regeln und Bestimmungen der Organisation rechtfertigt einen
Ausschluss.
Ein ausscheidendes oder ausgeschlossenes Mitglied hat keinen Anspruch auf irgendwelche Vermögenswerte der Or-
ganisation oder auch sonstige Gelder, es kann auch kein Dienstsiegel oder eine Bestandsaufnahme und/oder Kopien von
Konten und anderen Dokumenten verlangen.
III. Arbeitsprozesse / Verfahrensweisen
Art. 11. Mitglieder des Vorstands. Jedes Vollmitglied benennt mindestens einen, aber nicht mehr als drei Vertreterinnen
als Vorstandsmitglied/-er. Unabhängig von der Zahl der Vertreterinnen verfügt jedes Mitglied nur über eine Stimme.
Der Vorstand trifft alle Entscheidungen hinsichtlich
- der Vorgaben und Ziele der Organisation,
- der kuratorischen Aspekte der Ausstellungen,
- der Buch- oder Internetprojekte,
- der Jahresbeiträge und der gemeinsamen Projekte sowie deren Finanzierung.
Art. 12. Beschlussfähigkeit des Vorstands / Zahl der Sitzungen / gemeinsame Projekte und finanzielle Beiträge. Min-
destens einmal im Jahr sollte eine Versammlung stattfinden.
Der Vorstand kann mit einfacher Mehrheit und nur, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder ( Voll-oder Assoziiert)
plus ein Vollmitglied anwesend sind, Beschlüsse fassen.
Auf einer Mitgliederversammlung sollte über Folgendes entschieden werden:
- über Jahresbeiträge und Gebühren von allen Mitgliedern;
- über die Frage, welche Projekte als gemeinsame Projekte gelten;
50696
L
U X E M B O U R G
- über die Höhe der Beiträge der einzelnen Mitglieder zu dem gemeinsamen Projekt;
- über die Verwendung dieser Gelder für die Gestaltung, den Druck und die Übersetzung von Katalogen, für Künst-
lerinnenhonorare, Produktionskosten etc.;
- Zahlungsmodalitäten.
Art. 13. Vorsitzender / stellvertretender Vorsitzender / Finanzchef, Schatzmeister / Finanzaufseher. Der Vorstand wählt
einen Vorsitzenden und eine/n StellVertreterln - jeweils aus einer anderen Stadt -, die die Organisation vertreten. Ihr
Mandat erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Jahren und beginnt mit ihrer Wahl.
Der Vorstand muss ein Mitglied als Schatzmeister/Sekretär benennen, der für die Buchhaltung und anfallende Aufgaben
im Finanzbereich zuständig ist. Ihm steht ein Supervisor zur Seite.
Ihre Mandate erstrecken sich über einen Zeitraum von zwei Jahren und beginnen mit ihrer Wahl. Sie sind ebenfalls
aus verschiedenen Städten.
Vorstandsmitglieder werden ernannt, um bei einer eingetragenen Bank im Namen der Organisation Konten einzu-
richten und zu verwalten.
Sie sind berechtigt, im Zusammenhang mit Veranstaltungen offizielle Schriftstücke zu unterzeichnen, Gelder einzu-
sammeln und auszubezahlen.
Auf der Jahresvollversammlung entscheiden die Vorstandsmitglieder über Vergabe und Rücknahme dieser Zeich-
nungsberechtigung.
Sie überwachen auch den Haushalt und legen am Jahresende oder auf Aufforderung Rechenschaft darüber ab.
Sie sind verpflichtet, eine Jahresendabrechnung vorzulegen und jedes Jahr einen Haushaltsplan zu erstellen.
Einmal jährlich müssen sie sich auf einer Mitgliederversammlung die Zustimmung für ihre Aktivitäten (Entlastung)
einholen, für die eine 2/3-Mehrheit erforderlich ist.
Der Jahresbericht wird von einem/r Vertreterin eines jeden Vollmitglieds unterzeichnet.
Art. 14. Arbeitsgruppen. Der Vorstand kann für zeitlich befristete Projekte Mitglieder als Teil einer Arbeitsgruppe
bestimmen. Ihnen obliegen
- Anträge auf Bewilligung von Stipendien bei der Europäischen Kommission;
- tägliche Aufzeichnungen und Einrichtung einer finanziellen Berichterstattung;
- tägliche Verwaltung der Internetseite;
- Weiterleitung von Informationen an die Internetseite, an Blogs, Newsletters etc.;
- Projektkoordination für die Publikation von Katalogen, Büchern und die Übersetzung von Texten.
Diese Gruppen müssen den Vorstandsmitgliedern regelmäßig berichten.
Art. 15. Gemeinsame Projekte. Gemeinsame Projekte oder EMoP Projekte gelten als „gemeinsam“, wenn sie von
mindestens drei Mitgliedern getragen, und finanziert werden
Im Fall einer Ausstellung wird erwartet,
- dass die Ausstellung in den bestmöglichen Räumlichkeiten der jeweiligen Partnerstadt stattfindet;
- dass die Ausstellung allen Ansprüchen gerecht wird, was Größe und Qualität betrifft;
- dass sich jedes Mitglied verpflichtet, zusätzlich zu der vereinbarten Summe für die Gemeinschaftsaufgaben einen
entsprechenden Beitrag für die Realisierung der jeweiligen Ausstellung in der eigenen Stadt zu leisten;
- dass die Gestaltung und der Druck eines Katalogs von einem renommierten Unternehmen durchgeführt wird;
- dass eine gemeinsame Kommunikationsstrategie gewählt wird und sich alle Partnerstädte einig sind in Bezug auf
Werbung und Internetpräsenz;
- dass die teilnehmenden Künstlerinnen zur Eröffnung eingeladen werden;
- dass das EMoP-Logo auf den Schriftstücken gut sichtbar und von entsprechender Größe ist;
- dass EU-Gelder oder andere Fördermittel und Sponsorengelder ausschließlich für das Projekt verwendet und unter
den teilnehmenden Partnerstädten gleichmäßig aufgeteilt werden.
Alle Kosten, die in einem direktem Zusammenhang mit der Ausstellung eines Vollmitglieds stehen, z.B. die Anmietung
eines geeigneten Ausstellungsraums, Versicherungen, Werbekosten, Produktionskosten, für die jede Stadt ihre eigenen
Kriterien anwendet, sind nicht Teil des gemeinsamen Budgets.
Unterschriften und Daten:
Vollmitglieder:
Den 22.10.13.
Kulturprojekte Berlin GmbH, Berlin
Herr Moritz van Dülmen
<i>Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin GmbHi>
50697
L
U X E M B O U R G
Den 14.10.13.
Fotofo, o.z. / Central European House of Photography, Bratislava
Herr Vaclav Macek
<i>Direktori>
Den 8.10.13.
Vereinigung Ungarischer Fotografen, Budapest
Herr Zsolt Szamody
<i>Vorsitzender der Vereinigung Ungarischer Fotografeni>
Den 8.10.13.
Photon Association, Ljubljana
Herr Dejan Sluga
<i>Direktori>
Den 9.10.13.
Café-Crème asbl, Luxemburg
Herr Paul di Felice / Herr Pierre Stiwer
<i>Direktoreni>
Den 17.12.13.
Kulturabteilung der Stadt Wien
Herr Bernhard Denscher
<i>Leiter der Kulturabteilung der Stadt Wieni>
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 février 2014. Relation: EAC/2014/1945. Reçu douze euros 12,00 €.
Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2014025976/455.
(140031861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2014.
KPI Retail Property 25 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 114.515.
In the year two thousand and thirteen, on the twentieth day of December.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. “Babcock & Brown European Investments S.à r.l.”, having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 109.507, holder of two
hundred thirty-five (235) shares,
And
2. “GRE Management GmbH”, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) duly organised
and incorporated and validly existing under the laws of Germany, having its registered office at 10, Weissenburger Strasse,
D-81667 Munich and registered with the local court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under number HRB
173219, holder of fifteen (15) shares,
here duly represented by Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally at Luxembourg, by virtue of two
(2) proxies given under private seal on 26 November 2013 and 18 November 2013.
Said proxies after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.
The appearing parties, represented as aforesaid, are the shareholders of “KPI Retail Property 25 S.à r.l.”, having its
registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER
notary residing in Luxembourg, on 17 February 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Number 976 on 18 May 2006,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 114.515 (the “Company”).
The Shareholders, represented as aforesaid, request the undersigned notary to act resolutions contained into agenda
as following:
<i>Agenda:i>
1. Waiver of convening notices.
50698
L
U X E M B O U R G
2. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation.
3. Appointment of one Liquidator and determination of his powers.
4. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders decide to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (the “Liquida-
tion”).
<i>Third resolutioni>
The Shareholders appoint Mr. Mark Hatherly, company director, born in New Zealand on November 13
th
1965,
professionally residing at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, to assume the role of liquidator of the Company (the
“Liquidator”).
The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on
commercial companies of 10 August 1915 (the "Law"). He can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the
Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.
The Liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.
He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxy parts of
his powers which he will define and for the duration fixed by him.
The shareholders further resolve to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance
payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article
148 of the Law.
When the liquidation is complete, the Liquidator shall make a report to the general meeting of the shareholders, in
accordance with article 151 of the Law.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Expensesi>
All the expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated
at approximately nine hundred and twelve euro (EUR 912.-).
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt décembre.
Pardevant Maître Paul Decker, notaire, de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. «Babcock & Brown European Investments S.à r.l.», ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 109507, propriétaire de
deux cent trente-cinq (235) parts sociales,
Et
2. «GRE Management GmbH», une société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège social à 10,
Weissenburger Strasse, D-81667 Munich, immatriculée auprès du tribunal d'instance de Munich (Amtsgericht München)
sous le numéro HRB 173219, propriétaire de 15 (quinze) parts sociales de la Société,
ici représentées par Mlle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
de deux (2) procurations données sous seing privé le 26 novembre 2013 et 18 novembre 2013.
Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire agissant au nom des parties comparantes
et par le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Les parties comparantes, représentées comme ci-avant, sont les associés (les «Associés») de «KPI Retail Property 25
S.à r.l.», ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, constituée suivant un acte de Maître Joseph
50699
L
U X E M B O U R G
ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 976 en date du 18 mai 2006,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.515 («la Société»).
Les Associés, représentées comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter les points contenus dans l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du Jour:i>
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société.
3. Nomination d'un liquidateur de la Société et définition de ses responsabilités.
4. Divers.
<i>Première résolutioni>
L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-
vocation, les associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué en avance.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident la dissolution de la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (la «Liquida-
tion»).
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de nommer Monsieur Mark Hatherly, gérant, né à Auckland, Nouvelle Zélande, le 13 novembre
1965, ayant son siège professionnel à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, d'assumer le rôle du liquidateur de la
Société (le «Liquidateur»).
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés com-
merciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi"). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de
liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.
Lorsque la Liquidation sera terminée, le Liquidateur prépare un rapport à l'assemblée générale conformément à l'article
151 de la Loi.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de neuf cent douze
euros (912,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentaire par
son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. PIERRU, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23.12.2013. Relation: LAC/2013/59567. Reçu 12.-€ (douze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
Luxembourg, le 19.02.2014.
Référence de publication: 2014026130/130.
(140031647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2014.
50700
L
U X E M B O U R G
ECP Europe & North Africa Food & Beverage Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 184.585.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-ninth day of November.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
- ECP Africa Fund III PCC, a protected cell company, having its registered office at IFS Court, TwentyEight, Cybercity,
Ebene Mauritius, and registered with the Registrar of Companies under number 81608 C1/GBL, here duly represented
by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under
private seal.
The before said proxy, being initialed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of
association of a “société à responsabilité limitée” which such party declares to incorporate.
Name - Object - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, private limited liability company (the “Company”),
governed by the present articles of association (the “Articles”) and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular
the law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and
of 28 December 1992 on “sociétés à responsabilité limitée” (the “Commercial Companies Law”).
Art. 2. The Company’s name is “ECP Europe & North Africa Food & Beverage Sarl”.
Art. 3. The Company’s purpose is:
(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other,
Luxembourg or foreign companies or enterprises;
(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other
way any securities, rights, patents and licenses and other property, rights and interest in property as the Company shall
deem fit;
(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the
Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;
(4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;
(5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same
group of companies than the Company (the “Affiliates”) any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case,
even in favour of a third-party lender of the Affiliates);
(6) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; and
(7) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment
of the above objects or any of them.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board
of managers or the sole manager (as the case may be).
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required by the Law.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in the Grand Duchy
of Luxembourg and abroad.
In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.
50701
L
U X E M B O U R G
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Capital - Shares
Art. 8. The Company’s share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 125
(one hundred twenty-five) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the
extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the con-
ditions required for amendment of the Articles.
Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-
reholding.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred “inter vivos” to non-shareholders unless shareholders representing at least three quar-
ter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders
or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital
or of the class of shares concerned represented by their shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the Law or of the Articles.
Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.
Management
Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and of one or several category B
manager(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.
The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager or category B manager, and her/his/its/their
remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes
cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution
taken at the same majority conditions.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and “ad nutum”,
remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole
shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).
In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of one category A manager and one category B manager.
The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate her/his/its
powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
50702
L
U X E M B O U R G
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall have a casting
vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board
of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who
needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the
time set for such meeting except in the event of urgency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the
meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, electronic means or by any
other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, electronic means or by any other suitable communication
means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, or electronic means or any other
suitable communication means, another manager as his/her/its proxy.
A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,
including at least one category A manager and one category B manager.
Decisions of the board of managers are adopted by the majority of the managers participating to the meeting or duly
represented thereto including at least one category A manager and one category B manager.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman
or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed
by the chairman or one category A manager and one category B manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a
managers’ meeting.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, electronic means, or any other suitable telecommuni-
cation means.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.
General meetings of shareholders
Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than 25 (twenty-
five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted
in writing or by fax, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in
writing.
If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the
shareholders. In such a case 1 (one) general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within 6 (six) months
of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of
Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.
Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the
board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half
of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.
50703
L
U X E M B O U R G
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.
Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken
in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened
or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,
at a majority of shareholders representing at least threequarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-
reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company’s financial year begins on 1 January and closes on 31 December.
Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up
the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.
At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,
which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders’ number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen)
days preceding the annual general meeting of shareholders.
Supervision of the company
Art. 20. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to
one or more statutory auditor(s) (“commissaires”), who may or may not be shareholder(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following
their appointment dealing with the approval of the annual accounts.
At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function
by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.
Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies
Register, as amended, are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors
(“réviseurs d’entreprises agréés”) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case
may be) amongst the qualified auditors registered in the Financial Sector Supervisory Commission (“Commission de
Surveillance du Secteur Financier”)’s public register.
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/her/its/their mandate.
Dividend - Reserves
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.
The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case
may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,
or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
50704
L
U X E M B O U R G
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the
sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.
Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters
of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
shareholders proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2014.
<i>Subscription - Paymenti>
ECP Africa Fund III PCC here represented as mentioned above, subscribes to 125 (one hundred twenty-five) shares.
The shares having been fully paid up in cash, so that the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is
at the disposal of the Company.
<i>Description of the contributioni>
The contribution made by ECP Africa Fund III PCC against the issuance of shares in the Company is composed of EUR
12,500 (twelve thousand five hundred Euro) in cash.
<i>Evidence of the contribution’s existencei>
Proof of the contribution’s existence has been given.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entirety of
the subscribed capital, passed the following resolutions:
1) Are appointed as category A managers:
- Mr. Hurley Doddy, private employee, with professional address at 1602 L Street, NW, 6
th
Floor, Washington, DC
2003, United States of America, manager of category A;
- Mrs. Essia Ayadi, private employee, with professional address at c/o ECP, Immeuble Miniar, Bloc B, 2
ème
étage, rue
du Lac d'Ourmia, Les Berges du Lac, Tunis, Tunisia, manager of category A;
- Mrs. Carolyn Campbell, director, with professional address at 1602 L Street, NW, 6
th
Floor, Washington, DC 2003,
United States of America, manager of category A;
2) Is appointed as category B manager:
- Mr. Harald Charbon, private employee, with professional address at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
The managers shall serve for an undetermined duration.
According to article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of one category A manager
and one category B manager.
3) The Company shall have its registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.
50705
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxyholder signed with us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille treize, le vingt-neuvième jour de novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire public résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
Comparaît:
- ECP Africa Fund III PCC, une "protected cell company", ayant son siège social sis à IFS Court, TwentyEight, Cybercity,
Ebene Mauritius, et immatriculée auprès du Registre des Sociétés sous le numéro 81608 C1/GBL, ici dûment représentée
par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, résidant à Esch-sur-Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée
au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire de dresser les statuts suivants d'une société à
responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.
Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts
(les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et celle du 28 décembre
1992 sur les sociétés à responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).
Art. 2. La dénomination de la société est "ECP Europe & North Africa Food & Beverage Sarl".
Art. 3. L'objet de la Société est:
(1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;
(2) D'acquérir par voie de participations, d'apports, de souscriptions, de prises fermes ou d'options d'achats, de né-
gociations et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels
et intérêts, comme la Société le jugera utile;
(3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix
que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;
(4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;
(5) D'octroyer à toute société holding, filiale, ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou
à toute société appartenant au même groupe de sociétés que la Société (les «Affiliées»), tous concours, prêts, avances
ou garanties (dans ce dernier cas, même en faveur d’un tiers-prêteur des Affiliées);
(6) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute
somme empruntée; et
(7) De manière générale, de faire toutes autres choses que la Société juge circonstanciel ou favorable à la réalisation
des objets ci-dessus décrits ou à l’un quelconque d’entre eux.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs pré-décrits aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. La Société a son siège social établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou du gérant
unique (selon le cas).
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger
par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés ou de l’associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises par la Loi.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures pro-
visoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
demeurera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le
conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) de la Société.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
50706
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers de tout associé de la Société ne pourront, pour quelque
motif que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière
dans les actes de sa gestion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées des associés ou de l’associé unique (selon le cas).
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à 12.500 EUR (douze-mille cinq cents Euro) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts
sociales d’une valeur nominale de 100 EUR (cent Euro) chacune.
Le montant du capital social peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés ou de l’associé unique (selon le cas), adoptée selon les conditions requises pour la modification
des Statuts.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a un droit de vote proportionnel au
nombre de parts sociales qu'il détient.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire des associés ou de l’associé unique
(selon le cas), adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition qu'un tel rachat ait été
proposé à chaque associé de même catégorie en proportion de sa participation dans le capital social ou de la catégorie
de parts sociales concernée, représentée par ses parts sociales.
Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales devant être rachetées, le rachat ne pourra
être décidé que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin
du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes
sommes relevant de réserves disponibles à cet effet, et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en
réserve conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.
Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance composé d’un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et d’un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérant
(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désigné(s) comme gérant(s) de catégorie A ou gérant(s) de catégorie B, et sa/
leur rémunération est fixée par résolution de l’assemblée générale des associés prise à la majorité simple ou par décision
de l’associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée dans les mêmes conditions de
majorité.
L'assemblée générale des associés ou l’associé unique (selon le cas) peut, «ad nutum» et à tout moment, révoquer et
remplacer tout gérant.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou à l’associé unique (selon le cas)
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir en
toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec
l’objet social de la Société dans la mesure où les dispositions de ces Statuts auront été respectées.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses
pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) «ad hoc» qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé
(s) ou gérant(s) de la Société.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération
(s'il y a lieu) de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d'égalité de voix, aura un vote prépon-
dérant. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de
gérance sera présidé par un gérant présent et nommé à cette fonction. Il peut également choisir un secrétaire, lequel
50707
L
U X E M B O U R G
n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de rédiger les procès verbaux des réunions du conseil de gérance
ou de l’exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation donnée par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux)
jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans
le procès verbal de la réunion du conseil de gérance.
Toute convocation devra spécifier l’heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par fax, moyens électroniques ou par tout
autre moyen de communication approprié.
Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par fax, moyens électroniques ou par tout autre moyen
de communication approprié.
La réunion du conseil de gérance se tiendra valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou dûment
représentés.
Une convocation spécifique n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance qui se tiendront à l’heure et au
lieu précisés dans une précédente résolution du conseil de gérance.
Tout gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par fax, moyens électro-
niques ou tout autre moyen de communication approprié un autre gérant pour le représenter.
Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen
de communication approprié permettant à l’ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer
simultanément, à condition qu'une majorité de gérants n'assiste jamais à la réunion tout en étant située dans une même
juridiction étrangère.
Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si la majorité des gérants y est présente ou re-
présentée, dont au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants participant au conseil ou y étant représentés,
incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites dans un procès-verbal, qui est signé par le président ou par
un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le
président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans de tels cas, les résolutions écrites peuvent être documentées soit dans un seul et même document, soit dans
plusieurs documents séparés ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire, fax, moyens électroniques ou tout autre moyen
de télécommunication approprié.
Art. 14. Aucun gérant ne contracte en raison de sa fonction d’obligation personnelle quant aux engagements réguliè-
rement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l’exécution de son
mandat.
Assemblée générale des associés
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq).
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou
par fax, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Chaque associé émettra son vote
par écrit.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des
associés. Dans ce cas 1 (une) assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du
dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg à
l’heure et au jour fixé dans la convocation à l’assemblée.
Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites d’associés sont proposées
par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société.
Une convocation écrite convoquant une assemblée générale et indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la
Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l’assemblée, sauf pour l’assemblée générale annuelle
pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt-et-un) jours avant la date de l’assemblée.
50708
L
U X E M B O U R G
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l’assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par fax, moyens électro-
niques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou sur première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée, et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale
extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé
unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L'exercice social commence 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui
contiendra l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes du (des) gérant(s), du (des) commissaire(s) (s'il en existe) et du (des) associé(s) envers
la Société.
Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes
qui sera soumis à l’assemblée générale des associés avec le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze)
jours précédant l’assemblée générale annuelle des associés.
Surveillance de la société
Art. 20. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs
commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.
Chaque commissaire aux comptes sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale
annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l’approbation des comptes annuels.
A l’expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) aux comptes pourra/pourront
être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés ou de l’associé
unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l’ap-
probation des comptes annuels.
Lorsque les seuils de l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés, telle que
modifiée, seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises
agréé(s) nommés par l’assemblée générale des associées ou l’associé unique (selon le cas), parmi les membres inscrits au
registre public des réviseurs d’entreprises agréés tenu par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent
être nommés par résolution de l’assemblée générale des associés ou l’associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).
Dividendes - Réserves
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil d’un dixième.
L’assemblée générale des associés, à la majorité déterminée par la Loi, ou l’associé unique (selon le cas) peut décider
à tout moment que l’excédent soit distribué entre l('/es) associé(s) au titre de dividendes au pro rata de leur participation
dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
50709
L
U X E M B O U R G
Art. 22. Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’assemblée générale des associés de la Société ou l’associé
unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.
Dissolution - Liquidation
Art. 23. L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l’associé
unique (selon le cas), peut décider de la dissolution de la Société.
Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l’approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois-quarts
du capital social devra désigner un ou plusieurs liquidateurs, personne(s) physique(s) ou morale(s), et déterminer la
méthode de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateur(s) et leur rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata des parts sociales qu'ils
détiennent.
Loi applicable
Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2014.
<i>Souscription - Paiementi>
ECP Africa Fund III PCC, ici représentée comme mentionné ci-dessus, souscrit aux 125 (cent vingt-cinq) parts sociales.
Les parts sociales ont été entièrement payées par apport en numéraire, de sorte que la somme de 12.500 EUR (douze-
mille cinq cents Euro) est à la disposition de la Société.
<i>Description de l’apporti>
L’apport fait par ECP Africa Fund III PCC en échange de l’émission des parts sociales de la Société consiste en la somme
de 12.500 EUR (douze-mille cinq cents Euro) en numéraire.
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Preuve de l’existence de l’apport a été donnée.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé de la Société, représentant la totalité du capital social
souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de catégorie A:
- M. Hurley Doddy, employé privé, demeurant professionnellement au 1602 L Street, N.W., 6
th
Floor, Washington,
DC 2003, Etats-Unis d'Amérique, gérant de catégorie A;
- Mme. Essia Ayadi, employée privée, demeurant professionnellement au c/o ECP, Immeuble Miniar, Bloc B, 2
ème
étage, rue du Lac d'Ourmia, Les Berges du Lac, Tunis, Tunisia, gérante de catégorie A;
- Mme. Carolyn Campbell, directrice, demeurant professionnellement au 1602 L Street, NW, 6
th
Floor, Washington,
DC 2003, Etats-Unis d'Amérique, gérante de catégorie A;
2) Est nommé gérant de catégorie B de la Société:
- M. Harald Charbon, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article 12 des Statuts, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un
gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.
3) Le siège social de la Société est établi au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
50710
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare que sur demande de la personne comparante, les présents
Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de cette même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date figurant au commencement de ce document.
Le document ayant été lu au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16047. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014025987/549.
(140031667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2014.
CPPE Carbon Process & Plant Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.
R.C.S. Luxembourg B 137.066.
<i>Auszug der Beschlusss des Verwaltungsrates vom 30. Oktober 2013.i>
Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Aktiengesellschaft "CPPE Carbon Process & Plant Engineering S.A.", mit Sitz
in L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg («Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg») Nummer B 137.066, haben einstimmig folgenden Beschluss
genommen:
<i>Einziger Beschlussi>
Der Verwaltungsrat beschliesst das Mandat des Delegierter des Verwaltungsrates Herr Alain STRICKROTH, Ingenieur,
geboren in Düdelingen, am 17. Mai 1965, wohnhaft in L-3429 Düdelingen, 90, route de Burange, zu erneuern.
Sein Mandat erlischt nach der ordentlichen Gesellschafterversammlung welche im Jahre 2019 abgehalten werden wird.
Luxemburg, den 30. Oktober 2013.
Alain Strickroth / Bruno Schumm / Egbert Montag / Peter Wanken
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2014033611/19.
(140038141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.
Soficomex Holding S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Soficomex Holding Spf S.A.).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 23.052.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-second day of the month of January;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of “Soficomex Holding Spf S.A.”, a public limited
company (“société anonyme”), qualified as family wealth management company (“société de gestion de patrimoine fami-
lial”), governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-1449
Luxembourg, 18, rue de l'Eau, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under the
number 23052, (the”Company”), originally incorporated under the name of “SOCIETE FINANCIERE POUR LE COM-
MERCE EXTERIEUR EN AFRIQUE”, in abbreviation “SOFICOMEXA”, pursuant to a deed of Me Marc ELTER, notary
then residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on July 2, 1985, published in the Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, number 246 of August 28, 1985,
and whose articles of association (the “Articles”) have been amended pursuant to deeds:
- of Me Léon Thomas called Tom METZLER, notary then residing in Luxembourg-Bonnevoie (Grand Duchy of Lu-
xembourg), on November 30, 1989, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number
139 of April 27, 1990, containing the change of the corporate name into “SOCIETE FINANCIERE POUR LE COMMERCE
EXTERIEUR”, in abbreviation “SOFICOMEX”;
50711
L
U X E M B O U R G
- of Me André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary then residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
on December 29, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 699 of August 30,
2001, containing the change of the corporate name into “Soficomex Holding S.A.”;
- of Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on December 29, 2010,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 657 of April 7, 2011, containing notably the
transformation of the Company into a family wealth management company as well as the adoption of the current deno-
mination.
The Meeting is presided by Mr. Eric LECLERC, employee, residing professionally in L2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
The Chairman appoints Mr. Christophe JASICA, employee, residing professionally in L2370 Howald, 4, rue Peternel-
chen, as secretary.
The Meeting elects Mrs. Vanessa TIMMERMANS, employee, residing professionally in L2370 Howald, 4, rue Peter-
nelchen, as scrutineer.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Surrender of the tax regime on companies governed by the dispositions of the law of May 11
th
, 2007 concerning
the creation of a family wealth management company (“SPF”) and transformation of the Company into a fully taxable
financial participation company (“SOPARFI”), with effect on today's date;
2. Change of the denomination of the Company into “Soficomex Holding S.A.”;
3. Adoption by the Company of an unlimited duration;
4. Amendment of the corporate purpose in order to give it the following wording:
“The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and
foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any
kind, as well as the management, control and development of such participations.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.
The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and
debentures.
The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. Moreover, the company may
pledge its assets for the benefit of its associates/shareholders. It may also conduct all real estate transactions, such as
buying, selling, renting, development and management of real estate.
The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.”
5. Amendment of the statutory power of signature of the directors;
6. Increase of the share capital of the Company by an amount of thirteen Euros and thirty-one Cents (13.31 EUR) so
as to raise it from its present amount of thirty thousand nine hundred eighty-six Euros and sixty-nine Cents (30,986.69
EUR) to thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), without issuance of new shares, but by the increase of the nominal
value of the existing one thousand two hundred and fifty (1,250) shares up twenty-four Euros and eighty Cents (24.80
EUR);
7. Full payment of the capital increase by incorporation of free reserves;
8. Full restate of the articles of association in English and French;
9. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on
an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
50712
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Meeting decides:
- to surrender of the tax regime on companies governed by the dispositions of the law of May 11
th
, 2007 concerning
the creation of a family wealth management company (“SPF”) and to transform the Company into a fully taxable financial
participation company (“SOPARFI”), with effect on today's date;
- to change the Company's name into “Soficomex Holding S.A.”;
- to adopt for the Company an unlimited duration;
- to modify the purpose of the Company and to adopt in consequence for it the wording as reproduced under point
4) of the agenda; and
- to modify the statutory power of signature of the directors and to adopt in consequence for it the wording as
reproduced hereafter in article 12 of the restated Articles.
<i>Second resolutioni>
The Meeting decides to increase the share capital by an amount of thirteen Euros and thirty-one Cents (13.31 EUR)
so as to raise it from its present amount of thirty thousand nine hundred eighty-six Euros and sixty-nine Cents (30,986.69
EUR) to thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), without issuance of new shares, but by the increase of the nominal
value of the existing one thousand two hundred and fifty (1,250) shares up twenty-four Euros and eighty Cents (24.80
EUR).
The Meeting acknowledges that the capital increase realised here-before has been fully paid by capitalization of free
reserves in the aggregate amount of thirteen Euros and thirty-one Cents (13.31 EUR).
The evidence of existence of such reserves has been proved to the undersigned notary by accounting documents of
the Company.
All powers are conferred to the board of directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments.
<i>Third resolutioni>
The Meeting decides to proceed to a complete restate of the Articles, in English and French, and to give henceforth
to the said Articles the following wording:
“Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned person and all those that might become owners of the shares created hereafter,
a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of “Soficomex Holding S.A.”.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders'
meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, as well as the management, control and development of such participations.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.
The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and
debentures.
The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. Moreover, the company may
50713
L
U X E M B O U R G
pledge its assets for the benefit of its associates/shareholders. It may also conduct all real estate transactions, such as
buying, selling, renting, development and management of real estate.
The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented by
one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a nominal value of twenty-four Euros and eighty Cents (24.80
EUR) each.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders
voting with the same quorum as for the amendment of the articles.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law
prescribes the registered form.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Board of directors and statutory auditors
Art. 6. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only. If
the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a board of directors (“Board of Direc-
tors”) consisting of a minimum of three (3) directors (the “Directors”).
The number of directors is fixed by the General Meeting of Shareholders.
The General Meeting of Shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A Director
(s) and class B Director(s). Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the relevant
meeting and the Directors be identified with respect to the class they belong.
The Directors are to be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years
and until their successors are elected.
Decision to suspend or dismiss a Director must be adopted by the General Meeting of Shareholders with a majority
of more than one-half of all voting rights present or represented.
When a legal person is appointed as a Director of the Company, the legal entity must designate a permanent repre-
sentative (représentant permanent) in accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors'
meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the
chairman has a casting vote.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the
debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August
10
th
, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the com-
petence of the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders of the company.
Art. 12. Towards third parties, the Company is validly bound, in case of a sole director, by the sole signature of the
Sole Director, or by the joint signature of any two Directors of the Company, or by the signature(s) of any other person
(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means of an unanimous decision of the Board of
Directors.
In the event the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely class A Directors
and class B Directors) the Company will only be validly bound by the joint signature of two Directors, one of whom shall
50714
L
U X E M B O U R G
be a class A Director and one be a class B Director (including by way of representation), or by the signature(s) of any
other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means of an unanimous decision of
the Board of Directors.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by
the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed
by law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the
convening notice on the 3
rd
Thursday of the month of June at 10:30 a.m..
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the
written request of shareholders representing at least ten percent of the company's share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in
case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on January 1
st
and ends on December 31
st
of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.
Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such
contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong
to the usufructuary.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these
articles of incorporation do not provide for the contrary.”
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to
speak, the Chairman then adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand four
hundred Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
50715
L
U X E M B O U R G
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois de janvier;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de “Soficomex Holding Spf S.A.”, une société
anonyme, qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 23052, (la “Société”), constituée originairement sous le nom de “SOCIETE
FINANCIERE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR EN AFRIQUE”, en abrégé “SOFICOMEXA”, en vertu d'un acte reçu
par Maître Marc ELTER, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 12 juillet 1985,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 246 du 28 août 1985,
et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifies suivant actes reçus:
- par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de
Luxembourg), le 30 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 139 27
avril 1990, contentant le changement de la dénomination sociale en “SOCIETE FINANCIERE POUR LE COMMERCE
EXTERIEUR”, en abrégé “SOFICOMEX”;
- par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Lu-
xembourg), le 29 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 699 du 30 août
2001, contentant le changement de la dénomination sociale en “Soficomex Holding S.A.”;
- par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 29 décembre
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 657 du 7 avril 2011, contenant notamment la
transformation de la Société en société de gestion de patrimoine familial ainsi que l'adoption de la dénomination actuelle.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric LECLERC, employé, demeurant professionnellement à L2370 Howald, 4,
rue Peternelchen.
Le Président désigne Monsieur Christophe JASICA, employé, demeurant professionnellement à L2370 Howald, 4, rue
Peternelchen, comme secrétaire.
L'Assemblée choisit Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement à L2370 Howald, 4,
rue Peternelchen, comme scrutatrice.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Abandon du régime fiscal sur les sociétés régies par les dispositions de la loi du 11 mai 2007 concernant la création
d’une société de gestion de patrimoine familial (“SPF”) et transformation de la Société en société de participation financière
pleinement imposable (“SOPARFI”), avec effet en date de ce jour;
2. Changement de la dénomination de la Société en “Soficomex Holding S.A.”;
3. Adoption par la Société d'une durée illimitée;
4. Changement de l'objet social afin de lui donner la teneur suivante:
“La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-
geoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle peut également donner ses avoirs
en gage, dans l’intérêt de ses associés/actionnaires. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles
que l’achat, la vente, la location, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.”
5. Modification du le régime de signature statutaire des administrateurs;
50716
L
U X E M B O U R G
6. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de treize Euros et trente et un Cents
(13,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents
(30.986,69 EUR) à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), sans émission d'actions nouvelles, mais par l'augmentation de
la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes à vingt-quatre Euros et quatre-vingts Cents
(24,80 EUR);
7. Libération intégrale de l'augmentation de capital par incorporation de réserves libres;
8. Refonte complète des statuts en anglais et français;
9. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide:
- d'abandonner le régime fiscal sur les sociétés régies par les dispositions de la loi du 11 mai 2007 concernant la création
d’une société de gestion de patrimoine familial (“SPF”) et de transformer la Société en société de participation financière
pleinement imposable (“SOPARFI”), avec effet en date de ce jour;
- de changer la dénomination de la Société en “Soficomex Holding S.A.”;
- d'adopter pour la Société une durée illimitée;
- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du
jour sous le point 4); et
- de modifier le régime de signature statutaire des administrateurs et d'adopter en conséquence pour lui la teneur
comme reproduite dans ci-après dans l'article 12 des statuts refondus.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'une montant de treize Euros et trente et un Cents
(13,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents
(30.986,69 EUR) à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), sans émission d'actions nouvelles, mais par l'augmentation de
la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes à vingt-quatre Euros et quatre-vingts Cents
(24,80 EUR).
L'Assemblée reconnaît que l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été intégralement libérée moyennant incor-
poration au capital de réserves au montant total de treize Euros et trente et un Cents (13,31 EUR).
La justification de l'existence de ces réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de procéder à une refonte complète des Statuts, en anglais et français, et de donner dorénavant
auxdits Statuts la teneur suivante:
“Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital.
Art. 1
er
. Entre la personne ci-avant désignée et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de “Soficomex Holding S.A.”.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.
50717
L
U X E M B O U R G
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle peut également donner ses avoirs
en gage, dans l’intérêt de ses associés/actionnaires. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles
que l’achat, la vente, la location, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions avec une valeur nominale de vingt-quatre Euros et quatre-vingts Cents (24,80 EUR) chacune.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique
seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, elle est administrée par un conseil d'administration (le “Conseil d'Admi-
nistration”) composé de trois (3) Administrateurs au moins (les “Administrateurs”).
Le nombre des administrateurs est déterminé par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
L'Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de nommer des Administrateurs de deux classes différentes, à
savoir un ou des Administrateur(s) de la classe A et un ou des Administrateur(s) de la classe B. Toute classification
d'Administrateurs doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Administrateurs
doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
Les Administrateurs doivent être nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une durée qui ne peut
dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.
La décision de suspendre ou de révoquer un Administrateur doit être adoptée par l'Assemblée Générale des Action-
naires à la majorité simple de tous les droits de vote présents ou représentés.
Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-
sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, e-mail ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
50718
L
U X E M B O U R G
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration
et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l'assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'Administrateur Unique, selon le
cas, ou par la signature conjointe de deux Administrateurs de la Société ou par la/les signature(s) de toute(s) personne
(s) à qui un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d'Administration moyennant une décision unanime du
Conseil d'Administration.
Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à savoir
les Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la
signature conjointe d'un Administrateur de classe A et d'un Administrateur de classe B (y compris par voie de repré-
sentation), ou par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à qui un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil
d'Administration moyennant une décision unanime du Conseil d'Administration.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le 3
ème
jeudi du mois de juin à 10.30 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le com-
missaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant au moins dix pour cent du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l'usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.
Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l'usufruitier.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
50719
L
U X E M B O U R G
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.”
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille quatre cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. LECLERC, JASICA, TIMMERMANS, C. WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 janvier 2014. LAC/2014/4098. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 18 février 2014.
Référence de publication: 2014026305/479.
(140031196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2014.
Armadillo Lux Holding S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 3.600.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 107.516.
In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of December.
Before the undersigned, Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Armadillo Lux Holding S.A., a public limited
liability company (société anonyme) having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered
with Register of Commerce and Companies under number B 107516 (the Company).
The Company was incorporated on April 12, 2005 pursuant to a deed drawn up by Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 876 of September 10. 2005. The Company’s articles of association (the Articles)
have been amended since its incorporation and the last time on March 31
st
, 2006, pursuant to a deed of Maître André-
Jean-Joseph Schwactgen, prenamed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1229 of
26 June 2006.
The Meeting was chaired by Mr. Régis Galiotto, professionally residing in Luxembourg.
The chairperson appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Solange Wolter-Schieres, professio-
nally residing in Luxembourg.
The Meeting’s officers having thus been appointed, the chairperson declares and requests the notary to state:
I. that the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list signed by the shareholders or their authorized representatives, the Meeting’s officers and the notary. This
attendance list and the powers of attorney will be registered with this deed;
50720
L
U X E M B O U R G
II. that it appears from the attendance list that all the shares are represented. The Meeting is thus regularly constituted
and may deliberate and decide on the items on the agenda;
III. that the agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of convening notices.
2. Dissolution of the Company.
3. Appointment of the liquidator.
4. Powers of the liquidator.
5. Instructions for the liquidator.
6. Full and complete discharge to the directors and the statutory auditor of the Company.
7. Miscellaneous
IV. that the Meeting has unanimously taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entire share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the
shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda
which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (liquidation volon-
taire).
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to appoint Fairland Property Limited, having its registered office at Offshore Incorporations
Centre, P.O. Box 957, Road Town (Tortola), British Virgin Islands, 62, and as the Company’s liquidator (the Liquidator).
The Liquidator is empowered, by its sole signature, to do whatever is required for the liquidation of the Company and
the disposal of its assets.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to grant the Liquidator all the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg law of
10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
The Liquidator is entitled to execute all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without the prior authorisation of the shareholders. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate
some of its powers to one or more persons or entities for specifically defined operations or tasks.
The Liquidator is authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the sha-
reholders, subject to the drawing-up of interim accounts.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to instruct the Liquidator to realise all the Company’s assets on the best possible terms and to
pay all its debts.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to grant full and complete discharge to the directors of the Company and to the statutory auditor
of the Company for the performance of their respective mandates from the date of their appointment until the date
hereof.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Shareholders, this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, said
appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille treize, le trente décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de Armadillo Lux Holding S.A., une société
anonyme dont le siège social se situe au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107516 (la Société).
50721
L
U X E M B O U R G
La Société a été constituée le 12 avril 2005, suivant acte reçu par André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 876 du 10 septembre 2005. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés depuis sa constitution et la
dernière fois le 31 mars 2006 suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, prénommé, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1229 du 26 juin 2006.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire et l’assemblée élit comme scrutateur Madame Solange Wolter-Schieres, de-
meurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l’Assemblée ayant été formé, le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre de leurs actions sont renseignés sur une liste de
présence signée par eux ou leurs représentants, par le bureau de l’assemblée et le notaire. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations seront enregistrées avec le présent acte;
II. qu'il ressort de la liste de présence que toutes les actions sont représentées. L’Assemblée est par conséquent
régulièrement constituée et peut délibérer et décider sur les points de l’ordre du jour;
III. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Dissolution de la Société.
3. Nomination du liquidateur.
4. Pouvoirs du liquidateur.
5. Instructions au liquidateur.
6. Décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
7. Divers.
IV. que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social de la Société étant représenté à l’Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de
convocation, les actionnaires se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir une
parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer Fairland Property Limited, dont le siège social se situe 62, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.166 comme
liquidateur de la Société (le Liquidateur). Le Liquidateur est autorisé à accomplir, sous sa seule signature, tout ce qui est
nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation de ses actifs.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, y compris celles prévues à
l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable des actionnaires. Le Liquidateur peut déléguer, sous sa seule responsa-
bilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou des tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes
physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser aux actionnaires des acomptes sur le boni de liquidation, à condition que des
comptes intérimaires soient établis.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide d'autoriser le Liquidateur à procéder dans les meilleures conditions à la réalisation de l’actif et au
paiement de toutes les dettes de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs de la Société et au commissaire aux
comptes de la Société pour l’exécution de leurs mandats depuis la date de leurs nominations jusqu'à la date des présentes.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la demande des actionnaires, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
50722
L
U X E M B O U R G
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 janvier 2014. Relation: LAC/2014/979. Reçu douze euros (12.- EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 février 2014.
Référence de publication: 2014032067/138.
(140036355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2014.
Ersel Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 73.017.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 Mars 2014i>
En date du 3 mars 2014, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Henri Ninove, de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux et de Monsieur
Danilo Vitali en qualité d’Administrateurs pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2015.
- de renouveler le mandat de Deloitte Audit Sàrl en qualité de Réviseur d’Entreprises agréé jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2015.
Luxembourg, le 3 mars 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Ersel Sicav
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2014033649/18.
(140037750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.
DBI Private Equity Fund S.A., Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 181.451.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 03 février 2014, Monsieur Mogens HOLM, ayant
pour adresse, 4, Rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur
Klaus Monsted PEDERSEN, démissionnaire.
Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.
Luxembourg, le 28 février 2014.
<i>Pour: DBI PRIVATE EQUITY S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Christine Racot
Référence de publication: 2014033627/17.
(140037658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.
European Paper Group s. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 7.254.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014032822/9.
(140036899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.
50723
L
U X E M B O U R G
CPPE Carbon Process & Plant Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.
R.C.S. Luxembourg B 137.066.
<i>Auszug des Gesellschafterversammlung vom 04. März 2014.i>
In der ausserordentlichen Gesellschafteversalung der Aktiengesellschaft "CPPE Carbon Process & Plant Engineering
S.A.", mit Sitz in L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Lu-
xemburg («Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg») Nummer B 137.066, haben die Aktionäre einstimmig
folgenden Beschluss genommen:
<i>Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst folgende Person als neues Verwaltungsratsmitglied zu ernennen:
Herrn Stefan Christoph SCHÖPPEL, geboren in Baumholder, am 19. Juni 1957, wohnhaft in L-2215 Luxembourg, 12,
Rue de Neuerburg.
Sein Mandat endet am Ende der ordentlichen Gesellschafterversammlung welche im Jahre 2019 abgehalten wird.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 04. März 2014.
Alain Strickroth / Egbert Montag.
Référence de publication: 2014033612/19.
(140038302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.
Bullball S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 112.922.
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 4 mars 2014 au siège social de la société, il a été décidé:
- de transférer le siège social de la Société du 19 - 21 Boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, vers le 20
RUE DE LA POSTE, L-2346 LUXEMBOURG, avec effet immédiat.
- d'accepter la démission de Madame Gabrielle Mingarelli et de Madame Emanuela Corvasce de leur fonction d'admi-
nistrateur avec effet immédiat;
- de nommer comme nouveaux administrateurs Monsieur Emmanuel Briganti, résidant 20 rue de la Poste L-2346
Luxembourg et Monsieur Benoit Dessy, demeurant 20 rue de la Poste, leur mandat ayant comme échéance l'assemblée
statuant sur les comptes au 31.12.2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BULLBALL S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2014033576/18.
(140038010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.
Cabinet Immobilier Schmitt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.
R.C.S. Luxembourg B 135.919.
<i>Extrait de la décision des associés adoptée le 6 janvier 2014i>
Conformément à la cession de parts sociales du 6 janvier 2014, Monsieur Stéphane Schmitt, agent immobilier, né à
Thionville (France), le 29 juin 1972, demeurant au 47, rue Camille Wampach, L-2739 Luxembourg a vendu 24 parts sociales
détenues dans la Société à Madame Catherine Baudain, ouvrière, née à Epinal (France), le 18 juin 1968, épouse de Monsieur
Stéphane Schmitt, demeurant au 47, rue Camille Wampach, L-2739 Luxembourg.
Le capital se trouve alors répartit comme suit:
- Madame Catherine BAUDAIN épouse SCHMITT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Luxembourg, le 6 janvier 2014.
<i>Pour la Gérancei>
Référence de publication: 2014033587/17.
(140038173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.
50724
L
U X E M B O U R G
Beaumonde S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5451 Stadtbredimus, 2, Massewee.
R.C.S. Luxembourg E 1.019.
Le siège social est transféré avec effet immédiat à l'adresse suivante: 2, Massewée L-5451 Stadtbredimus.
La nouvelle adresse privée de Madame Martine Muller est: 2, Massewée L-5451 Stadtbredimus.
La nouvelle adresse privée de Madame Ginette Hoffmann est: 9, Place des Sacrifiés L-4115 Esch/AIzette.
Suite à une cession de parts faite en date du 18 février 2014 par Madame Martine Muller, associé, en faveur de ses
enfants Nina Wagner, Paul Wagner et Felix Wagner, ces derniers sont associés à raison de 1 part chacun. Ceci portera
la participation de Madame Martine Muller dans le capital social à 7 parts.
L'adresse privée de Madame Martine Muller, de Mademoiselle Nina Wagner et de Messieurs Paul Wagner et Felix
Wagner est: 2, Massewée L-5451 Stadtbredimus.
L'adresse privée de Madame Ginette Hoffmann est: 9, Place des Sacrifiés L-4115 Esch/AIzette.
Luxembourg, le 19 février 2014.
Martine Muller
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014033555/19.
(140037869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.
ABC S.A., Alpha Business Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 110.908.
<i>Extrait des résolutionsi>
Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société en date du 04 novembre 2013:
1, L'Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes actuel de la société;
Fiscalité Comptabilité Gestion Sà rl (anciennement Fiscoges Sarl), ayant son siège social au 4, rue de Kleinbettîngen, L
- 8362 Grass, enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B61071.
2. L'Assemblée nomme un nouveau commissaire aux comptes de la société:
FISCOGES Sàrl, ayant son siège social au 4, rue de Kleinbettîngen, L - 8362 Grass, enregistrée au Registre de Commerce
et des sociétés sous le numéro B174051.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Signatures
Référence de publication: 2014033525/18.
(140037903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.
Churchgate Capital Partners, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 165.505.
Il résulte des résolutions circulaires du conseil de gérance du 16 décembre 2013 que Monsieur Christophe Lentschat,
né le 26.09.1972 à Thionville (France) et ayant son adresse professionnelle au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
a été co-opté gérant de la société avec effet au 1
er
mars 2014, en remplacement du gérant démissionnaire Monsieur
Simon Benney.
Le nouveau gérant reprend le mandat de son prédécesseur pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour le fonds
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014033321/17.
(140037603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2014.
50725
L
U X E M B O U R G
Alba Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 117.426.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 27 février 2014, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société ALBAi>
<i>PROPERTIES S.A.i>
- La démission de Mme Noeleen GOES-FARRELL de son mandat d'Administrateur a été acceptée avec effet au 31
janvier 2014.
- Monsieur Nicolas MILLE, employé privé, né le 8 février 1978 à Antony (France), résidant professionnellement au 127
rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, a été nommé Administrateur de la Société avec effet au 31 janvier 2014. Son
mandat prendra fin le 27 juin 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ALBA PROPERTIES S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014033294/18.
(140037345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2014.
Rockwell Collins International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 96.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 145.840.
<i>Extrait des résolutions de l'associé uniquei>
En date du 2 décembre 2013, l'associé unique a pris connaissance de la démission de Monsieur Gary R. Chadick en
tant que gérant de classe A de la société, et ce avec effet immédiat.
L'associé unique a nommé Monsieur Vaughn Michael Klopfenstein, né le 31 juillet 1962 en lowa, Etats-Unis d'Amérique,
demeurant professionnellement au 105 34
th
Street SE, Cedar Rapids, lowa 52403, Etats-Unis d'Amérique en tant gérant
de classe A, et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2014.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014033119/18.
(140037185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.
Promo Kappa 94 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 171.041.
En date du 25 novembre 2013, l'assemblée générale a décidé la révocation du mandat de Madame Sandy OTT, admi-
nistrateur de la Société, de nationalité luxembourgeoise, né le 20 août 1974 à Luxembourg, et de nommer Monsieur
Antoine DAVID, de nationalité française, né le 16 août 1963 à La Guerche en Bretagne (France), demeurant profession-
nellement au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, aux fonctions d'administrateur de la Société, ceci jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.
Suite à la révocation du mandat de Madame Sandy OTT, l'assemblée générale a décidé de nommer la société Albatross
Capital S.A., enregistrée sous le numéro B. 109273 au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, ayant son
nouveau siège social au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, comme nouveau Président du Conseil d'Administration,
en remplacement de Madame Sandy OTT, ceci jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2014.
Référence de publication: 2014033097/18.
(140036568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.
50726
L
U X E M B O U R G
Sokaris Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5553 Remich, 26-28, Quai de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 152.267.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung Abgehalten am Firmensitz Ausserordentlich am 26. Februar 2014i>
<i>um 14.00 Uhri>
Die Versammlung verlängert einstimmig bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2020 stattfinden wird, folgende
Mandate:
- Peter PEETERS, Verwaltungsratsmitglied und Delegierter des Verwaltungsrates, geboren am 09.12.1969 in Reet (BE),
wohnhaft in L-9461 Nachtmanderscheid, 1a, Veinerstrooss
- Marchje W. KOSTER, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 17.03.1955 in Reeuwijk (NL), beruflich wohnhaft in
L-5401 Ahn, 7, route du Vin
- Silke KOSTER, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 29.03.1981 in Trier (D), beruflich wohnhaft in L-5401 Ahn, 7,
route du Vin
Das Mandat des Aufsichtskommissars FIRELUX S.A., eingeschrieben im Handelsregister unter der Nummer B 84589,
mit Sitz in L-9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy wird ebenfalls verlängert bis zur Generalversammlung, die im Jahre
2020 stattfinden wird.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2014033168/22.
(140036848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.
Spectrum Media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 568.132,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 131.105.
L'adresse professionnelle de M. Jens Hoellermann, gérant de la Société, est désormais au 15, Jean-Pierre Brasseur,
L-1258 Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 31 janvier 2014:i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Nomination de Mme Deniz Erkus, résidant professionnellement au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg, né le 16 May 1965 à Istanbul, Turquie en qualité de gérant avec effet au 31 janvier 2014
et pour une durée indéterminée (en remplacement de Mme Anne-Cécile Jourdren Vasseur, démissionnaire).
Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:
- M. Simon Barnes, gérant
- Mme Deniz Erkus, gérant
- M. Jens Hoellermann, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014033150/20.
(140036789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.
Shurgard Holding Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.700,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 128.535.
La Société prend acte du changement d'adresse professionnelle de Mr. Marc OURSIN et Mr. Jean KREUSCH, gérants
B de la Société.
Dorénavant celle-ci est établie au 29 Breedveld, B -1702 Groot-Bijgaarden.
Munsbach, le 28/02/2014.
Référence de publication: 2014033140/12.
(140037295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.
50727
L
U X E M B O U R G
WCG SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 147.887.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014033229/9.
(140036871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.
WCG SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 147.887.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014033230/9.
(140036885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.
Al Mi'yar Capital SA, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 140.210.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 26 février 2014i>
Le Conseil d'Administration accepte la démission de Johan Groothaert en tant qu'administrateur de la Société avec
effet au 26 février 2014.
Le Conseil d'Administration décide de coopter en tant que nouvel administrateur de la Société, avec effet au 26 février
2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014:
- Alain Delobbe, né le 2 Mars 1971 à Dinant, Belgique, avec adresse professionnelle au 33A, avenue J.F, Kennedy,
L-1855 Luxembourg.
À Luxembourg, le 28 février 2014.
Pour extrait conforme
La Société
Signatures
Référence de publication: 2014033524/18.
(140038081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.
Aaxxes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 125.297.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement commercial VI no 312/14 du 27 février 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième
section, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société AAXXES S.A.
en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.
Ledit jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, et désigné comme liquidateur Maître Laurent BIZZOTTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
Les créanciers sont invités à déposer leurs déclarations de créances au greffe du tribunal de commerce de ce siège
avant le 20 mars 2014.
Luxembourg, le 3 mars 2014.
Pour extrait conforme
Laurent BIZZOTTO
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2014033287/19.
(140037568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2014.
50728
L
U X E M B O U R G
Carehb S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9175 Niederfeulen, 15C, rue de la Fail.
R.C.S. Luxembourg B 184.698.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU
1. Monsieur Claude Albert PHILIPPS, restaurateur/hôtelier, né à Esch-sur-Alzette le 25 avril 1963, demeurant à L-7545
Mersch, 27, rue Lohr,
2. Madame Irène PRICKAERTS, vendeuse, née à Pettingen, le 12 août 1961, demeurant à L-7545 Mersch, 27, rue Lohr.
Ci-après dénommés collectivement les «Comparants».
Lesquels Comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à
responsabilité limitée qu’ils entendent constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la «Société») et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la «Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. La Société a pour objet principal l’exploitation d’un commerce de café-restaurant avec débit de boissons al-
cooliques et non alcooliques.
Elle a aussi pour objet la réalisation et la livraison de repas, l’organisation d’évènements ainsi que la location de matériel
de la branche et la mise à disposition de personnel.
Elle pourra en outre accomplir toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financiè-
res, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’associés, d’entreprises liées,
de sociétés liées ou de tiers liés.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prendra la dénomination «CAREHB S.à r.l.».
La société exploitera l’enseigne commerciale «Café Restaurant Am Hennesbau».
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Feulen.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux, agences et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) représenté par CENT (100)
parts sociales d’une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ (125.- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital social de la Société peut être modifié à tout moment par une décision des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
à des tiers que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.
50729
L
U X E M B O U R G
Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés.
Le(s) gérant(s) est(sont) révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient.
Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier (1
er
) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre.
Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre (31), les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas
de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et
passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été toutes souscrites de la manière suivante:
1) Monsieur Claude Albert PHILIPPS, pré-qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 parts sociales
2) Madame Irène PRICKAERTS , pré-qualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ
CENTS EUROS (12.500.- EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence au jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2014.
50730
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les Comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE EUROS (1.000.- EUR).
<i>Avertissementi>
L’attention des Comparants a été expressément attirée par le notaire instrumentant sur la nécessité d’obtenir des
autorités compétentes les autorisations (notamment, autorisation de commerce et autorisation de débit de boissons
alcooliques) requises afin d’exercer les activités telles que décrites à l’article 2 des présents Statuts.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société et ce, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Claude Albert PHILIPPS, préqualifié.
La société est engagée en toutes circonstances par sa signature individuelle.
2) L'adresse de la Société est fixée à L-9175 Niederfeulen, 15C, rue de la Fail.
DONT ACTE, fait et passé à Beringen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux Comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ces derniers ont signé le présent acte avec le notaire.
Signés: C. PHILIPPS, I. PRICKAERTS, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 21 février 2014. Relation: MER / 2014 / 307. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): WEBER.
POUR COPIE CONFORME.
Mersch, le 24 février 2014.
Référence de publication: 2014027693/126.
(140033784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.
Oranje-Nassau Développement S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investisse-
ment en Capital à Risque.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 166.568.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 4 mars 2014.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2014033830/12.
(140038014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.
Prize Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.775,02.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 150.480.
Les comptes au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 Mars 2014.
Pour extrait conforme
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014034249/12.
(140038751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2014.
50731
L
U X E M B O U R G
Valindus S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Valindus S.A., SPF).
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 52.813.
L’an deux mille treize, le trente décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence demeurant à 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette,
Grand Duché de Luxembourg soussigné,
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonymesociété de gestion de patrimoine familial
VALINDUS S.A.-SPF, avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, Avenue Pasteur,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 52.813,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 novembre 1995, publié au Mémorial
c numéro 21 du 12 janvier 1996,
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du
03 février 2009, en date du 11 janvier 2010, publié au Mémorial C numéro 602 du 19 mars 2009.
La séance est ouverte à 9.45 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée
privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, avec
adresse professionnelle à Esch/Alzette.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse
professionnelle à Esch/Alzette.
Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000)
actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de deux cent mille euros (EUR
200.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations
préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance
de l’ordre du jour. Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent acte, pour être soumise en même
temps aux formalités de l’enregistrement.
Madame la Présidente requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
L'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1) Transformation de la société de gestion de patrimoine familial («SPF») en société anonyme de participation finan-
cière; suppression dans les Statuts de toute référence à la loi du 11 mai 2007 relative aux sociétés de gestion de patrimoine
familial («SPF»), à compter de ce jour;
2) Changement du libellé de l’objet social (article 2 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:
La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou
sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus
généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à
l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
3) Modification de la dénomination de la société en VALINDUS S.A. et modification de l’article 1
er
- 1
er
alinéa des
statuts pour lui donner la teneur suivante: il existe une société anonyme, sous la dénomination de VALINDUS S.A.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L’assemblée décide de transformer la société de gestion de patrimoine familial («SPF») en une société anonyme de
participation financière («Soparfi»), et de supprimer dans les Statuts toute référence à la loi du 11 mai 2007 relative aux
sociétés de gestion de patrimoine familial («SPF»), à compter de ce jour
50732
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième Résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’objet social et de retirer toute référence à la loi du 11 mai 2007 relative à la création
d’une société de gestion de patrimoine familiale («SPF») de sorte que l’article deux (2) des statuts ont dorénavant la
teneur suivante:
La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou
sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus
généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à
l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
<i>Troisième Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en VALINDUS S.A., de sorte que le premier alinéa de
l’article premier (1
er
) des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 1
er
. 1
er
alinéa. Il existe une société anonyme, sous la dénomination de VALINDUS S.A.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, elle a tout signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 janvier 2014. Relation: EAC/2014/497. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014032592/87.
(140035968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2014.
Alder Consultancy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 156.519.
DISSOLUTION
In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth of December.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Elizabeth Verwaltung S.à r.l, a société à responsabilité limitée company with registered office at 2a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, registered with the R.C.S.Luxembourg under number B 152.587, here represented by Mr
Erwin VANDE CRUYS, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by
virtue of a proxy signed under private seal.
Such proxy after signature "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company "Adler Consultancy S.à r.l.", R.C.S.
Luxembourg B 156.519, hereafter called "the Company", incorporated pursuant to a deed of Maître Paul BETTINGEN,
notary residing in Niederanven, dated October 25
th
, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, N° 2683 of December 7
th
, 2010.
- The corporate capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), divided into one hundred
(100) shares with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125) each, entirely subscribed and fully paid-in.
50733
L
U X E M B O U R G
- The appearing resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it
is fully aware of the financial situation of the Company.
- The appearing party, declares that the activity of the Company has ceased;
- That the here represented sole shareholder appoints himself as liquidator of the Company and acting in this capacity
requests the notary to authentify his declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities
in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with
respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay
all such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid. The liquidation
report will remain attached to the present deed.
- The declarations of the liquidator have been certificated, pursuant to a report that remains attached as appendix,
established by Castle Services S.àr.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 2a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, registered with the RCS Luxembourg under number B152622, appointed as "commissaire-
to-the-liquidation" by the sole shareholder.
- The appearing party hereby grants full discharge to the managers for their mandates up to this date.
- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 2a, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg.
- JTC (Luxembourg) S.A., is authorized in the name and on behalf of the sole shareholder to file any tax declaration,
notice to the trade register and any other documents necessary or useful for the finalisation of the liquidation.
Upon these facts the notary stated that the company "Alder Consultancy S.à r.l." was dissolved.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read and translated to the mandatories of the appearing party, said mandatories signed
with Us the notary, the present original deed.
Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes
Im Jahre zweitausendunddreizehn, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Grosherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Elizabeth Verwaltung S.à r.l, eine société à responsabilité limitée company mit Gesellschaftssitz in 2a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, eingetragen im Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 152.587, hier vertreten
durch Herrn Erwin VANDE CRUYS, Privatbeamter, beruflich wiohnhaft in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,
gemäss einer Vollmacht ausgestellt unter Privatschrift.
Welche Vollmacht, nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, den unterfertigten Notar gebeten hat folgendes zu beurkunden:
- Die Komparentin ist die alleinige Anteilsinhaberin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Alder Consultancy S.à
r.l.", R.C.S. Luxemburg B 156.519, nachfolgend "die Gesellschaft" genannt, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch
Maître Paul BETTINGEN, Notar mit Amtssitz in Niederanven, vom 25. October 2010, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, N° 2683 vom 7.Dezember 2010.
- Das Gesellschaftskapital ist augenblicklich festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500 EUR) eingeteilt in
einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (125 EUR) je Anteil, alle vollständig
gezeichnet und eingezahlt.
- Andurch erklärt die Komparentin die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.
- Die Komparentin erklärt, dass sie genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft besitzt.
- Der Komparent ernennt sich als Liquidator der Gesellschaft und in seiner Eigenschaft als Liquidator ersucht der
Komparent den unterzeichnenden Notar zu beurkunden, dass jegliche Passiva der Gesellschaft beglichen ist, wie dies aus
der Zwischenbilanz der Gesellschaft hervorgeht, und dass die Passiva im Zusammenhang mit dem Liquidationsabschluss
hinreichend unterlegt worden ist; desweiteren erklärt der Komparent sämtliche Aktiva zu übernehme und erklärt, dass
er für eventuell derzeit nicht bekannte und nicht beglichene Passiva der Gesellschaft einstehen wird und sich somit
verpflichtet, diese eventuelle Passiva zu begleichen. Der Liquidationsbericht wird dieser Urkunde beigefügt bleiben.
- Die vorstehenden Erklärungen wurden direkt von dem Liquidationsprüfer Castle Services S.àr.l., eine société à res-
ponsabilité limitée mit Gesellschaftssitz in 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister
Luxemburg unter der Nummer, überprüft, gemäß Bericht welcher gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt.
50734
L
U X E M B O U R G
- Die Komparentin erteilt den Geschäftsführern Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage.
- Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in 2a, rue
Albert Borschette, L-1246 Luxemburg aufbewahrt.
- JTC (Luxembourg) S.A., ist ermächtigt im Namen von und für die alleinige Anteilsinhaberin alle Steuererklärungen,
Mitteilungen an das Handelsregister und sämtliche anderen zum Zweck des Abschlusses der Liquidation notwendigen
oder dienlichen Dokumente registrieren zu lassen.
Somit hat der instrumentierende Notar die endgültige Auflösung der Gesellschaft "Alder Consultancy S.à r.l." festge-
stellt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-
genden Urkunde auf Wunsch der Komparentin in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er
bestätigt weiterhin, dass es der Wunsch der Komparentin ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text der englische Text Vorrang hat.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Bevollmächtigten der Komparentin, haben dierselben mit Uns Notar ge-
genwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: E. Vande Cruys et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2013. LAC/2013/59854. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri>
(signée): Irène Thill.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2014.
Référence de publication: 2014026453/102.
(140032345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2014.
Bogey Investissements S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 77.204.
EXTRAIT
Il résulte du Conseil d’administration tenu le 3 décembre 2013, que:
- La société ARTEMIS AUDIT & ADVISORY S.A.R.L.., 25A boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (RCS Luxembourg
N° B 166.716) a été nommée réviseur d’entreprises agrée avec effet immédiat et ce, pour une durée de 3 ans, en
remplacement de la société TEAMAUDIT S.A.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2014033571/13.
(140038403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.
CHERRY Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 134.287.
<i>Extrait des Résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires en date du 21 février 2014i>
- L’assemblée a décidé de reconduire le mandat de commissaire aux comptes Ernst & Young S.A., ayant son siège social
au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxem-
bourg sous le numéro B47771 jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31 mars
2014.
- Les mandats des administrateurs de
* Monsieur Antonis TZANETIS,
* Monsieur Michiel KRAMER,
* Monsieur Sven-Gunnar SCHOUGH,
sont renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31 mars 2014.
Référence de publication: 2014033599/17.
(140037734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.
50735
L
U X E M B O U R G
VeTC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 388.125,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 181.273.
Conformément à la cession des parts sociales du 14 février 2014, la société Venn Capital S.à r.l. avec adresse au 11-13
Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a transféré ses 388,125 parts sociales détenues dans la Société, à Timbercreek
UK VTEC LP, société constituée et existente à Ontario et enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés d’Ontario
sous le numéro 002394977, avec adresse au 1000 Yonge St., Suite 500, Toronto, Ontario M4W 2K2.
Le nouvel associé de la Société est Timbercreek UK VTEC LP, et la cession des parts sociales, a été reportée sur le
registre des associés de la Société.
De plus, conformément aux résolutions de l’actionnaire unique de la Société, il est porté à la connaissance des tiers
que les personnes suivantes ont démissionné de leur fonction avec effet au 14 février 2014:
- Mr. Simon STEVENS, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle au 30, Charles II Street, GB - SW1Y 4AE
London, Royaume-Uni;
- Mr. Eystein ERIKSRUD, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle au 12, Jerpefaret, N - 0788 Oslo, Norvège;
- Mr. Stéphane HEPINEUZE, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg; et
- Mr. Julien FRANCOIS, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg.
Il est également porté à la connaissance des tiers que les personnes suivantes ont été nommées gérants avec effet au
14 février 2014 pour une période illimitée:
- Mr. Paul HOUSE, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle au 21-22 Grosvenor Street, London W1K 4QJ,
Royaume-Uni;
- Mr. Blair TAMBLYN, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle au 1000 Yonge Street, Suite 500, Toronto,
Ontario M4W 2K2; et
- Mr. Julien FRANCOIS, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg.
Ainsi le nouveau conseil de gérance de la Société est le suivant:
- Mr. Julien FRANCOIS, gérant de catégorie A;
- Mr. Blair TAMBLYN, gérant de catégorie A;
- Mr. Matthijs BOGERS, gérant de catégorie B; et
- Mr. Paul HOUSE, gérant de catégorie B.
Luxembourg, le 21 février 2014.
Pour extrait sincère et conforme
VeTC S.à r.l.
Représenté par M. Julien FRANCOIS
<i>Gérant de catégorie Ai>
Référence de publication: 2014032587/41.
(140035922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2014.
Hyridia, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5969 Itzig, 13, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 116.575.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 4 mars 2014.
<i>Pour la société
i>Me Martine DECKER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014033696/13.
(140038286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
50736
Aaxxes S.A.
Alba Properties S.A.
Alder Consultancy S.à r.l.
Al Mi'yar Capital SA
Alpha Business Consulting S.A.
Armadillo Lux Holding S.A.
Beaumonde S.C.I.
Bogey Investissements S.A.
Bullball S.A.
Cabinet Immobilier Schmitt S.à r.l.
Carehb S.à r.l.
CHERRY Luxembourg S.A.
Churchgate Capital Partners, S.à r.l.
CPPE Carbon Process & Plant Engineering S.A.
CPPE Carbon Process & Plant Engineering S.A.
DBI Private Equity Fund S.A.
ECP Europe & North Africa Food & Beverage Sàrl
Ersel Sicav
European Paper Group s. à r.l.
Hyridia
KPI Retail Property 25 S.à r.l.
Mois européen de la photographie
Oranje-Nassau Développement S.A., SICAR
Prize Holdings 1 S.à r.l.
Promo Kappa 94 S.A.
Rockwell Collins International Holdings S.à r.l.
Shurgard Holding Luxembourg
Soficomex Holding S.A.
Soficomex Holding Spf S.A.
Sokaris Shipping S.A.
Spectrum Media S.à r.l.
Valindus S.A.
Valindus S.A., SPF
VeTC S.à r.l.
WCG SA
WCG SA