This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3024
29 novembre 2013
SOMMAIRE
agraferm technologies luxembourg s.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145152
AXA Alternative Participations IV, SICAV-
FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145106
e-Guide S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145152
e-Space S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145152
IG Log 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145146
IHS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
145146
IK Investment Partners S.à r.l. . . . . . . . . . .
145126
Inovatec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145146
International Corporate Technologies
Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145121
International Corporate Technologies S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145121
IPFR S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145146
IS Eurologistics Investments Sàrl . . . . . . . .
145146
IS European Projects Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
145145
IS Projects One Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145145
IS Projects Two Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145145
Issin Investments SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145126
J.C.2A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145146
Kaporal Manco S.à r.l. Holdings SCA . . . .
145144
K-FÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145144
Kirpal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145145
KJK Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145130
Klee Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145136
Kochav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145144
Kochav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145145
Kochav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145129
Kompil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145136
Krentz & Griffin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
145118
La Cascade Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
145140
Le Colibri S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145149
Leverkusen Innovation Park S.à r.l. . . . . . .
145130
Lifetime Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . .
145118
L'Occitane International S.A. . . . . . . . . . . .
145145
Loizelle SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145148
Luminant Investments S.à.r.l. . . . . . . . . . . .
145136
Lungta s. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145148
Luxamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145121
Luxehold S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145147
Luximpe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145147
Luxparts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145148
Luxpresta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145120
Lux-Prestige Concept s.à r.l. . . . . . . . . . . . .
145147
LV Investissement Europe S.à r.l. . . . . . . . .
145148
LVS ULYSSE Invest S.A., SPF . . . . . . . . . . .
145147
M and M Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145148
Manling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145118
Marche Investissements SPF S.A. . . . . . . . .
145140
Marie Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145118
Mateco Location de Nacelles S.A. . . . . . . .
145149
Matignon Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145149
MB Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145150
Mediainspekt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145149
Medinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145149
Nouveaux Ets. Liebaert S.à r.l. . . . . . . . . . .
145150
NW G 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145151
Oasis Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
145150
Occitan Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
145150
Oekostroum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145150
Pfizer Holdings Luxembourg Sàrl . . . . . . . .
145152
Pronovem Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
145151
Quadra Hamburg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
145152
Quadra Mainz BZ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
145151
Quadra Mainz Telekom S.à r.l. . . . . . . . . . .
145151
Quadra Mainz Volkspark S.à r.l. . . . . . . . . .
145151
VB (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
145121
145105
L
U X E M B O U R G
AXA Alternative Participations IV, SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 161.205.
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-seventh day of September.
Before us Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of AXA Alternative Participations IV, SICAV-FIS, a
société d’investissement à capital variable – fonds d’investissement spécialisé governed by the laws of Luxembourg, with
registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following
a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 19 May 2011, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1704 of 28 July 2011 and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 161205 (the "Company"). The articles of incorporation of the
Company have for the last time been amended following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem,
Grand Duchy of Luxembourg, of 20 July 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2278 of 13 September 2012.
The meeting was declared open at 2.30 p.m. Mrs Stéfanie FABER, employee, with professional address in Luxembourg,
2, Place Dargent, in the chair.
The chairman appoints as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Katja SCHNEIDER, employee, with
professional address in Luxembourg, 2, Place Dargent.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
the following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agendai>
1 To restate the articles of incorporation of the Company.
2 To appoint Marcus Thiel as Class A Director and to confirm that the other directors shall be qualified as Class B
Directors.
3 Delegation of powers.
4 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the
undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented
declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.
(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to fully restate the articles of incorporation of the Company.
As a consequence the articles of incorporation of the Company shall from now on read as follows:
“1. Denomination, Duration, Corporate Object, Registered office
Art. 1
er
. Denomination. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter
issued, a corporation in the form of a public limited company (“société anonyme”) qualifying as an investment company
with variable share capital - specialised investment fund (“société d’investissement à capital variable – fonds d’investisse-
ment specialisé”) under the name of AXA Alternative Participations IV, SICAV-FIS (hereinafter referred to as the
“Company”).
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
The Company may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment
of these Articles of Incorporation.
Art. 3. Corporate object. The sole object of the Company is to invest directly, or indirectly through intermediary
vehicles, the funds available to it in accordance with the law of 13 February 2007 on specialised investment funds as
145106
L
U X E M B O U R G
amended from time to time (“Law of 13 February 2007”) in assets eligible there under provided that these assets are
shares in companies including shares in companies which qualify as undertakings for collective investments or as other
investment vehicles, and in interests in partnerships, with the purpose of spreading investment risks and affording its
shareholders the results of its portfolio.
The Company and any of its Sub-Funds may take any measures permitted under the Law of 13 February 2007 and
directly related or incidental to those referred to above, including the holding on an ancillary basis of cash.
The Company and any of its Sub-Funds must not take on borrowings, except for short-term borrowing up to an overall
amount equivalent to 10% of the total binding commitments received by the Company (whether drawn or undrawn),
provided that the borrowings must be consistent with market standards.
Art. 3a. Specific conditions for investment. Each of the investee structures shall have a business model and assume
business risks. The enterprise value of the investee may not be composed solely of the total of the net asset values. The
mere purchase and sale and the administration of investments (secondary business) by an investment company shall not
represent a business model associated with business risk.
The Company and any of its Sub-Funds will invest in investment structures whose primary purpose is the investment
and financing of private equity and/or infrastructure investments (the “Investment Structures”) and including Investment
Structures that invest in turn in other investment structures or funds (“Fund of Funds”).
The underlying investments (the “Underlying Investments”) of the Investment Structures may consist in any kind of
private equity and infrastructure investment instruments.
The Company or any of its Sub-Funds may also hold the Underlying Investments directly (“Direct Investments”)
provided that such Underlying Investments qualify as equity instruments for German tax purposes, and for German
regulatory purposes for German insurance companies. These Direct Investments may consist in co-investments together
with the Investment Structures in the Underlying Investments. Furthermore Direct Investments may be part of the
portfolio of a Sub-Fund as a result of payments in kind made by the Investment Structures.
The Company or any of its Sub-Funds may on an ancillary basis invest in Investment Structures that invest in real estate
funds and real estate vehicles.
Shares in closed-ended or open-ended securities or hedge funds held directly, or indirectly via a holding company (as
per section 4 (4) sentence 2 of the Anlageverordnung (AnlV)) shall not be equity interests considered as eligible assets.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg. Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economical, social or military deve-
lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
rarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall
have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg corporation.
2. Share capital, variations of the share capital, characteristics of the shares
Art. 5. Share capital. The share capital of the Company shall be at any time equal to the total net assets of the Company,
as defined in Article 12 hereof. The capital of the Company had to reach one million two hundred fifty thousand Euro (€
1,250,000.-) within the first twelve (12) months following its incorporation, and thereafter may not be less than this
amount.
The reference currency of the Company is Euro (“EUR”).
Art. 6. Variations in share capital. The share capital may be increased or decreased as a result of the issue by the
Company of new fully paid-up shares or the repurchase by the Company of existing shares from its shareholders.
Art. 7. Sub-Funds. The board of directors of the Company may, at any time, establish several pools of assets, each
constituting a sub-fund, a “compartiment” within the meaning of Article 71 of the Law of 13 February 2007 (each, a “Sub-
Fund”).
The board of directors of the Company shall attribute specific investment objectives and policies and a denomination
to each Sub-Fund.
The rights of shareholders and creditors relating to a particular Sub-Fund or created by the incorporation, the ope-
ration or the liquidation of a Sub-Fund are limited to the assets of such Sub-Fund. The assets of any Sub-Fund will be
available exclusively for satisfying claims relating to the rights of shareholders of such Sub-Fund and for those of the
creditors whose claim(s) arose in relation to the incorporation, the operation or the liquidation of such Sub-Fund. In the
relationship between Shareholders, each Sub-Fund will be deemed to be a separate entity.
Art. 8. Classes of shares. The board of directors of the Company may, at any time, issue other classes of shares within
one or more Sub-Funds. These other classes of shares may differ in, inter alia, their fee structure, currency, dividend
policy or type of target investors.
145107
L
U X E M B O U R G
Initially, one class of shares, Class A shares was issued. Other classes of shares within one or more Sub-Funds, once
created, shall differ in their characteristics as more fully described in the prospectus of the Company from time to time.
Art. 9. Form of the shares. The Company shall issue shares of each Sub-Fund and each class of shares in registered
form.
Shares are issued in uncertificated or certificated registered form. However the register of shareholders is conclusive
evidence of ownership. If a share certificate is requested at the time of subscription, and in such case, the subscriber will
bear the risk and any additional expense arising from the issue of such certificate. Holders of share certificates must return
their share certificates, duly renounced, to the Company before redemption instructions may be effected.
A register of shareholders shall be kept by a duly appointed agent of the Company. Such share register shall set forth
the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the Sub-Fund and
class of each such share, the amounts paid for each such share, the transfer of shares and the dates of such transfers. The
share register is conclusive evidence of ownership. The Company treats the registered owner of a share as the absolute
and beneficial owner thereof.
The transfer of a registered share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of
shareholders, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons
holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence of transfer other ins-
truments of transfer satisfactory to the Company.
Any owner of registered shares has to indicate to the Company an address to be maintained in the share register. All
notices and announcements of the Company given to owners of registered shares shall be validly made at such address.
Any shareholder may, at any moment, request in writing amendments to his address as maintained in the share register.
In case no address has been indicated by an owner of registered shares, the Company is entitled to deem that the necessary
address of the shareholder is at the registered office of the Company.
The shares are issued, and share certificates if requested are delivered, only upon the acceptance of the subscription
and the receipt of the subscription price under the conditions as set out in the prospectus.
The Company will recognise only one holder in respect of each share in the Company. In the event of joint ownership,
the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person shall
have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company.
Art. 10. Loss or destruction of share certificates. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that
his share certificate has been mislaid or destroyed, then at his request, a duplicate share certificate may be issued under
such conditions and guarantees as the Company may determine, including an indemnity or other verification of title or
claim to title countersigned by a bank, stockbroker or other party acceptable to the Company. Upon the issue of the
new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate shall become null
and void.
Mutilated or defaced share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The mutilated or
defaced certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately. The Company, at its discretion,
may charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate, as well as all costs and reasonable
expenses incurred by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the
annulment of the old share certificate.
Art. 11. Limitation to the ownership of shares. Shares of the Company may only be owned by and are freely transferable
between well-informed investors in accordance with the Law of 13 February 2007 and excluding at any time individuals
and entities which are not corporate entities for German tax purposes and which have one or more individuals as its
members or owners (“Institutional Investors”). The issue or transfer of shares may not result in shares of a Sub-Fund
being held by more than thirty (30) Institutional Investors.
The Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in a Sub-Fund by any person, firm,
partnership or corporate body, if in the sole opinion of the Company such holding may be detrimental to the interests
of the existing shareholders or of the Company or of any of its Sub-Funds, if it may result in a breach of any law or
regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company or of any of its Sub-Funds may become
exposed to tax disadvantages, fines or penalties that it would not have otherwise incurred (an “Excluded Investor”). Such
firms, partnerships or corporate bodies shall be determined by the board of directors.
For such purposes, the Company may, at its discretion and without liability:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears that such registration or
transfer would or may eventually result in the beneficial ownership of said share by a person who is precluded from
holding shares in the Company; or
b) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares in the Company, either
alone or in conjunction with any other person, is a beneficial owner of shares, compulsorily purchase from any such
shareholder all shares held by such shareholder; or
145108
L
U X E M B O U R G
c) where it appears to the Company that one or more persons are the owners of a proportion of the shares in the
Company which would render the Company subject to tax or other regulations of jurisdictions other than Luxembourg,
compulsorily repurchase all or a proportion of the shares held by such shareholders.
In such cases enumerated at (a) to (c) (inclusive) hereabove, the following proceedings shall be applicable:
1) The Company shall serve a notice (hereinafter referred to as the “redemption notice”) upon the holders of shares
subject to compulsory repurchase; the redemption notice shall specify the shares to be repurchased as aforesaid, the
redemption price (as defined here below) to be paid for such shares and the place at which this price is payable. Any such
notice may be served upon such shareholder by registered mail, addressed to such shareholder at his address as indicated
in the share register. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share
certificate, if issued, representing shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on
the date specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in the
redemption notice and the share certificate, if issued, representing such shares shall be cancelled in the books of the
Company.
2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be purchased (hereinafter referred to as the
“redemption price”) shall be an amount equal to the net asset value per share of the class to which the shares belong,
determined in accordance with Article 12 hereof, as at the date of the redemption notice plus any contingent deferred
sales charge or redemption fees, if applicable.
3) Subject to all applicable laws and regulations, payment of the redemption price will be made to the owner of such
shares in the currency in which the shares are denominated, and will be deposited by the Company with a bank in
Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such owner upon surrender of the
share certificate, if issued, representing the shares specified in such redemption notice. Upon deposit of such redemption
price as aforesaid, no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest
in such shares or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder
appearing as the owner thereof to receive the redemption price so deposited (without interest) from such bank upon
effective surrender of the share certificate, if issued, as aforesaid.
4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article 11 shall not be questioned or invalidated in
any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person at the date of any
redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.
The Company may also, at its discretion and without liability, decline to accept the vote of any person who is precluded
from holding shares in the Company at any meeting of shareholders of the Company, a Sub-Funds or a class of shares.
Specifically, the Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any
“US person”, meaning a citizen or resident of the United States of America or of any of its territories or possessions or
areas subject to its jurisdiction.
Notwithstanding any provisions in these Articles of Incorporation, a shareholder in the Company being a German
Regulated Investor shall have the right, at any time, to transfer all or part of its shares without the prior consent of the
Company or any other shareholder to a transferee that executes a subscription agreement and qualifies as an Institutional
Investor and who is not an Excluded Investor and provided that the transfer does not have the effect that the number of
shareholders of a Sub-Fund exceeds thirty (30). On the transfer of all or part of the shares by a German Regulated
Investor, the transferee shall accept and become solely liable for all liabilities and obligations relating to such shares,
including under these Articles of Incorporation, and the transferring German Regulated Investor shall be released from
(and shall have no further liability of any nature, not even a secondary or joint and several liability, for) such liabilities and
obligations.
Insofar and as long as a German Regulated Investor holds shares as part of its guarantee assets (“Sicherungsvermögen”
as defined in Sec. 66 or Sec. 115 of the German Insurance Supervisory Act (Versicherungsaufsichtsgesetz)) and such
German Regulated Investor is either in accordance with section 70 of the German Insurance Supervisory Act under the
legal obligation to appoint a trustee (Treuhänder) or is subject to similar legal requirements, such German Regulated
Investor shall dispose of such shares only with the prior written consent of such trustee or its authorized representative
appointed in accordance with section 70 of the German Insurance Supervisory Act, as amended from time to time.
“Disposal” includes, but is not limited to any sale exchange, transfer or assignment of all or part of the shares held by
such German Regulated Investor.
For the purpose of this Article, the term “German Regulated Investor” shall include any German insurance company,
German Pensionskasse or German pension fund (including a German Versorgungswerk) or any other entity subject to
the investment restrictions of the German Insurance Supervisory Act (Versicherungsaufsichtsgesetz) holding shares in
the Company as part of its guarantee assets (“Sicherungsvermögen”) or “other restricted assets” (“Sonstiges gebundenes
Vermögen” as defined in Sec. 66 and Sec. 54 para. 1 or Sec. 115 of the German Insurance Supervisory Act (Versiche-
rungsaufsichtsgesetz)).
3. Net asset value, issue and repurchase of shares, suspension of the calculation of the net asset value
Art. 12. Net asset value. The net asset value per share of each class of shares in each Sub-Fund of the Company shall
be determined periodically by the Company, but in any case not less than once per month, as the board of directors may
145109
L
U X E M B O U R G
determine (every such day for determination of the net asset value being referred to herein as the “valuation day”). If
such day falls on a legal or bank holiday in Luxembourg, then the valuation day shall be the first succeeding full business
day in Luxembourg.
The net asset value per share is expressed in the reference currency of each Sub-Fund, for each class of shares for all
Sub-Funds, and is determined by dividing the value of the total assets of each Sub-Fund properly allocable to such class
of shares less the value of the total liabilities of such Sub-Fund properly allocable to such class of shares by the total
number of shares of such class outstanding on any valuation day.
Upon the creation of a new Sub-Fund, the total net assets to each class of shares of such Sub-Fund shall be determined
by multiplying the number of shares of a class issued in the Sub-Fund by the applicable purchase price per share. The
amount of such total net assets shall be subsequently adjusted when shares of such class are issued or repurchased
according to the amount received or paid as the case may be.
The valuation of the net asset value per share of the different classes of shares in a Sub-Fund shall be made in the
following manner:
a) The assets of a Sub-Fund will be determined by application of the following principles:
- The valuation of the Sub-Fund’s interests in the investment structures (both by way of equity and debt investments)
will be effected in the following manner:
* An interest in an investment structure will be valued at cost as long as no report is available and no Evaluation Event
occured;
* If a report regarding the investment structure is available, the interest in the investment structure will be valued on
the basis of the latest available report as long as no major evaluation event (“Evaluation Event”) occurred. The following
events qualify as Evaluation Events: capital calls, distributions or redemptions effected by the investment structure or one
or more of its underlying investments as well as any material events or developments affecting either the underlying
investments or the investment structures themselves.
* The occurrence of an Evaluation Event will be taken into account.
- The valuation of direct investments, which are made as coinvestments, will be effected in the same manner as
described hereabove;
- If a net asset value is determined for the units or shares issued by an investment structure, those units or shares will
be valued on the basis of the latest net asset value determined according to the provisions of the particular issuing
documents of the investment structure. In case of the occurrence of an Evaluation Event that is not reflected in the latest
available net asset value of such units or shares issued by such investment structures, the valuation of such units or shares
issued by such investment structures may take into account this Evaluation Event;
- the value of cash held in hand or on deposit, of securities and bills payable at sight, of accounts receivable, of pre-
paid expenses, and of dividends and interest announced or which have become payable and have not yet been received,
will be constituted by the nominal value of these assets, except where it appears improbable that this value can be achieved;
in which case, their value will be determined by deducting a certain amount which is sufficient in the view of the directors
to reflect the true value of these assets;
- any transferable security negotiated or listed on a stock exchange will be valued on the basis of the last known price,
unless this price is not representative;
If, in the case of securities listed or traded on a stock exchange or another regulated market, the price determined
pursuant to the foregoing is not representative of the real value of these securities, these will be stated at Director’s
valuation. This will be at cost unless in the Director’s opinion a reduction in value is considered appropriate having regard
to a company’s prospects, or a change of valuation is justified by reference to significant transactions in the securities by
third parties;
- any transferable security negotiated on another market will be valued on the basis of the last available price;
- all other securities and other assets will be valued by the directors based on the reasonable foreseeable sales proceeds
determined prudently and in good faith;
- if, as a result of particular circumstances, valuation based on the above rules becomes impractical or inaccurate, other
valuation criteria which are generally accepted and verifiable in order to obtain a fair valuation will be applied.
The Sub-Funds may receive all kinds of eligible assets under the Law of 13 February 2007 if the Sub-Funds get distri-
bution in kind from underlying investments.
Any assets which are not expressed in the currency of the class of the Sub-Fund to which they belong will be converted
into the currency of this class at the exchange rate prevailing on the working day concerned, or at the exchange rate
provided for by the terms of the contract.
Any assets held by the Sub-Fund not expressed in the reference currency will be translated into the reference currency
at the official rate of exchange prevailing on the relevant valuation day.
b) The liabilities of the Sub-Fund shall be deemed to include:
- all loans, bills and accounts payable;
145110
L
U X E M B O U R G
- all accrued or payable administrative expenses (including investment advisory, consultancy or management fees (if
any), Custodian, paying agent and corporate agent fees);
- all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payment of money or pro-
perty;
- an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the relevant valuation day, as determined
from time to time by the Company, and other reserves, if any, authorised and approved by the directors; and
- all other liabilities of the Sub-Fund of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares of the Sub-
Fund. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable and all costs
incurred by the Company in relation to a particular Sub-Fund, which may inter alia comprise the fees payable to the
Custodian, the paying agent, the corporate agent, investment advisors, consultants or managers (if any), taxes, expenses
for legal and auditing services, due diligence costs, office and personal costs, costs of any intermediary company, payments
due to the investment structures or direct investments (e.g. in relation to management fees and capital calls), cost of any
proposed listings, maintaining such listings, printing share certificates, shareholders’ reports, prospectuses, reasonable
marketing and advertising expenses, costs of preparing, translating and printing in different languages, all reasonable out-
of-pocket expenses of the directors, shareholder’s travelling costs to the general meetings of the Company, Sub-Funds
or classes, registration fees and other expenses payable to supervisory authorities in any relevant jurisdictions, insurance
costs, interest, brokerage costs and the costs of publications. The Company may calculate administrative and other
expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue
the same in equal proportions over any such period.
As between the shareholders, each Sub-Fund shall be treated as a separate legal entity. The Company is a single legal
entity. However, each Sub-Fund is regarded as being separate from the others and is liable for all its own liabilities. The
assets, commitments, charges and expenses which cannot be allocated to one specific Sub-Fund will be charged to the
different Sub-Funds proportionally to their respective net assets, or pro rata to their respective net assets, if appropriate
due to the amounts considered.
All shares in the process of being redeemed by a Sub-Fund shall be deemed to be issued until the close of business on
the valuation day applicable to the redemption. The redemption price is a liability of the respective Sub-Fund from the
close of business on this date until paid.
All shares issued by a Sub-Fund in accordance with subscription applications received shall be deemed issued from the
close of business on the valuation day applicable to the subscription. The subscription price is an amount owed to the
Sub-Fund from the close of business on such day until paid.
As far as possible, all investments and divestments chosen and in relation to which action is taken by the Sub-Fund up
to the valuation day shall be taken into consideration in the valuation.
Art. 13. Issue, redemption and conversion of shares.
13.1. Issue of shares
The board of directors is authorised to issue further fully paid-up shares of each Sub-Fund and of each class at any
time and without reserving the existing shareholders a preferential right to subscription for the shares to be issued and
provided however that shares will not be issued to more than thirty (30) Institutional Investors per Sub-Fund at a price
based on the net asset value per share for each Sub-Fund or class of shares determined in accordance with Article 12
hereof, as of such valuation day as is determined in accordance with such policy as the board of directors may from time
to time determine. Such price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the
Sub-Fund when investing the proceeds of the issue and by applicable sales charges, as approved from time to time by the
board of directors.
The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly
authorised person, the duty of accepting subscriptions and of receiving payment for such new shares.
All new share subscriptions shall, under pain of nullity, be entirely liberated, and the shares issued carry the same rights
as those shares in existence on the date of the issuance.
The issue price will be paid within the delays detailed in the prospectus of the Company.
The board of directors may at its full discretion agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of
securities, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation
report from an auditor (“réviseur d’entreprises agréé”).
If the directors determine that it would be detrimental to the existing shareholders of a Sub-Fund to accept a sub-
scription for shares of the respective Sub-Fund that represents more than 10% of the net assets of such Sub-Fund then
they may postpone the acceptance of such subscription and, in consultation with the incoming shareholder, may require
him to stagger his proposed subscription over an agreed period of time.
The Company may reject any subscription in whole or in part, and the directors may, at any time and from time to
time and in their absolute discretion without liability and without notice, discontinue the issue and sale of shares of any
class in any one or more Sub-Funds.
13.2. Redemption of shares
145111
L
U X E M B O U R G
The directors may from time to time as they deem appropriate decide the repurchase of shares or fractions thereof
in one or more Sub-Funds. The decision to repurchase will be binding for all the shareholders of the respective Sub-Fund
and affect them on a pro rata basis in accordance with their shareholding. However the shares are not redeemable at the
unilateral request of the shareholders.
The Company will announce in due time the redemption through mail addressed to the registered shareholders. The
announcement will mention the duration of the redemption period, the method for calculating the redemption price
which will be determined on the last day of the redemption period and which will be equal to the net asset value calculated
on the last day of the redemption period.
The directors may in their sole and absolute discretion ask the shareholders to accept payment in whole or in part by
an in-kind distribution of securities in lieu of cash.
The redeemed shares will be cancelled. The redemption price will be paid within the delays detailed in the prospectus
of the Company.
13.3.Conversion of shares into shares of a different class of shares
Conversions of shares between different Sub-Funds and/or classes of shares, if any, are excluded.
Art. 14. Suspension of the calculation of the net asset value and of the issue, the redemption and the conversion of
shares. The Company may suspend the calculation of the net asset value per share of the Company or any of its Sub-
Funds in the following circumstances:
a) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the directors as a result
of which disposal or valuation of assets owned by the Company or a Sub-Fund would be impracticable;
b) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the investments of the Company or a Sub-Fund or the current price or value on any stock exchange or other market
in respect of the assets of the Company or a Sub-Fund;
c) if restrictions on foreign exchange or with regard to capital transactions prevent the settlement of transactions on
behalf of the Company or a Sub-Fund;
d) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company or a Sub-Fund cannot promptly
or accurately be ascertained;
e) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of winding-up the
Company or a Sub-Fund.
Under exceptional circumstances, which may adversely affect the rights of shareholders, the board of directors re-
serves the right to conduct the necessary sales of investments before setting the share price at which shareholders will
have their shares redeemed. In this case, subscriptions and redemptions in process shall be dealt with on the basis of the
net asset value thus calculated after the necessary sales.
The suspension of the calculation of the net asset value may be published by adequate means if the duration of the
suspension is to exceed a certain period.
Suspended subscription applications may be withdrawn by written notice provided that the Company receives such
notice before the suspension ends.
Suspended subscriptions and redemptions shall be executed on the first valuation day following the resumption of net
asset value calculation by the Company.
4. Investment policies and restrictions
Art. 15. General provisions. The board of directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to
determine the corporate and investment policy for the investments and the course of conduct of the management and
business affairs of the Company or any of its Sub-Funds, all within the investment powers and restrictions as shall be set
forth by the board of directors in the prospectus of the Company, in compliance with applicable laws and regulations.
The risk diversification requirements may not apply during a start-up period as determined in the prospectus of the
Company.
5. General shareholders’ meetings
Art. 16. General provisions. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent
the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts
relating to the operations of the Company.
Art. 17. Annual general shareholders’ meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance
with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may
be specified in the notice of the meeting, on 3
rd
Friday in March at 12.30 p.m. If such day is a bank holiday in Luxembourg,
then the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may
be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
145112
L
U X E M B O U R G
Art. 18. General meetings of shareholders of Sub-Funds and/or Classes of shares. The shareholders of any Sub-Fund
and/or class of shares may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such
Sub-Fund and/or class of shares. The general provisions set out in these Articles of Incorporation, as well as in the
Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies, shall apply to such
meetings.
Art. 19. Functioning of shareholders’ meetings. The quorum and time required by law shall govern the notice for and
conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share, regardless of the Sub-Fund and the class to which it belongs, is entitled to one vote, subject to the limitations
imposed by these Articles of Incorporation. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission. Fractions of shares are not entitled
to a vote.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by simple majority of those present or represented and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
Further, the shareholders of each Sub-Fund and of each class separately will deliberate and vote (subject to the con-
ditions of quorum and majority voting as provided by law) on the following items:
1. affectation of the net profits of their Sub-Fund and of their class; and
2. resolutions affecting the rights of the shareholders of one Sub-Fund or one class vis-à-vis of the other Sub-Funds
and/or classes.
Art. 20. Notice to the general shareholders’ meetings. Shareholders shall meet upon call by the board of directors.
To the extent required by law, the notice shall be published in the Mémorial of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper
and in such other newspapers as the board of directors may decide.
6. Management of the Company
Art. 21. Management. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three (3)
members who need not to be shareholders of the Company.
One (1) director (the “Class A Director”) will be appointed amongst a list of candidates set out by AXA Konzern AG;
such director will benefit from a specific veto right as described in Article 27 below.
The other directors of the Company will be qualified as Class B directors (the “Class B Directors”).
Art. 22. Duration of the functions of the directors, renewal of the Board of Directors. The directors shall be elected
by the general shareholders’ meeting for a period not exceeding six years and until their successors are elected and
qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by reso-
lution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy on a provisional basis until the next general
meeting of shareholders.
Art. 23. Committee of the board of directors. The board of directors shall choose from among its members a managing
director, and may choose from among its members one or more vice-managing directors. It may also choose a secretary,
who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors
and of the shareholders.
Art. 24. Meetings and deliberations of the board of directors. The board of directors shall meet upon call by the
managing director, or if any two (2) of its members so require or if the Class A Director so requires. The agenda for any
meeting of the board of directors is set by the person that convenes such meeting.
The managing director shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the
shareholders or the board of directors may appoint another director by a majority vote to preside at such meetings. For
general meetings of shareholders and in the case no director is present, any other person may be appointed as managing
director.
The board of directors may from time to time appoint officers of the Company, including a general manager, any
assistant managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the
Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors. Officers need not be directors
or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein, shall have the powers and
duties given to them by the board of directors.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least three (3) days in advance
of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. Whenever any of the above mentioned reserved matters is on the agenda of
a meeting, written notice shall be given to all directors at least five (5) business days in advance of the hour set for such
145113
L
U X E M B O U R G
meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission of
each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meetings of the board of directors by appointing, in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile transmission, another director as his proxy. One director may replace several other directors.
Any director who is not physically present at the location of a meeting may participate in such a meeting of the board
of directors by conference call or similar means of communication equipment, whereby all persons participating in the
meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.
Directors may not bind the Company by their individual signature, except as specifically permitted by resolution of
the board of directors.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least fifty per cent of the directors are present or
represented at a meeting of directors.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. The
managing director shall have the casting vote.
Resolutions signed by all members of the board of directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letters, cables, telegrams, telexes, facsimile transmission and similar means. The date of such a
resolution shall be the date of the last signature.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its
powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to natural persons or corporate entities
which need not be members of the board.
Art. 25. Minutes. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the managing director, or in
his absence, by the managing director pro-tempore who presides at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such managing director, or by the secretary, or by two (2) directors.
Art. 26. Engagement of the Company vis-à-vis third persons. The Company shall be engaged by the signature of two
(2) members of the board of directors or by the individual signature of any duly authorised director or officer of the
Company or by the individual signature of any other person to whom authority has been delegated by the board of
directors.
Art. 27. Powers of the board of directors. The board of directors determines the general orientation of the manage-
ment and of the investment policy, as well as the guidelines to be followed in the management of the Company, always
in application of the principle of risk diversification.
The Class A Director (i) can request any items of the reserved matters listed below to be put on the agenda of a
meeting of the board of directors and (ii) will have a veto right at any meeting of the board of directors on the list of
reserved matters listed below:
- Exercise of the rights attached to the portfolio funds’ securities and co-investment’s securities;
- (ii) Investment policy decisions at the level of the Company for (a) the funds in which the Company has invested and
(b) co-investments (in particular any decisions relating to investment, divestment or borrowing) and (ii) decisions relating
to the financing of any investment to be made in funds and/or co-investments by the Company;
- Appointment and revocation by the Company of service providers which are affiliated to AXA Investment Managers
Private Equity Europe SA (a French société anonyme with its registered office located at 20 place Vendôme in Paris
(France) and registered with the Paris Trade and Companies Register (Registre du Commerce et des Sociétés de Paris)
under number B 403 201 882) (“AXA PEE”);
- Appointment by any above-mentioned service providers which is affiliated to AXA PEE of agents acting in the name
of the Company under the services agreements;
- Delegation by the above-mentioned service provider affiliated to AXA PEE of its duties under the relevant services
agreement to any third party (excluding affiliates of AXA PEE);
- Any amendment to existing services agreements entered into by the Company;
- Any amendment to the private placement memorandum of the Company;
- Any proposal of the board of directors of the Company to the general meeting of shareholders of the Company to
amend the articles of incorporation of the Company;
- Decision to call for capital or to effect a repurchases of shares at the level of the Company.
The board of directors will need to obtain the approval of the Class A Director on the reserved matters listed above.
Before any of the above mentioned reserved matters can be put on the agenda of a meeting of the Board of directors,
and therefore before any convening notice is sent to the members of the Board of directors, the person that is willing
to convene a meeting of the Board will submit, at least five (5) business days before any convening notice is sent to the
145114
L
U X E M B O U R G
members of the Board of directors (except in cases the Class A Director would accept a shorter notice), the draft agenda
to the Class A Director and take into account, insofar as the reserved matters listed above are concerned, any comments
the Class A Director may have on this draft agenda.
Art. 28. Interest. No contract or other transaction which the Company and any other corporation or firm might enter
into shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company are
interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.
Any director or officer of the Company who serves as a director, officer of employee of any corporation or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
corporation or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.
In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.
The term “personal interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any position, relationship with or
interest in any matter, position or transaction involving the AXA group, its subsidiaries and associated companies or such
other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.
Art. 29. Indemnification of the directors. The Company shall indemnify any director or officer, and his heirs, executors
and administrators, against expenses reasonable incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request,
of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.
Art. 30. Allowances to the board of directors. The general meeting of shareholders may allow the members of the
board of directors, as remuneration for services rendered, a fixed annual sum, as directors’ remuneration, such amount
being carried as general expenses of the Company and which shall be divided at the discretion of the board of directors
among themselves.
Furthermore, the members of the board of directors may be reimbursed for any expenses engaged in on behalf of the
Company insofar as they are reasonable.
The remuneration of the managing director or the secretary of the board of directors as well as those of the general
manager(s) and officers shall be fixed by the board.
Art. 31. Advisor, fund managers, custodian and other contractual parties. The Company may enter into an investment
advisory agreement in order to be advised and assisted while managing its portfolio, as well as enter into investment
management agreements with one or more fund managers.
In addition, the Company shall enter into service agreements with other contractual parties, for example an adminis-
trative and corporate agent to fulfil the role of “administration centrale” as defined in the Institut Monétaire Luxem-
bourgeois Circular 91/75 of 21 January 1991.
The Company shall enter into a custody agreement with a bank (hereinafter referred to as the “Custodian”) which
shall satisfy the requirements of the Law of 13 February 2007. All transferable securities and cash of the Company are to
be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsi-
bilities provided by law.
In the event of the Custodian desiring to retire the board of directors shall use their best endeavours to find another
bank to be Custodian in place of the retiring Custodian and the board of directors shall appoint such bank as Custodian.
The board of directors may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and
until a successor Custodian shall have been appointed in accordance with these provisions to act in the place thereof.
7. Auditor
Art. 32. Auditor. The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be
supervised by an auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to
respectability and professional experience and who shall perform the duties foreseen by the Law of 13 February 2007.
The auditors shall be elected by the general meeting of shareholders.
8. Annual accounts
Art. 33. Annual accounts, accounting year. The shareholders shall be provided with the audited annual financial state-
ments of the Company within one hundred twenty (120) days following the end of the accounting year of the Company.
145115
L
U X E M B O U R G
The accounting year of the Company shall begin on 1 January in each year and shall terminate on 31 December of the
same year.
Art. 34. Profit balance. At the annual general meeting of shareholders, the shareholders of each Sub-Fund and/or class
shall determine, at the proposal of the board of directors, whether, and if so the amount thereof, dividends are to be
distributed to the shareholders of the Company, within the limits prescribed by the Law of 13 February 2007.
In each Sub-Fund, interim dividends may, subject to such further conditions as set forth by law and subject to the
decision of the board of directors, be paid out on shares.
Dividends which are not claimed within a period of five (5) years starting from their payment date will become fore-
closed for their beneficiaries and will return to the Company.
In order to repay to the investor the proceeds of sales of any underlying assets and/or other income which will not
be subject to a further investment, the board of directors may, instead of either proposing a dividend payment to the
general meeting of shareholders or making an interim payment on dividends, decide to redeem shares or fractions thereof
in accordance with the terms of Article 13.2 above. The board of directors is authorised to make in-kind distributions/
payments of securities of portfolio companies with the consent of the shareholders.
9. Dissolution and liquidation
Art. 35. Dissolution and Liquidation of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution taken
by the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements as defined in Article 19 hereof.
Whenever the capital falls below two thirds of the minimum capital as provided by the Law of 13 February 2007, the
board of directors has to submit the question of the dissolution of the Company to the general meeting of shareholders.
The general meeting for which no quorum shall be required shall decide on simple majority of the votes of the shares
presented at the meeting.
The question of the dissolution of the Company shall also be referred to the general meeting of shareholders whenever
the capital falls below one quarter of the minimum capital as provided by the Law of 13 February 2007. In such event the
general meeting shall be held without quorum requirements and the dissolution may be decided by the shareholders
holding one quarter of the votes present or represented at that meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from ascertainment that the net
assets of the Company have fallen below two thirds or one quarter of the legal minimum as the case may be.
The issue of new shares by the Company shall cease on the date of publication of the notice of the general shareholders’
meeting, to which the dissolution and liquidation of the Company shall be proposed.
One or more liquidators (who may be natural persons or legal entities) shall be appointed by the general meeting of
shareholders, which shall as well determine their powers and their compensation, to realise the assets of the Company,
subject to the supervision of the relevant supervisory authority in the best interests of the shareholders.
The proceeds of the liquidation, net of all liquidation expenses, shall be distributed by the liquidators among the holders
of shares in each class in accordance with their respective rights. The amounts not claimed by shareholders at the end
of the liquidation process shall be deposited, in accordance with Luxembourg law, with the Caisse de Consignation in
Luxembourg. If these amounts were not claimed before the end of a period of five (5) years, the amounts shall become
statute-barred and cannot be claimed any more.
Art. 36. Termination of a Sub-Fund and/or a class of shares. The directors may decide at any moment the termination
of any Sub-Fund and/or class of shares. In the case of termination of a Sub-Fund and/or a class of shares, the shareholders
will see their shares compulsory redeemed for cash at the net asset value per share determined on the day on which
such decision shall take effect. In the case of termination of a Sub-fund, the directors may offer to the shareholders of
such Sub-fund the conversion of their class of shares into classes of shares of another Sub-fund, under terms fixed by the
directors.
The Company shall serve a notice to the shareholders of the relevant class of shares prior to the effective date of the
compulsory redemption, which will indicate the reasons for and the procedure of the redemption operations.
Any request for subscription for shares of such Sub-Fund and/or class of shares shall be suspended as from the moment
of the announcement of the termination, of the relevant Sub-Fund and/or class of shares.
Assets which may not be distributed to their owners upon the implementation of the redemption will be deposited
with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.
All redeemed shares will be cancelled by the Company.
The termination of a Sub-Fund has no implications on the remaining Sub-Funds or on the Company as a whole. Only
the liquidation of the last remaining Sub-Fund will result in the liquidation of the Company itself.
Art. 37. Expenses borne by the Company. Each of the Custodian, the Paying Agent and the Corporate Agent are
entitled to receive fees out of the assets of the Company, pursuant to the relevant agreements between each of them
and the Company and in accordance with customary banking practice. In addition, reasonable disbursements and out-of-
pocket expenses incurred by such parties are charged to the Company as appropriate.
145116
L
U X E M B O U R G
The Company will also bear all other expenses incurred in the operation of the Company which include, without
limitation, fees payable to investment advisors, consultants or managers (if any), taxes, expenses for legal and auditing
services, due diligence costs, office and personal costs, costs of any intermediary company, payments due to the investment
structures or direct investments (e.g. in relation to management fees and capital calls), cost of any proposed listings,
maintaining such listings, printing share certificates, shareholders’ reports, prospectuses, reasonable marketing and ad-
vertising expenses, costs of preparing, translating and printing in different languages, all reasonable out-of-pocket expenses
of the directors, shareholder’s travelling costs to the general meetings of the Company, registration fees and other
expenses payable to supervisory authorities in any relevant jurisdictions, insurance costs, interest, brokerage costs and
the costs of publications.
The formation expenses of the Company will be borne by the Company and will not be written off. The formation
expenses of a Sub-Fund will be borne by such Sub-Fund and will not be written off.
The Company bears all its running costs as foreseen in Article 12 hereof.
Art. 38. Amendment of the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended from time to
time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and majority voting requirements provided by the laws of
Luxembourg.
Art. 39. General provisions. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies, the
Law of 13 February 2007 and any other applicable law.”
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to appoint Mr. Marcus THIEL, born on 5 March 1975 in Berlin, Germany,
with professional address at Colonia-Allee 10-20, D-51067 Köln, Germany, as Class A Director for a period ending at
the annual general meeting which will approve the annual accounts as at 31 December 2016.
The general meeting of shareholders resolved to confirm that the other directors currently in office, i.e. Julien ALEX,
Manuel HAUSER, Olivier DECANNIERE and Vincent GOMBAULT, shall be qualified as Class B Directors.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved that the foregoing resolutions will be conditional and effective upon the
closing of the acquisition by Holding PE SAS of a majority of the shares in AXA Investment Managers Private Equity S.A.
The general meeting of shareholders resolved that the appointment of Mr. Marcus Thiel will be conditional upon the
approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier.
The general meeting of shareholders further resolved to delegate all powers to each director of the Company, acting
individually and with power of substitution, to acknowledge the satisfaction or non-satisfaction of the above mentioned
conditions precedent.
The general meeting of shareholders further resolved to delegate all powers to each director of the Company and to
any lawyer at Linklaters LLP, Luxembourg, acting individually and with power of substitution, to have the effectiveness or
non-effectiveness of the foregoing resolutions recorded in a notarial deed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at EUR 1,500.-.
There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English only.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Signé: Stéfanie FABER, Katja SCHNEIDER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 octobre 2013. Relation GRE/2013/3994. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2013146512/672.
(130179439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.
145117
L
U X E M B O U R G
Marie Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 148.844.
Les comptes annuels au 30.11.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MARIE PROPERTY S.A.
Référence de publication: 2013150658/10.
(130184355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.
Manling, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 101.553.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2013150657/10.
(130183912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.
Lifetime Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 32.259.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013150634/10.
(130184162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.
Krentz & Griffin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 78.319.
L'an deux mil treize, le seizième jour du mois d'octobre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
ONT COMPARU:
1.- Madame Julie GRIFFIN épouse KRENTZ, conseiller d'entreprises, née le 5 août 1962 à Douglas (Iles Britanniques),
demeurant à L-8265 Mamer, 4, rue des Prés.
2.- Monsieur Charlton Lee John KRENTZ, conseiller d'entreprises, né le 23 décembre 1989 à Luxembourg, demeurant
à L-8265 Mamer, 4, rue des Prés, représenté par Madame Julie Griffin, prénommée, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant, ès qualités qu'il agit, déclare que Madame Julie GRIFFIN épouse KRENTZ et Monsieur Charlton Lee
John KRENTZ sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée KRENTZ & GRIFFIN S.àr.l., avec siège social
à L-8265 Mamer, 4, rue des Prés, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et
le numéro B 78319, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 octobre 2000, publié au
Mémorial, Recueil C numéro 264 du 12 avril 2001.
Les associés ont prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-8265 Mamer, 4, rue des Prés à L-1610 Luxembourg,
42-44, Avenue de la Gare.
<i>Deuxième résolutioni>
Suivant la résolution qui précède les associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des statuts de
la société comme suit:
145118
L
U X E M B O U R G
« Art. 2. (1
er
paragraphe). Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social d'un montant en vue de le porter de son montant actuel de EUR
12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) par l'émission de 300 (trois cents) parts
sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits et obli-
gations que les parts sociales existantes, à libérer intégralement.
<i>Souscription et Libérationi>
Les trois cents (300) parts sociales nouvelles mentionnées ci-dessus ont été souscrites par l'un des associés, Madame
Julie GRIFFIN, prénommée, comme suit:
- Julie GRIFFIN, trois cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Total: trois cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de EUR 37.500,- (trente-
sept mille cinq cents euros) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné
moyennant un certificat bancaire de blocage.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de refléter les résolutions ci-dessus, les associés décident de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), divisé en quatre cents (400)
parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés décident de modifier l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts qui
aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet un bureau d'activités commerciales et de services commerciaux.
D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.»
<i>Sixième résolutioni>
Les associés décident que la gérance de la Société sera dorénavant composée par deux gérants au moins, dont un
président et modifient en conséquence les articles 9 et 12 des statuts comme suit:
Art. 9. La Société sera gérée par au moins deux gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par
l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations, qui forment un conseil de gérance.
Les gérants sont nommés par l'Assemblée Générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs
sont définis dans l'acte de nomination.
La Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses membres un président qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires par lesquels toutes les personnes prenant part à cette réunion
peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
145119
L
U X E M B O U R G
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par
écrit. Le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Le conseil de gérance peut nommer des fondés de pouvoir, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte
de la société, dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.
Le conseil de gérance est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-
Duché qu'à l'étranger.
Art. 12. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
<i>Septième résolutioni>
Afin de refléter la résolution ci-dessus, les associés décident de nommer Madame Julie Griffin, actuellement gérante
de la Société, Président du conseil de gérance et de nommer un deuxième gérant pour une durée indéterminée Monsieur
Charlton Lee John Krentz, prénommé.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant.
<i>Huitième résolutioni>
Les associés décident d'introduire un nouvel article sous le numéro 13 qui se lira comme suit:
« Art. 13. Les opérations de la Société peuvent, et devront dans les cas prévus par la loi, être supervisées par un ou
plusieurs commissaires aux comptes ou, le cas échéant, par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises. Le(s) commissaire(s)
aux comptes / réviseur(s) d'entreprises sera(ont) élu(s) pour une durée maximum de six ans et seront rééligibles.
Le(s) commissaire(s) aux comptes / réviseur(s) d'entreprises sera(ont) nommé(s) par l'assemblée générale des ac-
tionnaires qui déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.»
Les anciens articles 13 à 17 sont renumérotés de 14 à 18.
<i>Pouvoirsi>
Le comparant, ès qualités qu'il agit, donne pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet
de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte sont estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu le comparant, ès qualités qu'il agit, attentif au fait qu'avant toute activité commerciale
de la société dont la modification de l'objet social ci-avant, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce
en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée du comparant, ès qualités qu'il agit, connu du notaire instrumentant par
nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Julie Griffin, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 21 octobre 2013. LAC / 2013 / 47687. Reçu 75,- €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 25 octobre 2013.
Référence de publication: 2013150612/121.
(130184215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.
Luxpresta S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 4-6, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 173.101.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1
er
octobre 2013 que:
1. L'assemblée transfère le siège social au 4-6 avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
145120
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 28 octobre 2013.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2013150644/15.
(130184373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.
Luxamo, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 169.229.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013150643/10.
(130184450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.
VB (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 22.720.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 169.694.
Par décision de l'associé unique, il a été pris connaissance de la démission de M. Rodney Cannon de ses fonctions de
gérant de la Société avec effet au 11 août 2013.
En remplacement de M. Rodney Cannon, l'associé unique a décidé de nommer, avec effet au 11 août 2013, M. Guy
Westmacott né le 6 juin 1977 à Edimbourg, Royaume-Unis, ayant son adresse professionnelle à Al Mamoura A, Muroor
Street, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, nouveau gérant de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2013151496/16.
(130184314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.
International Corporate Technologies S.A., Société Anonyme,
(anc. International Corporate Technologies Holding S.A.).
Siège social: L-1467 Howald, 42, rue Henri Entringer.
R.C.S. Luxembourg B 55.447.
Im Jahre zwei tausend dreizehn, den siebzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der
Aktiengesellschaft "INTERNATIONAL CORPORATE TECHNOLOGIES HOLDING S.A.", abgekürzt INCOTECH mit
Sitz in L-1467 Howald, 42, rue Entringer, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B,
unter der Nummer 55.447, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen Notar Frank BADEN, mit damaligem Amtssitz in
Luxemburg, am 20 Juni 1996,veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 490 vom 1.
Oktober 1996,
deren Satzungen wurden abgeändert gemäß Urkunden aufgenommen durch Notar Frank BADEN, mit damaligem
Amtssitz in Luxemburg, am 18. Oktober 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Num-
mer 1032 vom 22. Januar 1997
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Cristina REHFELD, Verwalterin, wohnhaft in L-1467 Howald, 42, rue Henri
Entringer.
Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung bestellt Herrn Paul MOODY, Geschäftsmann, wohn-
haft in L-1467 Howald, 42, rue Henri Entringer, zum Stimmzähler.
Der Vorstand der Versammlung war damit bestellt und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu
beurkunden:
A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
145121
L
U X E M B O U R G
<i>Tagesordnung:i>
1) Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in INTERNATIONAL CORPORATE TECHNOLOGIES S.A.
2) Abänderung des Gesellschaftszwecks wie dies in Artikel 2 der neuen Satzung wiedergespiegelt wurde.
3) Löschung des Nennwertes und der Kategorien der Aktien.
4) Aufstockung des Gesellschaftskapitals um 13,31 EUR ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien durch eine
Barzahlung in die Kasse.
5) Komplette Neufassung des Gesellschaftsvertrages auf Grund der obenstehenden Tagespunkte, um diesen an die
aktuelle luxemburgische Gesetzgebung anzupassen.
6) Statutarische Ernennungen
7) Verschiedenes.
B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer
Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevoll-
mächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten
Notar "ne varietur" unterzeichnet.
C) Dass sämtliche Aktien, welche das gesamte Kapital darstellen, anwesend oder vertreten sind und dass alle anwe-
senden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor
Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten.
Somit waren keine weiteren Einberufsmitteilungen erforderlich.
D) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass
rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.
Alsdann hat die Generalversammlung, nach eingehender Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt:
- die Gesellschaftsbezeichnung in INTERNATIONAL CORPORATE TECHNOLOGIES S.A. abgekürzt INCOTECH
abzuändern
- den Gesellschaftszweck abzuändern wie dies in Artikel 2 der Satzung wiedergespiegelt wird
- den Nennwert der Aktien sowie die Kategorie der Aktien zu löschen
- das Gesellschaftskapital um 13,31 EUR ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien durch eine Barzahlung in die
Kasse aufzustocken.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt folgende Neufassung des Gesellschaftsvertrages, um diesen, sowohl an die hiervor
genommenen Beschlüsse, als auch an die aktuelle luxemburgische Gesetzgebung anzupassen, und um die Sprache der
Satzung in Deutsch zu ändern:
Titel I - Name, Sitz, Dauer, Zweck
Art. 1. Die Aktiengesellschaft („société anonyme") besteht unter der Firmierung INTERNATIONAL CORPORATE
TECHNOLOGIES S.A. abgekürzt INCOTECH (im Folgenden: "Gesellschaft"). Sie unterliegt der vorliegenden Satzung
und dem geänderten luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Howald (Großherzogtum Luxemburg).
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung gemäß den Bestimmungen dieser Satzung
aufgelöst werden.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, die Forschung, die Entwicklung, die Produktion, die Vermarktung, die
Veröffentlichung und der Verkauf insbesondere auf den Gebieten Multi-Level Marketing, der Opto¬Elektronik, der Da-
tenverarbeitung, die Ausgabe in Druckschrift oder der Multimedia und der elektronischen Kommunikation, sowie das
Management und die Verwertung von Lizenzen, Patentrechten und Rechte an geistigem Eigentum.
Gegenstand der Gesellschaft sind ebenfalls alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der
Beteiligungsnahme in jeglicher Form in jeglicher Gesellschaft, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und
der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.
Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Management, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jegli-
chen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher
Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen
Sicherheiten und Patenten, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie verwerten, sowie zur
Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.
145122
L
U X E M B O U R G
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.
Titel II - Kapital, Aktien
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist eingeteilt in zwölftausend
fünfhundert (12.500) Stückaktien ohne Nennwert.
Art. 4. Die Aktien können nach Wahl der Aktionäre in Form von Inhaberaktien oder Namensaktien emittiert werden
mit Ausnahme derjenigen Aktien, für die Inhaberaktien gesetzlich vorgeschrieben sind.
Für die Gesellschaftsanteile können auf Wunsch des Aktionärs Sammelurkunden ausgegeben werden.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben. Der Tod oder die Auflösung des alleinigen Aktionärs
(oder irgendeines anderen Aktionärs) führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.
Die Gesellschaft kann mit ihren freien Reserven ihre eigenen Anteile gemäß Artikel 49-2 des Gesetzes über die Han-
delsgesellschaften zurückkaufen.
Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre in Einklang mit dem Gesell-
schaftsvertrag in einer oder mehreren Stufen aufgestockt oder verringert werden.
Die Hauptversammlung kann den Verwaltungsrat mit der Durchführung derartiger Änderungen des Gesellschaftska-
pitals beauftragen.
Wird die Hauptversammlung ersucht, über derartige Änderungen des Gesellschaftskapitals abzustimmen, kann sie das
Zeichnungsprivileg der bestehenden Aktionäre einschränken oder ganz aufheben.
Titel III - Verwaltungsrat
Art. 5. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, welche
keine Aktionäre sein müssen.
Falls die Gesellschaft jedoch von einem einzigen Aktionär gegründet wurde oder in der Generalversammlung der
Aktionäre festgestellt wird, dass alle Aktien der Gesellschaft von einem einzigen Aktionär gehalten werden, kann ein
einzelnes Verwaltungsratsmitglied die Geschäfte der Gesellschaft bis zur nächsten Hauptversammlung, welche die An-
wesenheit von mehr als einem Aktionär feststellt, führen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden in der ordentlichen Hauptversammlung für eine Dauer von bis zu sechs Jahren
gewählt und verbleiben in ihrer Funktion, bis ihre Nachfolger ernannt worden sind. Die Zahl der Verwaltungsratsmit-
glieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandats werden durch die Generalversammlung der Aktionäre festgesetzt.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Generalversammlung mit oder ohne Anlass und mit einfacher Meh-
rheit der gültigen Stimmen gewählt oder abberufen; eine Wiederwahl ist möglich.
Wird eine juristische Person zum Verwaltungsratsmitglied ernannt, so bestellt sie einen ständigen Vertreter, der in
ihrem Namen handelt. Die juristische Person kann ihren Vertreter erst abberufen, wenn sie für ihn gleichzeitig einen
Nachfolger bestellt.
Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds durch Tod, Ruhestand oder aus sonstigen Gründen frei, so können die
verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder vorübergehend bis zur nächsten Generalversammlung einen vorläufigen Nach-
folger bestellen.
Art. 6. Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsvorschriften und der vorliegenden
Satzung umfassende Befugnisse für alle Handlungen, die er zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks für notwendig oder
zweckmäßig hält.
Besteht der Verwaltungsrat aus einer einzigen Person, so besitzt sie sämtliche Verwaltungsratsbefugnisse.
Der Verwaltungsrat ist zur Emission von frei übertragbaren oder nicht übertragbaren Namens- und Inhaberschuld-
verschreibungen jeglicher Art und Währung berechtigt. Diese Emission ist auf die Höhe des Gesellschaftskapitals
beschränkt.
Der Verwaltungsrat bestimmt in diesem Zusammenhang Art, Preis, Zinssatz sowie Ausgabe- und Rückzahlungskon-
ditionen und alle sonstigen diesbezüglichen Konditionen.
Über die auf den Namen lautenden Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz ein Register geführt.
Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder tritt der Verwaltungsrat an dem im
Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen.
Der Vorsitzende leitet alle Versammlungen der Aktionäre und des Verwaltungsrates; ist er abwesend, kann der Ver-
waltungsrat unter den anwesenden Mitgliedern mit Stimmenmehrheit ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen,
das in den Versammlungen vorübergehend den Vorsitz übernimmt.
145123
L
U X E M B O U R G
Eine Sitzung des Verwaltungsrates bedarf einer schriftlichen Einladung der Verwaltungsratsmitglieder. Sie muss ihnen
mindestens 24 Stunden vor dem vorgesehenen Sitzungstermin durch Telefax oder E-Mail (ohne elektronische Unters-
chrift) zugehen, außer in dringlichen Fällen, in denen Art und Gründe der Dringlichkeit in dem Schreiben genannt werden.
Ein derartiges Einladungsschreiben ist entbehrlich, sofern jedes Verwaltungsratsmitglied dazu per Brief, Telefax oder E-
Mail (ohne elektronische Unterschrift) oder ein anderes Kommunikationsmittel seine Zustimmung erteilt, wobei eine
Kopie als ausreichender Beleg gilt.
Für eine Sitzung des Verwaltungsrates, deren Ort und Zeit bereits zuvor in einem Beschluss des Verwaltungsrates
festgelegt wurden, ist ein gesondertes Einberufungsschreiben nicht erforderlich.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Versammlung des Verwaltungsrats teilnehmen, indem es per Brief, per
Fernschreiben, per elektronischer Post (ohne elektronische Unterschrift) oder ein anderes Kommunikationsmittel ein
anderes Mitglied zu seinem Vertreter ernennt. Eine Kopie des entsprechenden Schreibens genügt als Beleg. Ein Verwal-
tungsratsmitglied kann einen oder mehrere Kollegen vertreten.
Verwaltungsratsmitglieder können an einer Sitzung auch im Rahmen einer Telekonferenz durch eine Konferenzschal-
tung oder sonstige Kommunikationsmittel teilnehmen, die es allen Sitzungsteilnehmern ermöglichen, alle anderen an der
Sitzung teilnehmenden Mitglieder durchgehend zu hören, so dass alle Teilnehmer an der Sitzung wirksam teilnehmen
können. Die Teilnahme an einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel gilt als persönliche Teilnahme an der Sitzung, und eine mit
solchen Mitteln abgehaltene Sitzung gilt als eine Sitzung am Gesellschaftssitz.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse werden mit Zustimmung der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Im Fall der
Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Der Verwaltungsrat kann einstimmige (Umlauf-)Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege fassen, sei es per Brief, Telefax
oder E-Mail (ohne elektronische Unterschrift) oder durch ein anderes Kommunikationsmittel, wobei eine Kopie als aus-
reichender Beleg gilt. Das Sitzungsprotokoll gilt als Beleg für die Beschlussfassung.
Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Geschäftsführern oder anderen Bediens-
teten sämtliche oder einen Teil seiner Befugnisse für die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft
übertragen.
Art. 7. Die Gesellschaft wird nach außen durch die Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder die Einze-
lunterschrift eines geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds im Rahmen der diesem erteilten Befugnisse, oder im Falle
eines alleinigen Verwalters durch dessen alleinige Unterschrift, rechtswirksam vertreten. Für die Vertretung der Gesell-
schaft gegenüber Behörden genügt die Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds.
Art. 8. Die Gesellschaft verpflichtet sich, jedes Verwaltungsratsmitglied für Verluste, Schäden und Kosten zu entschä-
digen, die ihm im Zusammenhang mit einer Klage entstehen könnten, an der es in seiner derzeitigen oder früheren
Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied beteiligt ist, außer wenn mit rechtskräftigem Urteil festgestellt wurde, dass es
wegen grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher Pflichtverletzung zu haften hat.
Titel IV – Aufsicht
Art. 9. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die nicht Aktionäre zu sein brauchen
und für bis zu sechs Jahre ernannt werden. Eine Wiederwahl ist zulässig. Sie können jederzeit abberufen werden.
Titel V - Generalversammlung
Art. 10. Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat
die weitestgehenden Befugnisse, um hinsichtlich der Tätigkeiten der Gesellschaft Anordnungen zu treffen, Handlungen
auszuführen oder zu ratifizieren. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben. Der Tod oder die Auflösung
eines Aktionärs führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.
Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf schriftlichen Antrag von Ak-
tionären einberufen werden, die mindestens zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals vertreten. Ebenso können
Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten, die Hinzufügung eines
oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung einer Generalversammlung beantragen. Ein solcher Antrag ist mit einges-
chriebenem Brief spätestens fünf (5) Tage vor dem Termin der Generalversammlung an den Sitz der Gesellschaft zu
richten.
Wenn alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und bestätigen, dass sie die Tage-
sordnung kennen, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einberufung stattfinden.
Für die Einberufungsschreiben und die Abhaltung der Generalversammlungen gelten, soweit diese Satzung nichts an-
deres vorsieht, die gesetzlichen Bestimmungen über die Beschlussfähigkeit und Fristen.
Aktionäre, die an einer Generalversammlung per Videokonferenz oder mit Hilfe anderer Kommunikationsmittel teil-
nehmen, die ihre Identifikation ermöglichen, gelten in Bezug auf die Beschlussfähigkeit und Abstimmungen als anwesend.
Das verwendete Kommunikationsmittel muss gewährleisten, dass sämtliche Sitzungsteilnehmer einander fortwährend
hören und an der Sitzung wirksam teilnehmen können.
145124
L
U X E M B O U R G
Jeder Anteil hat eine Stimme. Jeder Aktionär kann an einer Aktionärsversammlung teilnehmen, indem er per Brief, E-
Mail (ohne elektronische Unterschrift), Telefax oder ein anderes Kommunikationsmittel einen Vertreter ernennt, wobei
eine Kopie des entsprechenden Schreibens als Beleg genügt.
Die Stimmabgabe kann per Brief oder Fernschreiben, adressiert an den Gesellschaftssitz oder die im Einberufungss-
chreiben genannte Adresse, erfolgen. Die Aktionäre dürfen nur die von der Gesellschaft abgegebenen Stimmzettel
verwenden, die mindestens die folgenden Angaben enthalten: Ort, Datum und Zeit der Generalversammlung, Tagesord-
nung der Generalversammlung, die der Generalversammlung zur Entscheidung vorgelegten Abstimmungsgegenstände und
für jeden Abstimmungsgegenstand drei Kästchen, in denen der Aktionär ankreuzen kann, ob er dem vorgeschlagenen
Beschluss zustimmt, ihn ablehnt oder ob er sich der Stimme enthält.
Stimmzettel, die weder die Zustimmung noch die Ablehnung oder eine Stimmenthaltung zum vorgeschlagenen Bes-
chluss anzeigen, sind ungültig. Die Gesellschaft berücksichtigt nur Stimmzettel, die vor der Generalversammlung der
Aktionäre eingegangen sind, auf die sie sich beziehen.
Die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen getroffen, außer bei Abstimmungen über eine Änderung der Satzung. In diesem Fall werden Ent-
scheidungen mit einer Zweidrittelmehrheit der gültig abgegebenen Stimmen getroffen.
Der Verwaltungsrat kann alle sonstigen Bedingungen für die Teilnahme an Versammlungen der Aktionäre festlegen.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am ersten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz
oder an einem anderen im Einberufungsschreiben angegebenen Ort statt.
Fällt dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag, findet die Generalversammlung am nächsten darauf folgenden Werktag
statt.
Titel VI - Geschäftsjahr / Gewinne
Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines
jeden Jahres.
Art. 13. Es werden jährlich fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns der Gesellschaft als gesetzliche Rücklage abgeführt.
Diese Abführung ist zwingend, bis die Rücklage zehn Prozent (10 %) des in Artikel 3 dieser Satzung vorgesehenen Ge-
sellschaftskapitals bzw. des nach Artikel 3 aufgestockten oder verringerten Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Über die Verwendung des verbleibenden jährlichen Nettogewinns entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrats die
Generalversammlung der Aktionäre.
Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Zwischendividenden ausschütten.
Titel VII - Anwendbares recht
Art. 14. Für alle durch diese Satzung nicht geregelten Punkte gilt das geänderte Gesetz vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung stellt fest dass alle Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Prüfungskommissar ab-
gelaufen sind.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung bestellt als:
Alleinverwalter:
Frau Cristina REHFELD, Verwalterin, geboren in Mexiko-City am 10. August 1971, wohnhaft in Luxemburg Howald,
42, rue Henri Entringer.
Prüfungskommissar:
Euro Invest Management SA, Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, eingetragen
beim Handels-und Gesellschaftsreigster von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 71.129
Ihre Mandate enden voraussichtlich nach der ordentlichen Gesellschafterversammlung im Jahre 2018.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt ein tausend zwei hundert Euro veranschlagt sind,
sind zu Lasten der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Cristina REHFELD, Paul MOODY, Jean SECKLER.
145125
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Grevenmacher, le 21 octobre 2013. Relation GRE/2013/4221. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2013151174/245.
(130185097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Issin Investments SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 82.637.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 16 février 2013i>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social au 25A, Boulevard Royal à L-2449 Luxembourg (Luxembourg).
L'assemblée générale accepte la démission des administrateurs suivants:
- M. Alfonso GARCIA, né le 13/12/1967 à Madrid (Espagne) demeurant professionnellement 5 Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg (Luxembourg).
- Mme Beatriz GARCIA, née le 05/02/1966 à Madrid (Espagne) demeurant professionnellement 5 Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg (Luxembourg).
- Mme Colette WOHL, née le 18/02/1959 à Luxembourg (Luxembourg) demeurant professionnellement 5 Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg (Luxembourg).
L'assemblée générale décide de nommer en remplacement les administrateurs suivants:
- M. Bernard ZIMMER, né le 25/10/1952 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), demeurant professionnel-
lement L-2449 Luxembourg, 25A boulevard Royal (Luxembourg).
- M. Thomas SCHOENHERR, né le 17 novembre 1957 à Marktredwitz (Allemagne), demeurant professionnellement
L-2449 Luxembourg, 25A boulevard Royal (Luxembourg).
- M. Luc-Henri JAMAR, né LE 20/07/1954 à Ixelles (Belgique), demeurant au 4 rue d'Olm L-8281 KEHLEN (Luxem-
bourg).
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151190/25.
(130185344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
IK Investment Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 82.881,25.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.911.
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-second day of October.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Fatburen Europa B.V., a company duly incorporated under the laws of The Netherlands and having its registered
office in Claude Debussylaan 18, Amsterdam 1082 MD, The Netherlands;
2. Mr. Christopher Masek, residing at 7 Drayton Gardens, London, SW10 9RY, United Kingdom;
3. Mr. Mads Ryum Larsen, residing at South Rise, South Road, St George's Hill, Weybridge, Surrey, KT13 0NA, United
Kingdom;
4. Mr. James Yates, residing at 36 Montague Road, Richmond, TW10 6QJ, United Kingdom;
5. MAJA Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, a company duly incorporated under the laws of Germany and
having its registered office at Isestrasse 117, D-20149, Hamburg, Germany;
6. Stellaris AB, a company duly incorporated under the laws of Sweden and having its registered office at 32, Orrs-
pelsvägen, S-167 66 Bromma, Sweden and registered with the Registrar of Companies of Sweden under number
556706-4661;
7. International Kapital Investment Partners S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg) under number B 162242;
8. Mr. Anders Petersson, having his address at Jungfrauenthal 22, 20149 Hamburg, Germany;
145126
L
U X E M B O U R G
9. Goldcup 8998 AB (to be renamed Cosi AB), a company duly incorporated and validly existing under the laws of
Sweden, having its registered office at c/o Carlsson Kemppinen, Östermalmstorg 2, 11442 Stockholm, Sweden and re-
gistered with the Sweden register under number 556941-0078;
10. Stanhope Invest S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and
validly existing under the laws of France, having its registered office at 36 avenue Georges Mandel, 75116 Paris, France
and in process of registration; and
11. Mr. Remko Hilhorst, having his address at 17 Stokenchurch Street, London SW6 3TS, United Kingdom.
Here represented by Ms. Carmen André, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting by virtue of eleven (11)
proxies given in October 2013.
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
That they are the actual shareholders of "IK INVESTMENT PARTNERS S.à r.l.", (formerly Industri Kapital Luxembourg
Sàrl), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office in Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg)
under number B 98911, incorporated by a deed of the notary public Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, on
31 December 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 316 of 19 March 2004,
the articles of which have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 22 May 2013,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1747 of 20 July 2013, page 83852 (the "Com-
pany").
All this having been declared, the appearing parties, holding 100% of the share capital of the Company have immediately
proceeded to hold an extraordinary general meeting and have requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of one thousand three hundred Euros (EUR 1,300.-)
in order to bring it from its current amount of eighty-four thousand one hundred eighty-one Euros twenty-five Cents
(EUR 84,181.25) to eighty-two thousand eight hundred eighty-one Euros twenty-five Cents (EUR 82,881.25) by cancel-
lation of four hundred and sixteen (416) Class A Ordinary Shares, having a par value of three point one hundred twenty-
five Euros (EUR 3.125) each, and reimbursement of an amount of one thousand three hundred Euros (EUR 1,300. -) to
Fatburen Europa B.V. formerly IK Europa B.V.);
2. Modification of the provisions of Article 7.1 (Subscribed and paid Up Share Capital) of the articles of association of
the Company, as amended from time to time (the "Articles") as a result of the capital reduction; and
3. Miscellaneous.
After approval of the foregoing, the meeting passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to reduce the Company's subscribed share capital by an amount of one thousand three
hundred Euros (EUR 1,300.-) in order to bring it from its current amount of eighty-four thousand one hundred eighty-
one Euros twenty-five Cents (EUR 84,181.25) to eighty-two thousand eight hundred eighty-one Euros twenty-five Cents
(EUR 82,881.25) by cancellation of four hundred and sixteen (416) Class A Ordinary Shares, having a par value of three
point one hundred twenty-five Euros (EUR 3.125) each, and to reimburse to Fatburen Europa B.V. (formerly IK Europa
B.V.), sole class A shareholder of the Company, an amount of one thousand three hundred Euros (EUR 1,300.-).
<i>Second resolutioni>
Subsequently, the general meeting decides to amend Article 7.1 (Subscribed and Paid Up Share Capital) of the Articles,
that will read as follows.
" 7.1. Subscribed and Paid Up Share Capital. The Company's corporate capital is fixed at eighty-two thousand eight
hundred eighty-one Euros twenty-five Cents (EUR 82,881.25) represented by two thousand six hundred forty-two (2,642)
Class A Ordinary Shares, three thousand nine hundred and eighty (3,980) Class D Preference Shares, three thousand
nine hundred and eighty (3,980) Class E Preference Shares, three thousand nine hundred and eighty (3,980) Class F
Preference Shares, three thousand nine hundred and eighty (3,980) Class G Preference Shares, three thousand nine
hundred and eighty (3,980) Class H Preference Shares and three thousand nine hundred and eighty (3,980) Class I Pre-
ference Shares, all with a par value of three point one hundred twenty-five Euro (EUR 3.125) and all fully subscribed and
entirely paid up.
At the moment and as long as all the Shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company
("société unipersonnelle ") in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing."
There being no further business, the meeting is terminated.
145127
L
U X E M B O U R G
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately one thousand
two hundred Euro.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-deuxième jour d'octobre.
Pardevant, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Fatburen Europa B.V., une société constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Claude Debussylaan
18, Amsterdam 1082 MD, Pays-Bas;
2. Monsieur Christopher Masek, demeurant au 7 Drayton Gardens, Londres, SW10 9RY, Royaume Uni;
3. Monsieur Mads Ryum Larsen, demeurant à South Rise, South Road, St George's Hill, Weybridge, Surrey, KT13 0NA,
Royaume Uni;
4. Monsieur James Yates, demeurant à 36 Montague Road, Richmond, TW10 6QJ, Royaume Uni;
5. MAJA Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, une société constituée selon les lois d'Allemagne, ayant son siège
social à Isestrasse 117, D-20149, Hamburg, Allemagne;
6. Stellaris AB, une société constituée selon les lois de Suède, ayant son siège social au 32, Orrspelsvägen, S-167 66
Bromma, Suède et enregistrée auprès du Registre de Suède sous le numéro 556706-4661;
7. International Kapital Investment Partners S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, et enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162242;
8. Monsieur Anders Petersson, demeurant au Jungfrauenthal 22, 20149 Hamburg, Allemagne;
9. Goldcup 8998 AB (qui sera renommée Cosi AB), une société constituée et régie selon les lois de Suède, ayant son
siège social au c/o Carlsson Kemppinen, Ôstermalmstorg 2, 11442 Stockholm, Suède et enregistrée auprès du Registre
de Suède sous le numéro 556941-0078;
10. Stanhope Invest S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois de France, ayant son
siège social au 36 avenue Georges Mandel, 75116 Paris, France et en cours d'immatriculation; et
11. Monsieur Remko Hilhorst, demeurant au 17 Stokenchurch Street, London SW6 3TS, Royaume Uni.
Ici représentés par Melle Carmen André, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en vertu de
onze (11) procurations datées d'octobre 2013.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire soussigné,
resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
Les comparants, représentés comme dit avant, ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
Qu'ils sont les associés actuels de «IK INVESTMENT PARTNERS S.à r.l.», (anciennement Industri Kapital Luxembourg
Sàrl), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 98.911 constituée par acte du notaire Joseph Elvinger, demeurant
à Luxembourg, le 31 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 316 du 19 mars
2004, les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois selon un acte du notaire instrumentant, le 22 mai 2013, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1747 du 20 juillet 2013, page 83852 (la «Société»).
Ceci ayant été exposé, les comparants détenant 100% du capital social de la Société ont immédiatement procédé à
l'assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I.- L'agenda de l'assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de mille trois cent Euros (EUR 1.300,-) afin de porter le capital
social de la Société de son montant actuel de quatre-vingt-quatre mille cent quatre-vingt-un Euros vingt-cinq cents (EUR
84.181,25) à quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-un Euros vingt-cinq cents (EUR 82.881,25) par annulation de
quatre cent seize (416) Parts Sociales Ordinaires de Classe A, d'une valeur nominale de trois Euros cent vingt-cinq cents
(EUR 3,125) chacune, et remboursement d'un montant de mille trois cent Euros (EUR 1.300,-) à Fatburen Europa B. V.
(anciennement IK Europa B.V.);
2. Modification de l'Article 7.1. (Capital souscrit et libéré) des statuts de la Société, tels que modifiés (les «Statuts»)
suite à la réduction du capital social;
145128
L
U X E M B O U R G
3. Divers.
Après approbation de ce qui précède, l'assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de réduire le capital social d'un montant de mille trois cent Euros (EUR 1.300,-) afin de
porter le capital social de la Société de son montant actuel de quatre-vingt-quatre mille cent quatre-vingt-un Euros vingt-
cinq cents (EUR 84.181,25) à quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-un Euros vingt-cinq cents (EUR 82.881,25)
par annulation de quatre cent seize (416) Parts Sociales Ordinaires de Classe A, d'une valeur nominale de trois Euros
cent vingt-cinq cents (EUR 3,125) chacune, et de rembourser un montant de mille trois cent Euros (EUR 1.300,-) à
Fatburen Europa B.V. (anciennement IK Europa B.V.), seul associé détenteur de parts sociales ordinaires de classe A.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide en conséquence de modifier l'Article 7.1 des Statuts (Capital souscrit et libéré), qui se
lira comme suit:
« 7.1. Capital souscrit et Libéré. Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-
un Euros vingt-cinq cents (EUR 82.881,25) représenté par deux mille six cent quarante-deux (2.642) Parts Sociales
Ordinaires de Classe A, trois mille neuf cent quatre-vingt (3.980) Parts Sociales Préférentielles de Classe D, trois mille
neuf cent quatre-vingt (3.980) Parts Sociales Préférentielles de Classe E, trois mille neuf cent quatre-vingt (3.980) Parts
Sociales Préférentielles de Classe F, trois mille neuf cent quatre-vingt (3.980) Parts Sociales Préférentielles de Classe G,
trois mille neuf cent quatre-vingt (3.980) Parts Sociales Préférentielles de Classe H et trois mille neuf cent quatre-vingt
(3.980) Parts Sociales Préférentielles de Classe I, chacune ayant une valeur nominale de trois Euros et cent vingt-cinq
Cent (EUR 3,125) et toutes entièrement souscrites et libérées.
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est
une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi sur les Sociétés. Dans la mesure où les articles 200-1 et
200-2 de la Loi sur les Sociétés trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre
lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est estimé à environ mille deux cents Euros.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des comparants et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: C. ANDRE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 23 octobre 2013. Relation: LAC/2013/48079.
Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Référence de publication: 2013151165/177.
(130185168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Kochav, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 159.218.
Je vous informe de ma démission de mon mandat de Gérant du Conseil de Gérance de la société Kochav S.à r.l. avec
effet au 25 octobre 2013.
Luxembourg, le 25 octobre 2013.
HENRY Geoffrey.
Référence de publication: 2013151201/10.
(130184731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
145129
L
U X E M B O U R G
KJK Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 156.627.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 12 juillet 2013i>
En date du 12 juillet 2013, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de nommer Monsieur John Christopher Wilcockson, né le 10 octobre 1954 à Ilkley, Yorkshire, Royaume-Uni, résidant
à l'adresse suivante: 15, rue de l'Europe, L-7225 Bereldange, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet
au 29 octobre 2013 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en l'année
2016;
- de nommer Monsieur Martynas Cesnavicius, né le 9 décembre 1972 à Lietuva, Lituanie, résidant à l'adresse suivante:
6-6, A. Smetonos, öLTU - LT 0115 Vilnius, Lituanie, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 29
octobre 2013 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en l'année 2016;
- de renouveler le mandat de Réviseur d'entreprises agréé d'Ernst & Young S.A. pour une période venant à échéance
lors de l'assemblée générale annuelle de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2013 et qui se
tiendra en 2014:
Le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Kustaa Äimä
- Monsieur Jaakko Salmelin
- Monsieur Kari Salonen
- Monsieur Martynas Cesnavicius
- Monsieur John Christopher Wilcockson
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2013.
KJK Management S.A.
Signature
Référence de publication: 2013151205/29.
(130184917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Leverkusen Innovation Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 181.218.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen.
On the twenty-third day of October.
Before us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Zabar Group Holding S.à r.l., a private limited liability company under Luxembourg law, having its registered office at
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg number B 110753,
here represented by Mr Max MAYER, employee, professionally residing at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. Form. There is established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company")
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10, 1915 on commercial companies,
as amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation")
Art. 2. Purpose. The purpose of the Company is the acquisition of equity stake, in Luxembourg or abroad, in any
companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such equity stake. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other way, any stock, securities, bonds, debentures,
certificates of deposit or other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by
any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any
145130
L
U X E M B O U R G
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, promotion, sale, management and/
or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating
to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having
as principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. The Company may issue, by means of private
investment, shares, bonds and other securities representing debts or credits. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also grant guarantees and stand security in favour of third parties, to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise issue guarantees over all or over some of its assets.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. Name. The name of the Company is "Leverkusen Innovation Park S.à r.l.".
Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general
meeting of partners, as the case may be.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the management.
The management may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) repre-
sented by two thousand five hundred (2,500) shares in registered form with a par value of five Euro (EUR 5.-) each, all
subscribed and fully paid-up.
Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by a decision of the single partner or
pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.
Art. 8. Rights and Duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets
of the Company and to one vote at the general meetings of partners.
If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the
articles of incorporation to all the partners.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions
of the single partner or the general meeting of partners.
The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,
request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible insofar as the Company is concerned. Co-owners must be
represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares. If the Company is composed of one single partner, said single partner may transfer freely
its shares.
If the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.
In this same scenario, the shares may only be transferred amongst living persons to non-partners with the authorisation
of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or
accepted by the Company in accordance with Article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy or insolvency or any other similar
event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.
Art. 13. Managers. The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the
partners.
While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the
duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.
145131
L
U X E M B O U R G
The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with
or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation of
each manager.
Art. 14. Powers of the managers. The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administration,
management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls
within the object of the Company. They have the social signature and are empowered to represent the Company in court
either as plaintiff or defendant.
The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to
persons or agents chosen by the Manager(s).
Art. 15. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting
to a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the
Company.
Art. 16. Liability of the managers. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in
relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 17. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the sole signature of
the manager or in case of plurality of managers, by the joint signature of any two (2) managers or by the joint signatures
or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, but only
within the limits of such power.
Art. 18. General meetings of partners. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the
powers granted by law to the general meeting of partners.
Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of partners
or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the associates
by registered mail.
In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the
text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Art. 19. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners, as the case may be, are
documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The
documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.
Art. 20. Financial year. The financial year begins on the 1
st
day of January of each year and ends on the 31
st
day of
December the same year.
Art. 21. Balance-sheet. Each year, on the 31
st
day of December, a general inventory of the assets and liabilities of the
Company and a balance¬sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact carrying
a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.
Art. 22. Allocation of profits. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of
overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.
Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be
mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting
of partners, as the case may be.
Art. 23. Dissolution, Liquidation. In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or
several liquidators who may, but need not be partners, appointed by the single partner or the general meeting of partners,
who shall determine their powers and their compensation.
Art. 24. Matters not provided. All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be deter-
mined in accordance with the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2014.
<i>Subscription and paymenti>
All the two thousand five hundred (2,500) shares have been subscribed by the pre-named shareholder Zabar Group
Holding S.à r.l..
All shares have been fully paid-up by contribution in cash so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
145132
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following person is appointed as manager of the Company for an unlimited period of time:
Mr Alain HEINZ, Chartered accountant, born in Forbach (France) on May 17, 1968 with professional address at 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
2. The registered office of the Company is set at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, said proxy holder signed together with
the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Zabar Group Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg numéro B 110753,
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présente acte aux fins de formalisation.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par les lois du Grand-duché de
Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article
1832 du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").
Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de partici-
pation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute
société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
L'objet social de la Société inclus également l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et la
location de biens immobiliers au Grand Duché de Luxembourg ou à l'étranger ainsi que toutes opérations immobilières,
en ce inclus, la détention directe ou indirecte de participation dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, dont
l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et la location de biens immobiliers.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder, par
voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créan-
ces. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses
filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit
de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de
propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de
son objet social.
Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de «Leverkusen Innovation Park S.à r.l.».
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
145133
L
U X E M B O U R G
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée
générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-duché de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.
La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à
l'étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par deux mille
cinq cents (2.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision de
l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachées aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d'un associé unique, ledit associé unique peut librement céder
ses parts.
Si la Société est composée d'une pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément
donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou
acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 12. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre évé-
nement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Les gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou par l'assemblée générale des
associés.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un
gérant, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Art. 14. Pouvoirs des gérants. Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'adminis-
tration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à
condition qu'elles rentrent dans l'objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société
en justice soit en demandant soit en défendant.
Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou
temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).
Art. 15. Evénements atteignant les gérants. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
145134
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Responsabilité des gérants. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.
Art. 17. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique
ou en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe ou la signature
individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seulement dans les
limites de ce pouvoir.
Art. 18. Assemblée générale des associés. Lorsque la société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les
pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ces cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi
du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou par
vote écrite sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 19. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, seront établies
par écrit et consignée dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés,
ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.
Art. 20. Année sociale. L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même
année.
Art. 21. Bilan. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire général de l'actif et du passif de la société
et un bilan résumant cet inventaire.
Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication
desdits inventaire et bilan.
Art. 22. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des
frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.
Art. 23. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que
ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 24. Disposition générale. Toutes les matières qui seraient pas régies par les présents statuts seraient régies
conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2014.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les deux mille cinq cents (2.500) parts sociales ont été souscrites par l'associée Zabar Group Holding S.à r.l.,
pré-nommée.
Les parts sociales ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille euros.
<i>Décisions de l'associée uniquei>
Et aussitôt, l'associée représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Alain HEINZ, expert-comptable, né à Forbach (France) le 17 mai 1968, demeurant professionnellement au
121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
2. Le siège social de la Société est établi au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
145135
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER .
Enregistré à Grevenmacher, le 28 octobre 2013. Relation GRE/2013/4304. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2013151215/299.
(130184847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Klee Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 36.805.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013151206/10.
(130184978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Luminant Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 544.536,26.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 57.698.
L'adresse de l'associé unique de la Société a changé comme suite:
Barbara Mc Gauran-Boreel, avec adresse professionnelle au 19 Lodge Close, Cobham, Surrey, KT11 2SG, Royaume-
Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luminant Investments S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013151229/15.
(130185220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Kompil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 9, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 172.741.
L’an deux mille treize, le huit octobre.
Pardevant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réuni:
En assemblée générale extraordinaire l’actionnaire unique de KOMPIL S.A., une société anonyme ayant son siège social
au L-1537 Luxembourg, 9, rue des Foyers, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 172.741 (ci-après dénommée la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9
novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 3017 du 13 décembre 2012.
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Madame Marie Kaiser, employée privée, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Cheryl Geschwind, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emmanuel Lebeau, directeur, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
145136
L
U X E M B O U R G
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de trois millions deux cent soixante-cinq
mille deux cents euros (EUR 3.265.200.-) pour le porter de son montant actuel de soixante-dix mille euros (EUR 70.000.-),
représenté par sept cents (700) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, à trois millions
trois cent trente-cinq mille deux cents euros (EUR 3.335.200.-) par l’émission de trente-deux mille six cent cinquante-
deux (32.652) actions nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.
2. Souscription des nouvelles actions et libération des trente-deux mille six cent cinquante-deux (32.652) nouvelles
actions par apport en nature.
3. Modification de l’article 5, alinéa 1 des statuts de la Société.
4. Nomination de deux administrateurs supplémentaires.
5. Divers.
II. Que l’actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d’actions qu’il détient, sont indiqués sur une liste de
présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l’actionnaire unique représenté ainsi que
par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
III. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-
vocations d’usage, l’actionnaire unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de trois millions
deux cent soixante-cinq mille deux cents euros (EUR 3.265.200.-) pour le porter de son montant actuel de soixante-dix
mille euros (EUR 70.000.-), représenté par sept cents (700) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-)
chacune, à trois millions trois cent trente-cinq mille deux cents euros (EUR 3.335.200.-) par l’émission de trente-deux
mille six cent cinquante-deux (32.652) actions nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de cent euros (EUR
100.-) chacune.
<i>Souscription et Libérationi>
L’intégralité des trente-deux mille six cent-cinquante deux (32.652) actions nouvelles sont souscrites comme suit:
1) Monsieur Pascal Collotte, prénommé, né le 28 juin 1960 à Mont Saint Martin (France), demeurant à L-1537 Lu-
xembourg, 9, rue des Foyers, ici représenté par Monsieur Emmanuel Lebeau, prénommé, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 septembre 2013, déclare souscrire la pleine propriété de vingt-trois mille
cinq cent quarante-huit (23.548) actions de la Société.
2) Madame Marie-Chrystel Manon, épouse Collotte, née le 25 décembre 1965 à Libourne (France), demeurant à L-1537
Luxembourg, 9, rue des Foyers, ici représentée par Monsieur Emmanuel Lebeau, prénommé, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 septembre 2013, déclare souscrire la pleine propriété de quatorze (14)
actions de la Société.
3) Madame Clémence Collotte, née le 9 juillet 1990 à Libourne (France), demeurant à F-33000 Bordeaux (France), 4,
rue Emile Duployé, ici représenté par Monsieur Emmanuel Lebeau, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée à Luxembourg, le 20 septembre 2013, déclare souscrire la pleine propriété de six cents (600) actions de la
Société.
4) Monsieur Victor Collotte, né le 25 août 1993 à Bordeaux (France), demeurant à F-33350 Sainte-Radegonde, Château
Jean Faux, ici représenté par Monsieur Emmanuel Lebeau, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée
à Luxembourg, le 20 septembre 2013, déclare souscrire la pleine propriété de six cents (600) actions de la Société.
5) Monsieur Pascal Collotte, prénommé, déclare en outre souscrire l’usufruit de six mille vingt (6.020) actions de la
Société, la nue-propriété étant souscrite à concurrence de trois mille quatre cent soixante (3.460) actions par Madame
Clémence Collotte, prénommée et à concurrence de deux mille cinq cent soixante (2.560) actions par Monsieur Victor
Collotte, prénommé.
6) Madame Marie-Chrystel Manon, prénommée, déclare en outre souscrire l’usufruit de deux mille cinq cent soixante-
dix (2.570) actions de la Société, la nue-propriété étant souscrite à concurrence de huit cent trente-cinq (835) actions
par Madame Clémence Collotte, prénommée et à concurrence de mille sept cent trente-cinq (1.735) actions par Monsieur
Victor Collotte, prénommé.
Les trente-deux mille six cent cinquante-deux (32.652) actions sont souscrites à un prix par action de cent euros (EUR
100.-) soit un montant total de trois millions deux cent soixante-cinq mille deux cents euros (EUR 3.265.200.-), intégra-
lement affecté au capital social de la Société.
Lesdites actions sont entièrement libérées par un apport en nature consistant en les parts sociales, respectivement
l’usufruit ou la nue-propriété des parts sociales, détenues par Monsieur Pascal Collotte, Madame Marie-Chrystel Manon,
145137
L
U X E M B O U R G
Madame Clémence Collotte et Monsieur Victor Collotte, prénommés, dans les sociétés suivantes (ci-après les «Sociétés
Françaises») à savoir:
1) Dans la société «SCE DU CHATEAU JEAN FAUX», société civile d’exploitation agricole de droit français au capital
de EUR 3.465.975.-, ayant son siège social à F-33350 Sainte-Radegonde, Château Jean Faux, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro 443.768.908:
- quatre-vingt-douze mille quatre cent seize (92.416) parts sociales en pleine propriété appartenant à Monsieur Pascal
Collotte, évaluées à un million neuf cent soixante-six mille huit cents euros (EUR 1.966.800.-)
- dix (10) parts sociales en pleine propriété appartenant à Madame Marie-Chrystel Manon, évaluées à deux cents euros
(EUR 200.-)
Soit 100% du capital social de la SCE DU CHATEAU JEAN FAUX
2) Dans la société «SCI D’ALBRET», société civile immobilière de droit français au capital de EUR 42.484.-, ayant son
siège social à F-33350 Sainte-Radegonde, Château Jean Faux, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Libourne sous le numéro 431.382.688:
- neuf mille quatre cent soixante-dix-sept (9.477) parts sociales en usufruit appartenant à Monsieur Pascal Collotte,
évaluées à deux cent mille deux cents euros (EUR 200.200.-)
- mille cent quarante-quatre (1.144) parts sociales en usufruit appartenant à Madame Marie-Chrystel Manon, évaluées
à vingt-huit mille neuf cent euros (EUR 28.900.-)
- cinq mille trois cent dix (5.310) parts sociales en nue-propriété appartenant à Madame Clémence Collotte, évaluées
à cent neuf mille huit cents euros (EUR 109.800.-)
- cinq mille trois cent dix (5.310) parts sociales en nue-propriété appartenant à Monsieur Victor Collotte, évaluées à
cent neuf mille huit cents euros (EUR 109.800.-)
- une (1) part sociale en nue-propriété appartenant en indivision à Madame Clémence Collotte et Monsieur Victor
Collotte, évaluée à cent euros (EUR 100.-)
Soit 100% du capital social de la SCI D’ALBRET
3) Dans la société «SCI MANON-COLLOTTE», société civile immobilière de droit français au capital de EUR 4.110.-,
ayant son siège social à F-33350 Sainte-Radegonde, Château Jean Faux, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Libourne sous le numéro 419.425.798:
- cent trente-sept (137) parts sociales en pleine propriété appartenant à Monsieur Pascal Collotte, évaluées à deux
cent quarante-six mille trois cents euros (EUR 246.300.-)
- quatre-vingt-sept (87) parts sociales en usufruit appartenant à Monsieur Pascal Collotte, évaluées à soixante-dix-huit
mille deux cents euros (EUR 78.200.-)
- cinquante (50) parts sociales en usufruit appartenant à Madame Marie-Chrystel Manon, évaluées à cinquante-quatre
mille euros (EUR 54.000.-)
- soixante-huit (68) parts sociales en nue-propriété appartenant à Madame Clémence Collotte, évaluées à soixante-
et-un mille cent euros (EUR 61.100.-)
- soixante-huit mille (68) parts sociales en nue-propriété appartenant à Monsieur Victor Collotte, évaluées à cinquante-
deux mille deux cents euros (EUR52.200.-)
- une (1) part sociale en nue-propriété appartenant en indivision à Madame Clémence Collotte et Monsieur Victor
Collotte, évaluée à neuf cents euros (EUR 900.-)
Soit 100% du capital social de la SCI MANON-COLLOTTE
4) Dans la société «SCI DE LA DOUANE», société civile immobilière de droit français au capital de EUR 400.000.-,
ayant son siège social à F-33.350 Sainte-Radegonde, Château Jean Faux, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Libourne sous le numéro 750.449.241:
- quatre-vingts (80) parts sociales en pleine propriété appartenant à Monsieur Pascal Collotte, évaluées à soixante-
douze mille euros (EUR 72.000.-)
- cinquante-deux (52) parts sociales en usufruit appartenant à Monsieur Pascal Collotte, évaluées à vingt-trois mille
quatre cents euros (EUR 23.400.-)
- cent trente-deux (132) parts sociales en usufruit appartenant à Madame Marie-Chrystel Manon, évaluées à soixante-
et-onze mille deux cents euros (EUR 71.200.-)
- soixante-six (66) parts sociales en pleine propriété appartenant à Madame Clémence Collotte, évaluées à cinquante-
neuf-mille quatre cents euros (EUR59.400.-)
- quatre-vingt-douze (92) parts sociales en nue-propriété appartenant à Madame Clémence Collotte, évaluées à trente-
cinq mille cinq cents euros (EUR35.500.-)
- soixante-six (66) parts sociales en pleine propriété appartenant à Monsieur Victor Collotte, évaluées à cinquante-
neuf mille quatre cents euros (EUR59.400.-)
- quatre-vingt-douze (92) parts sociales en nue-propriété appartenant à Monsieur Victor Collotte, évaluées à trente-
cinq mille cinq cents euros (EUR 35.500.-)
145138
L
U X E M B O U R G
- quatre (4) parts sociales en pleine propriété appartenant en indivision à Monsieur Pascal Collotte (pour un tiers),
Madame Marie-Chrystel Manon (pour un tiers), Madame Clémence Collotte (pour un sixième) et Monsieur Victor Col-
lotte (pour un sixième), évaluées à trois mille six cents euros (EUR 3.600.-)
Soit 100% du capital social de la SCI DE LA DOUANE
Ci-après dénommées les «Parts Sociales Françaises».
Cette contribution a fait l'objet d'un rapport établi en date de ce jour par FIDEWA-CLAR S.A., réviseur d'entreprises,
ayant son siège social à Leudelange, 2, rue du Château, RCS Luxembourg B165.462, conformément aux articles 32-1 et
26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
La conclusion du rapport est la suivante:
<i>«Conclusioni>
Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de
l'apport autre qu'en numéraire d'un montant de EUR 3.268.500,- ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur
nominale des 32.652 nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 100,- à émettre par la Société en contrepartie,
assortie d'une soulte d'un montant de EUR 3.300,-.»
Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
Compte tenu du montant de l'augmentation de capital tel que décidée ci-avant et de la valeur des Parts Sociales
Françaises telle que déterminée ci-avant, la Société versera aux apporteurs une soulte d'un montant de trois mille trois
cents euros (EUR 3.300.-) à concurrence de deux mille trois cents euros (EUR 2.300.-) pour Monsieur Pascal Collotte,
quatre cent cinquante euros (EUR 450.-) pour Madame Clémence Collotte et cinq cent cinquante euros (EUR 550.-) pour
Monsieur Victor Collotte, selon les modalités fixées entre parties.
Les apporteurs, représentés comme indiqué ci-avant, certifient par la présente qu'au jour et au moment de la contri-
bution:
1. ils sont propriétaires de toutes les Parts Sociales Françaises apportées;
2. toutes les formalités de transfert ont été respectées et il n'y a pas de droit de préemption ni autres droits attachés
aux Parts Sociales Françaises par lesquels une quelconque personne serait en droit de demander qu'une ou plusieurs
Parts Sociales Françaises lui soient transférées;
3. ils ont tous pouvoirs sociaux pour accomplir et exécuter les documents nécessaires au présent transfert;
4. les Parts Sociales Françaises, sont, à la meilleure connaissance des apporteurs, libres de toute charge et librement
transférables à la Société;
5. le transfert des Parts Sociales Françaises dans les Sociétés Françaises sera inscrit dans le registre des associés de
ces sociétés.
Les documents confirmant que les apporteurs sont bien inscrits comme associés desdites sociétés et que les Parts
Sociales Françaises sont librement transférables à la Société, ont été fournis au notaire soussigné.
Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert des Parts Sociales Françaises, les appor-
teurs prendront toutes les mesures nécessaires dès que possible.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts
de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital Social. (Premier alinéa). La Société a un capital social de trois millions trois cent trente-cinq mille deux
cents euros (EUR 3.335.200.-) représenté par trente-trois mille trois cent-cinquante deux (33.352) actions avec une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, auxquelles sont attribués les droits et obligations tels que décrits dans les
présents statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts de la Société et de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée, l'assemblée générale décide de nommer deux administrateurs supplémentaires en plus
de l'administrateur actuel Monsieur Pascale Collotte, à savoir:
- Madame Marie-Chrystel Manon, prénommée, née le 25 décembre 1965 à Libourne (France), demeurant à L-1537
Luxembourg, 9, rue des Foyers.
- Madame Clémence Collotte, prénommée, née le 9 juillet 1990 à Libourne (France), demeurant à F-33000 Bordeaux
(France), 4, rue Emile Duployé.
Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de
l'exercice social prenant fin au 31 décembre 2013.
145139
L
U X E M B O U R G
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de trois mille huit cents euros (EUR 3.800.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M. KAISER, C. GESCHWIND, E. LEBEAU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 octobre 2013. LAC/2013 /45954. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri>
(signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 28 octobre 2013.
Référence de publication: 2013151207/201.
(130184565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Marche Investissements SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 88.237.
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 30 septembre 2013i>
Démission de Monsieur Sidney Bouvier en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Serge Hirsch, né le 22 décembre 1963, demeurant professionnellement au 16, boulevard
Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Marc Ambroisien, administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle de 2014.
POUR EXTRAIT SINCERE ET CONFORME
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013151241/15.
(130184585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
La Cascade Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 59, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 181.217.
STATUTS
L'an deux mille treize, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
Monsieur Vitaly MALKIN, homme d'affaires, né à Sverdlovsk (Russie), 16 septembre 1952, demeurant à L-2320 Lu-
xembourg, 59 boulevard de la Pétrusse, ici représenté par Monsieur Alexander FEDOSEEV, salarié, demeurant profes-
sionnellement à L-2320 Luxembourg, 59 boulevard de la Pétrusse, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après
avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.
Lequel comparant a, par son mandataire, arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:
Titre I
er
. - Dénomination - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme sous la dénomination de «LA CASCADE LUXEMBOURG S.A.» (ci-après la Société").
Art. 2. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La Société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un porte-feuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
145140
L
U X E M B O U R G
d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore
autrement; la Société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.
La Société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques,
sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-
cières, susceptibles de favoriser l'accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.
Titre II. - Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une
valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Titre III. - Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associé unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit
à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier mercredi du mois de juin à 11 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.
145141
L
U X E M B O U R G
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Titre IV. - Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
145142
L
U X E M B O U R G
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.
Titre V. - Surveillance de la Société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
Titre VI. - Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
Titre VII. - Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Titre VIII. - Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
Titre IX. - Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2014.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, préqualifié, lequel
les a toutes libérées par versements en espèces d'un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) entièrement
alloués au capital social.
La somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, tel qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le confirme expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de 1.150,- EUR.
145143
L
U X E M B O U R G
<i>Résolutions prises par l'actionnaire uniquei>
Le comparant, prédésigné et représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris
les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:
1.- L'adresse du siège social est établie à L-2320 Luxembourg, 59 boulevard de la Pétrusse.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à un, et celui des commissaires aux comptes à un.
3.- Comme autorisé par la Loi et les statuts, Monsieur Leon SIMAN, directeur, né à Leningrad (Russie), le 7 août 1966,
demeurant à L-8125 Bridel, 6 rue des Carrières, est appelé à la fonction d'administrateur unique et exercera les pouvoirs
dévolus au conseil d'administration de la Société.
4.- Fiduciaire Di Fino & associés S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre
Dupong, représenté par son gérant actuellement en fonction et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 103.178, est appelé aux fonctions de commissaire.
5.- Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de 2019.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Alexander FEDOSEEV, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 octobre 2013. Relation GRE/2013/4313. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2013151219/205.
(130184824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
K-FÉE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1424 Luxembourg, 13, rue André Duchscher.
R.C.S. Luxembourg B 151.547.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
S. François
<i>Gérant Administratifi>
Référence de publication: 2013151197/11.
(130185437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Kaporal Manco S.à r.l. Holdings SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 178.271.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 11 juillet 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 12 août 2013.
Référence de publication: 2013151199/11.
(130185111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Kochav, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 159.218.
Je vous informe de ma démission de mon mandat de Gérant du Conseil de Gérance de la société Kochav S.à r.l. avec
effet au 25 octobre 2013.
Luxembourg, le 25 octobre 2013.
EMOND Valérie.
Référence de publication: 2013151200/10.
(130184731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
145144
L
U X E M B O U R G
Kochav, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 159.218.
Je vous informe de ma démission de mon mandat de Gérant du Conseil de Gérance de la société Kochav S.à r.l. avec
effet au 25 octobre 2013.
Luxembourg, le 25 octobre 2013.
MORANDINI Alberto.
Référence de publication: 2013151202/10.
(130184731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Kirpal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 132.434.
Les comptes de clôture au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013151204/10.
(130185297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
L'Occitane International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 80.359.
Changement d'adresse à effet du 15 juillet 2013 de Monsieur Karl Guénard, Administrateur de l'Occitane International
S.A., au 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2013.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013151209/13.
(130184935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
IS European Projects Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 127.030.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151183/9.
(130184668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
IS Projects One Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 127.026.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151185/9.
(130184675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
IS Projects Two Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 127.261.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
145145
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151187/9.
(130184683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
IS Eurologistics Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 118.257.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151181/9.
(130184650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
IPFR S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 105.158.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151179/9.
(130184641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
J.C.2A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3712 Rumelange, 24, rue des Artisans.
R.C.S. Luxembourg B 136.504.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151191/9.
(130184768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
IG Log 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 117.030.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151158/9.
(130184624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
IHS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 171.974.
Les comptes annuels au 30 novembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151164/9.
(130185272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Inovatec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach.
R.C.S. Luxembourg B 117.741.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151173/9.
(130185178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
145146
L
U X E M B O U R G
LVS ULYSSE Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 59.711.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement à Larochette le 24 octobre 2013 que les mandats
des personnes suivantes ont été révoqués: de la société ANDREAS CAPITAL SUXESKEY S.A. (anc. "Suxeskey") et de
Mme Raymonde Gokke, "Administrateurs" ainsi que celui de la société A&C Management Services Sàrl avec effet le
03/01/2013 en tant que "commissaire".
En lieu et place, les personnes suivantes ont été élues jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2019:
<i>Administrateurs:i>
- ANDREAS MANAGEMENT SERVICES Sàrl, société de droit luxembourgeoise, ayant son siége social à 10-12, rue
de Medernach, L-7619 Larochette avec effet à partir du 15/08/2013;
- Monsieur Joseph ROTTEVEEL, ayant son siège professionnel à 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette avec
effet à partir du 01/07/2013;
<i>Commissaire aux comptes:i>
- ANDREAS AUDIT SERVICES, société de droit luxembourgeoise ayant son siége social à 10-12, rue de Medernach,
L-7619 Larochette avec effet à partir du 15/08/2013.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée
désigne Monsieur SCHREUDERS Bastiaan Lodewijk Melchior, 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette, comme
représentant permanent de la société ANDREAS MANAGEMENT SERVICES Sàrl, inscrite au RCSL sous le numéro
B-179712.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 24 octobre 2013.
*.
Référence de publication: 2013151236/27.
(130185340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Luxehold S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 171.936.
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions de gérant de votre
société et ceci avec effet au 4 septembre 2013.
Luxembourg, le 30 août 2013.
Ruslan Pankhasovich SHUMSHUMOV.
Référence de publication: 2013151232/10.
(130185201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Luximpe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2445 Luxembourg, 46, rue des Roses.
R.C.S. Luxembourg B 135.697.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2013151233/11.
(130185090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Lux-Prestige Concept s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 152.734.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
145147
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013151231/10.
(130184752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Lungta s. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4901 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.
R.C.S. Luxembourg B 145.747.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30/10/2013.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2013151230/12.
(130185177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Luxparts, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5532 Remich, 9, rue Enz.
R.C.S. Luxembourg B 137.126.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2013151234/11.
(130185409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
M and M Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 42.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 134.413.
Les comptes consolidés pour la période du 23 février 2009 au 21 février 2010 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2013.
Référence de publication: 2013151237/11.
(130185034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
LV Investissement Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 67.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 110.911.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2013.
Référence de publication: 2013151235/10.
(130185436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Loizelle SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 135.808.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
145148
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Référence de publication: 2013151228/10.
(130185355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Le Colibri S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3716 Rumelange, 2-4, rue de la Croix.
R.C.S. Luxembourg B 136.707.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2013151222/10.
(130185137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Matignon Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 105.777.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Matignon Finance S.A.
J-L Camuzat / L. Abensour / S. Faye Chellali
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013151242/13.
(130184976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Mateco Location de Nacelles S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1113 Luxembourg, 12A, rue John L. Mac Adam.
R.C.S. Luxembourg B 56.496.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151247/10.
(130184862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Medinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 115.727.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2013.
Référence de publication: 2013151253/10.
(130184883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Mediainspekt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 63.519.
Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013151252/10.
(130184835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
145149
L
U X E M B O U R G
Nouveaux Ets. Liebaert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, rue Neihaischen.
R.C.S. Luxembourg B 26.319.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151275/9.
(130185411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
MB Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 160.152.
<i>Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 juillet 2013i>
<i>Résolutionsi>
L'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions ci-dessous:
Monsieur CELSO GOMES DOMINGUES, né le 21 février 1978 à Luxembourg, demeurant à 4 Rue de Goetzange,
L-8393 Olm, est nommé en date de la présente assemblée comme administrateur de la société, suite à la démission de
Monsieur PATRICK ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS, datée du 10 juin 2013.
La durée du mandat des nouveaux administrateurs de la société prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de 2015.
Référence de publication: 2013151248/15.
(130184687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Occitan Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 67.922.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151282/9.
(130185439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Oekostroum S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6557 Dickweiler, 11, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 169.659.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151281/9.
(130184800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Oasis Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 147.221.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2013.
Référence de publication: 2013151280/10.
(130185430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
145150
L
U X E M B O U R G
NW G 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 175.667.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Référence de publication: 2013151279/11.
(130185286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Pronovem Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 10-12, avenue du Rock'n'Roll.
R.C.S. Luxembourg B 98.704.
L'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2013 accepte à l'unanimité la démission de l'administrateur Mon-
sieur Dominique Rifon.
Monsieur Armand Schmitt, demeurant à 3, rue Alphonse Munchen, L-8082 Bertrange, est nommé nouvel administra-
teur et administrateur délégué de la société, ses mandats se terminant en l'an 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2013.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2013151319/15.
(130185184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Quadra Mainz Volkspark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 120.171.
Der Jahresabschluss vom 31 Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151326/10.
(130184723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Quadra Mainz Telekom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 120.169.
Der Jahresabschluss vom 31 Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151325/10.
(130184722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Quadra Mainz BZ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 120.170.
Der Jahresabschluss vom 31 Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151324/10.
(130184721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
145151
L
U X E M B O U R G
Quadra Hamburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 120.175.
Der Jahresabschluss vom 31 Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013151323/10.
(130184720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Pfizer Holdings Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 136.369.
<i>Extrait rectificatif L130183661i>
Il résulte du transfert de parts réalisé en date du 28 octobre 2013 que Pfizer Holdings International Corporation,
transfère toutes les 2400 parts sociales qu'elle détient dans la Société à; Pharmacia Hepar LLC, (une société incorporated),
enregistrée au Registre du Delaware sous le numéro 2117527, ayant son siège social au 235 East 42
nd
Street, 10017
New York Etats Unis d'Amérique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2013.
Référence de publication: 2013151311/14.
(130184845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.
e-Space S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5371 Schuttrange, 9, An der Uecht.
R.C.S. Luxembourg B 114.701.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013151517/10.
(130185932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.
e-Guide S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1232 Howald, 53, rue Ernest Beres.
R.C.S. Luxembourg B 111.809.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013151516/10.
(130186357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.
agraferm technologies luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 17, rue de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 114.867.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013151514/10.
(130186363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
145152
agraferm technologies luxembourg s.à r.l.
AXA Alternative Participations IV, SICAV-FIS
e-Guide S.à r.l.
e-Space S.à r.l.
IG Log 2 S.à r.l.
IHS Luxembourg S.à r.l.
IK Investment Partners S.à r.l.
Inovatec S.à r.l.
International Corporate Technologies Holding S.A.
International Corporate Technologies S.A.
IPFR S.à.r.l.
IS Eurologistics Investments Sàrl
IS European Projects Sàrl
IS Projects One Sàrl
IS Projects Two Sàrl
Issin Investments SA
J.C.2A S.à r.l.
Kaporal Manco S.à r.l. Holdings SCA
K-FÉE
Kirpal S.A.
KJK Management S.A.
Klee Holding S.A.
Kochav
Kochav
Kochav
Kompil S.A.
Krentz & Griffin S.à r.l.
La Cascade Luxembourg S.A.
Le Colibri S.à r.l.
Leverkusen Innovation Park S.à r.l.
Lifetime Immobilière S.A.
L'Occitane International S.A.
Loizelle SA
Luminant Investments S.à.r.l.
Lungta s. à r.l.
Luxamo
Luxehold S.à r.l.
Luximpe S.à r.l.
Luxparts
Luxpresta S.A.
Lux-Prestige Concept s.à r.l.
LV Investissement Europe S.à r.l.
LVS ULYSSE Invest S.A., SPF
M and M Holdings Sàrl
Manling
Marche Investissements SPF S.A.
Marie Property S.A.
Mateco Location de Nacelles S.A.
Matignon Finance
MB Investment S.A.
Mediainspekt S.A.
Medinvest S.A.
Nouveaux Ets. Liebaert S.à r.l.
NW G 2 S.à r.l.
Oasis Real Estate S.à r.l.
Occitan Investments S.A.
Oekostroum S.A.
Pfizer Holdings Luxembourg Sàrl
Pronovem Luxembourg S.A.
Quadra Hamburg S.à r.l.
Quadra Mainz BZ S.à r.l.
Quadra Mainz Telekom S.à r.l.
Quadra Mainz Volkspark S.à r.l.
VB (Luxembourg) S.à r.l.