logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2857

14 novembre 2013

SOMMAIRE

Accretio SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137102

ACHM Global Hospitality Licensing S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137107

Adeline Institut S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137103

Alves Constructions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

137098

AOL Europe Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

137099

AOL Holdings (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

137098

AOL Holdings (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

137099

Aprotec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137099

Archi-Concept International S.à.r.l.  . . . . . .

137099

Argor International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

137101

Arina S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137112

Aropa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137101

Asco Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137101

Asco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137101

Atrilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137112

Babillou s. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137104

Baltis Investment, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

137104

Barthelme S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137103

Batimmo Constructions S.à r.l. . . . . . . . . . .

137104

BENESHARE TRANSPORT GROUP (Lu-

xembourg) S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137104

BISSELL International Finance Company,

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137111

Black & Decker International Holdings

B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137108

Blue Planet Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137111

BNP Paribas InstiCash  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137136

Bonnefoit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137116

Brading Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

137113

Brading Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

137113

Brandenburg Properties S.à r.l. . . . . . . . . . .

137099

Brunelcap S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137104

BTG Pactual Oil&Gas S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

137113

BTMU Unit Management S.A. . . . . . . . . . . .

137105

Bureau Immobilier Lea Kappweiler S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137112

Butzestuff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137112

Byron Enterprises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137100

Dexiastuff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137104

ECVV Business Solutions S.à r.l.  . . . . . . . . .

137098

Elvon Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

137090

Ely Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137098

European Institute for Applied Sciences SA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137095

Exelon Nuclear Partners International S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137096

Eye 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137095

Guineu Immobles Luxembourg S.A.  . . . . .

137134

International Mode Investment S.A.  . . . . .

137131

International Soccer Consulting S.A. . . . . .

137131

JFA & Interfaces Est.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137130

JM Investissements S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

137130

Jonas Architectes Associés S.A.  . . . . . . . . .

137130

Kara Finance SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137136

Kawa Solar Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

137117

Konstrulux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137130

Köpco Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137132

KUHN Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137131

Lafayette 23 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137132

Lagoon Finance S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

137131

Lagoon Holding S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

137132

Landgame S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137133

Leggett & Platt Luxembourg Finance

Company S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137116

Leggett & Platt Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

137133

Luxury Holding of Luxembourg S.à r.l.  . . .

137133

PE développement Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

137130

Shamil Real Estate Financing S.A.  . . . . . . .

137136

SW III Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137134

137089

L

U X E M B O U R G

Elvon Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 180.654.

STATUTES

In the year two thousand thirteen, on the twenty-sixth day of September.
Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BIANCHI PROPERTIES S.à r.l., a company limited by shares, having its registered office in L-1420 Luxembourg, 7,

Avenue Gaston Diderich, in course of registration with the Luxembourg trade and companies register,

here represented by Mr. Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, by virtue of a power

of attorney, given on September 25 

th

 , 2013.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may become

partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws
pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10 

th

 August, 1915 on commercial companies, as well as by

the present articles (hereafter the "Company").

Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, directly

or indirectly, of real estate of any nature or origin, whatsoever, located in Luxembourg or any other jurisdiction.

The object of the Company is further the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange

or in any other way undertakings and companies either Luxembourg or foreign entities as well as the management, control,
and development of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means
of sale, exchange or otherwise. The Company may further acquire by subscription, purchase, and exchange or in any
other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

The Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem

useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in other companies in Luxembourg
or foreign, remunerated or not.

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and intangible rights as well

as any other rights connected to them or which may complete them.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds  of  any borrowings and/or issues  of  debt securities  to  its subsidiaries,  affiliated companies  or to any  other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and others risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its the above described objects."

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name "Elvon Properties S.à r.l.".

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR

12,500.-) represented by FIVE HUNDRED (500) shares having a nominal value of TWENTY FIVE EUROS (EUR 25.-) per
share each.

137090

L

U X E M B O U R G

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders

meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements

of article 189 of the law of 10 

th

 August, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

individual signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a
general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of
the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state
that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any
manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex
another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the
board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing
in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the law of 10 

th

August, 1915, as amended.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31 

st

 December, the Company's accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities.

137091

L

U X E M B O U R G

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners

or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10 

th

 August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by the company "Bianchi Properties S.à r.l.", prenamed and

have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) corresponding to a
share capital of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company,
as has been proved to the notary.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 

st

 December, 2013.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand one hundred fifty
euros (EUR 1,150.-).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has

herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at three. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

a. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a Luxembourg société anonyme, having its registered office in

L-1653 Luxembourg, 2-8 Avenue Charles de Gaulle, registered with the Luxembourg trade and companies register under
the number B 37.974;

b. Mrs. Christelle FERRY, director, born on 10 October 1970 in Metz (France), professionally residing in L-1653

Luxembourg, 2-8 Avenue Charles de Gaulle;

c. Mr Xavier DE CILIA, born on 11 April 1978 in Nice (France), professionally residing at L-1653 Luxembourg, 2-8

Avenue Charles de Gaulle,

2) The address of the registered office is established in L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

BIANCHI PROPERTIES S.à r.l., une société constituée selon le droit du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège

social à L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich, en cours d'immatriculation auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés,

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, en

vertu d'une procuration donnée le 25 Septembre 2013.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

137092

L

U X E M B O U R G

Laquelle comparante, agissant en-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une

société à responsabilité limitée et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la vente pour son propre compte, direc-

tement ou indirectement, de biens immobiliers de quelque nature ou origine que ce soit, situés au Luxembourg ou dans
tout autre pays.

L'objet social de la Société est également l'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, par achat,

échange ou de toute autre manière, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La Société pourra également acquérir par souscription, achat, et échange
ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt
et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou
privée.

La Société pourra prendre toutes les mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent

lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d'administration d'au-
tres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérées ou non.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels

et incorporels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder par

voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra consentir
des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou celles de ses filiales, sociétés
affiliées ou de toute autre société. La Société pourra aussi gager, nantir, grever, transférer, grever tout ou partie de ses
avoirs.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque de crédit, les
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et tout autre risque.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions

se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à
la réalisation de son objet tel que décrit ci-dessus.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de «Elvon Properties S.à r.l.»

Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-)

représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée

des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas

fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil

de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

137093

L

U X E M B O U R G

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature individuelle de l'un quelconque des membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi
ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le
cadre des compétences du Conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence.
On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils
déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil
de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil
de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par
écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil
de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les
résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date
de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,

les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 15. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre
disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra
décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de

la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et Libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par la société «Bianchi Properties S.à r.l.», précitée et ont été

entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) correspondant à un capital

137094

L

U X E M B O U R G

social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) soit à la disposition de la Société, comme il a été justifié au notaire
soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cent cinquante euros (EUR
1.150,-EUR).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit

ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérant est fixé à trois. Sont nommés gérant pour une durée indéterminée:
a. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société anonyme avec siège social à L-1653 Luxembourg,

2-8, avenue Charles de Gaulle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
37.974;

b. Madame Christelle FERRY, née le 10 octobre 1970 à Metz (France), résidant professionnellement à L-1653 Luxem-

bourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle;

c. Monsieur Xavier DE CILLIA, né le 11 avril 1978 à Nice (France), résidant professionnellement au L-1653 Luxem-

bourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle,

2. L'adresse du siège social de la société est établi à L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich.

DONT ACTE, le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les comparantes l'ont requis de

documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi, fait et passé à Luxembourg, Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 septembre 2013. Relation GRE/2013/3930. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 8 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141186/302.
(130172504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

EIFAS SA, European Institute for Applied Sciences SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 36B, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 178.477.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Freitag, 16.08.2013

Der alleinige Aktionärt in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft wurde verlegt von 46, boulevard de la Fraternité, L-1541 Luxemburg zum neuen Gesell-

schaftssitz 36B, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg.

Référence de publication: 2013141198/11.
(130172668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Eye 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.915.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 111.137.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

137095

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141200/11.
(130172439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Exelon Nuclear Partners International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 161.386.

In the year two thousand and thirteen, on the ninth day of September.
Before Us Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the sole shareholder of Exelon Nuclear Partners In-

ternational S.à r.l., a private limited liability company (société à repsonsabilité limitée), having its registered office at 6C,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and com-
panies' register under number B 161.386, (the "Company"), which has been incorporated pursuant to a deed of the notary
Maître Francis Kesseler, dated May 9 

th

 , 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the

"Mémorial C"), number 1960, dated August 25 

th

 , 2011 (the "Articles"). The Articles have not been amended ever since.

THERE APPEARED:

Exelon Nuclear Partners, LLC, a limited liability company of the state of Delaware, United States of America, having

its registered office at 200 Exelon Way, Kennet Square, Pennsylvania 19348, United States of America, registered with
the register of commerce and companies of the state of Delaware under number 4931460, duly represented by Ms.
Nathalie Clercx, private employee, with professional address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in (the "Sole Shareholder").

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. Currently, the Sole Shareholder holds all the twelve thousand five hundred (12,500) shares in the subscribed share

capital of the Company;

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Decision to transfer the registered office of the Company from 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-

Duchy of Luxembourg to 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

2. Subsequent amendment of Article 2 of the Articles of the Company to reflect the transfer of the registered office

of the Company; and

3. Miscellaneous.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to transfer the registered office of the Company from 6C, rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg to 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg.

<i>Second resolution

As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder RESOLVES to adapt Article 2 of the Articles of the Company

to the aforementioned change, which shall forthwith read as follows: "The registered office of the Company is established
in Luxembourg. "It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by mean of a resolution
of an extraordinary meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

"However, the Board of Managers of the Company is authorised to transferthe registered office of the Company within

the City of Luxembourg.

"Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on this Company's nationality, which,  notwithstanding  this  temporary transfer of  the registered  office, will remain a
Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of
Managers."

137096

L

U X E M B O U R G

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

Whereof the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

<i>Declaration

The undersigned notary, who knows English and French, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le neuvième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Exelon Nuclear Partners In-

ternational  S.à  r.l.,  une  société  à  responsabilité  limitée,  ayant  son  siège  social  au  6C,  rue  Gabriel  Lippmann,  L-5365
Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 161.386 (la Société), qui a été constituée suivant un acte de Maître Francis Kesseler daté du 9
mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C»), numéro 1960, daté du 25 août
2011. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis ce jour-là.

A COMPARU

Exelon Nuclear Partners, LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) de l'état du Delaware,

Etats Unis d'Amérique, ayant son siège social au 200, Exelon Way, Kennet Square, Pennsylvania 19348, Etats-Unis d'Amé-
rique et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de l'état du Delaware sous le numéro 4931460,
dûment représentée par Mlle Nathalie Clercx, employé privé ayant son adresse professionnel au 121, avenue de la Faïen-
cerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé (l'«Associé
Unique»).

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. A cet instant, l'Associé Unique détiens toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales représentatives du

capital social souscrit de la Société;

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Décision de transférer le siège social de la Société du 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché

de Luxembourg au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

2. Modification subséquente de l'article 2 des Statuts afin de refléter le transfert du siège social de la Société; et
3. Divers
III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique DECIDE de transférer le siège social de la Société du 6C, rue Gabriel Lippman, L-5365 Munsbach,

Grand-Duché de Luxembourg au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique DECIDE de modifier l'Article 2 des Statuts de la Société

à la modification susmentionnée, qui se lira désormais comme suit: «Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
«Il peut être transféré en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg parune délibération de l'assemblée générale
extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

«Toutefois, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la Ville de

Luxembourg.

«Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compro-

mettre l'activité normale au siège social de la Société se serait produits ou seraient imminents, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire
n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Conseil de Gérance.»

137097

L

U X E M B O U R G

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont

mis à sa charge à raison des présentes sont estimés approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Le présent acte a été rédigé à Esch/Alzette, le jour figurant en en tête du document

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui connaît l'anglais et le français, constate sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise prévaudra.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de ladite comparante a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: Clercx, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11826. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013141199/118.
(130172246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Ely Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1947 Luxembourg, 22, rue Joseph Leydenbach.

R.C.S. Luxembourg B 163.831.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ELY CONSULTING S.A.

Référence de publication: 2013141206/10.
(130172478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

ECVV Business Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 161.886.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013141201/10.
(130172306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Alves Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8705 Useldange, 35, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 104.256.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013141753/10.
(130173621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

AOL Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 72.380.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des associées en date du 30 septembre 2013

La société anonyme ERNST &amp; YOUNG a été reconduite dans son mandat de réviseur d'entreprises agréé jusqu'à

l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.

137098

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AOL Holdings (Lux) S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013141759/14.
(130173333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

AOL Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 72.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AOL Holdings (Lux) S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013141758/11.
(130173323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

AOL Europe Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 72.728.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AOL EUROPE SERVICES S.à.r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013141757/11.
(130173341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Aprotec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9150 Eschdorf, 30A, Klatzber.

R.C.S. Luxembourg B 105.661.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour APROTEC S.A.
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013141760/11.
(130173400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Archi-Concept International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange.

R.C.S. Luxembourg B 76.670.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013141761/9.
(130172937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Brandenburg Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 115.636.

Les comptes annuels de la société au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

137099

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013141788/12.
(130173609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Byron Enterprises, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 85.073.

L'an deux mille treize, le trente septembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «BYRON ENTERPRISES»,

avec siège social à L-4629 Differdange, 8, Place Millchen, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse LENTZ,
alors  notaire  de  résidence  à  Remich  en  date  du  13  décembre  2001,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations, numéro 547 du 9 avril 2002, dont les statuts ont été modifiés pour a dernière fois par le notaire Francis
Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette en date du 6 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 198 du 16 février 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnel-

lement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

qui désigne comme secrétaire Madame Irena COLAMONICO, employée privée, demeurant professionnellement à la

même adresse.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à

la même adresse.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste
de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être sou-
mises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle à L-4629 Differdange, 8, Place Millchen vers L-2449

Luxembourg, 25a, Boulevard Royal et modification afférente de l’alinéa 3 

ème

 du 1 

er

 article des statuts de la société afin

de lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»
2. Divers.
Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de changer l’adresse du siège social de la société de L-4629 Differdange, 8, Place Millchen à L-2449

Luxembourg, 25a, Boulevard Royal et de modifier par subséquent l'article 1, 3 

e

 alinéa des statuts, qui aura désormais la

teneur suivante:

 Art. 1 

er

 . Troisième alinéa.  Le siège social est établi à Luxembourg.".

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Thill, I. Colamonico, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 octobre 2013. Relation: LAC/2013/44669. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur (signé) : Irène THILL.

137100

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141817/54.
(130173391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Aropa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 21, rue des Muguets.

R.C.S. Luxembourg B 152.983.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 11 octobre 2012

<i>Adminstrateur:

L'Assemblée générale accepte la démission de M. Marc Dieschbourg, né le 07.09.1961 à Luxembourg (Luxembourg)

du poste d'administrateur.

L'Assemblée générale décide de nommer administrateur M. Joachim Friedrich, né le 10.03.1954 à Wittlich (Allemagne),

demeurant Untern Burgberg 30, D-54518 Dreis (Allemagne)

Le mandat courra jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

<i>Commissaire:

L'Assemblée générale accepte la démission de M. Paul Dieschbourg, né le 23.11.1933 à Useldange (Luxembourg) du

poste commissaire aux comptes.

L'Assemblée générale décide de nommer commissaire M. Marc Dieschbourg, né le 07.09.1961 à Luxembourg (Lu-

xembourg), demeurant 78, rue des Eglantiers, L-1457 Luxembourg (Luxembourg).

Le mandat courra jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 octobre 2013.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2013141766/23.
(130173582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Asco Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 53.496.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2013141767/11.
(130173801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Asco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 77.875.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013141768/10.
(130173345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Argor International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 119.953.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

137101

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013141763/10.
(130172969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Accretio SPF, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Pa-

trimoine Familial.

Capital social: EUR 640.000,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 136.084.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le vingt septembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société coopérative organisée comme une société anonyme

"ACCRETIO SPF ", avec siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'activités, R.C.S Luxembourg numéro B136084, con-
stituée sous signe privé le 2 janvier 2008, publié au Mémorial C numéro 752 du 28 mars 2008,

ayant un capital social fixe de six cent quarante mille euros (640.000,-EUR), représenté par six cent quarante (640)

actions de la classe A d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux
assemblées générales.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Jun-

glinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Cristiana SCHMIT, employée, demeurant professionnellement à Jun-

glinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster,

3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée désigne Monsieur Filip VANHEUSDEN, de nationalité belge, né le 27 mai 1966 à Genk (Belgique), avec

résidence professionnelle à L-8308 Capellen, 75, Parc d'activités, comme liquidateur de la société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la

loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette auto-
risation est normalement requise.

137102

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société à savoir Messieurs Filip VANHEUSDEN,

Louis KEMPS et Gwenny Corry VAN PULVER, aux administrateurs délégués à savoir Messieurs Filip VANHEUSDEN et
Louis KEMPS, et au commissaire de la société à savoir Client Audit Services S.A., pour l'exécution de leur mandat.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de 1.300,- EUR, sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bob PLEIN, Cristiana SCHMIT, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 septembre 2013. Relation GRE/2013/3870. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013141742/64.
(130173117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Adeline Institut S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 54, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 94.086.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2013141744/10.
(130172929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Barthelme S.C.I., Société Civile.

Siège social: L-8041 Strassen, 34, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg E 1.004.

DISSOLUTION

<i>Extrait de dissolution du 4 octobre 2013

L'AN DEUX MILLE TREIZE
Le quatre octobre
Se sont réunis:
1. Monsieur Jean-Pierre Barthelme, demeurant à L-8041 Strassen, 34, rue des Romains.
2. Madame Lucienne Barthelme-Flick, demeurant à L-8041 Strassen, 34, rue des Romains
Qui ont déterminé:
I.- Qu'ils sont les seuls associés de la société civile BARTHELME S.C.I., avec siège social à L-8041 Strassen, 34, rue des

Romains, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro E 1004.

II.- Que le capital social de la BARTHELME S.C.I. est reparti de manière suivante:

1. Monsieur Jean-Pierre Barthelme, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Madame Lucienne Barthelme-Flick, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

III.- Que les associés, présents ou représentés comme dit ci-avant, décident la dissolution de la société avec effet au

4 octobre 2013.

IV.- Que les associés, présents ou représentés comme dit ci-avant, s'engagent à reprendre personnellement et soli-

dairement l'actif et le passif de la société selon les règles du droit luxembourgeois.

V.- Que les associés, présents ou représentés comme dit ci-avant, donnent décharge au gérant actuel de la société

pour l'exécution de son mandat.

VI.- Que les livres et documents comptables de la société seront conservés pendant cinq ans à L-8041 Strassen, 34,

rue des Romains.

VII.- Qu'il a été donné au porteur de cette expédition tous les pouvoirs pour la publication et l'enregistrement de cet

extrait.

137103

L

U X E M B O U R G

Suite aux résolutions qui précèdent, les associés prénommés comme dit ci-avant, constatent que la société BAR-

THELME S.C.I. a cessé d'exister et qu'elle est dissoute avec effet au 4 octobre 2013.

Strassen, le 4 octobre 2013.

Jean-Pierre Barthelme / Lucienne Barthelme-Flick.

Référence de publication: 2013141795/34.
(130173787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Babillou s. à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Dexiastuff).

Siège social: L-1635 Luxembourg, 37, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 161.359.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013141792/10.
(130173523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Brunelcap S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 172.852.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 9 octobre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013141791/11.
(130173399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Baltis Investment, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: PLN 156.267,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 160.672.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141783/11.
(130173349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

BENESHARE TRANSPORT GROUP (Luxembourg) S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de

Patrimoine Familial.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 61.232.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 Septembre 2013.

Référence de publication: 2013141798/11.
(130173322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Batimmo Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4451 Belvaux, 196, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 176.089.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

137104

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 9 octobre 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013141797/11.
(130173274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

BTMU Unit Management S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 40.510.

In the year two thousand and thirteen,
On the seventeenth day of September,
Before Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "BTMU UNIT Management S.A.", a Luxembourg

société anonyme (hereafter the "Company"), having its registered office in L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon,
incorporated by a deed drawn up by notary Jean-Paul HENCKS, then residing in Luxembourg, dated on 15 June 1992,
published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", under number 305 of 14 July 1992, recorded with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B and number 40,510 (hereafter the "Articles") and whose
Articles have been amended for the last time by a deed drawn up by the said notary HENCKS, on 29 December 2005,
published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", under number 586, dated on 21 March 2006.

The general meeting is called to order at 14.00 by Mr. Tsutomu HATTORI, Deputy Managing Director of Mitsubishi

UFJ Global Custody S.A., residing professionally in L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon, who acts as Chairman
and

who appointed as secretary to the meeting Mr. Hiroaki MATSUYAMA, Senior Vice-president of Mitsubishi UFJ Global

Custody S.A., residing professionally in L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

The meeting elected as scrutineer Mr. Gilles BASTENDORFF, Senior Vice President, residing professionally in L-1150

Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman, acting as proxyholder of the two shareholders

of the company, namely Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. being the holder of nine hundred ninety nine (999)
shares and Mitsubishi UFJ Global Custody S.A. being the holder of one (1) share, declared and requested the notary to
state:

I. That this meeting is passed by the Shareholders acting in their capacity as shareholders in the Company and pursuant

to Article 67-1 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended ("Article 67-1") before
Maître Emile SCHLESSER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Notary").

II. That Article 67-1 provides that resolutions of members of a société anonyme will normally be adopted at general

meetings and in case of liquidation of a company, the resolution should be taken with a majority of votes of two thirds
of the Shareholders.

III. That the Shareholders and the number of shares they hold in the Company are as follows:
a. Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd.: nine hundred ninety nine (999) shares,
b. Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.: one (1) share.
IV. That the Shareholders between them hold all of the issued shares of the Company.
V. That the proxy forms appointing Mr. Tsutomu HATTORI, Deputy Managing Director of Mitsubishi UFJ Global

Custody S.A., residing professionally in Luxembourg, as proxyholder representing the Shareholders, signed "ne varietur"
by the Shareholders represented by proxyholder, shall remain annexed to the present deed and be registered with it.

VI. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the Shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

VII. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

VIII. That the proxyholder, representing the Shareholders of the Company, hereby unanimously pass the following

written resolutions in accordance with Article 67-1:

1. It is resolved to dissolve and to put the Company into liquidation as of the date of the present deed; and
2. It is resolved to appoint Mr. Tsutomu HATTORI, Deputy Managing Director of Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.,

residing professionally in L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon, as liquidator of the Company (the "Liquidator"),
who has accepted his mandate.

The Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the Law without requesting the authorization

of the Shareholders in the cases in which it is requested.

137105

L

U X E M B O U R G

The Liquidator may, under his own responsibility, regarding special or specific operations, delegate such part of his

powers as he may deem fit, to one or several representatives and for the period he will fix.

The Liquidator shall be liable, both to third parties and to the Company, for the execution of the mandate given to

him hereby.

The Liquidator's signature binds validly and without limitation the Company in the process of liquidation.
The Liquidator may distribute the Company's assets to the Shareholders in cash or in kind to its willingness.
The Liquidator shall draft a report on the results of the liquidation and the employment of the corporate assets with

supporting accounts and documents.

The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a

French version, and that at the request of the Shareholders, in case of divergence between the English and the French
texts, the English version will prevail.

This notarial deed was prepared in Luxembourg City, on the day mentioned at the beginning of this document.
This document having been read to the Shareholders proxyholder, who is known to the Notary by his name, first

name, civil status and residence, the Shareholders proxyholder and the Notary have together signed this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize
Le dix-sept septembre,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "BTMU UNIT Management S.A.", une société

anonyme de droit luxembourgeois (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L- 1150 Luxembourg, 287-289, route
d'Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul HENCKS, alors de résidence à Luxembourg, en date du 15
juin 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et associations C, sous le numéro 305 du 14 juillet 1992, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 40.510 (ci-après les «Statuts» )
et dont les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le prédit notaire HENCKS en date du 29
décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et associations C, sous le numéro 586 du 21 mars 2006.

L'assemblée générale est ouverte à 14h00 par Monsieur Tsutomu HATTORI, "Deputy Managing Director" de Mitsu-

bishi UFJ Global Custody S.A., demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon, agissant
comme président et

qui a nommé comme secrétaire à la réunion, Monsieur Hiroaki MATSUYAMA, "Senior Vice-president" de Mitsubishi

UFJ Global Custody S.A., demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 287-289, route d' Arlon.

Le bureau a élu comme scrutateur Monsieur Gilles BASTENDORFF, "Senior Vice Président", demeurant profession-

nellement à L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président, agissant comme fondé de pouvoir des deux actionnaires

de la société, à savoir Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd, titulaire de neuf cent quatre-vingt dix-neuf (999) actions
et Mitsubishi UFJ Global Custody SA, titulaire de une (1) action, expose et prie le notaire d'acter:

I. Que cette réunion est tenue par les Actionnaires agissant en leur qualité d'actionnaires de la Société et conformément

à l'article 67- 1 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 tel que modifié ("Article 67-1"),
pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le «Notaire»).

II. Que l'article 67-1 prévoit que les décisions des membres d'une société anonyme seront normalement prises en

assemblées générales et, en cas de liquidation d'une entreprise, les décisions doivent être prises à la majorité des voix
des deux tiers des actionnaires.

III. Que les Actionnaires et le nombre d'actions qu'ils détiennent dans la Société sont les suivants:
a. Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd.: neuf cent quatre-vingt dix-neuf (999) actions
b. Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.: une (1) action.
IV. Que les Actionnaires détiennent ensemble la totalité des actions émises par la Société.
V. Que les formulaires de procuration nommant Monsieur Tsutomu HATTORI, Directeur général adjoint de Mitsubishi

UFJ Global Custody S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que mandataire représentant les Ac-
tionnaires, signés "ne varietur" par les Actionnaires représentés par le fondé de pouvoir, resteront annexés au présent
acte et seront enregistrés avec lui.

VI. Que la totalité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les Actionnaires présents

ou représentés déclarant qu'ils ont été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant cette réunion,
des convocations ne sont pas nécessaires.

VII. Que la présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

VIII. Que le mandataire, représentant les Actionnaires de la Société, par la présente adopte à l'unanimité les résolutions

suivantes conformément à l'article 67-1:

137106

L

U X E M B O U R G

1. Il est décidé de dissoudre et de mettre la Société en liquidation à la date du présent acte; et
2. Il est résolu de nommer, en tant que liquidateur de la Société Monsieur Tsutomu HATTORI, "Deputy Managing

Director" de Mitsubishi UFJ Global Custody S.A., demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 287-289, route
d'Arlon («le Liquidateur»), qui a accepté son mandat.

Le Liquidateur peut accomplir tous les actes prévus par l'article 145 de la Loi sans demander l'autorisation des Ac-

tionnaires dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer tout ou

partie de ses pouvoirs qu'il jugera opportun, à un ou plusieurs représentants et pour la période qu'il fixera.

Le Liquidateur est responsable, à la fois vis à vis des tiers et vis-à-vis de la Société, pour l'exécution de son mandat.
La signature du Liquidateur pourra engager intégralement la Société dans le processus de liquidation.
Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux Actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté.
Le Liquidateur doit rédiger un rapport sur les résultats de la liquidation et l'emploi des actifs de l'entreprise avec les

comptes et les pièces justificatives.

Le Notaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande des Actionnaires, le présent acte est rédigé en

anglais, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
prévaudra.

Cet acte notarié a été établi à Luxembourg, le jour mentionné en tête du présent acte.
Ce document ayant été lu au représentant des actionnaires, qui est connu du Notaire par nom, prénom, état civil et

résidence, le représentant des Actionnaires et le Notaire, ont ensemble signé le présent acte.

Signé: T. Hattori, H. Matsuyama, G. Bastendorff, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 septembre 2013. Relation: LAC / 2013 / 42614. Reçu douze euros 12,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141814/136.
(130173142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

ACHM Global Hospitality Licensing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 19.375,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 157.487.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 1 

<i>er

<i> Octobre 2013

En date du 1 

er

 Octobre 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Mark Bole, né le 16 Janvier 1959, a Maryland en USA, demeurant profession-

nellement au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant A de la Société
avec effet au 30 Septembre 2013;

- nommer Madame Sandrine BRUZZO, né 7 Septembre 1968 Rochefort-sur-Mer, Charente Maritime, France, avec

adresse professionnelle au 33 rue du Puits Romain, L-8070, Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant
A de la Société avec effet au 1 

er

 octobre 2013;

- Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
Mr. Pieter-Jan van der Meer, Gérant A
Ms. Sandrine Bruzzo, Gérant A
Mr. Philippe van den Avenne, Gérant A
Mr. Reiner Sachau, Gérant B
Mr. Satyajit Anand, Gérant B
Mr. Pankaj Birla, Gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 Octobre 2013.

Marriott ACHM Global Hospitality Licensing S.à r.l.

Référence de publication: 2013141743/26.
(130173876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

137107

L

U X E M B O U R G

Black &amp; Decker International Holdings B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 9.198.620,00.

Siège de direction effectif: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 68.227.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fifth day of September,
before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Black &amp; Decker International Holdings

B.V., a private limited liability company organized and existing under the laws of the Netherlands and Luxembourg, having
its registered office in Amsterdam, the Netherlands and its principal place of business at 40 Avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 9,198,620, registered with the Dutch Trade
Register of the Chamber of Commerce under file number 08055406 and with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 68227 (the Company). The Company has been incorporated on 30 July 1991 pursuant to a
deed of Maître Georgius Gerardus Bernardus Wortelboer, notary residing in the Netherlands. The place of effective
management has been transferred to Luxembourg pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, then
notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N° 259 of 14 April 1999. The articles of association of the Company have been amended several times and
for the last time on 5 September 2012 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2526 of 11 October
2012 (the Articles).

There appeared

the shareholders of the Company (the Shareholders), namely:
(1) Black &amp; Decker International Finance 3 Limited, a Luxembourg and Irish private limited liability company, with its

registered office at Castle River House, 14-15 Parliament Street, Dublin 2, Ireland and its seat of effective management
at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of USD 50,002, re-
gistered at the Companies Registration Office of Ireland under file number 391397 and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B150522, being the holder of all the 50,010 (fifty thousand and ten) class
A shares, all the 49,970 (forty-nine thousand nine hundred and seventy) class B shares and all the 20 (twenty) class E
shares in the Company;

hereby represented by Marine Baillet, lawyer, professionally residing at 33, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

(2) Black &amp; Decker International Finance (UK) Limited, a private limited company existing and organised under the

laws of the United Kingdom, having its registered office at 210, Bath Road, GB-SL1 3YD Slough, Berkshire, United King-
dom, registered with the Companies House under number 07060008, being the holder of all the 49,970 (forty-nine
thousand nine hundred and seventy) class D shares in the Company;

hereby represented by Marine Baillet, lawyer, professionally residing at 33, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

(3) Black &amp; Decker Finance SAS, a French société par actions simplifiée existing and organized under the laws of France,

having its registered office at 34, route Ecully, F-69570 Dardilly, France, registered with the Trade Register of Lyon
(Registre de Commerce de Lyon) under number 382344935, being the holder of all the 50,000 (fifty thousand) class C
shares in the Company;

hereby represented by Marine Baillet, lawyer, professionally residing at 33, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxies, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the Shareholders and by the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. all the 50,010 (fifty thousand and ten) class A shares, all the 49,970 (forty-nine thousand nine hundred and seventy)

class B shares, all the 50,000 (fifty thousand) class C shares, all the 49,970 (forty-nine thousand nine hundred and seventy)
class D shares and all the 20 (twenty) class E shares, having a nominal value of EUR 46 (forty-six) each and representing
the entirety of the share capital of the Company of EUR 9,198,620 (nine million one hundred and ninety-eight thousand
six hundred and twenty Euro) are duly represented at the Meeting, which is consequently regularly constituted and may
deliberate upon the items on the agenda, here below reproduced;

II. that the agenda of the Meeting was the following:
1. waiver of the convening notice;
2. amendment of the dates of the financial year of the Company;
3. amendment of article 19.1. of the Articles in order to reflect the amendment under item 2. above;

137108

L

U X E M B O U R G

4. power and authority given to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp; Overy, société

en commandite simple to see on behalf of the Company to any formalities in connection with items 2. and 3. above
(including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities);
and

5. miscellaneous.
III. After deliberation, the Meeting hereby takes the following resolutions:

<i>First resolution

The  entirety  of  the  share  capital  of  the  Company  being  represented  at  the  Meeting,  the  Shareholders  waive  the

convening notice, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:
(A) the financial year of the Company shall begin on 1 

st

 January rather than 31 December, and

(B) the financial year of the Company shall close on 31 December of each year.
The Shareholders resolve by way of derogation that the financial year of the Company that started on 31 December

2012 shall close on 31 December 2013 rather than on 30 December 2013.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to amend and they hereby amend article 19.1. of the Articles in order to reflect the second

resolution above, so that such article shall henceforth read as follows:

« Art. 19.
1. The financial year of the Company shall run from the first day of January up to and including the thirty-first day of

December of each year."

<i>Fourth resolution

The Shareholders empower and authorize any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp; Overy,

société en commandite simple to see on behalf of the Company to any formalities in connection with the resolutions
above  (including  for  the  avoidance  of  any  doubts  the  filing  and  publication  of  documents  with  relevant  Luxembourg
authorities).

<i>Estimate of Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,000.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Grand Duchy of Luxembourg on the day named at the beginning of

this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-cinquième jour du mois de septembre,
par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Black &amp; Decker International Holdings

B.V., une société à responsabilité limitée existant selon le droit des Pays-Bas et du Grand-Duché du Luxembourg et ayant
son siège social à Amsterdam, Pays-Bas et son siège d'administration centrale au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg, ayant un capital social de 9.198.620 EUR, immatriculée au Registre de Commerce Néerlandais sous le numéro
08055406 et au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.227 (la Société). La Société
a  été  constituée  le  30  juillet  1991  suivant  un  acte  de  Maître  Georgius  Gerardus  Bernardus  Wortelboer,  notaire  de
résidence aux Pays-Bas. Le siège de direction effective de la Société a été transféré au Grand-Duché de Luxembourg le
30 décembre 1998 suivant un acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 259 du 14 avril
1999. Les statuts de la société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 5 septembre 2012 suivant un acte
de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 2526 du 11 octobre 2012.

Ont comparu

137109

L

U X E M B O U R G

les associés de la Société (les Associés), nommément:
(1) Black &amp; Decker International Finance 3 Limited, société à responsabilité limitée (private limited liability company)

de droit irlandais et Luxembourgeois, ayant son siège social à Castle River House, 14-15 Parliament Street, Dublin 2 et
son siège d'administration centrale au 40, rue Monterey, L-2163 Luxembourg, ayant un capital social de 50.002 USD,
immatriculée auprès du Bureau des Sociétés d'Irlande sous le numéro 391397 et auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B150522, détentrice de la totalité des 50.010 (cinquante mille dix) parts
sociales A, 49.970 (quarante-neuf mille neuf cent soixante-dix) parts sociales B et 20 (vingt) parts sociales E de la Société;

ici représentée par Marine Baillet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé.

(2) Black &amp; Decker International Finance (UK) Limited, une société à responsabilité limitée existant selon le droit du

Royaume-Uni, ayant son siège social au 210, Bath Road, GB-SL1 3YD Slough, Berkshire, Royaume-Uni, enregistrée auprès
du Companies House sous le numéro 07060008, détentrice de la totalité des 49.970 (quarante-neuf mille neuf cent
soixante-dix) parts sociales D de la Société;

ici représentée par Marine Baillet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé; et

(3) Black &amp; Decker Finance SAS, une société par actions simplifiée existant et organisée selon le droit français, ayant

son siège social au 34, route Ecully, F-69570 Dardilly, France, enregistrée auprès du Registre de Commerce de Lyon sous
le numéro 382344935, détentrice de la totalité des 50.000 (cinquante mille) parts sociales C de la Société (collectivement
les Associés)

ici représentée par Marine Baillet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé.

Lesdites procurations des Associés, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des Associés et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés, tels que représentés ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que la totalité des 50.010 (cinquante mille dix) parts sociales A, des 49.970 (quarante-neuf mille neuf cent soixante-

dix) parts sociales B, des 50.000 (cinquante mille) parts sociales C, des 49.970 (quarante-neuf mille neuf cent soixante-
dix) parts sociales D et des 20 (vingt) parts sociales E, ayant une valeur nominale de 46 EUR (quarante-six euros) chacune
et représentant la totalité du capital social de la société d'un montant de 9.198.620 EUR (neuf millions cent quatre-vingt
dix-huit mille six cent vingt euros) sont dûment représentées à l'Assemblée qui est, par conséquent dûment constituée
et peut délibérer sur les point de l'ordre du jour reproduit ci-dessous:

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. modification des dates de l'année sociale de la Société;
3. modification de l'article 19.1 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus;
4. pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy, société en

commandite simple d'accomplir pour le compte de la Société toute formalité relative aux points 2. et 3. ci-dessous (en
ce compris, afin d'éviter tout doute, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises
compétentes); et

5. divers.
III. que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-

malités de convocation, les Associés représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui a été rendu accessible avant l'Assemblée.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
(A) l'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier, au lieu du 31 décembre, et

(B) l'année sociale de la Société se termine le 31 décembre de chaque année.
Les Associés décident que, par dérogation, l'année sociale de la Société, qui a commencé le 31 décembre 2012, se

terminera le 31 décembre 2013 au lieu du 30 décembre 2013.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 19.1. des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessus, de sorte

qu'il aura la teneur suivante:

« Art. 19.
1. L'année sociale de la Société commence le 1 janvier et expire le 31 décembre inclus de chaque année.»

137110

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

Les Associés donnent pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy,

société en commandite simple d'accomplir pour le compte de la Société toute formalité relative aux résolutions ci-dessus
(en ce compris, afin d'éviter tout doute, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises
compétentes).

<i>Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou

pour lesquels elle est responsable, en conséquence de la présente augmentation de capital, sont estimés approximative-
ment à EUR 1.000.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en date des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: M. BAILLET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 octobre 2013. Relation: LAC/2013/44633. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141801/187.
(130173900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

BISSELL International Finance Company, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 164.147.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141800/10.
(130173498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Blue Planet Group, Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 165.526.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par l'Assemblée Général Extraordinaire de l'Actionnaire unique de la société en date

<i>du 02 octobre 2013:

1) L'Assemblée décide d'accepter la démission de son poste d'administrateur de la société K-ey Dynamics GVC, avec

effet immédiat.

2) L'Assemblée décide de nommer, au poste d'administrateur de la société:
- La société YAKO, ayant son siège social à Jan De Trochstraat, 61, B-1703 Dilbeek-Schepdaal (Belgique), avec Monsieur

Wim HEYVAERT, né le 16 juin 1966, à Vilvoorde (Belgique) et demeurant à Jan De Trochstraat, 61, B-1703 Dilbeek-
Schepdaal (Belgique) agissant en qualité de représentant permanent.

avec effet immédiat et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l'Actionnaire unique

de la Société, devant se tenir en 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Blue Planet Group

Référence de publication: 2013141787/19.
(130173484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

137111

L

U X E M B O U R G

Atrilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 107.397.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 2 mai 2013

L'Assemblée Générale entérine la décision du Conseil d'Administration du 4 mars 2013 de nommer comme nouvel

administrateur suite au décès de Monsieur Patrick ROCHAS, Monsieur Eddy WIRTZ, employé privé, demeurant pro-
fessionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L - 2530 Luxembourg.

L'assemblée décide que le mandat de l'administrateur ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale

à tenir en 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2013141773/15.
(130173538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Arina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 74.710.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de Arina S.A. tenue au siège social le 13 août 2013 à 11 heures

L'Assemblée accepte les démissions de Madame Solange Leurquin, de Madame Peggy Krauss et de Monsieur Vincent

Demeuse de leur poste d'administrateurs de la société avec effet immédiat et nomme en remplacement des administra-
teurs démissionnaires Monsieur Jean-Claude Jolis, demeurant au 54, rue Schetzel, L-2518 Luxembourg, la société VP
Consult Sàrl, avec siège social au 63 Grand-Rue, L-8510 Redange/Attert représentée par Madame Véronique Pirotte, avec
adresse professionnelle au 63 Grand-Rue, L-8510 Redange/Attert et la société Mylène Products Sàrl, avec siège social au
5, rue Prince Jean, L4740 Pétange, représentée par Madame Martine Seutin, avec adresse professionnelle au 5, rue Prince
Jean, L-4740 Pétange.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 heures après signature du présent procès-

verbal par les membres du bureau.

Vincent Demeuse / Léon SEUTIN / Martine Seutin
<i>Secrétaire / Scrutateur / Présidente

Référence de publication: 2013141764/19.
(130173872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Bureau Immobilier Lea Kappweiler S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1363 Howald, 3B, rue du Couvent.

R.C.S. Luxembourg B 26.419.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013141815/10.
(130173366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Butzestuff, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 37, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 35.877.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013141816/10.
(130173525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

137112

L

U X E M B O U R G

Brading Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 138.292.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 Septembre 2013.

Brading Holding S.à r.l.
M.P. Galliver
<i>Manager

Référence de publication: 2013141808/14.
(130173627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Brading Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 138.292.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 Octobre 2013.

Brading Holding S.à r.l.
M.P. Galliver
<i>Manager

Référence de publication: 2013141807/14.
(130172992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

BTG Pactual Oil&amp;Gas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 178.407.

In the year two thousand and thirteen, on the seventeenth day of September.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of BTG Pactual Oil&amp;Gas S.à r.l., a Lu-

xembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 13-15, avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Com-
panies of Luxembourg under number B 178407, incorporated on June 13, 2013, pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2022, page 97040 of August 21, 2013 (the Company). The articles of association of the Company
(the Articles) have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary, on August 13, 2013, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

THERE APPEARED:

BTG Pactual E&amp;P S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its

registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with
the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B178405 (E&amp;P);

here represented by Mr. Henri DA CRUZ, private employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, route de

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

BTG Clients O&amp;G S.à r.l. a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its

registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 179828 (O&amp;G, and together with E&amp;P, the
Shareholders);

here represented by Mr. Henri DA CRUZ, private employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, route de

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

137113

L

U X E M B O U R G

The Shareholders, pre-named and represented as stated above, representing the entire share capital of the Company,

have requested the undersigned notary to record that:

I. The Company's share capital is presently set at one billion thirty-three million four hundred and four thousand eight

hundred and sixty-seven United States Dollars and seventy-three cents (USD 1,033,404,867.73) represented by one
hundred and three billion three hundred and forty million four hundred and eighty-six thousand seven hundred and
seventy-two (103,340,486,772) class A shares in registered form, having a par value of one cent of a United States Dollar
(USD 0.01) each, and one (1) Class B Premium share in registered form, having a par value of one cent of a United States
Dollar (USD 0.01) each, with a share premium attached of an amount of nine million nine hundred and ninety-nine
thousand nine hundred and ninety-nine United States Dollars and ninety-nine cents (USD 9,999,999.99), all subscribed
and fully paid-up.

II. The agenda of the meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2.  Conversion  of  two  billion  nine  hundred  and  twenty-three  million  four  hundred  and  seventy-four  thousand  six

hundred and four (2,923,474,604) Class A shares in registered form, having a par value of one cent of a United States
Dollar (USD 0.01) each, into two billion nine hundred and twenty-three million four hundred and seventy-four thousand
six hundred and four (2,923,474,604) Class B shares in registered form, having a par value of one cent of a United States
Dollar (USD 0.01) each, without allocation to the share premium account attached to the Class B shares;

3. Subsequent amendment of Article 5.1. of the Articles; and
4. Miscellaneous.
III. The Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the

Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has
been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to convert two billion nine hundred and twenty-three million four hundred and seventy-four

thousand six hundred and four (2,923,474,604) Class A shares in registered form, having a par value of one cent of a
United States Dollar (USD 0.01) each, into two billion nine hundred and twenty-three million four hundred and seventy-
four thousand six hundred and four (2,923,474,604) Class B shares in registered form, having a par value of one cent of
a United States Dollar (USD 0.01) each, without allocation to the share premium account attached to the Class B shares.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend Article 5.1. of the Articles, which shall henceforth read as follows:

5.1. The share capital is set at one billion and thirty-three million four hundred and four thousand eight hundred and

sixty-seven United States Dollars and seventy-three cents (USD 1,033,404,867.73) represented by (i) one hundred billion
four hundred and seventeen million and twelve thousand one hundred and sixty-eight (100,417,012,168) class A shares
in registered form, having a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each, (ii) two billion nine hundred
and twenty-three million four hundred and seventy-four thousand six hundred and four (2,923,474,604) Class B shares
in registered form, having a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each and (iii) one (1) Class B
Premium share in registered form, having a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01)each, all subscribed
and fully paid-up."

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 950.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, such proxyholder signed together with

the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-septième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

137114

L

U X E M B O U R G

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés BTG Pactual Oil&amp;Gas S.à r.l., une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg. immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 178407, constituée le 13 juin 2013 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2022, page
97040 du 21 août 2013 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 13 août
2013, suivant un acte du notaire instrumentant, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

ONT COMPARU:

BTG Pactual E&amp;P S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178405 (E&amp;P);

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, résidant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route

de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

BTG Clients O&amp;G S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179828 (O&amp;G, et avec E&amp;P, les Associés);

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, résidant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route

de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

Ladites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les Associés, précités et représentés comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social de la Société,

ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Le capital social de la société est actuellement fixé à un milliard trente-trois million quatre cent quatre mille huit cent

soixante-sept dollars américains et soixante-dix-treize centimes (USD 1.033.404.867,73) représenté par cent trois milliard
trois cent quarante million quatre cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-douze (103.340.486.772) parts sociales
de classe A sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune, et
une (1) part sociale Premium de classe B sous la forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime de Dollar
américain (USD 0,01), avec une prime d'émission y attachée d'un montant de neuf million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains et quatre-vingt-dix-neuf centimes (USD 9.999.999,99), toutes
souscrites et entièrement libérées;

II. L'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2.  Conversion  de  deux  milliard  neuf  cent  vingt-trois  million  quatre  cent  soixante-quatorze  mille  six  cent  quatre

(2.923.474.604)  parts  sociales  de  classe  A  sous  forme  nominative  ayant  une  valeur  nominale  d'un  centime  de  dollar
américain (USD 0,01) chacune, en deux milliard neuf cent vingt-trois million quatre cent soixante-quatorze mille six cent
quatre (2.923.474.604) parts sociales de classe B sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime de dollar
américain (USD 0,01) chacune, sans allocation au compte de prime d'émission connecté parts sociales de classe B;

3. Modification subséquente de l'article 5.1. des Statuts; and
4. Divers.
III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les

Associés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de convertir deux milliard neuf cent vingt-trois million quatre cent soixante-quatorze mille six

cent quatre (2.923.474.604) parts sociales de classe A sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime de
dollar américain (USD 0,01) chacune, en deux milliard neuf cent vingt-trois million quatre cent soixante-quatorze mille
six cent quatre (2.923.474.604) parts sociales de classe B sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime
de dollar américain (USD 0,01) chacune, sans allocation au compte de prime d'émission connecté parts sociales de classe
B.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social est fixé à un milliard trente-trois millions quatre cent quatre mille huit cent soixante-sept Dollars

des Etats-Unis et soixante-treize centimes (USD 1.033.404.867,73) représenté par (i) cent milliard quatre cent dix-sept
million douze mille cent soixante-huit (100.417.012.168) parts sociales de classe A nominatives ayant une valeur nomi-

137115

L

U X E M B O U R G

native d'un centime de Dollars des Etats-Unis (USD 0,01) chacune, (ii) deux milliard neuf cent vingt-trois million quatre
cent soixante-quatorze mille six cent quatre (2.923.474.604) parts sociales de classe B sous forme nominative ayant une
valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune et (iii) une (1) part sociale Premium de classe B
sous la forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime de Dollars des Etats-Unis (USD 0,01), toutes souscrites
et entièrement payées.»

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est estimé à environ EUR 950,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et
française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le

présent acte original.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 septembre 2013. Relation GRE/2013/3813. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013141811/158.
(130172911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Bonnefoit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 171.956.

Les comptes annuels au 15 octobre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013141804/10.
(130173358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Leggett &amp; Platt Luxembourg Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.173.

Par résolutions signés en date du 13 septembre 2013, il résulte que l'associé unique de la Société a pris les décisions

suivantes:

1) Démission du Gérant de catégorie B suivant à partir du 1 

er

 octobre 2013: Ms Shonna Koch

2) Nomination du nouveau gérant de catégorie B à partir du 1 

er

 octobre 2013 pour une durée indéterminée:

Mr Travis James Almandinger, né le 21 septembre 1972 à Iowa, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse privée à

1220 S Main ST 64836-2712 Carthage MO, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2013.

<i>Pour la société
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2013142190/20.
(130173085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

137116

L

U X E M B O U R G

Kawa Solar Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 180.695.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen,
on the twenty-seventh day of September.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

the appeared:

“Kawa Solar Holdings Limited”, a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its

registered office at c/o Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand
Cayman, KY1-1111, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under registration
number 280366,

duly represented by Mr Brian GILLOT, lawyer, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg,

by virtue of a proxy given on 26 September 2013 in Miami (USA).
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing parties have requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité

limitée, which they wish to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “Kawa Solar Europe S.à
r.l.” (the “Company”).

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose.
3.1. The Company’s purpose is the creation, holding, restructuring, development and realisation of a portfolio, con-

sisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg
and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by
purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments,
patents and licenses, as well as the administration, management and control of such portfolio.

3.2. The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds

a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which

the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

- participate in the incorporation, restructuring, development, management and/or control of any entity in the Grand

Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.

Art. 4. Registered office.
4.1. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2. Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

managers.

137117

L

U X E M B O U R G

4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

B. Share capital - Shares - Register of Shareholders - Ownership and Transfer of Shares

Art. 5. Share capital.
5.1. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), consisting of twelve

thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

5.2. Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

Art. 6. Shares.
6.1. The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2. The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise

provided by law.

6.3. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by

him/her/it in the Company's share capital.

6.4. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as

the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed

shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6. The Company's shares are in registered form.

Art. 7. Register of shareholders.
7.1. A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection

by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.

7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and Transfer of shares.
8.1. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-

holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.

8.2. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled  to  suspend  the  exercise  of  all  rights  attached  to  a  share  held  by  several  owners  until  one  owner  has  been
designated.

8.3. The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. ínter vivos, they may only be trans-

ferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor,
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law,
the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4. Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or

in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5. The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.

C. General meeting of Shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company's corporate bodies.

137118

L

U X E M B O U R G

9.2. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

9.3. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead

of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,

by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.

10.2. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in

the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice
of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.

10.3. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

10.4. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.
11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3. Quorum and vote
11.3.1. Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2. Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly

passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.

11.4. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.5. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

11.6. Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,

facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.7. The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them

to take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

137119

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In

case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board
of managers" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole manager".

14.2. The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the

corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).

14.3. The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management

may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting

alone or jointly as agents of the Company.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a

chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.

Art. 16. Election and Removal of managers and Term of the office.
16.1. Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of the office.

16.2. Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.

16.3. Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for

successive terms.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1. The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1. The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,

the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2. Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at

a meeting of the board of managers.

18.3. Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting

of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

137120

L

U X E M B O U R G

18.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5. Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6. The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1. The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the

board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2. The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3. Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.

Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any

two managers or by the signature of the sole manager or by the joint signatures or by the sole signature of any person
(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or by the sole manager. However if
different classes of managers have been appointed the company will only be bound by the joint signature of one Class A
manager and one Class B manger or by the signature of a person delegated by them. The Company will be bound towards
third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has
been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

E. Supervision

Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
21.1. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or

several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.

21.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

21.4. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

21.5. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

21.6. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7. If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the

law  of  19  December  2002  regarding  the  Trade  and  Companies  Register  and  the  accounting  and  annual  accounts  of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the ínstitut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on

thirty-first December of the same year.

137121

L

U X E M B O U R G

Art. 23. Profits.
23.1. From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal

reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve
amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

23.3. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4. Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders will determine how the

remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

Art. 24. Interim dividends Share premium.
24.1. The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends,

under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the
amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these
articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that
the first two conditions have been satisfied.

24.2. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)

or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31

December 2014.

2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

<i>Subscription and Payment

The subscriber has subscribed the shares to be issued as follows:
"Kawa Solar Holdings Limited", aforementioned,
paid twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) in subscription for thousand five hundred (12,500) shares.
Total: twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) paid for thousand five hundred (12,500) shares.
All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)

is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be thousand euro).

<i>Resolution of the sole Shareholder

The incorporating shareholder, representing the Company's entire share capital and considering itself as duly convened,

passed the following resolutions:

1. The number of members of the board of managers is fixed at two (2).
2. The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company:
a) Daniel Ades, born on 11 February 1980 in Sao Paulo (Brazil), having his professional address at 800 S Pointe Dr,

Apt 701, Miami, FL 33139, United States of America, as class A manager; and

b) Anne Catherine Grave, born on 23 July 1974 in Comines (France), having her professional address at 19, rue de

Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager.

137122

L

U X E M B O U R G

3. The term of the office of the members of the board of managers shall end on the date when the general meeting of

shareholders/sole shareholder shall resolve upon the approval of the Company's accounts of the financial year 2014 or
at any time prior to such date as the general meeting of shareholders/sole shareholder may determine.

4. The address of the Company's registered office is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing persons,

this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with

the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes

Im Jahre zweitausenddreizehn,
den siebenundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, GroBherzogtum Luxem-

burg,

ist erschienen:

„Kawa Solar Holdings Limited", eine gemäß dem Recht der Cayman Islands gegründete und existente Gesellschaft mit

eingetragenem Sitz in c/o Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand
Cayman, KY1-1111, Cayman Islands, eingetragen im Registrar of Companies of the Cayman Islands unter Registernummer
280366,

ordnungsgemäB vertreten durch Herrn Brian GILLOT, Jurist, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, GroBherzogtum

Luxemburg,

kraft einer am 26. September 2013 in Miami (USA) erteilten Vollmacht.
Nachdem  die  Vollmachten  durch  die  Bevollmächtigten  und  den  unterzeichneten  Notar  ne  varietur  unterzeichnet

worden sind, sollen diese dieser Urkunde angehängt bleiben, um mit derselben eingetragen zu werden.

Solch erschienene Parteien haben den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer société ä responsabilité limitée

aufzunehmen, welche sie gründen möchten und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten soll:

A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die

künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société ä responsabilité limitée unter der Firma "Kawa
Solar Europe S.à r.l. " (die "Gesellschaft").

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen

Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 3. Zweck.
3.1. Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Restrukturierung, die Entwicklung und Realisation eines

Portfolios bestehend aus Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden
oder zu gründenden Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen
Erwerb, Verkauf oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen
Instrumenten, Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung, das Management und die Kontrolle eines
solchen Portfolios.

3.2. Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-

gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
bindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines
Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie
auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren;
und

- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in

welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.

137123

L

U X E M B O U R G

3.3.  Die  Gesellschaft  kann  jedwede  Transaktionen  vornehmen,  welche  direkt  oder  indirekt  ihrem  Zweck  dienen.

Innerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:

- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-

papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;

-  sich  an  der  Gründung,  Restrukturierung,  Entwicklung,  Management  und/oder  Kontrolle  jedes  Rechtsgebildes  im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen; und

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes

beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.

Art. 4. Sitz.
4.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2. Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-

rerrats verlegt werden.

4.3. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxem-

burg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich
ist.

4.4.  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  im  Großherzogtum  Luxemburg  oder  im  Ausland

durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.

B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Ge-

schäftsanteilen

Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500) bestehend aus zwölftau-

send fünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil.

5.2. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Gesell-

schafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erfor-
derlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig

(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.

6.3. Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl

der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.

6.4. Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betref-

fend den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.

6.5. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurück-

gekauften  oder  zurückgenommenen  Geschäftsanteile  werden  sofort  gelöscht  und  das  Stammkapital  entsprechend
herabgesetzt.

6.6. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.

Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.
7.1. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-

schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem
Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.

7.2. Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung

mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.

Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.
8.1. Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-

schafterverzeichnis  erbracht  werden.  Auf  Ersuchen  und  auf  Kosten  eines  Gesellschafters  werden  Zertifikate  dieser
Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

8.2. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-

sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum

137124

L

U X E M B O U R G

mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.

8.3. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter

Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden
Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit
gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Ein-
willigung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte
der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4. Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des

Falles in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber
der Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Ge-
sellschaft zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das
Gesellschafterverzeichnis eintragen kann.

8.5. Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen

und diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen
Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Gesellschafterversammlung

Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1. Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe

der Gesellschaft bildet.

9.2. Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-

terversammlung  aus.  In  einem  solchen  Fall,  soweit  anwendbar  und  wo  der  Begriff  "alleiniger  Gesellschafter"  nicht
ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
"Gesellschafterversammlung" als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter" gelesen werden.

9.3. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich

verliehenen Befugnisse.

9.4. Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,

statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.

Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
10.1. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die

satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

10.2. Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-

sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeit-
raums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.

10.3. Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit

der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.

10.4. Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass

sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1. In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-

denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.

11.2. In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3. Quorum und Stimmabgabe
11.3.1. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.3.2. Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-

schafterbeschlüsse  bei der ersten  Abstimmung  wirksam  gefasst,  wenn sie  von  Gesellschaftern angenommen  werden,

137125

L

U X E M B O U R G

welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.

11.4. Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,

Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

11.5. Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz,

Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesell-
schafter identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durch-
gehend hören und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und
Mehrheit anwesend ist.

11.6. Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein unterzeichnetes Stimm-

formular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den eingetragenen
Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur
solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das
Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden
Vorschlag  drei  Kästchen  enthalten,  die  es  dem  Gesellschafter  ermóglichen,  seine  Stimme  zugunsten  oder  gegen  den
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Ge-
sellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie sich
beziehen, erhalten hat.

11.7. Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden

müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.

Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag

durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.

Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
13.1. Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern

sowie von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.

13.2. Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Be-

schlüsse aufnehmen und unterzeichnen.

13.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen

oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
14.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein

müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Ge-
schäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in diesem
Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den "Geschäftsführerrat"
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer" gelesen werden.

14.2. Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.

14.3. Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts

können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Ge-
schäftsführerrats festgesetzt.

14.4. Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede

Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.

Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten

des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des
Geschäftsführerrats sein muss.

137126

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
16.1. Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit

festlegt.

16.2. Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen

werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.

16.3. Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer

kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
17.1. Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner

Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

17.2. Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung

anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einver-
ständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist.
Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort
stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann
nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von
schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.

Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1. Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner

Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen

18.2. Quorum
Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder

an der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

18.3. Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder

vertretenen Mitglieder gefasst. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.

18.4. Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein

anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

18.5. Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Vide-

okonferenz  oder  durch  ein  anderes  Kommunikationsmittel  teilnimmt,  welches  es  ermöglicht,  dass  dieses  Mitglied
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und
effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird
vermutet,  dass  eine  durch  solche  Kommunikationsmittel  abgehaltene  Sitzung  am  eingetragenen  Sitz  der  Gesellschaft
abgehalten wurde.

18.6. Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in

einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
19.1. Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung

des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

19.2. Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
19.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden

sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei

Geschäftsführern oder durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift
oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den

137127

L

U X E M B O U R G

Geschäftsführerrat  oder  den  alleinigen  Geschäftsführer  übertragen  worden  ist.  Sind  jedoch  verschieden  Klassen  von
Geschäftsführern eingeführt, so wird die Gesellschaft nur durch die gemeinschaftliche Unterschrift eines Geschäftsführers
der Klasse A und eines Geschäftsführers der Klasse B oder die Unterschrift einer durch sie befugten Person gebunden.
Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen einer Übertragung der Führung des Tagesgeschäfts gegenüber
Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis in Verbindung mit der Führung
des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde.

E. Aufsicht

Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.
21.1. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder

mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.

21.2. Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und

ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.

21.3. Jeder satzungsmälige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung

abberufen werden.

21.4. Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Ge-

schäfte der Gesellschaft.

21.5. Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten

der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

21.6. Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher

aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von
Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.

21.7. Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/
werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am ein-

unddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Gewinne.
23.1. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamt-
summe der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.

23.2. Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage

zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.

23.3. Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt

werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.

23.4. Unter den gesetzlichen Bedingungen wird die Gesellschafterversammlung beschließen, wie der verbleibende Rest

des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden
soll.

Art. 24. Zwischendividenden – Emissionsagio.
24.1. Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden zahlen unter der Vo-

raussetzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende
Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der
Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu
diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die
gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesell-
schaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen
erfüllt sind.

24.2. Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Gesellschafterbeschluss oder Beschluss der Geschäftsführer unter

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche Rücklage frei
an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

137128

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-

toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.

H. Anwendbares recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-

burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäl dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2014.

2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zeichnende Gesellschafter hat die auszugebenden Geschäftsanteile wie folgt gezeichnet:
„Kawa Solar Holdings Limited", vorbenannt,
zahlte  zwölftausend  fünfhundert  Euro  (EUR  12.500)  gegen  Zeichnung  von  zwölftausend  fünfhundert  (12.500)  Ge-

schäftsanteilen.

Alle Geschäftsanteile sind voll in bar eingezahlt worden, so dass die Summe von zwölftausend ünfhundert Euro (EUR

12.500) von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Auslagen

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang

mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden
sollen, werden auf tausend Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Kapital der Gesellschaft vertritt und der sich selbst als ordnungs-

gemäß geladen erachtet, hat folgende Beschlüsse gefasst.

1) Die Zahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats wird auf zwei (2) festgesetzt.
2) Die folgenden Personen werden als Mitglieder des Geschäftsführerrats der Gesellschaft ernannt:
a) Herr Daniel Ades, geboren am 11 Februar 1980 in Sao Paulo, Brasilien, mit beruflicher Adresse in 800 S Pointe Dr,

Apt 701, Miami, FL 33139, Vereinigte Staaten von Amerika; Klasse A Geschäftsführer;

b) Frau Anne Catherine Grave, geboren am 26 Juli 1974 in Comines, Frankreich, mit beruflicher Adresse in 19, rue de

Bitbourg, L-1273 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, Klasse B Geschäftsführer.

3) Die Amtszeit der Mitglieder des Geschäftsführerrats soll zu dem Zeitpunkt enden, an dem die Gesellschafterver-

sammlung/der alleinige Gesellschafter, je nach Lage des Falles, über die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesell-
schaft für das Geschäftsjahr 2014 bestimmt, oder an jedem anderen, von der Gesellschafterversammlung/vom alleinigen
Gesellschafter, je nach Lage des Falles, festgesetzten Zeitpunkt vor diesem Datum.

4) Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der er-

schienenen  Parteien  auf  Englisch  geschrieben  ist,  gefolgt  von  einer  deutschen  Übersetzung.  Auf  Anfrage  derselben
erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische
Fassung vorrangig sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments

genannten Tag.

Nachdem das Dokument dem/den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, hat/haben der

Bevollmächtigte/die Bevollmächtigten diese originale Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: B. GILLOT, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 1. Oktober 2013. Relation: EAC/2013/12646. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-

EUR).

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2013142171/716.
(130173415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

137129

L

U X E M B O U R G

JM Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 10, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 142.429.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013142167/9.
(130173747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Jonas Architectes Associés S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 57, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 97.392.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013142168/10.
(130173827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Konstrulux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8280 Kehlen, 1, Op der Dresch.

R.C.S. Luxembourg B 57.924.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Kehlen au siège social, le 8 octobre

2013 que la résolution suivante a été adoptée par l'associé unique représentant l'intégralité du capital social:

<i>Résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de
L-8284 Kehlen 23, rue de Kopstal
à L-8280 Kehlen - 1, Op der Dresch
à compter de ce jour
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Kehlen, le 8 octobre 2013.

<i>Pour la société
Monsieur Kieffer Jean-Paul
<i>L'associé unique

Référence de publication: 2013142181/21.
(130173543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

JFA &amp; Interfaces Est., Société à responsabilité limitée,

(anc. PE développement Sàrl).

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 144.285.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 10 octobre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013142166/12.
(130173348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

137130

L

U X E M B O U R G

International Mode Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 53.129.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
INTERNATIONAL MODE INVESTMENT S.A.

Référence de publication: 2013142138/11.
(130173421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

International Soccer Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1138 Luxembourg, 5, rue des Arquebusiers.

R.C.S. Luxembourg B 136.443.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013142139/10.
(130173150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Lagoon Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 160.484.

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 7 octobre 2013 que les gérants, Randall Rothschild,

Dennis J. McDonagh, Robert W. Simon et Jean-François Bossy ont démissionné en tant que gérants de la Société avec
effet au 7 octobre 2013.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer la société BREDS Management S.A., société anonyme de droit

Luxembourgeois, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B180.408, en tant que gérant unique de la Société, avec effet au
7 octobre 2013 pour une durée indéterminée.

La Société est désormais gérée par la société BREDS Management S.A. en qualité de gérant unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2013.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2013142186/21.
(130173560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

KUHN Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 148, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 98.278.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10/10/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2013142183/12.
(130173474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

137131

L

U X E M B O U R G

Köpco Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5533 Remich, 15, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 89.091.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'Associé unique en date du 10 octobre 2013 que:
- La démission de Monsieur Theodorus KÖPPEN de son poste de Gérant de la Société est acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Eric WYNS, demeurant au 31, Driekastanjelaarsstraat, B-1850 Grimbergen, est nommé au poste de Gérant

unique de la Société pour une durée indéterminée.

La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du Gérant unique.
Suite à une convention de cession de parts sociales conclue sous-seing privé en date du 10 octobre 2013 et acceptée

par le Gérant au nom de la Société, il résulte que le capital social de la société KÖPCO S.à r.l., représenté par 100 parts
sociales d'une valeur nominale de 125 EUR chacune est désormais intégralement détenu par Monsieur Eric WYNS prén-
ommé.

Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Pour extrait conforme
Eric WYNS
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2013142184/21.
(130173886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Lagoon Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 160.416.

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 7 octobre 2013 que les gérants, Randall Rothschild,

Dennis J. McDonagh, Robert W. Simon et Jean-François Bossy ont démissionné en tant que gérants de la Société avec
effet au 7 octobre 2013.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer la société BREDS Management S.A., société anonyme de droit

Luxembourgeois, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 180.408, en tant que gérant unique de la Société, avec effet au
7 octobre 2013 pour une durée indéterminée.

La Société est désormais gérée par la société BREDS Management S.A. en qualité de gérant unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2013.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2013142187/21.
(130172979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Lafayette 23 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 152.776.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

137132

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Lafayette 23 S.à r.l.
Mr. Mark Doherty / Mr Jean-Christophe Ehlinger
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2013142185/13.
(130173494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Landgame S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.260.

Par résolutions signées en date du 18 juillet 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Fanny Him, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg, de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat.

2. Nomination de Gaël Sausy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013142188/15.
(130173743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Luxury Holding of Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 156.650.

<i>Extrait des résolutions de l’actionnaire unique de la Société prises en date du 1 

<i>er

<i> Octobre 2013

En date du 1 

er

 Octobre 2013, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d’accepter la démission de Monsieur Mark Bole, né le 16 Janvier 1959, a Maryland en USA, demeurant profession-

nellement au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant A de la Société
avec effet au 30 Septembre 2013;

- nommer Madame Sandrine BRUZZO, né 7 Septembre 1968 Rochefort-sur-Mer, Charente Maritime, France, avec

adresse professionnelle au 33 rue du Puits Romain, L-8070, Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant
A de la Société avec effet au 1 

er

 octobre 2013;

- Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
Mr. Pieter-Jan van der Meer, Gérant A
Ms. Sandrine Bruzzo, Gérant A
Mr. Philippe van den Avenne, Gérant A
Mr. Reiner Sachau, Gérant B
Mr. Satyajit Anand, Gérant B
Mr. Pankaj Birla, Gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 Octobre 2013.

Luxury Holding of Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2013142207/26.
(130173669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Leggett &amp; Platt Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 90.012.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.175.

Par résolutions signés en date du 17 septembre 2013, il résulte que l'associé unique de la Société a pris les décisions

suivantes:

137133

L

U X E M B O U R G

1) Démission du Gérant de catégorie B suivant à partir du 1 

er

 octobre 2013: Ms Shonna Koch

2) Nomination du nouveau gérant de catégorie B à partir du 1 

er

 octobre 2013 pour une durée indéterminée:

Mr Travis James Almandinger, né le 21 septembre 1972 à Iowa, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse privée à

1220 S Main ST 64836-2712 Carthage MO, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2013.

<i>Pour la Société
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2013142192/20.
(130173087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

SW III Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 121.718.

Suite au contrat de transfert de parts sociales daté du 8 octobre 2013, les parts sociales de la Société sont désormais

réparties comme suit:

Associés

Nombre de parts

Nadine Stichting
Schiphol Boulevard 231
1118 BH Schiphol
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Virbius Limited
18 Avenue Spyrou Kyprianou

ème

 /3 

ème

 étage

1075 Nicosie, Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 parts sociales
Pacento Limited
18 Avenue Spyrou Kyprianou

ème

 /3 

ème

 étage

1075 Nicosie, Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Référence de publication: 2013142482/25.
(130173839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Guineu Immobles Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 49.218.

L'an deux mille treize, le vingt-cinq septembre.
Par-devant, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Madame Sandra PASTI, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg, 40, rue du Curé,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d'administration de la société «GUINEU IMMOBLES LUXEM-

BOURG S.A.», (ci-après la "Société"), société anonyme existant et gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social à L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 49.218,

en vertu d'un pouvoir qui lui a été conférée par la résolution circulaire adoptée par le Conseil d'administration de la

Société en date du 25 septembre 2013, laquelle résolution signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte.

Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant, de documenter les déclarations et

constatations suivantes:

137134

L

U X E M B O U R G

1. La Société a été constituée suivant acte notarié en date du 20 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 60 du 7 février 1995, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieux suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2205 du 10 septembre 2013.

2. Le capital social souscrit est fixé à trente millions trente-six mille neuf cents euros (30.036.900,- EUR), représenté

par un million deux cent un mille quatre cent soixante-seize (1.201.476) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros
(25,-EUR) chacune.

3. Le cinquième, le sixième, le septième et le huitième alinéa de l'article 3 des statuts de la Société, sont libellés comme

suit:

«Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à 100.000.000,- EUR (cent millions d'euros),

le cas échéant par la création et l'émission d'actions nouvelles de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois par tranches successives par émission d'actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée

d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de 5 ans à partir de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et  Associations,  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  du  26  juin  2013  et  peut  être  renouvelée  par  une  assemblée
générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici-là n'auront pas été émises par le conseil d'admi-
nistration.

A la suite de chaque augmentation du capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.».

4. Le Conseil d'administration de la Société, en conformité avec les pouvoirs lui conférés en vertu de l'article 3 des

statuts de la Société, par résolution circulaire du 25 septembre 2013, a décidé la création et l'émission de cent quarante-
deux mille cinq cent vingt-quatre (142.524) actions nouvelles de valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune,
émises au prix de trente-cinq euros et douze cents (35,12- EUR) chacune, ensemble avec une prime d'émission par action
de dix euros et douze cents (10,12- EUR), jouissant des mêmes droits et avantages que les actions déjà émises, à souscrire
en totalité et à libérer intégralement par un apport en numéraire.

5. En conséquence de ce qui précède, le capital social a été augmenté à concurrence d'un montant de trois millions

cinq cent soixante-trois mille cents euros (3.563.100,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente millions
trente-six  mille  neuf  cent  euros  (30.036.900,-  EUR)  à  un  montant  de  trente-trois  millions  six  cents  mille  euros
(33.600.000,- EUR) par l'émission de cent quarante-deux mille cinq cent vingt-quatre (142.524) actions nouvelles de valeur
nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, émises au prix de trente-cinq euros et douze cents (35,12- EUR)
chacune, incluant une prime d'émission par action de dix euros douze cents (10,12- EUR), souscrites tel que détaillé dans
le procès-verbal du conseil d'administration du 25 septembre 2013, c'est-à-dire par son actionnaire unique Ventos S.A.,
ayant son siège social à L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé, et libérées intégralement en espèces pour un montant total
de cinq millions cinq mille quatre cent quarante-deux euros et quatre-vingt-huit cents (5.005.442,88- EUR) dont trois
millions cinq cent soixante-trois mille cent euros (3.563.100,- EUR) sont alloués au compte capital social et le solde un
million quatre cent quarante-deux mille trois cent quarante-deux euros et quatre-vingt-huit cents (1.442.342,88- EUR)
est alloué au compte prime d'émission.

6. La somme de cinq millions cinq mille quatre cent quarante-deux euros et quatre-vingt-huit cents (5.005.442,88-

EUR) se trouve à la libre disposition de la société ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation
d'une attestation bancaire.

7. Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l'Article 3 des statuts

est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à trente-trois millions six cents mille euros (33.600.000,- EUR) représenté par un

million trois cent quarante-quatre mille (1.344.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de trois mille six cents euros (EUR 3.600,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, ladite com-

parante a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Sandra PASTI, Jean SECKLER.

137135

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Grevenmacher, le 27 septembre 2013. Relation GRE/2013/396. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 11 octobre 2013.

Référence de publication: 2013142819/82.
(130174321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2013.

Kara Finance SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 48.745.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013142175/9.
(130173013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Shamil Real Estate Financing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.

R.C.S. Luxembourg B 135.338.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 21 août 2013:

<i>- Conseil d'administration:

L'assemblée générale des actionnaires a réélu les membres suivants du conseil d'administration:
1) Monsieur Mohamed Bucheeri, administrateur de sociétés, demeurant à Manama (Bahreïn), Villa 1, Gate 2415, Road

4571, Sanad 475, président du conseil d'administration,

2) Monsieur Ali Feqqoussi, employé privé, demeurant à B- 6780 Messancy, 38 rue du Castel, administrateur,
3) Madame Lucy Dupong, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, 11, av. Jean-Pierre Pescatore, ad-

ministrateur.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de la clôture de l'assemblée générale des actionnaires de l'année

2014 statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

<i>- Commissaire:

L'assemblée générale des actionnaires a réélu comme commissaire la société RSM Interfiduciaire, réviseurs d'entre-

prises, avec siège social à B- 1932 Zaventem, Lozenberg 22b3.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de la clôture de l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2014,

statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg, le 10 octobre 2013.

<i>Pour Shamil Real Estate Financing S.A.
Par mandat
Lucy DUPONG

Référence de publication: 2013143054/26.
(130174116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2013.

BNP Paribas InstiCash, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 65.026.

Les comptes annuels au 31/05/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BNP PARIBAS INSTICASH

Référence de publication: 2013141803/12.
(130173161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

137136


Document Outline

Accretio SPF

ACHM Global Hospitality Licensing S.à r.l.

Adeline Institut S.à r.l.

Alves Constructions S.à r.l.

AOL Europe Services S.à r.l.

AOL Holdings (Lux) S.à r.l.

AOL Holdings (Lux) S.à r.l.

Aprotec S.A.

Archi-Concept International S.à.r.l.

Argor International S.A.

Arina S.A.

Aropa S.A.

Asco Holding S.A.

Asco S.A.

Atrilux S.A.

Babillou s. à r.l.

Baltis Investment, S.à r.l.

Barthelme S.C.I.

Batimmo Constructions S.à r.l.

BENESHARE TRANSPORT GROUP (Luxembourg) S.A.-SPF

BISSELL International Finance Company, S.à r.l.

Black &amp; Decker International Holdings B.V.

Blue Planet Group

BNP Paribas InstiCash

Bonnefoit S.A.

Brading Holding S.à r.l.

Brading Holding S.à r.l.

Brandenburg Properties S.à r.l.

Brunelcap S.à r.l.

BTG Pactual Oil&amp;Gas S.à r.l.

BTMU Unit Management S.A.

Bureau Immobilier Lea Kappweiler S.à r.l.

Butzestuff

Byron Enterprises

Dexiastuff

ECVV Business Solutions S.à r.l.

Elvon Properties S.à r.l.

Ely Consulting S.A.

European Institute for Applied Sciences SA

Exelon Nuclear Partners International S.à r.l.

Eye 1 S.à r.l.

Guineu Immobles Luxembourg S.A.

International Mode Investment S.A.

International Soccer Consulting S.A.

JFA &amp; Interfaces Est.

JM Investissements S.à r.l.

Jonas Architectes Associés S.A.

Kara Finance SPF S.A.

Kawa Solar Europe S.à r.l.

Konstrulux S.à r.l.

Köpco Sàrl

KUHN Soparfi S.à r.l.

Lafayette 23 S.à r.l.

Lagoon Finance S. à r.l.

Lagoon Holding S. à r.l.

Landgame S.à r.l.

Leggett &amp; Platt Luxembourg Finance Company S.à r.l.

Leggett &amp; Platt Luxembourg S.à r.l.

Luxury Holding of Luxembourg S.à r.l.

PE développement Sàrl

Shamil Real Estate Financing S.A.

SW III Limited