logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1208

23 mai 2013

SOMMAIRE

Amber Agro and Food Industries Manage-

ment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57973

Arctic Lake S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57944

ATRINITY S.A., société de gestion de pa-

trimoine familial, "SPF"  . . . . . . . . . . . . . . .

57981

Belair Lotissements S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

57941

Bridinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57939

Canetto Participations Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57983

Capital United S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57983

Castel Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57982

Caulus Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

57984

Chemtex Global S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57983

Cirse S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57958

Deltaline S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57939

European Lux Trading S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

57939

Euro-Planning & Consultants S.A.  . . . . . . .

57939

HIB Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57943

Hines Holdings Luxembourg 1 S.à r.l.  . . . .

57939

Holding Dumont S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57943

I.C. Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57938

Impar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57938

Intraline S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57941

Les Pierres Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . .

57938

Linston S.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57938

Litoprint S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57943

Ma Clé S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57940

Mainzer Landstrasse S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

57942

map - MARKETING AND PROMOTION

LUXEMBOURG s.àr.l  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57941

Marimur S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57942

Market Overview S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57942

Massena Advisors S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57941

Massena Capital Partners Luxembourg  . .

57943

Masto Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

57940

Max Media Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

57942

Menuiserie-Ebenisterie Gérard Assen S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57942

M.R. Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57943

NewNet Communication Technologies S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57938

NovaTel IT Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

57944

Pentavest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57953

Resolution Quadrangle General Partner

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57984

Resolution Quadrangle S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

57984

Rushmore Development S.A.  . . . . . . . . . . .

57940

Smiths Finance Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

57959

SurveyMonkey Europe Sarl  . . . . . . . . . . . . .

57984

TUI Travel Card Processing S.à r.l.  . . . . . .

57965

57937

L

U X E M B O U R G

I.C. Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4795 Linger, 6A, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 84.026.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2013046163/10.
(130056567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

Impar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 23.254.

Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2013046170/10.
(130056184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

Les Pierres Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 158.784.

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013046246/10.
(130056541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

Linston S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 59.773.

Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013046249/10.
(130056532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

NewNet Communication Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 166.077.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil d’administration en date du 22 février 2013

Le siège social de la société a été transféré du L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové au L-1331 Luxembourg, 67,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 9 avril 2013.

Pour extrait sincère et conforme
NewNet Communication Technologies S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013045685/14.
(130055524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

57938

L

U X E M B O U R G

Euro-Planning &amp; Consultants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen.

R.C.S. Luxembourg B 106.123.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013046081/10.
(130056267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

European Lux Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 101.541.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013046087/10.
(130056266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

Hines Holdings Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 79.934.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alexie Arnould.

Référence de publication: 2013046136/10.
(130056092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

Deltaline S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 2, Am Broch.

R.C.S. Luxembourg B 155.868.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2013046050/11.
(130055930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

Bridinvest S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 61.864.

L'administrateur Monsieur Gérald CALAME, a changé son adresse du 16, Rue de Hesse, 1204 Geneva, Suisse à 18,

Place Chauderon, 1003 Lausanne, Suisse.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BRIDINVEST S.A.
Xenia KOTOULA
<i>Administrateur

Référence de publication: 2013045439/13.
(130055508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

57939

L

U X E M B O U R G

Ma Clé S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8825 Perle, 35A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 158.118.

<i>Extrait des contrats de cession de parts sociales signés le 02 janvier 2013

<i>Résolution

Madame Nicolina MAZZICHI, née le 13 août 1973 à Ougrée (Belgique), demeurant à 93, Rue sous les Haxhes B-4041

VOTTEM;

Ci-après dénommé le Cédant;
Et
Madame Giovanna MANCUSO, née le 18 octobre 1966 à Grotte (Italie), demeurant à 35A, Route d'Arlon L-8825

PERLE;

Ci-après dénommé le Cessionnaire;
Il a été décidé que le Cédant cède au Cessionnaire 100 (cent) parts sociales de la société Ma Clé S.à.r.l.

AFC Benelux Sàrl
Signature

Référence de publication: 2013045654/19.
(130055553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

Masto Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 148.919.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire de la société à responsabilité limité Masto Investments S.à r.l. tenue à Luxembourg, le 27

<i>novembre 2012 au siège de la société

L’Assemblée a décidé à l’unanimité:
1) De transférer le siège de la société de 49, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
à 15, Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg
2) De nommer M. Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 15 Boulevard Roosevelt, L-2450

Luxembourg en tant que gérant unique de la société pour une durée indéterminée en remplacement de M. Edgard Emile
Fernand Bisenius demeurant professionnellement au 205, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2012.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2013045657/19.
(130055340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

Rushmore Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 176.086.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration de la Société le 8 avril 2013

1. Madame Martine Grün, née le 19 mars 1975 à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), avec adresse profes-

sionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été cooptée en tant que nouvel administrateur de la
Société, avec effet au 3 avril 2013, jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle, qui se tiendra en 2018.

2. Le siège social de la Société a été transféré du 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg au 121, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg avec effet au 3 avril 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour RUSHMORE DEVELOPMENT S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2013045243/16.
(130054690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

57940

L

U X E M B O U R G

map - MARKETING AND PROMOTION LUXEMBOURG s.àr.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1110 Findel, Aeroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 47.255.

EXTRAIT

Suite à la cession de parts du 31 janvier 2013 entre les associés de la société map - MARKETING AND PROMOTION

LUXEMBOURG SARL, établie et ayant son siège social à L-1110 Aéroport Findel, Aéroport de Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 47 255, la nouvelle répartition des parts
de la société se présente comme suit:

- M. Aloyse Muller
demeurant à L-2167 Luxembourg, 96 rue des Muguets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
Luxembourg, le 31 janvier 2013.

Aloyse MULLER.

Référence de publication: 2013045372/16.
(130055386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

Belair Lotissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 35.014.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 décembre 2012:

1. L'Assemblée acte la démission en date du 28 décembre 2012 du commissaire TOP Audit S.A.(anciennement PKF

Abax Audit S.A.) R.C.S. Luxembourg B 142.867.

L'Assemblée nomme Compliance &amp; Control, 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg, R.C.S. B 172.482 comme com-

missaire de la société.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale se tenant en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 avril 2013.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2013045430/16.
(130055370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

Massena Advisors S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 133.048.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 enregistrés et déposés à Luxembourg le 30 janvier 2013, sous le numéro

L130018739 doivent être considérés comme nuls et sont dès lors rectifiés par les présents comptes annexés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MASSENA ADVISORS S.A.

Référence de publication: 2013046280/11.
(130056070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

Intraline S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 2, Am Broch.

R.C.S. Luxembourg B 152.541.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2013046194/11.
(130055934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

57941

L

U X E M B O U R G

Menuiserie-Ebenisterie Gérard Assen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 17, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 97.411.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013046289/10.
(130056272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

Market Overview S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 102.395.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013046279/10.
(130056095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

Marimur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 114.179.

Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013046277/10.
(130056538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

Max Media Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 82.929.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2013.

Hille-Paul Schut
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013046267/12.
(130056735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

Mainzer Landstrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.164.400,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 128.008.

Le bilan de la société au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013046262/12.
(130056107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

57942

L

U X E M B O U R G

Massena Capital Partners Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 139.143.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Massena Capital Partners Luxembourg

Référence de publication: 2013046281/10.
(130056343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

M.R. Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7653 Heffingen, 16, Um Beil.

R.C.S. Luxembourg B 127.161.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013046259/10.
(130056546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

HIB Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 104.505.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HIB INVEST S.A.

Référence de publication: 2013046156/10.
(130056073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

Litoprint S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 41.107.

Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LITOPRINT S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013046251/12.
(130056672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

Holding Dumont S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 154.772.

Les comptes annuels au 31 août 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HOLDING DUMONT S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013046159/12.
(130056528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

57943

L

U X E M B O U R G

Arctic Lake S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 152.316.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 27 mars 2013.

Référence de publication: 2013040391/10.
(130049930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

NovaTel IT Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 176.124.

STATUTES

In the year two thousand thirteen, on the sixth day of March;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

1) Mr Anouar FRIAA, citizen of Tunisia, born on 22 March 1974 in Paris, France, and residing at avenue Hedi Nouira,

RES Palace B13, 2037 El Mezah 8, Tunisia;

2) Mr Lassad CHAOUACHI, citizen of Tunisia, born on 27 February 1971 in Beja, Tunisia, and residing at 24, rue

Allaimoun, 624 Riad-Agdal Riad, 10100 Rabat, Morocco;

3) Mr Khalid HANAFI, citizen of Morocco, born on 26 January 1968 in Goulmima, Morocco, and residing at 9, avenue

Abderrahim Bouabid, 621 Riad-Agdal Riad, 10100 Rabat, Morocco;

4) Mr Anis ADDALA, citizen of Tunisia, born on 10 September 1978 in Zarzis, Tunisia, and residing at Residence

Fayrouz la Marsa, apartment N° 62, bloc A, La Soukra, Tunisia; and

5) Mr Anis ACHOUR, citizen of Tunisia, born on 27 October 1979 in Zarzis, Tunisia, and residing at A4.4 Residence

Badr, Cité El Mhiri, 2045 Tunis, Tunisia.

All appearing parties are represented by Mr Abdelrahime BENMOUSSA, private employee, with professional address

at 58, rue Charles Mattel, L-2134 Luxembourg by virtue of five (5) proxies given under private seal.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "NovaTel

IT Group S.à r.l."(hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of
association (hereafter the Articles).

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

57944

L

U X E M B O U R G

3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment  and  control  of  any  company  or  enterprise.  The  Company  shall  be  considered  as  a  "Société  de  Participations
Financières" according to the applicable provisions.

3.2 It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property

rights of any nature or origin whatsoever.

3.3 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company to the extent
permitted under Luxembourg law. To the extent permitted under Luxembourg law the Company may also give guarantees
and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee
its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other companies or persons that may or
may not be shareholders of the Company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other companies
or persons that may or may not be shareholders of the Company.

3.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.5 The Company may buy, sell, exchange, finance, lease, improve, demolish, construct for its own account, develop,

divide and manage any real estate. It may further execute all works of renovations and transformations as well as the
maintenance of these assets.

3.6 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at fifteen thousand euros (EUR 15,000) represented by six hundred (600)

shares in registered form with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.

6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of

the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

57945

L

U X E M B O U R G

III. Management - Representation

7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
7.3 The shareholder(s) may decide to appoint one or several Class A managers and one or several Class B managers.

8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.

8.2 Subject to article 8.3 special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons,

whether shareholders or not, by any manager of the Company.

8.3 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, special

and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether shareholders or not, only
by any Class A manager acting jointly with any Class B manager.

9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 The notice period may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-

mail, of each member of the board of managers of the Company or if all the members of the board of managers of the
Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full
knowledge of the agenda of the meeting.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the
shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, at least one Class
A manager and one Class B manager (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour of the resolution. The
chairman shall not be entitled to a second or casting vote.

9.6 The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present at the

meeting.

9.7 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.8 In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

10. Representation.
10.1 Subject to article 10.2 the Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any

manager of the Company or by the signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated
in accordance with article 8.2 and 8.3 of these Articles.

10.2 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, the

Company will be bound towards third parties by the joint signature of any Class A manager with any Class B manager.

11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any

commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these
Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

12. Powers and Voting rights.
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

57946

L

U X E M B O U R G

12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or email. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

14. Accounting year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of

December.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board

of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

15. Allocation of profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 The general meeting of shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts

prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed profits realised either since the end of the last fiscal year increased by profits carried
forward and distributable reserves, including share premium, but decreased by losses carried forward or, where the
distribution is to be made during the first financial year of the Company, since the date of incorporation of the Company
but, in either case, decreased by sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

VI. Dissolution - Liquidation

In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do

not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder
(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid

to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by
each shareholder in the Company.

VII. General provision

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2013.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Mr Anouar FRIAA, pre-named and represented as stated above, declares to subscribe to one hundred

and eighty (180) shares in registered form, with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each, representing 30% of the
Company's share capital, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to four thousand five hundred
euros (EUR 4,500);

Mr Lassad CHAOUACHI, pre-named and represented as stated above, declares to subscribe to one hundred and five

(105) shares in registered form, with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each, representing 17.5% of the Company's

57947

L

U X E M B O U R G

share capital, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to two thousand six hundred twenty-
five euros (EUR 2,625);

Mr Khalid HANAFI, pre-named and represented as stated above, declares to subscribe to one hundred and five (105)

shares in registered form, with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each, representing 17.5% of the Company's
share capital, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to two thousand six hundred twenty-
five euros (EUR 2,625);

Mr Anis ADDALA, pre-named and represented as stated above, declares to subscribe to one hundred and five (105)

shares in registered form, with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each, representing 17.5% of the Company's
share capital, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to two thousand six hundred twenty-
five euros (EUR 2,625); and

Mr Anis ACHOUR, pre-named and represented as stated above, declares to subscribe to one hundred and five (105)

shares in registered form, with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each, representing 17.5% of the Company's
share capital, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to two thousand six hundred twenty-
five euros (EUR 2,625).

The amount of fifteen thousand euros (EUR 15,000) is from this day on at the free disposal of the Corporation, as it

has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

<i>Extraordinary general meeting

The aforementioned appearing persons, representing the totality of the subscribed capital and considering themselves

as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions
by unanimity:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
- Mr Anis ADDALA, citizen of Tunisia, born on 10 September 1978 in Zarzis, Tunisia, and residing at Residence Fayrouz

la Marsa, apartment N° 62, bloc A, La Soukra, Tunisia.

2. The registered office of the Company is set at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand euros (EUR 1,000.-).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, said proxyholder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le six mars.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Anouar FRIAA, citoyen tunisien, né le 22 mars 1974 à Paris, France, et résidant à avenue Hedi Nouira,

RES Palace B13, 2037 El Mezah 8, Tunisie;

2)  Monsieur  Lassad  CHAOUACHI,  citoyen  tunisien,  né  le  27  février  1971  à  Beja,  Tunisie,  et  résidant  au  24,  rue

Allaimoun, 624 Riad-Agdal Riad, 10100 Rabat, Maroc;

3) Monsieur Khalid HANAFI, citoyen marocain, né le 26 janvier 1968 à Goulmima, Maroc, et résidant à 9, avenue

Abderrahim Bouabid, 621 Riad-Agdal Riad, 10100 Rabat, Maroc;

4) Monsieur Anis ADDALA, citoyen tunisien, né le 10 septembre 1978 à Zarzis, Tunisie, et résidant à Residence Fayrouz

la Marsa, apartment N° 62, bloc A, La Soukra, Tunisie; et

5) Monsieur Anis ACHOUR, citoyen tunisien, né le 27 octobre 1979 à Zarzis, Tunisie, et résidant à A4.4 Residence

Badr, Cité El Mhiri, 2045 Tunis, Tunisie.

Toutes les parties sont ici représentés par Monsieur Abdelrahime BENMOUSSA, employé privé, ayant son adresse

professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, en vertu de cinq (5) procurations données sous seing
privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et

le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

57948

L

U X E M B O U R G

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

1. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination NovaTel IT Group S.à r.l. (ci-

après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 Août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 II peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime
que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évé-
nements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée
entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes les sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. La Société sera considérée comme une Société
de Participations Financières selon les mesures en vigueur.

3.2 Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de

propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.3 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs
d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou toute autre société ou
personne qui peuvent être associés ou non de la Société, dans la limite de ce qui est permis par la loi luxembourgeoise.
Dans la limite de ce qui est permis par la loi luxembourgeoise la Société pourra également donner des garanties et nantir,
transférer, grever ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de
garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société ou personne qui
peuvent être associés ou non de la Société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société
ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société.

3.4 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.5  La  société  pourra  acheter,  vendre,  échanger,  financer,  louer,  améliorer,  démolir,  construire  pour  son  propre

compte, développer, diviser et gérer tous biens immobiliers. Elle pourra en outre effectuer tous travaux de rénovations
et de transformations ainsi que la maintenance de ces biens.

3.6 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-

actions  se  rapportant  à  la  propriété  immobilière  ou  mobilière,  qui  directement  ou  indirectement  favorisent  ou  se
rapportent à la réalisation de son objet social.

4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant l'un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

5. Capital.
5.1 Le capital de la Société est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000), représenté par six cents (600) parts sociales

sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.

57949

L

U X E M B O U R G

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.

6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément, donné

en assemblée générale, des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle aura été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi ou il pourra

être consulté par chaque associé.

6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la

Loi.

III. Gestion - Représentation

7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de

l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n' (ne) est (sont) pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum (sans aucune raison).
7.3 L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou

plusieurs gérants de Classe B.

8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus qu'un gérant, du conseil de gérance, lequel aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2 Sous réserve des dispositions de l'article 8.3, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent

être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, par tout gérant de la Société.

8.3 Si les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, des pouvoirs

spéciaux et limités pour des tâches spécifiques ne peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient
associés ou non, que par tout gérant de Classe A agissant conjointement avec tout gérant de Classe B.

9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 Il peut être renoncé à la période de convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la

Société  donné  par  écrit  soit  en  original,  soit  par  télégramme,  télex,  téléfax  ou  courrier  électronique,  ou  si  tous  les
membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été
dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou

représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix à la condition que,
si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe
B, au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B (à chaque fois soit en personne soit par procuration) votent
en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.

9.6 Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents à la réunion.
9.7 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent

57950

L

U X E M B O U R G

s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.8 En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valable-

ment adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants
peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.

10. Représentation.
10.1 Sous réserve des dispositions de l'article 10.2, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances

par la seule signature d'un gérant ou par la signature de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été
valablement délégués conformément aux articles 8.2 et 8.3 des Statuts.

10.2 Si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de

Classe B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de tout gérant de Classe A et de tout gérant
de Classe B.

11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent, en raison de leur mandat, aucune obligation personnelle

relativement à tout engagement valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où un tel engagement est
en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne ou entité comme mandataire.

13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique envoyé(e)s par
lettre ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui
sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3 L'assemblée générale des associés peut décider de distribuer des dividendes intérimaires sur la base d'un état

comptable préparé par les gérants dont il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu  que  le  montant  à  distribuer  ne  peut  excéder  les  bénéfices  réalisés  depuis  la  fin  du  dernier  exercice  social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, comprenant la prime d'émission, mais diminué des pertes
reportées ou, lorsque la distribution a lieu lors du premier exercice social de la Société, depuis la date de constitution
de la Société mais, dans tous les cas, diminué des sommes à allouer à la réserve légale établie en fonction de la loi ou des
présents statuts.

57951

L

U X E M B O U R G

VI. Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf
disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à

l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2013.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, Monsieur Anouar FRIAA, prénommé et représenté comme spécifié ci-dessus, déclare souscrire à

cent quatre-vingt (180) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune,
représentant 30% du capital social de la Société, et les libérer entièrement par versement en espèces de quatre mille cinq
cents euros (EUR 4.500);

Monsieur Lassad CHAOUACHI, prénommé et représenté comme spécifié ci-dessus, déclare souscrire à cent cinq

(105) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, représentant
17,5% du capital social de la Société, et les libérer entièrement par versement en espèces de deux mille six cent vingt-
cinq euros (EUR 2.625);

Monsieur Khalid HANAFI, prénommé et représenté comme spécifié ci-dessus, déclare souscrire à cent cinq (105)

parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, représentant 17,5%
du capital social de la Société, et les libérer entièrement par versement en espèces de deux mille six cent vingt-cinq euros
(EUR 2.625);

Monsieur Anis ADDALA, prénommé et représenté comme spécifié ci-dessus, déclare souscrire cent cinq (105) parts

sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, représentant 17,5% du
capital social de la Société, et les libérer entièrement par versement en espèces de deux mille six cent vingt-cinq euros
(EUR 2.625); et

Monsieur Anis ACHOUR, prénommé et représenté comme spécifié ci-dessus, déclare souscrire à cent cinq (105)

parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, représentant 17,5%
du capital social de la Société, et les libérer entièrement par versement en espèces de deux mille six cent vingt-cinq euros
(EUR 2.625).

La somme de quinze mille euros (EUR 15.000) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en

a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants pré-mentionnés, représentant la totalité du capital social et se considérant comme étant valablement

convoqués, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent les résolutions suivantes à l'unanimité:

1. La personne suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Anis ADDALA, citoyen tunisien, né le 10 septembre 1978 à Zarzis, Tunisie, et résidant à Résidence Fayrouz

la Marsa, apartment N° 62, bloc A, La Soukra, Tunisie.

2. Le siège social de la Société est établi au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date spécifiée en tête des présents Statuts.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, le mandataire a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: A. BENMOUSSA, C. WERSANDT.

57952

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mars 2013 LAC/2013/11775. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 21 mars 2013.

Référence de publication: 2013040167/484.
(130049029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2013.

Pentavest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 154.065.

In the year two thousand and thirteen, on the thirteenth day of February.
Before Me Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

Index Ventures V (Jersey), L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of Jersey, registered with the

Jersey Financial Services Commission under registration number LP1126, having its registered office at Ogier House, The
Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channel Islands, acting through its managing general partner Index Venture As-
sociates  V  Limited,  here  represented  by  Me  Nathalie  HOULLE,  Attorney-at-Law,  having  her  professional  address  in
Howald (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal;

Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P., a limited partnership formed and existing under the laws

of Jersey, registered with the Jersey Financial Services Commission under registration number LP1125, having its regis-
tered office at Ogier House, The Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channel Islands, acting through its managing
general partner Index Venture Associates V Limited, here represented by Me Nathalie HOULLE, Attorney-at-Law, having
her professional address in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal;

Yucca Partners L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of Quebec, registered with the Registre

des Entreprises du Quebec under registration number 3362083217, having its registered office at 1134 Sainte Catherine
Street West, H3B 5K2 Montreal, Quebec, Canada, acting for its Jersey branch Yucca Partners L.P. Jersey Branch, a branch
of Yucca Partners L.P. formed and existing under the laws of Jersey, registered with the Jersey Financial Services Com-
mission under registration number 23322, having its registered office at Ogier House, The Esplanade, St Helier, Jersey,
JE4 9WG, Channels Islands, here represented by Me Nathalie HOULLE, Attorney-at-Law, having her professional address
in Howald (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal;

Index Ventures Growth I (Jersey), L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of Jersey, registered

with the Jersey Financial Services Commission under registration number LP981, having its registered office at No 1,
Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 8YJ, Channel Islands, acting through its managing general partner Index Venture Growth
Associates I Limited, here represented by Me Nathalie HOULLE, Attorney-at-Law, having her professional address in
Howald (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal;

Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P., a limited partnership formed and existing under

the laws of Jersey, registered with the Jersey Financial Services Commission under registration number LP979, having its
registered office at No 1, Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 8YJ, Channel Islands, acting through its managing general
partner Index Venture Growth Associates I Limited, here represented by Me Nathalie HOULLE, Attorney-at-Law, having
his professional address in Howald (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxies initialled "ne varietur" by the representative of the appearing parties and the undersigned notary shall

remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That they are the current shareholders of Pentavest S.à r.l. having its registered office at 1, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number
B 154065 (the "Company"), incorporated by a deed of Me Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, on June
18, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1579 of August 3, 2010. The articles
have been modified for the last time by a deed of Me Francis KESSELER, prenamed, on March 27, 2012, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1348 of May 31, 2012.

II. That the capital of the Company is set at eleven million eighty-nine thousand eight hundred fifty-seven Euros and

thirty-four Cents (EUR 11,089,857.34) represented by twenty-five million (25,000,000) class A shares, by thirty-three
million five hundred thousand (33,500,000) class B shares, by three hundred and thirty-nine million six hundred fifteen
thousand five hundred twenty-eight (339,615,528) class C shares, by thirty-two million six hundred eighty-nine thousand
six hundred fifty-five (32,689,655) class D shares, by two hundred and eighty-two million (282,000,000) class E shares, by
thirty-eight million four hundred thirty-three thousand and six (38,433,006) class F shares, by eight million (8,000,000)
class G shares, by one hundred thirty-five million two hundred forty-nine thousand and three hundred (135,249,300) class
H shares, by twenty two millions (22,000,000) class I shares and by one hundred ninety-two million four hundred ninety-

57953

L

U X E M B O U R G

eight thousand two hundred forty-five (192,498,245) class J shares, each with a nominal value of one Cent (EUR 0.01),
entirely subscribed for and fully paid up.

III. These shares are allocated to the shareholders as follows:
1. 24,489,120 class A shares for Index Ventures V (Jersey), L.P.;
2. 32,815,421 class B shares for Index Ventures V (Jersey), L.P.;
3. 32,021,635 class D shares for Index Ventures V (Jersey), L.P.;
4. 7,444,691 class G shares for Index Ventures V (Jersey), L.P.;
5. 21,550,426 class I shares for Index Ventures V (Jersey), L.P.;
6. 198,380 class A shares for Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
7. 265,829 class B shares for Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
8. 259,399 class D shares for Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
9. 60,309 class G shares for Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
10. 174,574 class I shares for Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
11. 312,500 class A shares for Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch;
12. 418,750 class B shares for Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch;
13. 1,698,078 class C shares for Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch;
14. 408,621 class D shares for Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch;
15. 1,410,000 class E shares for Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch;
16. 192,165 class F for Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch;
17. 495,000 class G shares for Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch;
18. 275,000 class I shares for Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch;
19. 676,247 class H shares for Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch;
20. 962,491 class J shares for Yucca Partners L.P. acting for Yucca Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch;
21. 326,525,726 class C shares for Index Ventures Growth I (Jersey), L.P.;
22. 271,130,874 class E shares for Index Ventures Growth I (Jersey), L.P.;
23. 36,951,683 class F shares for Index Ventures Growth I (Jersey), L.P;.
24. 130,036,386 class H shares for Index Ventures Growth I (Jersey), L.P.;
25. 185,078,785 class J shares for Index Ventures Growth I (Jersey) L.P.;
26. 11,391,724 class C shares for Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
27. 9,459,126 class E shares for Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
28. 1,289,158 class F for Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
29. 4,536,667 class H shares for Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
30. 6,456,969 class J shares for Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.
That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1) Increase of the share capital of the Company by an amount of fifty-two thousand five hundred Euros (EUR 52,500)

so as to raise it from its present amount of eleven million eighty-nine thousand eight hundred fifty-seven Euros and thirty-
four Cents (EUR 11,089,857.34) to eleven million one hundred forty-two thousand three hundred fifty-seven Euros and
thirty-four Cents (EUR 11,142,357.34) by the creation and the issue of five million two hundred fifty thousand (5,250,000)
new class B shares of a par value of one Euro Cent (EUR 0.01) each.

2) Subscription and paying up of the five million two hundred fifty thousand (5,250,000) new class B shares as follows:
(a) Five million one hundred forty two thousand seven hundred fifteen (5,142,715.-) new class B shares by Index

Ventures V (Jersey), L.P., prenamed, by a contribution in cash of fifty-one thousand four hundred twenty seven Euros and
fifteen Cents (EUR 51,427.15);

(b) Forty-one thousand six hundred sixty (41,660) new class B shares by Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund

(Jersey), L.P., prenamed, by a contribution in cash of four hundred sixteen Euros and sixty Cents (EUR 416.60);

(c) Sixty-five thousand six hundred twenty-five (65,625) new class B shares by Yucca Partners L.P. acting for Yucca

Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch, prenamed, by a contribution in cash of six hundred fifty-six Euros and twenty-
five Cents (EUR 656.25).

3) Amendment of Article 6 of the articles of association so as to reflect the proposed increase of the share capital of

the Company.

After this had been set forth, the above named shareholders of the Company, representing the entire capital of the

Company, now request the undersigned notary to record the following resolutions:

57954

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The shareholders of the Company unanimously resolve to increase the capital of the Company by an amount of fifty-

two thousand five hundred Euros (EUR 52,500) so as to raise it from its present amount of eleven million eighty-nine
thousand eight hundred fifty-seven Euros and thirty-four Cents (EUR 11,089,857.34) to eleven million one hundred forty-
two thousand three hundred fifty-seven Euros and thirty-four Cents (EUR 11,142,357.34) by the creation and the issue
of five million two hundred fifty thousand (5,250,000) new class B shares of a par value of one Euro Cent (EUR 0.01)
each.

<i>Subscription and payment

All  the  five  million  two  hundred  fifty  thousand  (5,250,000)  new  class  B  shares  are  subscribed  for  by  the  existing

shareholders as follows:

(a) Five million one hundred forty two thousand seven hundred fifteen (5,142,715.-) new class B shares by Index

Ventures V (Jersey), L.P., prenamed, by a contribution in cash of fifty-one thousand four hundred twenty seven Euros and
fifteen Cents (EUR 51,427.15);

(b) Forty-one thousand six hundred sixty (41,660) new class B shares by Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund

(Jersey), L.P., prenamed, by a contribution in cash of four hundred sixteen Euros and sixty Cents (EUR 416.60);

(c) Sixty-five thousand six hundred twenty-five (65,625) new class B shares by Yucca Partners L.P. acting for Yucca

Partners LP Jersey Branch, its Jersey branch, prenamed, by a contribution in cash of six hundred fifty-six Euros and twenty-
five Cents(EUR 656.25).

The five million two hundred fifty thousand (5,250,000) new class B shares have been entirely paid up by a contribution

in cash from the above mentioned persons for an aggregate amount fifty-two thousand five hundred Euros (EUR 52,500)
which are now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution and subscription of the new class B shares, Article 6 of the Articles of

Association is amended and now reads as follows:

« Art. 6. The capital is fixed at eleven million one hundred forty-two thousand three hundred fifty-seven Euros and

thirty-four Cents (EUR 11,142,357.34) represented by twenty-five million (25,000,000) class A shares, by thirty-eight
million seven hundred fifty thousand (38,750,000) class B shares, by three hundred thirty-nine million six hundred fifteen
thousand  five  hundred  and  twenty-eight  (339,615,528)  class  C  shares,  by  thirty  two  million  six  hundred  eighty  nine
thousand six hundred fifty five (32,689,655) class D shares, by two hundred and eighty-two million (282,000,000) class E
shares, by thirty-eight million four hundred thirty three thousand and six (38,433,006) class F shares, by eight million
(8,000,000)  class  G  shares,  by  one  hundred  thirty-five  million  two  hundred  forty-nine  thousand  three  hundred
(135,249,300) class H shares, by twenty-two million (22,000,000) class I shares, and by one hundred ninety two million
four hundred ninety eight thousand two hundred forty five (192,498,245) class J shares, each with a nominal value of one
Cent (EUR 0.01), entirely subscribed for and fully paid up."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated approximately at one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing parties and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by surname, given name, civil

status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille treize, le treizième jour de février.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

ONT COMPARU:

Index Ventures V (Jersey), L.P., un limited partnership constitué et opérant sous le droit de Jersey, immatriculé auprès

du Jersey Financial Services Commission sous le numéro d'immatriculation LP1126, ayant son siège social à Ogier House,
The Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channel Islands, agissant par l'intermédiaire de son managing general partner
Index Venture Associates V Limited, ici représenté par Maître Nathalie HOULLE, avocat à la Cour, demeurant profes-
sionnellement à Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé;

57955

L

U X E M B O U R G

Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P., un limited partnership constitué et opérant sous le droit

de Jersey, immatriculé auprès du Jersey Financial Services Commission sous le numéro d'immatriculation LP1125, ayant
son siège social à Ogier House, The Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channel Islands, agissant par l'intermédiaire
de son managing general partner Index Venture Associates V Limited, ici représenté par Maître Nathalie HOULLE, avocat
à  la  Cour,  demeurant  professionnellement  à  Howald,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  en  vertu  d'une  procuration  lui
conférée sous seing privé;

Yucca Partners L.P., un limited partnership constitué et opérant sous le droit du Québec, immatriculé auprès du

Registre des Entreprises du Québec sous le numéro d'immatriculation 3362083217, ayant son siège social au 1134 Sainte
Catherine Street West, H3B 5K2 Montreal, Québec, Canada, agissant pour sa succursale de Jersey, Yucca Partners L.P.
Jersey Branch, une succursale de Yucca Partners L.P. constituée et opérant sous le droit de Jersey, immatriculé auprès
du Jersey Financial Services Commission sous le numéro d'immatriculation 23322, ayant son siège social au Ogier House,
The Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, Channel Islands, ici représentée par Maître Nathalie HOULLE, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée
sous seing privé;

Index Ventures Growth I (Jersey), L.P., un limited partnership constitué et opérant sous le droit de Jersey, immatriculé

auprès du Jersey Financial Services Commission sous le numéro d'immatriculation LP981, ayant son siège social au No 1,
Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 8YJ, Channel Islands, agissant par son managing general partner Index Venture Growth
Associates I Limited, ici représentée par Maître Nathalie HOULLE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé;

Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P., un limited partnership constitué et opérant sous

le droit de Jersey, immatriculé auprès du Jersey Financial Services Commission sous le numéro d'immatriculation LP979,
ayant son siège social au No 1, Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 8YJ, Channel Islands, agissant par son managing general
partner Index Venture Growth Associates I Limited, ici représentée par Maître Nathalie HOULLE, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous
seing privé.

Ces procurations signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes prénommées et le notaire soussigné,

demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les parties comparantes prénommées, représentées comme établit ci avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter

ce qui suit:

I. Ils sont les associés actuels de Pentavest S.à r.l. avec siège social au 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 154065
(la «Société»), constituée suivant acte du notaire Me Paul BETTINGEN, résidant à Niederanven, en date du 18 juin 2010,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1579 du 3 août 2010. Les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte du notaire Maître Francis KESSELER soussigné en date du 27 mars 2012, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1348 du 31 mai 2012.

II. Le capital social de la Société est fixé à onze millions quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante-sept euros et trente-

quatre cents (EUR 11.089.857,34) représenté par vingt-cinq millions (25.000.000) de Parts Sociales de classe A, par trente-
trois millions cinq cent mille (33.500.000) de Parts Sociales de classe B, par trois cent trente-neuf millions six cent quinze
mille cinq cent vingt-huit (339.615.528) Parts Sociales de classe C, par trente-deux millions six cent quatre-vingt-neuf
mille  six  cent  cinquante-cinq  (32.689.655)  Parts  Sociales  de  classe  D,  par  deux  cent  quatre-vingt-deux  millions
(282.000.000) Parts Sociales de classe E, par trente-huit millions quatre cent trente-trois mille six (38.433.006) Parts
sociales de classe F, par huit millions (8.000.000) de Parts sociales de classe G, par cent trente-cinq millions deux cent
quarante-neuf mille trois cent (135.249.300) Parts sociales de classe H, par vingt-deux millions (22.000.000) Parts sociales
de  classe  I  et  par  cent  quatre-vingt-douze  millions  quatre  cent  quatre-vingt-dix-huit  mille  deux  cent  quarante-cinq
(192.498.245) Parts sociales de classe J, chacune ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), entièrement
souscrites et libérées.

III. Ces parts sociales sont réparties entre les associés existants comme suit:
1. 24.489.120 parts sociales de classe A pour Index Ventures V (Jersey), L.P.;
2. 32.815.421 parts sociales de classe B pour Index Ventures V (Jersey), L.P.;
3. 32.021.635 parts sociales de classe D pour Index Ventures V (Jersey), L.P.;
4. 7.444.691 parts sociales de classe G pour Index Ventures V (Jersey), L.P.;
5. 21.550.426 parts sociales de classe I pour Index Ventures V (Jersey), L.P.;
6. 198.380 parts sociales de classe A pour Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
7. 265.829 parts sociales de classe B pour Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
8. 259.399 parts sociales de classe D pour Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
9. 60.309 parts sociales de classe G pour Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
10. 174.574 parts sociales de classe I pour Index Ventures V Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
11. 312.500 parts sociales de classe A pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa

succursale de Jersey;

57956

L

U X E M B O U R G

12. 418.750 parts sociales de classe B pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa

succursale de Jersey;

13. 1.698.078 parts sociales de classe C pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa

succursale de Jersey;

14. 408.621 parts sociales de classe D pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa

succursale de Jersey;

15. 1.410.000 parts sociales de classe E pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa

succursale de Jersey;

16. 192.165 parts sociales de classe F pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa

succursale de Jersey;

17. 495.000 parts sociales de classe G pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa

succursale de Jersey;

18. 275.000 parts sociales de classe I pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa

succursale de Jersey;

19. 676.247 parts sociales de classe H pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa

succursale de Jersey;

20. 962.491 parts sociales de classe J pour Yucca Partners L.P. agissant pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa

succursale de Jersey;

21. 326.525.726 parts sociales de classe C pour Index Ventures Growth I (Jersey), L.P.;
22. 271.130.874 parts sociales de classe E pour Index Ventures Growth I (Jersey), L.P.;
23. 36.951.683 parts sociales de classe F pour Index Ventures Growth I (Jersey), L.P.;
24. 130.036.386 parts sociales de classe H pour Index Ventures Growth I (Jersey), L.P.;
25. 185.078.785 parts sociales de classe J pour Index Ventures Growth I (Jersey), L.P.;
26. 11.391.724 parts sociales de classe C pour Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
27. 9.459.126 parts sociales de classe E pour Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P;
28. 1.289.158 parts sociales de classe F pour Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
29. 4.536.667 parts sociales de classe H pour Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.;
30. 6.456.969 parts sociales de classe J pour Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund (Jersey), L.P.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinquante-deux mille cinq cent euros (EUR 52.500)

afin de le porter de son montant actuel de onze millions quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante-sept euros et trente-
quatre cents (EUR 11.089.857,34) à onze millions cent quarante-deux mille trois cent cinquante-sept euros et trente-
quatre cents (EUR 11.142.357,34) par la création et l'émission de cinq millions deux cent cinquante mille (5.250.000)
nouvelles parts sociales de classe B d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

2) Souscription et libération des cinq millions deux cent cinquante mille (5.250.000) nouvelles parts sociales de classe

B comme suit:

(a) Cinq millions cent quarante-deux mille sept cent quinze (5.142.715) nouvelles parts sociales de classe B pour Index

Ventures V (Jersey), L.P par l'apport en numéraire de cinquante-et-un mille quatre cent vingt-sept euros et quinze cents
(EUR 51.427,15).

(b) Quarante-et-un mille six cent soixante (41.660) nouvelles parts sociales de classe B pour Index Ventures V Parallel

Entrepreneur Fund (Jersey), L.P. par l'apport en numéraire de quatre cent seize euros et soixante cents (EUR 416,60);

(c) Soixante-cinq mille six cent vingt-cinq (65.625) nouvelles parts sociales de classe B pour Yucca Partners L.P. agissant

pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa succursale de Jersey par l'apport en numéraire de six cent cinquante-six euros
vingt-cinq cents (EUR 656,25).

3) Modification de l'Article 6 des statuts afin de refléter cette augmentation de capital social de la Société.
Ceci ayant été exposé, les associés prénommés de la Société, représentant l'intégralité du capital de la société, re-

quièrent désormais le notaire instrumentaire de prendre acte des décisions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés de la Société décident à l'unanimité d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante-

deux mille cinq cent euros (EUR 52.500) afin de le porter de son montant actuel de onze millions quatre-vingt-neuf mille
huit cent cinquante-sept euros et trente-quatre cents (EUR 11.089.857,34) à onze millions cent quarante-deux mille trois
cent cinquante-sept euros et trente-quatre cents (EUR 11.142.357,34) par la création et l'émission de cinq millions deux
cent cinquante mille (5.250.000) nouvelles parts sociales de classe B d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune.

57957

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et libération

Toutes les cinq millions deux cent cinquante mille (5.250.000) nouvelles parts sociales classe B sont souscrites par les

associés actuels comme suit:

(a) Cinq millions cent quarante-deux mille sept cent quinze (5.142.715) nouvelles parts sociales de classe B pour Index

Ventures V (Jersey), L.P par l'apport en numéraire de cinquante-et-un mille quatre cent vingt-sept euros et quinze cents
(EUR 51.427,15).

(b) Quarante et un mille six cent soixante (41.660) nouvelles parts sociales de classe B pour Index Ventures V Parallel

Entrepreneur Fund (Jersey), L.P. par l'apport en numéraire de quatre cent seize euros et soixante cents (EUR 416,60);

(c) Soixante-cinq mille six cent vingt-cinq (65.625) nouvelles parts sociales de classe B pour Yucca Partners L.P. agissant

pour Yucca Partners LP Jersey Branch, sa succursale de Jersey par l'apport en numéraire de six cent cinquante-six euros
vingt-cinq cents (EUR 656,25).

Les cinq millions deux cent cinquante mille (5.250.000) parts sociales de classe B ont été entièrement libérées par

apport en numéraire de la part des personnes susmentionnées à concurrence d'un montant total de cinquante-deux mille
cinq cent euros (EUR 52.500) qui est à la disposition de la société, tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente et à la souscription des nouvelles parts sociales de classe B, l'Article 6 des statuts est

modifié et est à présent libellé comme suit:

« Art. 6. Le capital social émis est fixé à onze millions cent quarante-deux mille trois cent cinquante-sept euros et

trente-quatre cents (EUR 11.142.357,34) représenté par vingt-cinq millions (25.000.000) de parts sociales de classe A,
par trente-huit millions sept cent cinquante mille (38.750.000) de parts sociales de classe B, par trois cent trente-neuf
millions six cent quinze mille cinq cent vingt-huit (339.615.528) parts sociales de classe C, par trente-deux millions six
cent quatre-vingt-neuf mille six cent cinquante-cinq (32.689.655) parts sociales de classe D, par deux cent quatre-vingt-
deux  millions  (282.000.000)  de  parts  sociales  de  classe  E,  par  trente-huit  millions  quatre  cent  trente-trois  mille  six
(38.433.006) parts sociales de classe F, par huit millions (8.000.000) de Parts Sociales de classe G, par cent trente-cinq
millions  deux  cent  quarante-neuf  mille  trois  cents  (135.249.300)  parts  sociales  de  classe  H,  par  vingt-deux  millions
(22.000.000) parts sociales de classe I et par cent quatre-vingt-douze millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille deux
cent quarante-cinq (192.498.245) parts sociales de classe J, chacune ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01), entièrement souscrites et libérées»

<i>Coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente que sur demande des parties comparantes,

le présent document a été établi en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes parties com-
parantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le version anglaise fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, ledit comparant a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Houlle, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 février 2013. Relation: EAC/2013/2271. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013040697/316.
(130050050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

Cirse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 160.986.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2013.

Référence de publication: 2013040429/11.
(130049998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

57958

L

U X E M B O U R G

Smiths Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 35.141.443,67.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 142.379.

In the year two thousand and twelve, the thirty-first day of October, before Maître Francis Kesseler, notary residing

in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Smiths Finance Luxembourg S.à

r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 21, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg, with a share capital of USD 88,128,148.85 and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B 142379 (the Company). The Company was incorporated on 9 October
2008 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C - N° 2672 of 3 November 2008. The articles of association of the Company (the Articles)
have been amended most recently on 31 October 2012 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, prenamed, not
yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

There appeared:

Smiths Group Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)

with a share capital of USD 72,931,490, with registered office at 21, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 142380 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Robert Steinmetzer, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy given under private seal;

Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and by the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the 8,812,814,885 (eight billion eight hundred and twelve million eight hundred and fourteen thousand eight

hundred and eighty-five) shares having a nominal value of USD 0.01 (one United States Cent) each, representing the
entirety of the share capital of the Company are duly represented at the Meeting;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
(i) waiver of the convening notices;
(ii) change to the financial year of the Company;
(iii) subsequent amendment of article 15 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the amendment under item (ii) above;

(iv) approval of the repurchase of 5,299,670,518 (five billion two hundred and ninety-nine million six hundred and

seventy thousand five hundred and eighteen) shares held by the Sole Shareholder (the Repurchased Shares) for an ag-
gregate amount of USD 604,345,813.93 (six hundred and four million three hundred and forty-five thousand eight hundred
and thirteen United States Dollars ninety-three Cents) (the Repurchase Price);

(v)  reduction  of  the  share  capital  of  the  Company  to  bring  the  share  capital  from  its  current  amount  of  USD

88,128,148.85 (eighty-eight million one hundred and twenty-eight thousand one hundred and forty-eight United States
Dollars and eighty-five Cents), represented by 8,812,814,885 (eight billion eight hundred and twelve million eight hundred
and fourteen thousand eight hundred and eighty-five) shares having a nominal value of USD 0.01 (one United States Cent)
each to USD 35,131,443.67 (thirty-five million one hundred and thirty-one million four hundred and forty-three United
States Dollars sixty-seven Cents) represented by 3,513,144,367 (three billion five hundred and thirteen million one hun-
dred and forty-four thousand three hundred and sixty-seven) shares having a nominal value of USD 0.01 (one United
States Cent) each by way of cancellation of all the Repurchased Shares;

(vi) creation of preference shares in the share capital of the Company in addition to the existing ordinary shares in

the share capital of the Company, each share having a nominal value of USD 0.01 (one United States Cent) and approval
of their terms as well as any related matters such as the setting of the maximum number of ordinary shares and preference
shares under the authorised share capital;

(vii) conversion of 3,478,012,923 (three billion four hundred and seventy-eight million twelve thousand nine hundred

and twenty-three) existing shares of the Company into preference shares of the Company with a nominal value of USD
0.01 (one United States Cent) each;

(viii) subsequent amendment of articles 5, 7 and 17 of the Articles in order to reflect the share capital reduction

specified under item (v) above as well as the creation of the preference shares in the share capital of the Company as
specified under items (vi) and (vii) above, and in order to remove the possibility for the board of managers to issue shares
under the authorised share capital of the Company;

(ix) amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp; Overy Luxembourg to proceed, under his/

57959

L

U X E M B O U R G

her sole signature, on behalf of the Company with the registration of the repurchase and cancellation of the shares
specified under items (iv) and (v) above as well as the conversion of part of the ordinary shares of the Company into
preference shares in the share register of the Company; and

(x) miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions unanimously:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the Sole Shareholder represented considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend as from 1 November 2012 the financial year of the Company so that the financial year

of the Company shall begin on the 1 

st

 of January and shall close on the 31 

st

 of December of the same year.

The Meeting further resolves that as a result of the change of the financial year set out in this second resolution, the

financial year of the Company which shall start on 1 November 2012 shall close on 31 December 2012 and the following
financial year shall start on 1 January 2013.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 15 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so that it

shall henceforth read as follows:

« Art. 15. Financial year. As of 1 November 2012, the Company's financial year shall start on the 1 

st

 of January of each

year and shall end on the 31 

st

 of December of the same year. This is without prejudice to the financial year which started

on 1 August 2012 and which shall close on 31 October 2012 in accordance with the transitory provisions adopted by the
extraordinary general shareholders meeting of the Company held on 30 October 2012 as a result of the setting of the
Company's financial year to the period starting on 1 November of each year until 31 October of the following year."

<i>Fourth resolution

The Meeting notes the terms of article 5.7 of the Articles.
The Meeting acknowledges that the board of managers of the Company approved on 30 October 2012, subject to the

approval of the Sole Shareholder by way of a shareholder resolution, the repurchase of the Repurchased Shares, i.e.
5,299,670,518 (five billion two hundred and ninety-nine million six hundred and seventy thousand five hundred and eigh-
teen) shares in the share capital of the Company, each having a nominal value of USD 0.01 (one United States Cent), held
by the Sole Shareholder for the Repurchase Price corresponding to an aggregate amount of USD 604,345,813.93 (six
hundred and four million three hundred and forty-five eight hundred and thirteen United States Dollars ninety-three
Cents). The Meeting further acknowledges that a repurchase notice, in which are set out the terms and conditions of the
repurchase of the Repurchased Shares, effective as of the approval of the repurchase of the Repurchased Shares by the
Sole Shareholder by way of a shareholder resolution, has been signed by the Company and the Sole Shareholder.

The Sole Shareholder further acknowledges that, on the basis of the interim accounts dated 31 October 2012, the

Company has sufficient available distributable reserves (including share premium) and profits to proceed to the repurchase
of the Repurchased Shares for the Repurchase Price.

In the light of the foregoing, the Meeting therefore resolves (i) to approve the repurchase of the Repurchased Shares,

i.e. 5,299,670,518 (five billion two hundred and ninety-nine million six hundred and seventy thousand five hundred and
eighteen) shares of the Company held by the Sole Shareholder for the aggregate Repurchase Price, with immediate effect,
and (ii) that the part of the Repurchase Price that does not correspond to the amount of the share capital reduction
resulting from the cancellation of the Repurchased Shares (as per the fifth resolution below), i.e. USD 551,349,108.75
(five hundred and fifty-one million three hundred and forty-nine thousand one hundred and eight United States Dollars
seventy-five Cents), shall be financed by the share premium of the Company, in the amount of USD 551,349,108.75 (five
hundred and fifty-one million three hundred and forty-nine thousand one hundred and eight United States Dollars seventy-
five Cents) and shall be booked accordingly in the Company's accounts.

<i>Fifth resolution

The Meeting, pursuant to the repurchase of the Repurchased Shares under the fourth resolution above, resolves to

hereby cancel the Repurchased Shares that were repurchased under the fourth resolution above. Subsequently, the
subscribed capital is reduced by an amount of USD 52,996,705.18 (fifty-two million nine hundred and ninety-six thousand
seven  hundred  and  five  United  States  Dollars  and  eighteen  Cents)  and  is  brought  from  its  present  amount  of  USD
88,128,148.85 (eighty-eight million one hundred and twenty-eight thousand one hundred and forty-eight United States
Dollars and eighty-five Cents) to USD 35,131,443.67 (thirty-five million one hundred and thirty-one thousand four hun-
dred and forty-three United States Dollars sixty-seven Cents) represented by 3,513,144,367 (three billion five hundred

57960

L

U X E M B O U R G

and thirteen million one hundred and forty-four thousand three hundred and sixty-seven) shares having a nominal value
of USD 0.01 (one United States Cent) each.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to approve the creation of preference shares (the Preference Shares) of the Company, in addition

to the existing ordinary shares of the Company (the Ordinary Shares), with the terms of the Ordinary Shares and the
Preference Shares as set out in the seventh resolution below, each Preferred Share having a nominal value of USD 0.01
(one United States Cent).

The Meeting further resolves to convert 3,478,012,923 (three billion four hundred and seventy-eight million twelve

thousand nine hundred and twenty-three) of the existing Ordinary Shares into 3,478,012,923 (three billion four hundred
and seventy-eight million twelve thousand nine hundred and twenty-three) Preference Shares having a nominal value of
USD 0.01 (one United States Cent) each.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to remove the possibility for the board of managers of the Company to issue shares under the

authorised share capital of the Company and therefore to amend article 5 of the Articles in order to reflect such change
as well as the changes referred to under the fifth and sixth resolution above, so that it reads henceforth as follows:

Art. 5. Share capital.
5.1 The Company's subscribed share capital is fixed at USD 35,131,443.67 (thirty-five million one hundred and thirty-

one thousand four hundred and forty-three United States Dollars sixty-seven Cents), represented by 35,131,444 (thirty-
five million one hundred and thirty-one thousand four hundred and forty-four) ordinary shares having a nominal value of
USD 0.01 (one United States Cent) each (hereinafter referred to as an Ordinary Share and collectively as the Ordinary
Shares) and 3,478,012,923 (three billion four hundred and seventy-eight million twelve thousand nine hundred and twenty-
three) preference shares having a nominal value of USD 0.01 (one United States Cent) each (hereinafter referred to as
a Preference Share and collectively as the Preference Shares).

5.2. The Company shall have power to acquire shares, including Preference Shares, in its own capital provided that

the company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares, including Preference Shares, held by it in its own share capital

shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder
or the general meeting of the shareholders, as the case may be. The quorum and majority requirements applicable for
amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 14 of the articles of association."

The Meeting furthermore resolves to amend article 7 of the Articles in order to reflect the sixth resolution above, so

that it reads henceforth as follows:

« Art. 7. Profit sharing. The Ordinary Shares and the Preference Shares shall be entitled to distributions, whether by

way of dividend distribution, share redemption or otherwise, as set out in article 17 of these articles of association."

The Meeting furthermore resolves to amend article 17 of the Articles in order to reflect the sixth resolution above,

so that it reads henceforth as follows:

« Art. 17. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital.

Until 31 October 2012 (included), the remaining balance of the Company's distributable profits, may be distributed to

the shareholders of the Company, if declared by the general meeting of shareholder(s) of the Company, pro rata their
shareholding, regardless of share class.

As from 1 November 2012, the remaining balance of the Company's distributable profits, may be distributed to the

shareholders of the Company, if declared by the general meeting of shareholder(s) of the Company, in the following order
of priority:

(i) firstly, the holders of Preference Shares shall be entitled to receive with respect to each Financial Year a non-

cumulative aggregate amount equal to a maximum of USD 75,000 (seventy-five thousand United States Dollars) (the
Preferred Return), pro rata to the number of Preference Shares held by them; and

(ii) secondly, with respect to each Financial Year, after all holders of Preference Shares shall have received their portion

of the maximum amount of the Preferred Return referred to under articles 17 (i) above, the holders of Ordinary Shares
shall be entitled to receive all remaining amounts available for distribution pro rata to the number of Ordinary Shares
held by them.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends, in

accordance with the rules set out under items (i) and (ii) above.

57961

L

U X E M B O U R G

A dividend may not be declared by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders of the Company

unless the board of managers has made a recommendation as to its amount. Such a dividend must not exceed the amount
recommended by the board of managers."

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby

empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer and employee of Allen &amp; Overy Luxembourg to
proceed under his/her sole signature, on behalf of the Company, with the registration of the repurchase and cancellation
of the Repurchased Shares as well as the conversion of part of the Ordinary Shares into Preference Shares in the share
register of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of doubt, the
filing and publication of documents with the relevant Luxembourg authorities).

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, the said proxyholder signed together

with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le trente et unième jour du mois d'octobre, par devant Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Smiths Finance Luxembourg

S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 21, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, ayant un capital social de 88.128.148,85 USD et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142379 (la Société). La Société a été constituée le 9 octobre 2008 en vertu
d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C - N° 2672 du 3 novembre 208. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière
fois en date du 31 octobre 2012 en vertu d'un acte de Maître Francis Kesseler, précité, non encore publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C.

A comparu:

Smiths Group Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec un capital social

de 72.931.490 USD, ayant son siège social au 21, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142380 (l'Associé Unique),

ci-après représentée par Maître Robert Steinmetzer, Avocat à la Cour résidant professionnellement à Luxembourg,

au Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée sous seing privé.

Ladite procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l'Associé

Unique et par le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès
des autorités compétentes.

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:
I. Que les 8.812.814.885 (huit milliards huit cent douze millions huit cent quatorze mille huit cent quatre-vingt-cinq)

parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 USD (un Cent de Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune, repré-
sentant la totalité du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
(i) renonciation aux formalités de convocation;
(ii) modification de l'année sociale de la Société;
(iii) modification subséquente de l'article 15 des statuts de la Société (les Statuts) en vue de refléter la modification

sous le point (ii) ci-dessus;

(iv) approbation du rachat de 5.299.670.518 (cinq milliards deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions six cent soixante-

dix mille cinq cent dix-huit) parts sociales détenues par l'Associé Unique (les Parts Sociales Rachetées) pour un montant
total de 604.345.813,93 USD (six cent quatre millions trois cent quarante-cinq mille huit cent treize Dollars des Etats-
Unis d'Amérique et quatre-vingt-treize Cents) (le Prix de Rachat);

(v) réduction du capital social de la Société afin de ramener le capital social de son montant actuel de 88.128.148,85

USD (quatre-vingt-huit millions cent vingt-huit mille cent quarante-huit Dollars des Etats-Unis d'Amérique et quatre-vingt-
cinq Cents), représenté par 8.812.814.885 (huit milliards huit cent douze millions huit cent quatorze mille huit cent quatre-
vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 USD (un Cent de Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune,

57962

L

U X E M B O U R G

à un montant de 35.131.443,67 USD (trente-cinq millions cent trente-et-un mille quatre-cent quarante-trois Dollars des
Etats-Unis d'Amérique et soixante-sept Cents) représenté par 3.513.144.367 (trois milliards cinq cent treize millions cent
quarante-quatre mille trois cent soixante-sept) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 USD (un Cent de Dollar
des Etats-Unis d'Amérique) chacune via l'annulation de toutes les Parts Sociales Rachetées;

(vi) création de parts sociales préférentielles au sein de capital social de la Société en supplément des parts sociales

ordinaires au sein du capital social de la Société, chacune ayant une valeur nominale de 0,01 USD (un Cent de Dollar des
Etats-Unis d'Amérique) et approbation des dispositions auxquelles elles seront soumises et de toute matière qui y serait
liée, comme la détermination du nombre maximal de parts sociales ordinaires et de parts sociales préférentielles sous le
capital social autorisé;

(vii) conversion de 3.478.012.923 (trois milliards quatre cent soixante-dix-huit millions douze mille neuf cent vingt-

trois) parts sociales existantes de la Société en parts sociales préférentielles de la Société ayant une valeur nominale de
0,01 USD (un Cent de Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune;

(viii) modification subséquente des articles 5, 7 et 17 des Statuts afin de refléter la réduction de capital intervenue au

point (v) ci-dessus ainsi que la création de parts sociales préférentielles au sein du capital social de la Société spécifiée
aux points (vi) et (vii) ci-dessus, et également afin que le conseil de gérance n'ait plus la possibilité d'émettre des parts
sociales en vertu du capital social autorisé de la Société;

(ix) modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus, avec pouvoir et

autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy Luxembourg pour effectuer,
en vertu de sa seule signature et au nom de la Société, l'inscription du rachat et de l'annulation des parts sociales men-
tionnés aux points (iv) et (v) ci-dessus ainsi que la conversion d'une partie des parts sociales ordinaires de la Société en
parts sociales préférentielles dans le registre de parts sociales de la Société; et

(x) divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-

malités de convocation, l'Associé Unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'année sociale de la Société à compter du 1 

er

 novembre 2012, de sorte que l'année

sociale de la Société débutera le 1 

er

 janvier et prendra fin le 31 décembre de la même année.

L'Assemblée décide en outre qu'à la suite du changement d'année sociale intervenu dans la présente seconde résolu-

tion, l'année sociale de la Société qui commencera le 1 

er

 novembre 2012 prendra fin le 31 décembre 2012, et le prochain

exercice social débutera le 1 

er

 janvier 2013.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 15 des Statuts afin d'y refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte qu'il

aura la teneur suivante:

« Art. 15. Année sociale. A partir du 1 

er

 novembre 2012, l'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier de

chaque année et se termine le 31 décembre de la même année. Cela n'a aucune conséquence sur l'année sociale ayant
commencé le 1 

er

 août 2012 et prenant fin le 31 octobre 2012, conformément aux dispositions transitoires adoptées par

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue en date du 30 octobre 2012, au cours de laquelle
l'année sociale de la Société avait été fixée pour une période commençant le 1 

er

 novembre jusqu'au 31 octobre de l'année

suivante."

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée note les dispositions de l'article 5.7 des Statuts.
L'assemblée constate que le conseil de gérance de la Société a approuvé en date du 30 octobre 2012, sous réserve de

l'approbation de l'Associé Unique sous la forme d'une résolution d'associé, le rachat des Parts Sociales Rachetées, c'est-
à-dire 5.299.670.518 (cinq milliards deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions six cent soixante-dix mille cinq cent dix-huit)
parts sociales dans le capital social de la Société, chacune ayant une valeur nominale de 0,01 USD (un Cent de Dollar des
Etats-Unis d'Amérique) détenues par l'Associé Unique pour le Prix de Rachat correspondant à un montant total de
604.345.813,93  USD  (six  cent  quatre  millions  trois  cent  quarante-cinq  mille  huit  cent  treize  Dollars  des  Etats-Unis
d'Amérique et quatre-vingt-treize Cents). L'Assemblée constate en outre qu'une notice de rachat, dans laquelle figurent
les conditions générales régissant le rachat des Parts Sociales Rachetées, avec effet à compter de l'approbation du rachat
des Parts Sociales rachetées par l'Associé Unique en vertu d'une résolution d'associé, a été signée par la Société et
l'Associé Unique.

57963

L

U X E M B O U R G

L'Associé Unique note également que, sur la base des comptes intérimaires datés du 31 octobre 2012, la Société

dispose de réserves distribuables (y compris la prime d'émission) et des bénéfices suffisants pour procéder au rachat des
Parts Sociales Rachetées pour le Prix de Rachat.

Au vu de ce qui précède, l'Assemblée décide par conséquent (i) d'approuver le rachat des Parts Sociales Rachetées,

c'est-à-dire 5.299.670.518 (cinq milliards deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions six cent soixante-dix mille cinq cent
dix-huit) parts sociales de la Société détenues par l'Associé Unique pour le Prix de Rachat total, avec effet immédiat, et
(ii) que la partie du Prix de Rachat ne correspondant pas au montant de la réduction de capital à l'issue de l'annulation
des Parts Sociales Rachetées (en vertu de la cinquième résolution ci-dessous), c'est-à-dire 551.349.108,75 USD (cinq cent
cinquante et un millions trois cent quarante-neuf mille cent huit Dollars des Etats-Unis d'Amérique et soixante-quinze
Cents) sera financée par la prime d'émission de la Société, d'un montant de 551.349.108,75 USD (cinq cent cinquante et
un millions trois cent quarante-neuf mille cent huit Dollars des Etats-Unis d'Amérique et soixante-quinze Cents) et sera
comptabilisée à ce titre dans les comptes de la Société.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée, suite au rachat des Parts Sociales Rachetées en vertu de la quatrième résolution ci-dessus, décide par la

présente d'annuler les Parts Sociales Rachetées qui ont été rachetées en vertu de la quatrième résolution ci-dessus. Par
conséquent, le capital souscrit est réduit d'un montant de 52.996.705,18 USD (cinquante-deux millions neuf cent quatre-
vingt-seize mille sept cent cinq Dollars des Etats-Unis d'Amérique et dix-huit Cents) et est ramené de son montant actuel
de 88.128.148,85 USD (quatre-vingt-huit millions cent vingt-huit mille cent quarante-huit Dollars des Etats-Unis d'Amé-
rique et quatre-vingt-cinq Cents) à 35.131.443,67 USD (trente-cinq millions cent trente et un mille quatre-cent quarante-
trois Dollars des Etats-Unis d'Amérique et soixante-sept Cents) représenté par 3.513.144.367 (trois milliards cinq cent
treize millions cent quarante-quatre mille trois cent soixante-sept) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 USD
(un Cent de Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide d'approuver la création de parts sociales préférentielles (les Parts Préférentielles) de la Société

en plus des parts sociales ordinaires existantes de la Société (les Parts Ordinaires), les conditions générales applicables
aux Parts Ordinaires et aux Parts Préférentielles étant reprises dans la sixième résolution ci-dessous, et chaque Part
Préférentielle ayant une valeur nominale de 0,01 USD (un Cent de Dollar des Etats-Unis d'Amérique).

L'Assemblée décide en outre de convertir 3.478.012.923 (trois milliards quatre cent soixante-dix-huit millions douze

mille neuf cent vingt-trois) parts sociales existantes de la Société en parts sociales préférentielles de la Société ayant une
valeur nominale de 0,01 USD (un Cent de Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune.

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide de faire en sorte que le conseil de gérance n'ait plus la possibilité d'émettre des parts sociales en

vertu du capital social autorisé de la Société et, par conséquent, de modifier l'article 5 des Statuts afin d'y refléter ce
changement ainsi que les modifications découlant des cinquième et sixième résolutions ci-dessus, de telle sorte qu'il se
lira désormais comme suit:

« Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à un montant de 35.131.443,67 USD (trente-cinq millions cent trente

et  un  mille  quatre-cent  quarante-trois  Dollars  des  Etats-Unis  d'Amérique  et  soixante-sept  Cents)  représenté  par
35.131.444 (trente-cinq millions cent trente et un mille quatre cent quarante-quatre) parts sociales ordinaires ayant une
valeur nominale de 0,01 USD (un Cent de Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune (ci-après désignée comme étant
une Part Ordinaire et collectivement les Parts Ordinaires) et 3.478.012.923 (trois milliards quatre cent soixante-dix-huit
millions douze mille neuf cent vingt-trois) parts sociales préférentielles ayant une valeur nominale de 0,01 USD (un Cent
de Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune (ci-après désignée comme étant une Part Préférentielle et collectivement
les Parts Préférentielles).

5.2. La Société aura le pouvoir d'acquérir des parts sociales, y compris des Part Préférentielles, dans son propre capital

social, à condition toutefois qu'elle dispose des réserves distribuables et des fonds suffisants à cet effet.

L'acquisition et la cession de parts sociales de la Société, y inclus de Parts Préférentielles, détenues par la Société dans

son propre capital social, sera décidée par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, le
cas échéant, qui en fixera les conditions. Les exigences de quorum et de majorité applicables lors de la modification des
statuts s'appliqueront, conformément à l'article 14 des statuts."

L'Assemblée décide en outre de modifier l'article 7 des Statuts afin d'y refléter la sixième résolution ci-dessus, de sorte

qu'il aura désormais la teneur suivante:

« Art. 7. Distribution des bénéfices. Les Parts Ordinaires et les Parts Préférentielles donnent droit à des distributions,

que ce soit au moyen de la distribution de dividendes, du rachat de parts sociales ou de toute autre manière, tel que
stipulé à l'article 17 des présents statuts."

L'Assemblée décide en outre de modifier l'article 17 des Statuts afin d'y refléter la cinquième résolution ci-dessus, de

sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

57964

L

U X E M B O U R G

« Art. 17. Appropriation des bénéfices, Réserves. Les bénéfices bruts de la Société constatés dans les comptes annuels,

après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Un montant égal à cinq pour
cent (5%) du bénéfice net de la Société sera prélevé pour la constitution d'une réserve statutaire, jusqu'à ce que cette
dernière atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal.

Jusqu'au 31 octobre 2012 (inclus), le solde restant des bénéfices distribuables de la Société pourra être distribué aux

associés de la Société s'il a été déclaré par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés de la Société, propor-
tionnellement à sa/leur participation, quelle que soit la classe de parts sociales détenues.

A compter du 1 

er

 novembre 2012, le solde restant des bénéfices distribuables de la Société pourra être distribué aux

associés de la Société s'il a été déclaré par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés de la Société, selon l'ordre
de priorité suivant:

(i) premièrement, les détenteurs de Parts Préférentielles pourront recevoir pour chaque Année Sociale un montant

total non-cumulable équivalant à un maximum de 75.000 USD (soixante-quinze mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique)
(le Revenu Préférentiel), proportionnel au nombre de Parts Préférentielles qu'ils détiennent; et

(ii) deuxièmement, pour chaque Année Sociale, après que tous les détenteurs de Parts Préférentielles auront reçu leur

part du montant maximum de Revenu Préférentiel mentionné à l'article 17 (i) ci-dessus, les détenteurs de Parts Ordinaires
pourront recevoir tous les montants restants disponibles à la distribution, proportionnellement au nombre de Parts
Ordinaires qu'ils détiennent.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra décider de verser des dividendes intérimaires,

conformément aux règles décrites aux points (i) et (ii) ci-dessus.

Un dividende pourra ne pas être déclaré par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés de la Société si le

conseil de gérance n'a pas recommandé de montant. Un tel dividende ne doit pas être supérieur au montant déclaré par
le conseil de gérance."

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus

et accorde pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy Luxembourg
afin de procéder sous sa seule signature, pour le compte de la Société, à l'inscription du rachat et de l'annulation des Parts
Sociales Rachetées ainsi que la conversion d'une partie des Parts Ordinaires de la Société en Parts Préférentielles dans
le registre de parts sociales de la Société, et afin de procéder à toutes les formalités y relatives (y inclus, afin d'éviter tout
doute, l'enregistrement et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

<i>Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou

pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à mille cinq cents
euros (EUR 1.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française; à la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé en date des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: Steinmetzer, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 8 novembre 2012. Relation: EAC/2012/14731. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013040259/379.
(130048802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2013.

TUI Travel Card Processing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 176.146.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the sixth day of March.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch sur Alzette.

There appeared the following:

57965

L

U X E M B O U R G

TUI  Travel  Holdings  Limited,  an  English  law  governed  company  having  its  registered  office  at  TUI  Travel  House,

Crawley Business Quarter, Fleming Way, Crawley, West Sussex RH10 9QL, registered at the Register the Companies
House under number 6638818,

represented by Me Cécile JAGER, attorney-at-law, residing in Howald, Luxembourg, by virtue of a Power of Attorney

given in 26 February 2013.

Which Power of Attorney shall be signed "ne varietur" by the person representing the above named person and the

undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to incorporate by the present deed

a "société à responsabilité limitée" and to draw up the articles of association of it as follows:

Title I. - Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a "société à responsabilité limitée" which will be governed by the laws in effect and

especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on
limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as well as by
the present articles of association.

Art. 2. The denomination of the company is "TUI Travel Card Processing S. à r.l.".

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lu-

xembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio. The company may participate in the establishment
and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan,
guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The company may borrow in any form and proceed to
the issuance of bonds.

The company may also act as treasury platform with the TUI Travel PLC group of companies.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose
PROVIDED ALWAYS that the company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.

Art. 5. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants do

not trigger the dissolution of the company.

Title II. - Capital - Parts

Art. 7. The corporate capital of the company is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 12,500.-)

divided into TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) parts having a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each.

The issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.
The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the company as issue
premiums on the issue and sale of its parts, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers to
provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfers of parts inter

vivos to non-participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of parts, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August

10, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration

57966

L

U X E M B O U R G

In order to exercise their rights the participant in question as well as its heirs and representatives or entitled persons

and creditors of the participant have to refer to the financial statements and, if there is more than one participant, to the
decisions of the general meetings.

Title III. - Management

Art. 10. The Company is administered by a board of managers composed of at least four managers, comprised of: (i)

managers professionally resident in Luxembourg (Class A Managers) and (ii) other managers (Class B Managers). The
Board must always be composed so that a majority or at least half of the managers are professionally resident in Luxem-
bourg. The managers are not necessarily shareholders and are appointed by the general meeting of shareholders which
may at any time remove them.

The number of managers, their term and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case may be,

by the general meeting of the participants.

The office of a manager shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law to be a manager or he becomes prohibited or disqualified by law from

being a manager,

- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the

participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

Art. 11. The board of managers may elect from among its members a chairman.
The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It

must be convened each time two managers so request.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
The board of managers shall validly resolve on any matters if a majority of its members are present or represented.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device)
to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

Art. 12. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object of the company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the sole participant or, as the

case may be, to the general meeting of participants, fall within the competence of the board of managers.

Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of one A jointly with one B manager

unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies
given by the board of managers pursuant to article 14 of the present articles of association.

Art. 14. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or

more persons, who need not be selected from its own members. If selected from its own members, he will be called
General Manager. If not, he will be called managing director.

It may also commit the management of a special branch to one or more directors, and give special powers for deter-

mined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether participants or not.

Art. 15. Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

company by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.

Title IV. - General meeting of participants

Art. 16. If there is only one participant, the sole participant shall exercise at general meetings duly held in Luxembourg

all the powers vested in the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by

the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

57967

L

U X E M B O U R G

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting duly held in
Luxembourg, or in case such a general meeting cannot be held for any reason, by written consultation at the initiative of
the management. A participant shall be entitled to cast one vote for each ONE EURO (EUR 1.-) in share capital (parts)
possessed or represented by such participant, and no decision shall be deemed to be validly taken unless it has been
adopted by the participants possessing or representing more than fifty per cent (50%) of the present or represented share
capital (parts) of the company.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V. - Financial year - Profits - Reserves

Art. 17. The financial year of the company starts on the 1 

st

 of October and ends on the 30 

th

 of September of each

year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of formation of the company and shall
terminate on September 30 

th

 , 2013.

Art. 18.
A) Financial statements and Annual dividend
Each year on the last day of November an inventory of the assets and the liabilities of the company together with a

balance sheet and a profit and loss account will be set up.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions constitute

the net profit.

Five  per  cent  (5%)  out  of  this  net  profit  shall  be  appropriated  for  the  legal  reserve;  this  deduction  ceases  to  be

compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.
B) Interim dividends
The board of managers is authorized to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during

the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the board of
managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up no later
than 30 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that
sufficiently distributable profits exist.

Title VI. - Liquidation - Dissolution

Art. 19. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need

not be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants at the majority
defined by Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

Title VII. - Varia

Art. 20. The parties refer to the Law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto for

all matters not provided for in the present articles of association.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the appearing party, declares to subscribe the whole capital

as follows:

TUI Travel Holdings Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500

parts

The TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) parts have been fully paid up to the amount of ONE EURO

(EUR 1.-) per part by a contribution in cash of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 12,500.-).

As a result the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 12,500.-) is as of now at the disposal

of the company.

<i>Costs and Valuation

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand five hundred euro
(EUR 1,500.-).

<i>Extraordinary general meeting

After the articles of association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to

hold  an  extraordinary  general  meeting.  Having  first  verified  that  it  was  regularly  constituted,  it  passed  the  following
resolutions:

57968

L

U X E M B O U R G

1. The registered office of the company is fixed at 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-

bourg

2. The number of managers (gérants) of the company is fixed at four (4).
3. Are appointed as managers (gérants) of the company for an unlimited period:

<i>a. as Class A Manager:

- Mr Gianluca NINNO, born in Policoro, Italy, on 07 April 1975, residing professionally at 44, rue de la Vallée, L-2661

Luxembourg;

- Mr Jean-Bastien PASQUINI, born in Sarlat-La-Canéda, France, on 25 July 1965, professionally residing at 4 Montée

des Tilleuls, L-2621 Luxembourg;

<i>b. as Class B Managers:

- Mr Michael BOWERS, born in Dersingham (UK) on October 19, 1967, professionally residing at TUI Travel PLC,

TUI Travel House, Crawley Business Quarter, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9QL, UK and

- Mr Simon RUSHFORTH, born in Hitchin (UK) on November 14, 1978, professionally residing at TUI Travel PLC,

TUI Travel House, Crawley Business Quarter, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9QL, UK.

The managers are appointed for an unlimited period of time, unless they previously resign or are revoked.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Follows the french version

L'an deux mille treize, le sixième jour de mars,
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch sur Alzette, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu

TUI Travel Holdings Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Royaume-Uni, enregistrée

au Registre de Commerce et des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 6638818 et ayant son siège social au, TUI
Travel House, Crawley Business Quarter, Fleming Way, Crawley, West Sussex RH10 9QL, Royaume-Uni,

représentée par Me Cécile JAGER, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Howald, Luxembourg, en vertu

d'une procuration lui conférée sous seing privé;

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire

instrumentaire, restera annexée au présent acte, aux fins d'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts suivants

d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare former:

Titre I 

er

 . - Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les
Sociétés»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. La dénomination de la société est «TUI Travel Card Processing S.à r.l.»

Art. 3. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité

normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert

provisoire de siège social, restera de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger
sera prise par l'Associé Unique ou le Conseil de gérance, le cas échéant.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

57969

L

U X E M B O U R G

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

La société pourra aussi agir en tant que plateforme financière pour le groupe de Sociétés de TUI Travel PLC.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet
SOUS RESERVE que la Société n'entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du
secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l'autorisation
requise par celle-ci.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'incapacité, la faillite ou l'insolvabilité d'un associé ne mettent pas fin à la Société.

Titre II. - Capital parts sociales

Art. 7. Le capital social de la société est fixé DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) divisé en DOUZE

MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Le capital émis de la société pourra être augmenté ou diminué en conformité avec les dispositions légales luxembour-

geoises.

Les fonds reçus au titre de la prime d'émission des Parts perçus sur l'émission de ces Parts (si applicable) sont affectés

à une réserve spéciale pour les primes, sauf pour ceux qui sont affectés au fonds de réserve légale. La réserve spéciale
pour les primes est à la libre disposition des associés et du conseil de gérance, selon les cas.

Art. 8. Les Parts sont librement cessibles par l'associé unique, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.
S'il y a plus d'un associé, les Parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de Parts entre vifs à des

tiers non-associés ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telles que modifiées.

Art. 9. Un associé aussi bien que ses héritiers et ses représentants ou ayant-droits et créanciers d'un associé ne peuvent

pas, quelles que soient les circonstances, demander l'apposition de scellées sur les biens ou les documents de la Société,
ni même s'impliquer de quelque façon que ce soit dans l'administration de la société.

Afin d'exercer leurs droits, ils doivent se rapporter aux états financiers et aux décisions de l'assemblée générale.

Titre III. - Gérance

Art. 10. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'un minimum quatre gérants, dont: (i) gérants résidant

professionnellement au Luxembourg ( «Gérants de Catégorie A») et (ii) autres gérants («Gérants de Catégorie B»). Le
conseil de gérance doit toujours être composé de sorte que la majorité ou en tout la cas la moitié des gérants demeurent
professionnellement au Luxembourg. Les gérants ne sont pas nécessairement associés et sont nommés par l'assemblée
générale des associés, qui peut a tout moment les révoquer.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'associé unique ou, selon les cas,

par l'assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d'être gérant par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste de

gérant, ou

- il tombe en faillite ou fait un arrangement ou une composition avec ses créanciers en général, ou
- il est révoqué par une résolution de l'associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l'assemblée générale des

associés.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

Art. 11. Le Conseil de gérance peut choisir un président parmi ses membres.
Le Conseil de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.

Toutes les réunions du Conseil de gérance se tiendront à Luxembourg.
Le Conseil de gérance ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les résolutions signées par tous les membres du Conseil de gérance ont la même valeur juridique que celles prises

lors d'une réunion du Conseil de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document

57970

L

U X E M B O U R G

unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen
de communication.

En outre, tout membre du Conseil de gérance prenant part aux délibérations dudit Conseil par tout moyen de com-

munication  (notamment  par  téléphone)  permettant  à  tous  les  autres  membres  du  Conseil  de  gérance  présents  (en
personne, en vertu d'une procuration, par voie téléphonique ou autre) d'entendre et d'être entendus à tout moment par
les autres membres, sera réputé être présent audit Conseil aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur
l'ordre du jour du Conseil.

Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée comme prise à Luxembourg si l'appel téléphonique

est initié depuis le Luxembourg.

Art. 12. Le Conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et

de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'associé unique ou,

selon les cas, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du conseil de gérance.

Art. 13. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie

A et de un gérant de catégorie B, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation
de pouvoirs n'aient été prises par le conseil de gérance conformément à l'article 14 des présents statuts.

Art. 14. Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui ne

doivent pas nécessairement être membres du conseil de gérance.

Il peut aussi confier la gestion d'une branche spéciale à une ou plusieurs personnes autres que des gérants, et donner

des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas
nécessairement être membres du conseil de gérance ni associés

Art. 15. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités

au nom de la société par le conseil de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.

Titre IV. - Assemblée générale d'associés

Art. 16. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section

XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique ou, selon les cas, par

l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale ou par consultation écrite à

l'initiative de la gérance. Un associé à droit à un vote pour chaque UN EURO (EUR 1,-) dans le capital (parts sociales)
détenues ou représentés para chacun des associés et aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été
adoptée par des associés représentant la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V. - Année comptable - Profits - Réserves

Art. 17. L'année sociale commence le premier jour de octobre et finit le dernier jour de septembre de chaque année,

sauf en ce qui concerne le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s'achèvera le 30
septembre 2013.

Art. 18.
A) Comptes annuels et Dividendes intérimaires Annuels
Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan

et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième (10%) du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon les cas.
B) Dividendes intérimaires
Le conseil de gérance est autorisé à procéder, autant de fois qu'il le juge opportun et à tout moment de l'année sociale,

au paiement de dividendes intérimaires, uniquement sous le respect des deux conditions suivantes: le conseil de gérance
ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur base des comptes intérimaires préparés au
plus tard trente (30) jours avant la date dudit conseil de gérance; les comptes intérimaires, qui pourront ne pas avoir été
audités, doivent attester qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.

57971

L

U X E M B O U R G

Titre VI. - Liquidation - Dissolution

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 20. Les parties se rapportent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, pour tout

ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

TUI Travel Holdings Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500

Parts

Les 12,500 (DOUZE MILLE CINQ CENTS CINQUANTE) Parts ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant

d'UN Euro (EUR 1,-) par part par un apport en numéraire de DOUZE MILLE CINQ CENTS CINQUANTE EUROS (EUR
12.500,-).

Le montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS CINQUANTE EUROS (EUR 12.500,-) est par conséquent à la disposition

de la société à partir de ce moment.

<i>Evaluation et Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l'associé unique prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale

extraordinaire. Après avoir vérifié qu'elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à quatre (4).
3. Ont été élus gérants de la société:
- Mr. Gianluca NINNO, né à Policoro, Italie le 7 avril 1975, demeurant professionnellement au 44, rue de la Vallée,

L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Mr. Jean-Bastien PASQUINI, né à Sarlat-la-Canéda, France, le 25 juillet 1965, demeurant professionnellement au 4

Montée des Tilleuls, L-2621 Luxembourg;

- Mr. Michael BOWERS, né à Dersingham, Royaume-Uni, le 19 Octobre 1967, demeurant professionnellement au TUI

Travel PLC, TUI Travel House, Crawley Business Quarter, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9QL, Royaume-
Uni;

- Mr. Simon RUSHFORTH, né à Hitchin, Royaume-Uni, le 14 novembre 1978, demeurant professionnellement au TUI

Travel PLC, TUI Travel House, Crawley Business Quarter, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9QL, Royaume-
Uni.

Les gérants sont nommés pour une période indéterminée à moins qu'ils n'aient préalablement démissionné ou qu'ils

n'aient été révoqués.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la mandataire de la partie comparante, es qualités qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par

nom, prénom, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la partie comparante, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de la même comparante
il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: Jager, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 mars 2013. Relation: EAC/2013/3351. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013040322/383.
(130049387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2013.

57972

L

U X E M B O U R G

Amber Agro and Food Industries Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 176.163.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twelfth of March.
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

APPEARED:

1. FT Capital GmbH, a private limited liability company established under the laws of Germany, registered at Amts-

gericht Köln under the commercial register number HRB 64612, with registered address at Dürener Str. 295, 50935
Köln, Germany,

2. Projekt A2 SA, a public company limited by shares (Société Anonyme) having its registered seat at 34A, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 139.121 and,

3. DI-Advisor GmbH, a private limited liability company established under the laws of Germany, registered at Amts-

gericht Dortmund under the commercial register number HRB 25276, with registered address at Amsterdamer Weg 76,
44269 Dortmund, Germany.

The appearing parties are here represented by Mr. François GEORGES, professionally residing at L-1330 Luxembourg,

34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, represented by virtue of three proxies given under private seal; such proxies,
after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present deed in
order to be recorded with it.

Such appearing persons, represented as stated above, have required the officiating notary to enact the articles of

association of a private limited liability company (“Gesellschaft mit beschränkter Haftung”), which they deem to incor-
porate, as follows:

A. Name - Social Object - Duration - Registered Seat

Art. 1. There is hereby formed a private limited liability company (“Gesellschaft mit beschrànkter Haftung”) under the

name of “AMBER AGRO AND FOOD INDUSTRIES MANAGEMENT S.àr.l.” (“the Company”), which will be governed
by the present articles of association (“the Articles”) as well as by the respective laws and particularly by the modified
law of 10 August 1915 on commercial companies (the “Law of 1915”).

Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in the agricultural and food

industries in the Russian Federation, in any form whatsoever and/or the management of such participations in the agri-
cultural and food industries in the Russian Federation, interests and units. The Company may in particular acquire by
subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct or
indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any
affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the “Connected Companies”). It
may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or
over some of its assets

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual

property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments

in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, leasing, renting, dividing, re-
claiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise
encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The duration of the Company is unlimited.

57973

L

U X E M B O U R G

Art. 4. The Company's registered office is established in the municipality of Luxembourg, (Grand Duchy of Luxem-

bourg).

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or the board

of managers.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective

decision of the members deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as abroad by a simple decision of the board of managers.

B. Corporate Capital - Corporate Units

Art. 5. The Company's capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) corporate units with a par value of one Euro (1.- EUR) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the Law of 1915.

Art. 6. The Company will recognize only one member per share.
The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 7. The Company's corporate units are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be trans-

ferred to new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the corporate units of the deceased member may only be transferred to new members subject

to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the
remaining share capital. Such approval is, however, not required in case the corporate units are transferred either to
parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 8. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 9. The creditors, the assignees and the heirs of the members may not for whatever reason affix seals to the

property and the documents of the Company nor may they interfere in any manner in the management of the Company.
They have to refer to the Company's inventories.

C. Management

Art. 10. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be members.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. In the case

of several managers, the Company may be managed by a board of managers which may be made up of Managers “A” and
Managers “B”.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Should the Board of Managers be made of Manager(s) “A” and Manager(s) “B”, the Company shall be validly bound in

any circumstances without restrictions and in front of third parties by the individual signature of any manager A; the
Company shall also validly bound in matters limited to the daily management of the Company by the individual signature
of manager B provided that the matter has been communicated to managers A and that at least one manager A has
approved the matter via a simple communication done in any way whatsoever, such as by an email confirming for manager
B to proceed with the matter.

The Company may be bound towards third parties by the sole signature of any Manager or by the joint signatures or

single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers, but only
within the limits of such power.

The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason.

Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,

57974

L

U X E M B O U R G

by cable, telegram or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram or facsimile

another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or

by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board
of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire set of
such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers.

In the case of a sole manager all resolutions shall be taken in written minutes signed by the sole manager.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 14. The manager(s) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the Sole Member - Collective Decisions of the Members

Art. 15. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of corporate units which

he owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents corporate units.

Art. 16. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by members owning more than half of

the share capital.

The amendment of these Articles requires the approval of a majority of members representing at least three quarters

of the share capital.

Art. 17. The sole member exercises the powers granted to the general meeting of members under the provisions of

section XII of the Law of 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 18. The Company's accounting year begins on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December of each year.

Art. 19. Each year, with reference to December 31, the Company's accounts are established and the Managers prepare

an annual account in the form of a financial statement including profits and losses.

Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortizations,

expenses and other burdens is allocated as follows:

- five percent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital;

- the remaining amount is at the disposal of the members.

Art. 20. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these Articles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 21. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which

do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of
the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

members proportionally to the corporate units of the Company held by them.

57975

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Any litigation which will occur during the liquidation of the Company, either between the members themselves

or between the manager(s) and the Company, will be settled insofar as the Company's business is concerned by arbitration
in compliance with the civil procedure.

Art. 23. For all points not regulated by these bylaws, reference is made to the provisions of the modified Law of 1915

on commercial companies.

<i>Subscription and Payment of the Corporate Units

The Articles having thus been established, the corporate units have been subscribed as follows:
- one thousand two hundred fifty (1,250) corporate units have been subscribed by FT Capital GmbH, predesignated

and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of one thousand two hundred fifty
Euros (1,250.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the
undersigned notary, who expressly attests thereto.

- five thousand (5,000) corporate units have been subscribed by Projekt A2 SA, predesignated and fully paid up by the

aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of five thousand Euros (5,000,- EUR) is from this day on at
the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests
thereto.

- six thousand two hundred and fifty (6,250) corporate units have been subscribed by DI-Advisor GmbH, predesignated

and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of six thousand two hundred and
fifty Euros (6,250.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the
undersigned notary, who expressly attests thereto.

<i>Transitory Disposition

The first accounting year starts at the present day and ends on the 31 

st

 December 2013.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.

<i>Extraordinary General Meeting

The aforementioned appearing persons, representing the totality of the subscribed capital and considering themselves

as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions
by unanimity:

1. The registered office of the Company is established at 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Lu-

xembourg.

2. Ms. Galya KORSAK, born at the Republic of Belarus on the 17 

th

 August, 1985, professionally residing at Russian

Federation, City of Kaliningrad, Pobieda Square 10, office 419 is appointed as a manager A for an undetermined period.

3. Mr. Francois GEORGES, born in Luxembourg on the 20 

th

 March, 1967, professionally residing at 34A, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg is appointed as a manager B for an undetermined period.

4. The Company is validly bound in any circumstances without restrictions and in front of third parties by the individual

signature of any manager A; the Company is also validly bound in matters limited to the daily management of the Company
by the individual signature of manager B provided that the matter has been communicated to managers A and that at least
one manager A has approved the matter via a simple communication done in any way whatsoever, such as by an email
confirming for manager B to proceed with the matter.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing parties, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxemburg, on the day stated at the beginning.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary,

by surname, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us, the notary, the present original
deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, den zwölften März.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

57976

L

U X E M B O U R G

1. FT Capital GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet nach dem Recht von Deutschland, einge-

tragen im Amtsgericht Köln, unter der Handelsregisternummer HRB 64612, mit Sitz in Dürener Str. 295, 50935 Köln,
Deutschland und,

2. Projekt A2 SA, eine öffentliche Aktiengesellschaft (Société Anonyme), mit Sitz in 34A, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1330 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, unter der Nummer B 139.121
und,

3. DI-Advisor GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet nach dem Recht von Deutschland, ein-

getragen im Amtsgericht Dortmund, unter der Handelsregisternummer HRB 25276, mit Sitz in Amsterdamer Weg 76,
44269 Dortmund, Deutschland.

Die erschienenen Parteien sind rechtmäßig vertreten durch Herrn François GEORGES, beruflich wohnhaft in L-1330

Luxemburg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, auf Grund drei ihm erteilten privatschriftlichen Vollmachten;
welche Vollmachten, vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterschrieben, bleiben der ge-
genwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche erschienenen Parteien, vertreten wie hiervor erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Statuten

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit zu gründen beabsichtigen, zu beurkunden wie folgt:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „AMBER AGRO AND FOOD

INDUSTRIES MANAGEMENT S.à r.l.“ („die Gesellschaft“) gegründet, welche durch gegenwärtige Satzungen („die Sta-
tuten“), sowie durch die anwendbaren Gesetze und besonders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915“) geregelt wird.

Art. 2. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb von Beteiligungen, Anteilen und Einheiten, in der Agrar- und

Ernährungswirtschaft in der Russischen Föderation, in welcher Form und / oder die Verwaltung solcher Beteiligungen in
den Agrar- und Ernährungswirtschaft in der Russischen Föderation, Anteilen und Einheiten. Die Gesellschaft kann insbe-
sondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise jede Aktienkapital, Aktien und andere Beteiligungspa-
piere, Anleihen, Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate und andere Schuldtitel und generell jegliche Wertpapiere und
Finanzinstrumente erwerben die von einem öffentlichen oder private Unternehmen ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann in jeder Form ausleihen, außer im Wege eines öffentlichen Angebots. Es kann im Wege der

Privatplatzierung, Schuldscheine, Anleihen und Schuldverschreibungen und jede Art von Schuldverschreibungen und /
oder Aktien erteilen. Die Gesellschaft kann Fonds einschließlich der Erlöse aus Krediten und / oder die Ausgabe von
Schuldverschreibungen an Tochtergesellschaften oder Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung
hat, auch wenn es nicht erheblich ist, oder jedes Unternehmen, die ein direkter oder indirekter Aktionär der Gesellschaft
ist oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen der gleichen Gruppe wie die Gesellschaft (im Folgenden als die „verbun-
dene Unternehmen“ genannt) verleihen. Es kann auch Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten Dritter auf deren
Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu sichern. Die Gesellschaft kann außerdem
Verpfändung, Sicherungsübereignung belasten oder Sicherheit über alle oder über einen Teil seines Vermögens erschaffen.

Die Gesellschaft kann außerdem in der Akquisition und das Management eines Portfolios von Patenten und / oder

andere Rechte an geistigem Eigentum aller Art oder Herkunft investieren.

Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Techniken und Instrumente in Bezug auf ihre Investitionen zum Zweck der

effizienten  Verwaltung,  einschließlich  der  Techniken  und  Instrumente  entwickelt,  um  die  Gesellschaft  gegen  Kredit-,
Währungs-, Zins-und sonstige Risiken zu schützen.

Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und / oder finanzielle Transaktionen mit Bezug auf direkte oder indirekte

Investitionen in bewegliches und unbewegliches Vermögen einschließlich aber nicht begrenzt auf den Erwerb, Eigentum,
Anmietung, Verpachtung, Vermietung, Teilung, Rückforderung, Entwicklung, Verbesserung, Anbau, Bau, Verkauf oder
sonstige Veräußerung, hypothekarische Belastung, Verpfändung oder anderweitig beweglichen oder unbeweglichen Ver-
mögens belasten.

Die obige Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung ist nicht ausschließlich.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann Innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder

des Geschäftsführerrates verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen,

die für eine Änderungen der Statuten maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen, Büros oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großher-

zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

57977

L

U X E M B O U R G

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in zwölftausendfünf-

hundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR).

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesetzes von

1915 festgelegt ist.

Art. 6. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an.
Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 7. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des restlichen

Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendenten, Deszendenten
oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 8. Der Tod, der Verlust der Bürgerrechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters wird

nicht die Auflösung der Gesellschaft herbeiführen.

Art. 9. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Dokumente

der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungshandlungen
einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

C. Geschäftsführung

Art. 10. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen.
Der/Die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt, die die Dauer seines/ihres Mandates fest-

legt. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat verwaltet welche sich
aus Managern „A“ und Managern „B“ gebildet werden kann.

Vollmachten werden durch den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Sollte das Geschäftsführerrat mit Manager(n) „A“ und Manager(n) „B“ gebildet sein, wird die Gesellschaft rechtmässig

in allen Umständen und ohne Einschränkungen und vor Dritten durch die Unterschrift eines Geschäftsführers A rechts-
gültig gebunden sein; die Gesellschaft wird rechtmässig in Angelegenheiten beschränkt auf die tägliche Verwaltung der
Gesellschaft durch die Unterschrift eines Geschäftsführers B rechtsgültig gebunden sein, vorausgesetzt, dass die Angele-
genheit an einem Manager A kommuniziert wurde und dass mindestens ein Manager A die Sache über eine einfache
Kommunikation in irgendeiner Weise, zum Beispiel durch eine E-Mail-Bestätigung zum Manager B um mit der Sache
vorzugehen genehmigt.

Dritten gegenüber wird die Gesellschaft verpflichtet durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers oder durch

die  gemeinschaftliche  oder  alleinige  Unterschrift  jeglicher  Personen,  denen  vom  Geschäftsführerrat  eine  besondere
Zeichnungsvollmacht übertragen wurde, aber nur im Rahmen dieser besonderen Zeichnungsvollmacht.

Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Art. 11. Der Geschäftsführerrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch

einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates
sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen verantwortlich.

Gegenüber Dritten ist der Geschäftsführer, bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer,

unter allen Umständen unbeschränkt befugt im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesellschaftszweck
im Einklang stehende Geschäfte und Handlungen zu genehmigen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied
zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm oder Telefax oder durch
ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann auf die
Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des
Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

57978

L

U X E M B O U R G

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates vertreten
lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der je-
weiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden,
unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als
Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 12. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers, werden sämtliche Beschlüsse schriftlich in einem Protokoll festgehalten und

vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 13. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund

auch immer, aufgelöst.

Art. 14. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 16. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Statuten benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens

drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 17. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes von 1915 zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 19. Jedes Jahr, am 31. Dezember, werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jah-

resabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen, Rückstellungen und sonstigen Lasten verbleibende Nettogewinn wird

wie folgt verteilt:

- fünf Prozent (5%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen,

bis diese 10% des gezeichneten Kapitals erreicht;

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 20. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines

von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur
Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letztes Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Statuten vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

57979

L

U X E M B O U R G

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 22. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern

selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

Art. 23. Für alle Punkte, die nicht in den Statuten festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes

von 1915 über die Handelsgesellschaften, verwiesen.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Nach Feststellung der Statuten, erklären die Komparenten, dass die Anteile wie folgt gezeichnet wurden:
- tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile, sind durch FT Capital GmbH, vorgenannt, gezeichnet und voll in bar

eingezahlt worden, so dass der Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euros (1.250,- EUR) der Gesellschaft ab sofort
zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

- fünftausend (5.000) Anteile, sind durch Projekt A2 SA, vorgenannt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt worden, so

dass der Betrag von fünftausend Euros (5.000,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden
Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

- sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteile, sind durch DI-Advisor GmbH, vorgenannt, gezeichnet und voll in

bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von sechstausendzweihundertfünfzig Euros (6.250,- EUR) der Gesellschaft ab
sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2013.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, wird auf ungefähr eintausend Euro abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer au-

ßerordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft wird auf 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, festgelegt.
2. Frau Galya KORSAK, geboren in der Belarus Republik am 17. August 1985, beruflich wohnhaft in der Russischen

Föderation, Stadt von Kalingrad, Pobieda Square 10, Büro 419, wird als Manager A auf unbestimmte Dauer ernannt.

3.  Herr  François  GEORGES,  geboren  in  Luxembourg  (Großherzogtum  Luxemburg)  am  20.  März  1967,  beruflich

wohnhaft in 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, wird als Manager B auf unbestimmte Dauer
ernannt.

4. Die Gesellschaft wird rechtmässig in allen Umständen und ohne Einschränkungen und vor Dritten durch die Un-

terschrift eines Geschäftsführers A rechtsgültig gebunden sein; die Gesellschaft wird rechtmässig in Angelegenheiten
beschränkt  auf  die  tägliche  Verwaltung  der  Gesellschaft  durch  die  Unterschrift  eines  Geschäftsführers  B  rechtsgültig
gebunden sein, vorausgesetzt, dass die Angelegenheit an einem Manager A kommuniziert wurde und dass mindestens ein
Manager A die Sache über eine einfache Kommunikation in irgendeiner Weise, zum Beispiel durch eine E-Mail-Bestätigung
zum Manager B um mit der Sache vorzugehen genehmigt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der

erschienenen Parteien, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Parteien, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird
die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, namens

handelnd  wie  hiervor  erwähnt,  dem  instrumentierenden  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen,  Stand  und
Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: F. GEORGES, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 14 mars 2013. LAC/2013/11802. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

57980

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 21 mars 2013.

Référence de publication: 2013040387/431.
(130049653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

ATRINITY S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF", Société Anonyme - Société de Gestion

de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 76.289.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille treize.
Le huit février.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ATRINITY S.A., société de gestion de

patrimoine familial, "SPF", avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 76.289,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 05 juin 2000, publié au Mémorial C

numéro 738 du 09 octobre 2000,

dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30

décembre 2011 publié au Mémorial C numéro 594 du 07 mars 2012.

La société a été mise en liquidation aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 décembre

2012, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée

privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse

professionnelle à Esch/Alzette.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse

professionnelle à Esch/Alzette.

Madame la Présidente expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les DIX-HUIT

MILLE (18.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital de TROIS MILLIONS
D'EUROS (€ 3.000.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit,
sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après
avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps

aux formalités de l'enregistrement.

2. Que l'assemblée générale extraordinaire du 05 février 2013, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé

commissaire à la liquidation:

La société EURAUDIT S. à r.l., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 42.889 et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.

3. Madame la présidente expose que l'ordre du jour est le suivant:
1) Rapport du Commissaire-vérificateur,
2) Décharge aux liquidateur et Commissaire à la liquidation,
3) Clôture de la liquidation,
4) Désignation de l'endroit où seront déposés les livres et documents sociaux.
5) Divers
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>I. Rapport du commissaire à la liquidation

L'assemblée prend connaissance du rapport du commissaire-vérificateur.
Lecture est donnée du rapport du commissaire-vérificateur.
Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et restera annexé aux présentes.

<i>II. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction à la société FIDESCO S.A., établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16,

57981

L

U X E M B O U R G

Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 68.578, de sa gestion
de liquidateur de la société ainsi qu'au commissaire à la liquidation, la société EURAUDIT S. à r.l., préqualifiée.

<i>III. Clôture de liquidation

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme ATRINITY S.A., société de gestion

de patrimoine familial, "SPF", ayant son siège social à Luxembourg, a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période

de cinq (5) ans à l'adresse du siège de la société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 février 2013. Relation: EAC/2013/2238. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2013040393/69.
(130049892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

Castel Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3739 Rumelange, 32, rue des Martyrs.

R.C.S. Luxembourg B 87.618.

L'an deux mille treize, le quatre mars.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "CASTEL INVEST S.A.", établie et ayant son siège

à L-3429 Dudelange, 210, route de Burange, constituée suivant acte du notaire Emile SCHLESSER de Luxembourg en
date du 24 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 1195 du 9 août 2002,
modifiée une dernière fois suivant acte du notaire Emile SCHLESSER de Luxembourg du 23 avril 2004, publié au dit
Mémorial, Numéro 734 du 16 juillet 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 87618,

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Sophie BECKER, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri,

qui désigne comme secrétaire Guy BERNARD, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 43,

boulevard Prince Henri,

L'assemblée choisit comme scrutateur Bernard PUTZ, administrateur de société, demeurant à F-57650 FONTOY, 14,

rue du Castel,

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert de siège de Dudelange à Rumelange;
2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la société.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,

resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convo-
cation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Dudelange à Rumelange et par conséquent modifier

le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société, comme suit:

Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi dans la commune de Rumelange."

57982

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de fixer l'adresse du siège social à L-3739 Rumelange, 32, rue des Martyrs.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: BECKER, BERNARD, PUTZ, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 mars 2013. Relation: LAC / 2013 / 11025. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signe): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 27 mars 2013.

Référence de publication: 2013040453/50.
(130049989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

Capital United S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 172.206.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 27 mars 2013.

Référence de publication: 2013040449/10.
(130049958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

Canetto Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 59, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 117.891.

<i>Extrait de résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 05.04.2013

Les actionnaires de la société CANETTO PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A. réunis le 05.04.2013 au siège social,

ont décidé à l’unanimité ce qui suit:

1.  L’administrateur  GREENLINE  INVESTMENTS  S.A.  est  représenté  par  Madame  Liudmila  KUCHEROVA  née  le,

07.11.85 à Leningrad (RUSSIE), demeurant à 2-1-277, Turkustr., RUS – 192242 Saint Petersbourg (RUSSIE).

2. Transfert du siège social de l’administrateur GREENLINE INVESTMENTS S.A. au 59, Boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg.

Fait à Luxembourg le 05.04.2013.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2013044860/17.
(130055279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Chemtex Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 61.200.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 86.908.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance tenue le 28 mars 2013 à 12.00 heures au siège social

Le Conseil de Gérance décide de transférer, avec effet à partir du 28 mars 2013, le siège social de la Société du 9, rue

du Laboratoire L-1911 Luxembourg au 37/a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 avril 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013045470/13.
(130055895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

57983

L

U X E M B O U R G

Resolution Quadrangle General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: GBP 10.138,42.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 136.414.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2013.

Référence de publication: 2013040743/11.
(130049996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

Resolution Quadrangle S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: GBP 10.138,42.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 134.074.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2013.

Référence de publication: 2013040750/11.
(130049994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

Caulus Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 147.443.

EXTRAIT

Il convient de noter que l'adresse professionnelle de Humberto Jorge Pestana Gonçalves, gérant de la Société, sera

désormais au Philippou House, Apt 301, 24, Kostaki Pantelidis, St 6021 Larnaca - Cyprus.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 09 avril 2013.

Référence de publication: 2013045446/13.
(130055470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

SurveyMonkey Europe Sarl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 167.062.

<i>En date du 22 mars 2013, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:

- Démission de Timothy Maly, du poste de gérant de classe B;
- Nomination de David Goldberg, né le 2 octobre 1967 dans l'illinois, Etats-Unis d'Amérique et ayant pour adresse

professionnelle 285 Hamilton Avenue, Suite 500, Palo Alto 94301, Californie, Etats-Unis d'Amérique, au poste de gérant
de classe B pour une durée indéterminée et avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SurveyMonkey Europe Sarl
Fabrice Rota
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013045763/17.
(130055466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

57984


Document Outline

Amber Agro and Food Industries Management S.à r.l.

Arctic Lake S.àr.l.

ATRINITY S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF"

Belair Lotissements S.A.

Bridinvest S.A.

Canetto Participations Luxembourg S.A.

Capital United S.à r.l.

Castel Invest S.A.

Caulus Luxembourg S.à r.l.

Chemtex Global S.à r.l.

Cirse S.à r.l.

Deltaline S.A.

European Lux Trading S.à r.l.

Euro-Planning &amp; Consultants S.A.

HIB Invest S.A.

Hines Holdings Luxembourg 1 S.à r.l.

Holding Dumont S.A.

I.C. Lux S.A.

Impar S.A.

Intraline S.A.

Les Pierres Investment S.à r.l.

Linston S.P.F.

Litoprint S.A.

Ma Clé S.à.r.l.

Mainzer Landstrasse S.à r.l.

map - MARKETING AND PROMOTION LUXEMBOURG s.àr.l

Marimur S.A.

Market Overview S.A.

Massena Advisors S.A.

Massena Capital Partners Luxembourg

Masto Investments S.à r.l.

Max Media Holding S.A.

Menuiserie-Ebenisterie Gérard Assen S.A.

M.R. Services S.à r.l.

NewNet Communication Technologies S.à r.l.

NovaTel IT Group S.à r.l.

Pentavest S.à r.l.

Resolution Quadrangle General Partner S.à r.l.

Resolution Quadrangle S.à r.l.

Rushmore Development S.A.

Smiths Finance Luxembourg S.à r.l.

SurveyMonkey Europe Sarl

TUI Travel Card Processing S.à r.l.