logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1186

21 mai 2013

SOMMAIRE

AerCap Aviation Assets Fund Manage-

ment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56903

Allimac Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

56919

BPT Arista SA SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . .

56903

Cameron Lux BRL II Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

56912

Devera Brownfield Fund S.A. . . . . . . . . . . . .

56882

Ispat Inland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56927

Leiton Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56927

Liftinc Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

56927

LKRT Finance GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56928

Lux AC Concept  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56928

Mathey Mazout S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56928

Messageries du Livre S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . .

56923

Morote S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56924

Papilux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56925

Parlam Invest Holding SPF S.A.  . . . . . . . . .

56925

Passadena S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56925

Percose Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

56922

Perfeus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56882

Phoenix A2 - Prinzenallee . . . . . . . . . . . . . . .

56927

Phoenix A3 - Kaiser-Wilhelm-Strasse  . . . .

56927

Phoenix A4 - Bredowstrasse  . . . . . . . . . . . .

56923

Phoenix A5 - Fritz-Erler-Strasse  . . . . . . . . .

56923

Phoenix B1 - Niederbarnimstrasse . . . . . . .

56923

Phoenix D1 - Hohenstaufenstrasse . . . . . . .

56927

Phoenix E1 - Buckower Damm  . . . . . . . . . .

56925

Phoenix G1 - Emser Strasse  . . . . . . . . . . . . .

56924

Phoenix III Mixed P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56926

Phoenix III Mixed Q  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56926

Phoenix III Mixed T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56922

Phoenix III Mixed U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56921

Phoenix III Mixed V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56920

Phoenix III Mixed W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56922

Phoenix III Mixed X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56920

Phoenix III Mixed Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56920

Phoenix III Mixed Z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56921

Phoenix II Mixed H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56924

Phoenix II Mixed I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56922

Phoenix II Mixed J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56922

Phoenix II Mixed K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56922

Phoenix II Mixed M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56923

Phoenix II Mixed N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56924

Prize Holdings 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

56921

Purple Haze S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56921

SOCIETE FINANCIERE D'ARLES Spf S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56928

Tax & Consulting Services  . . . . . . . . . . . . . .

56928

Three Hills Partners I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

56925

UVZ International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

56928

Vauban S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56926

X-Change.Lu S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56926

56881

L

U X E M B O U R G

Perfeus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.551.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 02.Mai 2013

Die Bestellung von KPMG Luxembourg Sàrl (Geschäftsadresse: 9. Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg) für das am 31.

Dezember 2013 endende Geschäftsjahr wurde bereits am 20. Dezember 2012 durch die Gesellschafter beschlossen. Die
Generalversammlung beschließt am heutigen Tag die Bestellung von KPMG Luxembourg Sàrl auch für die Folgejahre bis
ein gegenteiliger Beschluss erfolgt.

Luxembourg, den 2. Mai 2013.

Perfeus S.A.
Gerd Kiefer / Katja Wilbert

Référence de publication: 2013058995/15.
(130072487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Devera Brownfield Fund S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 34-36, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 133.271.

L'an deux mille treize, le huit mai,
par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

ont comparu:

Devera Brownfield Fund S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 34-36,

Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 133.271 (la «Société Absorbée»),

représentée aux fins des présentes par Manfred Müller, avocat, en vertu des résolutions prises par le conseil d'admi-

nistration de la Société Absorbée en date du 8 mai 2013, et

PSR Brownfield Developers N.V., une société anonyme régie par le droit belge, ayant son siège social à Tragel 58, 9308

Aalst-Hofstade, Belgique et immatriculée au registre des personnes morales de Termonde sous le numéro d'entreprise
0476.155.776 (la «Société Absorbante»),

représentée aux fins des présentes par Michaël Heene, avocat, en vertu des résolutions prises par le conseil d'admi-

nistration de la Société Absorbante en date du 8 mai 2013.

Les prédites procurations resteront annexées au présent acte.
Le projet de fusion a été établi et approuvé le 8 mai 2013, par le conseil d'administration de la Société Absorbante, et

le 8 mai 2013, par celui de la Société Absorbée.

<i>Description de la fusion

Les conseils d'administration de PSR BROWNFIELD DEVELOPERS N.V. et de DEVERA BROWNFIELD FUND S.A.

ont établi ce projet commun de fusion.

Ce projet propose que par le biais d'une fusion transfrontalière par absorption, l'ensemble du patrimoine, aussi bien

les droits que les obligations, issu de la dissolution sans liquidation de DEVERA BROWNFIELD FUND S.A. soit transféré
à PSR BROWNFIELD DEVELOPERS NV qui détient déjà toutes les actions de DEVERA BROWNFIELD FUND S.A.

La présente fusion est régie par les articles 772/1 et suivants du Code belge des sociétés (le «Code des sociétés») ainsi

que par les articles 257 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la «Loi Luxembourgeoise»).

Les conseils d'administration susmentionnés s'engagent mutuellement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour

assurer la réalisation de la fusion aux conditions définies ci-dessous et déterminent par la présente le contenu du projet
de fusion qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante.

Mentions prévues à l'article 772/6 du Code des sociétés et à l'article 261 de la Loi luxembourgeoise

1. Renseignements généraux concernant les sociétés concernées par la fusion transfrontalière (art. 772/6. al. 2. a) du

Code des sociétés et art. 261. al. 2. a) de la Loi luxembourgeoise).

1.1 SOCIÉTÉ ABSORBÉE: DEVERA BROWNFIELD FUND S.A.
La société a été constituée sous la dénomination de «DEVERA BROWNFIELD FUND S.A.» en date du 30 octobre

2007 par acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 5 décembre 2007 sous le numéro 2819. Les statuts ont
été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par acte de Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-

56882

L

U X E M B O U R G

les-Bains,  Grand-Duché  de  Luxembourg  en  date  du  22  janvier  2013,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations en date du 16 avril 2013 sous le numéro 894.

Le siège social de la société est sis au 34-36, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg.

La société a la forme d'une «Société Anonyme» luxembourgeoise.

L'objet social de la société est le suivant:
«La société pourra accomplir pour des besoins personnels le commerce de titres de toutes sortes et toutes opérations

commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

Le capital social de la société s'élève à trente-sept millions cent soixante-huit mille euros (EUR 37.168.000,-) représenté

par trois cent soixante-onze mille six cent quatre-vingt (371.680) actions, sans valeur nominale. Le pair comptable de
chaque action s'élève à mille euros (EUR 1.000,-). Les actions sont nominatives.

La société DEVERA BROWNFIELD FUND S.A. est immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 133.271 et

auprès de l'administration TVA luxembourgeoise sous le numéro LU22158564.

L'exercice comptable de la société commence le 1 

er

 janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires doit être convoquée chaque année le troisième vendredi du mois de

juin.

Le conseil d'administration de DEVERA BROWNFIELD FUND S.A. est composé comme suit:
- M. Ir. Jan Pieter Jozef De Nul;
- M. Paul Lievens;
- M. Dirk Van Rompaey; et
- M. Patrick Van Speybroeck.
À cette date, le seul actionnaire de la société est:
- PSR BROWNFIELD DEVELOPERS NV: trois cent soixante et onze mille six cent quatre-vingt (371.680) actions
1.2 SOCIÉTÉ ABSORBANTE: PSR BROWNFIELD DEVELOPERS NV
Seul la Société Absorbante garde sa personnalité juridique suite à la fusion.
La société a été constituée comme société anonyme sous la dénomination «PSR» le 22 novembre 2001, par acte de

Maître  Joost  EEMAN,  notaire  à  Gand,  publié  aux  Annexes  du  Moniteur  Belge  le  6  décembre  2001  sous  le  numéro
20011206-236. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 21 décembre 2012, par acte de Maître
Danièle BRECKPOT, notaire à Alost, publié aux Annexes du Moniteur Belge le 11 janvier 2013 sous le numéro 13007510.

Le siège social de la société est sis à 9308 Aalst-Hofstade, Tragel 58, Belgique. La société a la forme juridique d'une

«Société Anonyme» belge et a comme dénomination «PSR BROWNFIELD DEVELOPERS».

La société a pour objet:

«I. Pour son propre compte:
a. La composition et la gestion de patrimoine immobilier et la location financement de biens immobiliers à des tiers,

l'acquisition par achat ou par d'autres moyens, la vente, l'échange, la promotion, l'érection, la construction, la recon-
struction, la reconversion, l'assainissement, le développement, la valorisation, l'amélioration, l'équipement, l'aménage-
ment,  l'adaptation,  la  décoration,  l'entretien,  la  location,  la  mise  en  location,  la  mise  à  disposition,  le  lotissement,  la
prospection et l'exploitation de biens immobiliers, le fait d'agir en tant que coordinateur et promoteur de transactions
immobilières ainsi que tous les actes qui, directement ou indirectement, sont liés à cet objet et qui sont de nature à
améliorer l'importance ou les bénéfices des biens immobiliers.

II. Pour son propre compte, pour celui de tiers, ou de concert avec des tiers, détenir une participation dans des

entreprises qui ont le même objet ou un objet similaire au sien ou dont la coopération peut contribuer à la réalisation
de l'objet social, en particulier:

a. la promotion de la constitution de sociétés par apport, participation ou investissement;
b. l'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des sociétés liées sous quelque forme que ce soit.
Dans ce contexte, la société peut également se porter caution ou, dans le sens le plus large, effectuer tout type de

transactions commerciales et financières à l'exception de celles qui sont réservées par la loi aux banques de dépôt, aux
détenteurs de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation;

c. l'octroi d'avis financiers, techniques, commerciaux ou de nature administrative dans le sens le plus large, à l'exception

de conseils concernant des investissements et des placements de trésorerie; l'offre d'assistance et de services, directement

56883

L

U X E M B O U R G

ou indirectement dans le domaine de l'administration, la vente, la production et l'administration en général, l'offre de
toute prestation de services en ce compris le management, la supervision, la gestion et l'exécution de toutes les missions
sous formes d'études d'organisation, expertises, opération techniques et conseils ou autres à tout point de vue à l'intérieur
du champ de l'objet social;

d. la conception, l'étude, la promotion et l'exécution de tous les projets liés à l'informatique et la bureautique et les

applications qui y sont liées;

e. l'exécution d'études, la programmation et la mise en place de systèmes d'organisation de ventes de publicité, de

marketing, l'application pratique de systèmes de traitement des données et toutes les techniques liées à la gestion admi-
nistrative, économique et technique générale des entreprises;

f. l'observation de tous les ordres de gestion, l'exécution des tâches et fonctions qui sont directement ou indirectement

liées à l'objet social;

g. le développement, l'achat, la vente, l'octroi ou la prise de licences sur des brevets, du savoir-faire et des immobili-

sations incorporelles liées;

h. l'octroi de prestations administratives et informatiques pour le compte de tiers ainsi que la fourniture de conseils

à ce sujet;

i. le développement d'études de rendement et d'études techniques;
j. la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits et services, de nouvelles

technologies et leurs applications;

k. toutes les opérations de commission portant sur les biens immobiliers.
La société peut effectuer toutes les opérations de nature commerciale, industrielle, immobilière, mobilière ou finan-

cière qui sont, directement ou indirectement, liées ou attachées à son objet social ou qui peuvent contribuer à la réalisation
de cet objet. L'énumération ci-dessus n'est pas exhaustive, de sorte que la société peut procéder à toutes les activités
qui peuvent, d'une façon ou l'autre, contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social. La société peut réaliser
son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, par tous les moyens et procédés qu'elle estimerait les plus adaptés.

La société ne peut en aucun cas s'engager dans la gestion de patrimoine ou donner des conseils en matière d'inves-

tissement au sens du livre 4 de la loi du quatre décembre 1994 sur les transactions financières et les marchés financiers
et l'arrêté royal sur la gestion de patrimoine et le conseil en placement du 5 août 1995.

La société peut réaliser son objet aussi bien en Belgique qu'à l'étranger.»

Le capital social de la société s'élève à trente millions euros (EUR 30.000.000,-) et est représenté par cent soixante-

cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit (165.198) actions, sans valeur nominale. Le pair comptable de chaque action est de
cent quatre-vingt et un euros soixante centimes (EUR 181,60). Les actions sont nominatives.

La société PSR BROWNFIELD DEVELOPERS NV est immatriculée au registre des personnes morales de Termonde

sous le numéro 0476.155.776 et auprès de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0476.155.776.

L'exercice social de la société commence le 1 

er

 janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires doit être convoquée chaque année le deuxième jeudi du mois de juin.
Le conseil d'administration de PSR BROWNFIELD DEVELOPERS NV est composé comme suit:
- M. Paul Lievens; et
- M. Patrick Van Speybroeck.

2. Rapport d'échange des actions et modalités de remise des actions de la Société Absorbante (art. 261, al. 2, b et c)

de la Loi Luxembourgeoise. Aucune nouvelle action ne sera émise par la Société Absorbante. Aucun rapport d'échange
ne devra être déterminé. Par conséquent, aucune modalité de remise des actions de la Société Absorbante ne sera
appliquée.

3. Effets probables de la fusion transfrontalière sur l'emploi (art. 772/6, al. 2, d) du Code des sociétés et art. 261, al.

4, b) de la Loi luxembourgeoise). La Société Absorbée n'a pas d'employés.

La Société Absorbante emploie actuellement 8 personnes. L'effectif de PSR BROWNFIELD DEVELOPERS N.V. a été

considérablement réduit ces dernières années dans le cadre d'une réduction des frais effectuée dans cette entreprise
(durant l'exercice social 2010 le montant moyen d'employés était de 20,4 ETP, en 2011: 15,2 ETP et en 2012: 8 ETP).

La gestion opérationnelle des activités de friches industrielles dans les sociétés de projets détenues par DEVERA

BROWNFIELD FUND S.A., est actuellement déjà effectuée par la Société Absorbante. Alors qu'auparavant PSR BROWN-
FIELD DEVELOPERS N.V. agissait à titre de gestionnaire d'investissement pour l'ancienne société mère DEVERA S.A.,
SICAR (entre-temps liquidée), la Société Absorbante fait maintenant le suivi du portefeuille de participations pour son
propre compte en tant que société mère de DEVERA BROWNFIELD FUND S.A.

La fusion transfrontalière et la disparition de DEVERA BROWNFIELD FUND S.A. (comme entreprise intermédiaire

entre la Société Absorbante et les sociétés de projets), n'auront en elles-mêmes pas de conséquences pour les employés
de la Société Absorbante.

Les employés ont été préalablement informés:

56884

L

U X E M B O U R G

- de la date prévue de la fusion:
La fusion sera probablement réalisée le 30 juin 2013.
- des raisons de la fusion:
La fusion est motivée par la nécessité de simplifier davantage la structure des sociétés auxquelles PSR BROWNFIELD

DEVELOPERS NV appartient, et l'absence d'utilité opérationnelle de DEVERA BROWNFIELD FUND S.A. en tant que
holding luxembourgeoise intermédiaire.

- des conséquences juridiques, économiques ou sociales pour les employés:
La fusion n'engendrera pas de modifications de la situation juridique, économique ou sociale des employés concernés.
- des mesures envisagées vis-à-vis des employés:
Il n'y a pas de mesures vis-à-vis des employés qui sont envisagées.

4. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront du point de vue comptable considérées

comme accomplies pour compte de la Société Absorbante: (art. 772/6, al. 2, f) du Code des sociétés et art. 261, al. 2. e)
de la Loi luxembourgeoise).
 La date à partir de laquelle les opérations de DEVERA BROWNFIELD FUND S.A. seront
considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de PSR BROWNFIELD DEVELOPERS NV
est fixée au 1 

er

 janvier 2013. Toutes les opérations faites après cette date seront, d'un point the vue comptable, aux

profits et risques de la Société Absorbante.

5. Droits assurés aux actionnaires ayant des droits spéciaux ou aux porteurs de titres autres que des actions ou parts

représentatives du capital social (art. 772/6. al. 2. g) du Code des sociétés et art. 261, al. 2. f) de la Loi luxembourgeoi-
se).
 Toutes les actions qui représentent le capital de la Société Absorbée sont identiques et accordent les mêmes droits
et avantages à leurs détenteurs, de sorte qu'aucune action conférant des droits particuliers ne sera créée dans la Société
Absorbante. Il n'existe pas d'autres titres dans la Société Absorbante. Aucune disposition particulière, rapport d'échange
ou méthode d'évaluation, ne doit donc être prise à cet égard.

6. Avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet de fusion transfrontalière ainsi qu'aux membres

des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés intéressées par la fusion (art.
772/6, al. 2, h) du Code des sociétés et art. 261, al. 2, g) de la Loi luxembourgeoise).
 Aucun avantage particulier n'est
accordé aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance des sociétés en raison de la fusion.

Il n'y a pas besoin d'un rapport écrit établi par un réviseur d'entreprise pour une opération assimilée à la fusion

transfrontalière (conformément à l'article 772/9 §3 du Code des sociétés et l'article 266, al 5 de la Loi luxembourgeoise).
Il n'y aura donc aucun avantage accordé à un réviseur d'entreprise.

7. Statuts de la société issue de la fusion (art. 772/6, al. 2, i) du Code des sociétés et art. 261, al. 4. a) de la Loi

luxembourgeoise). La réalisation de la fusion transfrontalière n'aura pas de conséquences qui rendraient nécessaire une
modification des statuts actuels de PSR BROWNFIELD NV.

L'ensemble du patrimoine de DEVERA BROWNFIELD FUND S.A. sera transféré à titre universel à la Société Absor-

bante au sein de laquelle les éléments d'actif et de passif de la Société Absorbée seront comptabilisés selon le principe
comptable de continuité.

L'activité actuelle de la Société Absorbée consiste pour le moment en la détention de participations dans des sociétés

de  projet  qui  traitent  principalement  des  sites  contaminés  à  développer  ou  en  cours  de  développement.  DEVERA
BROWNFIELD FUND S.A. détient la moitié des actions dans quatre sociétés de projet. Elle détient la presque totalité
des actions dans dix sociétés de projet.

Par le transfert de l'actif et du passif à PSR BROWNFIELD DEVELOPERS NV, cette activité sera poursuivie dans le

cadre de l'objet social actuel de la Société Absorbante.

Les statuts de PSR BROWNFIELD DEVELOPERS NV peuvent, par conséquent, rester inchangés. Les statuts de PSR

BROWNFIELD DEVELOPERS NV sont attachés en Annexe 1.

8. Procédures de fixation des modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de

participation dans la société issue de la fusion (art. 772/6, al. 2, j) du Code des sociétés et art. 261, al. 4, c) de la Loi
luxembourgeoise).
 Dans le cadre de la présente fusion transfrontalière, il n'y a pas d'employés concernés qui bénéficient
de droits de participation (au sens de la Directive 2005/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005
concernant les fusions transfrontalières des sociétés capitaux et de la Convention collective de travail n° 94 du 29 avril
2008, conclue au sein du Conseil National du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues
de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux) dans une des sociétés fusionnantes.

Une procédure déterminant les règles selon lesquelles les employés sont impliqués dans l'établissement de leurs droits

de participation dans la Société Absorbante ne doit donc pas être prévue.

9. Description et répartition précise des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à la Société Absorbante,

et date des comptes des sociétés qui fusionnent pour définir les conditions de la fusion transfrontalière (art. 772/6, al. 2.
k) et I) du Code des sociétés et art. 261, al. 4. d) et e) de la Loi luxembourgeoise).

9.1 COMPOSITION DU PATRIMOINE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE

56885

L

U X E M B O U R G

Ci-après l'actif et passif tels que présentés sous forme d'un état comptable conformément au droit luxembourgeois

pour les exercices sociales clôturés le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2011 (modèle eCDF).

ACTIF

Exercice

concerné

Exercice

précédent

A. Capital souscrit non versé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

102

I. Capital souscrit non appelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

104

II. Capital souscrit appelé et non versé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

106

B. Frais d'établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

108

C. Actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

19.972.718,00 110

24.536.965,00

I. Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

112

II. Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

126

III. Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

19.972.718,00 136

24.536.965,00

D. Actif Circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

18.920.045,00 152

12.776.664,00

I. Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

154

II. Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

18.580.602,00 164

5.919.526,00

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . 203

18.580.602,00 204

5.919.526,00

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . 205

206

III. Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

190

IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux,
chèques et en caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

339.443,00 198

6.857.138,00

E. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

381 200

865 00

TOTAL DU BILAN (ACTIF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

38.893.144,00 202

37.314.494,00

PASSIF

Exercice

concerné

Exercice

précédent

A. Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

36.668.709,00 302

-1.988.959,00

I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

37.168.000,00 304

32.000,00

II. Primes d'émissions et primes assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

306

III. Réserves de réévaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

308

IV. Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

310

V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

-2.020.959,00 320

-1.288.096,00

VI. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

1.521.668,00 322

-732.863,00

VII. Acomptes sur dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

324

VIII. Subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

326

IX. Plus-values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

328

B. Dettes subordonnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

C. Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

292.284,00 332

301.955,00

D. Dettes non subordonnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

1.932.151,00 340

39.001.498,00

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . 407

1.932.151,00 408

1.498,00

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . 409

410

39.000.000,00

E. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

404

TOTAL DU BILAN (PASSIF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

38.893.144,00 406

37.314.494,00

9.2 INFORMATION SUR LA VALORISATION DE L'ACTIF
La société DEVERA BROWNFIELD FUND S.A. montre un total de dix-neuf millions neuf cent soixante-douze mille

sept cent dix-huit euros (EUR 19.972.718,-) en actifs financiers.

La société DEVERA BROWNFIELD FUND S.A. détenait des actions dans les sociétés suivantes qui sont comptabilisées

à la valeur de capital de ces sociétés, ou prix d'achat des actions ou suivant une combinaison des deux critères.

Participation SPV

Participation

au capital /

Prix d'achat

en EUR

99,997%

Cortoria NV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.062.058

99,999%

De Nieuwe Filature NV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.061.924

56886

L

U X E M B O U R G

99,867%

Decor Oyenbrug BVBA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

843.476

99,900%

Devera 9000 NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.938

99,995%

Liras NV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.199.998

99,995%

PSR 1830.01 NV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.348.983

99,993%

PSR 2850 NV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

99,991%

PSR 8870 NV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

661.968

99,992%

Sportief NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700.928

99,976%

Zennepoort NV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

261.938

50%

Immo Vilvo NV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.681.366

50%

Zennebroeck NV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

655.976

50%

Zenneveen NV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

431.024

0%

Immo 8790 NV

-

Autres participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.140

19.972.718

Le 11 mai 2012, un contrat de vente a été signé (tel que modifié par avenant du 31 octobre 2012) entre la société

DEVERA BROWNFIELD FUND S.A. et International Real Estate Construction NV, concernant la vente de la société
immobilière De Nieuwe Filature NV. Le transfert des actions aura lieu au plus tard le 31 mai 2013.

Ce transfert résultera dans un gain de capital d'un million six cent quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-douze

euros (EUR 1.648.292,-), qui apporte la valeur de De Nieuwe Filature NV à un montant total de huit millions cinq cent
trente-six mille quatre cent quarante-huit euros (EUR 8.536.448,-).

La valeur totale des participations de DEVERA BROWNFIELD FUND S.A. dans les sociétés de projet mentionnées

ci-dessus s'élève donc à vingt et un millions six cent dix-neuf mille huit cent soixante-dix euros (EUR 21.619.870,-).

9.3 COMPOSITION DU PATRIMOINE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE PSR BROWNFIELD DEVELOPERS NV
Ci-après l'actif et le passif tels que présentés dans l'état comptable conformément au droit belge pour les exercices

clôturés le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2011 (modèle NBB).

BILAN APRES REPARTITION

Ann.

Codes

Exercice

Exercice

précédent

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20/28

37.127.211,69

224.196,95

Frais d'établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1

20

Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2

21

2.674,92

54.272,90

Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3

22/27

14.590,50

53.947,05

Terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Installations, machines et outillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

225,34

2.614,75

Mobilier et matériel roulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

2.625,87

39.892,20

Location-financement et droits similaires . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Autres immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

11.739,29

11.440,10

Immobilisations en cours et acomptes versés . . . . . . . . . . . . . .

27

Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4/5.5.1 28

37.109.946,27

115.977,00

Entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.14

280/1

37.109.946,27

115.977,00

Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280

37.109.946,27

115.977,00

Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281

Autres entreprises avec lesquelles
il existe un lien de participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.14

282/3

Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

282

Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283

Autres immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

284/8

Actions et parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

284

Créances et cautionnements en numéraire . . . . . . . . . . . . . . . .

285/8

ACTIFS CIRCULANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29/58

11.695.096,42

4.411.304,69

Créances à plus d'un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

4.080.000,00

340.000,00

Créances commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290

Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

291

4.080.000,00

340.000,00

Stocks et commandes en cours d'exécution . . . . . . . . . . . . . . .

3

56887

L

U X E M B O U R G

Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30/36

Approvisionnements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30/31

En-cours de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Produits finis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Immeubles destinés à la vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Acomptes versés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Commandes en cours d'exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Créances à un an au plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40/41

7.190.052,46

3.612.915,52

Créances commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

896.102,70

1.757.834,49

Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

6.293.949,76

1.855.081,03

Placements de trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5.1/5.6 50/53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actions propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Autres placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51/53

Valeurs disponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54/58

413.067,80

440.241,17

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6

490/1

11.976,16

18.148,00

TOTAL DE L'ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20/58

48.822.308,11

4.635.501,64

Ann. Codes

Exercice

Exercice

précédent

PASSIF
CAPITAUX PROPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10/15

29.948.106,08

618.309,72

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7

10

30.000.000,00

800.000,00

Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

30.000.000,00

800.000,00

Capital non appelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Primes d'émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Plus-values de réévaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

87.737,14

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

52.678,76

Réserves indisponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

Pour actions propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1310

Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1311

Réserves immunisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132

Réserves disponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

35.058,38

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

-139.631,06

-181.690,28

Subsides en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Avance aux associés sur répartition de l'actif net . . . . . . . . . . . . . .

19

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

. . . . . . . . . . . .

123.572,23

Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160/5

123.572,23

Pensions et obligations similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

Charges fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

Grosses réparations et gros entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162

122.172,23

Autres risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8

163/5

1.400,00

Impôts différés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168

DETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17/49

18.874.202,03

3.893.619,69

Dettes à plus d'un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9

17

Dettes financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170/4

Emprunts subordonnés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

Emprunts obligataires non subordonnés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

Dettes de location-financement et assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . .

172

Etablissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173

Autres emprunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174

Dettes commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1750

Effets à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1751

Acomptes reçus sur commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

56888

L

U X E M B O U R G

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178/9

Dettes à un an au plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42/48

18.858.808,35

3.886.249,48

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9

42

Dettes financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

12.108.877,46

Etablissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

430/8

Autres emprunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

439

12.108.877,46

Dettes commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

114.267,37

167.667,76

Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

440/4

114.267,37

167.667,76

Effets à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

441

Acomptes reçus sur commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Dettes fiscales, salariales et sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9

45

93.112,08

200.218,06

Impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450/3

19.478,67

110.669,76

Rémunérations et charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

454/9

73.633,41

89.548,30

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47/48

6.542.551,44

3.518.363,66

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9

492/3

15.393,68

7.370,21

TOTAL DU PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10/49

48.822.308,11

4.635.501,64

9.4 ÉVALUATION DE L'ACTIF ET PASSIF DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE PSR BROWNFIELD DEVELOPERS NV
Les actifs financiers sont évalués à leur prix d'acquisition ou à leur valeur du marché inférieure. Il n'y avait pas de

réévaluations effectuées pendant le dernier exercice social.

Les stocks sont évalués au prix d'acquisition ou à la valeur du marché inférieure.
9.5 DATES DES COMPTES
Les comptes annuels suivants ont été utilisés afin de déterminer les conditions de la fusion transfrontalière:
- les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2012 de PSR BROWNFIELD DEVELOPERS NV, approuvés par l'as-

semblée générale annuelle tenue extraordinairement le 10 avril 2013, tels que joints à l'Annexe 2; et

- les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2012 de DEVERA BROWNFIELD FUND SA, approuvés par l'assemblée

générale annuelle tenue extraordinairement le 30 avril 2013, tels que joints à l'Annexe 2.

10. Modalités d'exercice des droits des créanciers et des actionnaires minoritaires des sociétés appelées à fusionner.
Pour la Société Absorbante
Conformément à l'article 684 §1 du Code des sociétés, au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes

du Moniteur belge des actes constatant la fusion ou la scission, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à
la fusion ou à la scission dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, peuvent exiger une
sûreté, nonobstant toute convention contraire.

La société bénéficiaire à laquelle cette créance a été transférée et, le cas échéant, la société dissoute peuvent chacune

écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président

du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société débitrice a son siège. La procédure est introduite et instruite
comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue.

Tous droits sauf au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit

être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont
jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société bénéficiaire.

Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible et, dans le cas d'une

scission, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation.

Le droit belge ne prévoit pas de droits spécifiques pour les actionnaires minoritaires dans le cadre de fusions trans-

frontalières. En tout état de cause, toutes les actions de la Société Absorbée sont, à la date de la fusion, entièrement
détenues par la Société Absorbante; il n'y a donc pas d'actionnaires minoritaires.

Pour la Société Absorbée
La réglementation spécifique de protection des créanciers est prévue dans l'article 268 de la Loi luxembourgeoise. En

vertu de l'alinéa 1 de cet article, les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de
publication des actes constatant la fusion peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette
publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société
débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés
pour des créances échues ou non échues, au cas où l'opération de fusion réduirait le gage de ces créanciers. Le président
rejette cette demande si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu
du patrimoine de la société après la fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même
si la créance est à terme. Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la demande devient immédiatement exigible.

56889

L

U X E M B O U R G

Le droit luxembourgeois ne prévoit pas de droits spécifiques pour les actionnaires minoritaires dans le cadre de la

présente fusion transfrontalière. En tout état de cause, toutes les actions de la Société Absorbantes sont détenues par
PSR BROWNFIELD DEVELOPERS N.V.; il n'y a donc pas d'actionnaires minoritaires.

Les créanciers de chacune des sociétés pourront obtenir, sans frais, les modalités d'exercice de leurs droits au siège

social de chacune des sociétés participant à la fusion.

11. Mentions complémentaires. Le présent projet de fusion sera soumis à l'assemblée générale extraordinaire de la

Société Absorbante, et cela conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés.

L'original du présent texte sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Termonde et publié par extrait aux

Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 772/7 du Code des sociétés par la Société Absorbante et sera
déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg par la Société Absorbée conformément aux disposition
de l'article 9 de la Loi luxembourgeoise, et publié in extenso au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont

estimés à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par les nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. Müller, M. Heene, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 10 mai 2013. REM/2013/779. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 15 mai 2013.

MARC LOESCH.

“PSR Brownfield Developers”

Naamloze vennootschap

9308 Hofstade (Aalst), Tragel 58

Oudernemingsnummer: 0476.155.776

HISTORIEK

1) Opgericht (onder de benaming PSR) blijkens akte verleden voor Notaris Eeman Joost, te Gent, op tweeëntwintig

november tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes december tweeduizend en
één, onder nummer 20011206-236.

2) Waarvan de Statuten werden gewijzigd:
- bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 18 maart 2011, waarvan proces-

verbaal op dezelfde dag werd opgemaakt door notaris Fevery Fabienne, te Gent, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 5 april 2011, onder nummer 11051103.

- bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 7 november 2012, waarvan proces-

verbaal op dezelfde dag werd opgemaakt door notaris Danièle Breckpot te Aalst, neergelegd ter publicatie.

- bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 21 december 2012, waarvan proces-

verbaal op dezelfde dag werd opgemaakt door notaris Danièle Breckpot te Aalst, neergelegd ter publicatie.

Gecoördineerde Statuten per 21/12/2012

A. Naam - Duur - Zetel - Doel

Art. 1. Aard - Rechtsvorm - Naam. De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "PSR

Brownfield Developers".

Art. 2. Duur. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Art. 3. Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9308 Hofstade (Aalst), Tragel 58.
De zetel van de vennootschap mag zonder statutenwijziging en bij gewoon besluit van de raad van bestuur worden

overgebracht naar iedere andere plaats in België met inachtneming van de taalwetgeving.

Iedere beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal worden neergelegd ter griffie in het vennoot-

schapsdossier en bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag bij eenvoudig
besluit van de raad van bestuur bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten zowel in België als in het buitenland.

Art. 4. Doel. De vennootschap heeft tot doel:
I. Voor eigen rekening:

56890

L

U X E M B O U R G

a. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan

derden, het verwerven door aankoop of anderzijds, het verkopen, het ruilen, het promoveren, het oprichten, het bouwen,
het verbouwen, het reconverteren, het saneren, het ontwikkelen, het valoriseren, het verbeteren, het verbeteren, het
uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het ter beschikking
stellen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, het optreden als coördinator en als
promotor van onroerende goed transacties alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, participeren in ondememingen die

een gelijk of een gelijkaardig doel hebben als het hare of waarvan de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking
van het doel en inzonderheid:

a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan verbonden vennootschappen onder om het even welke vorm.
In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties

verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar-
kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, of afdministratieve aard in de ruimste zin, met

uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstpres-
taties inclusief management, supervisie, beheer en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

d. Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en

bureautica en aanverwante toepassingen;

e. Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen van publiciteitsverkoop, van

marketing, de praktische toepassing van Systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de
technische administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

f. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of on-

rechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

g. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante

immateriële duurzame activa;

h. Het verlenen van administratieve prestaties en Computer Services voor rekening van derden alsmede het verlenen

van adviezen hieromtrent;

i. Het uitwerken van rendementsstudies en technische studies;
j. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe diensten en producten, nieuwe

technologieën en hun toepassingen;

k. Alle commissieverrichtingen betreffende onroerende goederen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard

die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevor-
deren. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek 4 van de Wet van

vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het koninklijk besluit
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap kan haar doel realiseren zowel in België als in het buitenland.

Art. 5. Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertig miljoen euro (€ 30.000.000,00). Het

is vertegenwoordigd door honderdvijfenzestigduizend honderdachtennegentig (165.198) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.

Art. 6. Vorm van de aandelen. De volgestorte aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam.

Art. 6. bis. Voorkoopclausule. De aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde, moet

eerst de andere aandeelhouders uitnodigen hun voorkooprecht uit te oefenen, tegen de door de overdrager bepaalde
prijs.

Die aandeelhouder rieht een aangetekende brief aan de andere aandeelhouder(s) waarin hij mededeelt hoeveel aan-

delen hij wenst over te dragen, de prijs ervan, en de identiteit van de kandidaat aandeelhouder. De aandelen moeten bij
voorrang aan de bestaande aandeelhouder(s) aangeboden worden naar evenredigheid van zijn/hun aandelenbezit. Hie-
romtrent kan alle informatie bekomen worden bij de Raad van Bestuur.

56891

L

U X E M B O U R G

Elke aldus aangeschreven aandeelhouder beschikt over een termijn van maximaal drie maanden, na het verzoek tot

uitoefening van het voorkooprecht, om de aandelen te kopen, onder voorbehoud van wat hierna volgt:

- elke aandeelhouder die zijn voorkooprecht binnen voormelde termijn uitoefent, wordt eigenaar van bedoelde aan-

delen.

- indien een aandeelhouder zijn voorkooprecht niet uitoefent binnen voormelde termijn, begint een nieuwe termijn

van drie maanden te lopen binnen dewelke een of meer andere aandeelhouders de aandelen kunnen inkopen.

Daartoe zendt de aandeelhouder een nieuw schrijven aan de overige aandeelhouders, waarin hij opnieuw melding

maakt van het aantal aandelen dat hij wenst te verkopen evenals de prijs ervan alsook van het feit dat een nieuwe termijn
van drie maanden begint te lopen. De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen, na ontvangst van
de brief, om al dan niet hun voorkooprecht uit te oefenen.

Blijven er dan nog aandelen over of hebben de aandelen bij de aandeelhouders geen koper gevonden, dan zal tenslotte

de overdragende aandeelhouder onmiddellijk de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte brengen, die het recht heeft een
derde kandidaat koper te zoeken, die de aandelen inkoopt aan de hiervoor beschreven prijs, zonder dat dit alles evenwel
de tweede termijn van drie maanden mag overschrijden.

Wordt dergelijke koper niet gevonden, kan de overdragende aandeelhouder bedoelde aandelen overdragen aan de

kandidaat-aandeelhouder aan de prijs, hiervoor bepaald.

Bij niet-naleving door de overdrager van de voorschreven procedure is deze aan de overige aandeelhouder een for-

faitaire schadevergoeding verschuldigd a rato van vijftig procent van de boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen
aandeel verschuldigd onverminderd het recht voor de vennootschap en de aandeelhouders om de werkelijke geleden
schade te bewijzen en op te eisen. Deze som zal verdeeld worden tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tussen
hun aandelenbezit.

B. Verhoging, vermindering en aflossing van het kapitaal

Art. 7. Verhoging van het kapitaal. Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal volgens de artikelen 581 en

603 van het Wetboek van Vennootschappen kan tot verhoging van het kapitaal met nieuwe inbrengen of door omzetting
van reserves alleen worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens
de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Art. 8. Vermindering van het kapitaal. De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris

besluiten tot een reële of formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van artikel 612 van het Wetboek
van Vennootschappen.

C. Obligaties

Art. 9. Uitgifte van gewone obligaties. De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van de artikelen 486 en 487 van

het Wetboek van Vennootschappen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en
bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten. Hij beslist of de obligaties aan toonder dan wel op naam zijn.

Art. 10. Uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of Warrants. De buitengewone algemene vergadering

kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants volgens de artikelen 489 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen, onverminderd de bevoegdheid daartoe verleend aan de raad van bestuur.

D. Bestuur en vertegenwoordiging

Art. 11. Benoeming en ontslag van bestuurders. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samen-

gesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op
een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan
twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene
vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en

zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders, zaakvoerders,

bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.

Art. 12. Voorzitter. De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voor-

zitter.

Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door

de oudste in jaren van de bestuurders.

Art. 13. Collegiale besluitvorming. De bestuurders vormen een College dat beraadslaagt en besluit volgens de bepa-

lingen van deze Statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende
vergaderingen.

56892

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Vergadering van de raad van bestuur. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo

dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders of van de gedelegeerd bestuurder.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproe-

pingsbrief.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Art. 15. Oproeping en agenda. De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in

geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste drie volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief
bevat de agenda.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig

opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onre-
gelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Art. 16. Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van

bestuur slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen

en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De bestuurder die belet is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale

handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief,
telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander
lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere
van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten
heeft ontvangen.

De bestuurders vormen een College dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze Statuten en, bij onts-

tentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen,

kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze
procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan
kapitaal.

Met een besluit van de raad van bestuur Staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend

en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

Om hem in Staat te stellen zijn taak als bestuurder uit te voeren, heeft elke individuele bestuurder op eenvoudig

verzoek inzage in de vennootschapsdocumenten en -informatie.

Art. 17. Strijdig belang.
a) Indien een bestuurder rechtstreeks, of onrechtstreeks, een belang van Vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig

is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij die mededelen
aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. De betrokken bestuurder moet de commissaris,
indien er een is, tevens op de hoogte brengen.

b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze oms-

chrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke
gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het controleverslag dat de commissaris
aan de jaarvergadering voorlegt.

Art. 18. Intern bestuur - Beperkingen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te

verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap

opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Art. 19. Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht. De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen

te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van
de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald

is in artikel 4 van deze Statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennoot-
schap dientengevolge geleden heeft.

56893

L

U X E M B O U R G

Art. 20. Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht. De raad van bestuur vertegenwoordigt als College de

vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Art. 21. Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan de vertegen-

woordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, gedelegeerd bestuurder(s) genaamd,
die - indien er meerdere zijn - volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als College
moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap

vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als College
verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de

normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzake-
lijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden

worden tegengeworpen.

De hierna opgesomde lijst van bevoegdheden worden geacht geen onderdeel te vormen van het dagelijks bestuur.
Voor deze bevoegdheden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bes-

tuurders:

- het aangaan van transacties, zoals daar zijn maar niet beperkt tot kopen, verkopen, bezwaren, met kredieten belasten

van onroerende goederen;

- het aangaan van kredietovereenkomsten en financiële verbintenissen met derden en kredietinstellingen;
- hat aangaan van transacties van welke aard ook die 1.000.000 EUR overschrijden;
- het aangaan van engagementen, transacties, overeenkomsten met looptijd langer dan een (1) jaar.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan

derden worden tegengeworpen.

Art. 22. Bijzondere volmachten. Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt,

kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-

loofd.

E. Controle

Art. 23. Controle. Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder

individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan
door een accountant.

F. Algemene vergadering

Art. 24. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering. De gewone algemene vergadering van de aan-

deelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand
juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten

over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de Statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om

over enige wijziging van de Statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot

de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de
onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

Art. 25. Plaats van de vergadering. Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of

op de plaats aangewezen in de oproeping.

Art. 26. Bijeenroeping. De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of

buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan overeenkomstig de wet.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 bis van deze

Statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend
en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de
jaarvergadering.

56894

L

U X E M B O U R G

Art. 26 bis. Schriftelijke besluitvorming. Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden

verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager,

met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de
eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de
in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Samen met haar rondschrijven, zal de raad van bestuur, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele

commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten
ter beschikking worden gesteld.

Werd  binnen  deze  periode  de  goedkeuring  van  alle  aandeelhouders  met  betrekking  tot  alle  agendapunten  en  de

schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking

van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen
beslissingen.

Art. 27. Vertegenwoordiging van aandeelhouders. Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd wor-

den door een gemachtigde, die aandeelhouder moet zijn, mits hijzelf of de gemachtigde de bij deze Statuten bepaalde
formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel

1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld

in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag
de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen be-

schouwd.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of in geval van vruchtgebruik op aandelen, is de uitoefening

van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger
van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Art. 28. Stemrecht. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Wanneer één of meer aandelen aan toonder toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon, dan

kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het stemrecht aan dit aandeel verbonden, uitgeoefend door

de vruchtgebruiker.

G. Rekening en rekenschap - bepaling en bestemming van de winstopenbaarmaking van de jaarstukken

Art. 29. Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig

december van hetzelfde jaar.

Art. 30. Boekhouding. De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de Wet van zeventien

juli negentienhonderd vijfenzeventig (17 juli 1975) en haar uitvoeringsbesluiten.

Art. 31. Inventaris. De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing

van de waarderingsregels die door de raad van bestuur zijn vastgesteld.

Art. 32. Jaarrekening. Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken

de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Art. 33. Jaarverslag. De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid

volgens de voorschriften van artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 12 § 2 van de

Wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de onder-
nemingen.

Art. 34. Wettelijke reserve. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen

voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afheming houdt op wanneer het reservefonds een tiende
van het kapitaal heeft bereikt.

56895

L

U X E M B O U R G

Art. 35. Bestemming van de winst. Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering.

Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de
aandeelhouders, en een ander als tantieme aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of
gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

Art. 36. Interim-dividend. De raad van bestuur is bevoegd om een interim-dividend uit te keren met inachtneming van

de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

H. Ontbinding en vereffening

Art. 37. Ontbinding. Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter,

dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het Wetboek van Ven-

nootschappen.  Iedere  wijziging  van  de  naam  van  de  vennootschap  is  vanaf  haar  in  vereffeningstelling  verboden.  Een
beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de
beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Art. 38. Benoeming van vereffenaars. Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die op het tijdstip

van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien
van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen

een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als College de
vennootschap vertegenwoordigen.

Art. 39. Bevoegdheden van vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen

186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stem-
men, anders besluit.

Art. 40. Wijze van vereffening. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,

verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij ove-
rhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

I. Keuze van de woonplaats

Art. 41. Keuze van woonplaats. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars dienen de raad van bestuur bij hun

benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en
kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan

hun woonplaats zoals vermeid in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen of obligaties.

In geval hij zijn woonplaats verandert, moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief

meedelen aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet is gedaan, worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben
in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder of

in geval van verplaatsing van de zetel van een vennootrechtspersoon.

J. Algemene beschikkingen

De aandeelhouders verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg worden de

bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet geldig afgeweken is, geacht deel uit te maken van onderhavige Statuten en
worden de bepalingen die ingaan tegen de dwingende bepalingen van dit Wetboek voor niet geschreven gehouden.

VOOR GECOÖRDINEERDE TEKST
Daniele Breckpot, te Aalst
<i>Notaris

«PSR Brownfield Developers»

Société Anonyme

9308 Hofstade (Aalst), Tragel 58

Numéro d'entreprise: 0476.155.776

HISTORIQUE

1) Constituée (sous la dénomination PSR) suivant l'acte reçu par le notaire Eeman Joost, à Gand, le vingt-deux no-

vembre deux mil un, publié à l'annexe du Moniteur belge du six décembre deux mil un, sous le numéro 20011206-236.

2) Dont les statuts ont été modifiés:

56896

L

U X E M B O U R G

- par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 18 mars 2011, dont le procès-verbal a

été établi le jour même par le notaire Fevery Fabienne, à Gand, publiée aux annexes du Moniteur belge du 5 avril 2011,
sous le numéro 11051103;

- par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 7 novembre 2012, dont le procès-verbal

a été établi le jour même par le notaire Danièle Breckpot, à Alost, déposée aux fins de publication;

- par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 21 décembre 2012, dont le procès-

verbal a été établi le jour même par le notaire Danièle Breckpot, à Alost, déposée aux fins de publication.

Statuts coordonnés au 21/12/2012

A. Dénomination - Durée - Siège - Objet

Art. 1 

er

 . Nature - Forme juridique - Dénomination.  La société a été constituée sous la forme d'une société anonyme

et sous la dénomination «PSR Brownfield Developers».

Art. 2. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Siège. Le siège de la société est établi à 9308 Hofstade (Alost), Tragel 58.
Le  siège  de  la  société  peut,  sans  modification  des  statuts  et  par  simple  décision  du  conseil  d'administration,  être

transféré en tout autre endroit de Belgique, compte tenu de la législation relative à l'emploi des langues.

Toute décision de transfert du siège de la société sera déposée au greffe dans le dossier de la société et publiée aux

annexes du Moniteur belge. La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges adminis-
tratifs, succursales et agences, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Art. 4. Objet. La société a pour objet:
I. Pour son propre compte:
a. la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et le financement de la location de biens immobiliers à des

tiers, l'acquisition par achat ou autre, la vente, l'échange, la promotion, l'érection, la construction, la transformation, la
reconversion, l'assainissement, le développement, la valorisation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'adapta-
tion, l'embellissement, l'entretien, le louage, la location, la mise à disposition, l'allotissement, la prospection et l'exploi-
tation  de  biens  immobiliers,  toute  action  en  qualité  de  coordinateur  et  de  promoteur  de  biens  immobiliers,  toutes
transactions et opérations directement ou indirectement liées à cet objet et de nature à favoriser l'extension et le ren-
dement des biens immobiliers.

II. Pour son propre compte, le compte de tiers ou en participation avec des tiers, la société peut prendre des parti-

cipations dans des entreprises ayant un objet identique ou similaire au sien ou dont la collaboration peut contribuer à la
réalisation de son objet, et en particulier:

a. l'aide à la création de sociétés par apport, participation ou investissement;
b. l'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des sociétés liées sous quelque forme que ce soit.
Dans ce cadre, elle peut également se porter caution ou accorder son aval, au sens le plus large du terme, effectuer

toutes opérations commerciales et financières, à l'exception de celles qui sont réservées par la loi aux banques de dépôt,
dépositaires de dépôts à court terme, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et sociétés de capitalisation;

c. la fourniture de conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative au sens le plus large du

terme, à l'exception de conseils en matière d'investissements et de placements de capitaux; la fourniture d'une assistance
et de services directement ou indirectement liés au domaine de la gestion, de la vente, de la production et de l'adminis-
tration  générale,  la  fourniture  de  toutes  prestations  de  services,  y  compris  la  direction,  la  supervision,  la  gestion  et
l'exécution de toutes missions sous la forme d'études organisationnelles, d'expertises, d'actes techniques et de conseils
ou autres dans tout domaine conforme à l'objet social;

d. l'élaboration, l'étude, la promotion et la réalisation de tous projets liés à l'informatique, à la bureautique et à des

applications connexes;

e. la réalisation d'études, la programmation et le démarrage de systèmes organisationnels de vente de publicités, de

marketing, la mise en œuvre pratique de systèmes de traitement de données et de toutes techniques liées à la direction
technique, administrative, économique et générale d'entreprises;

f. l'exercice de tous mandats d'administrateur, de missions et de fonctions directement ou indirectement liées à l'objet

social;

g. le développement, l'achat, la vente, l'achat ou la vente de licences de brevets, de savoir-faire et d'actifs immatériels

durables connexes;

h. la fourniture de prestations administratives et de services informatiques pour le compte de tiers, ainsi que la four-

niture de conseils en la matière;

i. l'élaboration d'études de rendement et d'études techniques;
j. la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux services et produits, de nouvelles

technologies et de leurs applications;

56897

L

U X E M B O U R G

k. toutes opérations de commission concernant les biens immobiliers.
La société peut mener toutes opérations de nature commerciale, industrielle, immobilière, mobilière ou financière se

rapprochant de son objet, se rattachant à son objet ou pouvant favoriser sa réalisation, directement ou indirectement.
L'énumération susmentionnée n'est pas limitative, de sorte que la société peut accomplir tous actes pouvant contribuer
de quelque façon que ce soit à la réalisation de tout ou partie de son objet social. La société peut réaliser son objet, tant
en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les façons et manières qu'elle jugera les plus appropriées.

La société ne peut en aucun cas faire de la gestion de fortune ni donner des conseils en placements au sens du livre 4

de la Loi du quatre décembre mil neuf cent nonante relative aux transactions financières et aux marchés financiers et de
l'arrêté royal du cinq août mil neuf cent nonante et un relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements.

La société peut réaliser son objet en Belgique comme à l'étranger.

Art. 5. Capital. Le capital social s'élève à trente millions d'euros (30.000.000,00 €). Il est représenté par cent soixante-

cinq mille cent nonante-huit (165.198) actions sans mention de valeur nominale.

Art. 6. Forme des actions. Les actions intégralement libérées sont nominatives.
Un registre des actions nominatives est tenu au siège de la société.

Art. 6 bis. Clause de préemption. L'actionnaire qui souhaite céder une ou plusieurs actions à un tiers doit d'abord

inviter les autres actionnaires à exercer leur droit de préemption au prix fixé par le cédant.

Cet actionnaire adresse aux autres actionnaires un courrier recommandé dans lequel il communique le nombre d'ac-

tions  qu'il  souhaite  céder,  le  prix  des  actions  et  l'identité  du  candidat  actionnaire.  Les  actions  doivent  d'abord  être
proposées aux actionnaires existants en proportion des actions qu'ils détiennent. Toutes les informations y relatives
peuvent être obtenues auprès du conseil d'administration.

Chaque actionnaire ainsi invité à exercer son droit de préemption dispose d'un délai de trois mois au maximum, à

compter de l'invitation, pour acheter les actions, sous réserve de ce qui suit:

- Chaque actionnaire qui exerce son droit de préemption dans le délai susmentionné devient propriétaire des actions

visées.

- Si un actionnaire n'exerce pas son droit de préemption dans le délai susmentionné, un nouveau délai de trois mois

commencera à courir, durant lequel un ou plusieurs autres actionnaires pourront acheter les actions.

L'actionnaire cédant enverra à cet effet aux autres actionnaires un nouveau courrier dans lequel il mentionnera de

nouveau le nombre d'actions qu'il souhaite vendre, ainsi que leur prix et le fait qu'un nouveau délai de trois mois commence
à courir. Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la réception du courrier, pour exercer ou
non leur droit de préemption.

S'il reste encore des actions ou si les actions n'ont pas trouvé preneur parmi les actionnaires, l'actionnaire cédant en

informera enfin immédiatement le conseil d'administration qui aura le droit de chercher un tiers candidat acquéreur qui
achètera les actions au prix susvisé, sans que le deuxième délai de trois mois puisse toutefois être dépassé.

Si cet acheteur n'est pas trouvé, l'actionnaire cédant peut céder les actions visées au candidat actionnaire au prix prévu.
En cas de non-respect de la procédure prescrite par le cédant, celui-ci sera redevable envers le ou les autres action-

naires d'une indemnité forfaitaire correspondant à cinquante pour cent de la valeur comptable de chaque action cédée
de façon irrégulière, sans préjudice du droit pour la société et les actionnaires de prouver le dommage réellement subi
et de réclamer réparation. Cette somme sera répartie entre les autres actionnaires en proportion des actions qu'ils
détiennent.

B. Augmentation, réduction et amortissement du capital

Art. 7. Augmentation du capital. Sous réserve de la possibilité d'un capital autorisé selon les articles 581 et 603 du

Code des Sociétés, le capital ne peut être augmenté par des apports nouveaux ou par incorporation de réserves que sur
décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue en présence d'un notaire et statuant selon les règles établies pour
la modification des statuts.

Art. 8. Réduction du capital. L'assemblée générale extraordinaire peut, en présence d'un notaire, décider de procéder

à une réduction réelle ou formelle du capital selon les dispositions de l'article 612 du Code des Sociétés.

C. Obligations

Art. 9. Émission d'obligations ordinaires. Le conseil d'administration peut, selon les dispositions des articles 486 et 487

du Code des Sociétés, émettre des obligations ordinaires, garanties ou non par des sûretés réelles, et en fixe les parti-
cularités et les modalités. Il décide si les obligations sont au porteur ou sont nominatives.

Art. 10. Émission de warrants et/ou d'obligations convertibles en actions. L'assemblée générale extraordinaire peut

décider de procéder à l'émission de warrants et/ou d'obligations convertibles en actions, conformément aux articles 489
et suivants du Code des Sociétés, sans préjudice des pouvoirs conférés au conseil d'administration.

56898

L

U X E M B O U R G

D. Administration et représentation

Art. 11. Nomination et révocation des administrateurs. La société est administrée par un conseil d'administration

composé de minimum trois et maximum six administrateurs, actionnaires ou non de la société. Lorsqu'il est constaté, à
une assemblée générale des actionnaires de la société, que la société n'a pas plus de deux actionnaires, la composition
du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire qui suit la
constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans, et ils

peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Un administrateur est élu à la majorité simple. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses actionnaires, gérants,

administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent qui sera chargé d'exercer le mandat au nom et pour le compte
de la personne morale.

Art. 12. Président. Le conseil d'administration nomme un président parmi ses membres à la majorité simple des voix.
À défaut de président ou en son absence, les réunions du conseil d'administration seront présidées par le plus âgé des

administrateurs.

Art. 13. Processus décisionnel collégial. Les administrateurs forment un collège qui délibère et prend des décisions

selon les dispositions des présents statuts et, à défaut de telles dispositions, selon les règles ordinaires des assemblées
délibérantes.

Art. 14. Réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président aussi

souvent que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que dans les quinze jours qui suivent une demande faite dans ce sens par
deux administrateurs ou l'administrateur délégué.

Si le conseil d'administration ne compte que deux membres, chaque administrateur a le droit d'initiative de la convo-

cation.

La réunion est tenue au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Le conseil d'administration peut se réunir par télé- ou vidéoconférence.

Art. 15. Convocation et ordre du jour. L'avis de convocation à une réunion du conseil d'administration sera envoyé,

sauf en cas d'impérieuse nécessité, trois jours francs au moins avant la réunion. Il contiendra l'ordre du jour.

La convocation s'opère valablement par courrier postal, télécopie ou courrier électronique.
Un administrateur qui assiste à une réunion ou s'y fait représenter sera considéré comme régulièrement convoqué.

Un administrateur peut également renoncer à invoquer l'absence ou l'irrégularité de la convocation et ce, avant ou après
la réunion à laquelle il n'est pas présent.

Art. 16. Processus décisionnel - Représentation de membres absents. Sauf en cas de force majeure, le conseil d'ad-

ministration  ne  peut  délibérer  et  prendre  des  décisions  que  si  la  moitié  au  moins  de  ses  membres  est  présente  ou
représentée à la réunion.

Si cette condition n'est pas remplie, le conseil d'administration peut être de nouveau convoqué et il pourra, lors de

cette nouvelle réunion, valablement délibérer et prendre des décisions sur les points inscrits à l'ordre du jour de la
précédente réunion si deux administrateurs au moins sont présents ou représentés.

L'administrateur empêché peut, au moyen d'un document portant sa signature (y compris la signature électronique

prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et notifié par courrier postal, télécopie, courrier électronique ou tout autre
moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner procuration à un autre membre du conseil d'administration pour
qu'il le représente à une réunion bien déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et
exprimer, en plus de sa voix, autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Les administrateurs forment un collège qui délibère et prend des décisions selon les dispositions des présents statuts

et, à défaut de telles dispositions, selon les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration

peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être
recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ou l'utilisation du capital autorisé.

Un document daté et signé par tous les administrateurs, et dont il est fait mention dans le procès-verbal de la réunion,

équivaut à une décision du conseil d'administration.

Pour lui permettre d'accomplir sa tâche d'administrateur, chaque administrateur peut individuellement consulter sur

simple demande les documents de la société et les informations la concernant.

Art. 17. Opposition d'intérêts.
a) Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou

à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le faire savoir aux autres administrateurs avant que le conseil
d'administration prenne une décision. L'administrateur concerné doit également informer le commissaire, le cas échéant.

56899

L

U X E M B O U R G

b) Sa déclaration et les raisons justifiant l'intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'adminis-

tration.  Celui-ci  décrira  la  nature  de  la  décision  ou  de  l'opération,  justifiera  la  décision  prise  et  en  indiquera  les
conséquences patrimoniales. Ces dernières seront également reprises, le cas échéant, dans le rapport de contrôle que
le commissaire présente à l'assemblée annuelle.

Art. 18. Administration interne - Restrictions. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes

d'administration interne nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par
la loi à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut plus particulièrement charger un ou plusieurs de ses membres de la gestion journalière

interne de la société. Une répartition des tâches n'est pas opposable aux tiers.

Art. 19. Étendue du pouvoir de représentation externe. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous actes

juridiques, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. L'incompétence du conseil d'administration
résultant de cette disposition est opposable aux tiers.

La société est liée par les actes accomplis par les administrateurs qui excèdent son objet social, tel que défini à l'article

4 des présents statuts, sans préjudice de la responsabilité des administrateurs quant au dommage subi par la société en
conséquence de ces actes.

Art. 20. Exercice du pouvoir de représentation externe. Le conseil d'administration représente la société en tant que

collège dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il agit par la majorité de ses membres.

Art. 21. Organe de représentation concernant la gestion journalière. Le conseil d'administration peut déléguer la

représentation, en ce qui concerne la gestion journalière, à une ou plusieurs personnes, appelées administrateurs délégués,
qui - s'il y en a plusieurs - doivent agir seuls, conjointement ou en collège, selon la décision du conseil d'administration.

Dans l'extrait de l'acte de nomination, il doit en tout cas être indiqué si les personnes qui représentent la société, en

ce qui concerne la gestion journalière, engagent la société seuls, conjointement ou en collège.

Font partie des actes de gestion journalière tous les actes qui doivent être accomplis jour après jour pour assurer le

déroulement normal des activités de la société et qui ne requièrent pas l'intervention du conseil d'administration eu égard
à leur importance moindre et à la nécessité de prendre une décision immédiate.

L'incompétence résultant de cette disposition est opposable aux tiers, sauf entérinement par le conseil d'administration.
Les compétences énumérées ci-après sont réputées ne pas faire partie de la gestion journalière.
Pour ces compétences, la société est valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement:
- la conclusion de transactions telles que, sans s'y limiter, l'achat, la vente, le grevage de biens immobiliers, la constitution

de garanties de crédits sur des biens immobiliers;

- la conclusion de contrats de crédit et d'engagements financiers avec des tiers et des organismes de crédit;
- la conclusion de transactions, de quelque nature que ce soit, dépassant 1.000.000,- EUR;
- la conclusion d'engagements, de transactions, de contrats d'une durée de plus d'un (1) an.
Les restrictions du pouvoir de représentation en ce qui concerne la gestion journalière sont toutefois inopposables

aux tiers.

Art. 22. Pouvoirs spéciaux. L'organe qui représente la société conformément aux articles précédents peut désigner

des mandataires de la société.

Seules les délégations de pouvoirs spéciaux et limités pour certains actes juridiques ou une série d'actes déterminés

seront autorisées.

E. Contrôle

Art. 23. Contrôle. Aussi longtemps que la société n'est pas tenue de nommer un commissaire, chaque actionnaire a

individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable.

F. Assemblée générale

Art. 24. Assemblée générale ordinaire, spéciale et extraordinaire. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires,

appelée assemblée annuelle, doit être convoquée chaque année le deuxième jeudi du mois de juin à dix-sept heures. Si
ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant.

Une assemblée générale spéciale peut être convoquée à tout moment pour délibérer et statuer sur l'une ou l'autre

matière relevant de sa compétence et n'impliquant pas de modification des statuts.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment en présence d'un notaire pour délibérer

et statuer sur l'une ou l'autre modification des statuts.

Chaque assemblée générale a en outre le pouvoir de délibérer et de statuer dans toutes les matières qui relèvent de

la compétence du conseil d'administration, à la demande de cet organe, et plus particulièrement lorsque cet organe se
trouve dans l'impossibilité de parvenir à une décision.

56900

L

U X E M B O U R G

Art. 25. Lieu de la réunion. Chaque assemblée générale est tenue au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué

dans la convocation.

Art. 26. Convocation. Le conseil d'administration et, le cas échéant, le commissaire sont tenus de convoquer une

assemblée générale spéciale ou extraordinaire à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires représentant séparément
ou conjointement un cinquième du capital social.

Les convocations à une assemblée générale mentionnent l'ordre du jour; elles sont faites conformément à la loi.
Si l'on opte pour la procédure de la décision écrite, telle qu'exposée à l'article 26 des présents statuts, la société doit

recevoir la circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de résolutions, signée et approuvée par tous les
actionnaires, au plus tard le jour fixé dans les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle.

Art. 26 bis. Décision écrite. A l'exception des résolutions qui nécessitent un acte authentique, les actionnaires peuvent,

à l'unanimité, prendre par écrit toutes les résolutions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration enverra à cet effet, par courrier postal, télécopie, courrier électronique ou tout autre

support d'information, une circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de résolutions à tous les actionnaires
et aux commissaires éventuels, et il sera demandé aux actionnaires d'approuver les propositions de résolutions et de les
renvoyer dûment signées dans le délai indiqué dans la circulaire, après réception de celle-ci, au siège de la société ou à
tout autre endroit mentionné dans la circulaire.

Avec sa circulaire, le conseil d'administration enverra aux détenteurs d'actions nominatives et aux commissaires éven-

tuels une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des Sociétés.

Si l'approbation de tous les actionnaires n'est pas reçue durant cette période concernant l'ensemble des points de

l'ordre du jour et la procédure écrite, les décisions seront réputées non prises.

Les détenteurs d'obligations ou de warrants nominatifs, ainsi que les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la

collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions prises au siège de la société.

Art. 27. Représentation d'actionnaires. Chaque actionnaire peut être représenté à l'assemblée par un mandataire, qui

doit être un actionnaire, à condition qu'il ait lui-même ou que le mandataire ait accompli les formalités stipulées dans les
présents statuts pour être admis à l'assemblée.

Les procurations doivent porter une signature (y compris la signature électronique prévue à l'article 1322, alinéa 2 du

Code civil).

Les procurations doivent être notifiées par écrit par courrier postal, télécopie, courrier électronique ou tout autre

moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil et être déposées au bureau de l'assemblée. Le conseil d'administration
peut en outre exiger qu'elles soient déposées à l'endroit indiqué par lui trois jours ouvrables avant l'assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de

cet article.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action ou en cas d'usufruit sur des actions, l'exercice des droits qui y sont attachés

sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par écrit comme représentant de l'action à l'égard de la
société.

Art. 28. Droit de vote. Chaque action donne droit à une voix.
Lorsqu'une ou plusieurs actions au porteur appartiennent à différentes personnes ou à une personne morale, les droits

qui y sont attachés ne peuvent être exercés à l'égard de la société que par une seule personne désignée à cet effet par
écrit.

Tant que cette désignation n'aura pas eu lieu, tous les droits attachés aux actions resteront suspendus. Si une action

est grevée d'usufruit, le droit de vote attaché à cette action sera exercé par l'usufruitier.

G. Comptes et justification - détermination et affectation du bénéfice - publication du rapport annuel

Art. 29. Exercice. L'exercice de la société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre de la même année.

Art. 30. Comptabilité. La société tient une comptabilité selon les dispositions de la Loi du dix-sept juillet mil neuf cent

septante-cinq (17 juillet 1975) et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 31. Inventaire. Les administrateurs dressent un inventaire chaque année, après la clôture de l'exercice, en appli-

quant les règles d'évaluation établies par le conseil d'administration.

Art. 32. Comptes annuels. Après la mise en concordance des comptes avec les données de l'inventaire, les adminis-

trateurs établissent les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que
l'annexe.

Art. 33. Rapport annuel. Les administrateurs établissent en outre un rapport dans lequel ils rendent compte de leur

gestion conformément aux dispositions des articles 95 et 96 du Code des Sociétés.

Cette prescription ne s'applique pas si la société satisfait aux critères de l'article 12 § 2 de la Loi du dix-sept juillet mil

neuf cent septante-cinq concernant la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

56901

L

U X E M B O U R G

Art. 34. Réserve légale. Sur le bénéfice net, il sera d'abord effectué chaque année un prélèvement d'au moins un

vingtième pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve
atteint un dixième du capital social.

Art. 35. Affectation du bénéfice. L'assemblée générale décide de l'affectation du bénéfice. Elle peut décider qu'une

partie à déterminer par elle du bénéfice distribuable sera versée aux actionnaires à titre de dividende et une autre partie,
aux administrateurs à titre de tantième. Elle a toujours le pouvoir de décider que le bénéfice sera réservé ou reporté à
l'exercice suivant, en tout ou en partie.

Art. 36. Dividende intérimaire. Le conseil d'administration est habilité à verser un dividende intérimaire, compte tenu

des dispositions de l'article 618 du Code des Sociétés.

H. Dissolution et liquidation

Art. 37. Dissolution. Après sa dissolution, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, par le juge ou de plein

droit, la société continuera d'exister en tant que personne morale pour sa liquidation.

En cas de dissolution volontaire, les règles établies à l'article 181 du Code des Sociétés doivent être respectées. Toute

modification du nom de la société est interdite à partir de sa mise en liquidation. Une décision de transfert du siège de
la société ne peut être mise à exécution qu'après avoir été homologuée par le tribunal de commerce dans le ressort
duquel la société a son siège.

Art. 38. Nomination de liquidateurs. Si aucun liquidateur n'est nommé, les administrateurs en fonction au moment de

la dissolution seront d'office désignés liquidateurs, tant à l'égard des actionnaires qu'à l'égard des tiers.

L'assemblée générale de la société dissoute peut à tout moment nommer et révoquer un ou plusieurs liquidateurs à

la majorité simple des voix. Elle décide si les liquidateurs représentent la société seuls, conjointement ou en collège.

Art. 39. Pouvoirs des liquidateurs. Les liquidateurs sont habilités à mener toutes les opérations mentionnées aux articles

186 et 187 du Code des Sociétés, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple des voix.

Art. 40. Mode de liquidation. Après le paiement des dettes ou la consignation des sommes nécessaires à ce paiement,

les liquidateurs distribueront aux actionnaires les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales; ils leur
remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.

I. Élection de domicile

Art. 41. Élection de domicile. Les administrateurs, commissaires et liquidateurs doivent communiquer au conseil d'ad-

ministration, au moment de leur nomination ou ultérieurement par courrier recommandé, l'adresse à laquelle toutes les
assignations, notifications et communications peuvent leur être adressées concernant les affaires de la société.

À défaut d'adresse, ils seront censés élire domicile au siège de la société.
Toutes les communications aux actionnaires ou aux détenteurs d'obligations nominatives concernant la société seront

adressées à leur domicile, tel qu'il est mentionné dans l'acte constitutif ou dans le registre des actions ou obligations.

L'actionnaire ou l'obligataire qui change de domicile doit communiquer son nouveau domicile par courrier à la société.

Tant que cette communication n'aura pas eu lieu, ils seront censés avoir élu domicile en leur résidence initiale.

Cette disposition s'applique par analogie en cas de décès d'un actionnaire ou d'un obligataire ou en cas de transfert

du siège d'un associé personne morale.

J. Dispositions générales

Les actionnaires déclarent se conformer au Code des Sociétés.
Par conséquent, les dispositions de ce code auxquelles il n'est pas valablement dérogé sont réputées faire partie des

présents statuts et les dispositions qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce code seront tenues pour
non écrites.

POUR TEXTE COORDONNÉ
Danièle Breckpot, à Alost
<i>Le notaire

Jan Snyers
<i>Traducteur juré néerlandais-français-anglais-allemand

Enregistré à Remich, le 10 mai 2013. Relation: REM/2013/779. Reçu douze euros (EUR 12,00).

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Référence de publication: 2013062998/1130.
(130077774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.

56902

L

U X E M B O U R G

AerCap Aviation Assets Fund Management, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 176.227.

BERICHTIGUNG

Es erhellt aus der Gründungsurkunde der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "AerCap Aviation Assets Fund Ma-

nagement",  mit  Sitz  in  L-2180  Luxemburg,  4,  rue  Jean  Monnet,  eingetragen  im  Handels-  und  Firmenregister  von
Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 176227 (die "Gesellschaft"), unterzeichnet am 20. März 2013 durch Notar
Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxembourg, einregistriert in Luxemburg Actes Civils am 21. März 2013, Re-
ferenz:  LAC/2013/11212,  hinterlegt  im  Handels-  und  Firmenregister  von  Luxemburg  unter  der  Referenznummer
L130051385, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

dass materielle Fehler in der Zeichnung und Einzahlung der Anteile unterlaufen sind und zwar dahingehend dass die

betreffenden Absätze der vorgenannten Gründungsurkunde abgeändert werden sollen wie folgt:

<i>Zeichnung und Zahlung der Anteile

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
- HH Kapital Aviation Investment Services SL:
100 Anteile zum Preis von 25 EUR pro Anteil, d.h. insgesamt zum Preis von 2.500,- EUR;
- Dr. Wegner &amp; Co GmbH:
50 Anteile zum Preis von 25 EUR pro Anteil, d.h. insgesamt zum Preis von 1.250,-,EUR;
- HOST KG:
50 Anteile zum Preis von 25 EUR pro Anteil, d.h. insgesamt zum Preis von 1.250,- EUR; und
- AerCap B.V.:
300 Anteile zum Preis von 25 EUR pro Anteil, d.h. insgesamt zum Preis von 7.500,- EUR.

<i>Gesamt:

500 Anteile zum Preis von 25 EUR pro Anteil, d.h. insgesamt zum Preis von 12.500,- EUR.
Der unterzeichnete Notar fordert Erwähnung dieser Berichtigung überall, wo es sich als notwendig erweist.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 mai 2013. Relation: LAC/2013/21931. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Carlo WERSANDT.

Luxemburg, den 13. Mai 2013.

Carlo WERSANDT
<i>Notar

Référence de publication: 2013061234/34.
(130076033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.

BPT Arista SA SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 132.056.

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of April.
Before Us M 

e

 SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company BPT Arista SA SICAV-

SIF (hereinafter referred to as the "Company") with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132.056, incorporated by deed of Me
Joseph ELVINGER, on 23 August 2007, published in the Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations under number
2442 on 27 October 2007. The articles have been amended by deed of Me Jean SECKLER, on 24 May 2011 and published
in the Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations under number 2017 on 31 August 2011.

The extraordinary general meeting is presided by Mr. Franz Palludan, attorney, residing professionally in Denmark.
The chairman appoints as Secretary Mr. Piotr Czajkowski, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as Scrutineer Mr. Johan Montfort, employee, residing professionally in Luxembourg.
These three individuals constitute the board of the meeting.
Having thus been constituted, the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed "ne varietur"

by the proxy holders representing the shareholders, by the members of the board of the meeting and the notary, will

56903

L

U X E M B O U R G

remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the present deed, with
the registration authorities.

The Chairman thus declared, and requested the notary to acknowledge, the following:
Following the attendance list, all the shares in issue, representing % of the share capital of the Company, are duly or

rightfully represented at the present meeting and may effectively deliberate and decide upon all the items on the agenda.

That the agenda of the present meeting is as following:

<i>Agenda

1. Decision to amend and restate the articles of association of the Company (the "Articles");
2.  Granting  of  authorisation  to  any  one  director  of  the  Company,  with  single  signatory  power  and  full  power  of

substitution to carry out any necessary action in respect of the present agenda in the name and on behalf of the Company;

3. Any other business.

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company resolved to amend and restate the Articles

of the Company, which should henceforth read as follows:

"Title I. Name - Registered office - Duration - Purpose

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares

hereafter issued, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share
capital-specialised investment fund ("société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé") under
the name of" ARISTA SA SICAV- SIF" (the "Company").

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the commune of Luxembourg by

resolution of the Board of Directors (the "Board").

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad (but

in no event in the United States of America, its territories or possessions) by a decision of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent

which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation  of  these  abnormal  circumstances;  such  provisional  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the
Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration. The Company is established for a limited period of eight years starting January 31 

st

 , 2008.

The Company will seek a listing on an official stock exchange, either in Luxembourg or in another EU country prior

to the end of its term. If the Company is not listed on January 31 

st

 2016, the Company shall be liquidated, unless the

shareholders representing at least ninety percent (90%) of the share capital vote in favour of continuing the Company.
In such case, the remaining ten percent (10%) shareholders which did not vote for continuation the Company can claim,
within thirty (30) days, for the repurchase or cancellation of their shares to be repaid by the Company at NAV according
to latest valuation as outlined in article 11.

Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is to invest, either directly or indirectly through its wholly owned

subsidiaries, in commercial properties within the Russian Federation.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfillment and

development of its purpose to the fullest extent permitted under the law of 13 

th

 February 2007 on specialized investment

funds, as amended (the "Law of 2007").

Title II. Share capital - Shares - Net asset value

Art. 5. Share Capital. The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of no nominal value and

shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11. The minimum capital of the
Company is one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-).. The maximum number of shares to be
issued is four million (4,000,000.-).

Art. 6. Form of Shares. The shares of the Company shall be issued in registered form.
All issued shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Company

or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner
of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered shares held
by him and the amount paid up on each (fractional) share.

56904

L

U X E M B O U R G

The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership of such

registered shares.

The board of directors and the shareholders will have the right to access to and to inspect the shareholders' register.

Art. 7. Transfer of shares. Subject to the limits of the Law of 2007, the shares of the Company are freely transferable.

Every transfer of a share shall be entered in the register of shareholders upon payment of such customary fee as shall
have been approved by the Board for registering any other document relating to or affecting the title to any Share.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such

address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be

entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as
entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or
at such other address as may be set by the Company from time to time.

The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership

of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent
such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to
such share(s).

Shares may, if the Board so decides be issued in fractions up to three decimal places. Such fractional shares shall not

be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets on a pro rata basis.

Art. 8. Issuance of Shares. The Board is authorised, during a period of 48 months starting at January 31 

st

 , 2008, to

issue up to a maximum total of four million (4,000,000) fully paid up shares at any time with or without a preferential
subscription right to existing shareholders.

The Board may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued. The Board may, in particular,

decide, at its sole discretion, that shares shall only be issued during one or more offering periods.

Furthermore, the Board may temporarily discontinue or finally suspend the issuance of shares without any prior notice

to shareholders, if the Board determines that this is in the best interest of the Company and the existing shareholders.

Investors wishing to subscribe for shares or existing shareholders wishing to subscribe for further shares after January

31st, 2008 will be required to execute a subscription agreement and indicate therein their total committed capital (the
"Commitment" or "Commitments"); provided however that no shareholder of the Company may hold at any time more
than twenty five percent (25%) of the total number of shares in issue at the end of the Investment Period. The minimum
Commitment shall be one hundred twenty five thousand Euro (EUR 125,000.-), unless the Board in its discretion accepts
a lower amount. The Board may in its discretion accept or refuse an offer to subscribe for shares made by an Investor.
If a subscription is accepted by counter signature of the Board, Commitments received from Investors may be drawn
down by the Board, in whole or in part, during a period of maximum 48 months after January 31 

st

 , 2008 (the "Com-

mitment Period" or "Investment Period").

Commitments will cease to be available for draw-down after the expiry of 48 months period from January 31 

st

 , 2008;

provided however that Commitments may be drawn down thereafter to the extent necessary (i) to pay fees, expenses
and liabilities of the Company, (ii) to complete any investments that have been committed to during the Commitment
Period such as the acquisition of a new property upon its completion or a refurbishment project or (iii) to make any
follow- on investments in existing transactions, in this latter case up to a maximum of ten percent (10%) of Commitments.
After the expiry of 12 months following the end of the Commitment Period, Commitments will cease to be available for
draw downs. This is to satisfy any legal or contractual obligations of the Company, including without limitation in relation
to their position as a landlord of their existing real estate investments.

In no event will an Investor be required to make a capital contribution at any time in any amount in excess of its total

Commitment.

The price per share shall be the Net Asset Value per share as at the most recent Valuation Day, plus a subscription

fee of four percent (4%) of the subscription price. The Net Asset Value per share shall be determined in compliance with
Article 11 as further adjusted on the following basis:

(a) an adjustment shall be made for the difference between any deferred tax liability required to be provided for under

International Financial Reporting Standards as amended from time to time ("IFRS") and the estimated future tax liabilities
as estimated by the Board.

(b) the Board shall be entitled to require an additional assessment of the Net Asset Value including a property valuation,

prior to determining the Net Asset Value for the purpose of any issue of any shares, where the Board considers that
there has been an intervening event since the last Valuation Day which would render the current valuation materially
misleading.

56905

L

U X E M B O U R G

The Board may rely on advice from its advisors in quantifying the likely amount of any estimated tax liabilities and take

such other advice as they consider appropriate before making a determination as to the appropriate adjustment to the
NAV calculation.

Each new shareholder shall also be required (to the extent not already included in the Net Asset Value pursuant to

Article 11) to pay on subscription its pro rata share (as determined by the Board) of the costs of establishment, organi-
sation and administration of the Company, property advisor fees, acquisition fees, disposal fees, financing fees and other
fixed  fees  recalculated  from  January  31 

st

  ,  2008  as  if  all  shareholders  had  been  admitted  to  the  Company  and  had

subscribed for their Commitments on January 31 

st

 , 2008.

Where a new shareholder commits to subscribe for shares on a Subsequent Closing and Commitments are drawn

down by the Board, the Board shall draw down the entirety of the Commitments from the shareholders having made
their Commitments prior to the Subsequent Closing, until the proportion of their total Commitments have been fully
drawn down, before the Commitments of the new shareholders are drawn down.

The issue price, as determined by the Board, of the shares subscribed shall be payable within the time limit as deter-

mined from time to time by the Board which shall not be later than fifteen (15) business days from the relevant issue date
or Valuation Day. The Board may delegate to any director, manager, officer or other duly authorised agent the power
to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them.

The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities or other assets which

could be acquired by the Company pursuant to its investment policy and restrictions, in compliance with the conditions
set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company.

Art. 9. Redemption of Shares. Without prejudice to article 3 above, there will be no redemption at the option of the

shareholders.

Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares and Compulsory Sale of Shares by the Board. The Board may restrict

or prevent the ownership of shares in the Company by any person, including a US Person, firm or corporate body (a
"Precluded Person"), if in the judgment of the Board such holding may be detrimental to the Company or the majority
of its shareholders; if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign; if as a result
thereof it may have adverse regulatory, tax or fiscal consequences, in particular if as a result thereof the Company would
become subject to laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg (including but without limitation tax laws);
or if a single shareholder would hold at any time more than twenty five percent (25%) of the total number of shares in
issue. If the Board deems any such person to be a Precluded Person it shall inform such person of the reason and provide
reasonable evidence thereof.

Specifically, the Board shall restrict the issue of shares in the Company to well informed investors (a "Well Informed

Investor") as defined in article 2 of the Law of2007. For such purposes the Board may:

(a) decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry

or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a Precluded Person or an investor
other than a Well Informed Investor; and

(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares

in the register of shareholders, to provide it with any information, which it may consider necessary for the purpose of
determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a Precluded Person or an investor
other than an Well Informed Investor, or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a
Precluded Person or an investor other than a Well Informed Investor; and

(c) decline to accept the vote of any Precluded Person or investor other than a Well Informed Investor at any meeting

of shareholders of the Company; and

(d) where it appears to the Board that any Precluded Person or an investor other than a Well Informed Investor either

alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, direct such shareholder to sell his shares
and to provide to the Company evidence of the sale within thirty (30) days of the notice. If such shareholder fails to
comply with the direction, the Company may undertake, on behalf of the relevant shareholder, a compulsory sale of all
the shares held by such shareholder in the manner described hereafter.

In the circumstances described in this Article 10, the Board may decide to undertake on behalf of the relevant share-

holder a compulsory sale of his shares. Within thirty (30) calendar days from a correspondent notice (the "Notice of
Transfer") from the Board, the relevant shareholder shall be deemed to have given authority to the Board to sell his
shares to a person permitted, under these Articles and under any other terms which may be determined by the Board,
to acquire the shares (a "Permitted Transferee"), and for this purpose, he shall be deemed to have granted authority to
the Board to execute, on his behalf, a written declaration of transfer as referred to in Article 7 and to agree on a transfer
price (the "Transfer Price") with the Permitted Transferee.

The Transfer Price shall be negotiated by the Board without the requirement for the Board to achieve any minimum

Transfer Price. During the period of thirty (30) calendar days from the Notice of Transfer, the shareholder may notify
to the Board the name of a potential transferee. If such potential transferee meets all requirements normally imposed by
the Board on a Permitted Transferee, the Board shall not reasonably withhold its consent to such transfer. Upon a transfer
agreed by the Board, on behalf of the shareholder, to a Permitted Transferee after the period of thirty (30) calendar days

56906

L

U X E M B O U R G

from the Notice of Transfer, the Board and the Company shall have no other obligation towards the former shareholder
than to credit him with the Transfer Price agreed upon and paid by the Permitted Transferee, after deduction of any costs
incurred in relation with the transfer. In case the Board is not able to identify a Permitted Transferee who accepts to
acquire the shares within ninety (90) calendar days from the Notice of Transfer, the relevant shares shall be forfeited and
cancelled, and the former holder thereof shall no longer be a shareholder of the Company.

The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any

case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any notice of sale, provided in such case the
said powers were exercised by the Company in good faith.

Whenever used in these Articles, "United States" or "U.S." means the United States of America (including the States

and the District of Columbia) and any of its territories, possessions and other areas subject to its jurisdiction and "United
States Person" means a citizen or resident of the United States, or any corporation, partnership or other entity created
in or under the laws of the United States or any person falling within the definition of the term "U.S. Person" under
Regulation S promulgated under United States Securities Act of 1933.

Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value of a share of the Company ("Net Asset Value"

or "NAV") shall be calculated by the Central Administration (as defined in the Law of 2007) under the responsibility of
the Board in accordance with Luxembourg law and the IFRS, in accordance with the provisions of this Article.

The Net Asset Value per share shall be expressed in Euro as a per share figure. The Company will calculate a Net

Asset Value in the case of a further issue of shares. The Net Asset Value per share shall be determined on the last bank
business day of each quarter or more frequently as the Board may decide (each a "Valuation Day"), by dividing the net
assets of the Company, being the value of the assets less the liabilities, calculated at such time as the Board shall have set
for such purpose, by the total number of shares in the Company then outstanding, in accordance with the valuation rules
set forth below. The Net Asset Value per share may be rounded up or down as the Board shall determine.

The Net Asset Value per share will be available not later than twenty (20) business days after receipt of the Net Asset

Value valuation.

The valuation of the Net Asset Value of shares shall be made in the following manner; provided however that:
- defaulted shares shall be disregarded for the purpose of calculation of the Net Asset Value other than in relation to

the determination of the compulsory redemption price as described in Article 10 here above; and

- the unpaid portion of the committed capital in respect of any shares not already issued shall be disregarded in

calculating the Net Asset Value of such shares:

I. The assets of the Company shall include (without limitation):
1. property investments or property rights registered in the name of the Company or subsidiaries controlled by the

Company;

2. shareholdings in convertible and other debt securities of real estate companies;
3. all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
4. all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of properties, property rights, se-

curities or any other assets sold but not delivered);

5. all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, war-

rants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company
(provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (d) below with regard
to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);

6. all stock dividends, cash dividends and cash payments receivable by the Company to the extent information thereon

is reasonably available to the Company;

7. all rentals accrued on any property investments or interest accrued on any interest-bearing assets owned by the

Company except to the extent that the same is included or reflected in the value attributed to such asset;

8. the formation expenses of the Company, including Organisation Cost and the cost of issuing and distributing shares

of the Company, insofar as the same have not been written off; and

9. all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The value of such assets shall be determined as follows:
(a) subject as prescribed below, real estate will be valued by an independent appraiser annually as per 31 December

and on such other days as the Board may determine. Each such valuation will be made on the basis of the gross open
market value;

(b) subject as specified below, the securities of real estate companies which are not listed on a stock exchange nor

dealt in on another regulated market will be valued on the basis of the probable net realisation value (excluding any
deferred taxation) estimated with prudence and in good faith with the Company using the value of real estate as deter-
mined in accordance with (a) above and as prescribed below;

(c) the value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash

dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof,

56907

L

U X E M B O U R G

unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after
making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof;

(d) all other securities and other assets, including debt securities, restricted securities and securities for which no

market quotation is available, are valued on the basis of dealer-supplied quotations or by a pricing service approved by
the Board or, to the extent such prices are not deemed to be representative of market values, such securities and other
assets shall be valued at fair value as determined in good faith by the Board. Money market instruments held by the
Company with a remaining maturity of ninety (90) days or less will be valued by the amortised cost method, which
approximates market value.

The appraisal of the value of (i) property investments and property rights registered in the name of the Company or

any of its directly or indirectly wholly- owned subsidiaries and (ii) direct or indirect shareholdings of the Company in real
estate companies referred to under (b) above in which the Company shall hold more than fifty percent (50%) of the
outstanding voting stock, shall be undertaken by an independent appraiser. Such valuation may be established at the
accounting year end and used throughout the following year unless there is a change in the general economic situation
or in the condition of the relevant properties or property rights held by the Company or by any of the companies in
which the Company has a shareholding which requires new valuations to be carried out under the same conditions as
the annual valuations.

The value of all assets and liabilities not expressed in Euro will be converted into Euro at the relevant rates of exchange

ruling on the relevant Valuation Day. If such quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good
faith by the Board.

The Board may permit some other method of valuation to be used, if it considers that such valuation better reflects

the fair value of any asset of the Company.

II. The liabilities of the Company shall include (without limitation):
1. all loans, bills and accounts payable;
2. all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
3. all accrued or payable expenses (including administrative expenses, management fees, incentive fees, custodian fees,

and corporate agents' fees);

4. all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;

5. an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from

time to time by the Company, and other reserves (if any) authorised and approved by the Board, as well as such amount
(if any) as the Board may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company;

6. all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with Luxembourg law

and IFRS. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the
Company which may comprise:

(a) all organisational expenses relating to the establishment of the Company, preparation of the placing documents

and related agreements including but not limited to legal, accounting and independent valuer's fees, securities filing fees,
postage and out of pocket expenses incurred excluding marketing expenses and travel expenses;

(b) all operational expenses including, but not limited to fees and expenses payable to the Company's auditors and

accountants, custodian and its correspondents, domiciliary and corporate agent, registrar and transfer agent, any paying
agent, any permanent representatives in places of registration, as well as any other agent employed by the Company, the
remuneration (if any) of the directors and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage, fees and expenses
for legal and auditing services, any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the Com-
pany  with  any  Governmental  agencies  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  and  in  any  other  country,  reporting  and
publishing expenses, including the cost of preparing, printing, and distributing periodical reports or registration statements,
and the costs of any reports to shareholders, all taxes, duties, governmental and similar charges, and all other operating
expenses, including the cost of identifying, buying, holding and selling assets, property agency fees, if applicable, interest,
bank charges and brokerage, postage, telephone and telex, hedging costs and borrowing costs and fees and expenses and
costs of third party services related to the transactions, assets, projects, asset owning companies in relation to both
completed and uncompleted transactions. The Company may accrue administrative and other expenses of a regular or
recurring nature based on an estimated amount rateably for yearly or other periods. Legal, accounting and independent
valuer's fees and organisational expenses connected with the establishing of the Company shall be paid or reimbursed by
the Company after January 31st, 2008.

7. All financial liabilities of the Company shall be valued at their mark to market value and the net result in the figures

should be treated as an asset or a liability of the Company;

8. Any performance fees not ascertained at the relevant time shall be based on a bona fide estimate of the likely amount

of such fees.

Shareholders shall, on request, be given details of any of the fees and expenses referred to in this Article 11.
The value of the Company's liabilities is recorded at cost or amortised cost with the exception of any derivatives which

are recorded at fair value.

56908

L

U X E M B O U R G

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with Luxembourg law and

IFRS.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken

by the Board or by any bank, company or other organisation which the Board may appoint for the purpose of calculating
the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

Art. 12. Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share. The determination of the Net Asset Value

per share may be suspended:

- during any period when one or more exchanges which provide the basis for valuing a substantial portion of the assets

of the Company are closed other than for, or during, holidays or if dealings are restricted or suspended or where trading
is restricted or suspended; or

- during any period if, in the reasonable opinion of the Board, a fair valuation of the assets of the Company is not

practical for reasons of force majeure or act of nature beyond the control of the Board; or

- during the existence of any state of affairs as a result of which valuation of assets of the Company would be imprac-

ticable; or

- during any breakdown in excess of one week in the means of communication normally employed in determining the

value of the assets of the Company; or

-  when  the  central  administration  agent  advises  that  the  Net  Asset  Value  of  any  wholly  owned  subsidiary  of  the

Company may not be determined accurately; or

- on publication of a notice convening an extraordinary general meeting of shareholders for the purpose of resolving

the liquidation of the Company; or

- when for any reason the independent property valuer advises that the prices of any investments cannot be promptly

or accurately determined.

Any such suspension or lifting will be promptly notified to shareholders.

Title III. Administration and Supervision

Art. 13. Directors. The Company shall be managed by a board of directors (the "Board") composed of a minimum of

five members, divided into two categories, respectively denominated "Category A Directors" and "Category B Directors",
to be decided from time to time by the general meeting of shareholders. The members of the Board need not to be
shareholders of the Company. They shall be elected for a term of a maximum of one year and shall hold office until their
successor is appointed. The Investment Fund for Central and Eastern Europe (10) and Aage V. Jensens Foundation (AVJF)
are entitled from time to time to propose each of them one candidate as member of directors of the Company (the
"Designation Rights").

In addition, any shareholder who wants to propose a candidate for the position of directors of the Company to the

general meeting of shareholders must present such candidate to the Company in writing at least three weeks prior to
the date of such general meeting.

Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general

meeting.

In the event of a vacancy in the office of director, the remaining directors may temporarily fill such vacancy; the

shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting subject to CSSF approval.

Art. 14. Board Meetings. All Board meetings will be held in Luxembourg or such other place abroad, as specified in

the convening notice. The Board shall choose among its members a chairman, and may choose from among its members
one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall write and keep the
minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon call by the chairman or any
one Director, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman, and in his absence a vice-chairman, shall preside at the meetings of the Directors and of the shareholders.

In absence of the chairman and a vice- chairman, the shareholders or the Board members shall decide by a majority vote
that another Director, or in case of a shareholders' meeting, that any other person shall be in the chair of such meetings.

The Board may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as well as any

other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such appointments
may be cancelled at any time by the Board. The officers need not be Directors or shareholders of the Company. Unless
otherwise stipulated by these Articles of Association, the officers shall have the rights and duties conferred upon them
by the Board.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all Directors at least fourteen (14) days prior to the date

set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set
forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by email, fax or any other similar means
of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a resolution adopted
by the Board.

In case of absence, a director cannot be represented.

56909

L

U X E M B O U R G

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call or similar means of communication equipment

whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall
constitute presence in person at such meeting. Such conference calls shall, to the extent this is practicable, be initiated
in Luxembourg. The majority of the Directors participating will, to the extent this is practicable, be physically present in
Luxembourg at the time of the conference call.

The Directors may only act at duly convened meetings of the Board provided however that resolutions of the Board

may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms in the form of one or several documents in
writing, signed by all the Directors, by email, fax or any other similar means of communication, which shall together
constitute appropriate minutes evidencing such decision.

The Directors may not bind the Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by

resolution of the Board.

The Board can deliberate or act validly only if more than half of its Directors are present.
Resolutions of the Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting
Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present and, in case of equality of votes, the chairman shall

have a casting vote.

Art. 15. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and

administration within the Company's purpose, in compliance with its investment policy.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of share-

holders are in the competence of the Board.

Art. 16. Corporate Signature. The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of one Category

A and one Category B Director or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated
by the Board.

Art. 17. Delegation of Power. The Board of the Company may delegate its powers to conduct the daily management

and affairs of the Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry
out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities,
which need not be members of the Board, who shall have the powers determined by the Board and who may, if the Board
so authorises, subdelegate their powers.

The Board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

Art. 18. Investment Policies and Restrictions. The Board has the power to determine the investment policies and

strategies of the Company, based upon the principle of risk spreading, and the course of conduct of the management and
business affairs of the Company, within the restrictions as shall be set forth by the Board in compliance with applicable
laws and regulations.

When making investment decisions, the Board will ensure that the following investment limits are respected:
- Sixty percent (60%) of the total Commitments will be invested in Moscow,
- Thirty percent (30%) of the total Commitments will be invested in St. Petersburg,
- Ten percent (10%) of the total Commitments will be invested in to other growth cities in
Russia such like Yekaterinburg, Kazan and Nizhniy Novgorod.
In addition, in each of these areas, the Board will focus on prime properties primarily within the retail, office, and other

segments including logistics and leisure. In order to diversify its portfolio, the Board will do its best efforts to reach a
likely split between these sectors in the range of fifty percent (50%) in retail buildings, thirty percent (30%) in office building
and twenty percent (20%) in other segments including logistics and leisure.

Finally, the Board will ensure that the long term liabilities will be structured prudently in order to maintain a debt to

equity ratio of 60/40.

Investments of the Company may be made, either directly or indirectly through its wholly owned subsidiaries, in

commercial properties within the Russian Federation, as the Board may from time to time decide (as set forth in Article
4 "Purpose").

Reference in these Articles to "investments" and "assets" shall mean, as appropriate, either investments made and

assets held directly or investments made and assets held indirectly through the aforesaid subsidiaries.

Art. 19. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any Director or officer and her/his heirs, executors

and administrators, against expenses reasonably incurred by her/him in connection with any action, suit or proceeding
to which she/he may be made a party by reason of her/his being or having been a Director or officer of the Company or,
at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which she/he is not
entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which she/he shall be finally adjudged in such action, suit
or proceeding to be liable for her/his wilful misconduct, bad faith, fraud, reckless disregard or gross negligence; in the
event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement
as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty.
The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

56910

L

U X E M B O U R G

Art. 20. Auditors. The accounting information comprised in the annual report of the Company shall be audited by an

auditor ("réviseur d'entreprises agréé") appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Com-
pany.

The auditor shall fulfill all duties prescribed by the Law of 2007 as amended.

Title IV. General meetings - Accounting year - Distributions

Art. 21. General Meetings of Shareholders of the Company. The general meeting of shareholders of the Company

shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by any member of the Board or by the investment manager

of the Company (if any) or by the Company's auditor as set forth in the law. It may also be called upon the request of
shareholders representing at least five percent (5%) of the share capital.

The notice of the meeting shall set forth the agenda, time and place of the meeting, the applicable quorum and the

majority requirements and be sent at least ten (10) business days prior to the meeting to each registered shareholder at
the shareholder's address in the register of shareholders. The notice shall be sent by registered mail. The agenda shall be
prepared by the Board except in the instance where the meeting is called on the written demand of the shareholders in
which instance the Board may prepare a supplementary agenda.

The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting

of shareholders.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda

(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each whole share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles of Association. Sha-

reholders may act either in person or by giving a written proxy to another person who need not be a shareholder and
may also be a Director of the Company.

The annual meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, on the

thirtieth day of the month of April at 11 a.m.

If such day is not a business day, the annual meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of

meeting.

For the purposes of these Articles of Association:
(a) a "Qualified Majority" shall mean a decision taken by majority vote of two- thirds (2/3) of the shares present or

represented at a shareholder's meeting where a quorum of two-thirds (2/3) of all the shares in issue, at the date of the
meeting, has been reached. If the quorum is not reached at the first meeting, the meeting shall be reconvened. Any
reconvened meeting having the same agenda will not be subject to the above quorum requirement and decisions are
validly taken by majority vote of two-thirds (2/3) of the shares present or represented at such reconvened meeting.

(b) subject to the requirements of Luxembourg law, any other reference to a shareholders vote shall mean a decision

taken by majority vote of the shares present or represented at a shareholder's meeting in which there shall be no quorum
requirements.

Art. 22. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin at the first day of January and shall terminate

on the last day of December of each year.

Art. 23. Distributions. To the extent permitted by law and having retained such amounts as are required for the proper

running of the Company and any identifiable liabilities or expenses of the Company as determined by the Board, the
profits of the Company shall be distributed annually to the shareholders. The Board shall declare and pay to each sha-
reholder a distribution within a time period of twenty (20) business days after the approval of the same in general meeting.
The Board may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law.

If not reinvested pursuant to this article, net disposal proceeds and the proceeds of any refinancing after any deductions

required in relation to anticipated expenses or liabilities, as determined by the Board, can be distributed to shareholders
within sixty (60) days.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

Title V. Final - provisions

Art. 24. Custodian. As required by law, the Company shall enter into a custody agreement. The custodian shall fulfill

the duties and responsibilities as provided for by the Law of 2007 as amended.

If the custodian desires to withdraw, the Board shall use its best efforts to find a successor custodian within two

months of the effectiveness of such withdrawal. The Board may terminate the appointment of the custodian but shall not
remove the custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in the place thereof.

Art. 25. Dissolution of the Company. The Company may be dissolved by anticipation by a resolution of the general

meeting of shareholders. Decision to dissolve the Company, except as provided in the following paragraphs, must be
taken by a Qualified Majority.

56911

L

U X E M B O U R G

Whenever the share capital falls below two-thirds (2/3) of the minimum capital required by Luxembourg law, the

question of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the Board. The general meeting,
for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the
meeting.

The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share

capital falls below one-fourth (1/4) of the minimum capital required by Luxembourg law; in such an event, the general
meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-
fourth (1/4) of the votes of the shares represented at the meeting.

Art. 26. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or

legal entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compen-
sation.

Art. 27. Amendments to the Articles of Association. These Articles of Association may be amended by a general

meeting of shareholders subject to a Qualified Majority vote of the shareholders.

However, changes to the Designation Rights will require a quorum of the three fourth (3/4) of the share capital being

present or represented at such meeting and a positive vote of the three fourth (3/4) of the shareholders present or
represented.

In case a decision concerning changes to the Designation Rights has been adopted by the general meeting without the

required majority, the Board shall convene a new general meeting, at which the proposed resolution may be passed by
three-quarter of the votes present at the meeting, irrespective of the share capital represented.

Changes to article 4 will require an unanimous vote (100%) of the Shareholders.

Art. 28. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance

with the Law of 10 August 1915 on commercial companies and the Law of 2007 as amended."

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to grant authorisation to any one director of the Com-

pany, with single signatory power and full power of substitution to carry out any necessary action in respect of the present
resolutions in the name and on behalf of the Company.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company are

estimated at one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Signé: Franz Palludan, Piotr Czajkowski, Johan Montfort, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mai 2013. Relation GRE/2013/1921. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 13 mai 2013.

Référence de publication: 2013061334/516.
(130075744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.

Cameron Lux BRL II Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 176.143.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the eleventh day of March.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch sur Alzette.

There appeared the following:

Cameron  Lux  V  S.à  r.l.,  a  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée),  with  registered  office  at  26,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Commercial and Companies' Register under
section B number 155.711;

56912

L

U X E M B O U R G

represented by Me Cécile JAGER, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private

seal.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to incorporate by the present deed

a "société à responsabilité limitée" and to draw up the articles of association of it as follows:

Title I. - Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a "société à responsabilité limitée" which will be governed by the laws in effect and

especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on
limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as well as by
the present articles of association.

Art. 2. The denomination of the company is "CAMERON LUX BRL II SARL".

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg-Town.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lu-

xembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The
company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants do

not trigger the dissolution of the company.

Title II. - Capital - Parts

Art. 7. The capital is fixed at FORTY THOUSAND Brazilian Real (BRL 40,000.-) divided into EIGHT HUNDRED (800)

parts having a par value of FIFTY Brazilian Real (BRL 50.-) each, entirely subscribed for and fully paid up (the "Parts").

Parts may be issued with a share premium.
The issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.
The board of managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the company as issue
premiums on the issue and sale of its parts, which reserves or paid in surplus may be used by the board of managers to
provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfers of parts inter

vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of parts, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August

10, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its management as defined under Title III of the present articles of association.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

56913

L

U X E M B O U R G

Title III. - Management

Art. 10. The company is managed by a board of managers comprising at least three (3) members, whether participants

or not, who are appointed for a determined or an unlimited period of time by the sole participant or, as the case may
be, by the general meeting of the participants, which may at any time remove them.

The number of managers, their term and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case may be,

by the general meeting of the participants.

The office of a manager shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the

participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

Art. 11. The board of managers may elect from among its members a chairman.
The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It

must be convened each time two managers so request.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
The board of managers shall validly resolve on any matters if a majority of its members are present or represented.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device)
to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

Art. 12. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object of the company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the sole participant or, as the

case may be, to the general meeting of participants, fall within the competence of the board of managers.

The board of managers is authorized to proceed to the payment of interim dividends subject to the following condition

that interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient.

Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of

managers unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers
or proxies given by the board of managers pursuant to article 14 of the present articles of association.

Art. 14. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or

more persons, who need not be selected from its own members.

It may also commit the management of a special branch to one or more directors, and give special powers for deter-

mined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether Partners or not.

Art. 15. Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

company by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.

Title IV. - General meeting of participants

Art. 16. The sole participant shall exercise all the powers vested in the general meeting of the participants under section

XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by

the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one but less than twenty-five participants, decisions of participants shall be taken in a general

meeting or by written consultation at the initiative of the management.. No decision is deemed validly taken until it has
been adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

56914

L

U X E M B O U R G

Title V. - Financial year - Profits - Reserves

Art. 17. The financial year of the company starts on the first day of January and ends on the last day of December of

each year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of formation of the company and
shall terminate on the 31 

st

 of December 2013.

Art. 18. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company together

with a balance sheet and a profit and loss account will be set up.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortisation and provisions constitute

the net profit.

Five  per  cent  (5%)  out  of  this  net  profit  shall  be  appropriated  for  the  legal  reserve;  this  deduction  ceases  to  be

compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is
at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.

Art. 19. The board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time

during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the board
of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up no later
than 30 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that
sufficiently distributable profits exist.

Title VI. - Liquidation - Dissolution

Art. 20. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need

not to be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants at the
majority defined by Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

Title VII. - Varia

Art. 21. The parties refer to the Law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto for

all matters not provided for in the present articles of association.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the appearing party, declares to subscribe the whole capital

as follows:

CAMERON LUX V SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 parts

The 800 (EIGHT HUNDRED) parts have been fully paid up to in cash so that the amount in EURO equivalent to

FORTY THOUSAND Brazilian Real (BRL 40,000.-)

is as of now at the disposal of the company.

<i>Costs and valuation

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand five hundred euro
(EUR 1,500.-).

<i>Extraordinary General Meeting

After the articles of association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to

hold  an  extraordinary  general  meeting.  Having  first  verified  that  it  was  regularly  constituted,  it  passed  the  following
resolutions:

1. The registered office of the company is fixed at 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg

2. The number of managers (gérants) of the company is fixed at 4 (four).
3. The following are appointed managers (gérants) of the company:
- Mr. William C. LEMMER, born in Washington D.C. on June 6, 1944, residing professionally at 1333 West Loop South,

Houston, Texas (U.S.A.);

- Mr. Keith JENNINGS, born in Spanish Town, Jamaica, on December 28, 1969, residing professionally at 1333 West

Loop South, Suite 1700, Houston Texas 77027;

-  Mr.  Fulton  CROOS-MORAES,  born  in  Colombo,  Sri  Lanka,  on  12  October  1960,  residing  professionally  at  26,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mrs. Cécile JAGER, attorney at law, born in Metz, France, on 6 February 1977, residing professionally at 2, rue

Peternelchen, L-2370 Howald, Grand Duchy of Luxembourg.

The managers are appointed for an unlimited period of time, unless they previously resign or are revoked.

56915

L

U X E M B O U R G

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Follows the french version:

L'an deux mille treize, le onze mars.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Cameron Lux V S.à r.l., a société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449 Lu-

xembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B numéro
155.711,

représentée par Me Cécile JAGER, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous

seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne représentant le comparant susnommé et le

notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

Titre I 

er

 . - Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les
sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est CAMERON LUX BRL II SARL.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite ou l'insolvabilité de l'associé unique ou de l'un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la société.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 7. Le capital social de la société est fixé à quarante mille Real Brésiliens (BRL 40.000,-) divisé en huit cents (800)

parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante Real Brésiliens (BRL 50,-) chacune.

Les parts sociales peuvent être émises avec prime d'émission.
Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit suivant les règles légales en vigueur au Luxembourg.
Le collège de gérance pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales)

et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors de l'émission et de la vente
de ses parts sociales, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Collège de Gérance en vue du rachat de ses

56916

L

U X E M B O U R G

parts sociales par la Société ainsi que l'y autorise les présents statuts, pour compenser des moins values réalisées ou
latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l'associé unique, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul

associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs

à des tiers non-associés ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telles que modifiées.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer, de quelque manière
que ce soit, dans les actes de son administration, tel que prévu au Titre III des présents statuts.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées gé-

nérales.

Titre III. - Administration

Art. 10. La société est administrée par un collège de gérance composé de trois (3) membres au moins, associés ou

non, nommés pour une période ne pouvant dépasser six années par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée
générale des associés, qui peut les révoquer à tout moment.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'associé unique ou, selon les cas,

par l'assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d'être gérant par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste de

gérant, ou

- il tombe en faillite ou fait un arrangement ou une composition avec ses créanciers en général, ou
- il est révoqué par une résolution de l'associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l'assemblée générale des

associés.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

Art. 11. Le collège de gérance peut choisir un président parmi ses membres.
Le collège de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.

Toutes les réunions du collège de gérance se tiendront à Luxembourg.
Le collège de gérance ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les membres du collège de gérance ont la même valeur juridique que

celles prises lors d'une réunion du collège de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.

En outre, tout membre du collège de gérance prenant part aux délibérations dudit collège par tout moyen de com-

munication  (notamment  par  téléphone)  permettant  à  tous  les  autres  membres  du  collège  de  gérance  présents  (en
personne, en vertu d'une procuration, par voie téléphonique ou autre) d'entendre et d'être entendus à tout moment par
les autres membres, sera réputé être présent audit collège aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur
l'ordre du jour du collège.

Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée comme prise à Luxembourg si l'appel téléphonique

est lancé de Luxembourg.

Art. 12. Le collège de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de

disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'associé unique ou,

selon les cas, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du collège de gérance.

Le collège de gérance est autorisé à procéder au paiement des dividendes intérimaires, sous réserve que les comptes

intérimaires attestent la disponibilité de fonds suffisants pour procéder à une telle distribution.

Art. 13. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, à

moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises
par le collège de gérance conformément à l'article 14 des présents statuts.

56917

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui ne

doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance.

Il peut aussi confier la gestion d'une branche spéciale à une ou plusieurs personnes autres que des gérants, et donner

des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas
nécessairement être membres du collège de gérance ni associés.

Art. 15. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités

au nom de la société par le collège de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.

Titre IV. - Assemblée Générale des associés

Art. 16. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section

XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique ou, selon les cas, par

l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale

ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été
adoptée par des associés représentant la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V. - Année Comptable - Profits - Réserves

Art. 17. L'année sociale commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année,

sauf en ce qui concerne le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s'achèvera le 31
décembre 2013.

Art. 18. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi

qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième (10%) du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon les cas.

Art. 19. Le conseil de gérance est autorisé à procéder, autant de fois qu'il le juge opportun et à tout moment de l'année

sociale, au paiement de dividendes intérimaires, uniquement sous le respect des deux conditions suivantes: le conseil de
gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur base des comptes intérimaires
préparés au plus tard soixante (60) jours avant la date dudit conseil de gérance; les comptes intérimaires, qui pourront
ne pas avoir été audités, doivent attester qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.

Titre VI. - Liquidation - Dissolution

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 20. Les parties se rapportent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, pour tout

ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

CAMERON LUX V SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 parts

Les 800 (HUIT CENTS) parts ont été entièrement libérées en espèces de sorte que l'équivalent en EURO du montant

de QUARANTE MILLE Real Brésiliens (BRL 40.000,-)

est par conséquent à la disposition de la société à partir de ce moment.

<i>Evaluation et frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

56918

L

U X E M B O U R G

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l'associé unique prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale

extraordinaire. Après avoir vérifié qu'elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi au 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à quatre (4).
3. Ont été élus gérants de la société:
- Mr. William C. LEMMER, né à Washington le 6 juin 1944, demeurant professionnellement au 1333 West Loop South,

Houston, Texas (U.S.A.);

- Mr. Keith JENNINGS, né à Spanish Town, le 28 décembre 1969, demeurant professionnellement au 1333 West Loop

South, Suite 1700, Houston Texas 77027;

- Mr. Fulton CROOS-MORAES, né à Colombo, Sri Lanka, le 12 Octobre 1960, demeurant professionnellement au 26,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Mrs. Cécile JAGER, née à Metz, France, le 6 février 1977, demeurant professionnellement au 2 Rue Peternelchen,

L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg.

Les gérants sont nommés pour une période indéterminée à moins qu'ils n'aient préalablement démissionné ou qu'ils

n'aient été révoqués.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la mandataire de la partie comparante, es qualités qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par

nom, prénom, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la partie comparante, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de la même comparante
il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: Jager, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 mars 2013. Relation: EAC/2013/3425. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013039824/357.
(130049386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2013.

Allimac Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 162.725.

L'an deux mille treize, le sept mars,
par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

International Future Ventures and Investments N.V., société anonyme ayant son siège social à Landhuis Joonchi, Kaya

Richard J. Beaujon z/n, Curaçao, Antilles néerlandaises,

ici représentée par Monsieur Umberto CERASI, licencié en droit, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 1 

er

 mars 2013, laquelle, signée ne varietur par le

mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société Allimac Management S.àr.l., ci-après la «Société», société à

responsabilité limitée ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 162725, constituée le 27 juillet
2011 suivant acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2351 du
3 octobre 2011.

- Tout ceci ayant été déclaré, la comparante, représentée comme dit ci-avant, détenant cent pour cent (100%) du

capital de la Société, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 400.000 (quatre cent mille euros) pour

le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 412.500 (quatre cent douze mille

56919

L

U X E M B O U R G

cinq cents euros) par la création et l'émission de 4.000 (quatre mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de
EUR 100 (cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

L'associée unique, représentée comme dit ci-avant, déclare alors souscrire aux 4.000 (quatre mille) nouvelles parts

sociales de EUR 100 (cent euros) chacune à émettre et les libérer intégralement moyennant conversion en capital d'une
créance certaine, liquide et immédiatement exigible qu'elle détient sur la Société.

Preuve de la détention et de la valeur de la créance a été donnée au notaire instrumentant au moyen d'une déclaration

des gérants.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article 6.1.1. des statuts de la

Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« 6.1.1. Le capital social est fixé à EUR 412.500 (quatre cent douze mille cinq cents euros) représenté par 4.125 (quatre

mille cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, toutes entièrement souscrites
et libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du

présent acte sont évalués à environmille cinq cents euros (EUR 1.500).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: U. CERASI, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 13 mars 2013. Relation: RED/2013/365. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 26 mars 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013039711/54.
(130049596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2013.

Phoenix III Mixed Y, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.635.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045202/10.
(130054888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix III Mixed X, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.634.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045201/10.
(130054889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix III Mixed V, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.632.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

56920

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045199/10.
(130054891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix III Mixed U, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.631.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045198/10.
(130054892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Purple Haze S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 108.459.

Conformément à la cession des parts sociales du 26 juin 2012, la société Wisley S.A., avec adresse au 11-13 Boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg, a vendu 500 parts sociales détenues dans la Société, à LUXROYAL MANAGEMENT
S.A., avec adresse au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le nouvel associé de la Société est LUXROYAL MANAGEMENT S.A. ainsi que la cession des parts sociales ont été

reportés sur le registre des associés de la Société.

Luxembourg, le 8 avril 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013045207/14.
(130054943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Prize Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.775,02.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 150.480.

Le compte consolidé du groupe au 30 septembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2013.

Pour extrait conforme
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2013045206/13.
(130054570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix III Mixed Z, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.636.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045203/10.
(130054887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

56921

L

U X E M B O U R G

Phoenix III Mixed W, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.633.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045200/10.
(130054890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix III Mixed T, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.630.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045197/10.
(130054893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Percose Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 169.383.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Percose Investments S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013045175/11.
(130055117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix II Mixed I, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 110.518.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045187/10.
(130054843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix II Mixed J, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 110.512.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045188/10.
(130054842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix II Mixed K, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 110.513.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

56922

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045189/10.
(130054841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix II Mixed M, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 110.515.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045191/10.
(130054839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Messageries du Livre S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2411 Luxembourg, 5, rue Frédérique Guillaume Raiffeisen.

R.C.S. Luxembourg B 53.763.

Monsieur Stefan TIEDCHEN, domicilié à 10, Trienendorferstrasse, D-58300 Wetter, démissionne de ses fonctions de

délégué à la gestion journalière de la s.à r.l. Messageries du Livre, 5, rue Raiffeisen, L-2411 Luxembourg avec effet au 1

er

 avril 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2013.

Christian SCHOCK
<i>Président-directeur général

Référence de publication: 2013045137/14.
(130054849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix A4 - Bredowstrasse, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 108.715.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045178/10.
(130054811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix A5 - Fritz-Erler-Strasse, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 108.716.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045179/10.
(130054810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix B1 - Niederbarnimstrasse, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 108.717.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

56923

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045180/10.
(130054809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Morote S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 20.471.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire Unique en date du 2 avril 2013

1. Les mandats d'Administrateur de:
- Mademoiselle Noëlle PICCIONE, employée privée, demeurant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086

Luxembourg,

- Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Lu-

xembourg,

- Monsieur Daniel PIERRE, employé privé, demeurant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an

2019.

2. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, ayant son siège

social au 12 rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de
6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2019.

Fait à Luxembourg, le 2 avril 2013.

Certifié sincère et conforme
MOROTE S.A., SPF
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013045145/24.
(130054984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix II Mixed N, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 110.516.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045192/10.
(130054838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix II Mixed H, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 110.517.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045186/10.
(130054845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix G1 - Emser Strasse, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 108.722.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

56924

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045184/10.
(130054805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix E1 - Buckower Damm, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 108.720.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045183/10.
(130054806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Three Hills Partners I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 119.924.

<i>Cession de parts sociales

En date du 27 Février 2013, Marco MORETTI, né le 12 Novembre 1982, resident au 45 Emperor's Gate, Londres,

Royaume-Uni SW7 4HJ, a transféré 25 parts sociales détenues dans la société THREE HILLS PARTNERS I S.à r.l.,

à Mauro MORETTI, né le 17 juillet 1981, résidant au 42 Egerton Gardens, Londres, Royaume-Uni, SW3 2BZ.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 Février 2013.

THREE HILLS PARTNERS I S.à r.l.

Référence de publication: 2013045297/14.
(130055081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Parlam Invest Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 81.337.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045210/10.
(130054780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Papilux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 125.542.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045209/10.
(130054862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Passadena S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 57.703.

Le Bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

56925

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045212/10.
(130054744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix III Mixed P, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.626.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045194/10.
(130054836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Vauban S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.001,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 134.945.

EXTRAIT

La Société a pris note de la démission de Lola Goggins en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 30 juin

2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 avril 2013.

Vauban S.A.

Référence de publication: 2013045331/14.
(130055196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

X-Change.Lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.767.

<i>Extrait du procès-verbal de la résolution de l'associé unique prise le 2 avril 2013

Il résulte du procès-verbal de la résolution de l'associé unique prise le 2 avril 2013 que:
- Le siège social est établi au 43, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg au avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2013.

Signature
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2013045347/14.
(130054601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix III Mixed Q, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.627.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045195/10.
(130054835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

56926

L

U X E M B O U R G

Phoenix D1 - Hohenstaufenstrasse, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 108.719.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045182/10.
(130054807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix A3 - Kaiser-Wilhelm-Strasse, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 108.714.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045177/10.
(130054812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Phoenix A2 - Prinzenallee, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 108.713.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013045176/10.
(130054813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

Ispat Inland S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 73.171.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013045613/9.
(130055897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

Leiton Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 99.523.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013045638/9.
(130055815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

Liftinc Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 163.717.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013045642/9.
(130055406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

56927

L

U X E M B O U R G

LKRT Finance GmbH, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 152.547.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013045643/9.
(130055568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

Lux AC Concept, Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 147.490.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013045645/9.
(130055860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

Mathey Mazout S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1141 Luxembourg, 103, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 170.977.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013045658/9.
(130055697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

UVZ International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 156.199.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013045821/9.
(130055428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

Tax &amp; Consulting Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 100, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 120.630.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013045797/9.
(130055405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

SOCIETE FINANCIERE D'ARLES Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 34.544.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013045784/9.
(130055849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

56928


Document Outline

AerCap Aviation Assets Fund Management

Allimac Management S.à r.l.

BPT Arista SA SICAV-SIF

Cameron Lux BRL II Sàrl

Devera Brownfield Fund S.A.

Ispat Inland S.A.

Leiton Holding S.A.

Liftinc Luxembourg S.A.

LKRT Finance GmbH

Lux AC Concept

Mathey Mazout S.à r.l.

Messageries du Livre S.à.r.l.

Morote S.A., SPF

Papilux

Parlam Invest Holding SPF S.A.

Passadena S.A., SPF

Percose Investments S.à r.l.

Perfeus S.A.

Phoenix A2 - Prinzenallee

Phoenix A3 - Kaiser-Wilhelm-Strasse

Phoenix A4 - Bredowstrasse

Phoenix A5 - Fritz-Erler-Strasse

Phoenix B1 - Niederbarnimstrasse

Phoenix D1 - Hohenstaufenstrasse

Phoenix E1 - Buckower Damm

Phoenix G1 - Emser Strasse

Phoenix III Mixed P

Phoenix III Mixed Q

Phoenix III Mixed T

Phoenix III Mixed U

Phoenix III Mixed V

Phoenix III Mixed W

Phoenix III Mixed X

Phoenix III Mixed Y

Phoenix III Mixed Z

Phoenix II Mixed H

Phoenix II Mixed I

Phoenix II Mixed J

Phoenix II Mixed K

Phoenix II Mixed M

Phoenix II Mixed N

Prize Holdings 1 S.à r.l.

Purple Haze S.à r.l.

SOCIETE FINANCIERE D'ARLES Spf S.A.

Tax &amp; Consulting Services

Three Hills Partners I S.à r.l.

UVZ International S.à r.l.

Vauban S.A.

X-Change.Lu S.à r.l.