logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 794

4 avril 2013

SOMMAIRE

A bis Z Gérances d'Immeubles S.à r.l. . . . .

38088

Afinis Communications S.A.  . . . . . . . . . . . .

38089

Alliance Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

38090

AMT Servilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38066

Asars Constructions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

38067

Azincour S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38067

Bella Vista Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

38071

Berbou International Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

38066

Biotechnology Ingredient Supplement S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38071

Biotoscana Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . .

38068

Biotoscana Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . .

38068

Blue Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38071

Borletti Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38070

Borletti Group Finance SCA  . . . . . . . . . . . .

38070

Bruskort International S.à.r.l.  . . . . . . . . . . .

38071

Caesar International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38099

Calpam Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

38099

Calpam Transports Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38100

Career Education Corporation Luxem-

bourg S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38080

Carta Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

38090

C. Buijsen & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38079

C&E Holdings Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

38080

Centuria Real Estate Asset Management

International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38089

Challenger Luxembourg Holding No. 1A

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38100

Challenger Luxembourg Holding No. 1B

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38101

Challenger Luxembourg Holding No. 2 S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38104

Chicama Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

38105

Cima S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38105

Cirse S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38090

Clairmont S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38106

Class Real Estate Investments S.à r.l.  . . . .

38098

Clifter S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38106

Clovis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38106

Compact Holding S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

38107

Compagnie Interoceanique pour le Trans-

port des Liquides S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38107

Conical SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38111

Crea'Plus Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38112

Credit Suisse Capital Partners (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38068

Credit Suisse Portfolio Investments (Lu-

xembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38098

Crousseilles Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

38112

Diamond Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

38072

Diamond Midco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38081

Diamond Topco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38091

Dianco Sourcing S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38101

Embrun S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38080

EPGF Finance (Luxembourg), Sàrl . . . . . . .

38081

EPGF Pliening Property S.à r.l.  . . . . . . . . . .

38081

Euro Properties Investments III S.A.  . . . . .

38107

Evraz Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38112

38065

L

U X E M B O U R G

Berbou International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8373 Hobscheid, 33, rue du Neuort.

R.C.S. Luxembourg B 99.984.

L'an deux mille treize, le neuf janvier.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Bert Bouton, administrateur de sociétés, né le 4 février 1962 à Bruges, Belgique, demeurant professionnel-

lement à L-8373 Hobscheid, Rue du Neuort 33.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'il est le seul et unique associé de la société BERBOU INTERNATIONAL S.à r.l., société à responsabilité limitée

unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 30 mars 2004, publié au Mémorial Recueil
Spécial des Sociétés et Associations numéro 541 du 25 avril 2004 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

- Qu'il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-2273 Luxembourg, 20/18, rue de l'Ouest à

L-8373 Hobscheid, rue du Neuort 33.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts comme suit:

Art. 3. (Premier alinéa). Le siège social est établi à Hobscheid.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ huit cents euros (800.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Bouton, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 janvier 2013. Relation: LAC/2013/1735. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): I. Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2013.

Référence de publication: 2013022199/34.
(130027350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

AMT Servilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4833 Rodange, 9, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 66.440.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2012:

- n'a pas renouvelé les mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Roger HENRY;
- n'a pas renouvelé le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Claude GELINOTTE;
- n'a pas renouvelé le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick HENRY;
- a renouvelé Monsieur Laurent MALISAN, né le 30 juillet 1965 à Longwy (France), demeurant à F-54 400 Cosnes-et-

Romain, 12 rue de la Maurienne, dans ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017;

- a nommé en qualité de nouvel administrateur de la société, Mademoiselle Marine MALISAN, née le 21 avril 1993 à

Mont-Saint-Martin (France), demeurant à F-54 400 Cosnes-et-Romain, 12 rue de la Maurienne, jusqu'à l'issue de l'assem-
blée générale annuelle de 2017;

- a nommé en qualité de nouvel administrateur de la société, Madame Myriam MALISAN, née le 27 juillet 1965 à Mont-

Saint-Martin (France), demeurant à F-54 400 Cosnes-et-Romain, 12 rue de la Maurienne, jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale annuelle de 2017;

38066

L

U X E M B O U R G

- a renouvelé en qualité de commissaire de la société la société à responsabilité limitée INTERAUDIT. établie et ayant

son siège social, à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.501, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2013026361/25.

(130032020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Asars Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 63.479.

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 13 février 2013 a accepté la démission de ses fonctions de réviseur d’entreprises

agréé de la société anonyme TOP Audit (anc. PKF Abax Audit S.A.), avec effet au 22 octobre 2012.

L’Assemblée a nommé en qualité de réviseur d’entreprises agréé, la société à responsabilité limitée Deloitte Audit,

avec  siège  à  L-2220  Luxembourg,  560,  rue  de  Neudorf,  immatriculée  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg sous le No B 67895.

Le mandat du réviseur d’entreprises agréé viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de

2013.

Certifié conforme
ASARS CONSTRUCTIONS S.A R.L.
Société à responsabilité limitée
Rahim AGAAJANI
<i>Gérant

Référence de publication: 2013026369/21.

(130032424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Azincour S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 121.120.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 29 juin 2012

1. Le mandat du commissaire aux comptes, la société à responsabilité limitée Kohnen &amp; Associés S.à r.l., R.C.S. Lu-

xembourg B114190, avec siège social à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la liberté, a été renouvellé jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale statutaire de 2016.

2. Le mandat d’administrateur et de président du conseil d’administration, Monsieur Jean FELL, a été renouvellé jusque

à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2016.

3. Le mandat d’administrateur, Monsieur Cornelius BECHTEL, a été renouvellé jusque à l’issue de l’assemblée générale

statutaire de 2016.

4. Le mandat d’administrateur, Madame Christine SCHWEITZER, a été renouvellé jusque à l’issue de l’assemblée

générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 22 février 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AZINCOUR S.A.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2013026372/21.

(130032359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

38067

L

U X E M B O U R G

Biotoscana Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.840.

EXTRAIT

Il résulte du transfert de parts réalisé en date du 08 novembre 2011 que la société Biotoscana Seamar Family Luxco

S.à r.l., transfère 3, 500, 000 parts sociales qu’elle détient dans la Société de la façon suivante;

2,  800,  000  parts  sociales  à  Advent  Cartagena  (Luxembourg)  Holding  S.à  r.l.,  une  société  à  responsabilité  limitée

constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 162.821,

634, 375 parts sociales à Essex Woodlands Health Ventures Fund VIII, LP, une société à responsabilité limitée constituée

et régie selon les lois du Delaware aux Etats-Unis, ayant son siège social au c/o Capitol Services, Inc. 615 S Dupont Hwy,
DE 19901 Dover, Etats-Unis d’Amérique, immatriculée auprès du Delaware Division of Corporations sous le numéro
4501534,

45, 739 parts sociales à Essex Woodlands Health Ventures Fund VIII-A, LP, une société à responsabilité limitée con-

stituée et régie selon les lois du Delaware aux Etats-Unis, ayant son siège social au c/o Capitol Services, Inc. 615 S Dupont
Hwy Dover, DE 19901 Dover, Etats-Unis d’Amérique, immatriculée auprès du Delaware Division of Corporations sous
le numéro 4502695, et

19, 886 parts sociales à Essex Woodlands Health Ventures Fund VIII-B, LP, a une société à responsabilité limitée

constituée et régie selon les lois du Delaware aux Etats-Unis, ayant son siège social au c/o Capitol Services, Inc. 615 S
Dupont Hwy Dover, DE 19901 Dover, Etats-Unis d’Amérique, immatriculée auprès du Delaware Division of Corpora-
tions sous le numéro 4628338,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2013.

Référence de publication: 2013026375/28.
(130032073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Biotoscana Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.840.

EXTRAIT

Il résulte d’une décision des associés en date du 15 octobre 2012;
D’accepter la démission de Monsieur Diego Pablo Seresbrisky Solano et de Monsieur Andres Marulanda Bernal avec

effet immédiat;

et
De nommer en tant que gérants de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée illimitée:
Monsieur Jose Mauricio Salgar Hurtado, né le 28 janvier 1970 à Bogota, Colombie, résidant professionnellement au

82, Avenida Calle, Oficina 902, Bogota, DC, Colombie; et

Monsieur Luiz Otavio Riberio, né le 11 avril 1984 à Montes Claros, Minas Gerais, Brésil, résidant professionnellement

au 82, Avenida Calle, Oficina 902, Bogota, DC, Colombie

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2013.

Référence de publication: 2013026376/19.
(130032257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Credit Suisse Capital Partners (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 140.897.

In the year two thousand and twelve, on the tenth day of October.
Before Us M 

e

 Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

38068

L

U X E M B O U R G

"Credit Suisse Alzette Holdings (Luxembourg) S.à r.l.", a company incorporated under the laws of Luxembourg, having

its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Register of Commerce and
Companies in Luxembourg under number B 143709

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder

and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, through its mandatory, has declared and requested the officiating notary to act the following:
- That the private limited liability company "Credit Suisse Capital Partners (Luxembourg) S.à r.l.", (the "Company"),

established and having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, inscribed in the Trade and
Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 140.897,

has been incorporated under the name of CREDIT SUISSE ISSUER 1 FINANCE (LUXEMBOURG) S.à r.l., by a deed

of M e Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on the 21 

st

 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, number 2054, on the 25 August 2008,

whose articles have been amended by deed of M e Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, on the 13 

th

of May 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 1749 on the 2 

nd

 of August

2011.

- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that it has

taken, through its mandatory, the following resolution:

<i>Resolution

The general meeting decides to change the last sentence of article 17 of the bylaws as follows:

« Art. 17. (Last sentence). The Board of Managers is duly authorized to pay interim and annual dividends."

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred Euro.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Junglinster at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed together with Us, the notary, the present
deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le dix octobre.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

"Credit Suisse Alzette Holdings (Luxembourg) S.à r.l.", une société constituée sous les lois du Grand-Duché de Lu-

xembourg ayant son siège social au L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143709

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Lu-

xembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par

le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter les suivant:
- Que la société à responsabilité limitée "Credit Suisse Capital Partners (Luxembourg) S.à r.l.", ", établie et ayant son

siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 140897,

a été constituée originairement sous la dénomination de CREDIT SUISSE ISSUER 1 FINANCE (LUXEMBOURG) S.à

r.l. suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 2008 et
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2054, page 98546, le 25 août 2008

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 13 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1749 du 2 août 2011.

38069

L

U X E M B O U R G

- Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule associée actuelle de la Société et qu'elle a

pris, par son mandataire, la résolution suivante:

<i>Résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dernière phrase de l'article 17 des statuts comme suit:

« Art. 17. (Dernière phrase). Le Conseil de gérance est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur divi-

dendes."

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 octobre 2012. Relation GRE/2012/3870. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2013022226/82.
(130027204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

Borletti Group, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 120.572.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée tenue le 5 février 2013.

<i>Résolution:

Le mandat du réviseur d'entreprises agrée venant à échéance, l'assemblée décidé de renouveler le mandat de HRT

Révision S. A, avec siège social à 163, rue Kiem, L-8030 Strassen, jusqu'au l'assemblée qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 février 2013.

Référence de publication: 2013026378/14.
(130032450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Borletti Group Finance SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 144.123.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion d'assemblée tenue le 5 février 2013.

<i>Résolution:

Le mandat du réviseur d'entreprises agrée venant à échéance, l'assemblée décidé de renouveler le mandat de HRT

Révision S. A, avec siège social à 163, rue Kiem, L-8030 Strassen, jusqu'au l'assemblée qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 février 2013.

Référence de publication: 2013026379/14.
(130032449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

38070

L

U X E M B O U R G

Bella Vista Finance S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 157.415.

Nous, FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A., domiciliataire de la société BELLA VISTA FINANCE S.A., inscrite au Re-

gistre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B-157.415, confirmons que le siège social de
ladite société au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, est dénoncé à compter du 21 février 2013, et que par
conséquent la convention de domiciliation conclue entre les sociétés FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A. et BELLA VISTA
FINANCE S.A. est résiliée d’office à cette date.

Luxembourg, le 21 février 2013.

<i>Pour les démissionnaires
FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A.

Référence de publication: 2013026386/14.
(130032021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Biotechnology Ingredient Supplement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 67.286.

L’Institut Domiciliataire, Comptabilité Générale et Eurolation Sàrl, dénonce avec effet immédiat, ce 19 février 2013,

le siège social de la société BIOTECHNOLOGY INGREDIENT SUPPLEMENT S.à R.L., inscrite au R.C.S. Luxembourg
sous B numéro 67 286 et ayant son siège social au 43, Route d’Arlon L-8009 Strassen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Comptabilité Générale et Eurolation Sàrl
Représentée par Willem VAN CAUTER
<i>Gérant

Référence de publication: 2013026391/13.
(130032540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Blue Alpha, Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 174.526.

<i>Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale tenue le 20 décembre 2012

L ’Assemblée a adopté les résolutions suivantes:
- Accepte la démission de MULLERBACH INC de ses mandats d'administrateur &amp; administrateur-délégué.
- Nomme 3 nouveaux administrateurs:
* Thierry CALLAULT, né le 13/12/1961 à Draveil, et domicilié au 64 rue de Rennes à F-75006 PARIS (France)
* Guillaume LAUNAY, né le 30/11/1961 à Maison-Lafitte, et domicilié au 64 rue de Rennes à F-75006 PARIS (France)
* Sébastien GRASSET, né le 17/08/1981 à Villecresne, et domicilié au 15 rue Ernest Renan à F-93400 Saint Ouen

(France)

- Nomme 2 nouveaux administrateurs-délégués:
* Thierry CALLAULT, né le 13/12/1961 à Draveil, et domicilié au 64 rue de Rennes à F-75006 PARIS (France)
* Guillaume LAUNAY, né le 30/11/1961 à Maison-Lafitte, et domicilié au 64 rue de Rennes à F-75006 PARIS (France)
Ces nominations prennent effet dès ce jour et jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2017.

Mr Thierry CALLAULT / Mr Guillaume LAUNAY
<i>Président / Secrétaire

Référence de publication: 2013026392/21.
(130031997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Bruskort International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.345.

En date du 29 décembre 2012, la société anonyme SERINOR S.A a cédé ses 2.929 parts sociales de la société à

responsabilité limitée BRUSKORT INTERNATIONAL S.à.r.l. à la société anonyme MJB S.A., enregistrée sous le numéro

38071

L

U X E M B O U R G

10375/1996 auprès du Registre des Sociétés de Fribourg (Suisse), avec siège social à CH-1700 Fribourg (Suisse), 7, bou-
levard de Pérolles.

Nouvelle situation associées:
BRUSKORT S.L.: 11.875 parts sociales
MJB S.A.: 2.929 parts sociales
Palm Hotel Ventures, LLC: 4.465 parts sociales
BRUSKORT INTERNATIONAL S.à.r.l.: 3.053 parts sociales

Luxembourg, le 22 février 2013.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BRUSKORT INTERNATIONAL S.à.r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013026393/20.
(130032451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Diamond Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 175.115.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the first day of the month of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Diamond Mezzco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited company), governed by the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifteen thousand Pound Sterling (GBP 15,000) and registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) of Luxembourg under number B172.139,

represented by Mr Joe Zeaiter, juriste, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 29 January 2013, which shall

be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of incorporation of a limited liability company Diamond Holdco S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Diamond Holdco

S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly

in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

38072

L

U X E M B O U R G

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand Pound Sterling (GBP 15,000.-)

represented seven hundred fifty (750) shares with a nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be

shareholders.

The sole manager or as the case may be the board of managers is vested with the broadest powers to manage the

business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers. Vis-à-vis third parties
the sole manager or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the
Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not
reserved by law or the articles of association to the general meeting or as may be provided herein.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid

38073

L

U X E M B O U R G

or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by

the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-

scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to

become a shareholder of the Company.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31st December of the

same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December

2013.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

38074

L

U X E M B O U R G

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial com-

panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Subscription and Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has

subscribed and entirely paid-up the following shares:

Subscriber

Number

of shares

Subscription

price (GBP)

Diamond Mezzco S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

GBP 15,000.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

GBP 15,000.-

Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the

articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:

- BRE/Management 6 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at

2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 164.777.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal
knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the

English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, am ersten Tag des Monats Februar,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen,

Diamond Mezzco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen

Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftska-
pital von fünfzehntausend Pfund Sterling (GBP 15.000,-) und eingetragen im luxemburgischem registre de commerce et
des société (Handelsregister) unter der Nummer B 172.139.

hier vertreten durch Herr Joe Zeaiter, juriste, mit Wohnsitz in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht

vom 29. Januar 2013, welche vorliegender Urkunde beigefügt um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht
zu werden.

Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-

satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Diamond Holdco S.à r.l." (société à responsabilité limitée) wie folgt
zu beurkunden.

38075

L

U X E M B O U R G

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

"Diamond Holdco S.à r.l." wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als
Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende lu-
xemburgische Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung des Gesellschaftportfolios.

Die Gesellschaft kann Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft di-

rekte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört,
in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-

bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und

Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,

durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Veränderung
der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxembourg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-

schäftsführung innerhalb der Stadtgemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-

liche  politische,  wirtschaftliche  oder  soziale  Ereignisse  eingetreten  sind  oder  unmittelbar  bevorstehen  welche  die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem  Sitz  und  Personen  im  Ausland  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  bis  zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das herausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfzehntausend Pfund

Sterling (GBP 15.000,-), eingeteilt in siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je zwanzig
Pfund Sterling (GBP 20,-).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss des/der Gesellschafter(s) in der für die Veränderung

der Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Ge-
sellschaftsanteile durch Beschluss des/der Gesellschafter(s) zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz

nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer

die keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit der weitestreichenden Macht ausgestattet,

das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem Gegenstand
der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich
per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich
der Geschäftsführung beziehungsweise der Gesellschaftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung (im Falle einer Geschäftsführung) die weites-

treichende Macht um in allen Lagen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Lagen, jeden Akt
und jede Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzge-
bung im Kompetenzbereich der Gesellschafter liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzu-
heißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und

abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-

38076

L

U X E M B O U R G

führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen

zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Per-
sonen sich hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz
oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe
dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den
Sitzungen  ohne  Einschränkung  der  Anzahl  der  Vollmachten  durch  einen  anderen  Geschäftsführer,  der  hierzu  bevoll-
mächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung

mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig

abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers im Falle eines alleinigen Geschäftsführers

und durch die Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft
ist in jedem Fall wirksam durch die Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, oder
im Falle einer Geschäftsführung, einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich

haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen sind unterworfen jede Person, die ein Verwaltungsratsmit-

glied oder leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, soll von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten,
Umfang gegen Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt
wurden in Verbindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen,
dass er ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten
Beträge oder von durch deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden.

Die Begriffe „Klage", „Streitsache", „Prozess" oder „Verfahren" finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen,

Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel)
Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit" und „Ausgaben" beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozess-
kosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Verwaltungsratsmitglied oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihre Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen

Delikten, Bösgläubigkeit, grober Vernachlässigung oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in seiner Amts-
führung enthalten sind;

(ii) in (Straf-)Verfahren in denen das Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte aufgrund eines Verstoßes,

Bösgläubigkeit oder nicht im Interesse der Gesellschaft gehandelt zu haben, verurteilt wurde.

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder

vom Verwaltungsrat genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das

Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der
Erben,  Testamentsvollstreckern  und  Verwaltern  einer  solchen  Person  dienen.  Nichts  hierin  Enthaltenes  berührt  die
Rechte zur Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Verwaltungsratsmitglieder und leitende Ange-
stellte Anspruch haben könnten aufgrund von Vertrag oder anderweitig durch Gesetz.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder

Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Verwaltungsratsmitglieds vorgestreckt
werden, um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schad-
loshaltung unter diesem Artikel hat.

38077

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl

seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-

schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, in Gesellschafterversammlungen oder
durch Zirkularbeschlüsse (soweit dies gesetzlich möglich ist), gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafter-
versammlung der Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der
Gesellschafter der Gesellschaft.

Die Einberufung der Sitzung durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage vor der

Sitzung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft eingetragene
Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung ohne vor-
herige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses

mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Brief übersandt. Der Beschluss wird wirksam bei Zustimmung der vom
Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung der
Mehrheitsvoraussetzungen, an Tag dieser Urkunde). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können jederzeit ohne vorherige
Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nicht anders vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-

schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte der Geschäftsanteile vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen

Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember

eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. De-
zember 2013 enden.

Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die

Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich

vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-

schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet

werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.

Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-

datoren,  bei  welchen  es  sich  nicht  um  Gesellschafter  handeln  muss,  zwecks  der  Durchführung  der  Auflösung  und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.

Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern die Gesellschaft nur aus einem (1) Gesellschafter besteht, gilt Artikel 179(2) des

Gesetzes und u.a. die Artikel 200-1 und 200-2 finden Anwendung. In einem solchen Fall übt der alleinige Gesellschafter
alle Befugnisse aus, welche auch der Gesellschafterversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten

sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes.

38078

L

U X E M B O U R G

<i>Zeichnung und Zahlung

Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt

eingezahlt und gezeichnet:

Einzahler

Zahl der

Geschäftsanteile

Einzahlungspreis

(GBP)

Diamond Mezzco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

GBP 15.000.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

GBP 15.000.-

Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden ungefähr EUR 1.200,- betragen.

<i>Ausserordentliche Beschlüsse des Gesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der

Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:

-  BRE/Management  6  S.A.,  eine  Aktiengesellschaft  (société  anonyme)  luxemburgischen  Rechts  mit  Sitz  in  2-4,  rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 164.777.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-

nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-

schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach

Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: J. ZEAITER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 février 2013. Relation: LAC/2013/5669. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 13. Februar 2013.

Référence de publication: 2013022254/410.
(130027248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

C. Buijsen &amp; Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 159.206.

DISSOLUTION

<i>Extrait du Rapport de l'Assemblée générale extraordinaire des associés de C. Buijsen &amp; Cie

L’assemblée des associés est tenue, extraordinairement, au siège social en date du 22 février 2013 à 11 heures.

<i>Résolutions

1. L’Assemblée approuve la liquidation volontaire de la société C. Buijsen &amp; Cie. A ce jour la société est donc dissoute

et liquidée.

2. L’Assemblée approuve que les livres comptables et documents sociaux de la société seront conservés à l’adresse

suivante : 5, rue Prince Jean L-4740 Pétange et ce pour une durée minimale de cinq ans.

Toutes les résolutions sont prises à l’unanimité des voix.
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 heures après signature du présent procès-

verbal par les membres du bureau.

Christel Buijsen / Geoffroy Steyt.

Référence de publication: 2013026394/19.
(130032357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

38079

L

U X E M B O U R G

C&amp;E Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 148.895.

<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 20 février 2013

1. Monsieur Michael L. GRAVELLE a démissionné de son mandat de gérant de type A.

2. Monsieur Michael Peter OATES, administrateur de sociétés, né à Maryland (Etats-Unis d’Amérique), le 14 mars

1960, demeurant professionnellement à FL 32204 Jacksonville (Etats-Unis d’Amérique), 601, Riverside Avenue, Tower
Bldg., 12 

ème

 étage, a été nommé gérant de type A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 22 février 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour C&amp;E Holdings Luxembourg
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013026395/16.

(130032533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Career Education Corporation Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 600.000,00.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 92.215.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique

Il résulte des résolutions de l'actionnaire signées le 31 décembre 2012 que:

L'actionnaire prend note de la démission de M. Freddy DIEBOLD.

L'actionnaire décide de la nomination d'un nouveau gérant de classe B, pour une durée indéterminée:

- Monsieur Sébastien PAUCHOT, né le 1 

er

 mars 1976, à Paris (F), avec adresse professionnelle à 208 Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg.

L'actionnaire confirme que les mandats de gérant de Colleen O'Sullivan (gérant A), Kenneth R. Zilch (gérant A) et Kuy

Ly ANG (gérant B) restent valides.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Valérie CZAPLA-STOEHR.

Référence de publication: 2013026396/18.

(130032517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Embrun S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 18.923.

<i>Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d’administration du 28 décembre 2012 tenue au siège social de la société

Le conseil a accepté la démission de Monsieur Serge Cammaert de son poste d’administrateur.

En remplacement, le conseil a nommé la société BIA S.A., dont le siège social est situé à L – 1150 Luxembourg, route

d’Arlon, 287, immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B 93879.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013026484/12.

(130032504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

38080

L

U X E M B O U R G

EPGF Finance (Luxembourg), Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 83.465.

Le nom de Madame Anne-Marie PHIPPS, gérante de la société EPGF Finance (Luxembourg) S.à r.l. , a été modifié en

Madame Anne-Marie KIDD.

Référence de publication: 2013026486/10.
(130032419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

EPGF Pliening Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.012.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 166.316.

Le nom de Madame Anne-Marie PHIPPS, gérante de la société EPGF Pliening Property S.à r.l., a été modifié en Madame

Anne-Marie KIDD.

Référence de publication: 2013026487/10.
(130032413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Diamond Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 175.113.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the fisrt day of the month of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Diamond Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited company), governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg and having its registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, having a share capital of fifteen thousand Pound Sterling (GBP 15,000.-) and not yet registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) of Luxembourg,

represented by Mr Joe Zeaiter, juriste, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 1 February 2013, which shall

be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of incorporation of a limited liability company Diamond Midco S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Diamond Midco S.à

r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly

in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

38081

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand Pound Sterling (GBP 15,000.-)

represented seven hundred fifty (750) shares with a nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20,-) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be

shareholders.

The sole manager or as the case may be the board of managers is vested with the broadest powers to manage the

business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers. Vis-à-vis third parties
the sole manager or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the
Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not
reserved by law or the articles of association to the general meeting or as may be provided herein.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of

38082

L

U X E M B O U R G

any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by

the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-

scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to

become a shareholder of the Company.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December

2013.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

38083

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial com-

panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Subscription and Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has

subscribed and entirely paid-up the following shares:

Subscriber

Number

of shares

Subscription

price (GBP)

Diamond Topco S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 GBP 15,000.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 GBP 15,000.-

Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the

articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:

- BRE/Management 6 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at

2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 164.777,

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal
knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the

English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am ersten Tag des Monats Februar,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen,

Diamond Topco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen

Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschafts-

38084

L

U X E M B O U R G

kapital von fünfzehn tausend Pfund Sterling (GBP 15.000,-) und noch nicht im luxemburgischem registre de commerce et
des société (Handelsregister) eingetragen.

hier vertreten durch Herr Joe Zeaiter, juriste, mit Wohnsitz in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht

vom 1. Februar 2013, welche vorliegender Urkunde beigefügt um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht
zu werden.

Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-

satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Diamond Midco S.à r.l." (société à responsabilité limitée) wie folgt
zu beurkunden.

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

"Diamond Midco S.à r.l." wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als
Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende lu-
xemburgische Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung des Gesellschaftportfolios.

Die Gesellschaft kann Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft di-

rekte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört,
in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-

bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und

Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,

durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Veränderung
der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxembourg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-

schäftsführung innerhalb der Stadtgemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-

liche  politische,  wirtschaftliche  oder  soziale  Ereignisse  eingetreten  sind  oder  unmittelbar  bevorstehen  welche  die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem  Sitz  und  Personen  im  Ausland  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  bis  zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das herausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfzehntausend Pfund

Sterling (GBP 15.000,-), eingeteilt in siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je zwanzig
Pfund Sterling (GBP 20,-).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss des/der Gesellschafter(s) in der für die Veränderung

der Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Ge-
sellschaftsanteile durch Beschluss des/der Gesellschafter(s) zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz

nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer

die keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit der weitestreichenden Macht ausgestattet,

das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem Gegenstand
der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich

38085

L

U X E M B O U R G

per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich
der Geschäftsführung beziehungsweise der Gesellschaftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung (im Falle einer Geschäftsführung) die weites-

treichende Macht um in allen Lagen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Lagen, jeden Akt
und jede Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzge-
bung im Kompetenzbereich der Gesellschafter liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzu-
heißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und

abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen

zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Per-
sonen sich hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz
oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe
dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den
Sitzungen  ohne  Einschränkung  der  Anzahl  der  Vollmachten  durch  einen  anderen  Geschäftsführer,  der  hierzu  bevoll-
mächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung

mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig

abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers im Falle eines alleinigen Geschäftsführers

und durch die Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft
ist in jedem Fall wirksam durch die Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, oder
im Falle einer Geschäftsführung, einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich

haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen sind unterworfen jede Person, die ein Verwaltungsratsmit-

glied oder leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, soll von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten,
Umfang gegen Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt
wurden in Verbindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen,
dass er ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten
Beträge oder von durch deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden.

Die Begriffe „Klage", „Streitsache", „Prozess" oder „Verfahren" finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen,

Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel)
Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit" und „Ausgaben" beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozess-
kosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Verwaltungsratsmitglied oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen

Delikten, Bösgläubigkeit, grober Vernachlässigung oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in seiner Amts-
führung enthalten sind;

(ii) in (Straf-)Verfahren in denen das Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte aufgrund eines Verstoßes,

Bösgläubigkeit oder nicht im Interesse der Gesellschaft gehandelt zu haben, verurteilt wurde.

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder

vom Verwaltungsrat genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das

Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der
Erben,  Testamentsvollstreckern  und  Verwaltern  einer  solchen  Person  dienen.  Nichts  hierin  Enthaltenes  berührt  die

38086

L

U X E M B O U R G

Rechte zur Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Verwaltungsratsmitglieder und leitende Ange-
stellte Anspruch haben könnten aufgrund von Vertrag oder anderweitig durch Gesetz.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder

Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Verwaltungsratsmitglieds vorgestreckt
werden, um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schad-
loshaltung unter diesem Artikel hat.

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl

seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-

schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, in Gesellschafterversammlungen oder
durch Zirkularbeschlüsse (soweit dies gesetzlich möglich ist), gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafter-
versammlung der Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der
Gesellschafter der Gesellschaft.

Die Einberufung der Sitzung durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage vor der

Sitzung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft eingetragene
Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung ohne vor-
herige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses

mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Brief übersandt. Der Beschluss wird wirksam bei Zustimmung der vom
Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung der
Mehrheitsvoraussetzungen, an Tag dieser Urkunde). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können jederzeit ohne vorherige
Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nicht anders vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-

schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte der Geschäftsanteile vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen

Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember

eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. De-
zember 2013 enden.

Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die

Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich

vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-

schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet

werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.

Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-

datoren,  bei  welchen  es  sich  nicht  um  Gesellschafter  handeln  muss,  zwecks  der  Durchführung  der  Auflösung  und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.

38087

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern die Gesellschaft nur aus einem (1) Gesellschafter besteht, gilt Artikel 179(2) des

Gesetzes und u.a. die Artikel 200-1 und 200-2 finden Anwendung. In einem solchen Fall übt der alleinige Gesellschafter
alle Befugnisse aus, welche auch der Gesellschafterversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten

sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes.

<i>Zeichnung und Zahlung

Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt

eingezahlt und gezeichnet:

Einzahler

Zahl der

Geschäftsanteile

Einzahlungspreis

(GBP)

Diamond Topco S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

GBP 15.000,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

GBP 15.000,-

Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden ungefähr EUR 1.200,- betragen.

<i>Ausserordentliche Beschlüsse des Gesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der

Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:

- BRE/Management 6 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 164.777.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-

nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-

schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach

Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: J. ZEAITER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 février 2013. Relation: LAC/2013/6089. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 13. Februar 2013.

Référence de publication: 2013022255/410.
(130027216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

A bis Z Gérances d'Immeubles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 94.620.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution de société, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 31 janvier 2013, numéro 2013/0226 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 12 février 2013, relation: CAP/2013/487
de la société à responsabilité limitée "A bis Z Gérances d'Immeubles S.à r.l.", avec siège social à L-4306 Esch-sur-Alzette,
97, rue Michel Rodange, inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro B 94 620, constituée sous la dénomination de
«PROMOTEURS ASSOCIES - GERANCE, S.à r.l.» suivant acte reçu par Maître Aloyse BIEL, alors notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, en date du 4 juillet 2003, publié au Mémorial C numéro 900 du 3 septembre 2003, ce qui suit:

- Messieurs Fabrizio BEI et Christian FASSBINDER, seuls associés, ont déclaré procéder à la dissolution et à la liqui-

dation de la société prédite, avec effet à compter du 31 décembre 2012,

38088

L

U X E M B O U R G

- la société dissoute n'a plus d'activités.
- les associés ont déclaré en outre que la liquidation de la prédite société a été achevée et qu'ils assument tous les

éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à l'adresse

suivante: L-4492 Soleuvre, 2G, rue Scheierhaff.

Bascharage, le 21 février 2013.

Pour extrait conforme
Alex WEBER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2013026327/26.
(130032318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Afinis Communications S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 95.745.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 21 janvier 2013

- Le Conseil d’administration accepte la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Iftah Amit, administrateur

de société, demeurant, 8, Hanagar Street à 4501309 Hod Hasharon (Israel).

- Le Conseil d’administration nomme en remplacement Monsieur Mordecai Schreiber, administrateur de sociétés,

demeurant, 8, Hanagar Street à 4501309 Hod Hasharon (Israel). Son mandat se terminera le 2 août 2018.

Luxembourg, le 21 janvier 2013.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013026328/15.
(130032355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Centuria Real Estate Asset Management International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 96.465.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 février 2013

L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
- L'assemblée générale a décidé d'accepter les démissions de:
* Monsieur Emmanuel Limido, né le 5 janvier 1959 à Paris, ayant son adresse professionnelle au 10, Avenue de Friedland,

F-75008 Paris, en qualité d'Administrateur et Président, avec effet immédiat;

* ICE (Internal Control Expertise), Société Anonyme, ayant son siège social au 2, Rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg

et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-130213, dont le
représentant permanent est monsieur Jean-Noël Lequeue, né le 18 décembre 1946 à Lincent (Belgique), ayant son adresse
professionnelle au 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 janvier 2013.

- Par ailleurs l'assemblée générale a décidé de nommer à compter du 1 

er

 janvier 2013:

* Monsieur Jean-Noël Lequeue, né le 18 décembre 1946 à Lincent (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 2,

rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, en qualité d'Administrateur de la société Centuria Real Estate Asset Management
International S.A.

Son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels au 31 dé-

cembre 2012 et qui se tiendra en l'année 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2013.

<i>Pour Centuria Real Estate Asset Management International S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013026398/27.
(130032321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

38089

L

U X E M B O U R G

Alliance Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 172.411.

EXTRAIT

Suite à la dissolution intervenue le 24 Décembre 2012 de LH investments Sàrl, ayant son siège social au 47, rue

Grünewald, L-1646 Senningerberg, la répartition du capital de la société Alliance Services Sàrl est la suivante à partir du
24 Décembre 2012:

Madame Anick Martine Hung Kwok Choi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

Monsieur Bishen Jacmohone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 parts

Monsieur Rui Avelino Fernandes da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 parts

TOTAL: CENT parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Martine Hung Kwok Choi
<i>Gérante

Référence de publication: 2013026332/20.
(130031905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Carta Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 175.331.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 24 janvier 2013:
- Ancienne situation associées:
Intertrust (Luxembourg) S.A.: 12.500 parts sociales
- Nouvelle situation associées:

Parts

sociales

The Summerville Unit Trust, un trust, agissant par son trustee Cidel Trust Services Inc., une corporation,
ayant son siège social au R.G. Hodge Plaza, 3 

ème

 Etage, Wickams Cay 1, Road Town, Tortola

(Iles Vierges Britanniques), enregistrée auprès du Registre des sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le
numéro 635739. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Luxembourg, le 21 février 2013.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Carta Investments S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013026397/22.
(130031862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Cirse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 160.986.

EXTRAIT

Par résolution écrite de l'associé unique en date du 19 février 2013, l'associé unique a décidé d'adopter les résolutions

suivantes:

1. La démission de Monsieur Olivier Dorier de son mandat de gérant a été acceptée par l'associé unique.
2. La démission de Monsieur Stewart Kam-Cheong de son mandat de gérant a été acceptée par l'associé unique.

38090

L

U X E M B O U R G

3. Monsieur Christophe Gaul, né le 3 Avril 1977 à Messancy, Belgique, avec adresse professionnelle au 17, rue des

Jardiniers, L-1835 Luxembourg, a été nommé en tant que gérant de la société avec effet immédiat et pour une durée
illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2013026399/20.
(130032066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Diamond Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 175.111.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the first day of the month of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

UK Logistics Topco I S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited company), governed by the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifteen thousand Pound Sterling (GBP 15,000.-) and registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) of Luxembourg under number B 166.408,

represented by Mr Joe Zeaiter, juriste, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 29 January 2013, which shall

be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of incorporation of a limited liability company Diamond Topco S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Diamond Topco

S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly

in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary

38091

L

U X E M B O U R G

transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand Pound Sterling (GBP 15,000.-)

represented seven hundred fifty (750) shares with a nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20,-) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be

shareholders.

The sole manager or as the case may be the board of managers is vested with the broadest powers to manage the

business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers. Vis-à-vis third parties
the sole manager or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the
Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not
reserved by law or the articles of association to the general meeting or as may be provided herein.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

38092

L

U X E M B O U R G

(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by

the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-

scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to

become a shareholder of the Company.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December

2013.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

38093

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial com-

panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Subscription and Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has

subscribed and entirely paid-up the following shares:

Subscriber

Number

of shares

Subscription

price (GBP)

UK Logistics Topco I S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 GBP 15,000.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 GBP 15,000.-

Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the

articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:

- BRE/Management 6 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at

2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 164.777,

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal
knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the

English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am ersten Tag des Monats Februar,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen,

UK Logistics Topco I S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxembur-

gischen  Rechts  mit  Sitz  in  2-4  rue  Eugène  Ruppert,  L-2453  Luxembourg,  Großherzogtum  Luxemburg,  mit  einem
Gesellschaftskapital von fünfzehntausend Pfund Sterling (GBP 15.000,-) und eingetragen im luxemburgischem registre de
commerce et des société (Handelsregister) unter der Nummer B 166.408.

hier vertreten durch Herr Joe Zeaiter, juriste, mit Wohnsitz in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht

vom 29. Januar 2012, welche vorliegender Urkunde beigefügt um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht
zu werden.

Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-

satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Diamond Topco S.à r.l." (société à responsabilité limitée) wie folgt
zu beurkunden.

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

"Diamond Topco S.à r.l." wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als
Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende lu-
xemburgische Gesetzgebung geregelt.

38094

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung des Gesellschaftportfolios.

Die Gesellschaft kann Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft di-

rekte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört,
in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-

bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und

Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,

durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Veränderung
der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxembourg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-

schäftsführung innerhalb der Stadtgemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-

liche  politische,  wirtschaftliche  oder  soziale  Ereignisse  eingetreten  sind  oder  unmittelbar  bevorstehen  welche  die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem  Sitz  und  Personen  im  Ausland  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  bis  zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das herausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfzehntausend Pfund

Sterling (GBP 15.000,-), eingeteilt in siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je zwanzig
Pfund Sterling (GBP 20,-).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss des/der Gesellschafter(s) in der für die Veränderung

der Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Ge-
sellschaftsanteile durch Beschluss des/der Gesellschafter(s) zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz

nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer

die keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit der weitestreichenden Macht ausgestattet,

das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem Gegenstand
der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich
per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich
der Geschäftsführung beziehungsweise der Gesellschaftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung (im Falle einer Geschäftsführung) die weites-

treichende Macht um in allen Lagen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Lagen, jeden Akt
und jede Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzge-
bung im Kompetenzbereich der Gesellschafter liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzu-
heißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und

abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen

zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Per-

38095

L

U X E M B O U R G

sonen sich hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz
oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe
dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den
Sitzungen  ohne  Einschränkung  der  Anzahl  der  Vollmachten  durch  einen  anderen  Geschäftsführer,  der  hierzu  bevoll-
mächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung

mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig

abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers im Falle eines alleinigen Geschäftsführers

und durch die Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft
ist in jedem Fall wirksam durch die Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, oder
im Falle einer Geschäftsführung, einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich

haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen sind unterworfen jede Person, die ein Verwaltungsratsmit-

glied oder leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, soll von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten,
Umfang gegen Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt
wurden in Verbindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen,
dass er ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten
Beträge oder von durch deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden.

Die Begriffe „Klage", „Streitsache", „Prozess" oder „Verfahren" finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen,

Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel)
Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit" und „Ausgaben" beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozess-
kosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Verwaltungsratsmitglied oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen

Delikten, Bösgläubigkeit, grober Vernachlässigung oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in seiner Amts-
führung enthalten sind;

(ii) in (Straf-)Verfahren in denen das Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte aufgrund eines Verstoßes,

Bösgläubigkeit oder nicht im Interesse der Gesellschaft gehandelt zu haben, verurteilt wurde.

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder

vom Verwaltungsrat genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das

Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der
Erben,  Testamentsvollstreckern  und  Verwaltern  einer  solchen  Person  dienen.  Nichts  hierin  Enthaltenes  berührt  die
Rechte zur Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Verwaltungsratsmitglieder und leitende Ange-
stellte Anspruch haben könnten aufgrund von Vertrag oder anderweitig durch Gesetz.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder

Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Verwaltungsratsmitglieds vorgestreckt
werden, um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schad-
loshaltung unter diesem Artikel hat.

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl

seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-

schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, in Gesellschafterversammlungen oder

38096

L

U X E M B O U R G

durch Zirkularbeschlüsse (soweit dies gesetzlich möglich ist), gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafter-
versammlung der Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der
Gesellschafter der Gesellschaft.

Die Einberufung der Sitzung durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage vor der

Sitzung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft eingetragene
Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung ohne vor-
herige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses

mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Brief übersandt. Der Beschluss wird wirksam bei Zustimmung der vom
Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung der
Mehrheitsvoraussetzungen, an Tag dieser Urkunde). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können jederzeit ohne vorherige
Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nicht anders vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-

schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte der Geschäftsanteile vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen

Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember

eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. De-
zember 2013 enden.

Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die

Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich

vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-

schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet

werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.

Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-

datoren,  bei  welchen  es  sich  nicht  um  Gesellschafter  handeln  muss,  zwecks  der  Durchführung  der  Auflösung  und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.

Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern die Gesellschaft nur aus einem (1) Gesellschafter besteht, gilt Artikel 179(2) des

Gesetzes und u.a. die Artikel 200-1 und 200-2 finden Anwendung. In einem solchen Fall übt der alleinige Gesellschafter
alle Befugnisse aus, welche auch der Gesellschafterversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten

sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes.

<i>Zeichnung und Zahlung

Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt

eingezahlt und gezeichnet:

38097

L

U X E M B O U R G

Einzahler

Zahl der

Geschäftsanteile

Einzahlungspreis

(GBP)

UK Logistics Topco I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

GBP 15.000,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

GBP 15.000,-

Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden ungefähr EUR 1.200,- betragen.

<i>Ausserordentliche Beschlüsse des Gesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der

Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:

- BRE/Management 6 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 164.777.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-

nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-

schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach

Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: J. ZEAITER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 février 2013. Relation: LAC/2013/6085. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 13. Februar 2013.

Référence de publication: 2013022256/410.
(130027205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

Class Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 118.586.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 février 2013, l'associé unique a décidé d'accepter la

démission de Fabrice Meeuwis, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat
de Gérant, avec effet au 4 février 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2013.

Référence de publication: 2013026400/13.
(130031835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Credit Suisse Portfolio Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 940.001,88.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.672.

Par résolutions signées en date du 19 février 2013, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
Acceptation de la démission de Madame Sophie Mellinger, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, de son mandat de gérant de la société avec effet au 7 février 2013.

Nomination de Madame Polyxeni Kotoula, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg, en tant que gérant avec effet au 7 février 2013 et pour une durée indéterminée.

38098

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2013.

<i>Pour la société
TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2013026406/18.
(130032454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Caesar International, Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 174.084.

<i>Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale tenue le 11 janvier 2013

L ’Assemblée a adopté les résolutions suivantes:
- Accepte la démission de MULLERBACH INC de ses mandats d'administrateur &amp; administrateur-délégué.
- L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué la société PUNDAMILIA

FAMILY OFFICE, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège à L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon, inscrite
au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B171.385, ayant pour représentant permanent sa gérante, Ariane
Vansimpsen, demeurant professionnellement à Strassen L-8011 au 283, route d'Arlon,

- Accepte la démission de Pundamilia Family Office Sàrl de sa fonction de Commissaire aux Comptes
L'assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes la société GRAHAM THOMAS INVEST

SA, société anonyme, établie et ayant son siège à L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon, inscrite au registre du commerce
et des sociétés sous le numéro B121.824.

Ces nominations prennent effet dès ce jour et jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2017.

PUNDAMILIA FAMILY OFFICE Sàrl
<i>Pour acceptation du mandat
Signature

Référence de publication: 2013026407/22.
(130032006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Calpam Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8069 Bertrange, 14, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 9.646.

EXTRAIT

Il résulte des décisions écrites de l'associé unique de la Société du 7 janvier 2013 comme suit:
1. Révocation du mandat de gérant technique de Monsieur Carlo Boulanger avec effet immédiat.
2. Révocation du mandat de gérant de Monsieur Gerrit Ruitinga avec effet immédiat.
3. Nomination de Monsieur Sven Dochez, de nationalité belge, né le 22 octobre 1977, à Wilrijk, Belgique, résidant à

Vlaamsekaai 90, 2000 Anvers, Belgique, en qualité de gérant technique de la Société avec effet immédiat et ce pour une
durée illimitée.

4. Nomination de Monsieur Azzam Al-Mutawa, né le 3 juillet 1969 à Koweït, résidant à Museumstraat 23, 2000 Anvers,

Belgique, en qualité de gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée illimitée.

En conséquence, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Monsieur Sven Dochez, gérant technique;
- Monsieur Koen Vankelst, gérant;
- Monsieur Johan Innegraeve, gérant; et
- Monsieur Azzam Al-Mutawa, gérant.
Conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3 des statuts de la Société, la Société est valablement re-

présentée à l'égard des tiers et en justice par la signature conjointe de deux gérants dont une doit obligatoirement être
celle d'un gérant technique ou par la signature individuelle de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de signature
auront été délégués par le conseil de gérance.

5. Nomination en sa qualité de réviseur d'entreprises agréé la société coopérative PriceWaterhouseCoopers, dont le

siège social est établi au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

38099

L

U X E M B O U R G

Le mandat ainsi conféré couvre l'examen des comptes pour l'exercice social actuellement en cours, qui a commencé

le 1 

er

 avril 2012 et se terminera le 31 mars 2013 ainsi que l'examen des comptes pour l'exercice social qui commencera

le 1 

er

 avril 2013 et se terminera le 31 mars 2014.

Le mandat ainsi conféré prendra donc fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014

pour approuver les comptes de l'exercice qui se terminera le 31 mars 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2013.

... DELPECH
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2013026409/37.
(130031863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Calpam Transports Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8069 Bertrange, 14, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 70.997.

EXTRAIT

Il résulte des décisions écrites de l'associé unique de la Société du 7 janvier 2013 comme suit:
1. Révocation du mandat de gérant technique de Monsieur Carlo Boulanger avec effet immédiat.
2. Révocation du mandat de gérant de Monsieur Gerrit Ruitinga avec effet immédiat.
3. Nomination de Monsieur Sven Dochez, de nationalité belge, né le 22 octobre 1977, à Wilrijk, Belgique, résidant à

Vlaamsekaai 90, 2000 Anvers, Belgique, en qualité de gérant technique de la Société avec effet immédiat et ce pour une
durée illimitée.

4. Nomination de Monsieur Azzam AI-Mutawa, né le 3 juillet 1969 à Koweït, résidant à Museumstraat 23, 2000 Anvers,

Belgique, en qualité de gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée illimitée.

5. En conséquence, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Monsieur Sven Dochez, gérant technique;
- Monsieur Koen Vankelst, gérant;
- Monsieur Johan Innegraeve, gérant; et
- Monsieur Azzam Al-Mutawa, gérant.
Conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3 des statuts de la Société, la Société est valablement re-

présentée à l'égard des tiers et en justice par la signature conjointe de deux gérants dont une doit obligatoirement être
celle d'un gérant technique ou par la signature individuelle de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de signature
auront été délégués par le conseil de gérance.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2013.

... DELPECH
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2013026410/30.
(130031882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Challenger Luxembourg Holding No. 1A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.625.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.890.

Veuillez noter que, suite à la décision de l'Associé Unique de la Société, intervenue en date du 1 

er

 Février 2013,

- Robert van't Hoeft démissionne du poste de gérant avec effet au 1 

er

 Février 2013;

- Martinus C.J. Weijermans démissionne du poste de gérant avec effet au 1 

er

 Février 2013;

- Fabrice Mas, né le 24 Avril 1979 à Meaux, République Française, de nationalité française et résidant professionnelle-

ment au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est nommé au poste de gérant avec effet au 1 

er

 Février 2013;

- Jacob Mudde, né le 14 Octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, de nationalité hollandaise et résidant professionnellement

au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est nommé au poste de gérant avec effet au 1 

er

 Février 2013.

38100

L

U X E M B O U R G

Par conséquent, à partir du 1 

er

 Février 2013, le conseil de gérance de la Société est constitué de la manière suivante:

- Fabrice Mas, gérant;
- Jacob Mudde, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fabrice Mas
<i>Gérant

Référence de publication: 2013026417/21.
(130032401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Challenger Luxembourg Holding No. 1B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.625.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.891.

Veuillez noter que, suite à la décision de l'Associé Unique de la Société, intervenue en date du 1 

er

 Février 2013,

- Robert van't Hoeft démissionne du poste de gérant avec effet au 1 

er

 Février 2013;

- Martinus C.J. Weijermans démissionne du poste de gérant avec effet au 1 

er

 Février 2013;

- Fabrice Mas, né le 24 Avril 1979 à Meaux, République Française, de nationalité française et résidant professionnelle-

ment au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est nommé au poste de gérant avec effet au 1 

er

 Février 2013;

- Jacob Mudde, né le 14 Octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, de nationalité hollandaise et résidant professionnellement

au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est nommé au poste de gérant avec effet au 1 

er

 Février 2013.

Par conséquent, à partir du 1 

er

 Février 2013, le conseil de gérance de la Société est constitué de la manière suivante:

- Fabrice Mas, gérant;
- Jacob Mudde, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fabrice Mas
<i>Gérant

Référence de publication: 2013026418/21.
(130032402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Dianco Sourcing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 152.630.

In the year two thousand and twelve, on the eleventh day of December.
Before the undersigned Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg.
Was held a meeting of the shareholders of DIANCO SOURCING S.A., a société anonyme, having its registered office

at L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under
number B 152.630, incorporated by a notarial deed of Maître Roger ARRENSDORFF, notary then residing in Mondorf-
les-Bains, drawn up on 26 March 2010 and whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations on 3 June 2010, number 1158.

The meeting is opened by Mr Guy BERNARD, employee, professionally in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appointed as Secretary, Mr Henri DA CRUZ, employee, professionally in Luxembourg.
The meeting elected as Scrutineer, Mr Koen Van Huynegem, director of companies, residing professionally in Luxem-

bourg

The bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The names of the shareholders represented at the meeting, the proxies of the represented shareholders and the

number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list and proxies, signed ne varietur by the
appearing persons and the notary, shall remain annexed to the present deed to be registered with it.

II.- It appears from the attendance list, that the whole share capital of the Company, are represented at this meeting.

The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

38101

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

a. To create a new category of shares, the "Preferred Shares", having a nominal value of ten thousand Euro (EUR

10,000.-) each.

b. To increase the share capital of the Company from one hundred thousand Euro (EUR 100,000) to four million five

hundred ninety thousand Euro (EUR 4,590,000.-) by the issue of two hundred twenty (220) ordinary shares and two
hundred twenty-nine (229) Preferred Shares with a nominal value of ten thousand Euro (EUR 10,000.-) each, to be
subscribed by the current shareholders of the Company.

The issue of the two hundred twenty (220) ordinary shares and two hundred twenty-nine (229) Preferred Shares will

be made in consideration of a contribution in kind of four million four hundred ninety-eight thousand four hundred ninety-
three Euro (EUR 4,498,493.-), four million four hundred ninety thousand Euro (EUR 4,490,000.-) to be allocated to the
share capital and eight thousand four hundred ninety-three Euro (EUR 8,493.-) to be allocated to the legal reserve of the
company.

c. To amend accordingly Article 5. of the Articles."
After due and careful deliberation, the following resolutions are taken unanimously:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to create a new category of shares, the "Preferred Shares", having a nominal value of ten

thousand Euro (EUR 10,000.-) each.

<i>Second resolution

The  Shareholders  resolve  to  increase  the  share  capital  of  the  Company  from  one  hundred  thousand  Euro  (EUR

100,000) to four million five hundred ninety thousand Euro (EUR 4,590,000.-) by the issue of two hundred twenty (220)
ordinary shares and two hundred twenty-nine (229) Preferred Shares with a nominal value of ten thousand Euro (EUR
10,000.-) each to be subscribed by a contribution in kind.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, Dianco Singapore PTE. LTD, a company incorporated under the laws of the Republic of Singapore and

having its registered office at 158, Cecil Street 11-01, Singapore 069545, here represented by Mr. Koen VAN HUYNEGEM,
by virtue of a proxy given on December 11 

th

 2012, the said proxy, signed "ne varietur' by the person appearing and the

undersigned notary, declares to subscribe two hundred twenty (220) ordinary shares and two hundred twenty-nine (229)
Preferred Shares with a nominal value of ten thousand Euro (EUR 10,000.-) each, by a contribution in kind consisting.

The contribution in kind consisted of the ownership of the Claim of four million four hundred ninety-eight thousand

four hundred ninety-three Euro (EUR 4,498,493.-), four million four hundred ninety thousand Euro (EUR 4,490,000.-) to
be allocated to the share capital and eight thousand four hundred ninety-three Euro (EUR 8,493.-) to be allocated to the
legal reserve of the company.

The contribution in kind is the purpose of a report established by Callens, Pirenne, Theunissen &amp; Co, independent

auditor, member of the "Institut des Réviseurs d'Entreprises" and authorized by the Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF), having its registered office at 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
dated on Octobre 31 

st

 , 2012 (the Report) attached to the present deed, concluding as follows:

"Based on audits conducted as described above, we have no observation to formulate on the value of the contribution

which matches at least the number and nominal value of shares to be issued in return."

The notary further certifies that the conditions set forth in article 26-1 of the law of 10 

th

 August 1915, on commercial

companies, as amended, have been fulfilled. The Report, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions and the contribution having been fully carried out, it was unanimously

resolved to amend article 5 of the Company's articles of association so as to read as follows:

Art. 5. The subscribed capital is set at four million five hundred ninety thousand Euro (EUR 4,590,000.-) represented

by four hundred fifty-nine (459) shares with a par value of ten thousand Euro (EUR 10.000,-) each, carrying one voting
right in the general assembly.

All the shares are, at the owner's option, in bearer or nominative form.
The company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the amendments of its Articles are estimated at approximately two thousand eight hundred Euro (EUR 2.800,-).

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

38102

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le onze décembre.
Par-devant le notaire soussigné, Maître Roger ARRENSDORFF, de résidence à Luxembourg,
S'est tenue une assemblée des actionnaires de DIANCO SOURCING S.A., une société anonyme, ayant son siège social

au L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 152.630, constituée suivant un acte de Maître Roger ARRENSDORFF, notaire alors de résidence à Mondorf-
les-Bains, en date du 26 mars 2010 et dont les statuts (les «Statuts») ont été publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations le 3 juin 2010, numéro 1158.

L'assemblée est ouverte par Monsieur Guy BERNARD, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, étant

le président.

Le Président désigne comme Secrétaire, Monsieur Henri DA DRUZ, employé, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme Scrutateur, Monsieur Koen Van Huynegem, administrateur de sociétés, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg,.

Le bureau étant formé, le Président déclare et requiert du notaire qu'il acte que:
I.- Les noms des actionnaires représentés à l'assemblée, les procurations des actionnaires représentés et le nombre

de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration ne varietur,
une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées
avec lui.

II.- Il ressort de la liste de présence que les six mille quatre cents (6.400) actions ordinaires représentant l'entièreté

du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée. L'assemblée est donc régulièrement constituée
et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

a. Création d'une nouvelle catégorie d'actions, les «Actions Préférentielles», ayant une valeur nominale de dix mille

euros (EUR 10.000,-) chacune.

b. Augmentation du capital social de cent mille Euros (EUR 100.000,-) à quatre million cinq cent quatre-vingt-dix mille

Euros (EUR 4.590.000,-) par l'émission de deux cent vingt (220) Actions ordinaire et deux cent vingt-neuf (229) actions
préférentielles ayant une valeur nominale de dix mille Euros (EUR 10.000,-) chacune devant être souscrite par les ac-
tionnaires actuels de la Société.

L'émission des deux cent vingt (220) Actions ordinaire et deux cent vingt-neuf (229) actions préférentielles sera faite

en échange d'un apport en nature évalué à de quatre million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-
vingt-treize  Euros  (EUR  4.498.493,-),  quatre  million  quatre  cent  mille  quatre-vingt-dix  mille  Euros  (EUR  4.490.000,-)
devant être alloués au capital social et huit mille quatre cent quatre-vingt-treize Euros (EUR 8.493.-) devant être alloués
à la réserve légale de la société.

c. Modification conformément à ce qui précède de l'Article 5. des Statuts.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de créer une nouvelle catégorie d'actions, les «Actions Préférentielles», ayant une valeur nominale

de dix mille Euros (EUR 10.000,-) chacune.

<i>Seconde résolution

L'assemblée  décide  d'augmenter  le  capital  social  de  quatre  million  cinq  cent  quatre-vingt-dix  mille  Euros  (EUR

4.590.000,-) par l'émission de deux cent vingt (220) Actions ordinaire et deux cent vingt-neuf (229) actions préférentielles
ayant une valeur nominale de dix mille Euros (EUR 10.000,-) souscrites par un apport en nature.

<i>Souscription - Paiement

Est intervenu la société «Dianco Singapore PTE. LTD», avec siège social à 158, Cecil Street 11-01, Singapore 069545,

38103

L

U X E M B O U R G

représenté par Monsieur Koen VAN HUYNEGEM, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 11 décembre

2012, laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

déclare souscrire deux cent vingt (220) Actions ordinaire et deux cent vingt-neuf (229) actions préférentielles ayant

une valeur nominale de dix mille Euros (EUR 10.000,-) par un apport en nature.

L'apport en nature consiste en la propriété de la Créance, pour un montant total de quatre million quatre cent quatre-

vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-treize Euros (EUR 4.498.493,-), dont quatre million quatre cent quatre-vingt-
dix mille Euros (EUR 4.490.000,-) seront alloués au capital social et huit mille quatre cent quatre-vingt-treize Euros (EUR
8.493.-) seront alloués à la réserve légale de la société.

Selon un rapport de révision établi par le réviseur d'entreprise indépendant Callens, Pirenne, Theunissen &amp; Co, membre

de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et autorisés par la Commission de Surveillance du Secteur financier (CSSF), avec
siège social à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, daté au 31 octobre 2012, annexé au présent
acte, se lit comme suit:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale

des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie. Sans
remettre en cause notre opinion, nous attirons l'attention sur le fait que la valeur des actions à émettre est établie sur
base des capitaux propres indiqués dans les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011. Cette valeur est la valeur
nette comptable qui ne reflète pas forcement la valeur réelle de ces actions.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier conformément à ce qui précède l'Article 5 des Statuts qui devra être lu comme suit:

« Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre million cinq cent quatre-vingt-dix mille Euros (EUR 4.590.000,-), représenté

par quatre cent cinquante-neuf (459) actions d'une valeur nominale de dix mille euros (EUR 10.000,-), disposant chacune
d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la modification de ses Statuts, est évalué sans nul préjudice à deux mille huit cent
Euros (EUR 2.800,-).

Aucun autre sujet ne figurant à l'ordre du jour, et personne n'ayant pris la parole, l'assemblée générale a été clôturée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte

soit dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de ces mêmes personnes, et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.
Après que lecture de l'acte a été faite au mandataire des personnes comparantes, connues du notaire par son nom,

prénom, statut marital, lieu de résidence, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: BERNARD, DA CRUZ, VAN HUYNEGEM, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 décembre 2012. Relation: LAC/2012/59893. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 13 février 2013.

Référence de publication: 2013022257/175.
(130027127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

Challenger Luxembourg Holding No. 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.090.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.889.

Veuillez noter que, suite à la décision des Associés de la Société, intervenue en date du 4 Février 2013,
- Robert van't Hoeft démissionne du poste de gérant avec effet au 4 Février 2013;
- Martinus C.J. Weijermans démissionne du poste de gérant avec effet au 4 Février 2013;

38104

L

U X E M B O U R G

- Fabrice Mas, né le 24 Avril 1979 à Meaux, République Française, de nationalité française et résidant professionnelle-

ment au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est nommé au poste de gérant avec effet au 4 Février 2013;

- Jacob Mudde, né le 14 Octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, de nationalité hollandaise et résidant professionnellement

au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est nommé au poste de gérant avec effet au 4 Février 2013.

Par conséquent, à partir du 4 Février 2013, le conseil de gérance de la Société est constitué de la manière suivante:
- Fabrice Mas, gérant;
- Jacob Mudde, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fabrice Mas
<i>Gérant

Référence de publication: 2013026419/21.
(130032400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Chicama Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 170.797.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société du 14 septembre 2012

<i>Première résolution

Approbation de la révocation du Commissaire aux Comptes.
L'Assemblée Générale décide de révoquer Ernst &amp; Young, demeurant au 7, Parc d'Activité Syrdall, à L-5365 Munsbach,

et portant le numéro RCS Luxembourg B 47771 en tant que Commissaire aux Comptes de la Société pour l'exercice se
terminant au 31 décembre 2012.

<i>Deuxième résolution

Approbation de la nomination du Réviseur d'Entreprises.
L'Assemblée Générale décide de nommer DeloiUe Audit S.à.r.l, demeurant au 560 rue de Neudorf à L-2220 Luxem-

bourg, et portant le numéro RCS Luxembourg B 67895, aux fonctions de Réviseur d'Entreprises de la Société pour
l'exercice se terminant au 31 décembre 2012. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale approu-
vant les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2013.

CHICAMA INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2013026422/22.
(130032310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Cima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 97.992.

EXTRAIT

Par décision du Conseil d'Administration du 22 février 2013,
M. Antonio RAFFA, avocat, 54, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg
est coopté comme administrateur de la société jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2015, en remplacement de

M. Patrick K. OESCH, démissionnaire.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

CIMA S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2013026428/15.
(130032377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

38105

L

U X E M B O U R G

Clairmont S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 27, Alfred de Musset.

R.C.S. Luxembourg B 89.459.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 19 février 2013 que:
1. Madame Anne SCHMITT est remplacée dans sa fonction d'administrateur par Madame Corinne PARMENTIER avec

adresse professionnelle au 27 Rue Alfred de Musset L-2175 Luxembourg jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2018.

2. Les mandats d’administrateurs de Monsieur Raymond FRITSCH et Manuela MARAITE demeurant à L-2175 Luxem-

bourg, au 27, Rue Alfred de Musset, sont renouvelés pour une période de 5 ans qui prendra fin jusqu’à l’assemblée générale
de l’année 2018.

3. Madame Corinne PARMENTIER est remplacée dans sa fonction de commissaire aux comptes par Madame Sara

SZYLAR avec adresse professionnelle au 27 Rue Alfred de Musset L-2175 Luxembourg jusqu’à l’assemblée générale de
l’année 2018.

Luxembourg, le 19 février 2013.

Pour extrait conforme
CLAIRMONT S.A.

Référence de publication: 2013026429/20.
(130032338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Clifter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 74.830.

Il résulte de la résolution écrite de l’actionnaire unique datée du 20 décembre 2012 que:
- Me Daniel BÖHM, avocat, avec adresse professionnelle au 2, Via dei Gorini, CH-6901 Lugano, Suisse, a été nommé

à la fonction d’administrateur en remplacement de Me Daniele BORELLI suite au décès de ce dernier.

Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

- Me Simona DANZI-LEPORI a démissionné de sa fonction d’aministrateur avec effet au 1 

er

 novembre 2012.

- Mme Daniela SOVERA a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.
- Le nombre d’administrateurs de la société a par conséquent été réduit de trois à un.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013026433/16.
(130032520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Clovis S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 95.065.

EXTRAIT

Maître Christian GAILLOT avocat, agissant en qualité de domiciliataire de la société CLOVIS SA, société anonyme

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B.95.065 ayant son siège social à L-2550 Luxem-
bourg, 32, avenue du X septembre, déclare par la présente que le siège social de la société est dénoncé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21.02.13.

Maître Christian GAILLOT
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2013026434/14.
(130031989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

38106

L

U X E M B O U R G

Compact Holding S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 120.967.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Allgemeinen Gesellschafterversammlung Behalten am 28. Dezember 2012

<i>Beschluss

Die Gesellschafter beschließen einstimmig:
dass das Mandat von Herrn Siegfried Kittinger, geboren am 8. April 1969 in Loeben, Österreich, wohnhaft in Dorf 73,

6323 Bad Häring, Österreich, als Geschäftsführer mit Wirkung zum 31. Dezember 2012 beendigt wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2013026436/14.
(130031246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Compagnie Interoceanique pour le Transport des Liquides S.A., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 10.753.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, a déclaré

closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme holding COMPAGNIE INTEROCEA-
NIQUE POUR LE TRANSPORT DES LIQUIDES, S.A. et a ordonné la publication dudit jugement par extrait au Mémorial,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Me Sonja VINANDY.

Référence de publication: 2013026438/13.
(130032139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Euro Properties Investments III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 103.448.

L'an deux mille douze,
le vingt-quatre décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

la société «FISHER ISLAND LIMITED», une société constituée et existant sous les lois du Royaume-Uni, établie et

ayant son siège social 11 Grosvenor Place, London SW1X 7HH (Royaume-Uni),

ici représentée par:
Monsieur Francis N. HOOGEWERF, directeur de société, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118

Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée le 12 décembre 2012.
Ladite procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, est l'actionnaire unique Actionnaire») de la société

«EURO PROPERTIES INVESTMENTS III S.A.» (la «Société») une société anonyme, établie et ayant son siège social actuel
au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section
B sous le numéro 103 448, constituée suivant acte notarié dressé, en date du 1 

er

 octobre 2004, lequel acte fut publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») en date du 10 décembre 2004, sous le numéro 1268
et page 60818.

Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis lors.
Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique et re-

présentant ainsi l'intégralité du capital social actuellement fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté
par trois cent dix (310) actions ordinaires d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune, toutes intégra-
lement libérées, a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

38107

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'Actionnaire DECIDE de modifier intégralement l'objet social existant de la Société, afin que cette dernière n'exerce

plus les activités commerciales exercées jusqu'à présent et qu'elle adoptera désormais l'objet social classique d'une société
de participations financières (SOPARFI).

<i>Deuxième résolution

L'Actionnaire DECIDE que libellé du nouvel objet social sera désormais le suivant:
«La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

La Société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»

<i>Troisième résolution

L'Actionnaire DECIDE de procéder à une refonte complète des statuts de la Société afin de refléter le prédit chan-

gement d'objet social et en sus de les mettre en concordance avec la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales et plus particulièrement la faculté pour la Société d'avoir un seul ac-
tionnaire et la possibilité d'un administrateur unique, sans néanmoins toucher à son son capital social et ni à sa forme
juridique, qui demeurera une société anonyme:

Les nouveaux articles des statuts refondus auront désormais la teneur suivante:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de «EURO PROPERTIES INVEST-

MENTS III S.A.» (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La Société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par trois cent

dix (310) actions ordinaires d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune, toutes intégralement libérées,

38108

L

U X E M B O U R G

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra  les  indications  prévues à  l'article  39  de  la Loi.  La propriété des actions  nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des Actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de juin de chaque année
à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

38109

L

U X E M B O U R G

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

38110

L

U X E M B O U R G

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi."

DONT ACTE, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

taire par nom, prénom usuel, état et demeure, le même représentant a signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: F.N. HOOGEWERF, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 décembre 2012. Relation: EAC/2012/17743. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013022283/224.
(130027148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

Conical SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.581.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire Unique en date du 20 février 2013

- Monsieur Carlo Schlesser, licencié en Sciences Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant pro-

fessionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommé Administrateur, en remplacement de Madame
Corinne Bitterlich. Son mandat viendra échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2019.

- Madame Isabelle Schul, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

est nommée Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2019,

Fait le 20 février 2013.

Certifié sincère et conforme
CONICAL SPF S.A.
IMT Trust Services AG / SGG Anstatt / I. SCHUL
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur
Représentée par D. KIEBER / F. LANNERS / -
<i>Représentant Permanent / Représentant Permanent / -

Référence de publication: 2013026439/20.
(130031906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

38111

L

U X E M B O U R G

Crea'Plus Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3237 Bettembourg, 19, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 150.419.

<i>Extrait du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire

Le 30 novembre 2012 à 18h00 heures les associés se sont réunis en assemblée générale au siège social de la société

à L-1382 Bettembourg, 2, rue Vieille.

La décision suivante est adoptée:

- Transfert du siège de la Société à L-3237 Bettembourg, 19, Rue de la gare avec effet au 1 

er

 décembre 2012.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les associés.

Priscilla Beretta / Anne-Marie Mai.

Référence de publication: 2013026442/15.
(130032587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Crousseilles Holdings S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 73.486.

EXTRAIT

En date du 2 janvier 2013, les résolutions suivantes ont été adoptées par l’actionnaire unique de la Société:
- La démission de Monsieur Herman Törnblom en tant qu’administrateur a été acceptée avec effet au 31 décembre

2012.

- La nomination de Madame Natacha Hainaux, domicilié au 13-17, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au poste

d’administrateur, avec effet au 1 

er

 janvier 2013, est acceptée. Elle poursuit le mandat de son prédécesseur qui prendra

fin lors de l’Assemblée Générale annuelle de 2019.

Luxembourg, le 20 février 2013.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Natacha Hainaux

Référence de publication: 2013026443/19.
(130032172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Evraz Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 105.615.

Suivant l'assemblée générale extraordinaire tenue par les associés en date du 21 février 2013, il a été décidé de:
Acceptation de la démission de Monsieur Rober van 't Hoeft, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F, Kennedy,

L-1855 Luxembourg, de son mandat d'administrateur de la société avec effet immédiat au 15 février 2013.

Nomination de Monsieur Jacob Mudde, né le 14 octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que d'administrateur avec effet immédiat au 15 février 2013 et
pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2013.

<i>Pour la Société
TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2013026475/18.
(130032183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

38112


Document Outline

A bis Z Gérances d'Immeubles S.à r.l.

Afinis Communications S.A.

Alliance Services S.à r.l.

AMT Servilux S.A.

Asars Constructions S.à r.l.

Azincour S.A.

Bella Vista Finance S.A.

Berbou International Sàrl

Biotechnology Ingredient Supplement S.à r.l.

Biotoscana Investments S.à r.l.

Biotoscana Investments S.à r.l.

Blue Alpha

Borletti Group

Borletti Group Finance SCA

Bruskort International S.à.r.l.

Caesar International

Calpam Luxembourg S.à r.l.

Calpam Transports Luxembourg S.à r.l.

Career Education Corporation Luxembourg S.à.r.l.

Carta Investments S.à r.l.

C. Buijsen &amp; Cie

C&amp;E Holdings Luxembourg

Centuria Real Estate Asset Management International S.A.

Challenger Luxembourg Holding No. 1A S.à r.l.

Challenger Luxembourg Holding No. 1B S.à r.l.

Challenger Luxembourg Holding No. 2 S.à r.l.

Chicama Investments S.A.

Cima S.A.

Cirse S.à r.l.

Clairmont S.A.

Class Real Estate Investments S.à r.l.

Clifter S.A.

Clovis S.A.

Compact Holding S.àr.l.

Compagnie Interoceanique pour le Transport des Liquides S.A.

Conical SPF S.A.

Crea'Plus Sàrl

Credit Suisse Capital Partners (Luxembourg) S.à r.l.

Credit Suisse Portfolio Investments (Luxembourg) S.à r.l.

Crousseilles Holdings S.A.

Diamond Holdco S.à r.l.

Diamond Midco S.à r.l.

Diamond Topco S.à r.l.

Dianco Sourcing S.A.

Embrun S.A.

EPGF Finance (Luxembourg), Sàrl

EPGF Pliening Property S.à r.l.

Euro Properties Investments III S.A.

Evraz Group S.A.