This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 732
26 mars 2013
SOMMAIRE
Askania II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35117
Askania S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35115
atHome Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35094
FGP VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35129
Football Club Nordstad Association sans
but lucratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35096
Frena Intermediate Holdings S.à r.l. . . . . .
35136
Futsal Club Nordstad Association sans but
lucratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35096
Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35132
Grainger Luxembourg Germany (No.7) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35111
Gruppo di Partecipazioni e Servizi S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35092
Guardian Managers S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
35092
Hackl Hofmann Landschaftsarchitekten
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35091
Hobevest S.A. société de gestion de patri-
moine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35095
IMC Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35092
Immobilière du GRÄFGEN S.A. . . . . . . . . .
35091
Imondial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35091
Independent Directors Luxembourg, La-
guerre-Lemaire-Weyders Secs . . . . . . . . .
35091
International Lift System S.à r.l. . . . . . . . . .
35090
Intertrust Corporate Services S.A. . . . . . .
35091
I-Wohnen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35099
Jardins en Beauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35090
JTG Holdings S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35093
JTG Holdings S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35093
MCL Prop Co. C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
35120
Moncour S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35136
New Life Settlement Scenarios S.A.- So-
ciété de Titrisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35092
OPENB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35090
Orium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35093
Pasarela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35093
Pâtisserie-Confiserie PICHON-CREMER
Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35094
Phi-Logos A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35093
Primigenia International S.A. . . . . . . . . . . .
35090
Red Diamond Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .
35090
Resource Revision s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
35094
Resto-Rial S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35094
Simark International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
35095
Sofagi S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35097
Specialized Investment Management Sicav
- SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35096
TEAM CAR REPAIRS S.A. en abrégé
T.C.R. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35134
Vimo & Partner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35131
VTC Real Estate Holdings II S.à r.l. . . . . . .
35095
Wick Lane (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
35113
Winnebago Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
35113
35089
L
U X E M B O U R G
Primigenia International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 145.886.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRIMIGENIA INTERNATIONAL S.A.
Référence de publication: 2013024222/10.
(130029106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Red Diamond Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 159.475.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2013.
Référence de publication: 2013024231/10.
(130029441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
OPENB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 73.570.
J'ai le regret de vous informer que je renonce par la présente à mes fonctions d'administrateur au sein de votre société,
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 12 février 2013.
Frédérique VIGNERON.
Référence de publication: 2013024202/10.
(130029155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
International Lift System S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 75.082.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2013.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2013024108/12.
(130028858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Jardins en Beauté, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3593 Dudelange, 73, route de Volmerange.
R.C.S. Luxembourg B 103.992.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14/02/2013.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2013024110/12.
(130028811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
35090
L
U X E M B O U R G
Independent Directors Luxembourg, Laguerre-Lemaire-Weyders Secs, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 145.487.
Par la présente lettre écrite sous seing privé, je soussigné, Jean R LEMAIRE, résident 12A, rue Randlingen, L-8366
HAGEN, désire remettre ma démission avec effet immédiat de mes fonctions de gérant associé commandité de Inde-
pendent Directors Luxembourg, Laguerre-Lemaire-Weyders Secs, Siège social: 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg: B 145.487.
Fait à Hagen, le 11 février 2012.
Jean R LEMAIRE.
Référence de publication: 2013024086/12.
(130028855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Intertrust Corporate Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 51.100.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Intertrust Corporate Services S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013024093/11.
(130029210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Imondial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 49, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 101.233.
Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013024099/11.
(130029492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Hackl Hofmann Landschaftsarchitekten S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 25, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 136.192.
Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18/02/2013.
Référence de publication: 2013024064/10.
(130029184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Immobilière du GRÄFGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 16-18, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 106.165.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013024084/10.
(130029292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
35091
L
U X E M B O U R G
Gruppo di Partecipazioni e Servizi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 128.465.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013024034/10.
(130029277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Guardian Managers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 147.745.
Les comptes annuels au 31/12/11 de la société Guardian Managers S.àr.l., Société à responsabilité limitée, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013024037/10.
(130029343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
IMC Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 94.741.
EXTRAIT
L'un des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Eric DUPHIL, a désormais l'adresse suivante:
- 33, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1313 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 février 2013.
<i>Pour IMC HOLDING
i>Société anonyme
Référence de publication: 2013024097/13.
(130029047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
New Life Settlement Scenarios S.A.- Société de Titrisation, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 158.693.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 26 octobre 2012 au siège sociali>
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg en date du 26 0octobre
2012 que le l'Assemblée a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
- Renouvellement, avec effet immédiat, des mandats des administrateurs suivants:
* M. Marco Domenico PETRONIO, né le 4 juin 1974 à Milan (Italie), demeurant professionnellement à Luxembourg,
administrateur;
* M. Bruno H.H. VANDERSCHELDEN, né le 2 novembre 1965, à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement
à Luxembourg, administrateur;
* M. Alain TIRCHER, né le 13 mars 1959 à Watermael-Boitsfort (Belgique) demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, administrateur.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires devant approuver les
comptes annuels au 31 décembre 2012, qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Signatures.
Référence de publication: 2013024177/21.
(130029368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
35092
L
U X E M B O U R G
JTG Holdings S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 17.012.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2013.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2013024113/11.
(130029363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
JTG Holdings S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 17.012.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2013.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2013024114/11.
(130029364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Orium S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 73.038.
Les comptes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ORIUM S.A.
Jean-Marc HEITZ / Jacopo ROSSI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013024206/12.
(130028766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Pasarela, Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 125.060.
Les comptes annuels audités au 31/12/2011 de la société Pasarela, Société anonyme de droit luxembourgeois, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013024214/10.
(130029375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Phi-Logos A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9755 Hupperdange, 20, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 94.121.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 18 février 2013.
Référence de publication: 2013024217/10.
(130029148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
35093
L
U X E M B O U R G
Resto-Rial S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 52.
R.C.S. Luxembourg B 95.944.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 18 février 2013.
Référence de publication: 2013024244/10.
(130029203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Resource Revision s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 67.678.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013024243/10.
(130029258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Pâtisserie-Confiserie PICHON-CREMER Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 41, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 63.795.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013024208/10.
(130029074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
atHome Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 78.663.
<i>Excerpt from the resolutions taken by the board of directors of the company on the 15 i>
<i>thi>
<i> February 2013i>
The board of directors of atHome Group S.A. (hereafter, the "Company") has decided with effect on 15 February
2013, to appoint Mr. Tim Pittevils, residing in 25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, born on 29 May 1977 in Diest
(Belgium), as delegate in charge of the daily management of the Company for a period ending at the time of the annual
general meeting of shareholders that will consider the approval of the annual accounts for the year ending 31 December
2015, with individual signing authority for all matters relating to the daily management of the Company.
To be published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
Le conseil d'administration d'atHome Group S.A. (ci-après, la «Société») a décidé avec effet au 15 février 2013, de
nommer M. Tim Pittevils, demeurant à 25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, né le 29 mai 1977 à Diest (Belgique), en
tant qu'administrateur délégué à la gestion journalière de la Société pour un terme prenant fin à l'assemblée générale des
actionnaires statuant sur les comptes de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2015, avec pouvoir
de signature individuelle pour les matières relatives à la gestion journalière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2013.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2013024349/24.
(130028970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
35094
L
U X E M B O U R G
Hobevest S.A. société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Pa-
trimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 15.574.
L'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 21 janvier 2013 a ratifié la décision prise par le
Conseil d'administration en date du 10 octobre 2011 de coopter Madame Marie BOURLOND au poste d'administrateur
de la société, en remplacement de Monsieur Guy KETTMANN démissionnaire.
Lors de cette même assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement, Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la
Vallée, L-2661 Luxembourg a été nommé administrateur en remplacement de l'Administrateur démissionnaire Madame
Marie BOURLOND.
Enfin, lors de cette même assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement, Monsieur Cédric JAUQUET, 42,
rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été nommé avec effet rétroactif au 05 décembre 2012 administrateur en rempla-
cement de l'Administrateur démissionnaire Monsieur Olivier LECLIPTEUR.
Leur mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.
Luxembourg, le 14 FEV. 2013.
<i>Pour: HOBEVEST S.A. - société de gestion de patrimoine familial
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Lucile Wernert
Référence de publication: 2013024356/24.
(130029188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Simark International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 83.921.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013024275/10.
(130029280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
VTC Real Estate Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 139.872.
Il se dégage des résolutions de l’associé unique de la société Vistec Holdings S.à r.l., établie et ayant son siège social à
412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 138.203, tenue en date du 30
janvier 2013 par devant Me Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, numéro 157/2013 de son réper-
toire, que la société a changé sa dénomination en «VTC Holdings S.à r.l.».
Vistec Holdings S.à r.l. est l’associé unique de la société Vistec Real Estate Holdings II S.à r.l., établie et ayant son siège
social à 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 139.872, qui par acte
tenu en date du 30 janvier 2013 par devant Me Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, numéro
156/2013 de son répertoire, a changé sa dénomination en «VTC Real Estate Holdings II S.à r.l.».
Par conséquent l’associé unique de la société VTC Real Estate Holdings II S.à r.l. est la société VTC Holdings S.à r.l..
Luxembourg, le 18 février 2013.
Pour extrait conforme
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013024312/20.
(130029403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
35095
L
U X E M B O U R G
FC Nordstad Asbl, Futsal Club Nordstad Association sans but lucratif, Association sans but lucratif,
(anc. FC Nordstad ASBL, Football Club Nordstad Association sans but lucratif).
Siège social: L-9043 Ettelbruck, 14, rue de Feulen.
R.C.S. Luxembourg F 8.553.
Les membres de l'association sans but lucratif FOOTBALL CLUB NORDSTAD se sont réunis en assemblée générale
annuelle en date du 16/11/2012 et ont décidé les modifications statutaires suivantes suivant l'ordre du jour:
1. Changement de dénomination
2. Changement de l'objet
3. Suppression de l'article 7
4. Augmentation de la durée des mandats des membres du comité
5. Convocation de l'assemblée générale
6. Publication des résolutions des assemblée générale
Art. 1
er
. L'association est dénommée «FUTSAL CLUB NORDSTAD ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF», en
abrégé «FC NORDSTAD ASBL», ou encore «FCN ASBL». La durée de l'association est illimitée.
Art. 2. FC NORDSTAD ASBL a pour objet, l'initiation, la promotion, le divertissement et la pratique du Futsal ainsi
que toute autre activité sportive au Luxembourg comme à l'étranger.
Art. 7. Suppression pure et simple de l'article 7 des statuts de l'association.
Art. 11. FC NORDSTAD ASBL est administrée par un comité. Ses membres sont nommés lors de l'assemblée générale.
Chaque membre du comité est révocable à tout moment par l'assemblée générale. La durée du mandat des membres du
comité est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. La nomination des membres se fera jusqu'au nombre maximal fixé
dans l'article 12 des statuts de l'association. Toutefois pour le cas où il y aurait plus de candidats que de places, chaque
candidat proposé devra être élu par les membres à la majorité simple.
Art. 21. L'assemblée générale annuelle se réunira le troisième vendredi du mois de novembre de chaque année au
siège de l'association. Pour le cas où ce jour est un jour férié, l'assemblée générale sera reportée au prochain vendredi
ouvrable. Les membres seront convoqués au siège de l'association. Le comité mettra l'ordre du jour à disposition de tous
ses membres ainsi qu'à toute tierce personne intéressée, un mois en avance au siège social de l'association.
Art. 23. Toutes les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale par celle-ci seront mises à disposition de tous
les membres ainsi qu'à toute tierce personne intéressée au siège social de l'association.
Ettelbruck, le 12/02/2013.
HELIO DOMINGUES / Azevedo Leite Frederic
<i>Président / Vice-Présidenti>
Référence de publication: 2013024352/35.
(130029257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Specialized Investment Management Sicav - SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 147.171.
<i>Extrait des Résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 Janvier 2013i>
En date du 25 janvier 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs Jérôme Wigny, Alexandre Prost-Gargoz, Christian Zugel
et Michael Szymanski pour une durée d’un an prenant fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires
en 2014;
- de renouveler le mandat de réviseur d’entreprises de Deloitte Audit (anciennement Deloitte S.A.) pour une durée
d’un an prenant fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2014.
Luxembourg, le 15 février 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SPECIALIZED INVESTMENT MANAGEMENT SICAV-SIF
i>BNP Paribas Securities Services, Succursale de Luxembourg
Référence de publication: 2013024264/19.
(130029026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
35096
L
U X E M B O U R G
Sofagi S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 143.114.
L'an deux mille douze, le vingt décembre.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions SOFAGI S.C.A. (la «So-
ciété»), ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.114, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 20 octobre
2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2892 du 3 décembre 2008.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 30 novembre 2012, en voie de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Monsieur Jean Zorbibe, demeurant à CH-01206 Genève,
10, rue de Beaumont,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-David Zorbibe, demeurant à CH-1231 Conches, 20A, Chemin du velours.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emmanuel Lebeau, directeur, L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri
Schnadt.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
- Approbation de l'apport en nature de titres GENIMO S.A.;
- Augmentation du capital social de la société SOFAGI SCA à concurrence de 19.737.000 € pour le porter de son
montant actuel de 33.000.100 € à 52.737.100 € par l'émission de 197.370 actions nouvelles de la société ayant une valeur
nominale de 100 € chacune;
- Souscription des nouvelles actions et libération des 197.370 nouvelles actions par un apport en nature de titres;
- Modification de l'article 5.1 des statuts;
- Constatation, en application de l'article 27 des statuts, de l'accord de l'actionnaire commandité, détenteur d'actions
de classe B et par voie de conséquence de la réalisation de l'augmentation du capital social et de la modification de l'article
5 des statuts;
- Approuver toutes déclarations afférentes aux frais et honoraires liées à l'augmentation du capital social de la Société.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de dix-neuf millions
sept cent trente-sept mille euros (EUR 19.737.000) pour le porter de son montant actuel de trente-trois millions cent
euros (EUR 33.000.100) représenté par 330.000 (trois cent trente mille) actions de commanditaire d'une valeur nominale
de EUR 100 (cent euros) chacune et 1 (une) action de commandité ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros),
à un montant de cinquante-deux millions sept cent trente-sept mille cent euros (EUR 52.737.100) par la création et
l'émission de cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent soixante-dix (197.370) actions de commanditaire nouvelles de la
Société ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
L'intégralité des cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent soixante-dix (197.370) actions de commanditaire nouvelles
sont souscrites comme suit:
35097
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Jean Zorbibe, né le 14 juin 1930 à Alger (Algérie), demeurant à CH-1206 Genève, 10, rue de Beaumont,
ici présent, déclare souscrire quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt-deux (95.682) actions de commanditaire
d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune,
- Monsieur Edgard Zorbibe, né le 6 mai 1926 à Douera (Algérie), demeurant à CH-1205 Genève, 10, rue Jean Senebier,
ici représenté par Monsieur Jean Zorbibe, prénommé, en vertu d'une procuration générale donnée à Genève, le 6 sep-
tembre 2012, dont une copie restera annexée aux présentes, déclare souscrire quinze mille cinq cent quatre-vingt-huit
(15.588) actions de commanditaire d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune,
- Monsieur Jean-David Zorbibe, né le 13 juin 1971 à Boulogne Billancourt (France), demeurant à CH-1231 Conches,
20A Chemin du velours, ici présent, déclare souscrire quarante-trois mille cinquante (43.050) actions de commanditaire
d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune,
- Madame Emilie Zorbibe, née à Neuilly-sur-Seine (France), le 18 décembre 1972, demeurant à CH-1223 Genève, 72A,
Quai de Cologny, ici représentée par Monsieur Emmanuel Lebeau, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing
privé donnée à Luxembourg, le 20 décembre 2012, qui restera annexée aux présentes, déclare souscrire quarante-trois
mille cinquante (43.050) actions de commanditaire d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune;
à un prix total de dix-neuf millions sept cent trente-sept mille euros (EUR 19.737.000) intégralement affectés au capital
social de la Société.
Lesdites actions sont entièrement libérées par un apport en nature consistant en cent quatre-vingt-dix-sept mille trois
cent soixante-dix (197.370) actions de la société anonyme GENIMO S.A., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg,
4A, rue Henri Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.547.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
l'apport en nature ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi en date de ce jour par FIDEWA-CLAR S.A., réviseur
d'entreprises, avec adresse professionnelle à Leudelange, 2-4, rue du Château d'Eau, lequel rapport, après signature ne
varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
La conclusion du rapport est la suivante:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de
l'Apport autre qu'en numéraire d'un montant de EUR 19.737.000.- ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur
nominale des 197.370 nouvelles actions de SOFAGI S.C.A. d'une valeur nominale de EUR 100.- à émettre en contrepartie.»
Les apporteurs, représentés comme indiqué ci-avant, agissant par leurs mandataires, certifient par la présente qu'au
jour et au moment de la contribution:
1. ils sont propriétaires de toutes les actions apportées;
2. toutes les formalités de transfert ont été respectées et il n y a pas de droit de préemption ni autres droits attachés
aux actions par lesquels une quelconque personne serait en droit de demander qu'une ou plusieurs actions lui soient
transférées;
3. ils ont tous pouvoirs sociaux pour accomplir et exécuter les documents nécessaires au présent transfert;
4. les actions sont, à la meilleure connaissance des apporteurs, libres de toute charge et librement transférables à la
Société;
5. l'apport des actions de la société GENIMO S.A. à la Société sera inscrit dans le registre d actionnaires de la société
GENIMO S.A.
Un certificat signé par GENIMO S.A. confirmant que les apporteurs sont bien inscrits comme actionnaires de ladite
société et que les actions sont librement transférables à la Société, a été fourni au notaire soussigné et restera annexé
au présent acte.
Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert des actions, les apporteurs prendront
toutes les mesures nécessaires dès que possible.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l assemblée générale décide de modifier le 1
er
alinéa de l article 5 des statuts de la
Société qui aura désormais la teneur suivante:
" 5.1. La Société a un capital social de EUR 52.737.100 (cinquante-deux millions sept cent trente-sept mille cent euros)
représenté par 527.370 (cinq cent vingt-sept mille trois cent soixante-dix) actions de commanditaire d'une valeur nominale
de EUR 100 (cent euros) chacune et 1 (une) action de commandité ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros)."
<i>Constatationi>
L'assemblée générale constate, conformément à l article 27 des statuts de la Société, que l'augmentation de capital ci-
dessus est faite avec l'accord de l'Actionnaire Commandité.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale approuve l'évaluation des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme
de six mille euros (EUR 6.000).
35098
L
U X E M B O U R G
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. ZORBIBE, J.-D. ZORBIBE, E. LEBEAU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2012. LAC/2012/61858. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2013.
Référence de publication: 2013019575/121.
(130023094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2013.
I-Wohnen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 172.166.
In the year two thousand and thirteen, on the fifteenth day of January.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
1. the company ELLIOTT INTERNATIONAL, L.P., with registered office at c/o Maples Corporate Services Limited,
P.O. Box 309, Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands,
2. the company ELLIOTT ASSOCIATES, L.P., with registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corpo-
ration Trust Center, 1209 Orange Street, DE 19801 Wilmington, County of New Castle, United States of America, and
3. the company Westfalen Grundstücks- und Immobilien GmbH & Co. KG, with registered office at Lüdinghauser
Strasse 23, D-59387 Ascheberg, Germany,
represented by Mr. Max MAYER, employee, residing professionally at Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of three proxies given under private seal.
Such proxies, after having been signed “ne varietur” by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
The appearing parties, through their attorney, declared and requested the notary to act:
That the appearing parties are the sole present partners of the private limited company (société à responsabilité limitée)
“I-Wohnen S.à r.l.”, having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S.
Luxembourg section B and number 172.166, incorporated by deed of the officiating notary, on October 10, 2012, pu-
blished in the Mémorial C number 2796 of November 17, 2012,
and that the appearing parties, representing the whole corporate capital, have taken, in the present extraordinary
general meeting, the following resolutions unanimously:
<i>First resolutioni>
Two categories of shares are created, namely class A shares and class B shares.
<i>Second resolutioni>
The five thousand eight hundred and twelve (5,812) existing shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each
held by the company ELLIOTT INTERNATIONAL, L.P., pre-named, are exchanged against five thousand eight hundred
and twelve (5,812) class A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
The five thousand eight hundred and twelve (5,812) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each held by
the company ELLIOTT ASSOCIATES, L.P., pre-named, are exchanged against five thousand eight hundred and twelve
(5,812) class A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
The eight hundred and seventy six (876) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each held by the company
Westfalen Grundstücks- und Immobilien GmbH & Co. KG, pre-named, are exchanged against eight hundred and seventy
six (876) class B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
<i>Third resolutioni>
The corporate capital is increased to the extent of forty two thousand and five hundred Euro (EUR 42,500.-) in order
to raise it from the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) to fifty five thousand Euro (EUR
55,000.-) by the issue of thirty nine thousand two hundred and ten (39,210) new class A shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1.-) each vested with the same rights and obligations as the existing class A shares and by the issue of
35099
L
U X E M B O U R G
three thousand two hundred and ninety (3,290) new class B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each
vested with the same rights and obligations as the existing class B shares.
<i>Subscription - Paymenti>
The company ELLIOTT ASSOCIATES, L.P., pre-named, having partially waived its preferential subscription right, the
forty two thousand and five hundred (42,500) new class A and B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each
are subscribed by the current shareholders as follows:
- twenty seven thousand two hundred and thirty (27,230) new class A shares with a nominal value of one Euro (EUR
1.-) each are subscribed by the company ELLIOTT INTERNATIONAL, L.P., pre-named, and are fully paid up by contri-
bution in cash of twenty seven thousand two hundred and thirty Euro (EUR 27,230.-)
- eleven thousand nine hundred and eighty (11,980) new class A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-)
each are subscribed by the company ELLIOTT ASSOCIATES, L.P., pre-named, and are fully paid up by contribution in
cash of eleven thousand nine hundred and eighty Euro (EUR 11,980.-)
- three thousand two hundred and ninety (3,290) new class B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each
are subscribed by the company Westfalen Grundstücks- und Immobilien GmbH & Co. KG, pre-named, and are fully paid
up by contribution in cash of three thousand two hundred and ninety Euro (EUR 3,290.-).
The total amount of forty two thousand and five hundred Euro (EUR 42,500.-) is now at the free disposal of the
company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
An accounting year beginning on July 1
st
and ending on June 30 of the following year is adopted and acknowledgement
that as an exception the first accounting year which has begun on October 10, 2012 will end on June 30, 2013.
<i>Fifth resolutioni>
The articles of association are fully restated and will henceforth have the following wording:
Art. 1. Formation of the Company. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated
10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter
the “Articles”).
Art. 2. Corporate object.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in
any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct
or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any
affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the “Connected Companies”). It
may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or
over some of its assets.
2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect
investments in movable and immovable property including but not limited to promoting, managing, acquiring, owning,
hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or
otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
2.6. The Company may further, in particular in relation to real estate properties, render administrative, technical,
financial, economic or managerial services to other companies, persons or enterprises which are, directly or indirectly,
controlled by the Company or which are, directly or indirectly, under the control of the same shareholders of the
Company.
2.7. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
35100
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Name. The private limited liability company will have the name “I-Wohnen S.à r.l.”.
Art. 5. Registered office.
5.1. The registered office is established in Luxembourg-City.
5.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the
general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
5.3. The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the board of
managers.
5.4. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Capital - Share
Art. 6. The capital is set at FIFTY-FIVE THOUSAND EURO (55,000.- EUR) divided into fifty thousand eight hundred
and thirty four (50,834) class A shares (the “Class A Shares”) and four thousand one hundred sixty six (4,166) class B
shares (the “Class B Shares”) of ONE EURO (1.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the general meeting of shareholders.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10.
10.1. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
10.2. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of
the requirements of article 189 of the Law and subject to any additional transfer restrictions by written agreement among
the shareholders of the Company. Any transfer made in violation of any said written agreement between the shareholders
shall be considered as null and void.
10.3. Corporate details regarding the shareholders of the Company and any transfer of shares shall be reflected in the
Company's share register.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Management
Art. 12.
12.1. The Company is managed by a board of managers (conseil de gérance) composed of managers, which shall be
divided into 3 (three) categories respectively denominated category A manager(s) (the “Category A manager(s)”), cate-
gory B manager(s) (the “Category B Manager(s)”) and category C manager(s) (the “Category C Manager(s)”). The manager
(s) need not be shareholders of the Company.
12.2. The holders of Class A Shares shall have the right to propose the designation of the Category A Manager(s), who
shall be appointed by the general meeting of shareholders among a list of candidates proposed by the holders of Class A
Shares.
12.3. In case of termination of the mandate of a Category A Manager for whatever reason, the holders of Class A
Shares who initially proposed the designation of such Category A Manager for appointment, shall have the right to propose
the designation of a replacement Category A Manager, who shall be appointed by the general meeting of shareholders
and who shall serve for the remaining term of her/his predecessor.
12.4. The holders of Class A Shares shall ensure that the majority of the Category A Managers are resident outside
of the United Kingdom and Germany.
12.5. Upon proposal of the holder(s) of Class A Shares who initially proposed a candidate for appointment of Category
A Manager the general meeting of shareholders shall dismiss the relevant Category A Manager.
12.6. The holders of Class B Shares shall have the right to propose the designation of the Category B Manager(s), who
shall be appointed by the general meeting of shareholders among a list of candidates proposed by the holders of Class B
Shares.
12.7. In case of termination of the mandate of a Category B Manager for whatever reason, the holders of Class B
Shares who initially proposed the designation of such Category B Manager for appointment, shall have the right to propose
the designation of a replacement Category B Manager, who shall be appointed by the general meeting of shareholders
and who shall serve for the remaining term of her/his predecessor.
12.8. Upon proposal of the holder(s) of Class B Shares who initially proposed a candidate for appointment of Category
B Manager the general meeting of shareholders shall dismiss the relevant Category B Manager.
12.9. The managers may be dismissed ad nutum.
35101
L
U X E M B O U R G
12.10. The Category C Managers shall be professionally Luxembourg residing natural persons and shall be appointed
by the general meeting of shareholders.
12.11. The shareholders and the Company shall ensure that the central management and control of the Company is
exercised and substantiated in Luxembourg (and in any case outside the United Kingdom and Germany).
12.12. The board of managers may from time to time dub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad
hoc agent(s) who need not to be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
12.13 The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration
of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 13.
13.1. The board shall have responsibility for the supervision, management, overall direction and decision making of the
Company and its business in accordance with the Law save in respect of those matters which are specifically reserved by
the Law, these Articles, or by any written agreement between the shareholders and relating to the Company to the
general meeting of shareholders.
13.2. In dealing with third parties, the board will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided that the terms of
these Articles or any written agreement between the shareholders and relating to the Company shall have been complied
with.
13.3. The quorum for any meeting of the board shall be one (1) Category A Manager and one (1) Category C Manager.
For the avoidance of doubt, and subject to clause 13.9 and 13.10, the attendance of a Category B Manager shall not be
required for any meeting of the board to be quorate.
13.4. Notwithstanding any provision to the contrary in these Articles, to be quorate any meeting of the board must
be attended by a majority of managers (by reference to combined voting strength) that are resident outside of the United
Kingdom and Germany.
13.5. The board shall decide on matters by simple majority vote and each manager shall have one vote at any meeting
of the board.
13.6. The chairman shall be elected among the Category A Managers and as chairman will have a casting vote in case
of parity of votes.
13.7. The Company shall be bound by the sole signature of any Category A Manager subject to the consent requirement
as described under Article 13.10. In addition, the Company shall be bound by the sole signature of any Category C Manager
for actions to which power has been delegated in accordance with these Articles.
13.8. Subject to the terms of these Articles, Category C Managers may, without prior board meeting, carry out the
following actions on behalf of the board provided the relevant action has been approved in advance (either specifically or
in a general approval) by a Category A Manager:
- concluding, amending or terminating any commercial lease agreement on the part of the Company or in respect of
any of its subsidiaries;
- concluding, amending or terminating any residential lease agreement on the part of the Company or in respect of
any of its subsidiaries where the total annual net rent (excluding any ancillary costs) per lease is equal or greater than
EUR 15,000 (fifteen thousand Euro) provided that this is in accordance with any business plan in relation to the Company;
- initiating litigation or engaging advisors on behalf of the Company or in respect of any of its subsidiaries in relation
thereto;
- concluding any contract for the refurbishment and/or maintenance of any asset on the part of the Company or in
respect of any of its subsidiaries in accordance with any business plan in relation to the Company where the amount
payable under such contract is equal or greater than EUR 10,000 (ten thousand Euro);
- concluding of confidentiality and insurance agreements on the part of the Company or in respect of any of its
subsidiaries;
- concluding any agreement on the part of the Company or in respect of any of its subsidiaries other than where such
conclusion is reserved to the board pursuant to clause 13.9; and
- opening bank accounts and making payments on behalf of the Company or in respect of any of its subsidiaries,
and in carrying out any of the actions described in this clause the relevant Category C Manager may have regard to
recommendations of an asset manager.
13.9. Subject to the provisions of these Articles, the following matters may only be taken at a board meeting or by a
written resolution signed by such number and type of managers who could, on their own, form a quorum and approve
the matter concerned at a duly convened meeting of the board:
- concluding any agreement on the part of the Company or in respect of any of its subsidiaries relating to the receipt
or provision of finance (including the renewal, extension or refinancing of any previous financing) or relating to hedging
arrangements or the provision of any guarantee, security or indemnity;
- concluding any agreement on the part of the Company or in respect of any of its subsidiaries in relation to the
acquisition or sale of any asset;
35102
L
U X E M B O U R G
- deciding all significant standard terms which must be included in any lease of any asset which is to be entered into
by the Company or in respect of any of its subsidiaries; and
- concluding any contract on the part of the Company or in respect of any of its subsidiaries relating to the refurbish-
ment and/or maintenance of any asset not in accordance with the any business plan in relation to the Company.
13.10. Any decision relating to any of the following matters shall require the prior written consent of each shareholder
or a vote in favour of each shareholder at a general meeting of the shareholders of the Company properly convened and
held or the unanimous approval of the board:
- acquisition of any property, shares, bonds, debt or any other interest or commitment other than where this is done
in accordance with, or in order to implement a matter approved in any business plan relating to the Company;
- disposal of any asset or property which has not been provided for in any business plan relating to the Company (save
for any sale in accordance with any written agreement between the shareholders and relating to the Company);
- commencement or settlement of material litigation;
- entry or termination of any material contract (being a contract of a value of more than EUR 50,000 (fifty thousand
Euro) per annum;
- grant of any guarantee or indemnity by the Company or any of its subsidiaries (other than in the ordinary course of
business);
- appointment, termination and replacement of appointment of any material parties relevant to the existence and
operation of the Company other than an asset manager;
- adoption or material amendment to any business plan relating to the Company;
- subject to the provisions of any written agreement between the shareholders and relating to the Company, any
arrangement for any joint venture or partnership as between the Company and another person or for the acquisition of
the whole or substantially the whole of the assets and undertaking of the Company or an acquisition by the Company of
any part of the issued share capital or of the assets and undertaking of another person; and
- any transaction between the Company and a shareholder or an associated company or affiliate of a shareholder and
any transaction which is not on arm's length terms and in the ordinary course of business.
Art. 14.
14.1. Meetings of the board of managers shall be properly convened and minuted and held at such times as may be
determined by the board and in any event not less than quarterly at such times in Luxembourg as may be determined by
the board.
14.2. The shareholders shall procure that any manager proposed for appointment by them shall (either themselves or
through their representative or proxies) personally attend such meetings of the board in Luxembourg, subject to Article
14.5.
14.3. No board meeting shall ordinarily be convened on less than five (5) business days' notice, but board meetings
may be convened by giving not less than one (1) hours' notice if the interests of the Company or its shareholders would
in the reasonable opinion of a Category A Manager be likely to be adversely affected to a material extent if the business
to be transacted at such board meeting were not dealt with as a matter of urgency or if all the managers agree.
14.4. Any notice of a board meeting shall include an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed
at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.
14.5. The managers may, in accordance with the Articles, attend a meeting of the board by telephone or video con-
ferencing provided that:
- the telephone conference is at no time initiated from within the United Kingdom or Germany;
- the majority (by combined voting strength) of the managers are attending the meeting of the board in Luxembourg
and no manager participates in the meeting from Germany;
- the minutes of the relevant meeting(s) of the board record from which location the relevant manager(s) attended
the meeting(s) of the board by means of telephone or video conferencing (as applicable).
14.6. Each manager may appoint for a given board meeting a representative for himself or herself, subject that a manager
may only appoint a representative for the same category.
14.7. A representative appointed shall be entitled to attend and vote at any meeting at which the manager appointing
him/her is not personally present, and generally in the absence of his/her appointor to do all the things which his appointor
is authorised or empowered to do.
14.8. A manager who is also a representative shall be entitled, in the absence of his/her appointor:
- to a separate vote on behalf of his appointor in addition to his own vote on his own account; and
- to be counted as part of the quorum of the board on his own account and in respect of the manager for whom he
is the representative.
14.9. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.
35103
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Shareholders.
15.1. Any sole shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting of shareholders.
15.2. In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
15.3. However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholder
owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1
st
of July of each year and ends on the 30
th
of June of the
following year.
Art. 17. Financials.
17.1. Each year, with reference to 30 of June, the Company's accounts are established and the board of managers
prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
17.2. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Reserve - Dividend.
18.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit.
18.2. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until
this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
18.3. The balance of net profits may be distributed to the shareholders in accordance with the provisions of any written
agreement between the shareholders and relating to the Company.
18.4. The board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following
conditions:
- The board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim
dividends;
- These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Legal and contractual references. Reference is made to the provisions of the Law and to any written agreement
relating to the Company between the shareholders for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Sixth resolutioni>
Discharge is given the resigning manager, Mrs Tessy LANG for the performance of her mandate of manager.
<i>Seventh resolutioni>
Mr Elliot GREENBERG, company director, born in New York (USA) on January 19, 1959, residing at 35 Winding Brook
Road, New Rochelle, New York 10804, USA, is appointed as manager of the category A for an unlimited duration.
Mr Steven Howard KASOFF, company director, born in New York (USA) on April 23 19, 1971, residing at 105
Deertrack Lane, Irvington, New York 10533, USA, is appointed as manager of the category A for an unlimited duration.
Mr. Christoph SCHMID, employee, born in Stuttgart (Germany), on December 18 19, 1975, residing at Melcherstrasse
74, 48149 Münster, Germany, is appointed as manager of the category B for an unlimited duration.
Mr. Mark GORHOLT, company director, born in Trier (Germany) on November 26, 1980, residing professionally at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Grand Duchy of Luxembourg is appointed as manager
of the category C for an unlimited duration.
Mr. Frank PLETSCH, company director, born in Trier (Germany) on July 15, 1974, residing professionally at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Grand Duchy of Luxembourg is appointed as manager of the
category C for an unlimited duration.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,350.-.
35104
L
U X E M B O U R G
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and German states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by its surname, Christian name, civil status and
residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.
Follows the German translation of the preceding text:
Im Jahre zwei tausend dreizehn, am fünfzehnten Januar.
Vor mit Maître Jean SECKLER, Notar mit Amtswohnsitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
SIND ERSCHIENEN:
1. die Gesellschaft ELLIOTT INTERNATIONAL, L.P., mit Sitz in c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309,
Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands,
2. die Gesellschaft ELLIOTT ASSOCIATES, L.P., mit Sitz in c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, DE 19801 Wilmington, County of New Castle, Vereinigte Staaten von Amerika, and
3. die Gesellschaft Westfalen Grundstücks- und Immobilien GmbH & Co. KG, mit Sitz in Lüdinghauser Strasse 23,
D-59387 Ascheberg, Deutschland,
hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Angestellter, berufsansässig in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Gross-
herzogtum Luxemburg, auf Grund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht.
Besagte Vollmachten, werden nach gehöriger „ne varietur“ Signatur, durch den amtierenden Notar und den Bevoll-
mächtigten gegenwärtiger Urkunde beigebogen.
Die Erschienenen ersuchen dem amtierenden Notar, durch ihren Bevollmächtigten, nachstehenden zu beurkunden:
Die Erschienenen sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) „I-Wohnen S.à r.l.“, mit Sitz in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxem-
bourg Sektion B Nummer 172.166, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 10.
Oktober 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 2796 am 17. November 2012.
Die Erschienen, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter welche das gesamte Gesellschaftskapital ver-
treten, haben in gegenwärtiger ausserordentlichen Gesellschafterversammlung einstimmig folgende Beschlüsse genom-
men:
<i>Erster Beschlussi>
Es werden zwei (2) Klassen von Anteilen erschaffen, nämlich Anteile der Klasse A, und Anteile der Klasse B.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die fünf tausend acht hundert zwölf (5.812) bestehenden Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (1,- EUR),
welche von der Gesellschaft ELLIOTT INTERNATIONAL, L.P., vorbenannt, gehalten werden, werden gegen fünf tausend
acht hundert zwölf (5.812) neue Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgetauscht.
Die fünf tausend acht hundert zwölf (5.812) bestehenden Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (1,- EUR),
welche von der Gesellschaft ELLIOTT ASSOCIATES, L.P., vorbenannt, gehalten werden, werden gegen fünf tausend acht
hundert zwölf (5.812) neue Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgetauscht.
Die acht hundert sechsundsiebzig (876) bestehenden Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (1,- EUR), welche
von der Gesellschaft Westfalen Grundstücks- und Immobilien GmbH & Co. KG, vorbenannt, gehalten werden, werden
gegen acht hundert sechsundsiebzig (876) neue Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je einem Euro (1,- EUR)
ausgetauscht.
<i>Dritter Beschlussi>
Das Gesellschaftskapital wird um eine Summe von zwei und vierzig tausend fünf hundert Euro (42.500,- EUR) aufge-
stockt, und somit das Gesellschaftskapital von seinem aktuellen Stand von zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR)
auf fünf und fünfzig tausend Euro (55.000,- EUR) zu erhöhen, durch Schaffung und Ausgabe durch neun und dreissig tausend
zwei hundert und zehn (39.210) neue Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je einem Euro (1,- EUR), welche
dieselben Rechte und Pflichten haben wie die bestehenden Anteile der Klasse A, und durch Schaffung und Ausgabe von
drei tausend zwei hundert neunzig (3.290) neue Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je einem Euro (1,- EUR),
welche dieselben Rechte und Pflichten haben wie die bestehenden Anteile der Klasse B.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Gesellschaft ELLIOTT ASSOCIATES, L.P., vorbenannt, hat teilweise auf ihr Zeichnungsvorrecht verzichtet, und
die zweiundvierzig tausend fünf hundert (42.500) neuen Anteile der Klasse A und B mit einem Nennwert von je einem
Euro (1,- EUR), wurden durch die aktuellen Gesellschafter, gezeichnet wie folgt:
35105
L
U X E M B O U R G
- sieben und zwanzig tausend zwei hundert dreissig (27.230) neue Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je
einem Euro (1,- EUR), alle gezeichnet durch die Gesellschaft ELLIOTT INTERNATIONAL, L.P., vorbenannt, und voll
eingezahlt durch eine Barzahlung von sieben und zwanzig tausend zwei hundert dreissig Euro (27.230,- EUR)
- elf tausend neun hundert achtzig (11.980) neue Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je einem Euro (1,-
EUR), alle gezeichnet durch die Gesellschaft ELLIOTT ASSOCIATES, L.P., vorbenannt, und voll eingezahlt durch eine
Barzahlung von elf tausend neun hundert achtzig Euro (11.980,- EUR)
- drei tausend zwei hundert neunzig (3.290) neue Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je einem Euro (1,-
EUR), alle gezeichnet durch die Gesellschaft Westfalen Grundstücks- und Immobilien GmbH & Co. KG, vorbenannt, und
voll eingezahlt durch eine Barzahlung von drei tausend zwei hundert neunzig Euro (3.290,- EUR).
Die Summe von zwei und vierzig tausend fünf hundert Euro (42.500,- EUR) steht der Gesellschaft zur freien Verfügung,
so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Vierter Beschlussi>
Das Geschäftsjahr soll von nun jeden 1. Juli beginnen und am 30. Juni des darauf folgenden Jahres enden, ausser für das
erste Geschäftsjahr, welches am 10. Oktober 2012 begann und am 30. Juni 2013 endet.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Statuten der Gesellschaft werden komplett neu formuliert, und werden jetzt folgenden Wortlaut erhalten:
Art. 1. Gesellschaftsgründung. Gegründet wird eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à respon-
sabilité limitée), die durch die für ein solches Rechtssubjekt geltenden Gesetze, insbesondere durch das Gesetz vom 10.
August 1915 über Wirtschaftsunternehmen in geänderter Fassung (das „Gesetz“), sowie durch die Satzung (nachfolgend
die „Satzung“) geregelt wird (nachfolgend die „Gesellschaft“).
Art. 2. Gesellschaftszweck.
2.1. Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen und Anteilsscheinen in Luxemburg oder
im Ausland in jeder Form gleich welcher Art sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile und Anteilsscheine. Die
Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien, Anteile und andere
Kapitalbeteiligungen, Anleihen, Schuldtitel, Einlagenzertifikate und andere schuldrechtliche Wertpapiere und im allgemei-
neren Sinne alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von einer Publikums- oder privaten Gesellschaft gleich
welcher Art ausgegeben wurden.
2.2. Die Gesellschaft kann Mittel in jeder Form außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot aufnehmen. Sie kann
ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung Wechsel, Anleihen und Schuldtitel sowie Schuldverschreibungen und/oder
Anteilspapiere emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen und/oder Emissi-
onen von Wertpapieren, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder
mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter
Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind
(nachfolgend die „verbundenen Unternehmen“). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten
Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu besichern. Die
Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in sonstiger
Weise Sicherheiten dafür schaffen.
2.3. Die Gesellschaft kann des Weiteren in Erwerb und Management eines Portfolios von Patenten und/oder sonstigen
geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.
2.4. Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des
effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen
Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.
2.5. Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indi-
rekten Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Fördern,
Verwalten, Erwerb, Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwick-
lung, Umbau, Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, hypothekarische Beleihung, Verpfändung
oder Belastung in anderer Weise von beweglichem Eigentum oder Immobilien.
2.6. Darüber hinaus kann die Gesellschaft in Zusammenhang mit Immobilien administrative, technische, finanzielle,
wirtschaftliche und Managementdienstleistungen für andere Gesellschaften, Personen oder Unternehmen erbringen, die
unmittelbar oder mittelbar von der Gesellschaft kontrolliert werden oder unmittelbar oder mittelbar unter der Kontrolle
derselben Gesellschafter der Gesellschaft stehen.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Firma. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung trägt den Namen „I-Wohnen S.à r.l.“.
Art. 5. Gesellschaftssitz.
5.1 Der Hauptgeschäftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt.
35106
L
U X E M B O U R G
5.2 Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter mit Beratungen in der für Satzungsänderungen
vorgesehenen Weise an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
5.3 Die Adresse des Hauptgeschäftssitzes kann innerhalb der Stadt durch Entscheidung des Vorstands verlegt werden.
5.4 Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland haben.
Art. 6. Kapital - Geschäftsanteile. Das Kapital wird auf FÜNFUNDFÜNFZIGTAUSEND EURO (55.000,- EUR) festge-
setzt, unterteilt in FÜNFZIGTAUSENDACHTHUNDERTVIERUNDDREISSIG (50.834) Geschäftsanteile der Klasse A
(die „Geschäftsanteile der Klasse A“) und VIERTAUSENDEINHUNDERTSECHSUNDSECHZIG (4.166) Geschäftsanteile
der Klasse B (die „Geschäftsanteile der Klasse B“) zu jeweils EINEM EURO (1,00 EUR).
Art. 7. Das Kapital kann jederzeit durch Entscheidung der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 8. Jeder Geschäftsanteil verleiht Anspruch auf einen Bruchteil des Unternehmensvermögens und der Gewinne
der Gesellschaft in direktem Verhältnis zur Anzahl der bestehenden Geschäftsanteile.
Art. 9. Gegenüber der Gesellschaft sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro
Geschäftsanteil zulässig ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft
benennen.
Art. 10.
10.1 Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, können die von diesem einzigen Gesellschafter gehaltenen Ge-
schäftsanteile frei übertragen werden.
10.2. Hat die Gesellschafter mehrere Gesellschafter können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß
den Anforderungen des Art. 189 des Gesetzes sowie vorbehaltlich etwaiger weiterer Übertragungsauflagen, die zwischen
den Gesellschaftern der Gesellschafter schriftlich vereinbart worden sind, übertragen werden. Übertragungen unter Ver-
letzung derartiger schriftlicher Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern sind null und nichtig.
10.3. Detaillierte Angaben zu den Gesellschaftern der Gesellschaft und Anteilsübertragungen sind im Anteilsregister
der Gesellschaft enthalten.
Art. 11. Die Gesellschaft darf nicht auf Grund von Tod, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, Insolvenz oder
Konkurs des Alleingesellschafters oder eines der Gesellschafter aufgelöst werden.
Geschäftsführung
Art. 12.
12.1. Die Gesellschaft steht unter der Leitung der Geschäftsführung (conseil de gérance), die sich aus Geschäftsführern
zusammensetzt, die wiederum in 3 (drei) Kategorien aufgeteilt sind, nämlich der/die Geschäftsführer der Kategorie A
(der/die „Geschäftsführer der Kategorie A“), der/die Geschäftsführer der Kategorie B (der/die „Geschäftsführer der
Kategorie B“) und der/die Geschäftsführer der Kategorie C (der/die „Geschäftsführer der Kategorie C“). Die Geschäfts-
führer müssen nicht notwendigerweise Gesellschafter sein.
12.2. Die Inhaber der Geschäftsanteile der Klasse A haben das Recht, den/die Geschäftsführer der Kategorie A zu
designieren; diese/r wird/werden sodann von der Gesellschafterversammlung aus einer von den Inhabern der Geschäfts-
anteile der Klasse A vorgeschlagenen Kandidatenliste in sein Amt/ihre Ämter bestellt.
12.3. Bei Aufhebung des Mandats für einen Geschäftsführer der Kategorie A aus jedweden Gründen haben die Inhaber
der Geschäftsanteile der Klasse A, die anfangs die Designierung jenes Geschäftsführers der Kategorie A zwecks Bestellung
vorgenommen haben, das Recht, als Nachfolger einen Geschäftsführer der Kategorie A zu benennen, der sodann von der
Gesellschafterversammlung bestellt wird und das Amt für die noch verbleibende Amtszeit seines Vorgängers ausübt.
12.4. Die Inhaber der Geschäftsanteile der Klasse A stellen sicher, dass die Mehrheit der Geschäftsführer der Kategorie
A außerhalb des Vereinigten Königreichs und außerhalb von Deutschland ansässig ist.
12.5. Auf Vorschlag des/der Inhaber/s der Geschäftsanteile der Klasse A, der/die anfangs einen Kandidaten für die
Bestellung eines Geschäftsführers der Kategorie A vorgenommen hat/haben, wird die Gesellschafterversammlung den
betreffenden Geschäftsführer der Kategorie A seines Amtes entheben.
12.6. Die Inhaber der Geschäftsanteile der Klasse B haben das Recht, den/die Geschäftsführer der Kategorie B zu
designieren; diese/r wird/werden sodann von der Gesellschafterversammlung aus einer von den Inhabern der Geschäfts-
anteile der Klasse B vorgeschlagenen Kandidatenliste in sein Amt/ihre Ämter bestellt.
12.7. Bei Aufhebung des Mandats für einen Geschäftsführer der Kategorie B aus jedweden Gründen haben die Inhaber
der Geschäftsanteile der Klasse B, die anfangs die Designierung jenes Geschäftsführers der Kategorie B zwecks Bestellung
vorgenommen haben, das Recht, als Nachfolger einen Geschäftsführer der Kategorie B zu benennen, der sodann von der
Gesellschafterversammlung bestellt wird und das Amt für die noch verbleibende Amtszeit seines Vorgängers ausübt.
12.8. Auf Vorschlag des/der Inhaber/s der Geschäftsanteile der Klasse B, der/die anfangs einen Kandidaten für die
Bestellung eines Geschäftsführers der Kategorie B vorgenommen hat/haben, wird die Gesellschafterversammlung den
betreffenden Geschäftsführer der Kategorie B seines Amtes entheben.
12.9. Die Geschäftsführer können ihrer Ämter ad nutum enthoben werden.
35107
L
U X E M B O U R G
12.10. Bei den Geschäftsführern der Kategorie C muss es sich um natürliche, in Luxemburg ansässige oder beruflich
ansässige Personen handeln, die von der Gesellschafterversammlung bestellt werden.
12.11. Die Gesellschafter und die Gesellschaft werden sicherstellen, dass das zentrale Management und die zentrale
Kontrolle der Gesellschaft in Luxemburg (und in jedem Fall außerhalb des Vereinigten Königreichs und außerhalb von
Deutschland) ausgeübt und bestätigt werden.
12.12. Die Geschäftsführung kann ihre Vollmachten für spezifische Aufgaben von Zeit zu Zeit an einen oder mehrere
ad hoc-Handlungsbevollmächtigte/n weiterdelegieren, der/die nicht notwendigerweise Gesellschafter oder Geschäftsfüh-
rer der Gesellschaft sein muss/müssen.
12.13 Die Geschäftsführung legt die Vollmachten, Pflichten und (etwaigen) Vergütungen ihres/ihrer Handlungsbevoll-
mächtigten, die Dauer des Vertretungszeitraums sowie alle weiteren sachdienlichen Bedingungen der Vertretung fest.
Art. 13.
13.1. Die Geschäftsführung trägt die Verantwortung für die Beaufsichtigung, das Management, die gesamte Anleitung
und das Treffen von Entscheidungen der Gesellschaft und ihrer Geschäftstätigkeiten nach Maßgabe des Gesetzes, außer
in Bezug auf die Angelegenheiten, die kraft Recht, gemäß diesem Gesellschaftsvertrag oder einer sonstigen zwischen den
Gesellschaftern getroffenen schriftlichen Vereinbarung über die Gesellschaft der Gesellschafterversammlung vorbehalten
sind.
13.2. Im Umgang mit Dritten stehen der Geschäftsführung unter jeglichen Umständen sämtliche Vollmachten für die
Vornahme von Handlungen im Namen der Gesellschaft und für die Durchführung und Genehmigung sämtlicher Maßnah-
men und Geschäftsvorgänge zu, die mit dem Zweck der Gesellschaft einher gehen; dabei gilt die Voraussetzung, dass die
Bedingungen dieses Gesellschaftsvertrags oder einer zwischen den Gesellschaftern getroffenen schriftlichen Vereinbarung
über die Gesellschaft eingehalten werden.
13.3. Zwecks Beschlussfähigkeit der Geschäftsführer ist die Anwesenheit eines (1) Geschäftsführer der Kategorie A
und eines (1) Geschäftsführer der Kategorie C erforderlich. Zur Klarstellung wird hier festgehalten, dass die Anwesenheit
eines Geschäftsführers der Kategorie B vorbehaltlich der in Art. 13.9 und 13.10 getroffenen Regelungen für die Be-
schlussfähigkeit der Geschäftsführung nicht erforderlich ist.
13.4. Unbeschadet gegenteiliger Bestimmungen in diesem Gesellschaftsvertrag muss (unter Bezugnahme auf die kom-
binierten Stimmrechte) die Mehrheit der Geschäftsführer, die außerhalb des Vereinigten Königreichs und außerhalb von
Deutschland ansässig sind, zwecks Beschlussfähigkeit einer Geschäftsführungssitzung anwesend sein.
13.5. Die Geschäftsführung trifft ihre Entscheidungen mit einfacher Mehrheit, und jedem Geschäftsführer steht bei
Geschäftsführungssitzungen eine Stimme zu.
13.6. Der Vorsitzende einer Sitzung wird aus dem Kreis der Geschäftsführer der Kategorie A gewählt und hat in dieser
Kapazität im Falle einer Stimmengleichheit das Recht der Abgabe der ausschlaggebenden Stimme.
13.7. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A gebunden, unter
Vorbehalt des in Artikel 13.10 enthaltenen Zustimmungserfordernisses. Außerdem kann die Gesellschaft bei Maßnahmen,
für die die Vollmacht gemäß diesem Gesellschaftsvertrag delegiert wurde, durch die alleinige Unterschrift eines Ge-
schäftsführers der Kategorie C gebunden werden.
13.8. Vorbehaltlich der in diesem Gesellschaftsvertrag getroffenen Regelungen können Geschäftsführer der Kategorie
C ohne eine vorherige Geschäftsführungssitzung die folgenden Maßnahmen im Namen der Geschäftsführung durchführen,
soweit die betreffenden Maßnahmen im Voraus (entweder spezifisch oder anhand einer allgemeinen Genehmigung) von
einem Geschäftsführer der Kategorie A genehmigt worden sind:
- Abschluss, Änderung oder Ergänzung oder Kündigung eines Gewerbemietvertrags seitens der Gesellschaft oder einer
Ihrer Filialen;
- Abschluss, Änderung oder Ergänzung oder Kündigung eines Wohnungsmietvertrags seitens der Gesellschaft oder
einer Ihrer Filialen, wenn die gesamte jährliche Nettomiete (ohne Nebenkosten) pro Vermietung sich auf EUR 15.000
(fünfzehntausend Euro) oder mehr beläuft, vorausgesetzt, dieser Vorgang entspricht dem Geschäftsplan für die Gesell-
schaft;
- Einleitung von Rechtsstreitigkeiten oder Inanspruchnahme von Beratern im Namen der Gesellschaft oder einer Ihrer
Filialen in derartigen Zusammenhängen;
- Abschluss von Verträgen über die Renovierung und/oder Wartung von Vermögenswerten seitens der Gesellschaft
oder einer Ihrer Filialen gemäß dem Geschäftsplan, wenn der im Rahmen eines derartigen Vertrags zu zahlende Betrag
sich auf EUR 10.000 (zehntausend Euro) oder mehr beläuft;
- Abschluss von Geheimhaltungs- und Versicherungsverträgen seitens der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen;
- Abschluss jeglicher Verträge seitens der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen, außer den Verträgen, deren Abschluss
gemäß Art. 13.9 der Geschäftsführung vorbehalten ist; und
- Eröffnung von Bankkonten und Vornahme von Zahlungen im Namen der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen,
wobei der betreffende Geschäftsführer der Kategorie C bei der Durchführung der in diesem Artikel beschriebenen
Maßnahmen die Empfehlungen eines Vermögensverwalters in Betracht ziehen kann.
35108
L
U X E M B O U R G
13.9. Vorbehaltlich der in diesem Gesellschaftsvertrag getroffenen Regelungen müssen die folgenden Angelegenheiten
ausschließlich im Rahmen einer Geschäftsführungssitzung oder anhand eines schriftlichen Beschlusses entschieden wer-
den, der von einer Anzahl und Art von Geschäftsführern zu unterzeichnen ist, die eigenständig eine Beschlussfähigkeit
begründen und die betreffende Angelegenheit bei einer ordnungsgemäß abgehaltenen Geschäftsführungssitzung geneh-
migen könnten:
- Abschluss von Verträgen seitens der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen, die sich auf die Entgegennahme oder die
Beschaffung von Finanzen beziehen (einschließlich Verlängerungen, Ausweitungen oder Refinanzierungen vorangegange-
ner Finanzierungen) oder auf Hedging-Vorkehrungen oder die Beschaffung von Garantien, Bürgschaften, Sicherheiten
oder Freistellungen beziehen;
- Abschluss von Verträgen seitens der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen, die sich auf den Erwerb oder Verkauf von
Vermögenswerten beziehen;
- Entscheidung aller signifikanten Standardbedingungen, die in Leasingverträgen über Vermögenswerte enthalten sein
müssen, welche von der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen abzuschließen sind; und
- Abschluss von Verträgen seitens der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen, die sich auf die Renovierung und/oder
Wartung von Vermögenswerten beziehen, die nicht gemäß den Geschäftsplänen der Gesellschaft vorgenommen werden.
13.10. Jegliche Entscheidungen zu den folgenden Angelegenheiten bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung
eines jeden Gesellschafters oder der Ja-Stimme eines jeden Gesellschafters bei ordnungsgemäß einberufenen und abge-
haltenen Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft oder aber der einstimmigen Genehmigung der Geschäftsführung:
- Erwerb von Immobilien, Aktien, Anteilen, Anleihen, Schulden oder sonstigen Interessen oder Verpflichtungen, soweit
dies nicht gemäß oder zwecks Umsetzung einer Angelegenheit geschieht, die in einem Geschäftsplan der Gesellschaft
genehmigt worden sind;
- Veräußerung von Vermögenswerten oder Immobilien, wenn diese nicht in einem Geschäftsplan der Gesellschaft
vorgesehen ist (außer Verkäufen gemäß einer schriftlichen Vereinbarung bezüglich der Gesellschaft zwischen den Ge-
sellschaftern);
- Einleitung oder Beilegung wesentlicher Rechtsstreitigkeiten;
- Abschluss oder Beendigung wesentlicher Verträge (d.h. Verträge mit einem Wert von über € 50.000 (fünfzigtausend
Euro) pro Jahr;
- Gewährung von Garantien, Bürgschaften oder Freistellungen seitens der Gesellschaft oder einer ihrer Tochterge-
sellschaften (außer im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs);
- Bestellung, Kündigung und Austausch einer Bestellung von wesentlichen Parteien, die für den Bestand und Betrieb
der Gesellschaft von Bedeutung sind, außer Vermögensverwaltern;
- Annahme oder wesentliche Änderungen von Geschäftsplänen der Gesellschaft;
- vorbehaltlich der Bestimmungen schriftlicher Vereinbarungen über die Gesellschaft zwischen den Gesellschaftern:
jegliche Vorkehrungen für Joint Ventures oder Mitbeteiligungen zwischen der Gesellschaft und einer anderen Person oder
über den Erwerb der Gesamtheit oder nahezu der Gesamtheit von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft oder ein Erwerb beliebiger Teile des ausgegebenen Gesellschaftskapitals oder der Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten einer anderen Person seitens der Gesellschaft; und
- jegliche Transaktionen zwischen der Gesellschaft und einem Gesellschafter oder einer verbundenen oder ange-
schlossenen Gesellschaft eines Gesellschafters sowie jegliche Transaktionen, die nicht nach rein geschäftlichen Bedingun-
gen und nicht im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs durchgeführt werden.
Art. 14.
14.1. Die Sitzungen der Geschäftsführer sind ordnungsgemäß einzuberufen und protokollarisch festzuhalten und finden
zu den von der Geschäftsführung festgelegten Zeiten und in jedem Fall mindestens in vierteljährlichen Abständen zu den
von der Geschäftsführung bestimmten Zeiten in Luxemburg statt.
14.2. Die Gesellschafter werden dafür sorgen, dass jeder von ihnen für eine Bestellung designierte Geschäftsführer
(entweder persönlich oder anhand seines Vertreters oder Stimmrechtsbevollmächtigten) diesen Sitzungen der Ge-
schäftsführung in Luxemburg persönlich beiwohnt, unter Vorbehalt von Artikel 14.5.
14.3. Jede Sitzung der Geschäftsführung muss unter Einhaltung einer Frist von mindestens fünf (5) Geschäftstagen
einberufen werden; allerdings können Geschäftsführungssitzungen unter Einhaltung einer Frist von mindestens einer (1)
Stunde einberufen werden, wenn die Interessen der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter nach vernünftiger Beurteilung
eines Geschäftsführers der Kategorie A aller Wahrscheinlichkeit nach in erheblichem Ausmaß nachteilig beeinträchtigt
würden, wenn die Angelegenheit, die bei einer solchen Sitzung zu behandeln ist, nicht als dringend eingestuft wird, oder
wenn sämtliche Geschäftsführer einer solchen kurzfristig einberufenen Sitzung zustimmen.
14.4. Den Einladungen zu Sitzungen der Geschäftsführung ist eine Tagesordnung beizufügen, in der unter Angabe
angemessener Einzelheiten die während der Sitzung zu behandelnden Angelegenheiten aufgeführt sind; darüber hinaus
sind Kopien aller sachdienlichen Unterlagen beizufügen, die bei der Sitzung besprochen werden sollen.
14.5. Die Geschäftsführer können gemäß diesem Gesellschaftsvertrag einer Geschäftsführungssitzung auch per Telefon
oder Videokonferenz beiwohnen, vorausgesetzt:
35109
L
U X E M B O U R G
- die Telefonkonferenz wird zu keinem Zeitpunkt von einem Ort aus initiiert, der im Vereinigten Königreich oder in
Deutschland liegt;
- die Mehrheit (im Sinne der kombinierten Stimmrechte) der Geschäftsführer wohnt der Geschäftsführungssitzung in
Luxemburg bei und kein Geschäftsführer nimmt von Deutschland aus teil;
- in dem Protokoll der betreffenden Sitzung/en der Geschäftsführung wird angegeben, von welchem Ort aus der/die
jeweilige/n Geschäftsführer der/den Sitzung/en per Telefon oder Videokonferenz beigewohnt hat/haben.
14.6. Jeder Geschäftsführer kann für eine gegebene Geschäftsführungssitzung einen Vertreter für sich bestimmen; dabei
gilt allerdings, dass ein Geschäftsführer nur einen Vertreter für dieselbe Kategorie bestellen darf.
14.7. Ein bestellter Vertreter hat das Recht, jeder Sitzung beizuwohnen und dabei abzustimmen, bei der der ihn be-
stellende Geschäftsführer nicht persönlich anwesend ist, und im Allgemeinen im Falle der Abwesenheit der ihn bestel-
lenden Person sämtliche Angelegenheiten zu erledigen, zu denen die ihn bestellende Person ermächtigt und berechtigt
ist.
14.8. Ein Geschäftsführer, der außerdem die Funktion eines Vertreters erfüllt, ist bei Abwesenheit der ihn bestellenden
Person befugt:
- im Namen der ihn bestellenden Person eine separate Stimme zusätzlich zu seiner eigenen Stimme auf seine eigene
Verantwortung abzugeben; und
- bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit sowohl in eigener Person als auch in Bezug auf den Geschäftsführer, den
er vertritt, mitgezählt zu werden.
14.9. Kein Geschäftsführer übernimmt in dieser Kapazität eine persönliche Verpflichtung bezüglich der von ihm im
Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als Vertreter der Gesellschaft ist er nur für die Erledigung seines
Mandats verantwortlich.
Art. 15. Gesellschafter.
15.1 Der Alleingesellschafter übernimmt alle der Generalversammlung übertragenen Befugnisse.
15.2 Sind mehrere Gesellschafter vorhanden, kann sich jeder Gesellschafter ungeachtet der Anzahl der von ihm ge-
haltenen Geschäftsanteile an gemeinsamen Entscheidungen beteiligen. Jeder Gesellschafter hat Stimmrechte im Verhältnis
zu seiner Beteiligung. Gemeinsame Entscheidungen sind nur dann rechtsgültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern
verabschiedet werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals halten.
15.3 Beschlüsse zur Änderung der Satzung der Gesellschaft können jedoch vorbehaltlich der Bestimmungen des Ge-
setzes nur von der Mehrheit der Gesellschafter gefasst werden, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der
Gesellschaft halten.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli eines jedes Jahres und endet am 30. Juni
des darauffolgenden Jahres.
Art. 17.
17.1 In jedem Geschäftsjahr wird zum 30. Juni der Jahresabschluss der Gesellschaft aufgestellt und der Vorstand erstellt
eine Ergebnisrechnung mit Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.
17.2 Jeder Gesellschafter kann die vorgenannte Ergebnisrechnung und Bilanz am Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft
einsehen.
Art. 18.
18.1 Die im Jahresabschluss angegebenen Bruttogewinne der Gesellschaft stellen nach Abzug allgemeiner Aufwendun-
gen den Nettogewinn dar.
18.2 Ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft wird in die gesetzliche Rücklage
eingestellt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des nominellen Stammkapitals der Gesellschaft beträgt.
18.3 Der Saldo des Reingewinns kann an den/die Gesellschafter entsprechend der Vorschriften eines schriftlichen
Vertrages zwischen Gesellschaftern bezüglich der Gesellschaft verteilt werden.
18.4 Der Vorstand ist bevollmächtigt, jederzeit unter folgenden Bedingungen Zwischendividenden zu beschließen und
auszuschütten:
- Der Vorstand erstellt Zwischenbeschlüsse als Grundlage für die Ausschüttung von Zwischendividenden;
- Aus diesen Zwischendividenden geht hervor, dass ausreichende Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
als vereinbart gilt, dass der Ausschüttungsbetrag die realisierten Gewinne zum Ende des letzten Geschäftsjahres, zuzüglich
steuerlich vorgetragener Gewinne und ausschüttungsfähiger Reserven, jedoch abzüglich steuerlich vorgetragener Verluste
und Beträge, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz oder dieser Satzung in eine Rücklage eingestellt werden müssen,
nicht übersteigen darf.
Art. 19. Abwicklung. Bei Abwicklung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren,
gleich ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt, die von den Gesellschaftern bestellt und deren Befugnisse und Vergütung
von den Gesellschaftern festgelegt werden.
35110
L
U X E M B O U R G
Art. 20. Juristische und vertragliche Referenzen. Bei allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in dieser Satzung
vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes und die Vorschriften eines schriftlichen Vertrages zwischen
Gesellschaftern bezüglich der Gesellschaft Bezug genommen.
<i>Sechster Beschlussi>
Hiermit wird der kündigenden Geschäftsführerin, Tessy LANG, Entlastung für die Ausübung ihres Mandats erteilt.
<i>Siebter Beschlussi>
Herr Elliot GREENBERG, Geschäftsführer, geboren in New York (USA) am 19. Januar 1959, wohnhaft in 35 Winding
Brook Road, New Rochelle, New York 10804, USA wird als neuer Geschäftsführer der Kategorie A, für eine Unbestimmte
Dauer ernannt.
Herr Steven Howard KASOFF, Geschäftsführer, geboren in New York (USA) am 23. April 1971, wohnhaft in 105
Deertrack Lane, Irvington, New York 10533, USA wird als neuer Geschäftsführer der Kategorie A, für eine Unbestimmte
Dauer ernannt.
Herr Christoph SCHMID, Angestellter, geboren in Stuttgart (Deutschland), am 18. Dezember 1975, wohnhaft in
Melcherstrasse 74, 48149 Münster, Deutschland wird als neuer Geschäftsführer der Kategorie B, für eine Unbestimmte
Dauer ernannt.
Herr Mark GORHOLT, Geschäftsführer, geboren in Trier (Deutschland) am 26. November 1980, beruflich wohnhaft
in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Grossherzogtum Luxembourg wird als neuer Ge-
schäftsführer der Kategorie C, für eine Unbestimmte Dauer ernannt.
Herr Frank PLETSCH, Geschäftsführer, geboren in Trier (Deutschland) am 15. Juli 1974, beruflich wohnhaft in L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Grossherzogtum Luxembourg wird als neuer Geschäftsführer
der Kategorie C, für eine Unbestimmte Dauer ernannt.
<i>Schätzungi>
Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Lasten jeder Art, die von dem Zeichner auf Grund dieser Gründung zu
tragen sind, werden auf circa 1.350,- EUR geschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der
erschienenen Parteien in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung, und bei Unstimmigkeiten
zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist die englische Fassung bindend.
URKUNDLICH DESSEN wurde die vorliegende Urkunde in Junglinster an dem eingangs dieses Dokuments angege-
benen Datum errichtet.
Nachdem das Dokument dem erschienenen Vollmachtnehmer vorgelesen worden war, unterzeichnete er gemeinsam
mit dem Notar die vorliegende Urkunde.
Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 janvier 2013. Relation GRE/2013/360. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
FÜR GLEICHLAUTENDE ABLICHTUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Junglinster, den 6. Februar 2013.
Référence de publication: 2013019974/689.
(130023652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Grainger Luxembourg Germany (No.7) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.510.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 113.799.
DISSOLUTION
On the twenty-first day of December of the year two thousand and twelve,
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg;
THERE APPEARED:
Grainger Luxembourg Germany Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 16, avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 112.062
and with a share capital of twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400),
35111
L
U X E M B O U R G
here represented by Torsten Sauer, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed "ne varietur' by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
This appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:
1) That Grainger Luxembourg Germany (No. 7) S.à r.l. is a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated and existing under laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 16, avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 113.799 and having a share capital of three million five hundred ten thousand Euro (EUR
3,510,000) and that it has been incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
dated December 20, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 762 of April 20, 2006
(the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the
last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated December 8, 2010,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 341 of February 21, 201.
2) That the Company's share capital is fixed at three million five hundred ten thousand Euro (EUR 3,510,000) repre-
sented by one hundred forty thousand four hundred (140,400) shares in registered form, having a par value of twenty-
five Euro (EUR 25) each, all of which are fully paid up.
3) That the appearing party is the holder of all the shares of the Company.
4) That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.
5) That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company, and in its capacity as liquidator of the Company
has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything
necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
6) That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to settle
any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.
7) That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any existing
debt of the Company even if unknown at present.
8) That the liquidation of the Company is to be construed as definitely terminated.
9) That full and entire discharge is granted to the managers for the performance of their assignment.
10) That all the shares of the dissolved Company have been cancelled.
11) That the corporate documents of the dissolved Company shall be kept for the duration of five years at least at
Grainger plc, Citygate, St James' Boulevard, Newcastle upon Tyne, NE1 4JE, United Kingdom.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the Company as a result of the present deed, is approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède
Le vingt-et-un décembre de l'an deux mille douze,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A COMPARU:
Grainger Luxembourg Germany Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe à 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.062 et disposant d'un capital social de
douze mille quatre cents euros (EUR 12.400),
ici représentée par Torsten Sauer, attorney-at-law, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur' par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée comme ci-dessus, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:
35112
L
U X E M B O U R G
1) Que Grainger Luxembourg Germany (No. 7) S.à r.l. est une société à responsabilité limitée constituée et régie par
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.799
et disposant d'un capital social de trois millions cinq cent dix mille euros (EUR 3.510.000) et qu'elle a été constituée
suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence au Luxembourg, en date du 20 décembre 2005, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, No. 762 du 20 avril 2006 (la Société). Les statuts de la Société (les
Statuts) ont été modifies à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire
de résidence à Luxembourg, date du 8 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No.
341 du 21 février 2011.
2) Que le capital social de la Société est fixé à de trois millions cinq cent dix mille euros (EUR 3.510.000) représenté
par cent quarante mille quatre cents (140.400) parts sociales, sous forme nominative, d'une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25) chacune, toute entièrement libérées.
3) Que la comparante détient la totalité des parts sociales de la Société.
4) Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
5) Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs pour signer, exécuter et
délivrer tout acte et document, procéder à toute déclaration et entreprendre tout ce qui est nécessaire ou utile pour
rendre effectives les stipulations du présent acte.
6) Que la comparante en sa qualité de liquidateur de la société déclare s'engager de manière irrévocable à régler tout
le passif dû actuellement connu et inconnu de la Société dissoute.
7) Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tous les engagements
de la Société même inconnus à l'heure actuelle.
8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
9) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exécution de leur mandat.
10) Qu'il a été procédé à l'annulation des parts sociales de la Société dissoute.
11) Que les documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à Grainger plc, Citygate,
St James' Boulevard, Newcastle upon Tyne, NE1 4JE, Royaume-Uni.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cents euros
(EUR 1.400,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes qu'à la requête de la
personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, ce dernier a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: Sauer, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2012. Relation: EAC/2012/17736. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2013019923/113.
(130023430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Winnebago Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Wick Lane (Lux) S.à r.l.).
Capital social: GBP 1.010.000,00.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 167.395.
In the year two thousand and thirteen on the tenth day of January.
Before us, Maître Francis KESSELER, Public Notary residing in Esch-sur-Alzette.
THERE APPEARED:
35113
L
U X E M B O U R G
DS (Wick Lane Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, rue des Jardiniers,
L-1835 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 167139, and Viper Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8, rue Dicks,
L-1417 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 163447,
Both hereby represented by Andreea Antonescu, Avocat à la cour, with professional address in Luxembourg.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact:
- that the appearing parties are the existing shareholders (the "Shareholders") of Wick Lane (Lux) S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg,
with a share capital of GBP 1.010.000.-, having its registered office at 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 167395, incor-
porated by a deed of the undersigned notary, dated 5 March 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 1010, on 19 April 2012, page 48451 (the "Company");
- that the agenda of the meeting is as follows:
1. Change of corporate name of the company into "Winnebago Holdings S.à r.l.";
2. Subsequent decision to amend article 1 of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
- that the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to change the corporate name of the Company from "Wick Lane (Lux) S.à r.l." into "Win-
nebago Holdings S.à r.l."
<i>Second resolutioni>
Subsequently, the Shareholders resolve to amend Article 1 of the articles of association of the Company, which shall
henceforth read as follows:
" Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of Winnebago
Holdings S.à r.l., which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the "Company"), and in
particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the "Law"), as well as by the
present articles of association (hereinafter, the "Articles")."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day mentioned
at the beginning of this deed.
The deed having been read to the representative of the appearing party, said representative appearing signed together
with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le dixième jour de janvier.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
ONT COMPARU:
DS (Wick Lane Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167139, et
Viper Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163447,
Toutes deux ci-après représentées par Andreea Antonescu, avocat à la cour, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
35114
L
U X E M B O U R G
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la représentante et le notaire soussigné, resteront
annexées avec le présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter:
- que les parties comparantes sont les associés (les "Associés") de Wick Lane (Lux) S.à r.l, une société à responsabilité
limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de GBP 1.010.000.-ayant son
siège social au 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 167395, constituée par acte du notaire soussigné,
en date du 5 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1010, du 19 avril 2012, page
48451 (la "Société").
- que l'ordre du jour de la réunion est le suivant:
1. Changement de la dénomination de la société en «Winnebago Holdings S.à r.l.»;
2. Décision subséquente de modifier l'article 1 des statuts de la Société;
3. Divers.
- que les Associés ont pris les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés ont décidé de modifier la dénomination sociale de la Société de "Wick Lane (Lux) S.à r.l." en "Winnebago
Holdings S.à r.l.".
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence, les Associés ont décidé de modifier l'article 1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur
suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Winnebago Holdings S.à r.l. qui est
régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les «Statuts»).»
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s'élèvent approximativement à mille trois cents euros (EUR 1,300.-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande du comparant le présent acte
est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, en l'Etude du notaire soussigné, à la date qu'en tête du présent acte.
Et après que lecture ait été faite au représentant de la comparante, celui-ci a signé le présent acte ensemble avec le
notaire.
Signé: Antonescu, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 janvier 2013. Relation: EAC/2013/833. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013019632/103.
(130022941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2013.
Askania S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 120.177.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-first day of December,
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch sur Alzette, Grand Duchy of Luxembourg;
There appeared:
Freo Germany II Partners (SCA) SICAR, an investment company in risk capital (société d'investissement en capital à
risque), formed as a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), registered with the
Luxembourg register for commerce and trade under number R.C.S. Luxembourg B 123.906, having its registered office
at L-1331 Luxembourg 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, duly represented by its managing general partner Freo
Investment Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at EBBC 6D, route de Trèves
35115
L
U X E M B O U R G
L-2633 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.898 with a
share capital of EUR 12,600,
duly represented by Jeannette Vaude-Perrin, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Askania S.à r.l. a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which is registered with
the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 120.177, with a share capital of EUR 12,600 (the "Com-
pany"),
The appearing party, representing the entire share capital of the Company, then reviewed the following agenda (the
"Agenda"):
<i>Agendai>
1. Modification of the required quorum of category A managers in order for the board of managers to validly deliberate
and act;
2. Subsequent modification of article 9.5 of the articles of incorporation which shall read as follows:
" 9.5. Except where a greater majority is required under any joint venture agreement entered into between the
members from time to time, the board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is
present or represented, including at least one Category A manager. Resolutions of the board of managers are validly
taken by the majority of the votes cast including at least one Category A manager. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting"; and
3. Miscellaneous.
Further to the review of the different items composing the Agenda, the Sole Shareholder, requested the notary to act
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to modify the number of Category A managers which shall be present or represented
in order for the board of managers to validly deliberate and act in presence of at least one category A manager.
<i>Second resolution:i>
Further to the adoption of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves that article 9.5 of the articles of
incorporation of the Company shall be amended in order to henceforth read as follows:
" 9.5. Except where a greater majority is required under any joint venture agreement entered into between the
members from time to time, the board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is
present or represented, including at least one Category A manager. Resolutions of the board of managers are validly
taken by the majority of the votes cast including at least one Category A manager. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting."
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between
the English and the French version, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, which proxyholder signed together with
us, the notary, this original notarial deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-et-unième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire demeurant à Esch sur Alzette, Grand-Duché de Luxembourg;
A comparu:
Freo Germany II Partners (SCA) SICAR.., une société en commandite par actions organisée sous la forme d'une société
d'investissement en capital à risque, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 123.906,
Dûment représentée par Jeannette Vaude-Perrin, Maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
35116
L
U X E M B O U R G
La procuration paraphée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La partie comparante est l'actionnaire unique (l'Actionnaire unique) de Askania S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le
numéro B 120.177 (la Société),
La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a ensuite revu l'ordre du jour suivant
(l'Ordre du jour):
<i>Ordre du jouri>
1. Modification du quorum requis de gérants de catégorie A afin que le conseil de gérance puisse délibérer et agir
valablement.
2. Modification substantielle de l'article 9.5 des statuts qui doivent être lus de la manière suivante:
«A l'exception des cas où une majorité plus grande est requise pour tout accord de partenariat entre les gérants de
temps à autre, le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et agir que si seulement une majorité de ses membres
est présente ou représentée, incluant au moins un gérant de catégorie A. Les résolutions du conseil de gérance sont
valablement prises à la majorité des voix exprimées, incluant au moins un gérant de catégorie A. Les résolutions du conseil
de gérance seront consignées dans des procès-verbaux qui seront signés par tous les gérants présents ou représentés au
conseil»; et
3. Divers.
Après avoir revu les différents éléments composant l'Ordre du jour, l'Actionnaire unique a prié le notaire instrumentant
d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire unique décide de modifier le nombre de gérants de catégorie A qui doivent être présents ou représentés
afin que le conseil de gérance puisse valablement délibérer et agir en présence d'au moins un gérant de catégorie A.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à l'adoption de la résolution précédente, l'Actionnaire unique décide que l'article 9.5 des statuts de la Société
doit être modifié afin d'être lu de la manière suivante:
«A l'exception des cas où une majorité plus grande est requise pour tout accord de partenariat entre les gérants de
temps à autre, le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et agir que si seulement une majorité de ses membres
est présente ou représentée, incluant au moins un gérant de catégorie A. Les résolutions du conseil de gérance sont
valablement prises à la majorité des voix exprimées, incluant au moins un gérant de catégorie A. Les résolutions du conseil
de gérance seront consignées dans des procès-verbaux qui seront signés par tous les gérants présents ou représentés au
conseil.»
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, le jour qu'en tête des présentes.
Le document, ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce-dernier a signé avec nous, le notaire, le présent
acte en original.
Signé: Vaude-Perrin, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2012. Relation: EAC/2012/17742. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2013019723/113.
(130023446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Askania II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 120.189.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-first day of December,
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch sur Alzette, Grand Duchy of Luxembourg;
There appeared:
35117
L
U X E M B O U R G
Freo Germany II Partners (SCA) SICAR, an investment company in risk capital (société d'investissement en capital à
risque), formed as a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), registered with the
Luxembourg register for commerce and trade under number R.C.S. Luxembourg B 123.906, having its registered office
at L-1331 Luxembourg 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, duly represented by its managing general partner Freo
Investment Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at EBBC 6D, route de Treves
L-2633 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.898 with a
share capital of EUR 12,600,
duly represented by Jeannette Vaude-Perrin, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Askania II S.à r.l. a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered
office at 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which is regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 120.189, with a share capital of EUR 12,600
(the "Company"),
The appearing party, representing the entire share capital of the Company, then reviewed the following agenda (the
"Agenda"):
<i>Agendai>
1. Modification of the required quorum of category A managers in order for the board of managers to validly deliberate
and act;
2. Subsequent modification of article 9.5 of the articles of incorporation which shall read as follows:
" 9.5. Except where a greater majority is required under any joint venture agreement entered into between the
members from time to time, the board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is
present or represented, including at least one Category A manager. Resolutions of the board of managers are validly
taken by the majority of the votes cast including at least one Category A manager. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting"; and
3. Miscellaneous.
Further to the review of the different items composing the Agenda, the Sole Shareholder, requested the notary to act
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to modify the number of Category A managers which shall be present or represented
in order for the board of managers to validly deliberate and act in presence of at least one category A manager.
<i>Second resolution:i>
Further to the adoption of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves that article 9.5 of the articles of
incorporation of the Company shall be amended in order to henceforth read as follows:
" 9.5. Except where a greater majority is required under any joint venture agreement entered into between the
members from time to time, the board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is
present or represented, including at least one Category A manager. Resolutions of the board of managers are validly
taken by the majority of the votes cast including at least one Category A manager. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting."
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between
the English and the French version, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, which proxyholder signed together with
us, the notary, this original notarial deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-et-unième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire demeurant à Esch sur Alzette, Grand-Duché de Luxembourg;
A comparu:
Freo Germany II Partners (SCA) SICAR.., une société en commandite par actions organisée sous la forme d'une société
d'investissement en capital à risque, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
35118
L
U X E M B O U R G
65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 123.906,
Dûment représentée par Jeannette Vaude-Perrin, Maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration paraphée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La partie comparante est l'actionnaire unique (l'Actionnaire unique) de Askania II S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
B 120.189 (la Société),
La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a ensuite revu l'ordre du jour suivant
(l'Ordre du jour):
<i>Ordre du jouri>
1. Modification du quorum requis de gérants de catégorie A afin que le conseil de gérance puisse délibérer et agir
valablement.
2. Modification substantielle de l'article 9.5 des statuts qui doivent être lus de la manière suivante:
«A l'exception des cas où une majorité plus grande est requise pour tout accord de partenariat entre les gérants de
temps à autre, le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et agir que si seulement une majorité de ses membres
est présente ou représentée, incluant au moins un gérant de catégorie A. Les résolutions du conseil de gérance sont
valablement prises à la majorité des voix exprimées, incluant au moins un gérant de catégorie A. Les résolutions du conseil
de gérance seront consignées dans des procès-verbaux qui seront signés par tous les gérants présents ou représentés au
conseil»; et
3. Divers.
Après avoir revu les différents éléments composant l'Ordre du jour, l'Actionnaire unique a prié le notaire instrumentant
d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire unique décide de modifier le nombre de gérants de catégorie A qui doivent être présents ou représentés
afin que le conseil de gérance puisse valablement délibérer et agir en présence d'au moins un gérant de catégorie A.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à l'adoption de la résolution précédente, l'Actionnaire unique décide que l'article 9.5 des statuts de la Société
doit être modifié afin d'être lu de la manière suivante:
«A l'exception des cas où une majorité plus grande est requise pour tout accord de partenariat entre les gérants de
temps à autre, le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et agir que si seulement une majorité de ses membres
est présente ou représentée, incluant au moins un gérant de catégorie A. Les résolutions du conseil de gérance sont
valablement prises à la majorité des voix exprimées, incluant au moins un gérant de catégorie A. Les résolutions du conseil
de gérance seront consignées dans des procès-verbaux qui seront signés par tous les gérants présents ou représentés au
conseil.»
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, le jour qu'en tête des présentes.
Le document, ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce-dernier a signé avec nous, le notaire, le présent
acte en original.
Signé: Vaude-Perrin, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2012. Relation: EAC/2012/17745. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013019722/113.
(130023465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
35119
L
U X E M B O U R G
MCL Prop Co. C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 174.923.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-ninth day of January.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326
Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 158.363,
here represented by Christine Schaub, born on January 6, 1958 in Sulzburg, Germany, with professional address at 17,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 21 January
2013.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "MCL Prop Co. C S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Contern, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may further acquire, develop, manage and/or sell directly or indirectly real estate assets in the Grand
Duchy of Luxembourg or abroad.
3.3 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
35120
L
U X E M B O U R G
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1,-) each, all subscribed and fully paid-
up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing
three-quarters of the rights owned by the survivors.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the shareholders,
which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if all members are present or represented. Resolutions of the Board
are validly taken by unanimous vote of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded
in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or
represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of at least two managers.
35121
L
U X E M B O U R G
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law and that the manager has acted in good faith.
IV. Shareholder(s)
Art. 10. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
10.3. Subject-Matters of Resolutions
(i) The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.
(ii) The shareholders shall resolve on the following subject matters whereas the legitimation of the Board to implement
such resolutions shall in addition require (1) the approval of the investment committee of the ECE Real Estate Partners
S.a r.l. and such approval shall be documented in writing and (2) the unanimous decision of all parties to any parallel
investment agreement between ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, ECE European Prime Shopping
Centre SCS SICAF SIF B and ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF C and, as the case may be, further
parties and such consent shall be documented in writing:
(a) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent
from the proportion of the Company's ownership) acquisition of shopping centres.
(b) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent
from the proportion of the Company's ownership) disposal of shopping centres.
(c) Any decision relating to direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion
of the Company's ownership) real estate financings.
(d) Any decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the
proportion of the Company's ownership) enlargement of shopping centres, in particular the structural alteration of parts
or extensions of a building.
Art. 11. Sole shareholder.
11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
35122
L
U X E M B O U R G
11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 13. Allocation of profits.
13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of
the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
(1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.
14.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
15.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one
original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same
document.
15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject
to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2013.
35123
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and Paymenti>
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.a r.l., prenamed and represented as stated above, declares to
subscribe for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-)
each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-).
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a. Richard Neal Basire Goddard, Director, born on December 5, 1959 in Fareham, Great Britain, with professional
address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;
b. Ulrich Binninger, Managing Director, born on August 30, 1966 in Trier, Germany, with professional address at 19,
rue des Lilas, L-8035 Strassen; and
c. José Maria Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 17, rue Edmond
Reuter, L-5326 Contern.
2. The registered office of the Company is established at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, upon request of the appearing party, this
deed are drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.
Whereupon the present deed was drawn up in Contern by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
This deed has been read to the representative of the appearing party,, who is known to the undersigned notary by his
surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Am neunundzwanzigsten Tag des Monats Januar im Jahre zweitausenddreizehn.
Ist vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,
ERSCHIENEN:
Die ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reu-
ter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister
unter der Nummer B 158.363,
hier vertreten durch Christine Schaub, mit Geschäftsadresse in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großher-
zogtum Luxemburg, aufgrund der Vollmacht welche am 21. Januar 2013 erteilt wurde.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, wird
der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.
Die erschienene Partei, vertreten wir oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzu-
setzen.
I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „MCL Prop Co. C S.à r.l." (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).
35124
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Contern, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann
durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt
werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende
Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung
des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in¬oder ausländischen Gesellschaften oder Un-
ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.
Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.
3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung und/oder der direkte oder indirekte
Verkauf von Immobilienvermögen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.
3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie
kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die
erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.
3.4. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu
verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.
3.5. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf
Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,
Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
II. Kapital - Geschäftsanteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), bestehend aus zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-); die Gesellschafts-
anteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-
stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.
6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.
Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel
1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.
35125
L
U X E M B O U R G
6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter
eingesehen werden kann.
6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über
ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.
III. Verwaltung - Stellvertretung
Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch
einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen
keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen
werden.
Art. 8. Geschäftsführungsrat. Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Ge-
schäftsführungsrat (der Rat).
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern
vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.
(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-
lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.
8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-
nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.
(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder
vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des
Rates vertreten zu lassen.
(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse
des Rates sind wirksam, wenn sie einstimmigen von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst werden.
Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder,
wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern un-
terzeichnet werden müssen.
(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu-
nikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.
(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Ge-
schäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von
mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden.
(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1.
(ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.
Art. 9. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Ver-
bindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäfts-
führer in gutem Glauben gehandelt hat.
35126
L
U X E M B O U R G
IV. Gesellschafter
Art. 10. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
10.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch
Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.
(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse
gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten
Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig
und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst
wurde.
(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im
Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.
(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten
Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden.
(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemäß einberufen betrachten.
(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine
schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.
(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse
werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.
(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten, abgeändert werden.
(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters
gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
10.3. Gegenstände von Beschlüssen
(i) Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.
(ii) Die Gesellschafter sollen über die folgenden Gegenstände entscheiden, wobei die Legitimation des Rates zur Im-
plementierung solcher Beschlüsse zudem von (1) der Genehmigung des Investment Komitees der ECE Real Estate
Partners S.ä r.l., und eine solche Genehmigung soll schriftlich festgehalten werden und (2) der einstimmigen Entscheidung
aller Parteien einer jeden parallelen Investitionsvereinbarung zwischen dem ECE European Prime Shopping Centre SCS
SICAF SIF A, dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B und dem ECE European Prime Shopping Centre
SCS SICAF SIF C und, gegebenenfalls, weiteren Parteien, und eine solche Zustimmung soll schriftlich festgehalten werden,
abhängt:
(a) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich des direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) des Erwerbs von Einkaufszentren.
(b) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Veräußerung von Einkaufszentren.
(c) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Immobilien Finanzierung.
(d) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Erweiterung von Einkaufszentren,
dass heißt insbesondere die bauliche Veränderungen durch neue Gebäudeteile und Anbauten, von Einkaufszentren.
Art. 11. Alleingesellschafter.
11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch
der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.
11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter
innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.
11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.
35127
L
U X E M B O U R G
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht
Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden
Jahres.
12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,
welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines
Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.
Art. 13. Gewinnausschüttung.
13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-
lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu
verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.
13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Aus-
schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten
ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;
(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-
tung nicht gefährdet werden; und
(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so
müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.
VI. Auflösung - Liquidation
14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschaf-
ter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen
einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung
der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch
die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.
14.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesell-
schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.
VII. Allgemeine Bestimmungen
15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkular-
beschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax,
E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.
15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer
Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.
15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-
den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkular-
beschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz
gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments,
welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.
15.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-
enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.
35128
L
U X E M B O U R G
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2013.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet zwölftausendfünfhundert
(12.500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser
Geschäftsanteile in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500).
Die Geschäftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit
dieser Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-) betragen.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Alleingesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeich-
neten Geschäftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
a. Richard Neal Basire Goddard, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 5. Dezember 1959 in Fareham, Großbritanien,
geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
b. Ulrich Binninger, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland,
geschäftsansässig in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen; und
c. José María Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 17,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern.
2. Sitz der Gesellschaft ist in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt
hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.
Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Contern aufge-
nommen wurde.
Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, dem
Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit
dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: C. SCHAUB, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 31 janvier 2013. Relation: DIE/2013/1616. Reçu soixante-quinze (75,-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): pd. RECKEN.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 06. Februar 2013.
Référence de publication: 2013019434/530.
(130023164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2013.
FGP VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 138.641.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-first day of December,
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch sur Alzette, Grand Duchy of Luxembourg;
There appeared:
Freo Germany II Partners (SCA) SICAR, an investment company in risk capital (société d'investissement en capital à
risque), formed as a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), registered with the
Luxembourg register for commerce and trade under number R.C.S. Luxembourg B 123.906, having its registered office
at L-1331 Luxembourg 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, duly represented by its managing general partner Freo
Investment Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at EBBC 6D, route de Treves
35129
L
U X E M B O U R G
L-2633 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.898 with a
share capital of EUR 12,600,
duly represented by Jeannette Vaude-Perrin, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of FGP VI S.à r.l. a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at
65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which is registered with
the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 138.64, with a share capital of EUR 12,600 (the "Com-
pany"),
The appearing party, representing the entire share capital of the Company, then reviewed the following agenda (the
"Agenda"):
<i>Agendai>
1. Modification of the required quorum of category A managers in order for the board of managers to validly deliberate
and act;
2. Subsequent modification of article 9.5 of the articles of incorporation which shall read as follows:
" 9.5. Except where a greater majority is required under any joint venture agreement entered into between the
members from time to time, the board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is
present or represented, including at least one Category A manager. Resolutions of the board of managers are validly
taken by the majority of the votes cast including at least one Category A manager. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting"; and
3. Miscellaneous.
Further to the review of the different items composing the Agenda, the Sole Shareholder, requested the notary to act
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to modify the number of Category A managers which shall be present or represented
in order for the board of managers to validly deliberate and act in presence of at least one category A manager.
<i>Second resolution:i>
Further to the adoption of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves that article 9.5 of the articles of
incorporation of the Company shall be amended in order to henceforth read as follows:
" 9.5. Except where a greater majority is required under any joint venture agreement entered into between the
members from time to time, the board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is
present or represented, including at least one Category A manager. Resolutions of the board of managers are validly
taken by the majority of the votes cast including at least one Category A manager. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting."
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between
the English and the French version, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, which proxyholder signed together with
us, the notary, this original notarial deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-et-unième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire demeurant à Esch sur Alzette, Grand-Duché de Luxembourg;
A comparu:
Freo Germany II Partners (SCA) SICAR.., une société en commandite par actions organisée sous la forme d'une société
d'investissement en capital à risque, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 123.906,
Dûment représentée par Jeannette Vaude-Perrin, Maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
35130
L
U X E M B O U R G
La procuration paraphée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La partie comparante est l'actionnaire unique (l'Actionnaire unique) de FGP VI S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
B 138.641 (la Société),
La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a ensuite revu l'ordre du jour suivant
(l'Ordre du jour):
<i>Ordre du jouri>
1. Modification du quorum requis de gérants de catégorie A afin que le conseil de gérance puisse délibérer et agir
valablement.
2. Modification substantielle de l'article 9.5 des statuts qui doivent être lus de la manière suivante:
«A l'exception des cas où une majorité plus grande est requise pour tout accord de partenariat entre les gérants de
temps à autre, le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et agir que si seulement une majorité de ses membres
est présente ou représentée, incluant au moins un gérant de catégorie A. Les résolutions du conseil de gérance sont
valablement prises à la majorité des voix exprimées, incluant au moins un gérant de catégorie A. Les résolutions du conseil
de gérance seront consignées dans des procès-verbaux qui seront signés par tous les gérants présents ou représentés au
conseil»; et
3. Divers.
Après avoir revu les différents éléments composant l'Ordre du jour, l'Actionnaire unique a prié le notaire instrumentant
d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire unique décide de modifier le nombre de gérants de catégorie A qui doivent être présents ou représentés
afin que le conseil de gérance puisse valablement délibérer et agir en présence d'au moins un gérant de catégorie A.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à l'adoption de la résolution précédente, l'Actionnaire unique décide que l'article 9.5 des statuts de la Société
doit être modifié afin d'être lu de la manière suivante:
«A l'exception des cas où une majorité plus grande est requise pour tout accord de partenariat entre les gérants de
temps à autre, le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et agir que si seulement une majorité de ses membres
est présente ou représentée, incluant au moins un gérant de catégorie A. Les résolutions du conseil de gérance sont
valablement prises à la majorité des voix exprimées, incluant au moins un gérant de catégorie A. Les résolutions du conseil
de gérance seront consignées dans des procès-verbaux qui seront signés par tous les gérants présents ou représentés au
conseil.»
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, le jour qu'en tête des présentes.
Le document, ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce-dernier a signé avec nous, le notaire, le présent
acte en original.
Signé: Vaude-Perrin, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2012. Relation: EAC/2012/17756. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013019894/113.
(130023483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Vimo & Partner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4972 Dippach, 32, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 113.973.
Les comptes annuels au 31-12-2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013024974/9.
(130029556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2013.
35131
L
U X E M B O U R G
Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 224.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 112.071.
DISSOLUTION
On the twenty-first day of December of the year two thousand and twelve,
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg;
THERE APPEARED:
Grainger Luxembourg Germany Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 16, avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 112.062
and with a share capital of twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400),
here represented by Torsten Sauer, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed "ne varietur' by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
This appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:
1) That Grainger Luxembourg Germany (No. 2) S.à r.l. is a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated and existing under laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 16, avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 112.071 and having a share capital of two hundred twenty-four thousand Euro (EUR 224,000)
and that it has been incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated
October 11, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 394 of February 22, 2006 (the
Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last
time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated December 8, 2010, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 339 of February 19, 2011.
2) That the Company's share capital is fixed at two hundred twenty-four thousand Euro (EUR 224,000) represented
by eight thousand nine hundred sixty (8,960) shares in registered form, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25)
each, all of which are fully paid up.
3) That the appearing party is the holder of all the shares of the Company.
4) That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.
5) That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company, and in its capacity as liquidator of the Company
has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything
necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
6) That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to settle
any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.
7) That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any existing
debt of the Company even if unknown at present.
8) That the liquidation of the Company is to be construed as definitely terminated.
9) That full and entire discharge is granted to the managers for the performance of their assignment.
10) That all the shares of the dissolved Company have been cancelled.
11) That the corporate documents of the dissolved Company shall be kept for the duration of five years at least at
Grainger plc, Citygate, St James' Boulevard, Newcastle upon Tyne, NE1 4JE, United Kingdom.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the Company as a result of the present deed, is approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
35132
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède
Le vingt-et-un décembre de l'an deux mille douze,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A COMPARU:
Grainger Luxembourg Germany Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe à 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.062 et disposant d'un capital social de
douze mille quatre cents euros (EUR 12.400),
ici représentée par Torsten Sauer, attorney-at-law, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur' par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée comme ci-dessus, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:
1) Que Grainger Luxembourg Germany (No. 2) S.à r.l. est une société à responsabilité limitée constituée et régie par
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.071
et disposant d'un capital social de deux cent vingt-quatre mille euros (EUR 224.000) et qu'elle a été constituée suivant
acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence au Luxembourg, en date du 11 octobre 2005, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, No. 394 du 22 février 2006 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts)
ont été modifies à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de
résidence à Luxembourg, date du 8 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 339
du 19 février 2011.
2) Que le capital social de la Société est fixé à deux cent vingt-quatre mille euros (EUR 224.000) représenté par huit
mille neuf cent soixante (8.960) parts sociales, sous forme nominative, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25) chacune, toute entièrement libérées.
3) Que la comparante détient la totalité des parts sociales de la Société.
4) Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
5) Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs pour signer, exécuter et
délivrer tout acte et document, procéder à toute déclaration et entreprendre tout ce qui est nécessaire ou utile pour
rendre effectives les stipulations du présent acte.
6) Que la comparante en sa qualité de liquidateur de la société déclare s'engager de manière irrévocable à régler tout
le passif dû actuellement connu et inconnu de la Société dissoute.
7) Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tous les engagements
de la Société même inconnus à l'heure actuelle.
8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
9) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exécution de leur mandat.
10) Qu'il a été procédé à l'annulation des parts sociales de la Société dissoute.
11) Que les documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à Grainger plc, Citygate,
St James' Boulevard, Newcastle upon Tyne, NE1 4JE, Royaume-Uni.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cents euros
(EUR 1.400,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes qu'à la requête de la
personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, ce dernier a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: Sauer, Kesseler.
35133
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2012. Relation: EAC/2012/17733. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2013019922/113.
(130023418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
TEAM CAR REPAIRS S.A. en abrégé T.C.R. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie Coin des Artisans.
R.C.S. Luxembourg B 174.925.
STATUTS
L'an deux mille treize, le huit janvier.
Par-devant Maître Francis KESSELER notaire de résidence à Esch/Alzette.
A comparu:
Monsieur Jean Christophe PONSSON, directeur de société, né à Thann (France), le 27 février 1965, demeurant à
L-4243 Esch/Alzette, 16A, rue Jean Pierre Michels,
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'il déclare
constituer.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:
TEAM CAR REPAIRS S.A. en abrégé T.C.R. S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège social est établi à Foetz.
Art. 4. La société a pour objet la recherche et le recrutement de personnes qualifiées dans l'art du débosselage (manuel
uniquement) de carrosseries automobiles, afin d'effectuer ces prestations de services dans les ateliers des concession-
naires, garages et revendeurs partout en Europe.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par CENT (100) ACTIONS
d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310,- €), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil administration peut être limitée à
un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous
les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous
désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou actionnaires ou non.
35134
L
U X E M B O U R G
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou en cas d'administrateur unique par
la signature individuelle de cet administrateur.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des
administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne
peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
au Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.
Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
S'il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de la
société.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2013.
- La première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le troisième mardi du mois de juin 2014.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Monsieur Jean Christophe PONSSON, prénommé, CENT ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de
TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à MILLE DEUX CENTS EUROS (€
1.200,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant l'actionnaire unique, se considérant comme réuni en assemblée générale extraordinaire a pris les réso-
lutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à un Est nommé administrateur:
Monsieur Jean Christophe PONSSON, prénommé.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
La société Fiduciaire EURO CONSEIL ENTREPRISE S.A., établie et ayant son siège social à L-3895 Foetz, rue de
l'Industrie Coin des Artisans, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 90.331.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2018.
35135
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
L'adresse de la société est fixée à L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, coin des Artisans.
L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Ponsson, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 janvier 2013. Relation: EAC/2013/577. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. Halsdorf.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013019598/107.
(130023160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2013.
Moncour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 112.596.
Suite aux résolutions de l’associé unique en date du 15 février 2013 de la Société les décisions suivantes ont été prises:
- Démission du gérant A suivant à compter du 15 février 2013:
Monsieur Marco Weijermans, né le 26 août 1970 à ‘s-Gravenhage, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- Nomination du gérant de catégorie A suivant à compter du 15 février 2013 pour une durée indéterminée:
Madame Gwenaëlle Cousin, née le 3 avril 1973 à Rennes, France, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la société est comme suit:
- Franciscus Welman, gérant de catégorie A;
- Gwenaëlle Cousin, gérant de catégorie A;
- Manacor (Luxembourg) S.A., gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Gwenaëlle Cousin
<i>Gérant de catégorie Ai>
Référence de publication: 2013024156/22.
(130029253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Frena Intermediate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 900.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.057.
En date du 15 février 2013, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Révocation de Robert van 't Hoeft, du poste de gérant de classe B;
- Nomination de Martin Paul Galliver, né le 15 juin 1980 à Monaco, Monaco, et ayant pour adresse professionnelle le
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, au poste de gérant de classe B pour une durée indéterminée
et avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Frena Intermediate Holdings S.à r.l.
Fabrice Rota
<i>Gérant de classe Bi>
Référence de publication: 2013024004/17.
(130029017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
35136
Askania II S.à r.l.
Askania S.à r.l.
atHome Group S.A.
FGP VI S.à r.l.
Football Club Nordstad Association sans but lucratif
Frena Intermediate Holdings S.à r.l.
Futsal Club Nordstad Association sans but lucratif
Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à r.l.
Grainger Luxembourg Germany (No.7) S.à r.l.
Gruppo di Partecipazioni e Servizi S.à r.l.
Guardian Managers S.à r.l.
Hackl Hofmann Landschaftsarchitekten S.à r.l.
Hobevest S.A. société de gestion de patrimoine familial
IMC Holding
Immobilière du GRÄFGEN S.A.
Imondial S.à r.l.
Independent Directors Luxembourg, Laguerre-Lemaire-Weyders Secs
International Lift System S.à r.l.
Intertrust Corporate Services S.A.
I-Wohnen S.à r.l.
Jardins en Beauté
JTG Holdings S.A. SPF
JTG Holdings S.A. SPF
MCL Prop Co. C S.à r.l.
Moncour S.à r.l.
New Life Settlement Scenarios S.A.- Société de Titrisation
OPENB S.A.
Orium S.A.
Pasarela
Pâtisserie-Confiserie PICHON-CREMER Sàrl
Phi-Logos A.G.
Primigenia International S.A.
Red Diamond Holdings S.à r.l.
Resource Revision s.à r.l.
Resto-Rial S.à.r.l.
Simark International S.A.
Sofagi S.C.A.
Specialized Investment Management Sicav - SIF
TEAM CAR REPAIRS S.A. en abrégé T.C.R. S.A.
Vimo & Partner S.A.
VTC Real Estate Holdings II S.à r.l.
Wick Lane (Lux) S.à r.l.
Winnebago Holdings S.à r.l.