This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 127
18 janvier 2013
SOMMAIRE
Absolu Digital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6089
Aquarius Capital Development S.A. . . . . .
6096
Arden Delice Immo SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
6090
Arden Delice Immo SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
6091
Arden Delice Immo SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
6091
Arden Delice Immo SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
6091
Duplex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6088
Encore Plus Properties II S.à.r.l. . . . . . . . . .
6088
Euro Holiday Properties S.A. . . . . . . . . . . . .
6088
Euro Partner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6089
GCG Manager S.A. Luxco S.C.A. . . . . . . . .
6050
Halliburton Luxembourg Intermediate S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6055
Halliburton Luxembourg Minority S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6084
Jantes Pneus Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
6069
King's Cross Asset Funding 15 . . . . . . . . . . .
6054
Liberty Sea Trading S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
6089
LKT Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6058
M7 Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6090
Methanex Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
6069
Mexbrew S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6093
Mobitrading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6087
Moorgarth Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6050
Natura Vita Wurst und Fleisch Handelsge-
sellschaft GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6094
Neuilly (Lux) II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6093
Next Step S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6094
Nici Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6087
Niessen Restaurants s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
6094
Nimax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6094
Nol S.à r.l. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6093
Normalux Maritime S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
6090
North West Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . .
6090
Novatiss S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6093
Nutri-Logics S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6092
Olinat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6093
Pajo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6083
Pan European Finance Framework HRE
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6087
Parkstadt Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6091
Parkstadt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6092
Parkwood (Cologne) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
6092
Parkwood (Köln) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
6091
Pempa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6090
Pizzeria Peperoncino S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
6079
PMB Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6079
Pocolena S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6080
Presidio Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6092
Presidio Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6092
Puro Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6086
Rheimolux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6088
Rockwell Collins European Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6078
Rosefield Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
6079
T6 HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6058
Trema Architecture Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
6065
Tricone Geological Consulting . . . . . . . . . .
6065
True Holding 1 S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6065
Unexpected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6094
Urbe Aero SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6065
Urbe Aero SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6065
Valbonne Rail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6065
Varuna Infinity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6066
WPP Luxembourg Germany Holdings 3
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6066
Xylem Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6080
6049
L
U X E M B O U R G
Moorgarth Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 156.358.
Les comptes annuels au 29 février 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012164259/11.
(120217385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
GCG Manager S.A. Luxco S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 153.484.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of November, before Us, Maître Francis Kesseler, notary
residing in Esch-sur-Alzette,
there appeared:
GCG MANAGER S.A., a public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 5, rue Guil-
laume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 153468 (the GP), being the general partner of GCG MANAGER S.A. LUXCO S.C.A., a
Luxembourg corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 153484 (the Company),
duly represented by Jean-Baptiste Beauvoir Planson, having his professional address in Luxembourg,
by virtue of the authority conferred upon his by resolutions adopted by the board of directors of the GP (the Board)
on November 26, 2012, an extract of such resolutions, signed ne varietur by the representative and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed with which they shall be formalized.
The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg,
on May 25, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on July 8, 2010, under number 1399.
The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on June 4, 2012 pursuant
to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations on August 4, 2012 under number 1942.
The said appearing person, acting in her aforesaid capacity, has requested the undersigned notary to record the fol-
lowing declarations and statements:
(i) That the current Articles provide that the issued share capital of the Company is set at two million five hundred
twenty-one thousand six hundred seventeen Pounds Sterling and seventy-nine Pence (GBP 2,521,617.79), represented
by:
- one hundred (100) class A1 shares (in case of plurality, the General Partner Shares and individually, a General Partner
Share),
- one hundred twelve million five hundred thousand three hundred fifteen (112,500,315) class A2 shares (in case of
plurality, the Class A2 Shares and individually, a Class A2 Share),
- one hundred twelve million four hundred ninety-nine thousand six hundred eighty-five (112,499,685) class A3 shares
(in case of plurality, the Class A3 Shares and individually, a Class A3 Share),
- one million two hundred sixty-four thousand four hundred seventy-one (1,264,471) class B shares (in case of plurality,
the Class B Shares and individually, a Class B Share),
- seven million four hundred eighty-five thousand six hundred seventy (7,485,670) class C shares (in case of plurality,
the Class C Shares and individually, a Class C Share),
- thirteen million two hundred twenty-seven two hundred three (13,227,203) class D shares (in case of plurality, the
Class D Shares and individually, a Class D Share),
- one million three hundred ninety thousand nine hundred twenty (1,390,920) class E shares (in case of plurality, the
Class E Shares and individually, a Class E Share),
- two million five hundred twenty eight thousand nine hundred forty-three (2,528,943) class F shares (in case of plurality,
the Class F Shares and individually, a Class F Share),
- six hundred thirty-two thousand two hundred thirty-six (632,236) class G shares (in case of plurality, the Class G
Shares and individually, a Class G Share), and
6050
L
U X E M B O U R G
- six hundred thirty-two thousand two hundred thirty-six (632,236) class H shares (in case of plurality, the Class H
Shares and individually, a Class H Share),
in registered form, having a par value of one Penny (GBP 0.01) each.
(ii) That pursuant to article 6.2 of the Articles, the authorized share capital of the Company has been set at four
hundred million Pounds Sterling (GBP 400,000,000) represented by four hundred (400) General Partner Shares, four
billion four hundred forty-four million four hundred forty-four thousand four hundred (4,444,444,400) Class A2 Shares,
four billion four hundred forty-four million four hundred forty-four thousand four hundred (4,444,444,400) Class A3
Shares, four billion four hundred forty-four million four hundred forty-four thousand four hundred (4,444,444,400) Class
B Shares, four billion four hundred forty-four million four hundred forty-four thousand four hundred (4,444,444,400)
Class C Shares, four billion four hundred forty-four million four hundred forty-four thousand four hundred
(4,444,444,400) Class D Shares, four billion four hundred forty-four million four hundred forty-four thousand four hun-
dred (4,444,444,400) Class E Shares with, four billion four hundred forty-four million four hundred forty-four thousand
four hundred (4,444,444,400) Class F Shares, four billion four hundred forty-four million four hundred forty-four thousand
four hundred (4,444,444,400) Class G Shares, and four billion four hundred forty-four million four hundred forty-four
thousand four hundred (4,444,444,400) Class H Shares, and that the GP is authorized to increase the Company's sub-
scribed share capital within the limits of the authorized share capital, article 6.1 then to be amended so as to reflect the
increase of capital.
(iii) That the GP, by resolutions adopted on November 26, 2012 (the GP Resolutions) and in accordance with the
authority conferred upon it pursuant to article 6.2 of the Articles, approved the issuance within the authorised share
capital of (i) two hundred fifty-two thousand eight hundred ninety-four (252,894) Class D Shares, (ii) four hundred six
thousand four hundred nineteen (406,419) Class F Shares, (iii) two hundred fifty-four thousand twelve (254,012) Class
G Shares, and (iv) four hundred fifty-seven thousand two hundred twenty-one (457,221) Class H Shares, and the resulting
increase of the share capital of the Company by an amount of thirteen thousand seven hundred five Pounds Sterling and
forty-six Pence (GBP 13,705.46) so as to bring the share capital from its current amount of two million five hundred
twenty-one thousand six hundred seventeen Pounds Sterling and seventy-nine Pence (GBP 2,521,617.79) to the amount
of two million five hundred thirty-two thousand seven hundred ninety-four Pounds Sterling and thirty-one Pence (GBP
2,535,323.25) represented by:
- one hundred (100) General Partner Shares;
- one hundred twelve million five hundred thousand three hundred fifteen (112,500,315) Class A2 Shares;
- one hundred twelve million four hundred ninety-nine thousand six hundred eighty-five (112,499,685) Class A3 Shares;
- one million two hundred sixty-four thousand four hundred seventy-one (1,264,471) Class B Shares;
- seven million four hundred eighty-five thousand six hundred seventy (7,485,670) Class C Shares;
- thirteen million four hundred eighty thousand ninety-seven (13,480,097) Class D Shares;
- one million three hundred ninety thousand nine hundred twenty (1,390,920) Class E Shares;
- two million nine hundred thirty-five thousand three hundred sixty-two (2,935,362) Class F Shares;
- eight hundred eighty-six thousand two hundred forty-eight (886,248) Class G Shares; and
- one million eighty-nine thousand four hundred fifty-seven (1,089,457) Class H Shares.
in registered form, having a par value of one Penny (GBP 0.01) each
(iv) That the GP Resolutions record the decision of the GP, taken in accordance with article 6.2 of the Articles, to
withdraw the preferential subscription rights of the existing shareholders of the Company and issue all the new shares
to the Subscribers (as defined in the GP Resolutions).
(v) That the new shares have been paid up by contributions in cash to the Company as follows:
(i) a contribution in cash by Neil Goulden for an amount of GBP 11,176.52, and (ii) a contribution in cash by Rob
Wood in an amount of GBP 632.24 representing one fourth of the amount he subscribes to (i.e. GBP 2,528.94).
(vi) That the amount of thirteen thousand seven hundred five Pounds Sterling and forty-six Pence (GBP 13,705.46) is
to be entirely allocated to the share capital of the Company.
(vii) That the amount of eleven thousand eight hundred eight Pounds Sterling and seventy-six Pence (GBP 11,808.76)
has been at the free disposal of the Company, as was evidenced to the undersigned notary.
(viii) That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital, Article 6.1 of the Articles is
therefore amended and shall henceforth read as follows:
" 6.1 Issued share capital. The share capital of the Company is set at two million five hundred thirty-five thousand three
hundred twenty-three Pounds Sterling and twenty-five Pence (GBP 2,535,323.25), represented by:
- one hundred (100) class A1 shares (in case of plurality, the "General Partner Shares" and individually, a "General
Partner Share"),
- one hundred twelve million five hundred thousand three hundred fifteen (112,500,315) class A2 shares (in case of
plurality, the "Class A2 Shares" and individually, a "Class A2 Share"),
6051
L
U X E M B O U R G
- one hundred twelve million four hundred ninety-nine thousand six hundred eighty-five (112,499,685) class A3 shares
(in case of plurality, the "Class A3 Shares" and individually, a "Class A3 Share"),
- one million two hundred sixty four thousand four hundred seventy one (1,264,471) Class B shares (in case of plurality,
the "Class B Shares" and individually, a "Class B Share"),
- seven million four hundred eighty-five thousand six hundred seventy (7,485,670) class C shares (in case of plurality,
the "Class C Shares" and individually, a "Class C Share"),
- thirteen million four hundred eighty thousand ninety seven (13,480,097) class D shares (in case of plurality, the "Class
D Shares" and individually, a "Class D Share"),
- one million three hundred ninety thousand twenty (1,390,920) class E shares (in case of plurality, the "Class E Shares"
and individually, a "Class E Share"),
- two million nine hundred thirty-five thousand three hundred sixty-two (2,935,362) Class F Shares (in case of plurality,
the "Class F Shares" and individually, a "Class F Share"),
- eight hundred eighty-six thousand two hundred forty-eight (886,248) Class G Shares (in case of plurality, the "Class
G Shares" and individually, a "Class G Share"), and
- one million eighty-nine thousand four hundred fifty-seven (1,089,457) Class H Shares (in case of plurality, the "Class
H Shares" and individually, a "Class H Share"),
in registered form, having a par value of one Penny (GBP 0.01) each."
<i>Estimated costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the appearing party signed together with
us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-sixième jour de novembre, par devant Maître Kesseler, notaire de résidence à Esch-
sur-Alzette,
a comparu:
GCG MANAGER S.A., une société anonyme, dont le siège social se situe au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 153468 (l'Actionnaire Commandité), en sa qualité d'actionnaire commandité de GCG MANAGER S.A. LUXCO
S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois dont le siège social se situe au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 153484 (la Société),
dûment représentée par Jean-Baptiste Beauvoir Planson dont l'adresse professionnelle se situe à Luxembourg,
en vertu d'une procuration qui lui a été accordée par résolutions adoptées par le conseil d'administration de l'Ac-
tionnaire Commandité (le Conseil) le 26 novembre 2012, un extrait desdites résolutions, signé ne varietur par le
mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.
La Société a été constituée suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg le 25 mai
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 8 juillet 2010 sous le numéro 1399. Les statuts de la
Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 4 juin 2012, suivant un acte de Maître Francis Kesseler,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 4 août sous le
numéro 1942.
La partie comparante, agissant en la qualité précitée, a prié le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:
(i) Que selon les statuts actuels de la Société, le capital social de la Société est fixé à deux millions cinq cent vingt et
un mille six cent dix-sept livres Sterling et soixante-dix-neuf pence (GBP 2.521.617,79), représenté par:
- cent (100) actions de classe A1 (les Actions du Commandité et individuellement, une Action du Commandité),
- cent douze millions cinq cent mille trois cent quinze (112.500.315) actions de classe A2 (les Actions de Classe A2 et
individuellement, une Action de Classe A2),
- cent douze millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-cinq (112.499.685) actions de classe
A3 (les Actions de Classe A3 et individuellement, une Action de Classe A3),
6052
L
U X E M B O U R G
- un million deux cent soixante-quatre mille quatre cent soixante et onze (1.264.471) actions de classe B (les Actions
de Classe B et individuellement, une Action de Classe B);
- sept millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille six cent soixante-dix (7.485.670) actions de classe C (les Actions de
Classe C et individuellement, une Action de Classe C);
- treize millions deux cent vingt-sept mille deux cent trois (13.227.203) actions de classe D (les Actions de Classe D
et individuellement, une Action de Classe D);
- un million trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt (1.390.920) actions de classe E (les Actions de Classe E et
individuellement, une Action de Classe E);
- deux millions cinq cent vingt-huit mille neuf cent quarante-trois (2.528.943) actions de classe F (les Actions de Classe
F et individuellement, une Action de Classe F);
- six cent trente-deux mille deux cent trente-six (632.236) actions de classe G (les Actions de Classe G et individuel-
lement, une Action de Classe G); et
- six cent trente-deux mille deux cent trente-six (632.236) actions de classe H (les Actions de Classe H et individuel-
lement, une Action de Classe H),
sous forme nominative, d'une valeur d'un penny (GBP 0,01) chacune.
(ii) Que conformément à l'article 6.2 des Statuts, le capital social autorisé de la Société est fixé à quatre cent millions
de livres Sterling (GBP 400.000.000) représenté par quatre cents (400) Actions du Commandité, quatre milliards quatre
cent quarante-quatre millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cents (4.444.444.400) Actions de Classe A2,
quatre milliards quatre cent quarante-quatre millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cents (4.444.444.400)
Actions de Classe A3, quatre milliards quatre cent quarante-quatre millions quatre cent quarante-quatre mille quatre
cents (4.444.444.400) Actions de Classe B, quatre milliards quatre cent quarante-quatre millions quatre cent quarante-
quatre mille quatre cents (4.444.444.400) Actions de Classe C, quatre milliards quatre cent quarante-quatre millions
quatre cent quarante-quatre mille quatre cents (4.444.444.400) Actions de Classe D, quatre milliards quatre cent qua-
rante-quatre millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cents (4.444.444.400) Actions de Classe E, quatre milliards
quatre cent quarante-quatre millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cents (4.444.444.400) Actions de Classe
F, quatre milliards quatre cent quarante-quatre millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cents (4.444.444.400)
Actions de Classe G, quatre milliards quatre cent quarante-quatre millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cents
(4.444.444.400) Actions de Classe H et que l'Actionnaire Commandité est autorisé à augmenter le capital social souscrit
de la Société dans les limites du capital social autorisé, l'article 6.1 sera alors modifié afin de refléter l'augmentation de
capital.
(iii) Que, par des résolutions prises le 26 novembre 2012 (les Résolutions du Commandité) et conformément au
pouvoir qui lui a été attribué en vertu de l'article 6.2 des Statuts, l'Actionnaire Commandité a approuvé l'émission dans
le cadre du capital social autorisé de (i) deux cent cinquante-deux mille huit cent quatre-vingt-quatorze (252,894) Actions
de Classe D, (ii) quatre cent six mille quatre cent dix-neuf (406.419) Actions de Classe F, (iii) deux cent cinquante-quatre
mille douze (254.012) Actions de Classe G, (iv) quatre cent cinquante-sept mille deux cent vingt et une (457.221) Actions
de Classe H, et (v) l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de treize mille sept cent cinq livres Sterling
et quarante-six pence (GBP 13,705.46) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux millions cinq cent
vingt et un mille six cent dix-sept livres Sterling et soixante-dix-neuf pence (GBP 2.521.617,79) au montant de deux
millions cinq cent trente-cinq mille trois cent vingt-trois livres Sterling et vingt-cinq pence (GBP 2,535,323.25), représenté
par:
- cent (100) Actions du Commandité;
- cent douze millions cinq cent mille trois cent quinze (112.500.315) Actions de Classe A2;
- cent douze millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-cinq (112.499.685) Actions de Classe
A3;
- un million deux cent soixante-quatre mille quatre cent soixante et onze (1.264.471) Actions de Classe B;
- sept millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille six cent soixante-dix (7.485.670) Actions de Classe C;
- treize millions quatre cent quatre-vingt mille quatre-vingt-dix-sept (13,480,097) Actions de Classe D;
- un million trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt (1.390.920) Actions de Classe E;
- deux millions neuf cent trente-cinq mille trois cent soixante-deux (2.935.362) Actions de Classe F;
- huit cent quatre-vingt-six mille deux cent quarante-huit (886.248) Actions de Classe G; et
- un million quatre-vingt-neuf mille quatre cent cinquante-sept (1.089.457) Actions de Classe H,
sous forme nominative, d'une valeur d'un penny (GBP 0,01) chacune.
(iv) Que les Résolutions du Commandité enregistrent la décision de l'Actionnaire Commandité, prise conformément
à l'Article 6.2 des Statuts, de retirer les droits de souscription préférentielle aux actionnaires existants de la Société et
d'émettre les nouvelles actions aux Souscripteurs (définis dans les Résolutions du Commandité) le 26 novembre 2012
dans la proportion détaillée dans les Résolutions du Commandité.
6053
L
U X E M B O U R G
(v) Que les nouvelles actions ont été libérées par des apports en numéraire faits à la Société comme suit: (i) un apport
en numéraire de Neil Goulden d'un montant de GBP 11.176,52, et (ii) un apport en numéraire de Rob Wood d'un montant
de GBP 632,24 équivalant à 25% du montant auquel il souscrit (GBP 2.528,94).
(vi) Que le montant de treize mille sept cent cinq livres Sterling et quarante-six pence (GBP 13,705.46) sera affecté
entièrement au capital social de la Société.
(vii) Que le montant de onze mille huit cent huit livres Sterling et soixante-seize pence (GBP 11.808,76) a été à la libre
disposition de la Société, comme il l'a été prouvé au notaire instrumentant.
(viii) En conséquence de l'augmentation de capital social émis décrite ci-dessus, l'Article 6.1 des Statuts est modifié et
aura désormais la teneur suivante:
« 6.1 Capital social émis. Le capital social de la Société est fixé à deux millions cinq cent trente-cinq mille trois cent
vingt-trois livres Sterling et vingt-cinq pence (GBP 2,535,323.25), représenté par:
- cent (100) actions de classe A1 (les Actions du Commandité et individuellement, une Action du Commandité),
- cent douze millions cinq cent mille trois cent quinze (112.500.315) actions de classe A2 (les Actions de Classe A2 et
individuellement, une Action de Classe A2),
- cent douze millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-cinq (112.499.685) actions de classe
A3 (les Actions de Classe A3 et individuellement, une Action de Classe A3),
- un million deux cent soixante-quatre mille quatre cent soixante et onze (1.264.471) actions de classe B (les Actions
de Classe B et individuellement, une Action de Classe B),
- sept millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille six cent soixante-dix (7.485.670) actions de classe C (les Actions de
Classe C et individuellement, une Action de Classe C),
- treize millions quatre cent quatre-vingt mille quatre-vingt-dix-sept (13,480,097) actions de classe D (les Actions de
Classe D et individuellement, une Action de Classe D),
- un million trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt (1.390.920) actions de classe E (les Actions de Classe E et
individuellement, une Action de Classe E),
- deux millions neuf cent trente-cinq mille trois cent soixante-deux (2.935.362) actions de classe F (les Actions de
Classe F et individuellement, une Action de Classe F),
- huit cent quatre-vingt-six mille deux cent quarante-huit (886.248) actions de classe G (les Actions de Classe G et
individuellement, une Action de Classe G), et un million quatre-vingt-neuf mille quatre cent cinquante-sept (1.089.457)
actions de classe H (les Actions de Classe H et individuellement, une Action de Classe H),
sous forme nominative d'une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune.»
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, coûts et frais ou charges de toute nature qui seront à régler par la Société puisque découlant de cet
acte, atteindront le montant approximatif de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare, par la présente, qu'à la demande de la partie com-
parante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la demande de la même comparante, en cas
de divergences entre le texte en anglais et celui en français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite à la partie comparante, ladite partie comparante a signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: Beauvoir Planson, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15811. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012161040/259.
(120212636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.
King's Cross Asset Funding 15, Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.015.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
6054
L
U X E M B O U R G
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012164139/11.
(120217315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.537.745,00.
Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 167.154.
In the year two thousand and twelve, on the thirtieth day of November.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at Navas Business
Center, 2B Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 167.151,
here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, with professional address at 9 Rabatt, L-6402 Echternach,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 30, 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the entity appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing entity is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")
established in Luxembourg under the name of "Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l.", registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies Register under number B 167.154, having its registered office at Navas Business Center,
2B Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri
Beck, notary public residing in Echternach, dated February 27
th
, 2012, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés
et Associations number 970, on April 14
th
, 2012 (the "Company").
II. The Company's share capital is set at two million, five hundred and thirty-seven thousand, seven hundred and forty-
four U.S. Dollars (USD 2,537,744.-) represented by two million, five hundred and thirty-seven thousand, seven hundred
and forty-four (2,537,744) shares, with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.
III. The appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by one U.S. Dollar (USD 1.-) in order to
raise it from its present amount of two million, five hundred and thirty-seven thousand, seven hundred and forty-four
U.S. Dollars (USD 2,537,744.-) to two million, five hundred and thirty-seven thousand, seven hundred and forty-five U.S.
Dollars (USD 2,537,745.-) by the creation and issue of one (1) new share.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Halliburton Luxembourg Holdings S.a r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to
the new share and to have it fully paid up in the amount of one U.S. Dollar (USD 1.-), along with the payment of a share
premium in the amount of two billion, eight hundred and one million, eight thousand and twenty-two U.S. Dollars (USD
2,801,008,022.-), by a contribution in kind consisting of eighteen thousand (18,000) shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1.-) each, representing one hundred percent (100%) of the share capital of HESI Holdings B.V., a private limited
liability company existing under the laws of The Netherlands, having its registered office at Verrijn Stuartlaan 1 c, 2288
EK Rijswijk, Zuid-Holland, The Netherlands, which are hereby transferred to and accepted by the Company at the fair
market value of two billion, eight hundred and one million, eight thousand and twenty-three U.S. Dollars (USD
2,801,008,023.-) (the "Contribution in Kind").
Proof of the Contribution in Kind's existence and value has been given to the undersigned notary by an ad hoc decla-
ration signed by Halliburton Luxembourg Holdings S.a r.l., dated November 30, 2012, and an ad hoc declaration signed
by HESI Holdings B.V., dated November 30, 2012.
Halliburton Luxembourg Holdings S.a r.l., prenamed, declared that:
- it is the sole full owner of the Contribution in Kind and possesses the power to dispose of it, it being legally and
conventionally freely transferable; and
- all further formalities are in course in the country of residence of the entity whose shares are contributed, in order
to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.
6055
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the capital increase, the sole shareholder resolved to amend and fully restate article 6 of the
Company's articles of association as follows:
" Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at two million, five hundred and thirty-seven thousand, seven
hundred and forty-five U.S. Dollars (USD 2,537,745.-) represented by two million, five hundred and thirty-seven thousand,
seven hundred and forty-five (2,537,745) shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve".
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowered and authorized any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration
of the newly issued shares in the share register of the Company.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever will be borne by the Company.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by her
Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le trente novembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au Navas Business
Center, 2B Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167.151,
ici représentée par Mme Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6402, Echternach,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 novembre 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l., enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 167.154, ayant son siège social au Navas Business Center, 2B Ennert dem Bierg, L-5244
Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à
Echternach en date du 27 février 2012, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 970, le 14
avril 2012 (la «Société»).
II. Le capital social de la Société est fixé à deux millions, cinq cent trente-sept mille, sept cent quarante-quatre dollars
U.S. (USD 2.537.744,-) divisé en deux millions, cinq cent trente-sept mille, sept cent quarante-quatre (2.537.744) parts
sociales d'un montant d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.
III. La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un dollar U.S. (USD 1,-) pour le porter de
son montant actuel de deux millions, cinq cent trente-sept mille, sept cent quarante-quatre dollars U.S. (USD 2.537.744,-)
à deux millions, cinq cent trente-sept mille, sept cent quarante-cinq dollars U.S. (USD 2.537.745,-) par la création et
l'émission d'une (1) nouvelle part sociale.
6056
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription - Paiementi>
Sur ce, Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire à la nouvelle
part sociale et la libérer intégralement pour un montant d'un dollar U.S. (USD 1,-), avec le paiement d'une prime d'émission
d'un montant de deux milliards, huit cent un millions, huit mille vingt-deux dollars U.S. (USD 2.801.008.022,-), par un
apport en nature consistant en dix-huit mille (18.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune,
représentant cent pourcent (100%) du capital social d'HESI Holdings B.V., une société à responsabilité limitée constituée
selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Verrijn Stuartlaan 1 c, 2288 EK Rijswijk, Zuid-Holland, Pays-Bas, qui
sont transférées et acceptées par la Société à une valeur de marché de deux milliards, huit cent un millions, huit mille
vingt-trois dollars U.S. (USD 2.801.008.023,-) (l'«Apport en Nature»).
Preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport en Nature a été donnée au notaire soussigné par la production d'une
déclaration ad hoc signée par Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., en date du 30 novembre 2012, et par une décla-
ration ad hoc signée par HESI Holdings B.V., en date du 30 novembre 2012.
Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., prénommée, a déclaré que:
- elle est l'unique propriétaire de l'Apport en Nature contribué et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant
légalement et conventionnellement librement transmissibles; et
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence de l'Apport en Nature, aux fins
d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de l'augmentation de capital de la Société, l'associée unique a décidé de modifier et reformuler l'article
6 des statuts de la Société comme suit:
Art. 6. Capital souscrit. «Le capital social est fixé à deux millions, cinq cent trente-sept mille, sept cent quarante-cinq
dollars U.S. (USD 2.537.745,-) représenté par deux millions, cinq cent trente-sept mille, sept cent quarante-cinq
(2.537.745) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale».
<i>Troisième résolutioni>
L'associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui
précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à
l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit à raison des présentes seront mis à la
charge de la Société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 4 décembre 2012. Relation: ECH/2012/2055. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 10 décembre 2012.
Référence de publication: 2012161051/151.
(120212404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.
6057
L
U X E M B O U R G
LKT Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 166.453.
Il résulte du transfert de parts sociales en date du 12 décembre 2012 que:
- Péter Tamás LAKATOS, 69, Fodor u., H-1124 Budapest
a transféré dix mille parts sociales (10.000) à Pentera Trustees Limited, Trustees du Locksmith Family Trust, enregistré
au Registre des Sociétés de Jersey sous le numéro 91413, avec adresse à Pentera Chambers, Century Buildings, Patriotic
Place, St Helier, Jersey, JE4 8PS.
Luxembourg, le 14 décembre 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012164200/16.
(120216508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
T6 HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 173.484.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the fifth day of December.
Before, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
CORESTATE CAPITAL AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at
Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug (Switzerland), registered with the trade register of Kanton Zug under number
CH-020.3.030.000-1,
here represented by Mr Michael Jonas, avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given on 4 December 2012 in Luxembourg.
Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1
er
. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "T6
HoldCo S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of its portfolio.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or
indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
6058
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 50,000.- (fifty thousand Euro), represented
by 50,000 (fifty thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) per share each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf
of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the share-
holders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any manager may subdelegate his powers for specific tasks to one
or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-
sented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
6059
L
U X E M B O U R G
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers
attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 st December, the Company's accounts are established
and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies, as amended does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
CORESTATE CAPITAL AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 (fifty thousand) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 (fifty thousand) shares
6060
L
U X E M B O U R G
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 50,000.- (five thousand Euro) is at
the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2013.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company
has herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers is set at 1 (one). The sole shareholder appoints as sole manager of the Company for an
unlimited period of time:
Matthias Sprenker, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with professional address in L-2163
Luxemburg, 35, avenue Monterey; and
2. the registered office is established in L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof, the undersigned notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendzwölf, am fünften Tag des Monats Dezember.
Vor Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
CORESTATE CAPITAL AG, eine Gesellschaft Schweizer Rechts mit Gesellschaftssitz in Baarerstrasse 135, CH-6300
Zug (Schweiz), eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug unter der Nummer CH-020.3.030.000-1,
vertreten durch Herrn Michael Jonas, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht
unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 4. Dezember 2012.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter
der Bezeichnung "T6 HoldCo S.à r.l." (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-
schaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder
der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art
und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräu-
ßern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.
Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,
sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art
und Weise unterstützen.
Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder
indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
6061
L
U X E M B O U R G
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 50.000,- (fünfzigtausend Euro), eingeteilt in 50.000
(fünfzigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen,
soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-
stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei
eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt
wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten
und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die
Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen
Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflich-
tet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers
verpflichtet.
Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne
Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevoll-
mächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern,
der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die
Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
6062
L
U X E M B O U R G
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf
Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt,
persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizu-
fügen.
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung
eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Lu-
xemburg stattgefunden hat.
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkei-
ten.
Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem an-
deren in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schrift-
lich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein
präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befug-
nisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftska-
pitals vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
6063
L
U X E M B O U R G
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artikel 69(2) des abge-
änderten Gesetzes vom 19 Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister, wie abgeändert, keine Anwen-
dung findet.
Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
CORESTATE CAPITAL AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 (fünfzigtausend) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 (fünfzigtausend) Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 50.000,- (fünfzigtausend Euro) ab sofort
der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegenüber er-
bracht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2013.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr eintausendzweihundert euro (EUR 1.200,-).
<i>Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person
für eine unbestimmte Zeit ernannt:
Herr Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163
Luxemburg, 35, avenue Monterey; und
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten
Datum unter diese Urkunde setzen.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unter-
zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. JONAS, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 06 décembre 2012. Relation: DIE/2012/14621. Reçu soixante-quinze (75,-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): pd. RECKEN.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 17. Dezember 2012.
Référence de publication: 2012164518/362.
(120217130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
6064
L
U X E M B O U R G
Trema Architecture Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4818 Rodange, 8, avenue du Docteur Gaasch.
R.C.S. Luxembourg B 118.354.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012164513/9.
(120217338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Tricone Geological Consulting, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 164.002.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012164515/9.
(120216608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
True Holding 1 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 159.917.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012164517/9.
(120217059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Urbe Aero SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 139.067.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012164523/9.
(120217402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Urbe Aero SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 139.067.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012164524/9.
(120217415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Valbonne Rail S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 153.378.
Les comptes annuels au 31/12/10 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012164527/9.
(120216399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
6065
L
U X E M B O U R G
Varuna Infinity Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 150.229.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Varuna Infinity Fund
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012164531/11.
(120216516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
WPP Luxembourg Germany Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 39.541.678,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 157.627.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the Shareholders of WPP Luxembourg Germany Holdings
3 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg
with its registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 157627 and having a share capital of EUR 39,541,678 (the Company)
incorporated under Luxembourg law on 15 December 2010 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number
358 of 23 February 2011. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and
for the last time on 29 December 2011 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 634 of 9 March
2012.
THERE APPEARED:
(1) Taylor Nelson Sofres International Limited, a company incorporated under the laws of the United Kingdom, with
registered office at 27 Farm Street, London, England, W1J 5RJ, United Kingdom, registered with the Trade Registry of
England and Wales under the number 01953112, being the holder of 330,630 shares;
(2) Poster Publicity Holdings Limited, a company incorporated under the laws of the United Kingdom, with registered
office at The Inspire, Hornbeam Park, Harrogate, HG2 8PA, United Kingdom, registered with the Trade Registry of
England and Wales under the number 3170737, being the holder of 1,003,548 shares;
(3) Vincent Square Holding B.V. a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office
at 167, Laan op Zuid, Nl-3072 DB Rotterdam and being registered with the Rotterdam Register of Commerce under the
number 24313381 being the holder of 21,912,500 shares
(4) WPPIH 2001, Inc., a company incorporated under the laws of Delaware, United States of America, with registered
address at 874 Walker Road, Suite C, Dover, Delaware 19904, United States of America, registered with the Division of
Corporations of the State of Delaware under the number 3096915 (IH 2001), being the holder of 16,295,000 preferred
shares, (the Shareholders), (the parties listed under items 1. to 4. above are referred to hereunder each as a Shareholder
and collectively as the Shareholders),
all hereby represented by Marine Baillet, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxies given
under private seal.
The proxies from the Shareholders after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the
Shareholders and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the
registration authorities.
The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR
39,541,678 (thirty-nine million five hundred and forty-one thousand six hundred and seventy-eight Euro), divided into
23,246,678 (twenty-three million two hundred and forty-six thousand six hundred and seventy-eight) ordinary shares
having a nominal value of EUR 1 and 16,295,000 (sixteen million two hundred and ninety-five thousand) preferred shares
having a nominal value of EUR 1 (one Euros) each;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1) Waiver of the convening notices;
6066
L
U X E M B O U R G
2) Amendment to the dates of the financial year of the Company;
3) Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above; and
4) Miscellaneous.
III. that the Meeting takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the
convening notices, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been made available to them in advance of the Meeting.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:
1) the financial year of the Company shall begin on the 1
st
of December rather than the 1
st
of January, and
2) the financial year of the Company shall close on the 30
th
of November of the next year.
The Shareholders resolve that the financial year of the Company that started on the 1
st
of January 2012 shall close
on the 30
th
of November 2012 rather than on the 31
st
of December 2012.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second reso-
lution above, so that it shall henceforth read as follows:
" Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on 1 December and ends on 30 November of the following
year."
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholders of the appearing parties
signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire (l'Assemblée) des associés de WPP Luxembourg Germany Hol-
dings 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 124, Boulevard de
la Pétrusse L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 157627 et ayant un capital social de 39.541.678 EUR (la Société) constituée sous la loi Luxembourgeoise le 15 décembre
2010 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - numéro 358 du 23 février 2011. Les statuts de la Société
(les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois le 29 décembre 2011 en vertu d'un acte de Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 634 du 9 mars 2012.
ONT COMPARU:
(1) Taylor Nelson Sofres International Limited, une société constituée selon le droit du Royaume Uni ayant son siège
social au 27 Farm Street, Londres, Angleterre, W1J 5RJ, Royaume-Uni, enregistrée auprès du Registre de Commerce
d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 01953112, étant le propriétaire de 330.630 parts sociales;
(2) Poster Publicity Holdings Limited, une société constituée selon le droit du Royaume Uni ayant son siège social au
The Inspire, Hornbeam Park, Harrogate, HG2 8PA, Royaume-Uni, enregistrée auprès du Registre de Commerce d'An-
gleterre et du Pays de Galles sous le numéro 3170737, étant le propriétaire de 1.003.548 parts sociales;
(3) Vincent Square Holding B.V., une société constituée selon le droit des Pays-Bas ayant son siège social au 167, Laan
op Zuid, Nl-3072 DB Rotterdam et enregistrée auprès de la Chambre de Commerce de Rotterdam sous le numéro
24313381, étant le propriétaire de 21.912.500 parts sociales;
(4) WPPIH 2001, Inc., une société constituée selon le droit du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social
au 874 Walker Road, Suite C, Dover, Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès de la Division of
6067
L
U X E M B O U R G
Corporations de l'Etat du Delaware sous le numéro 3096915 (IH 2001), étant le propriétaire de 16.295.000 parts sociales
préférentielles (les Associés),
(les parties mentionnées des points 1. à 4. étant individuellement désignées comme un Associé et collectivement
comme les Associés),
ici représentées par Marine Baillet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations
données sous seing privé.
Lesdites procurations des Associés, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des Associés
et par le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès des
autorités compétentes.
Les Associés, tels que représentés ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:
I. Que les Associés représentent la totalité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à 39.541.678
EUR (trente-neuf millions cinq cent quarante-et-un mille six cent soixante-dix-huit Euros), divisé en 23.246.678 (vingt-
trois millions deux cent quarante-six mille six cent soixante-dix-huit) parts sociales ordinaires ayant chacune une valeur
nominale de 1 EUR (un Euro) et 16.295.000 (seize millions deux cent quatre-vingt-quinze mille) parts sociales préféren-
tielles ayant une valeur nominale de 1 EUR (un Euro);
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société;
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus; et
4. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-
malités de convocation, les Associés représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été rendu accessible avant l'Assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
1) l'année sociale de la Société commence le 1
er
décembre, au lieu du 1
er
janvier, et
2) l'année sociale de la Société se termine le 30 novembre de l'année suivante.
Les Associés décident que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1
er
janvier 2012 se termine le 30 novembre
2012 au lieu du 31 décembre 2012.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte
qu'il aura la teneur suivante:
" Art. 14. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 décembre et se termine le 30 novembre de
l'année suivante."
<i>Estimation des coûtsi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou
pour lesquels elle est responsable, en conséquence de la présente augmentation de capital, sont estimés approximative-
ment à EUR 1.300.-
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé en date des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: M. BAILLET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2012. Relation: LAC/2012/57256. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
6068
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 6 décembre 2012.
Référence de publication: 2012159206/151.
(120210053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.
Jantes Pneus Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4516 Differdange, 30, rue Henri Bessemer.
R.C.S. Luxembourg B 138.377.
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, en date du 15 avril 2008, publié Mémorial C
numéro 1338 du 31 mai 2008,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 138.377
au capital social de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400,-), représenté par CENT (100) PARTS
SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (€ 124,-) chacune,
EXTRAIT
Il résulte d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire prénommé, en date du 11 octobre 2012,
enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 octobre 2012, relation: EAC/2012/13525
- que Monsieur Ilidio ABREU LOPES, né le 3 0 juin 1962 à Laurinha/Mortagua (Portugal), gérant de société, demeurant
à L-5740 Filsdorf, 18, Draikantongsstrooss, a cédé ses CINQUANTE (50) parts sociales, avec effet au 1
er
janvier 2011,
comme suit:
- dix (10) parts sociales à Monsieur Fernando ROLO LOURENÇO, né le 17 septembre 1965 à Santa Justa/Lisboa
(Portugal), monteur de pneus, demeurant à L-4516 Differdange, 30, rue Henri BESSEMER et,
- quarante (40) parts sociales à Madame Rosa Maria CARNEIRO MARTINS, née le 04 janvier 196 7 à Santo Tirso
(Portugal), employée, demeurant à L-4516 Differdange, 30, rue Henri BESSEMER,
- que suite aux cessions de parts sociales, les parts sociales sont détenues comme suit:
1) Monsieur Fernando ROLO LOURENÇO, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) Madame Rosa Maria CARNEIRO MARTINS, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
- que La démission de Monsieur Ilidio ABREU LOPES, prénommé, en tant que gérant administratif de société a été
acceptée,
- que Monsieur Fernando ROLO LOURENÇO, prénommé, exerçant actuellement la fonction de gérant technique de
la société est nommé pour le futur, gérant de la société.
- que la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
POUR EXTRAIT CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 09 novembre 2012.
Référence de publication: 2012160419/34.
(120212098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2012.
Methanex Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 200.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 172.158.
In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of November.
Before us, Maître Francis Kesseler, notary residing at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the member of Methanex Luxembourg S.à r.l., a private limited liability
("société à responsabilité limitée") established under the laws of Luxembourg having its registered office at 16, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg, incorporated on 21 September 2012, following a deed of the undersigned notary, registered
at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 172158 (the "Company").
The meeting was declared open at 11.30 am with Mr. Randall Milner with professional address in 1800, 200 Burrard
Street, Vancouver, British Columbia V6C3M1 (Canada), in the chair, who appointed as secretary, Nojan Abrary, with
professional address in 1800, 200 Burrard Street, Vancouver, British Columbia V6C3M1 (Canada).
The meeting elected as scrutineer, David Valembois, with professional address in David Valembois, with professional
address in Waterloo Office Park - Building P, Dreve Richelle 161 - Box 31, B-1410 Waterloo (Belgium).
6069
L
U X E M B O U R G
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
the following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
1. Waiver of the convening notices;
2. Creation of new class of corporate units called mandatory redeemable preferred corporate units ("MRPCU");
3. Increase of the Company's capital by an amount of one hundred fifty thousand US Dollars (USD $150,000.-) and
creation of:
(a) a MRPCU Reserve to be set up in respect of the MRPCU for an amount of one hundred eighty one million eight
hundred fifty thousand US Dollars (USD $181,850,000.-);
(b) an ordinary share premium for an amount of two million nine hundred eighty thousand US Dollars (USD
$2,980,000.-); and
(c) a legal reserve for an amount of twenty thousand US Dollars (USD $20,000.-);
in order to bring the capital from its present amount of fifty thousand US Dollars (USD $50,000.-) to an amount of
two hundred thousand US Dollars (USD $200,000.-) and issue of:
(a) fifty thousand additional ordinary corporate units (50,000) in registered form, with a nominal value of one US Dollar
(USD $1.-) each, all subscribed and fully paid up; and
(b) one hundred thousand (100,000) MRPCU, with a nominal value of one US Dollar (USD $1.-) each, all subscribed
and fully paid up;
4. Subsequent modification of the Article 5.1 of the articles of incorporation to reflect the above capital increase;
5. Insertion of new Articles 5.3 and 15.4 in the articles of association of the Company to reflect the foregoing resolutions
namely the creation of a new class of corporate units called "mandatory redeemable preferred corporate units" and the
capital increase as per resolutions 2 and 3;
6. Amendments to Articles 6.1 and 15.2 of the articles of association of the Company to reflect the resolution 5 above.
(ii) That the whole capital was represented at the meeting and the sole member being present declared that it had due
notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived its right to be formally convened.
(iii) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(iv) That the general meeting, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to waive the convening notices, the shareholders having full knowledge
of the agenda.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to create a new class of corporate units called mandatory redeemable preferred cor-
porate units (hereafter the "MRPCU"), having such rights and privileges as set out in the articles of association of the
Company and the law of 10 August 1915 relating to commercial companies, as amended.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolved to increase the Company's capital by an amount of one hundred fifty thousand US Dollars
(USD $150,000.-) and to create:
(a) a MRPCU Reserve to be set up in respect of the MRPCU for an amount of one hundred eighty one million eight
hundred fifty thousand US Dollars (USD $181,850,000.-),
(b) an ordinary share premium for an amount of two million nine hundred eighty thousand US Dollars (USD
$2,980,000.-); and
(c) a legal reserve for an amount of twenty thousand US Dollars (USD $20,000.-);
in order to bring the capital from its present amount of fifty thousand US Dollars (USD $50,000.-) to an amount of
two hundred thousand US Dollars (USD $200,000.-) and issue of:
(a) fifty thousand additional ordinary corporate units (50,000), in registered form, with a nominal value of one US
Dollar (USD $1.-) each, all subscribed and fully paid up; and
(b) one hundred thousand (100,000) MRPCU, with a nominal value of one US Dollar (USD $1.-) each, all subscribed
and fully paid up.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolved to amend the article 5.1. of the articles of association of the Company to reflect the
capital increase hereby decided and the creation of the new class of corporate units called MRPCU, which will have
henceforth the following wording:
" Art. 5.1. The Company's capital is set at two hundred thousand US Dollars (USD $200,000.-) represented by one
hundred thousand (100,000) ordinary corporate units in registered form with nominal value of one US Dollar (USD $1.-)
6070
L
U X E M B O U R G
each and by one hundred thousand (100,000) mandatory redeemable preferred corporate units (hereafter the "MRPCU")
with nominal value of one US Dollars (USD $1.-) each, each all subscribed and fully paid up.
Corporate units shall mean ordinary corporate units and MRPCU collectively.
Holder(s) of MRPCU are referred to in these articles of incorporation as MRPCU holder(s), and the terms "member"
or "members" shall mean the holder(s)s of the ordinary corporate units and/or the holder(s)s of MRPCU, as the context
requires.
The Company may redeem its ordinary corporate units within the limit fixed by the Law."
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the general meeting resolved to insert new articles 5.3 and 15.4 to
reflect the foregoing changes to set out the rights and privileges of the MRPCU.
The following articles are inserted:
Art. 5.3. MRPCU. Each MRPCU is a redeemable corporate unit. Subscribed and fully paid-up MRPCU shall be man-
datorily redeemed upon decision by the managers of the Company pursuant to article 8.2. (v) or article 9, as the case
may be, of the articles of association in accordance with the provisions of the Law on the tenth (10
th
) anniversary of
the date of issuance of the MRPCU or at an earlier date as proposed by the managers and approved by the Member(s)
of the Company but in no case such date should be later that ten (10) years as from the date of issuance of the MRPCU.
The Holder of the MRPCU is also entitled before the expiry date to request in writing that the Company redeems all or
part of the MRPCU. The redemption of the MRPCU can only be made by using sums available for distribution.
Original Redemption Price: Except as provided otherwise (i) in these articles of association or, alternatively, (ii) by a
written agreement which may be entered into between the Company and the holder(s) of the MRPCU, the redemption
price (the "Original Redemption Price") of each outstanding MRPCU to be redeemed will be, at the sole discretion of
the Company, paid in cash or in kind and will be equal to the subscription price for the said MRPCU to be redeemed as
paid by the MRPCU holder(s) at the time of issue (i.e. MRPCU capital and related MRPCU reserve) plus any accrued but
unpaid preferred dividends on each MRPCU to be redeemed through to the date of redemption. For the avoidance of
doubt, and preferred dividends declared but not paid in respect of the MRPCU to be redeemed shall be paid prior to any
redemption of MRPCU.
If, at the time of redemption of the MRPCU, there is an Impairment of the Underlying Asset(s) acquired and financed
directly or indirectly by the MRPCU to be redeemed, the redemption price of each outstanding MRPCU to be redeemed
("Impaired Redemption Price") will be limited to (a) the impaired book value, at the time of redemption, under Luxem-
bourg GAAP, of the Underlying Asset(s) acquired and financed directly or indirectly by the MRPCU to be redeemed (this
limitation also applies to the redemption of MRPCU with cash/assets deriving from the disposal/reimbursement of the
considered Underlying Asset subject to the said Impairment) plus any accrued but unpaid dividends on each MRPCU to
be redeemed through the date of redemption divided by (b) the number of the outstanding MRPCUs to be redeemed at
the time of the redemption. For the avoidance of any doubt, this adjustment cannot result in the Impaired Redemption
Price being greater than the Original Redemption Price. Furthermore, MRPCUs can only be redeemed to the extent that
these redemptions would not have the effect of reducing the net assets below the aggregate of the capital and the reserves
which may not be distributed under law.
For the purpose of the previous paragraph:
Impairment shall mean in respect to Underlying Assets any decrease in value recorded or to be recorded under
Luxembourg GAAP at the time of redemption in the interim financial statements of the Company used to determine
among other things the existence of sufficient available funds for the redemption.
Luxembourg GAAP shall mean the Luxembourg generally accepted accounting principles.
Underlying Asset(s) shall mean the financial asset(s) in USD acquired or to be acquired and financed directly by the
issuance of the MRPCU and/or any other financial asset(s) in USD replacing any such financial asset(s), or purchased or
financed with the Income and other proceeds arising out of such financial asset(s) or of a disposal of all or part of such
financial asset(s).
Income in respect to Underlying Assets during any relevant accounting period of the Company shall mean the income
accrued or received (such as but not limited to interest income) and any gains realized by the Company according to the
Luxembourg GAAP.
Redemption Procedure: Except as otherwise provided, as an alternative, in a written agreement which may be entered
into among the Company and the MRPCU holder, at least ten (10) days prior to the redemption date, written notice
shall be sent by the Company by registered mail or fax or e-mail to the registered MRPCU holder, at its address shown
in the register of members, notifying such MRPCU holder of the number of MRPCUs so to be redeemed, specifying the
redemption date, the Original Redemption Price (or Impaired Redemption Price as the case may be) and the procedures
necessary to submit the MRPCUs to the Company for redemption. The Original Redemption Price (or Impaired Re-
demption Price as the case may be) of such MRPCUs shall be payable to the order of the holder of MRPCU whose name
appears on the register of members as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such member
before the redemption date.
6071
L
U X E M B O U R G
Upon the redemption, the payment of the Original Redemption Price (or Impaired Redemption Price as the case may
be) on the MRPCU to be redeemed may be deferred in whole or in part in case where the Company does not have
sufficient amounts available for distribution to redeem all the MRPCUs. In such case, the Company shall still redeem all
the MRPCUs and only pay at the time of the redemption the part of the Original Redemption Price (or Impaired Re-
demption Price as the case may be), which is equal to the amount of the sums available for distribution as at the redemption
date. Thereafter, the Company shall, in priority to any other amounts payable in respect of its capital, pay to the former
MRPCU holder(s) the difference between the amount of the partial MRPCU payment and the amount of the Original
Redemption Price (or Impaired Redemption Price as the case may be) plus a penalty to be determined by the MRPCU
holder(s) and the Company within fifteen (15) days after the occurrence of the shortfall over the remaining Original
Redemption Price (or Impaired Redemption Price as the case may be), but only upon the condition and at the moment
when the Company will recover sufficient available sums, cash or assets for such payment.
In case of a partial payment of MRPCU, the Company may not proceed to any other distribution or payment to any
member until the complete repayment on the applicable redemption price (i.e., Original Redemption Price or Impaired
Redemption Price as applicable) of the MRPCU.
Subject to the terms of the present article, in the event of any liquidation, dissolution or winding up of the Company,
after payment of all third party debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the MRPCU
holder(s) will be only entitled to the applicable redemption price (i.e., Original Redemption Price or Impaired Redemption
Price as applicable) plus an amount payable in cash or in kind equal to any accrued but unpaid dividends, prior to the
payment of any amount in respect to its other share capital.
For the avoidance of doubt, the MRPCU holders shall not have the right to participate to any liquidation proceeds
other than the right to payment of the applicable redemption price plus accrued but unpaid dividends attached to the
outstanding MRPCU through the date of liquidation as described in the above paragraph.
MRPCU Reserve: The Company shall constitute for the class of MRPCU a reserve to be exclusively used for any
payment to be made to the subscriber thereof (in addition to the nominal value) on the class of MRPCU or by the Company
in accordance with these articles of association or the Law.
Special Reserve: An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting value (meaning the
amount of the subscribed capital divided by the number of corporate units) of all the redeemed MRPCUs (MRPCU share
capital account and related share premium) must be included in a special reserve account which cannot be distributed to
the members except in the event of a reduction of the subscribed capital; the reserve may only be used to increase the
subscribed capital by capitalization of reserves.
The MRPCU carry full voting rights same as the ones related to the ordinary corporate units.
Any convening notices, reports and documents which, by virtue of Luxembourg law must be sent or notified to the
members of the Company shall likewise be sent or notified to the MRPCU holder(s).
Art. 15.4. After allocation to the Legal Reserve, any remaining profit shall be allocated by priority to the payment to
the MRPCU holder(s) or to the allocation to the MPRCU Reserve of the following preferred dividends entitlements:
Each MRPCU entitles a MRPCU holder to a first preferential and cumulative dividend (the "Dividend 1") at an annual
rate of 1% over the nominal value of the MRPCU share capital, which shall accrue daily from the date of the transfer of
the corresponding Underlying Assets or the last dividend payment date and to be calculated assuming a year of 365 or
366 days, as the case might be.
Secondly, each MRPCU entitles a MRPCU holder to a second preferential and cumulative dividend (the "Dividend 2"),
which shall accrue daily from the date of the transfer of the Underlying Assets referred to a MRPCU to the Company
and to be calculated assuming a year of 365 or 366 days. Dividend 2 shall equal to the Income accrued or received by the
Company on each of the Underlying Assets since the last dividend payment date referred to each MRPCU, minus (i) a
margin to be determined by the board of managers of the Company) on the basis of a transfer pricing study (as amended
from time to time) expressed in basis points on the annual average outstanding principal amount of the (relevant class)
MRPCU plus attached MRPCU reserve account or similar MRPCU reserve accounts and (ii) less the amount corres-
ponding to Dividend 1 paid on each MRPCU.
For the purpose of this article:
Underlying Asset(s) shall mean the financial assets in USD acquired or to be acquired and financed directly or indirectly
by the issuance of the MRPCU and/or any other financial assets in USD replacing any such financial assets, or purchased
or financed with the proceeds arising out of such financial assets or of a disposal of all or part of such financial assets.
Each Underlying Asset (when transferred to the Company) shall expressly be referred by a managers' resolution to a
specific class of MRPCU.
Income in respect to Underlying Assets during any relevant accounting period of the Company shall mean the income
accrued or received (such as but not limited to interest income) and any gains realized by the Company according to the
Luxembourg GAAP.
Outstanding principal amount shall mean the sum of nominal value and the amount of the MRPCU reserve of an
outstanding MRPCU shares.
6072
L
U X E M B O U R G
The MRPCU holders are entitled to the preferred cumulative dividend due even for the years in which the company
incurs losses. If Dividends 1 and 2 are not declared despite the existence of profits available for that purpose or not, they
may be compounded each accounting year, at the latest on the last day of the relevant accounting year.
If Dividends 1 and 2 are not declared despite the existence of profits available for that purpose or not, the amount of
Dividend 1 and 2 (i) shall be allocated to a MRPCU reserve account upon decision of the shareholder of the company,
(ii) shall remain exclusively to the benefit of the MRPCU holder(s) and (iii) shall be available in order to pay the outstanding
Dividends 1 and 2 at the time of the next distribution of dividends of the Company.
The second preferential dividend on any MRPCU may only accrue and be declared once the Company has acquired
the Underlying Assets financed by the relevant MRPCU.
For the avoidance of doubt, if the profits of the Company for the relevant financial year are not sufficient to fully pay
or allocate to the MRPCU Reserve the preferred Dividends 1 and 2, any shortfall amount shall be paid or allocated to
the MRPCU Reserve in priority from the profits of the following financial years each time pro rata of the total number
of MRPCU in issue.
The general meeting of shareholders will have discretionary power to freely allocate any surplus profit remaining after
allocation to the Legal Reserve and payment or allocation to the MRPCU Reserve of the preferred Dividends 1 and 2. It
may in particular allocate such surplus profit in the form of payment of an additional dividend or a transfer to a reserve
account or to carry it forward.
No dividend or interim dividend shall be distributed to the holder(s) of the ordinary corporate units until the preferred
dividends have been fully paid to the MRPCU holder(s) when declared or sufficient amounts for the payment of such
preferred dividends have been set aside in the MRPCU Reserve.
Dividends shall be paid in United States dollars and they may be paid at such places and times as may be determined
by the board of managers of the Company pursuant to article 8.2. (v) or the article 9, as the case may be, of the articles
of association.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting resolved to amend the articles 6.1 and 15.2 of the articles of association of the Company to reflect
the foregoing resolution, which will henceforth have the following wording:
" 6.1. Subject to clauses 5.3 and 15.4 of these Articles, each corporate unit entitles the holder to a fraction of the
corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of corporate units in existence."
" 15.2. Subject to clauses 5.3 and 15.4 of these Articles, the general meeting of members has discretionary power to
dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve
or carry it forward."
<i>Subscription and Paymenti>
The sole member, Methanex Corporation, declares:
(i) to subscribe for
a) the fifty thousand additional ordinary corporate units (50,000) with a nominal value of one US Dollar (USD $1.-)
each; and
b) to subscribe for the one hundred thousand (100,000) new MRPCU, with a nominal value of one US Dollar (USD
$1.-) each;
(ii) to fully pay them up by a contribution in kind of one hundred eighty-five million dollars of the United States (USD
$185,000,000.), (the "Contribution") including:
a) a MRPCU Reserve to be set up in respect of the MRPCU for an amount of one hundred eighty one million eight
hundred fifty thousand US Dollars (USD $181,850,000.-),
b) a legal reserve of the Company for an amount of twenty thousand US Dollars (USD $20,000.-),
c) an ordinary share premium in respect of the ordinary corporate units for an amount of two million nine hundred
eighty thousand US Dollars (USD $2,980,000.-).
<i>Description of the contributioni>
The assets contributed are legally owned by the Subscriber. The assets contributed to the Company are composed
of a financial asset of one hundred eighty-five million dollars of the United States (USD 185,000,000.-).
<i>Evaluationi>
The aggregate value of this contribution in kind is one hundred eighty-five million dollars of the United States (USD
185,000,000.-). Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contri-
bution value dated 20 November 2012, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality
of registration.
6073
L
U X E M B O U R G
<i>Evidence of the contribution's existencei>
Proof of the Contribution has been given.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire résident à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de Methanex Luxembourg S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,
constituée le 21 septembre 2012 suivant acte du notaire soussigné, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 172158 (la «Société»).
L'assemblée a été déclarée ouverte à 11.30 heures sous la présidence de M. Randall M. Milner, domicilié profession-
nellement au 1800, 200 Burrard Street, Vancouver, British Columbia V6C3M1 (Canada), qui a désigné comme secrétaire
Mr. Nojan Abrary, domicilié professionnellement au 1800, 200 Burrard Street, Vancouver, British Columbia V6C3M1
(Canada).
L'assemblée a choisi comme scrutateur David Valembois, domicilié professionnellement au Waterloo Office Park -
Building P, Dreve Richelle 161 - Box 31, B-1410 Waterloo, (Belgique).
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Création d'une nouvelle catégorie de parts sociales nommées actions préférentielles à rachat obligatoire (ci-après
«APRO»);
3. Augmentation du capital social de la Société de cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
150.000,-) et création:
(a) d'une Réserve APRO à créer pour les APRO pour un montant de cent quatre-vingt un millions huit cent cinquante
mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 181.850.000,-);
(b) d'une prime d'émission ordinaire de deux millions neuf cent quatre-vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique
(USD 2.980.000,-); et
(c) d'une réserve légale de la Société pour un montant de vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 20.000,-);
afin de porter le montant du capital social actuel de cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 50.000,-)
à un montant de deux cent mille dollars des États-Unis d'Amérique (USD 200.000,-) et émission:
(a) de cinquante mille parts sociales ordinaires additionnelles (50.000), sous forme nominative, d'une valeur nominale
de un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées; et
(b) de cent mille (100.000) APRO, d'une valeur nominale de un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées;
4. Modification subséquente de l'Article 5.1 des statuts de la Société afin de rendre compte de l'augmentation du capital
social décrite ci-dessus;
5. Insertion de nouveaux Articles 5.3 et 15.4 dans les statuts de la Société afin de tenir compte des résolutions pré-
cédentes à savoir la création d'une nouvelle catégorie de parts sociales nommées «actions préférentielles à rachat
obligatoire» et l'augmentation de capital selon les résolutions 2 et 3;
6. Modifications des Articles 6.1 et 15.2 des statuts de la Société afin de rendre compte de la résolution 3 ci-dessus.
(ii) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les associés présents ou représentés ont
déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.
(iii) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.
6074
L
U X E M B O U R G
(iv) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée a décidé de renoncer aux formalités de convocation, tous les associés ayant complète connaissance de
l'ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée a décidé de créer une nouvelle catégorie de parts sociales nommées actions préférentielles à rachat
obligatoire (ci-après «APRO»), ayant les droits et privilèges prévus par les statuts de la Société et par la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée a décidé de d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent cinquante mille dollars des
États-Unis d'Amérique (USD 150.000,-) et de créer:
(a) une Réserve APRO à créer pour les APRO pour un montant de cent quatre-vingt un millions huit cent cinquante
mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 181.850.000,-);
(b) une prime d'émission ordinaire de deux millions neuf cent quatre-vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique
(USD 2.980.000,-); et
(c) une réserve légale de la Société pour un montant de vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 20.000,-);
afin de porter le montant du capital social actuel de cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 50.000,-)
à un montant de deux cent mille dollars des États-Unis d'Amérique (USD 200.000,-) et émission de:
(a) cinquante mille parts sociales ordinaires additionnelles (USD 50.000,-), sous forme nominative, d'une valeur no-
minale de un dollar des États-Unis d'Amérique (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées; et
(b) cent mille (100.000) APRO, d'une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée a décidé de modifier l'Article 5.1 des statuts de la Société afin de rendre compte de l'augmentation de
capital décidée ainsi que de la création d'une nouvelle catégorie d'actions nommées APRO, qui aura désormais la teneur
suivante:
« Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 200.000,-)
représenté par cent mille (100.000) parts sociales ordinaires sous forme nominative ayant une valeur nominale de un
dollars des États-Unis d'Amérique (USD 1) chacune et par cent mille (100.000) actions préférentielles à rachat obligatoire
(ci-après «APRO») ayant une valeur nominale de un dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.»
Parts sociales signifient les parts sociales ordinaires et APRO collectivement.
Les propriétaires des APRO sont indiqués dans les statuts comme les associés des APRO, et les termes «associé» ou
«associés» désigneront les propriétaires des Parts sociales et/ou les Associés des APRO, selon le contexte.
La Société peut rembourser ses parts sociales dans les limites fixées par la loi.»
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-avant, l'assemblée a décidé d'insérer les nouveaux articles 5.3 et 15.4 afin de rendre
compte des changements ci-avant afin de déterminer les droits et privilèges des APRO.
Les articles suivants sont insérés:
Art. 5.3. APRO. Chaque APRO correspond à des actions rachetables. Les APRO émises et entièrement libérées seront
obligatoirement rachetées sur décision du conseil de gérance de la Société conformément à l'article 8.2.(v) ou à l'article
9, selon le cas, des statuts de la Société conformément aux dispositions de la Loi à la date du dixième (10
e
) anniversaire
de la date d'émission des APRO ou à une date antérieure proposée par le conseil de gérance et approuvée par les associés
de la Société mais en aucun cas une telle date devra être postérieure à dix (10) années après la date d'émission des APRO.
L'Associé des APRO est autorisé avant la date d'expiration à demander par écrit à ce que la Société rachète toutes ou
partie des APRO. Les APRO peuvent uniquement être rachetées en utilisant les montants distribuables disponibles.
Prix de Rachat d'Origine: Sauf disposition contraire prévue (i) par les présents Statuts ou (ii) par un accord écrit qui
peut être conclu entre la Société et l'Associé des APRO, le Prix de Rachat d'Origine de chaque APRO rachetée restant
due sera, à la seule discrétion de la Société, payé en numéraire ou en nature et sera égal au prix de souscription desdites
APRO rachetées tel que payé par l'Associé d'APRO au moment de leur émission (soit le capital social APRO et la prime
d'émission y attachée) plus tout dividende préférentiel couru mais impayé sur chaque APRO rachetée à la date de rachat.
De plus, afin d'éviter tout doute, tout dividende déclaré mais impayé pour les APRO rachetées seront payées avant tout
rachat d'APRO.
6075
L
U X E M B O U R G
Si, au moment du rachat des APRO, il existe un ajustement de valeur de l'Actif Sous-jacent acquis ou en voie d'acqui-
sition et directement ou indirectement financée par les APRO rachetées, le Prix de Rachat de chaque APRO restant due
(«Prix de Rachat Diminué») sera limité à (a) la valeur comptable ajustée, au moment du rachat, déterminé selon les
Standards Comptables luxembourgeois de l'Actif Sous-jacent acquis et directement ou indirectement financée par les
APRO rachetées (cette limitation s'applique aussi au rachat d'APRO par numéraire/actifs provenant du remboursement
de l'Actif Sous-jacent en considération et sujet audit ajustement de valeur) plus tout dividende préférentiel couru mais
impayé sur chaque APRO rachetée à la date de rachat divisé par (b) le nombre d'APRO restant dues au moment du
rachat. Pour éviter tout doute, cet ajustement ne peut pas être d'un montant plus élevé que le Prix de Rachat d'Origine.
De plus, les APRO ne peuvent être rachetées que si ces rachats n'auraient pas pour effet de réduire les actifs nets en-
dessous de la valeur du capital social et des réserves qui ne peuvent être distribuées en vertu de la Loi.
Pour l'application des dispositions du paragraphe précédent:
Le terme Ajustement de valeur signifie, en ce qui concerne les Actifs Sous-jacents, toute réduction de valeur enregistrée
ou en cours d'enregistrement selon les Standards Comptables luxembourgeois au moment du rachat dans l'état financier
intérimaire de la Société utilisé pour déterminer entre autres l'existence de fonds suffisants disponibles pour le rachat.
Standards Comptables luxembourgeois signifie les principes comptables reconnus de façon générale au Luxembourg.
Actifs Sous-jacents signifie les actifs financiers en USD acquis ou devant être acquis et financés directement ou indi-
rectement par l'émission des APRO et/ou tout autre actif financier en USD remplaçant ce type d'actif financier, ou acquis
ou financé avec le Revenu issu de tels actifs financiers ou d'une vente de tout ou partie de tels actifs financiers.
Le Revenu à l'égard des Actifs Sous-jacents au cours de toute période comptable de la Société concernée désigne les
revenus courus ou acquis (tels que, mais sans s'y limiter, les revenus d'intérêts) et tout gain réalisé par la Société selon
les Standards Comptables luxembourgeois.
Procédure de Rachat: Sauf disposition contraire d'un contrat écrit conclu entre la Société et l'Associé des APRO, une
notification écrite sera envoyée par la Société par lettre recommandée ou téléfax ou courrier électronique, à l'Associé
des APRO au moins dix (10) jours avant la date de rachat, à l'adresse indiquée dans le registre des associés, notifiant à
l'Associé des APRO le nombre d'APRO devant être rachetées et indiquant la date de rachat, le Prix de Rachat d'Origine
(ou le Prix de Rachat Diminué selon le cas) et les procédures nécessaires afin de soumettre les APRO à la Société pour
leur rachat. Le Prix de Rachat d'Origine (ou le Prix de Rachat Diminué selon le cas) de ces APRO sera payable à l'ordre
du de l'Associé des APRO dont le nom figure sur le registre des associés comme leur propriétaire sur le compte en
banque tel que fourni à la Société par cet associé avant la date de rachat.
Lors du rachat, le paiement du Prix de Rachat d'Origine (ou le Prix de Rachat Diminué selon le cas) peut être totalement
ou partiellement différé si la Société n'a pas d'actifs nets disponibles pour racheter toutes les APRO. Dans ce cas, la
Société devra racheter toutes APRO et payer uniquement au moment du rachat la part du Prix de Rachat d'Origine (ou
le Prix de Rachat Diminué selon le cas), qui est égale au montant des fonds distribuables disponibles à la date de rachat.
Ensuite, la Société devra payer en priorité aux Associés des APRO la différence entre le montant du paiement partiel des
APRO et le montant du Prix de Rachat d'Origine (ou le Prix de Rachat Diminué selon le cas), plus une pénalité qui sera
déterminée par les Associés des APRO et la Société, dans les quinze (15) jours suivant l'apparition de l'insuffisance en
fonction de la part du Prix de Rachat d'Origine restante (ou le Prix de Rachat Diminué selon le cas), mais seulement à la
condition et au moment où la Société récupérera suffisamment de fonds disponibles, espèce ou actifs pour un tel paiement.
En cas de paiement partiel du prix de rachat des APRO, la Société pourra ne procéder à aucune autre distribution ou
aucun autre paiement d'un associé ordinaire jusqu'au paiement complet du prix de rachat applicable (i.e., Prix de Rachat
d'Origine ou Prix de Rachat Diminué le cas échéant) des APRO.
Sous réserve des dispositions du présent article, en cas de liquidation, dissolution ou radiation de la Société, après le
paiement des dettes envers des tiers ou passifs de la Société, ou dépôt de fonds à cette fin, l'Associé d'APRO aura
seulement droit au prix de rachat applicable ajouté du montant payable en numéraire ou en nature égal à son dividende
couru mais impayé, avant le paiement de tout montant à l'égard des autres parts sociales.
Pour éviter tout doute, les propriétaires des APRO n'auront le droit de participer à aucun produit de liquidation autre
que le droit de paiement du prix de rachat applicable augmenté du montant des dividendes courus mais impayés liés aux
APRO restant dues jusqu'à la date de la liquidation comme décrit au paragraphe précédent.
Réserve APRO: La Société constituera pour les APRO une réserve utilisée uniquement pour tout paiement fait par le
souscripteur (en plus de la valeur nominale) sur cette catégorie d'APRO ou par la Société conformément aux Statuts ou
à la Loi.
Réserve spéciale: Un montant égal à la valeur nominale, ou, en l'absence de valeur nominale, à la valeur comptable
(c'est-à-dire le montant du capital social émis divisé par le nombre de parts sociales émises) de toutes les APRO rachetées
doit être versé sur un compte de réserve spéciale, lequel ne peut pas être distribué aux associés sauf en cas de réduction
du capital souscrit; la réserve peut uniquement être utilisée pour augmenter le capital souscrit par incorporation des
réserves.
Les APRO jouissent pleinement des mêmes droits de vote que ceux attachés à des parts sociales ordinaires.
Toute convocation, rapport et document, qui en vertu de la loi luxembourgeoise doivent être envoyée ou notifiée aux
associés de la Société devront également être envoyés ou notifiés aux associés APRO.
6076
L
U X E M B O U R G
Art. 15.4. Après affectation à la Réserve Légale, le solde des bénéfices sera affecté en priorité au paiement à l'Associé
des APRO ou à l'affectation à la Réserve APRO des droits à dividende préférentiel suivants:
Chaque APRO donne droit à son propriétaire de recevoir un dividende privilégié et cumulatif («Dividende 1») au taux
annuel de 1% calculé sur la valeur nominale du capital social représenté par ces APRO et qui court de manière journalière
à partir de la date du transfert des Actifs Sous-jacents correspondants ou de la dernière date de paiement de dividende,
qui se réfèrent aux APRO à la Société et qui est calculé sur la base d'une année de 365 jours ou de 366 jours selon le
cas.
Deuxièmement, chaque APRO donne droit à son propriétaire de recevoir un deuxième dividende privilégié et cumulatif
(«Dividende 2»), qui court de manière journalière à partir de la date du transfert des Actifs Sous-jacents ou à la date du
dernier paiement de dividendes qui se réfèrent aux APRO à la Société et qui est calculé sur la base d'une année de 365
jours ou de 366 jours selon le cas. Le Dividende 2 sera égal au Revenu courus ou reçus par la Société sur chaque Actif
Sous-jacent depuis le dernier paiement de dividende, qui se réfère à chaque APRO moins (i) une marge déterminée par
le Conseil de gérance de la Société sur la base d'une étude des prix de transfert (avec ses modifications successives),
exprimée en point de base et calculée sur le montant annuel moyen des APRO restant à payer plus les compte de Réserves
APRO et autres comptes similaires de réserves APRO y attachées, (ii) moins le montant du Dividende 1 payé sur chaque
APRO.
Pour l'application des dispositions du paragraphe précédent:
Actifs Sous-jacents signifie les actifs financiers en USD acquis ou devant être acquis et financés directement ou indi-
rectement par l'émission des APRO et/ou tout autre actif financier en USD remplaçant ce type d'actif financier, ou acquis
ou financé avec les profits issus de tels actifs financiers ou d'une vente de tout ou partie de tels actifs financiers. Chaque
Actif Sous-jacent (quand il est transféré à la Société) sera expressément affecté par une résolution des gérants à une
catégorie spécifique d'APRO.
Le Revenu à l'égard des Actifs Sous-jacents au cours de toute période comptable de la Société concernée désigne les
revenus courus ou acquis (tels que, mais sans s'y limiter, les revenus d'intérêts) plus tout gain réalisé par la Société selon
les Standards Comptables luxembourgeois.
Montant principal restant dû signifie la somme de la valeur nominale et du montant de la réserve APRO pour les APRO
restant dues.
Les Associés d'APRO ont droit au dividende préférentiel et cumulatif même les années où la Société subit des pertes.
Si les Dividendes 1 et 2 ne sont pas déclarés malgré l'existence de bénéfices disponibles à cet effet, il sera capitalisé chaque
année comptable, au plus tard le dernier jour de l'exercice comptable concerné.
Si les Dividendes 1 et 2 ne sont pas déclaré malgré l'existence de bénéfices disponibles à cet effet, le montant du
Dividende 1 et du 2 (i) sera alloué au compte de réserve APRO sur décision de l'actionnaire de la Société, (ii) restera
exclusivement au bénéfice des propriétaires d'APRO et (iii) sera disponible afin de payer les Dividendes 1 et 2 restant
dus au moment de la prochaine distribution de Dividendes de la Société.
Afin d'éviter toute incertitude, si les bénéfices de la Société pour l'exercice correspondant ne sont pas suffisants pour
payer entièrement ou pour affecter à la Réserve APRO les dividendes préférentiels 1 et 2, toute insuffisance sera payée
ou affectée à la Réserve APRO en priorité à partir des bénéfices des années suivantes, à chaque fois au pro rata du nombre
total des APRO émis.
Le second dividende préférentiel sur tout les APRO peut seulement courir et être déclaré une fois que la Société a
acquis les Actifs Sous-jacents financées par les APRO correspondants.
L'assemblée générale des associés pourra affecter de manière discrétionnaire tout surplus de bénéfice restant après
l'affectation à la Réserve Légale ainsi que le paiement ou l'affectation à la Réserve APRO des Dividendes privilégiés 1 et
2. Elle peut en particulier affecter ce surplus de bénéfice sous la forme d'un paiement d'un dividende additionnel ou d'un
transfert à un compte de réserve ou d'un report.
Aucun dividende ou acompte sur dividende sera distribué aux propriétaires de parts ordinaires de la Société jusqu'à
ce que les dividendes préférentiels soient entièrement versée aux propriétaires d'APRO au moment prescrits ou des
montants suffisants pour le paiement de ces dividendes préférentiels ont été mis de côté dans la Réserve d'APRO.
Les dividendes seront payés en dollars des États-Unis et ils peuvent être payés aux lieux et aux dates qui peuvent être
déterminés par le conseil de gérance de la Société conformément à l'article 8.2 (v) ou de l'article 9, selon le cas, des
statuts de la société.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée a décidé de modifier les articles 6.1 et 15.2 des statuts de la Société afin de rendre compte des résolutions
ci-avant, qui auront la teneur suivante:
« 6.1. Sous réserve des articles 5.3 et 15.4 des Statuts, chaque part sociale donne droit à son propriétaire à une fraction
des actifs et profits de la Société en proportion directe avec le nombre de parts sociales existantes.»
« 15.2. Sous réserve des articles 5.3 et 15.4 des Statuts, l'assemblée générale des associés a un pouvoir discrétionnaire
de disposer du surplus. Elle peut en particulier affecter ces profits au paiement d'un dividende ou les transférer à la réserve
ou un report.»
6077
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et paiementi>
L'associé unique, Methanex Corporation (le «Souscripteur»), représenté par Mr. Randall M. Milner, pré qualifié, dé-
clare:
(i) souscrire aux
a) cinquante mille nouvelles parts ordinaires (50.000) ayant une valeur nominale de un dollar des États-Unis d'Amérique
(USD 1) chacune,
et;
b) cent mille (100.000) APRO, ayant une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1) chacune.
(ii) libérer ces parts sociales intégralement par un apport en nature d'un montant total de cent quatre-vingt cinq millions
de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 185.000.000,-) Apport ») incluant:
a) une Réserve APRO à créer pour les APRO pour un montant de cent quatre-vingt un millions huit cent cinquante
mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 181.850.000,-);
b) une réserve légale de la Société pour un montant de vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique et dix Cents
(USD 20.000,-) et
c) une prime d'émission ordinaire de deux millions neuf cent quatre-vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
2.980.000,-).
<i>Description de l'Apporti>
L'Apport est légalement détenu par le Souscripteur. L'Apport à la Société est composé d'un actif financier d'un montant
de cent quatre-vingt cinq millions de dollars des États-Unis d'Amérique (USD 185.000.000,-).
<i>Evaluationi>
La valeur totale de l'Apport en nature est de cent quatre-vingt cinq millions de dollars des États-Unis d'Amérique (USD
185.000.000,-). Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à la déclaration de la valeur
de l'apport daté du 20 Novembre 2012, qui sera annexée à cet acte et qui sera soumise aux formalités d'enregistrement.
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
La preuve de l'Apport a été apportée.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de cet acte s'élèvent
approximativement à sept Euros (EUR 7.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par son nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné le présent acte.
Signé: Milner, Abrary, Valembois, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15413. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012160487/506.
(120211880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2012.
Rockwell Collins European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 96.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 106.509.
<i>Extrait des résolutions de l'associé uniquei>
En date du 13 décembre 2012, l'associé unique a décidé de nommer Deloitte Audit, une société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistrée auprès du
6078
L
U X E M B O U R G
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895. en tant que réviseur d'entreprises agréé
de la société, et ce avec effet rétroactif au 1
er
octobre 2009, et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012164364/17.
(120217117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Rosefield Luxembourg S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.475.
Les comptes annuels au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012164366/10.
(120217181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Pizzeria Peperoncino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 55, rue de Vianden.
R.C.S. Luxembourg B 111.527.
<i>Rapport de l'assemblée générale du 10.12.2012i>
<i>Résolution des associés:i>
Les associés réunis en assemblée générale extraordinaire le 10.12.2012 à 15h10 au siège social de la société, constatent
que, suite à la cession de parts sociales du 10 décembre 2012, le capital social de la société Pizzeria Peperoncino Sàrl, RC
B 111527, est détenu comme suit:
Antonio Gasparro, né le 12.06.1962 à Acquaviva Delle Fonti (Italie),
demeurant à L-4023 Esch/Alzette, 72 rue J.P. Bausch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts sociales
Madame Angele Lisarelli, née le 27.8.1963 à Dudelange (Luxembourg),
demeurant à L-8351 Dahlem, 4a Cité Wuesheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
Monsieur Tiziano Gasparro, né le 21 février 1989 à Luxembourg (Luxembourg),
demeurant à L-8351 Dahlem, 4a Cité Wuesheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2012.
Monsieur Antonio Gasparro / Monsieur Tiziano Gasparro / Madame Angèle Lisarelli
<i>Les associés
i>Les membres du bureau
Monsieur Antonio Gasparro / Monsieur Tiziano Gasparro / Madame Angèle Lisarelli
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur
i>Les organes compétents
Monsieur Antonio Gasparro / Madame Angèle Lisarelli
Référence de publication: 2012164339/27.
(120217107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
PMB Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 110.519.
La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2010 a été déposée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
6079
L
U X E M B O U R G
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2012164341/11.
(120216838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Pocolena S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 66.570.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012164342/11.
(120217398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Xylem Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 172.763.
In the year two thousand and twelve, on the fourth day of December, at 10.00 a.m.
Before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Xylem Delaware, Inc., an incorporation organized and existing under the laws of the state of Delaware (U.S.A), having
its registered office at 1105, North Market Street, Wilmington DE19801, U.S.A. with tax payer number 06-1077415 (the
Sole Shareholder),
hereby represented by Ms Danielle Kolbach, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
pursuant to a power-of-attorney under private seal given in New York on December 3, 2012,
which power-of-attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing
party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be submitted with such deed to the
registration authorities,
for the extraordinary general meeting of shareholders (the Meeting) of Xylem Global S.à r.l., a private limited company
(société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg having its registered office at 9, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
172.763 (the Company), the Sole Shareholder acting in lieu of the Meeting.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that
I. It is the sole shareholder of the Company and holds all twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares having
a par value of EUR 1.- (one euro) per share representing the entire subscribed share capital of the Company amounting
to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro).
II. The Sole Shareholder recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
<i>Agendai>
1. Capital increase of the Company by an amount of EUR 10,225,507 (ten million two hundred and twenty-five thousand
five hundred and seven euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
euro) to an amount of EUR 10,238,007.- (ten million two hundred and thirty eight thousand and seven euro) and issue
of 10,225,507 (ten million two hundred and twenty-five thousand five hundred and seven) ordinary shares having a par
value of EUR 1.- (one euro) each (the Shares) having the same rights and privileges as the existing shares.
2. Subscription to and payment of the Shares specified under 1) above and payment of a share premium to be allocated
to the premium reserve of the Company by Xylem Inc. and payment in full of the capital increase and each of the Shares
(nominal value and share premium) by a contribution in kind of all 818,093 shares in Xylem Water Solutions Australia
Limited.
3. Amendment of article 4, first paragraph, of the Company's articles of incorporation so as to reflect the resolutions
to be adopted under items 1) and 2) of the Agenda.
III. The Sole Shareholder has passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 10,225,507 (ten
million two hundred and twenty-five thousand five hundred and seven euro) so as to bring it from its present amount of
6080
L
U X E M B O U R G
EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) Shares having
a par value of EUR 1.- (one euro) each to an amount of EUR 10,238,007.- (ten million two hundred and thirty-eight
thousand and seven euro) and to create and issue 10,225,507 (ten million two hundred and twenty-five thousand five
hundred and seven) new Shares, having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each and having the same rights and privileges
as the existing shares. The sole shareholder approves the new shareholder as new shareholder.
<i>Second resolutioni>
<i>Subscription and allotmenti>
A. Xylem Inc., a company organized under the laws of Indiana, having its registered office at 1133 Westchester Avenue,
Suite N200, White Plains, New York, 10604, U.S.A. and with tax ID 45-2080495,
represented by Mrs Danielle Kolbach, prenamed,
by virtue of a power of attorney under private seal given in New York, on December 4, 2012, and with the consent
of the Sole Shareholder, represented as mentioned above,
declares to subscribe to the 10,225,507 (ten million two hundred and twenty-five thousand five hundred and seven)
new Shares and to pay up such new Shares and the share premium thereon by a contribution in kind representing 100%
of the issued shares, consisting of 818,093 (eight hundred eighteen thousand ninety-three) ordinary shares in Xylem
Water Solutions Australia Limited, an unlisted public company incorporated and existing under the laws of New South
Wales, Australia, with registered office in Unit 2, 2 Capicure Drive, Eastern Creek, New South Wales 2766, Australia,
together with all rights and duties, in particular the right to receive profits including those of the current business year
and all profits not yet distributed as of today, having an aggregate value of EUR 102,267,571.95 (one hundred and two
million two hundred and sixty-seven thousand five hundred and seventy one euro and ninety-five cents).
B. The contributions made to the Company by Xylem Inc. is to be recorded at fair market value which amounts to
EUR 102,267,571.95 (one hundred and two million two hundred and sixty-seven thousand five hundred and seventy one
euro and ninety-five cents) as it results from the valuation certificate as of December 3, 2012 (the Certificate) which
remains attached hereto and to be allocated as follows:
1) EUR 10,225,507 (ten million two hundred and twenty-five thousand five hundred and seven euro) to the nominal
share capital of the Company; and
2) the balance, i.e. EUR 92,042,064.95 (ninety-two million forty-two thousand sixty-four euro and ninety-five cents),
is to be allocated to the premium reserve of the Company; it being noted that the contribution shall be accounted for at
fair market value and it being further noted that any value adaptation, for any accounting or tax reasons generally what-
soever in Luxembourg or abroad, of the fair market value of the contribution shall be effectuated by way of increase or
decrease (as the case may be) of the issue premium in which case a corresponding premium adaptation of the premium
reserve shall be made.
The Certificate, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
As a result of the above, the shareholding in the Company is as of now as follows:
Xylem Delaware Inc., prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500 shares
Xylem Inc., prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,225,507 shares
<i>Third resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder together with Xylem Inc. resolve to amend the 1st paragraph
of article 4 of the articles of association of the Company, which shall have the following wording:
"The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 10,238,007.- (ten million two hundred and thirty-eight thou-
sand and seven euro), represented by 10,238,007.- (ten million two hundred and thirty-eight thousand and seven) ordinary
shares with a par value of EUR 1.- (one euro) per share."
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed at six thousand five hundred euro (EUR 6,500).
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a German version; at the request of the proxyholder of the appearing party and in case of divergences
between the two versions, the English version will prevail.
Whereas, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, in the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxy-holder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendzwölf, am vierten Dezember, um 10.00 Uhr.
6081
L
U X E M B O U R G
Vor dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Xylem Delaware, Inc., eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht des Staates Delaware (U.S.A.) mit
Gesellschaftssitz 1105, North Market Street, Wilmington DE19801, U.S.A. mit Steuernummer 06-1077415 (der Alleinige
Gesellschafter),
hier vertreten durch Frau Danielle Kolbach, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in New York am 3. Dezember 2012,
welche Vollmacht, nach der Unterzeichnung ne varietur durch den Vollmachtsnehmer und den unterzeichnenden
Notar, dieser Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit dergleichen einregistriert zu werden,
zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die Versammlung) der Gesellschaft Xylem Global S.à r.l., eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 9,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, eingetragen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister unter der
Nummer B 172.763 (die Gesellschaft), wobei der Alleinige Gesellschafter anstelle der Versammlung handelt.
Der Alleinige Gesellschafter ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
I. Der Alleinige Gesellschafter hält alle zwölftausend fünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert
von je EUR 1.- (einem Euro), welche ein Gesamtkapital von EUR 12.500.- (zwölftausend fünfhundert Euro) darstellen.
II. Der Alleinige Gesellschafter erklärt, ausführlich über die auf der Grundlage der folgenden Tagesordnung zu fassenden
Beschlüsse informiert zu sein:
<i>Tagesordnungi>
1. Aufstockung des Gesellschaftskapitals um EUR 10.225.507.- (zehn Millionen zwei hundert fünfundzwanzig tausend
fünfhundert und fünf Euro), um das bestehende Kapital in Höhe von EUR 12.500.- (zwölftausend fünfhundert Euro) auf
EUR 10.238.007.- (zehn Millionen zwei hundert achtunddreißig tausend und sieben Euro) zu erhöhen, durch Ausgabe von
10.225.507 (zehn Millionen zwei hundert fünfundzwanzig tausend fünfhundert und fünf) neuen Gesellschaftsanteilen mit
einem Nennwert von jeweils EUR 1.- (einem Euro) (die Anteile) mit den gleichen Rechten und Privilegien wie die beste-
henden Gesellschaftsanteile.
2. Zeichnung und Zahlung der unter Tagesordnungspunkt 1) erwähnten Anteile, zusammen mit einem an die Agio-
rücklage der Gesellschaft zuzuweisenden Agio, durch Xylem Inc., und Zahlung der Agiorücklage durch eine Sacheinlage
von allen 818.093 Anteilen der Xylem Water Solutions Australia Limited.
3. Abänderung von Artikel 4, erster Absatz der Satzung, entsprechend den gemäß den Tagesordnungspunkten 1) bis
2) zu fassenden Beschlüssen.
III. Der Alleinige Gesellschafter fasst folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um EUR 10.225.507.- (zehn Millionen zweihundert-
fünfundzwanzigtausendfünfhundert und sieben Euro) von EUR 12.500 (zwölftausend fünfhundert Euro), eingeteilt in
zwölftausend fünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,- (einem Euro), auf EUR
10.238.007.- (zehn Millionen zweihundertachtunddreißigtausend und sieben Euro) aufzustocken, durch Schaffung und
Ausgabe von 10.225.507.- (zehn Millionen zwei hundert fünfundzwanzig tausend fünfhundert und sieben) neuen Anteilen
mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,- (einem Euro) und mit den gleichen Rechten und Privilegien wie die bestehenden
Gesellschaftsanteile. Der Alleinige Anteilsinhaber erklärt sich einverstanden dass der neue Anteilsinhaber neuer Anteils-
inhaber wird.
<i>Zweiter Beschlussi>
<i>Zeichnung und Zuteilungi>
A. Daraufhin ist Xylem Inc., eine Gesellschaft unter Indiana Recht, mit Sitz in 1133 Westchester Avenue, Suite N200,
White Plains, New York, 10604, Vereinigte Staaten von Amerika, mit Steuerkennzeichnungsnummer 45-2080495
vertreten durch Frau Danielle Kolbach, vorgenannt,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in New York am 4. Dezember 2012, mit dem Einverständnis
des Alleinigen Gesellschafters, vertreten wie eingangs beschrieben,
erschienen und erklärt die 10.225.507.- (zehn Millionen zwei hundert fünfundzwanzig tausend fünfhundert und sieben)
neuen Anteilen zu zeichnen und den Nennwert der Anteile sowie das Agio einzuzahlen durch eine Sacheinlage bestehend
aus 100% der ausgegebenen Anteile, welche sich auf 818.093 (achthundertachtzehntausend dreiundneunzig) belaufen, der
Xylem Water Solutions Australia Limited, eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft des Rechtes von New Süd Walis
(Australien), mit Geschäftssitz in Unit 2, 2 Capicure Drive, Eastern Creek, New South Wales 2766 (Australien), gemeinsam
mit den Gewinnrechten, welche zu diesem Tage noch nicht ausgeschüttet worden sind, mit einem Gesamtwert von EUR
102.267.571,95 (hundert und zwei Millionen zweihundertsiebenundsechzigtausendfünfhunderteinundsiebzig Euro und
fünfundneunzig Cents).
6082
L
U X E M B O U R G
B. Die Einlage in die Gesellschaft durch den Alleinigen Gesellschafter wird zu ihrem fairen Marktwert bewertet, welcher
EUR 102.267.571,95 (hundert und zwei Millionen zweihundertsiebenundsechzigtausendfünfhunderteinundsiebzig Euro
und fünfundneunzig Cents) beträgt, so wie es aus dem Bewertungszertifikat vom 3. Dezember 2012 (das Zertifikat),
welcher beigebogen bleibt, hervorgeht und welcher wie folgt zugeteilt wird:
1) ein Betrag von EUR 10.225.507.- (zehn Millionen zwei hundert fünfundzwanzig tausend fünfhundert und sieben Euro)
wird dem nominalen Gesellschaftskapital zufließen;
2) der Restbetrag, d.h. EUR 92.042.064,95 (zweiundneunzig Millionen zweiundvierzigtausend und vierundsechzig Euro
und fünfundneunzig Cents) wird der Agiorücklage der Gesellschaft zugewiesen; wobei zu beachten ist, dass die Einlage in
den Büchern der Gesellschaft zum fairen Marktwert auszuweisen ist; und wobei ferner zu beachten ist, dass jede Wert-
anpassung des Marktpreises der Einlage aus Rechnungslegungs- oder Steuergründen in Luxemburg oder anderswo durch
Erhöhung oder Herabsetzung (je nachdem was zutrifft) des Ausgabeagios unter Vornahme der entsprechenden Agioan-
gleichung der Agiorücklage erfolgen muss.
Ein Kopie jeweils der obengenannten Zertifikats bleibt nach der ne varietur Unterzeichnung des Bevollmächtigten der
erschienenen Parteien und des unterzeichnenden Notars der gegenwärtigen Urkunde beigebogen um mit dieser einre-
gistriert zu werden.
Als Folge obiger Beschlüsse, bestätigt die Versammlung dass sich die Anteile an der Gesellschaft wie folgt verteilen:
Xylem Delaware Inc., vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500 Anteile
Xylem Inc., vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.225.507 Anteile
<i>Dritter Beschlussi>
Infolge der obengenannten Beschlüsse beschließt der Alleinige Gesellschafter zusammen mit Xylem Inc., den 1. Absatz
von Artikel 4 der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:
"Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 10.238.007.- (zehn Millionen zweihundertachtunddreißigtausend
und sieben Euro) und ist eingeteilt in 10.238.007.- (zehn Millionen zwei hundertachtunddreißigtausend und sieben) Anteile
mit einem Nennwert von je EUR 1.- (einem Euro)."
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit vorliegender Urkunde zu Lasten gehen, belaufen sich auf
sechs tausend fünfhundert Euro (EUR 6.500.-).
Der Unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der Vollmachtnehmerin der erschienenen Parteien in englischer Sprache, gefolgt von einer deut-
schen Übersetzung, verfasst worden ist, und dass auf Verlangen derselben Vollmachtnehmerin bei Abweichungen zwischen
dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung maßgebend ist.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube des unterzeichenden Notars, am Datum wie
eingangs erwähnt.
Nach Verlesung der Urkunde hat die Vollmachtnehmerin der erschienenen Partei zusammen mit uns, dem Notar, die
vorstehende Originalurkunde unterzeichnet.
Signé: D. Kolbach, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 6 décembre 2012, REM/2012/1567. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 10 décembre 2012.
Référence de publication: 2012161380/194.
(120212304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.
Pajo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4164 Esch-sur-Alzette, 6, Kleesgrendchen.
R.C.S. Luxembourg B 163.949.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
ACA - Atelier Comptable & Administratif S.A.
Signature
Référence de publication: 2012164316/12.
(120217325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
6083
L
U X E M B O U R G
Halliburton Luxembourg Minority S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.507.845,00.
Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 167.159.
In the year two thousand and twelve, on the thirtieth day of November.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at Navas
Business Center, 2B Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 167.154,
here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, with professional address at 9 Rabatt, L-6402 Echternach,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 30, 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the entity appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing entity is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")
established in Luxembourg under the name of "Halliburton Luxembourg Minority S.à r.l.", registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 167.159, having its registered office at Navas Business Center, 2B Ennert
dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Beck,
notary public residing in Echternach, dated February 27
th
, 2012, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et
Associations number 976, on April 16
th
, 2012 (the "Company").
II. The Company's share capital is set at two million, five hundred and seven thousand, eight hundred and forty-four
U.S. Dollars (USD 2,507,844.-) represented by two million, five hundred and seven thousand, eight hundred and forty-
four (2,507,844) shares, with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.
III. The appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by one U.S. Dollar (USD 1.-) in order to
raise it from its present amount of two million, five hundred and seven thousand, eight hundred and forty-four U.S. Dollars
(USD 2,507,844.-) to two million, five hundred and seven thousand, eight hundred and forty-five U.S. Dollars (USD
2,507,845.-) by the creation and issue of one (1) new share.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Halliburton Luxembourg Intermediate S.a r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe
to the new share and to have it fully paid up in the amount of one U.S. Dollar (USD 1.-), along with the payment of a
share premium in the amount of twenty-eight million, ten thousand and seventy-nine U.S. Dollars (USD 28,010,079.-), by
a contribution in kind consisting of one hundred eighty (180) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each,
representing one percent (1%) of the share capital of HESI Holdings B.V., a private limited liability company existing under
the laws of The Netherlands, having its registered office at Verrijn Stuartlaan 1 c, 2288 EK Rijswijk, Zuid-Holland, The
Netherlands, which are hereby transferred to and accepted by the Company at the fair market value of twenty-eight
million, ten thousand and eighty U.S. Dollars (USD 28,010,080.-) (the "Contribution in Kind").
Proof of the Contribution in Kind's existence and value has been given to the undersigned notary by an ad hoc decla-
ration signed by Halliburton Luxembourg Intermediate S.a r.l., dated November 30, 2012, and an ad hoc declaration signed
by HESI Holdings B.V., dated November 30, 2012.
Halliburton Luxembourg Intermediate S.a r.l., prenamed, declared that:
- it is the sole full owner of the Contribution in Kind and possesses the power to dispose of it, it being legally and
conventionally freely transferable; and
- all further formalities are in course in the country of residence of the entity whose shares are contributed, in order
to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the capital increase, the sole shareholder resolved to amend and fully restate article 6 of the
Company's articles of association as follows:
6084
L
U X E M B O U R G
" Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at two million, five hundred and seven thousand, eight hundred
and forty-five U.S. Dollars (USD 2,507,845.-) represented by two million, five hundred and seven thousand, eight hundred
and forty-five (2,507,845) shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve ".
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowered and authorized any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration
of the newly issued shares in the share register of the Company.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever will be borne by the Company.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by her
Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le trente novembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au Navas
Business Center, 2B Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167.154,
ici représentée par Mme Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6402, Echternach,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 novembre 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de Halliburton Luxembourg Minority S.à r.l., enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 167.159, ayant son siège social au Navas Business Center, 2B Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler,
Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach en
date du 27 février 2012, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 976, le 16 avril 2012 (la
«Société»).
II. Le capital social de la Société est fixé à deux millions, cinq cent sept mille, huit cent quarante-quatre dollars U.S.
(USD 2.507.844,-) divisé en deux millions, cinq cent sept mille, huit cent quarante-quatre (2.507.844) parts sociales d'un
montant d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.
III. La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un dollar U.S. (USD 1,-) pour le porter de
son montant actuel de deux millions, cinq cent sept mille, huit cent quarante-quatre dollars U.S. (USD 2.507.844,-) à deux
millions, cinq cent sept mille, huit cent quarante-cinq dollars U.S. (USD 2.507.845,-) par la création et l'émission d'une
(1) nouvelle part sociale.
<i>Souscription - Paiementi>
Sur ce, Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l., prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire à la nouvelle
part sociale et la libérer intégralement pour un montant d'un dollar U.S. (USD 1,-), avec le paiement d'une prime d'émission
d'un montant de vingt-huit millions, dix mille soixante-dix-neuf dollars U.S. (USD 28.010.079,-), par un apport en nature
consistant en cent quatre-vingt (180) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, représentant un
pourcent (1%) du capital d'HESI Holdings B.V., une société constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social
6085
L
U X E M B O U R G
à Verrijn Stuartlaan 1 c, 2288 EK Rijswijk, Zuid-Holland, Pays-Bas, qui sont transférées et acceptées par la Société à une
valeur de marché de vingt-huit millions, dix mille quatre-vingt dollars U.S. (USD 28.010.080,-)
(l'«Apport en Nature»).
Preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport en Nature a été donnée au notaire soussigné par la production d'une
déclaration ad hoc signée par Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l., en date du 30 novembre 2012, et par une
déclaration ad hoc signée par HESI Holdings B.V., en date du 30 novembre 2012.
Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l., prénommée, a déclaré que:
- elle est l'unique propriétaire de l'Apport en Nature contribué et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant
légalement et conventionnellement librement transmissibles; et
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence de l'Apport en Nature, aux fins
d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de l'augmentation de capital de la Société, l'associée unique a décidé de modifier et reformuler l'article
6 des statuts de la Société comme suit:
Art. 6. Capital souscrit. «Le capital social est fixé à deux millions, cinq cent sept mille, huit cent quarante-cinq dollars
U.S. (USD 2.507.845,-) représenté par deux millions, cinq cent sept mille, huit cent quarante-cinq (2.507.845) parts sociales
d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale».
<i>Troisième résolutioni>
L'associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui
précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à
l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit à raison des présentes seront mis à la
charge de la Société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 4 décembre 2012. Relation: ECH/2012/2056. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 10 décembre 2012.
Référence de publication: 2012161052/150.
(120212357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.
Puro Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 152.975.
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale des associés de la Société tenue en date du 10 décembre 2012, les résolutions
suivantes:
- La nomination de Monsieur Beltran Alvarez de Estrada, administrateur de la Société, né le 28 juin 1974 à Madrid,
Espagne et résidant à Orellana 15, piso 2, Madrid 28004, Espagne, au poste d’administrateur délégué à la gestion journalière
avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
6086
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012164315/15.
(120217405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Pan European Finance Framework HRE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 124.831.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012164296/10.
(120216148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Nici Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 121.785.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assembléei>
<i>générale des actionnaires du 29 novembre 2012i>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 31,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg;
L'assemblée générale des actionnaires accepte la démission de Madame Virginie DERAINS, Madame Sonja BEMTGEN
et Madame Carole FARINE en tant qu'administrateurs de la société;
L'assemblée générale des actionnaires accepte la démission de PICIGIEMME SARL, 38, Haerebierg, L-6868 Wecker,
en tant que commissaire aux comptes de la société;
L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer le conseil d'administration suivant pour la période expirant
à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014:
- Monsieur Raffaele SAURWEIN, né le 28 mai 1966 à Cesena (Italie), domicilié professionnellement au 1, Via Ferruccio
Pelli, CH-6901 Lugano, Suisse, Administrateur;
- Monsieur Tarcisio PICCO, né le 5 décembre 1951 à Cumiana (TO) (Italie), domicilié professionnellement au 1, Via
Ferruccio Pelli, CH-6901 Lugano, Suisse, Administrateur;
- Monsieur Olivier CAGIOULIS, né le 14 mars 1974 à Montignies-sur-Sambre (Belgique), domicilié professionnellement
au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg,Administrateur.
L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer le Commissaire aux Comptes suivant pour la période ex-
pirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014:
- AUDIT & CONSULTING SERVICES SARL, Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social au 9-11, rue
Louvigny, L-1946 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 151.342.
NICI INVESTMENTS S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012161189/29.
(120212668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.
Mobitrading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4776 Pétange, 9, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 107.194.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale de la société tenue au siège de la société en date du 8 juin 2012i>
Tous les actionnaires étant présents.
Les administrateurs décident:
- de prendre acte de la démission du Commissaire aux Comptes CONCORD INTERNATIONAL MARKETING SARL.
- de nommer comme Commissaire aux Comptes la société MATHILUX SARL, dont le siège social se situe au 8, rue
Théodore de Wacquant à L - 3899 FOETZ, immatriculée au RCSL sous le numéro B 125120. Son mandat viendra à
expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de 2015.
6087
L
U X E M B O U R G
La décision a été prise à l'unanimité.
Après cela, l'assemblée générale est déclarée comme terminée.
MOBITRADING S.A.
Philippe DUPONT
<i>Administrateur Déléguéi>
Référence de publication: 2012164255/19.
(120216682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Rheimolux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6794 Grevenmacher, 18, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 86.170.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012164374/9.
(120217096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Encore Plus Properties II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 111.140.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 65507 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012164877/10.
(120218544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Duplex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 76.546.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2012.i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.
Monsieur Norbert SCHMITZ, domicilié au 16, rue Eugène Wolff, L-2376 Luxembourg, et les sociétés FMS SERVICES
S.A., ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg et S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social au
39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
Monsieur Eric HERREMANS adresse professionnelle au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est réélu Commissaire
aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
<i>Pour la société
i>DUPLEX S.A.
Référence de publication: 2012164863/16.
(120218175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Euro Holiday Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 59.766.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 14 décembre 2012i>
L'assemblée, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Willy Xaveer A. Vercauteren de sa fonction d'ad-
ministrateur, décide d'accepter sa démission avec au 30 novembre 2012.
L'assemblée nomme comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Alessandro Giacomini, résidant
professionnellement Via Per Alzo, 39, I-28017 San Maurizio d'Opaglio (Italie) son mandat ayant la même échéance que le
mandat de son prédécesseur.
L'assemblée décide d'appeler à la fonction de Président du Conseil d'Administration Madame Valentina Giacomini
L'assemblée décide d'appeler à la fonction de Vice Président du Conseil d'Administration Monsieur Elia Filiberti.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
6088
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012164905/21.
(120217433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Euro Partner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 112, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 59.254.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012164906/10.
(120218393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Liberty Sea Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
R.C.S. Luxembourg B 111.648.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
- La société à responsabilité limitée Liberty Sea Trading Sàrl, dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard
Royal, a été dénoncé en date du 11 juillet 2011
Par jugement rendu en date du 13 décembre 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée Liberty Sea Trading Sàrl, dont le siège
social à L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal, a été dénoncé en date du 11 juillet 2011.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg et a désigné comme liquidateur Maître Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocate, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs
créances avant le 4 janvier 2013, ainsi que la publication du présent jugement pas extrait au Mémorial, ainsi que dans les
journaux Luxemburger Wort et Tageblatt.
Il ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et met les frais à charge de la société, sinon, en cas d'absence
ou d'insuffisance d'actif, à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
Me Isabelle PETRICIC-WELSCHEN
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012164621/23.
(120216925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Absolu Digital S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 8, Porte de France.
R.C.S. Luxembourg B 148.723.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 novembre 2012i>
Révocation d’un administrateur avec effet immédiat
- Monsieur Philippe PISANI
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012164663/12.
(120217802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
6089
L
U X E M B O U R G
M7 Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 148.073.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012165219/9.
(120217693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
North West Finance SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 120.193.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012165236/9.
(120217769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Normalux Maritime S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 164.707.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012165235/9.
(120217944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Pempa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.850,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 116.315.
<i>Extrait de Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 17 décembre 2012i>
L’assemblée a décidé de:
- Accepter la démission de Monsieur Martin Kasperczyk avec effet au 03 mai 2012.
- Accepter, pour une durée illimitée, la nomination d’un nouveau gérant:
Monsieur Diogo Alves, né le 14 mars 1983 à Macieira de Cambra – Vale de Cambra, Portugal, ayant son adresse
professionnelle au 412F route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012165270/15.
(120218273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Arden Delice Immo SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9665 Liefrange, 15, Burewee.
R.C.S. Luxembourg B 102.561.
Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012165257/10.
(120217806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
6090
L
U X E M B O U R G
Arden Delice Immo SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9665 Liefrange, 15, Burewee.
R.C.S. Luxembourg B 102.561.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012165258/10.
(120217851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Arden Delice Immo SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2A, rue Hannelast.
R.C.S. Luxembourg B 102.561.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012165259/10.
(120217880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Arden Delice Immo SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2A, rue Hannelast.
R.C.S. Luxembourg B 102.561.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012165260/10.
(120217908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Parkwood (Köln) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 130.973.
A noter:
- changement de domicile de l'associé Parkwood Europe LLP, 52 Brook'S Mews, W1K 4EE London, Royaume-Uni,
- changement de domicile du gérant Derek Lucie-Smith, 5
th
Floor, 17 Grosvenor Gardens, SW1W OBD London,
Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2012.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012165269/14.
(120218586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Parkstadt Hotel, Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 138.197.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 18 décembre 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012165266/11.
(120218149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
6091
L
U X E M B O U R G
Parkstadt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 131.838.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 18 décembre 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012165267/11.
(120218215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Presidio Investments, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 122.234.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012165274/10.
(120217481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Presidio Investments, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 122.234.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012165275/10.
(120217511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Parkwood (Cologne) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 125.027.
A noter le changement de domicile de l'associé Parkwood Europe LLP, 52 Brook'S Mews, W1K 4EE London, Royaume-
Uni,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2012.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012165268/12.
(120218587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Nutri-Logics S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 31, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 165.942.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012165239/10.
(120217558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
6092
L
U X E M B O U R G
Olinat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 138.302.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012165241/10.
(120218459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Novatiss S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 152.192.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012165238/10.
(120218418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Nol S.à r.l. - SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 106.388.
Les comptes annuels au 31 août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012165233/10.
(120217967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Mexbrew S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 172.854.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012165192/14.
(120218278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Neuilly (Lux) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 89.232.
Le Dépôt rectificatif du document <L120154471> pour les comptes annuels agrée au 25 Juin 2012 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 Décembre 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012165222/11.
(120218274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
6093
L
U X E M B O U R G
Natura Vita Wurst und Fleisch Handelsgesellschaft GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9944 Beiler, 1, Hasselt.
R.C.S. Luxembourg B 128.546.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012165223/10.
(120217530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Niessen Restaurants s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 103, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 146.637.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012165231/10.
(120217449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Nimax S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 90.126.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012165232/10.
(120217504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Next Step S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8612 Pratz, 3, rue Maetschent.
R.C.S. Luxembourg B 112.651.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2010i>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Gaëtan SEEL (né le 1
er
août 1979 à Liège (Belgique) et demeurant au
3, rue Maetcshent à L-8612 PRATZ) de son poste de gérant avec effet au 1
er
octobre 2010.
Pour extrait sincère et conforme
LAURENT Cédric
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2012165228/13.
(120217724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Unexpected, Association sans but lucratif.
Siège social: L-9378 Lipperscheid, route de Clervaux.
R.C.S. Luxembourg F 9.371.
STATUTS
Art. 1
er
. Dénomination, Siège et Durée. Les soussignés,
- Leweck Alphonse, indépendant, demeurant à L-9378 Lipperscheid, Hotel Leweck, de nationalité luxembourgeoise
- Nepgen Daniel, employé privé, demeurant à L-4408 Beles, rue Waassertrap, 173, de nationalité luxembourgeoise
- Hoffeld Mario, employé privé, demeurant à L-9376 Hoscheid, Haaptstrooss, 2, de nationalité luxembourgeoise
membres fondateurs, ont convenu de créer entre eux une association sans but lucratif dénommée
6094
L
U X E M B O U R G
UNEXPECTED.
Son siège social est à Lipperscheid. Il peut être transféré sur décision du conseil d'administration.
L'association est créée pour une durée illimitée.
L'association observera une stricte neutralité idéologique, politique et confessionnelle.
Art. 2. Objet. L'association a pour objet de promouvoir des activités de loisir associatives et collectives telles que des
soirées musicales a thèmes, fêtes diverses, excursions culturelles dans le pays et à l'étranger, en vue d'accroître le bien-
être physique et moral de ses membres.
Art. 3. Membres. L'association se compose d'un conseil d'administration, de membres actifs et de membres d'honneur.
Les membres peuvent être des personnes physiques ou morales.
Les membres actifs ont le droit de vote. Leur nombre est illimité, sans pouvoir être inférieur à trois. La qualité de
membre actif est attestée par le payement d'une cotisation annuelle et par l'inscription au registre tenu à cette fin. Les
premiers membres actifs sont les comparants au présent acte.
La qualité de membre d'honneur est conférée aux personnes physiques et morales qui sans prendre part aux activités
de l'association lui apporteront leur appui matériel ou moral et auront payé la cotisation annuelle. Les cotisations annuelles
sont fixées annuellement par l'assemblée générale.
Art. 4. Conseil d'Administration. Le conseil d'administration est l'organe créé par les membres actifs pour administrer
l'association. Il se compose d'un nombre impair de membres, 3 membres au moins et 7 membres au plus. Ces membres
sont choisis parmi les membres actifs et élus par l'assemblée générale ordinaire et annuelle, statuant à la majorité simple
des voix des membres actifs présents ou représentés.
L'assemblée générale déterminera également la durée de leur mandat.
Les administrateurs sont rééligibles et sont toujours révocables par l'assemblée générale.
Le conseil d'administration désignera dans son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président ou à défaut de ce dernier, par le plus âgé des
administrateurs présents.
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige. Il ne peut délibérer valablement
que si la majorité des membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
En cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Les décisions du conseil
d'administration sont consignées dans un procès-verbal.
Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de loi du 21 avril 1928.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par les présents statuts, ou par la loi, est de leur
compétence.
Art. 5. Assemblée Générale. L'assemblée générale est composée de l'assemblée des membres actifs qui peuvent s'y
faire représenter moyennant une procuration écrite par un mandataire ayant lui-même le droit de vote. Les membres
d'honneur y ont voix délibérative.
L'assemblée générale décide de l'activité générale, des buts et de l'orientation de l'association. Elle élit le conseil
d'administration et nomme les réviseurs de caisse.
L'Assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration une fois par an; elle peut se réunir extraordinai-
rement toute les fois que l'intérêt de l'association l'exige.
Les convocations sont faites par le conseil d'administration au moyen d'une simple lettre, huit jours avant l'assemblée.
Le conseil d'administration doit annexer aux convocations un ordre de jour qui prévoit tous les points sur lesquels il
sera délibéré. Des résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre de jour dans le seul cas où la majorité des
membres présents ou représentés y marqueront leur accord.
A l'ordre du jour de l'assemblée générale doit être portée l'approbation des comptes de l'exercice écoulé et du budget
prévisionnel du prochain exercice.
Après approbation des comptes, sur propositions des réviseurs de caisse, l'assemblée accorde décharge au trésorier
en exercice, ensuite elle se prononcera sur la décharge à accorder aux autres administrateurs.
Art. 6. Comptes-Budget. Les ressources de l'association se composent notamment:
- des cotisations,
- des dons et legs en sa faveur,
- des subsides et subventions,
- des réalisations faites par l'association,
- des intérêts et revenus généralement quelconques.
Cette énumération n'est pas limitative. L'association peur recevoir des libéralités entre vifs ou testamentaires con-
formément à l'article 16 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. L'année sociale commence le
premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année; exceptionnellement le premier exercice commence
6095
L
U X E M B O U R G
avec la ratification des statuts et l'assemblée générale constituante. Les comptes sont tenus et réglés par le trésorier.
Chaque mouvement devra être justifié par une pièce comptable à l'appui.
Les livres, les comptes et la caisse feront l'objet d'un contrôle par un réviseur de caisse, désigné par l'assemblée
générale. L'excédent favorable appartient à l'association. Celle-ci sera valablement engagée quant aux mouvements fi-
nanciers, par la signature du trésorier.
Art. 7. Gestion. L'association est valablement engagée par la signature individuelle du président, du sécretaire ainsi par
celle du trésorier.
Le président représente l'association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du conseil d'administration. Le
secrétaire est chargé de la rédaction des documents de l'association, des listes d'affiliation et des procès-verbaux des
assemblées générales ainsi que des réunions du conseil exécutif.
Le trésorier est chargé du recouvrement des cotisations et de la tenue de la comptabilité.
A la fin de chaque exercice, qui est la fin de l'année civile, le trésorier soumet le compte financier au conseil d'admi-
nistration qui le présentera à l'approbation de l'assemblée générale ensemble avec le budget pour l'exercice futur.
L'approbation de l'assemblée générale vaut décharge pour le secrétaire et pour le conseil d'administration.
Art. 8. Dissolution. La dissolution et la liquidation de l'association sont régies par les articles 18 à 25 de la loi du 21
avril 1928. En cas de dissolution volontaire, le conseil d'administration fera fonction de liquidateur. Après apurement du
passif, l'excédent favorable sera affecté à une association ou à une oeuvre de charité. L'assemblée la désignera à la majorité
des voix.
Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables pour tous les cas non prévus par les présents statuts.
Fait et passé en autant d'exemplaires que de parties à Lipperscheid, le 22 novembre 2012.
Alphonse Leweck / Daniel Nepgen / Mario Hoffeld.
Référence de publication: 2012159249/89.
(120209989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.
Aquarius Capital Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 137.866.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2012:i>
Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Jacques RECKINGER, demeurant à 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'adminis-
trateur;
- Monsieur Antoine CALVISI, demeurant à 15, Cité Ledenberg, L-5341 Moutfort, aux fonctions d'administrateur;
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.
L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2012165615/19.
(120219312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
6096
Absolu Digital S.A.
Aquarius Capital Development S.A.
Arden Delice Immo SA
Arden Delice Immo SA
Arden Delice Immo SA
Arden Delice Immo SA
Duplex S.A.
Encore Plus Properties II S.à.r.l.
Euro Holiday Properties S.A.
Euro Partner S.A.
GCG Manager S.A. Luxco S.C.A.
Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l.
Halliburton Luxembourg Minority S.à r.l.
Jantes Pneus Services S.à r.l.
King's Cross Asset Funding 15
Liberty Sea Trading S.à r.l.
LKT Holding S.à r.l.
M7 Group S.A.
Methanex Luxembourg S.à r.l.
Mexbrew S.à r.l.
Mobitrading S.A.
Moorgarth Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Natura Vita Wurst und Fleisch Handelsgesellschaft GmbH
Neuilly (Lux) II S.à r.l.
Next Step S.à r.l.
Nici Investments S.A.
Niessen Restaurants s.àr.l.
Nimax S.A.
Nol S.à r.l. - SPF
Normalux Maritime S.A.
North West Finance SA
Novatiss S.A.
Nutri-Logics S.A.
Olinat S.A.
Pajo S.A.
Pan European Finance Framework HRE S.à r.l.
Parkstadt Hotel
Parkstadt S.A.
Parkwood (Cologne) S.à r.l.
Parkwood (Köln) S.à r.l.
Pempa S.à r.l.
Pizzeria Peperoncino S.à r.l.
PMB Real Estate S.A.
Pocolena S.A.
Presidio Investments
Presidio Investments
Puro Group S.A.
Rheimolux Sàrl
Rockwell Collins European Holdings S.à r.l.
Rosefield Luxembourg S.A.
T6 HoldCo S.à r.l.
Trema Architecture Sàrl
Tricone Geological Consulting
True Holding 1 S.C.A.
Unexpected
Urbe Aero SA
Urbe Aero SA
Valbonne Rail S.A.
Varuna Infinity Fund
WPP Luxembourg Germany Holdings 3 S.à r.l.
Xylem Global S.à r.l.