This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2606
19 octobre 2012
SOMMAIRE
1A Gérances S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125047
Adonis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125042
Adonis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125042
A-Style S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125062
BHM & Oriental Fund SCA SICAV-SIF . .
125043
Brysam Lux (Colombia) S.à r.l. . . . . . . . . . .
125042
Bureau d'Assurances Kintzele Sàrl . . . . . . .
125043
Bureau Immobilier Goergen . . . . . . . . . . . .
125043
C2I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125050
Ceryx S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125047
Circuit Foil Service S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
125047
Coller Epee S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125047
Contel Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125046
DBP Design Build Property Holding S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125043
D'Haus vun der Natur . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125044
Digit S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125086
Exoworld Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125050
Figupar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125042
FinnAust Mining S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
125044
Identitag Secondary Opportunities S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125080
International Machinery Trading Corpora-
tion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125088
Invest Association Luxembourg S.A. . . . . .
125088
JP Immo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125085
Julienne Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
125079
Liac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125081
Lux Concept Real Estate SCI . . . . . . . . . . . .
125058
Luxindra Investment Corporation SA . . . .
125061
Meat Co Maghreb S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
125048
Mediflex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125085
Men Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125080
M&G Real Estate Finance 2 Co. S.à r.l. . . .
125062
MIB BP Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125079
Mili Malo, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125047
MMB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125079
Molko SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125084
Nei Aarbecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125086
ONC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125082
P1 Immo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125085
Parker Hannifin Europe S.à r.l. . . . . . . . . . .
125049
Rayshark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125081
RE German Office General Partners S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125049
RE German Properties General Partners S.
à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125078
RE German Small Properties General
Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125049
RE Mosse Zentrum General Partners S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125078
Risk & Reinsurance Solutions S.A. en abré-
gé "2RS" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125081
Sanderlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125065
Slif S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125082
Solvadis Holding S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
125065
Teamlog Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125065
Telenet Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
125080
The Isidor Company GmbH . . . . . . . . . . . . .
125060
Thetis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125062
THIEL Romain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125048
Transports - Déménagements «Beim Plën-
nermann S.à r.l.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125048
Transtrend Fund Alliance . . . . . . . . . . . . . . .
125066
Tyco Flow Control International Holding
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125060
Union Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125049
Union Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125062
Union Retail REIT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
125048
Venusia Real Estate Investment S.A. . . . . .
125058
125041
L
U X E M B O U R G
Adonis S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 146.986.
Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ADONIS S.A.
Régis DONATI / Jacopo ROSSI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012126769/12.
(120168318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Adonis S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 146.986.
Les comptes au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ADONIS S.A.
Régis DONATI / Jacopo ROSSI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012126770/12.
(120168319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Brysam Lux (Colombia) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 140.162.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012126800/10.
(120168323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Figupar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R.C.S. Luxembourg B 70.301.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration de la société FIGUPAR S.A qui s'est tenue à Luxembourg le 1
er
octobre 2012:
Monsieur Guy Meert, demeurant L-9671 Neunhausen, Maison 35, a démissionné de son poste comme administrateur
et administrateur-délégué en date du 30 avril 2012.
Le siège social de la société a été changé de 51, route de Thionville, L-2611 Luxembourg à 3, rue de la Loge, L-1945
Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
octobrer 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour mandat
i>TREUCONSULT SA
3, RUE DE LA LOGE
Signature
Référence de publication: 2012126910/20.
(120168250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
125042
L
U X E M B O U R G
BHM & Oriental Fund SCA SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV
- Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 163.846.
Les comptes Annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
Octobre 2012.
Référence de publication: 2012126807/11.
(120168057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Bureau d'Assurances Kintzele Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2167 Luxembourg, 141, rue des Muguets.
R.C.S. Luxembourg B 158.474.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 1
er
octobre 2012.
Référence de publication: 2012126819/10.
(120168255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Bureau Immobilier Goergen, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2342 Luxembourg, 25, rue Raymond Poincaré.
R.C.S. Luxembourg B 47.029.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2012.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012126820/12.
(120168390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
DBP Design Build Property Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 127.960.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 14 Septembre 2012, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société DBP Designi>
<i>Build Property Holding S.A.i>
- Le mandat de M. Christian BÜHLMANN en tant qu'Administrateur de la Société a été renouvelé. Son mandat se
terminera le 14 septembre 2018.
- Le mandat de M. Alexandre TASKIRAN en tant qu'Administrateur de la Société a été renouvelé. Son mandat se
terminera le 14 septembre 2018.
- Le mandat de M. Thierry TRIBOULOT en tant qu'Administrateur de la Société a été renouvelé. Son mandat se
terminera le 14 septembre 2018.
- Le mandat de TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A. en tant que Commissaire aux Comptes de la Société a été
renouvelé. Son mandat se terminera le 14 septembre 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DBP Design Build Property Holding S.A.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012126868/21.
(120168136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
125043
L
U X E M B O U R G
D'Haus vun der Natur, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg F 759.
DISSOLUTION
<i>Extrait d'une assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2012i>
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire reçue par le notaire Roger ARRENSDORFF de résidence à Lu-
xembourg en date du 13 juillet 2012, concernant la association sans but lucratif «D'Haus vun der Natur«, avec siège social
à L-1899 Kockelscheuer, route de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro F759,
que: suite à la fusion avec natur&ëmwel a.s.b.l. association sans but lucratif, ayant son siège social à L-1899, Kockelscheuer,
Kràizhaff, 5 route de Luxembourg, et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg N° F9032.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'apporter tous les actifs et passifs connus ou inconnus appartenant à l'a.s.b.l. d'Haus vun
der Natur, à natur&ëmwelt a.s.b.l. et d'avoir préalablement à l'apport acquitté le passif de l'a.s.b.l. d'Haus vun der Natur.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide la réalisation de l'apport de l'a.s.b.l. d'Haus vun der Natur dès que l'assemblée des mem-
bres de natur&ëmwelt l'aura accepté aux conditions ci-énoncées, sous condition que cette acceptation intervienne dans
les trois mois.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'approuver la conservation des documents sociaux de l'a.s.b.l. d'Haus vun der Natur
pendant le délai de 5 ans au siège social de natur&ëmwelt.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'approuver la dissolution de l'a.s.b.l. d'Haus vun der Natur avec effet au jour de l'accep-
tation de l'apport par natur&ëmwelt, sans qu'il n'y ait lieu à liquidation, tous les actifs et passifs ayant été repris par
natur&ëmwelt.
Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Signé: AENDEKERK, PISSINGER, PELTZER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2012. Relation: LAC/2012/34794. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivré aux fins de la publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 20 août 2012.
Référence de publication: 2012126862/35.
(120168178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
FinnAust Mining S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 153.801.
In the year two thousand twelve, on the nineth day of August.
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
Appeared:
The company FinnAust Mining Plc, a company organized under the laws of the United Kingdom, with registered office
at 15 Appold Street, EC2A 2HB London, United Kingdom, duly registered under number 7245568,
duly represented by Mr Carmine REHO, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be registered at the same time with the registration authorities.
The presaid FinnAust Mining Plc is the sole member (the "Sole Member") of the private limited liability company "société
à responsabilité limitée" FinnAust Mining S.à r.l. with registered office at L-2320 Luxembourg, 69 boulevard de la Pétrusse,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 153801, incorporated by a deed
received by the undersigned notary, on 2 June 2010, published in the Mémorial C number 1576 on 3 August 2010, as
125044
L
U X E M B O U R G
amended for the last time by a deed received by the undersigned notary, on 19 June 2012, not yet published in the
Mémorial C (the "Company").
Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity of sole member of the Company, has requested
the undersigned notary to state its following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Member resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred Euros
(EUR 100) so as to bring it from its present amount of thirty thousand and seven hundred Euros (EUR 30,700) to an
amount of thirty thousand and eight hundred Euros (EUR 30,800) represented by three hundred and eight (308) corporate
units, with a par value of one hundred Euros (EUR 100) each and with such rights and obligations as set out in the articles
of association of the Company, in consideration for a contribution in cash amounting to one hundred Euros (EUR 100)
together with a share premium amounting to eight hundred twenty nine thousand nine hundred Euros (EUR 829,900).
<i>Subscription and Paymenti>
Further Mr Carmine REHO, prenamed, acting in his capacity as duly appointed attorney of the Sole Member, by virtue
of a power of attorney granted under private seal,
declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Member for one (1) newly issued corporate unit, with a
par value of one hundred Euros (EUR 100) in consideration for a contribution in cash amounting to one hundred Euros
(EUR 100) together with a share premium amounting to eight hundred twenty nine thousand nine hundred Euros (EUR
829,900).
Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary by way of a bank certificate issued by
BIL Banque Internationale à Luxembourg S.A., and the undersigned notary formally acknowledges the availability of the
aggregate amount of eight hundred and thirty thousand Euros (EUR 830,000) to the Company.
<i>Second resolutioni>
The Sole Member resolves to subsequently amend Article 5, paragraph 1, of the articles of association of the Company
so as to reflect the first resolution.
Consequently, Article 5, paragraph 1, of the articles of association of the Company shall henceforth be read as follows:
"The subscribed corporate capital is set at thirty thousand and eight hundred Euros (EUR 30,800) represented by three
hundred and eight (308) corporate units with a par value of one hundred Euros (EUR 100) each."
<i>Third resolutioni>
The Sole Member resolved to grant authorization to any one manager of the Company, with single signatory power,
and/or to any lawyer of the law firm Wildgen in Luxembourg, to carry out any action in relation to or necessary to
implement or incidental to the above taken resolutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately EUR 2,200.-.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, acting as here above stated, he signed together with us, the
notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le neuvième jour du mois d’août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire, de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
La société FinnAust Mining Plc, une société régie par le droit du Royaume-Uni, ayant son siège social au 15 Appold
Street, EC2A 2HB Londres, Royaume-Uni, dûment enregistrée sous le numéro 7245568, dûment représentée par Maître
Carmine REHO, avocat, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée sous seing
privé.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne comparante et par le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée dans le même temps par les autorités en charge de l’enregistrement.
Ladite FinnAust Mining Plc est l’associé unique (l’"Associé Unique") de la société à responsabilité limitée FinnAust
Mining S.à r.l., ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153801, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 2 juin 2010, publié au Mémorial C numéro 1576 du 3 août 2010, et modifié pour la dernière
fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 19 juin 2012, en voie de publication au Mémorial C (la "Société").
125045
L
U X E M B O U R G
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, en sa qualité d’associé unique de la Société, a prié le
notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique a décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent Euros (EUR 100) pour le
porter de son montant actuel de trente mille sept cents Euros (EUR 30.700) au montant de trente mille huit cents Euros
(EUR 30.800) représenté par trois cent huit (308) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR
100) auxquelles sont attachés les droits et obligations tels que prévus dans les statuts de la Société, en contrepartie d’un
apport en numéraire d’un montant de cent Euros (EUR 100) avec une prime d’émission d’un montant de huit cent vingt-
neuf mille neuf cents Euros (EUR 829.900).
<i>Souscription et Libérationi>
Ensuite Maître Carmine Reho, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment désigné par l’Associé Unique
en vertu d’une procuration accordée sous seing privé,
a déclaré souscrire au nom et pour le compte de l’Associé Unique une (1) part sociale nouvellement émise, d’une
valeur nominale de cent Euros (EUR 100) en contrepartie d’un apport en numéraire d’un montant de cent Euros (EUR
100) ensemble avec une prime d’émission d’un montant de huit cent vingt-neuf mille neuf cents Euros (EUR 829.900).
Preuve du paiement en numéraire mentionné ci-dessus a été donnée au notaire instrumentant par un certificat bancaire
émis par la banque BIL Banque Internationale à Luxembourg S.A., et le notaire instrumentant reconnaît officiellement la
disponibilité au profit de la Société d’un montant total d’huit cent trente mille Euros (EUR 830.000).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide en conséquence de modifier l’article 5, paragraphe 1, des statuts de la Société afin de refléter
la première résolution.
Par conséquent, l’article 5, paragraphe 1, des statuts de la Société devra dorénavant être lu comme il suit:
"Le capital souscrit est fixé à trente mille huit cents Euros (EUR 30.800), représenté par trois cent huit (308) parts
sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune."
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’autoriser tout gérant de la Société, avec pouvoir de signature unique, et/ou tout avocat de
l’étude Wildgen à Luxembourg, à accomplir toute action en relation ou nécessaire à l’exécution ou accessoire aux réso-
lutions prises ci-dessus.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à 2.200,- EUR.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que sur demande de la comparante, le
présent acte est libellé en anglais suivi de la traduction française. Sur demande de la même personne, et en cas de
divergence entre la version anglaise et française du texte, la version anglaise fera foi.
Le présent acte notarié a été établi à Luxembourg en date indiquée en tête des présentes.
Après lecture à la mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, elle signa, avec le notaire le présent acte original.
Signé: Carmine REHO, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 apût 2012. Relation GRE/2012/3074. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 1 octobre 2012.
Référence de publication: 2012126898/115.
(120168483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Contel Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 110.036.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
125046
L
U X E M B O U R G
Extrait sincère et conforme
CONTEL GROUP S.A.
Signature
Référence de publication: 2012126856/12.
(120168392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Ceryx S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 118.495.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 1
er
octobre 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012126824/11.
(120168210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Circuit Foil Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle C Salzbaach.
R.C.S. Luxembourg B 94.668.
Les comptes annuels au 31-12-2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Catherine Sonnet.
Référence de publication: 2012126825/10.
(120167991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Coller Epee S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 165.001.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher.
Carlo GOEDERT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012126827/12.
(120168173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
1A Gérances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 69.229.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
ACA - Atelier Comptable & Administratif S.A.
Signature
Référence de publication: 2012127269/12.
(120168309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Mili Malo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 114.400.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
125047
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012127064/9.
(120168325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Union Retail REIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 154.411.
Les comptes annuels consolidés pour la période du 13 juillet 2010 (date d'incorporation) au 31 décembre 2011 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Union Retail REIT S.A.
i>Samantha Pepper
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012127237/13.
(120168326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Transports - Déménagements «Beim Plënnermann S.à r.l.», Société à responsabilité limitée uniperson-
nelle.
Siège social: L-4460 Soleuvre, 245, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 128.432.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
ACA - Atelier Comptable & Administratif S.A.
Signature
Référence de publication: 2012127228/13.
(120168307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
THIEL Romain, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 120, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 56.216.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
ACA - Atelier Comptable & Administratif S.A.
Signature
Référence de publication: 2012127226/12.
(120168308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Meat Co Maghreb S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 166.464.
Il résulte d’un contrat de cession de parts du 1
er
juillet 2012 que:
- Samarcande Food Investments S.A., associé unique de la société, a cédé la moitié de ses parts (250) à Foodfund
Investments Ltd., ayant son siège social au 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Buildings, 2
nd
Floor, Wickham’s Cay,
Road Town, Tortola, British Islands et enregistrée sous le «Registrar of Corporate Affairs» sous le numéro 1694182.
Par conséquent, les 500 parts sociales de la société sont réparties comme suit:
125048
L
U X E M B O U R G
- Samarcande Food Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales
- Foodfund Investment Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales
Munsbach, le 28 septembre 2012.
Référence de publication: 2012127036/16.
(120167874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
RE German Small Properties General Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 117.415.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 Septembre 2012.
RE Mosse Zentrum General Partners S.àr.l.
Mutua (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Sole Manageri>
Référence de publication: 2012127151/15.
(120168240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
RE German Office General Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 118.341.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 Septembre 2012.
RE German Office General Partners S.àr.l.
Mutua (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Sole Manageri>
Référence de publication: 2012127149/15.
(120168135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Union Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 139.115.
Je prie les actionnaires de la société d'accepter par la présente ma démission en tant qu'Administrateur de la société
UNION CONSULTING S.A. avec effet immédiat.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Christine Lecas.
Référence de publication: 2012127239/10.
(120168297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Parker Hannifin Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 155.482.
EXTRAIT
En date du 1
er
octobre 2012 l'associé unique de la Société décide;
- D'accepter la démission de Monsieur William Robert Hoelting date du 1
er
octobre 2012
- en tant que gérant de la Société.
125049
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012127095/14.
(120168186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Exoworld Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-2528 Luxembourg, 20, rue des Trévires.
R.C.S. Luxembourg B 162.715.
<i>Cession de parts sociales:i>
Après la cession de parts sociales, la composition du capital est la suivante:
- NOUKOUKOU Enopenyon Kokou: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 parts sociales
- AKOUETE Kafui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 patrs sociales
FAIT A Luxembourg, le 31/08/2012.
Signature
<i>LA GERANCEi>
Référence de publication: 2012127794/15.
(120168208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
C2I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 171.680.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the thirteenth day of August.
Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, acting on behalf of Maître
Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep the original
of the present deed.
THERE APPEARED:
1) Mrs. Nadège MORICE, born in Saint-Denis (France), on May 27, 1973, residing in F-60270 Gouvieux (France), 18,
avenue Aristide Briand, and
2) Mr. Cédric COLLET, born in Gouvieux (France), on February 25, 1972, residing in F-60270 Gouvieux (France), 18,
avenue Aristide Briand,
here represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing in Junglinster (Grand Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of two proxies given under private seal.
The said proxies signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing parties, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the
Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is "C2I S.à r.l.".
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-
pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
125050
L
U X E M B O U R G
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
The Company may also provide administrative and/or management services in GROUPE C SAS and/or any of the
subsidiaries of GROUPE C SAS.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the
articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at three million nine hundred seventy three thousand and five hundred Euro (EUR
3,973,500.-) represented by one thousand and five hundred (1,500) shares of two thousand six hundred and forty nine
Euro (EUR 2,649.-) each.
When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting
are not applicable.
The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share
is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usu-
fructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third
parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the
corporate capital.
The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the
general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse.
If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.
125051
L
U X E M B O U R G
Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.
The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of
the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their re-
muneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.
In case the number of shareholders exceeds twenty five (25), the supervision of the company must be entrusted to
one or more supervisory auditor(s).
Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or
several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).
The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting
of shareholders or by the board of managers.
The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be re-appointed.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.
Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions
and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital,
but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons
the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
125052
L
U X E M B O U R G
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing parties, duly represented, declare to subscribe
all the one thousand and five hundred (1,500) shares with a nominal value of two thousand six hundred and forty nine
Euro (EUR 2,649.-) each as follows:
- one hundred and thirty four (134) shares are subscribed by Mrs. Nadège MORICE, pre-named, and are fully paid up
by the latter by contribution in kind of one hundred and thirty four (134) shares, representing eight percent (8 %) of the
capital of "GROUPE C", a simplified joint-stock company incorporated and existing under the laws of France, registered
with the "RCS Compiègne 445 068 984", having its registered office at F-60230 Chambly, De l'Oise R Becquerel ZAC
des Portes, valued at three hundred eighty seven thousand three hundred and four Euro and sixty nine Cent (EUR
387,304.69); three hundred fifty four thousand nine hundred and sixty six Euro (EUR 354,966.-) representing the capital,
thirty two thousand two hundred and sixty six Euro and forty one Cent (EUR 32,266.41) representing the cash adjustment
and seventy two Euro and twenty nine Cent (EUR 72.29) representing the share premium to be allocated to a share
premium account in accordance with the attached valuation report;
- and one thousand three hundred and sixty six (1,366) shares are subscribed by Mr. Cédric COLLET, pre-named, and
are fully paid up by the latter by contribution in kind of one thousand three hundred and sixty six (1,366) shares held by
him, representing eighty seven percent (87 %) of the capital of "GROUPE C", pre-named, valued at three million nine
hundred forty eight thousand one hundred and ninety five Euro and sixty two Cent (EUR 3,948,195.62); three million six
hundred eighteen thousand five hundred and thirty four Euro (EUR 3,618,534.-) representing the capital, three hundred
twenty eight thousand nine hundred and twenty four Euro and seventy four Cent (EUR 328,924.74) representing the cash
adjustment and seven hundred and thirty six Euro and eighty eight Cent (EUR 736.88) representing the share premium
to be allocated to a share premium account in accordance with the attached valuation report.
A valuation report has been drawn-up by the managers of the private limited company "C2I S.à r.l.", pre-named, wherein
the contribution in kind of the shares of the company "GROUPE C", pre-named, has been valued.
The report, after having been signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary, will be annexed to the
present deed for the purpose of registration.
The subscribers are represented by Mr. Alain THILL, pre-named.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at three thousand one hundred Euro.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the company, the shareholders representing the entire corporate capital have
taken the following resolutions unanimously:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as manager of the category A and managers of the category B for an unlimited
duration:
<i>Manager of the category A:i>
- Mr. Cédric COLLET, born in Gouvieux (France), on February 25, 1972, residing in F-60270 Gouvieux (France), 18,
avenue Aristide Briand.
<i>Managers of the category B:i>
- Mr. Xavier SOULARD, company director, born in Châteauroux (France), on August 14, 1980, residing professionally
in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, and
- Mr. Sébastien ANDRE, company director, born in Metz (France), on October 29, 1974, residing professionally in
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
125053
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing parties, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,
he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
Le treize août.
Pardevant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rempla-
cement de son collègue empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.
ONT COMPARU:
1) Madame Nadège MORICE, née à Saint-Denis (France), le 27 mai 1973, demeurant à F-60270 Gouvieux (France),
18, avenue Aristide Briand, et
2) Monsieur Cédric COLLET, né à Gouvieux (France), le 25 février 1972, demeurant à F-60270 Gouvieux (France),
18, avenue Aristide Briand,
représentés par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu de deux procurations sous seing privé.
Les prédites procurations, signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Les comparants, représentés par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, ont requis le notaire instrumentaire de docu-
menter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "C2I S.à r.l.".
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
La société pourra également fournir des services administratifs et/ou de gestion dans la société GROUPE C SAS et/
ou dans une des filiales de GROUPE C SAS.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
125054
L
U X E M B O U R G
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à trois millions neuf cent soixante-treize mille cinq cents Euros (EUR 3.973.500,-),
représenté par mille cinq cents (1.500) parts sociales de deux mille six cent quarante-neuf Euro (EUR 2.649,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés
sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité
des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera
valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la
signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
125055
L
U X E M B O U R G
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,
qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte, en raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés
de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq (25), la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs
commissaire(s).
Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs
réviseurs d'entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).
Les réviseurs d'entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale,
soit par le conseil de gérance.
Les réviseurs d'entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.
Les commissaires et les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être réélus.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, dûment représentés, déclarent souscrire à toutes les
mille cinq cents (1.500) parts sociales d'une valeur nominale deux mille six cent quarante-neuf Euros (EUR 2.649,-) chacune
comme suit:
- cent trente-quatre (134) actions sont souscrites par Madame Nadège MORICE, pré-nommée, et sont intégralement
libérées par cette dernière par un apport en nature de cent trente-quatre (134) actions, représentant huit pour cent (8%)
du capital de GROUPE C, une société par actions simplifiées constituée et existant sous les lois françaises, enregistrée
125056
L
U X E M B O U R G
auprès du RCS Compiègne 445 068 984, avec siège à F-60230 Chambly, De l'Oise R Becquerel ZAC des Portes, évalué
à trois cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre Euros et soixante-neuf Cents (EUR 387.304,69); trois cent cinquante-
quatre mille neuf cent soixante-six Euros (EUR 354.966,-) représentant le capital, trente-deux mille deux cent soixante-
six Euros et quarante et un Cent (EUR 32.266,41) représentant la soulte et soixante-douze Euros et vingt-neuf Cents
(EUR 72,29) représentant la prime d'émission à affecter au compte prime d'émission et conformément au certificat
d'évaluation annexe;
- et mille trois cent soixante-six (1.366) actions sont souscrites par Monsieur Cédric COLLET, pré-nommé, et sont
intégralement libérées par ce dernier par un apport en nature de mille trois cent soixante-six (1.366) actions représentant
quatre-vingt-sept pour cent (87%) du capital de "GROUPE C", pré-nommée, évalué à trois millions neuf cent quarante-
huit mille cent quatre-vingt-quinze Euros et soixante-deux Cents (EUR 3.948.195,62); trois millions six cent dix-huit mille
cinq cent trente-quatre Euros (EUR 3.618.534,-) représentant le capital, trois cent vingt-huit mille neuf cent vingt-quatre
Euros et soixante-quatorze Cents (EUR 328.924,74) représentant la soulte et sept cent trente-six Euros et quatre-vingt-
huit Cents (EUR 736,88) représentant la prime d'émission à affecter au compte prime d'émission et conformément au
certificat d'évaluation annexe.
Un rapport d'évaluation a été émis par la gérance de la société à responsabilité limitée "C2I S.à r.l.", par lequel l'apport
en nature des actions de la société "GROUPE C", pré-nommée, a été évalué.
Le rapport, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent
acte et sera soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les souscripteurs sont représentés par Monsieur Alain THILL, pré-nommé.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de trois mille cent Euros.
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la société, les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les
résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérant de catégorie A et gérant de catégorie B pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Monsieur Cédric COLLET, né à Gouvieux (France), le 25 février 1972, demeurant à F-60270 Gouvieux (France), 18,
avenue Aristide Briand.
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et
- Monsieur Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant pro-
fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande des comparants, le
présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes comparants et en cas
de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par ses nom, prénom, état civil et
domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2012. Relation GRE/2012/3108. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 2 octobre 2012.
Référence de publication: 2012127953/412.
(120169356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2012.
125057
L
U X E M B O U R G
Venusia Real Estate Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 96.585.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Internationale SA
Référence de publication: 2012127256/10.
(120168294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Lux Concept Real Estate SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg E 4.885.
STATUTS
L'an deux mil douze, le premier octobre.
Ont comparu:
1. Nabil KADRI né le 24/08/1966 à El Harrach (Algérie) de nationalité française, demeurant 27 Grand rue 57365 Flévy
France;
2. Mounia BADIS KADRI née le 26/11/1976 à Oran (Algérie) de nationalité française demeurant 27 Grand rue 57365
Flévy France 57365 France.
Les comparants ont requis de dresser acte de constitution d'une société civile immobilière qu'ils déclarent avoir arrêté
entre eux comme suit:
Titre I
er
. Dénomination - Objet - Durée - Siège
Art. 1
er
. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination LUX CONCEPT REAL
ESTATE SCI
Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la vente, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de
plusieurs immeubles en-dehors de toute opération commerciale.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège de la société est établi à 70 Grand-rue L-1660 Luxembourg.
Titre II. - Capital - Apports - Parts
Art. 5. Le capital est fixé à deux mille (2000) euros, divisé en vingt (20) parts sociales de 100 euros chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants:
1. Nabil KADRI pour dix parts sociales (15)
2. Mounia BADIS KADRI pour trois parts sociales (5)
Total des parts sociales: vingt (20)
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
En cas de cession projetée de parts sociales entre vifs par un associé à un non-associé, les nom, prénom, profession
et adresse du cessionnaire potentiel non-associé sont, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception,
communiqués par le cédant ou le cessionnaire au(x) gérant(s).
En cas de dévolution de parts sociales pour cause de mort de leur propriétaire à un non-associé (à l'exception toutefois
des descendants en ligne directe ou du conjoint survivant), les associés obligent d'ores et déjà irrévocablement leurs
héritiers et ayants-cause généralement quelconques à les offrir aux associés survivants - par l'intermédiaire du(des) gérant
(s) - endéans les six (6) mois de leur décès par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Tant que cette rétrocession n'aura pas été faite, le droit de vote aux assemblées générales des parts sociales concernées
est suspendu et, si l'associé décédé était gérant, il ne sera pas pourvu à son remplacement de sorte que la société pourra
temporairement être engagée par le (les) gérant(s) survivant(s).
Dans les deux hypothèses, le(s) gérant(s) continuera(ont) cette information aux associés restants respectivement
survivants endéans un (1) mois, également par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Les parts peuvent être reprises par les associés restants respectivement survivants dans le mois de la susdite infor-
mation. Ils y ont droit en proportion de leur participation dans la société.
Chaque associé peut cependant céder son droit de reprise à un autre associé.
125058
L
U X E M B O U R G
Le prix de cession est celui dont question infra, ce que tous les associés acceptent dès à présent expressément tant
pour eux mêmes que pour leurs héritiers et ayants-cause généralement quelconques.
Si les associés restants respectivement survivants laissent passer le susdit délai, sans exercer leur droit de préférence,
le cédant est libre de céder les parts sociales à l'amateur non-associé dont question ci-dessus, respectivement l'héritier
peut garder les parts recueillies dans la succession de l'associé décédé.
Le prix de reprise des parts sociales est fixé sur base de la valeur vénale de l'actif net au 31 décembre de l'année
précédant la susdite information des associés sans prise en compte des bénéfices éventuels de l'année en cours. Cette
valeur sera fixée de commun accord des parties. En cas de désaccord, chaque partie nommera un expert qui désigneront
ensemble un troisième expert. Le collège d'experts arrêtera forfaitairement et sans droit de recours le prix de vente des
parts sociales, dans les six mois de la désignation des experts.
Le prix de cession sera payable, dans le mois de l'accord intervenu entre parties à ce sujet respectivement de sa fixation
par le susdit collège d'experts, sans intérêts jusque-là et ensuite avec les intérêts à un taux supérieur de deux unités au
taux d'intérêt légal jusqu'à solde.
Art. 7. Tant dans leurs rapports respectifs que vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes
de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il détient.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, le gérant doit, sauf accord contraire et
unanime des associés, sous sa responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une
action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite
que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.
Titre III. Administration
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) par les associés à la majorité des voix. Le
ou les gérant(s) a ou ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire et autoriser tous actes et
opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.
La société est engagée à l'égard de tiers par la signature du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par leur signature
conjointe.
Art. 9. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
Art. 10. Le vote des délibérations des associés, sur tous les points, y comprises les modifications statutaires, est
déterminé par la majorité des trois-quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à
une voix.
Art. 11. L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur la convocation du
(des) gérant(s) ou sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l'ordre du jour.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé et du (des) gérant
(s).
Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation, sera faite par les associés à moins que l'assemblée n'en décide autrement.
Titre V. Dispositions générales
Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par
la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé
par les présents statuts.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approxi-
mativement à la somme de
<i>Désignationi>
Et aussitôt, les associés se sont réunis en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués
et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à un
2) Est nommé gérant: Nabil KADRI
3) La durée de sa fonctions est illimitée.
4) Le siège social est fixé à 70 Grand-rue L-1660 Luxembourg
125059
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et
de l'infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées
à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte.
Signatures.
Référence de publication: 2012128494/103.
(120168553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
The Isidor Company GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 86.268.
Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Me Nicolas SCHAEFFER
Par mandat
Référence de publication: 2012127224/12.
(120168292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Tyco Flow Control International Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 17.000,15.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 166.277.
En date du 28 septembre 2012, l'associé unique de la Société a pris acte de la démission des personnes suivantes de
leurs fonctions de gérant de la Société, avec effet au 28 septembre 2012 à 15H00:
- Madeleine Barber
- Mirza Dautbegovic
- Joe Mandala
En date du 28 septembre 2012, l'associé unique de la Société a pris acte de la démission de Madame Andrea Goodrich
et Monsieur Peter Schieser de leurs fonctions de gérant et de délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet au
28 septembre 2012 à 15H00.
En outre, l'associé unique a décidé de nommer:
- Monsieur Mark Charles Borin, ayant comme adresse professionnelle 6425 Ranier Lane North, Maple Grove, MN 55
311, Etats-Unis d'Amérique, comme gérant de la Société, avec effet au 28 septembre 2012-15 H00 pour une durée
indéterminée;
- Monsieur Yves Defraigne, ayant comme adresse professionnelle Regus Center, 26 boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, comme gérant de la Société, avec effet au 28 septembre 2012 — 15 H00 pour une durée indéterminée;
- Monsieur Michael Gerald Meyer, ayant comme adresse professionnelle 5500 Wayzata Boulevard, Suite 800, Min-
neapolis, MN 55416-1261, Etats-Unis d'Amérique, comme gérant de la Société, avec effet au 28 septembre 2012-15 H00
pour une durée indéterminée; et
- Monsieur Christopher Rush Oster, ayant comme adresse professionnelle 76 Sussex Square, London W2 255, Roy-
aume-Uni, comme gérant de la Société, avec effet au 28 septembre 2012 - 15 H00 pour une durée indéterminée.
En conséquence de quoi, le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mark Charles Borin;
- Yves Defraigne;
- Michael Gerald Meyer; et
- Christopher Rush Oster.
125060
L
U X E M B O U R G
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Tyco Flow Control International Holding S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012127218/36.
(120168190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Luxindra Investment Corporation SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 50.776.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze, le vingt-cinq septembre;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
A COMPARU:
Mademoiselle Christine STUMPERT, employée privé, demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, 128,
boulevard de la Pétrusse,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame Christina HORNE demeurant à B-1060 Bruxelles, 5, rue du
Fort, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 août 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société anonyme LUXINDRA INVESTMENT CORPORATION, établie et ayant son siège social à L-2330
Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 50776, a été constituée suivant acte de Maître Frank MOLITOR, notaire alors de résidence à Mondorf-
les-Bains, en date du 5 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 337 du 24 juillet
1995;
- que la comparante est la seule et unique propriétaire des actions;
- que la comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société (l'"Actionnaire Unique"), a décidé de procéder à
la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation,
- que l'Actionnaire Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 20 août 2012,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'Actionnaire Unique est investi de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du
passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 20 août 2012 étant seulement
un des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de
leurs mandats;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au moins à l'ancien
siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ neuf cent cinquante euros (950,- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par
son nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. STUMPERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 septembre 2012. LAC/2012/44877. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
125061
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 2 octobre 2012.
Référence de publication: 2012128196/50.
(120169507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2012.
Union Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 139.115.
Je prie les actionnaires de la société d'accepter par la présente ma démission en tant qu'Administrateur et Adminis-
trateur-délégué de la société UNION CONSULTING S.A. avec effet immédiat.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
François Georges.
Référence de publication: 2012127238/10.
(120168297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Thetis S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 99.365.
Par la présente, je vous informe de ma démission de la fonction d'administrateur au sein de votre société, avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Alain Driancourt.
Référence de publication: 2012127225/10.
(120168073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
A-Style S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 41, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 170.737.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de A-Style S.A. tenue à Marner le 19 septembre 2012i>
L'assemblée générale décide de prendre acte de la démission de Monsieur Nunzio Scarpa de son poste d'administrateur
de la Société avec effet immédiat.
L'assemblée générale décide de nommer Madame Audrey Scarpa, employée privée, demeurant au 37, route d'Arlon,
L-8211 Mamer, en tant que nouvel administrateur pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des
actionnaires qui se tiendra en 2016.
<i>Pour A-Style S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012127786/15.
(120168206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
M&G Real Estate Finance 2 Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 171.314.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth day of September.
Before the undersigned Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
M&G Real Estate Debt Fund II LP, a Guernsey limited partnership having its registered office at 3rd Floor, NatWest
Tower, Le Truchot, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1WD, recorded with the Guernsey Registry under number 1736,
in its capacity as sole shareholder of M&G Real Estate Finance 2 Co. S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée), having its registered office at 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 171.314 and incorpo-
rated by a deed drawn up by the notary Maître Jean Seckler, pre-named, on 31 August 2012 and whose articles of
association (the "Articles") in the process of being published in the Mémorial C, Journal Officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"),
here represented by Mr Jean-Paul Schmit, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given in Guernsey on 20 September 2012.
125062
L
U X E M B O U R G
Said proxy, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of the
appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
M&G Real Estate Debt Fund II LP is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of the Company;
The Company's share capital is presently fixed at twelve thousand five hundred Pound sterling (GBP 12,500.-) repre-
sented by twelve million five hundred thousand (12,500,000) shares with a par value of one thousandth Pound sterling
(GBP 0.001) each.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the Company’s share capital by an amount of nineteen thousand six hundred
and twenty Pound Sterling and six hundred and ninety-three thousandth (GBP 19,620.693) in order to raise it from its
current amount of twelve thousand five hundred Pound Sterling (GBP 12,500.-) represented by twelve million five hundred
thousand (12,500,000) shares in registered form with a par value of one thousandth Pound Sterling (GBP 0.001) each to
thirty-two thousand one hundred and twenty Pound Sterling and six hundred and ninety-three thousand (GBP
32,120.693), represented by thirty-two million one hundred and twenty thousand six hundred and ninety-three
(32,120,693) shares, through the issue of nineteen million six hundred and twenty thousand six hundred and ninety-three
(19,620,693) shares having a par value of one thousandth Pound Sterling (GBP 0.001) each.
The nineteen million six hundred and twenty thousand six hundred and ninety-three (19,620,693) new shares are
subscribed by the Sole Shareholder at a total price of nineteen million six hundred and twenty thousand six hundred and
ninety-three (19,620,693) out of which:
nineteen thousand six hundred and twenty Pound Sterling and six hundred and ninety-three thousandth (£ 19,620.693)
are allocated to the share capital, and
nineteen million six hundred and one thousand and seventy-two Pound Sterling and three hundred and seven thousands
(£ 19,601,072.307) are allocated to the share premium.
The nineteen million six hundred and twenty thousand six hundred and ninety-three (19,620,693) shares are fully paid
up in cash by the Sole Shareholder, so that the total amount of nineteen million six hundred and twenty thousand six
hundred and ninety-three Pound Sterling (GBP 19,620,693) is at the free disposal of the Company, as it has been shown
to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so that
it shall henceforth read as follows:
" Art. 5.1. The Company's share capital is set at thirty-two thousand one hundred and twenty Pound Sterling and six
hundred and ninety-three thousandth (GBP 32,120.693), represented by thirty-two million one hundred and twenty
thousand six hundred and ninety-three (32,120,693) shares having a par value of one thousandth Pound Sterling (GBP
0.001) each."
The rest of article 5 and the articles of incorporation of the Company remain unchanged.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the shares' register of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company acting individually with full power of substitution to
proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the shares' register of the Company.
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be
borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
six thousand five hundred euro (EUR 6,500.00).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English
version and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxy holder acting on behalf of the appearing parties, the proxy holder signed
together with the notary the present original deed.
125063
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-quatrième jour du mois de septembre.
Par devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
M&G Real Estate Debt Fund II LP, un Guernsey limited partnership ayant son siège social au 3e étage, NatWest Tower,
Le Truchot, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1WD, immatriculé au Guernsey Registry sous le numéro 1736,
en sa capacité d'associé unique de M&G Real Estate Finance 2 Co. , une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social au 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 171.314, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler en date du 31 août
2012, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n'ont pas été modifiés
depuis (ci-après la "Société").
ici représenté par M. Jean-Paul Schmit, salarié, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-duché de Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 20 septembre 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire soussigné et le mandataire agissant pour le compte
de la partie comparante, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
M&G Real Estate Debt Fund II LP est l'associé unique (l'«Associé Unique») de la Société;
Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12,500.-), représenté
par douze millions cinq cent mille (12.500.000) parts sociales, d'une valeur nominale d’un millième de livres sterling (GBP
0,001) chacune.
Sur ceci, la partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-neuf mille six cent vingt livres sterling et
six cent quatre-vingt-treize millièmes (GBP 19.620,693) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents
livres sterling (GBP 12.500,-) représenté par douze millions cinq cent mille (12.500.000) parts sociales, jusqu'à trente-
deux mille cent vingt livres sterling six cent quatre-vingt-treize millièmes (GBP 32.120,693) représentés par trente-deux
millions cent vingt mille six cent quatre-vingt-treize (32.120.693) parts sociales par l'émission de dix-neuf millions six cent
vingt mille six cent quatre-vingt-treize (19.620.693) parts sociales d'une valeur nominale d'un millième de livres sterling
(GBP 0,001) chacune.
Les dix-neuf millions six cent vingt mille six cent quatre-vingt-treize (19.620.693) nouvelles parts sociales sont sou-
scrites par l'Associée Unique représentée comme indiqué ci-dessus, pour un montant de dix-neuf millions six cent vingt
mille six cent quatre-vingt-treize livres sterling (GBP 1.620.693) dont:
Dix-neuf mille six cent vingt livres sterling et six cent quatre-vingt-treize (GBP 19.620,693) sont alloués au capital social;
et
Dix-neuf millions six cent un mille soixante-douze livres sterling et trois cent sept millièmes (GBP 19.601.072,307)
sont alloués à la prime d'émission.
Les dix-neuf millions six cent vingt mille six cent quatre-vingt-treize (19.620.693) nouvelles parts sociales ainsi sou-
scrites sont entièrement libérées en numéraire par l'Associée Unique, de sorte que le montant total de dix-neuf millions
six cent vingt mille six cent quatre-vingt-treize livres sterling (GBP 19.620.693,-) est à la libre disposition de la Société tel
qu'il a été démontré au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Associée Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société pour lui
donner désormais la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à la somme de trente-deux mille cent vingt livres sterling six cent quatre-
vingt-treize millièmes (GBP 32.120,693) représentés par trente-deux millions cent vingt mille six cent quatre-vingt-treize
(32.120.693) parts sociales, d'une valeur nominale d’un millième de livres sterling (GBP 0,001) chacune."
Le reste de l’article 5 et des statuts de la Société demeure inchangé.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant total des frais, charges, rémunérations ou dépenses, sous toute forme qu'ils soient, qui incombent à la
Société ou qui seront facturés à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à six mille cinq
cents euros (EUR 6.500,-).
125064
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une version française.
En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête du présent acte.
Le document ayant été lu au mandataire agissant pour le compte de la partie comparante, le mandataire a signé le
présent acte original avec le notaire.
Signé: Schmit, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 septembre 2012. Relation: LAC/2012/44791. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Référence de publication: 2012128203/137.
(120168691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2012.
Teamlog Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 140.476.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2012.
Référence de publication: 2012127204/11.
(120168287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Solvadis Holding S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.067.800,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 111.081.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 septembre 2012.
Référence de publication: 2012127193/12.
(120168284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Sanderlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 61.718.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 27i>
<i>septembre 2012i>
Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur HEITZ Jean-Marc et Monsieur ANIASI Luca sont renommés administra-
teurs.
Monsieur DE BERNARDI Alexis est nommé Président du Conseil d'administration.
Monsieur VEGAS-PIERONI Louis est renommé commissaire aux comptes.
Les nouveaux mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.
125065
L
U X E M B O U R G
Pour extrait sincère et conforme
SANDERLUX S.A.
Jean-Marc HEITZ
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012127175/18.
(120168171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Transtrend Fund Alliance, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 97.101.
In the year two thousand and twelve, on the on the seventeen of September,
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Transtrend Fund Alliance", a société d'investisse-
ment à capital variable with registered office at 5 allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the
"Company"), incorporated following a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, dated November 4
th
2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated
December 18
th
2003 number 1346 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 97101.
The meeting is opened at 10 a.m.,
and Mrs Laetitia Boeuf, residing professionally in Luxembourg is elected chairman of the meeting.
Mrs Christelle Vaudémont, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.
The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Céline Parmentier, residing professionally in Luxembourg, is ap-
pointed to assume the role of secretary.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II.- It appears from the attendance list, that out of 858,385.8215 shares in circulation, 307,715.4506 shares are present
or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of
the agenda.
III.- That all the Shareholders, after a first meeting on ninth August, 2012, by reason of not having the fulfilled the
quorum requirements, have been duly reconvened by notices containing the agenda published in Memorial, Tageblatt and
Luxemburger Wort on August 17, 2012 and September 1, 2012.
IV.- That consequently the present extraordinary general meeting is regularly constituted and has legal power to act
on the following agenda.
<i>Agenda:i>
1. Amendment and restatement of the Articles of Incorporation in the form filed with and approved by the Commission
de Surveillance du Secteur Financier, in the form attached hereto.
2. Miscellaneous.
<i>Sole resolutioni>
The meeting decides to amend and restate the Articles of Incorporation of Transtrend Fund Alliance which will be
read in the form attached hereto:
"ARTICLES OF INCORPORATIONS
Heading I. Denomination - Registered office - Period - Object
Art. 1. Denomination. There exists among the shareholders ("Shareholders"), a company in the form of a "société
anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of Transtrend Fund Alliance (the
"Company").
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy
of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board
of directors (the "Board" or "Board of Directors", and each director, a "Director").
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, military, economic or social deve-
lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
125066
L
U X E M B O U R G
rarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall
have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg company.
Art. 3. Period. The Company is established for an indefinite period. The Company may be dissolved by a resolution
of the Shareholders adopted at any time in the manner required for amendment of these articles of incorporation (the
"Articles").
Art. 4. Object. The object of the Company is to invest the funds available to it in derivatives, such as futures, option,
option on futures, swap, swap on futures, and forward contracts (collectively, "Financial Instruments"), with the purpose
of achieving long-term capital appreciation while attempting to control risks, thus affording its Shareholders the results
of the management of its portfolio. The Company may also invest in transferable securities and financial instruments of
any kind, in any other instruments representing rights of ownership, claims or transferable securities and in cash.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by part II of the Luxembourg law of 17 December 2010
regarding Undertakings for Collective Investment (the "Law of 2010").
Heading II. Capital - Shares - Net Asset Value
Art. 5. Capital - Sub-Funds, Shares and Classes. The capital of the Company shall be represented by shares of no par
value fully paid up (the "Shares") and shall at any time be equal to the total value of the net assets of the Company as
defined in Article 11 hereof.
The minimum capital of the Company may not be less than one million two hundred fifty thousand euro (EUR
1,250,000).
The Shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes (each a "Class") in a number of sub-
funds of the Company (each a "Sub-Fund"). The Company shall establish segregated opposable accounts each constituting
a Sub-Fund within the meaning of article 181 of the Law of 2010 and the proceeds of the issue of the relating Class or
Classes shall be invested, pursuant to Article 4 hereof, in such assets and instruments as the Board of Directors shall
from time to time determine in respect of the relating Sub-Fund and in respect of the specific assets and liabilities com-
plement of each Class, as described in the selling documents. The Board of Directors may create at any moment additional
Classes and Sub-Funds.
The Board of Directors may decide to apply for listing of the Shares of a Class or Sub-Fund on any stock exchange.
The Board of Directors shall establish each Sub-Fund or Class for an unlimited or limited duration. For limited duration
Sub-Funds or Classes, the Board of Directors shall extend the duration for one or more periods, if the general meeting
of Shareholders (the "General Meeting") of the Sub-Fund or Class concerned decides accordingly at the quorum and the
majority of votes required for a modification of these Articles. On the expiring date of a Sub-Fund or a Class with limited
duration, the Company shall redeem all outstanding Shares of such Sub-Fund or Class in accordance with Article 8 hereof.
Shareholders shall be informed in writing. Selling documents of each Sub-Fund or Class shall indicate the duration of such
Sub-Fund or Class and their extension, if any.
The initial capital of the Company amounts to fifty thousand euro (EUR 50,000), represented by fifty (50) Shares of
one thousand euro (EUR 1,000) with no par value and fully paid.
The annual accounts of the Company, including all Sub-Funds' accounts, shall be expressed in EUR, which is the refe-
rence currency (the "Reference Currency") of the Company.
When Sub-Funds' accounts are not expressed in EUR, such accounts are translated into EUR and added together with
the accounts of the Sub-Funds expressed in EUR for the purposes of establishing the annual accounts of the Company.
Art. 6. Form of Shares. With respect to each Class, the Company shall issue Shares in registered form. The Board
shall determine whether Shareholders can elect to obtain Share certificates; else, Shareholders will receive instead a
confirmation of their shareholding. If a Shareholder desires that more than one Share certificate be issued for his Shares,
if so allowed, the cost of such additional certificates may be charged to such Shareholder.
Each Share can be available as institutional Share ("Institutional Share") or as ordinary Share ("Ordinary Share"), as
determined by the Board and specified in the selling documents. Institutional Shares may be only owned by institutional
investors ("Institutional Investors") who qualify as such according to the guidelines and recommendations issued by the
Luxembourg supervisory authorities. Ordinary Shares may be owned by all types of investors.
Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and after receipt of the subscription monies. The
subscriber will, without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the subscription monies by the
Company, receive title to the Shares purchased by him and upon application obtain delivery of definitive Share certificates
or a confirmation of his shareholding.
Payments of dividends will be made to Shareholders to a bank account in their own name or, only if not in breach with
any law, rule, regulation, order or directive applicable to the Company's business, in the name of designated third parties.
All issued Shares shall be written down in the register of Shareholders, which shall be kept by the Company or by one
or more persons designated for that purpose by the Company. Such register shall contain for each Shareholder, in case
125067
L
U X E M B O U R G
of an individual, at least his name, his nationality, his residence or elected domicile and the number of Shares held by him,
and in case of an entity, at least its statutory name, its jurisdiction of incorporation, its principal or registered address
and the number of Shares held by it. Every transfer of a Share shall be entered in the register of Shareholders.
Transfer of Shares shall be effected (a) if Share certificates have been issued, upon delivering the certificate(s) repre-
senting such Shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company, and (b), if no
Share certificates have been issued, by written declaration of transfer to be inscribed in the register of Shareholders,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.
The Company may also recognise any other evidence of transfer satisfactory to it.
Every Shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the
Company may be sent. Such address will be entered in the register of Shareholders and may be changed by the Shareholder
at any time by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may
be set by the Company from time to time.
Provided the Company issues Share fractions of the Class concerned, if payment made by any subscriber results in the
issue of a Share fraction, the person entitled to such fraction shall not be entitled to vote on that fraction but shall, to
the extent the Company shall determine as to the calculation of fractions, be entitled to dividends and to all other actions
on a pro rata basis.
If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid or destroyed,
then, at his request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including a bond
delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Company may determine. At the issuance of
the new Share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate in place of which
the new one has been issued shall become void.
Mutilated Share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The mutilated certificates shall
be delivered to the Company and shall be annulled immediately.
The Company may, at its election, charge the Shareholder for the costs of a duplicate or of a new Share certificate
and all reasonable expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in
connection with the annulment of the old Share certificate.
Art. 7. Issue of Shares. Within each Class, the Board of Directors is authorised without limitation to issue further
Shares to be fully paid at any time, generally without reserving to the existing Shareholders a preferential right to sub-
scription of the Shares to be issued.
When the Company issues Shares for subscription, the price per Share at which such Shares are offered and sold,
unless otherwise indicated in the selling documents, shall be based on the net asset value ("Net Asset Value") as hereinafter
defined for the relevant Class, taking the investor's performance fee deficit or credit related to his investment in such
Class resulting from equalisation (the "Equalisation Adjustment") into account, if applicable, and net of such sales fee as
the selling documents may provide. The price so determined shall be payable within a period from the relevant date of
valuation of the net assets of the Class (the "Valuation Day"), as described in the selling documents.
The Board of Directors may also accept subscriptions whereby the payment of subscription monies is made by means
of the transfer of an existing portfolio, as provided for in the Luxembourg law of 10 August 1915 (the "Law of 1915") as
amended, subject that all investments of this portfolio comply with the investment objectives and restrictions of the
relevant Sub-Fund. Such a portfolio must be easy to evaluate. A valuation report, the cost of which is to be borne by the
relevant investor, will be drawn up by the auditor, appointed pursuant to Article 22, according to article 26-1 (2) of the
Law of 1915 and will be filed at the registered office of the Company.
The Board of Directors may lay down restrictions on the frequency of issuance of Shares of a Class. In particular, the
Board of Directors may decide to issue Shares of a Class during one or more subscription periods or according to another
periodicity as provided for in the selling documents. Shares shall be issued only upon acceptance of the application and
after subscription monies have been received by the Company. The Board of Directors may subject subscriptions to any
further restrictions it considers fit and suitable.
The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company or to any other duly
authorised person, the duty of accepting subscriptions, receiving subscription monies and issuing new Shares relating
thereto.
Art. 8. Redemptions. The Board of Directors has the authority at any time, for efficient management purposes, to have
the Company redeem Shares of a Class closed to Shareholders' redemption requests, at a price determined hereafter.
As regards a limited duration Class, the Board of Directors will in principle have the Company redeem the Shares of
that Class on the last Valuation Day of the period determined in the selling documents, at a price based on the Net Asset
Value determined on that day, taking the Shareholder's Equalisation Adjustment into account, if applicable, and in principle
without redemption fee, as specified in the selling documents. The redemption proceeds shall normally be paid no later
than ten (10) Luxembourg business days ("Business Days") after such Valuation Day. The Class will then be dissolved,
unless the Board of Directors, on the occasion of an extraordinary general meeting of Shareholders of the Class to be
held in principle one (1) month before the last Valuation Day of the period, makes an offer to the General Meeting of
the Class concerned for the continuation and/or the restructuring of the Class, possibly under slightly different terms
125068
L
U X E M B O U R G
and conditions, and the General Meeting of the Class approves such an offer with the quorum and the majority of votes
as is required for a modification of the Articles. In any case, the right of the Shareholders to obtain redemption of their
Shares on the Valuation Day in principle without redemption fee shall remain fully preserved, whatever the resolution
taken at such extraordinary general meeting of Shareholders of the Class concerned.
Shareholders may not request the Company to redeem their Shares, unless the Board of Directors resolves to grant
such right to such Class Shareholders, according to such terms and conditions, as specified in the selling documents.
When Shareholders have redemption rights the following provisions apply.
The redemption proceeds shall normally be paid not later than ten (10) Business Days after the redemption day
("Redemption Day") concerned. The redemption price shall be based on the Net Asset Value of the relevant Shares, as
determined at the Redemption Day concerned and in accordance with the provisions of Article 11 hereof, less a charge
at the rate provided by the selling documents and also taking the Shareholder's Equalisation Adjustment into account, if
applicable. The relevant redemption price may be rounded upward or downward as the Board of Directors may decide.
Any redemption request must be filed by such Shareholder in written form at the registered office of the Company or
at any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of Shares and shall be accompanied
by the certificate(s) for such Shares in proper form (if issued) and by proper evidence of transfer or assignment (if
applicable).
In the event of suspension of the determination of the Net Asset Value pursuant to Article 12 hereof, if a redemption
request has not been revoked following the suspension, redemption will occur as of the first Redemption Day following
the lifting of the suspension. Shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.
No redemption by a single Shareholder may, unless otherwise decided by the Board of Directors, be for an amount of
less than that of the minimum redemption amount for the relevant Class as determined from time to time by the Board
of Directors and as specified in the selling documents, unless the Board of Directors agrees on the contrary.
If a redemption of Shares would reduce the value of the holdings of a single Shareholder of Shares of one Class below
the minimum holding as the Board of Directors shall determine for such Class from time to time and as specified in the
selling documents, then such Shareholder shall be deemed to have requested the redemption, as the case may be, of all
his Shares of such Class, unless the Board agrees on the contrary.
Further, if on any Valuation Day conversion requests pursuant to Article 9 and redemption requests pursuant to this
Article on aggregate exceed a determined ceiling of the number of Shares in issue of a specific Class or Sub-Fund, the
Board of Directors may decide that part or all of such requests for redemption and conversion will be deferred for a
period and in a manner that the Board of Directors considers to be in the best interests of the Company, such a period
in principle not exceeding three (3) Redemption Days. On the applicable Redemption Day following that period, these
redemption and conversion requests will be dealt with in a manner that the Board of Directors considers to be in the
best interest of the Company and its Shareholders. Any redemption and conversion request may again be subject to the
ceiling, if the Board of Directors considers that the implementation of all redemption and conversion requests on such
Redemption Day would adversely affect or prejudice the interests of the Company.
Under special circumstances affecting the interests of the Company, the Board of Directors may in turn delay a
proportionate part of the payment to Shareholders requesting redemption of Shares. The right to obtain redemption is
contingent upon the corresponding Sub-Fund having sufficient liquid assets to honour redemptions requests. The Com-
pany may also defer payment of the redemption of a Class if raising funds to pay such redemption would, in the opinion
of the Board of Directors, be unduly burdensome to the corresponding Sub-Fund. The payment may be deferred until
the special circumstances have ceased; the redemption price will be based on the then prevailing Net Asset Value, taking
the Shareholder's Equalisation Adjustment into account, if applicable, and taking into account any redemption fee provided
in the selling documents, if applicable.
The Board of Directors may proceed to a compulsory redemption of all outstanding Shares of a specific Class or Sub-
Fund, if so authorised by a simple majority of the Shares present or represented and voting at a general meeting of
Shareholders of such Class or Sub-Fund, in any event that the Board of Directors thinks it necessary for the best interest
of the Shareholders and the Company. The Board of Directors may also proceed to such compulsory redemption, without
authorisation, in case the net assets of a specific Class or Sub-Fund fall below the amount determined for the relevant
Class or Sub-Fund in the selling documents, upon thirty (30) days notice to the Shareholders concerned, or in other cases
as provided for in the selling documents.
The Board of Directors may subject redemptions to any restrictions it considers fit and suitable; in particular, the
Board of Directors may decide that Shares are not redeemable during a determined period, as specified in the selling
documents.
Art. 9. Conversion of Shares. Shareholders are not authorised to convert Shares of one Class into Shares of another
Class, unless the Board of Directors resolves to grant such right to Shareholders of such Class(es) under the terms and
conditions provided for in the selling documents.
When Shareholders have conversion right, the following provisions apply taking into account the terms and conditions
provided for in the selling documents. The conversion price shall be derived from the respective Net Asset Value of both
Classes concerned, determined on the same or subsequent Valuation Day, taking the Shareholder's Equalisation Adjust-
ment(s) on both sides into account, if applicable, as defined in Article 11 hereafter, and, if necessary, taking into account
125069
L
U X E M B O U R G
the applicable exchange rate between the currencies of quotation (the "Dealing Currencies") of the Classes concerned.
If a conversion of Shares would reduce the value of the holdings of a single Shareholder of Shares of one Class below the
minimum holding applicable to such Class as the Board of Directors shall determine from time to time, then such Sha-
reholder could be requested to convert all his Shares of the Class concerned. The Shares of the Class switched out of
shall be cancelled. The provisions applicable to redemptions pursuant to Article 8 apply mutatis mutandis to conversions.
Art. 10. Restrictions on acquisition, Holding and Ownership of Shares. The Board of Directors may restrict or prevent
the acquisition, holding or ownership of Shares by any person, firm, corporate body or other entity, alone or in conjunction
with anyone else, (a) if in the judgement of the Board of Directors such acquisition, holding or ownership may be detri-
mental to the Company, any of its agents or the majority of its Shareholders or any Sub-Fund or Class, or (b) if it may
result in a breach of any law, rule, regulation or other requirement, whether Luxembourgish or foreign, or (c) if as a
result thereof it may have adverse regulatory, tax or legal consequences for the Company or any of its agents and/or its
service providers, in particular if as a result thereof the Company or any of its agents and/or service providers would
become subject to laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg (including but without limitation tax laws).
Such person, firm, corporate body or other entity who is prevented or restricted to acquire, hold or own Shares due to
restrictions imposed by the Board of Directors is hereinafter being referred to as a "Prohibited Person".
For such purposes the Board of Directors may:
(i) decline to issue any Shares and decline to register any transfer of a Share, where it appears to it that such issuance
or registry of transfer would or might result in the acquisition, holding or ownership of such Shares by a Prohibited
Person; and
(ii) at any time, whenever it thinks necessary, require a Shareholder, or anyone seeking to register the transfer of
Shares in the register of Shareholders, to furnish it with any information, supported by an affidavit, which it may consider
necessary for the purpose of determining whether or not the acquisition, holding or ownership of such Shareholder's
Shares rests or will rest in a Prohibited Person; and
(iii) decline to accept the vote by or on behalf of any Prohibited Person, holding or owning Shares, at any general
meeting of Shareholders; and
(iv) where it appears to the Board of Directors that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any
other person is a holder or an owner of Shares, direct such Prohibited Person, and if required such other person acting
in conjunction with such Prohibited Person in this respect, to validly transfer the holding or ownership of the relevant
Shares, whatever is the case, to a person not being a Prohibited Person and to provide to the Board of Directors evidence
of such transfer within a period determined by the Board. If the Board has decided to not give such a direction, or such
Prohibited Person and/or such other person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect fail(s) to
comply with the direction, the Board may compulsorily redeem or cause to be redeemed all Shares held or owned by
such Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person in the following manner:
(1) The Board shall serve a notice (the "Compulsory Redemption Notice") upon the Prohibited Person and if required
any other person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect holding such Shares or appearing in
the register of Shareholders as the owner(s) of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to be redeemed as
aforesaid, the date of redemption, the manner in which the price to be paid for such Shares will be calculated, and the
place at which the redemption proceeds in respect of such Shares are payable. Any such notice may be served upon such
Prohibited Person and if required any other person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect by
posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such Prohibited Person and if required any other person
acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect at his/their last address known to or appearing in the
register of Shareholders. The said Prohibited Person and if required any other person acting in conjunction with such
Prohibited Person in this respect shall thereupon forthwith be obliged to deliver promptly to the Company the Share
certificate(s) representing the Shares specified in the Compulsory Redemption Notice. Immediately as of the close of
business on the date specified in the Compulsory Redemption Notice, such Prohibited Person and if required any other
person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect shall cease to be the holder(s) or owner(s) of
the Shares specified in such notice, and his/their name(s) shall be removed from the register of Shareholders.
(2) The price at which the Shares specified in a Compulsory Redemption Notice will be redeemed (the "Compulsory
Redemption Price") shall be the redemption price as defined in Article 8 hereof, less any redemption fee provided for in
the selling documents and less any extraordinary expenses incurred by the Company in relation to the compulsory
redemption.
(3) Payment of the Compulsory Redemption Price will be made available to the former Shareholder of such Shares
normally in the Dealing Currency of the Class concerned and will be deposited for payment to such former Shareholder
by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere as specified in the Compulsory Redemption Notice, upon final
determination of the Compulsory Redemption Price, following, if applicable, surrender of the Share certificate(s) specified
in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the Compulsory Redemption Notice
as aforesaid such former Shareholder shall have no further interest in such Shares or any of them, nor any claim against
the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the Compulsory Redemption Price (without
interest) from such bank following, if applicable, effective surrender of the Share certificate(s) as aforesaid. Any funds
receivable by a former Shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five (5) years from the date
125070
L
U X E M B O U R G
specified in the Compulsory Redemption Notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the Sub-Fund that
comprises the relevant Class or Classes. The Board of Directors shall have the power from time to time to take all steps
necessary to perfect such reversion and to authorise such action on behalf of the Company.
(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Compulsory Redemption Notice, provided
that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.
U.S. Persons (as hereinafter defined) constitute a specific category of Prohibited Persons. The Sub-Funds are not open
to investment by U.S. Persons. Where it appears to the Board that any Shareholder is a U.S. Person, who either alone
or in conjunction with any other person is a holder or an owner of Shares, the Board may compulsorily redeem or cause
to be redeemed all Shares held or owned by such Prohibited Person, and if applicable by such other person acting in
conjunction with such Prohibited Person in this respect, without delay.
For the purpose of these Articles, the term "U.S." or "United States" means the United States of America, its states,
districts, territories or possessions or an enclave of the United States government, its agencies or instrumentalities. The
term "U.S. Person" means a citizen or resident of the U.S., a corporation, partnership or other entity created or organised
in the U.S. or under U.S. laws, or any person falling within the definition of the term U.S. Person under Regulation S
promulgated under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or under Rule 4.7 under the U.S. Commodity Exchange
Act, as amended.
Art. 11. Net Asset Value calculation.
1. Valuation.
For the purpose of determining the issue, conversion, and redemption price thereof, the Net Asset Value of Shares
in each Sub-Fund shall be determined by the Company or its delegate from time to time, but in principle not less than
once a month, as the Board of Directors may decide.
The Net Asset Value of each Sub-Fund will be expressed in the Reference Currency of the Sub-Fund concerned, and
will be determined on each Valuation Day by deducting total liabilities attributable to a Sub-Fund from total assets attri-
butable to such Sub-Fund.
When the Sub-Fund is comprised of one Class, the Net Asset Value per Share of the Class will be expressed in the
Reference Currency of the Sub-Fund and will be determined on each Valuation Day by dividing the net assets attributable
to the Sub-Fund by the number of Shares of the Class then outstanding and by rounding the resulting sum per Share to
the nearest lowest (current) sub-division of the currency concerned.
When the Sub-Fund is comprised of different Classes, the Net Asset Value of each Class will be valued in the Reference
Currency of the Sub-Fund and determined according to the provisions mentioned hereon, taking into account the specific
assets and liabilities attributable to each Class. If the Dealing Currency of a Class is different from the Reference Currency
of the corresponding Sub-Fund, the net assets of the Sub-Fund attributable to that Class valued in the Reference Currency
of the Sub-Fund will be converted into and expressed in the Dealing Currency of the Class concerned.
The Net Asset Value per Share of a Class in a Sub-Fund with multiple Classes will be expressed in the Dealing Currency
of the Class concerned and will be determined on each Valuation Day by dividing the total Net Asset Value of that Class
on that Valuation Day by the total number of Shares of that Class then outstanding and by rounding the resulting sum
per Share to the nearest lowest (current) sub-division of the currency concerned.
On each occasion when a dividend is declared payable, the Net Asset Value of the Shares which are entitled to such
dividend shall be reduced in line with the amount of the dividend.
If since the close of business of the relevant Valuation Day there has been a material change in the quotations on the
markets on which a substantial portion of the investments of the Sub-Fund is dealt or quoted, the Company may in order
to safeguard the interest of Shareholders and the Sub-Fund, cancel the first valuation and carry out a second valuation.
All subscription, conversion and redemption applications without any exception will be processed at the price of this
second valuation.
The determination of the net assets of each Sub-Fund will normally occur at the latest within a specific number of
Business Days following the relevant Valuation Day, as provided in the selling document.
The assets attributable to a Sub-Fund shall be deemed to include: (1) all cash in hand or on deposit, including accrued
interest; (2) all accounts receivable on demand and any amounts due to the Sub-Fund (including the yet uncollected
proceeds of Financial Instruments positions which have been closed out); (3) the net equity in all Financial Instruments
positions and any other investments; (4) all accrued interest on any interest bearing accounts held by the Company on
behalf of the Sub-Fund except to the extent that such interest is comprised in the principal thereof; (5) the prepaid
expenses as far as these have not been written off or reimbursed; and (6) all other assets of any kind and nature attributable
to the Sub-Fund.
The valuation of the assets will be made as follows:
a. the value of any cash on hand or on deposit and accounts receivable, prepaid expenses and interest declared or
accrued and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless the same is unlikely to be paid or
125071
L
U X E M B O U R G
received in full, in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount as the Company may consider
appropriate in such case to reflect the fair value of the asset;
b. the liquidating value of Financial Instruments not traded on exchanges shall mean their liquidating value determined,
pursuant to policies established by the Board, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The
liquidating value of Financial Instruments traded on exchanges shall normally be based upon the settlement prices esta-
blished on the exchanges on which the particular Financial Instruments are traded by the Sub-Fund; provided that if a
contract could not be liquidated on the Valuation Day, the basis for determining the liquidating value of such contract
shall be such value as the Board may deem fair and reasonable;
c. the value of assets which are quoted or dealt in on any exchange shall normally be based, except as defined in (e)
below, on the last available price on the exchange on which the trade in such assets occurred or on that which is normally
the principal market for such assets;
d. investments dealt in on another organised market are valued in a manner as near as is reasonably possible to that
described in the preceding paragraph; and
e. in the event that any of the assets on the Valuation Day are not quoted or dealt in on any exchange or other organised
market or if, with respect to any asset quoted or dealt in on any exchange or dealt in on another organised market, the
price as determined pursuant to the preceding paragraphs is not, in the opinion of the Board of Directors, representative
of the fair market value of the relevant asset, the value of such asset will be determined prudently and in good faith on
the basis of the estimated settlement or sales price, in line with logical and customary points of reference in other markets.
The valuation of the assets shall be based on information (including without limitation, position reports, confirmation
statements, recap ledgers, etc.) which is available at the time of such valuation with respect to all positions in portfolio
and accrued interest income, accrued management, performance and service fees, and accrued brokerage commissions
and other trading costs.
The Board of Directors may rely upon confirmation from the Company's clearing brokers and counterparties (col-
lectively, the "Clearing Brokers"), the Custodian (as defined in Article 28), the banks of the Company and their affiliates
in determining the value of assets held for the Sub-Funds. The Sub-Funds' income and expenses (including fees but ex-
cluding organisational expenses not yet charged) will normally be determined on an accrual basis.
The liabilities attributable to a Sub-Fund shall be deemed to include: (1) all loans and accounts payable; (2) all known
liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or property, including
the amount of any unpaid dividends declared by the Company with respect to the Sub-Fund concerned; (3) an appropriate
provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day and any other provisions or reserves au-
thorised and approved by the Board of Directors; and (4) all other liabilities of whatsoever kind and nature comprising,
without limitation, formation expenses, fees payable to its brokers or Trading Adviser, as defined in Article 19, accoun-
tants, custodians, domiciliary, registrar, transfer and paying agents and permanent representatives in places of registration,
any other agent, officer or delegate employed by the Company, fees for legal and auditing services, promotional, printing,
reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of the selling documents of
the Company, explanatory memoranda or registration statements, the cost of translating such documents in such lan-
guages as deemed appropriate, reasonable marketing expenses in connection with the offering of Shares, the cost of
obtaining and maintaining a listing on a stock exchange, all taxes or governmental charges, all other operating expenses
including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, insurance, postage, telephone, telefax
and telex, and all extraordinary expenses not incurred in the ordinary course of business including litigation and indem-
nification expenses, taking reimbursements by third parties into account. The Company may calculate in respect of each
Sub-Fund, administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure of yearly or other
periods in advance and may accrue the same in suitable proportions over any such period.
The Board of Directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if they consider that
such valuation better reflects the fair value of any asset or liability.
As far as possible, all investments and disinvestments decided upon until the Valuation Day will be included in the Net
Asset Value calculations.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, any Net Asset Value determined by the Company shall
be final and binding on the Sub-Funds, third parties and present, past and future Shareholders. The valuation will not be
audited or adjusted without good reason.
2. Allocation of assets and liabilities and of income and expenses
The Board shall establish a separate pool of assets and liabilities, income and expenses for each Sub-Fund. Such pool
shall be attributed only to the Sub-Fund concerned.
Pools of assets and liabilities, income and expenses of Sub-Funds are kept in segregated accounts, unless otherwise
specifically disclosed in the selling documents, and shall be established in the following manner:
a. the proceeds from the issue of Shares of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Company to the pool
of assets established for that Sub-Fund, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall
be applied to such Sub-Fund subject to the provisions of this chapter;
125072
L
U X E M B O U R G
b. where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same Sub-Fund as the assets from which it is derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant Sub-Fund;
c. where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated
to the relevant Sub-Fund, and the creditors' recourse with respect of such a liability or of such an action, notwithstanding
anything to the contrary contained herein or in any other agreement or instrument with respect to such liability or such
an action, shall be limited solely to the assets of the relevant Sub-Fund which constitute, form and are the assets of the
relevant Sub-Fund and the creditor shall have no recourse for the satisfaction of such a liability or of such an action against
any attorney-in-fact acting on behalf of the Company, any other Sub-Fund, or any Shareholder, Director, officer, employee,
agent, service provider, representative or affiliate of the Company. Pursuant to article 181 of the Law of 2010, the
Company constitutes a single legal entity. However, each Sub-Fund corresponds to a distinct part of the assets and
liabilities of the Company;
d. in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
Sub-Fund, such asset or liability shall be allocated between the relevant Sub-Funds on an equitable basis pro rata to their
number or to their respective net assets; and
e. in addition, upon the record date of assets and/or liabilities attributed to a specific Class according to its specific
management complement, the Net Asset Value of such Class shall be adapted accordingly by taking into account such
attributed assets and/or liabilities.
Assets allocated to an account at the Clearing Brokers, Custodian, banks or other financial intermediary may comprise
assets of different Sub-Funds, only if and to the extent specifically provided in the selling documents. In such event each
Sub-Fund will have a pro rata entitlement to the assets comprised in such account. The pro rata entitlements will be
calculated at each Valuation Day and will vary with allocations and withdrawals made on behalf of each Sub-Fund, and
with changes in the exchange rates of the Reference Currency of each Sub-Fund involved relative to the Reference
Currencies of other Sub-Funds involved.
All income and realised gains or losses and changes in valuation of open positions attributable to each Sub-Fund shall
accrue to such Sub-Fund and all expenses and liabilities related to a particular Sub-Fund and any redemption of the Shares
related thereto shall be charged to and paid from the assets attributable to the relevant Sub-Fund. Thus, the Shareholders
of any Sub-Fund will not have any interest in any assets of the Company other than the assets attributable to the Sub-
Fund in which they are invested.
Pursuant to article 181 of the Law of 2010, the Company constitutes a single legal entity. Each Sub-Fund corresponds
to a distinct part of the assets and liabilities of the Company. The rights of Shareholders and creditors concerning a Sub-
Fund or which have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of a Sub-Fund are limited to the assets
of that Sub-Fund. The assets of a Sub-Fund are exclusively available to satisfy the rights of Shareholders in relation to that
Sub-Fund and the rights of those creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or
liquidation of that Sub-Fund. For the purpose of the relation between Shareholders, each Sub-Fund will be deemed to be
a separate entity. Therefore, the Net Asset Value of its Shares fluctuates according to the net assets to which they relate.
For the purposes of this Article:
a. Shares in respect of which application of subscription has been accepted but payment of the subscription monies
has not yet been received, shall be deemed to be existing as of the close of business on the Valuation Day on which they
have been allotted and the price therefore, until received by the Sub-Fund, shall be deemed an asset of the respective
Sub-Fund;
b. Shares of the Sub-Fund to be redeemed under Article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account
until immediately as of the close of business on the Valuation Day referred to in this Article, and from such time and until
paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the respective Sub-Fund;
c. all investments, cash balances and other assets of the Sub-Fund not expressed in the currency in which the Net
Asset Value of any Class of such Sub-Fund is denominated, shall be converted in that currency after taking into account
the market rate or rates of exchange prevailing at the relevant Valuation Day; and
d. effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of financial instruments contracted for by the
Sub-Fund on such Valuation Day, to the extent practicable.
Art. 12. Suspension of the Net Asset Value determination. The Board of Directors may suspend the determination of
the Net Asset Value and the issue, redemption and conversion of Shares of a Sub-Fund if caused by any of the items under
(a) through (e) below:
a. any period when any of the principal exchanges or other markets on which a substantial portion of the assets of the
Company attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary
holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended;
b. the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposals or a valuation of
assets owned by the Company attributable to such Sub-Fund cannot be made normally or without seriously prejudicing
the interests of the Shareholders;
125073
L
U X E M B O U R G
c. any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price or value
of any of the assets attributable to such Sub-Fund or the current price or values on any exchange in respect of the assets
attributable to such Sub-Fund;
d. any period when the Company is unable to repatriate funds for the purposes of making payments on the redemption
of the Shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of invest-
ments or payments due on redemption of Shares cannot in the opinion of the Board of Directors be effected at normal
rates of exchange; or
e. upon the publication of a notice convening a general meeting of Shareholders for the purpose of resolving dissolution
of the Company, a liquidation of a Sub-Fund or a compulsory redemption of all outstanding Shares of a Sub-Fund or, in
cases where any such action does not require approval of the General Meeting of the Company or of the respective Sub-
Fund, upon the publication of a notice to the Shareholders for the purpose of notifying them of such action.
Any such suspension shall be notified to investors requesting issue, redemption or conversion of Shares by the Com-
pany at the time of application, or, if the resolution to suspend occurs after application but before an issue, redemption
or conversion of Shares has been effectuated, upon the resolution to suspend. In the event of a suspension the Board of
Directors may determine another Valuation Day which will be announced in the same publication. The publication will
also be sent to the Shareholders.
Heading III. Management and Audit
Art. 13. The Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than
three members; members of the Board of Directors need not be Shareholders.
The Directors shall be elected by the General Meeting of the Company at the annual general meeting of Shareholders
for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a
Director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by means of a resolution adopted by the
General Meeting of the Company at a general meeting of Shareholders.
The Directors, whose names are specified on the meeting agenda for the annual general meeting of Shareholders for
the purposes of being proposed as Directors, are elected by the General Meeting of the Company at the majority of the
Shares present or represented and voting. The Directors, whose names are not proposed in the agenda, are elected by
the General Meeting of the Company at the majority votes of the outstanding Shares.
In the event of a vacancy in the office of director, the remaining Directors may elect, by a three-fifth (3/5) majority of
the Directors present or represented and voting at such meeting of the Board of Directors, a Director to fill for the time
being such vacancy until the next annual general meeting of Shareholders.
Art. 14. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors may choose from among its members a chairman
(the "Chairman", which will also refer to his duly appointed proxy), and may choose from among its members one or
more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who does not need to be a Director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.
The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors. If the Chairman is not present, the Board of
Directors may appoint another Director as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented and
voting at any such meeting. The Board of Directors from time to time may appoint officers of the Company, including a
general manager, and any assistant general managers, assistant secretaries, advisory committees or other officers consi-
dered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time
by the Board of Directors. Officers need not be Directors or Shareholders. The officers appointed, unless otherwise
stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given to them by the Board of Directors.
The Board of Directors shall meet upon written notice by the Chairman, or by two Directors, to all Directors at least
five (5) days in advance of the hour set for such meeting. Such notice shall also set forth the place for the meeting. The
notice requirements may be waived by the consent in writing or by e-mail or fax of each Director. Separate notice shall
not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Directors. In circumstances of emergency, any Director may convene a meeting of the Board of Directors
without delay by notice by any means, specifying the emergency circumstances.
Any Director may have himself represented at a meeting of the Board of Directors by appointing in writing, duly signed,
another Director as his proxy. A Director duly appointed as proxy, may represent only one other Director at a meeting.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company
by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if more than three-fifth (3/5) of the Directors is present or
represented and voting at a meeting of the Board of Directors. Resolutions shall be taken by a majority of the Directors
present or represented and voting at such meeting.
In the event that in any meeting of the Board of Directors the number of votes for and against a resolution are equal,
the Chairman will have a casting vote.
125074
L
U X E M B O U R G
Circular resolutions may also be passed by the Board of Directors, provided all Directors, by affixing their signature
to the wording of the written resolution on one or several similar documents, have hereby consented to the passing of
such circular resolution.
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its
powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to one or more Directors or officers of
the Company or to other contracting parties, as set forth in Article 17 hereafter.
Art. 15. Board of Directors' powers. The Board of Directors has the widest powers to carry out all acts of management
or of disposition that shall interest the Company, subject to the investment policy provided for in Article 18 hereafter.
All powers not expressly reserved for the General Meeting by law or by these Articles are intra vires the Board of
Directors.
Art. 16. Joint signature. The Company will be bound by the joint signature of at least two Directors or by the joint or
individual signature of any person(s) to whom signatory authority has been delegated by the Board of Directors.
Art. 17. Delegation of powers. In compliance with article 60 of the Law of 1915 the Board of Directors may delegate
its powers of the daily management of the Company, as well as the representation of the Company with respect to
management, either to one or more Directors (whereby the Chairman may always replace one Director in such Director's
absence), or to one or more individuals, which may not necessarily be Directors, or legal entity or entities, and which
may, upon approval of the Board, sub-delegate his/their duties. The Board of Directors may give also special powers of
attorney under private or authentic form.
The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the affairs of the Sub-Funds and specific tasks to
committees consisting of persons involved in the management of the Sub-Funds other than Directors. Any committee so
formed shall, according to the powers so delegated, manage the Sub-Fund concerned, implement the investment policy
of the Sub-Fund concerned, be responsible for monitoring the compliance of the investments with these Articles and the
selling documents and be responsible for monitoring the marketing policy of the Sub-Fund concerned. Any committee
so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulation which may from time to time be
imposed by the Board of Directors.
Art. 18. Investment policy. The Board of Directors shall have power to determine, based upon the principle of risk
control, the investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, the
Sub-Funds and their relating Classes, as well as any restrictions which shall from time to time be applicable to the in-
vestments of the Sub-Funds and their related Classes, in compliance with applicable laws.
Art. 19. Trading Adviser. The Board of Directors has appointed by means of an advisory agreement Transtrend B.V.,
a Dutch limited liability company, as the core investment adviser (the "Trading Adviser") to the Company, who shall supply
the Company with recommendation and advice with respect to the Company's investment policy pursuant to Article 18
hereof. In the event of termination of said agreement in any manner whatsoever, the Company shall change its name and
the name(s) of its Sub-Fund(s) forthwith upon the request of the Trading Adviser to a name not resembling the one
specified in Article 1 hereof.
Art. 20. Directors' opposing interest. No contract or other transaction between the Company and any other corpo-
ration or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company
is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any Director or officer
of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any corporation or firm with which the
Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation
or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other
business.
In the event that any Director or officer of the Company may have an opposing interest in a transaction of the Company,
such Director or officer shall make known to the Board of Directors such opposing interest and shall not consider or
vote on any such transaction, and such transaction and such Director's or officer's interest therein shall be reported to
the General Meeting of the Company at the next succeeding general meeting of Shareholders.
The term "opposing interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving the Trading Adviser, the central administration agent, the Custodian, the
Clearing Brokers or a bank of the Company, any subsidiary or affiliate thereof or such other company or entity as may
from time to time be determined by the Board of Directors at its discretion.
Art. 21. Indemnification. The Company shall indemnify, protect and hold harmless any Director or officer of the
Company (each, an "Indemnitee") against losses, claims, damages, liabilities, costs and expenses (including, without limi-
tation, attorneys' and accountants' fees and disbursements), reasonably incurred by the Indemnitee in connection with
any action, suit or proceeding to which the Indemnitee may be a party,by reason of the Indemnitee being or having been
a Director or officer of the Company or, at the Company's request, of any other corporation of which the Company is
a shareholder or creditor and from which the Indemnitee is not entitled to similar indemnification (each, a "Proceeding").
Indemnification by the Company shall not apply if in a Proceeding the relevant judge(s) or arbitrator(s) shall have finally
125075
L
U X E M B O U R G
ruled against the Indemnitee, or in relation to matters as to which the Indemnitee shall be finally adjudged in such Pro-
ceeding to be liable for gross negligence, willful misconduct, fraud or any other wrongful act. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Com-
pany is advised by counsel that the Indemnitee did not commit gross negligence, willful misconduct, fraud or any other
wrongful act. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the Indemnitee may be entitled.
Any indemnification obtained by the Indemnitee other than from the Company shall reduce to such extent the indem-
nification of the Company under this Article 21.
Art. 22. Audit of the Company. The Company shall appoint an authorised auditor who shall carry out the duties
prescribed by the Law of 2010.
Heading IV. General Meeting - Accounting year - Dividends and Reserves
Art. 23. Representation. The General Meeting of the Company shall represent the entire body of Shareholders. Its
resolutions shall be binding upon all the Shareholders regardless of the Class held by them. It shall have the broadest
powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
However, if the resolutions only concern the particular rights or duties of the Shareholders of one Class or if the
possibility exists of a conflict of interest between different Classes, such resolutions are to be taken by the General
Meeting of such Class(es).
Art. 24. General Meetings. The Board of Directors has the authority to call any general meeting of Shareholders. The
Board of Directors must call the general meeting upon written request, specifying the agenda, emanating from Sharehol-
ders representing at least one-fifth (V5) of the capital.
The annual general meeting of Shareholders is held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office of
the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the second Thursday
of May at 10.00 a.m. If such day is not a Business Day, the annual general meeting of Shareholders shall be held on the
next following Business Day.
Other general meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
The Chairman shall preside at all general meetings of Shareholders. If the Chairman is not present, the General Meeting
of the Company, the Sub-Fund or the Class, as the case may be, may appoint another Director or any other person as
chairman pro tempore by vote of the majority present or represented and voting at any such meeting. The Chairman,
or, in his absence, the chairman pro tempore, may choose a secretary who shall be responsible for keeping the minutes
of the general meeting.
Notices of all general meetings of Shareholders shall be sent by registered mail at least eight (8) days prior to the
meeting to each Shareholder at the Shareholder's address in the register of Shareholders. Such notices include the agenda
and specify the time and place of the meeting, the conditions for admission and refer to the requirements of applicable
Luxembourg law with regard to the necessary quorum and majorities required for the meeting. The convening notice for
the annual general meeting will be accompanied by a copy of the Company's audited annual report, or this notice will
indicate the place where and how such report may be obtained by Shareholders free of charge.
The Board of Directors may determine all conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to attend and
vote in any meeting of Shareholders.
If all Shareholders in a general meeting are present or represented and consider themselves duly convened and infor-
med of the agenda set forth for that meeting, such a meeting may take place without notice.
The General Meeting of the Company, Sub-Fund or Class may duly resolve only on the points set forth in the agenda
and on business incidental to such points. When the agenda provides for a director's election, the director's name,
proposed to be elected, shall be specified in the agenda. Resolutions passed by the General Meeting of the Company are
binding for all Shareholders, irrespective of the Class to which their Shares belong. Matters of interest to one Class will
require the vote of the holders of the Shares of the Class concerned, subject to the provisions of Article 31 hereof.
Each amendment to the Articles entailing a variation of rights of the Shareholders of a Class must be approved by a
resolution of the General Meeting of the Company and by a resolution of the General Meeting of the Class concerned.
Art. 25. Quorum and Majority conditions. The quorum required by law shall govern the conduct of the General Meeting
of the Company, Sub-Fund or Class, as the case may be, unless otherwise provided herein.
Each Share of whatever Sub-Fund and regardless of the Net Asset Value per Share within its Class, is entitled to one
vote, subject to the restrictions contained in these Articles. A Shareholder may act at any general meeting of Shareholders
by giving a written proxy to another person, who does not need to be a Shareholder but can not be a Prohibited Person.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a general meeting of Shareholders
duly convened will be passed by simple majority of Shares present or represented and voting.
Art. 26. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
of January of each year and shall
end on the 31
st
of December of the same year.
125076
L
U X E M B O U R G
Art. 27. Dividends. With respect to each Class, the General Meeting of each Class shall, upon the proposal of the
Board of Directors in respect of such Class, determine how the annual results of such Class shall be disposed of.
Any resolution as to the dividend payable on Shares of a Class shall be subject only to the vote of the General Meeting
of that Class; in this case, each Class is entitled to distribute the maximum dividend authorised by Luxembourg law.
With respect to each Class, the Board of Directors may decide to pay interim dividends in accordance with the law.
Payments of dividends will be made to Shareholders to a bank account in their own name or, only if not in breach with
any law, rule, regulation, order or directive applicable to the Company's business, in the name of designated third parties.
The Board of Directors may pay the dividends in such currency and at such time and place that it shall determine from
time to time.
Heading V. Final provisions
Art. 28. Custodian. To the extent provided for by the Law of 2010, the Company shall enter into a custodian agreement
with a bank (the "Custodian") which shall satisfy the requirements of the Law of 2010. All Financial Instruments, cash and
other assets of the Company are to be held by or to the order of the Custodian, who shall assume towards the Company
and its Shareholders the responsibilities provided by law.
In the event of the Custodian desiring to terminate the custodian agreement, the Board of Directors shall use its best
endeavours to find a successor custodian within two (2) months. The Board of Directors may terminate the appointment
of the Custodian, but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian has been appointed to act
in the place thereof.
Art. 29. Dissolution - Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting of the
Company adopted at any time in the manner required for an amendment in the Articles.
If the net assets of the Company fall below two-third (2/3) of the minimum capital, the Board of Directors is required
by law to submit the question of dissolution of the Company to the General Meeting for which no quorum shall be
prescribed and which shall decide by a simple majority of Shares present or represented and voting at the general meeting.
If the net assets of the Company fall below one-fourth (VV) of the minimum capital, the Board of Directors must
submit the question of the dissolution of the Company to the General Meeting for which no quorum shall be prescribed;
dissolution may be resolved by Shareholders holding one-fourth (V) of the Shares at the general meeting.
The general meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) days as from the ascertainment
that the net assets have fallen below two-third (2/3) or one-fourth (VV) of the minimum capital, as the case may be.
The liquidation procedure provided for in Article 30 shall apply.
A Sub-Fund or Class may be liquidated by a resolution of its Shareholders adopted at any time in the manner required
for an amendment in the Articles.
The Board of Directors may also proceed, without authorisation, to the liquidation of a Sub-Fund or Class, if the
existence of such Sub-Fund or Class or the holding or owning of its Shares by certain investors would, in the opinion of
the Board of Directors, place the Company or any of its agents and/or service providers in breach of an applicable law,
a regulation or requirement of any jurisdiction, otherwise adversely affect or prejudice the tax status, residence or good
standing of the Company or any of its agents and/or service providers or otherwise cause the Company or any of its
agents to suffer material financial, legal or any other disadvantage.
In accordance with Article 8, the Board of Directors may, under certain circumstances, proceed to a compulsory
redemption of all Shares of a specific Sub-Fund or Class outstanding, which will in principle result in the Sub-Fund or Class
being liquidated, unless otherwise decided by the Board.
Each Sub-Fund or Class may be liquidated separately, i.e. the liquidation of one Sub-Fund or Class shall not by itself
mean that other Sub-Funds or Classes will have to be liquidated as well. Only the liquidation of the last remaining Sub-
Fund shall lead to dissolution of the Company within the meaning of article 145 of the Law of 2010.
At the discretion of the Board, the General Meeting of two or more Sub-Funds or Classes may at any time and upon
notice of the Board of Directors decide, without quorum and at the majority of the Shares present or represented and
voting for each Sub-Fund or Class concerned, to merge one or more Sub-Funds or Classes (the "Absorbed Sub-Fund(s)
or Class(es)") into another Sub-Fund or Class. In any case shall the Shareholders of the Absorbed Sub-Fund(s) or Class
(es) be offered the opportunity to redeem their Shares free of charge during a thirty (30) days period starting as from
the date on which the Company has notified them of the resolution to merge, it being understood that, at the expiration
of the same period, the resolution to merge will bind all the Shareholders who have not made use of this prerogative.
Further to the closing of any merger procedure, the auditor of the Company will report upon the way the entire procedure
has been conducted and shall certify the exchange parity of the Shares.
All Shareholders concerned by the resolution to liquidate a Sub-Fund or Class or to merge different Sub-Funds or
Classes will be notified. The Company may not merge one of its Sub-Funds with a third party, Luxembourgish or not.
In accordance with Article 12, the Board of Directors may suspend the determination of the Net Asset Value of Sub-
Funds and the issue, redemption and conversion of the Shares of such Sub-Funds upon the publication of a notice convening
a general meeting of Shareholders for the purpose of resolving dissolution of the Company, a liquidation of a Sub-Fund
or a compulsory redemption of all outstanding Shares of a Sub-Fund or, in cases where any such action does not require
125077
L
U X E M B O U R G
approval of the General Meeting of the Company or of the respective Sub-Fund, upon the publication of a notice to the
Shareholders for the purpose of notifying them of such action.
Art. 30. Liquidation procedure. In the event of the dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one
or several liquidators (who may be natural persons or legal entities), named by the General Meeting of the Company
deciding such dissolution and determining the liquidator's powers and remuneration.
The net proceeds of liquidation corresponding to each Class shall be distributed by the liquidator to the Shareholders
of each Class in proportion of their holding of Shares in such Class.
Art. 31. Articles amendment. These Articles may be amended from time to time by the General Meeting of the
Company, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg. Any amendment affecting
the rights of the Shareholders of any Class shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in
respect of each such relevant Class.
Art. 32. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of
2010 and the Law of 1915.
Nothing else being on the agenda the meeting was closed at 10.30 a.m.
<i>Costsi>
The expenses, costs remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be nine hundred seventy five euros (EUR 975.-).
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian
name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, Notary, the present original deed.
Signé: L. BOEUF, C. VAUDÉMONT, C. PARMENTIER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 septembre 2012. Relation: LAC/2012/43613. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 2 octobre 2012.
Référence de publication: 2012128419/715.
(120169073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2012.
RE Mosse Zentrum General Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 115.579.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 Septembre 2012.
RE Mosse Zentrum General Partners S.àr.l.
Mutua (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Sole Manageri>
Référence de publication: 2012127152/15.
(120168224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
RE German Properties General Partners S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 129.145.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
125078
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 27 Septembre 2012.
RE German Properties General Partners S.àr.l.
Mutua (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Sole Manageri>
Référence de publication: 2012127150/15.
(120168194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Julienne Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 128.162.
<i>Exrait des résolutions prises par les associés en date du 30 juin 2012i>
1) Il est décidé de transférer le siège social de la société du 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
2) Il est décidé d'accepter la démission de TMF CORPORATE SERVICES S.A. comme gérant de catégorie B.
3) Conformément à l'article 13 des statuts il est décidé de nommer comme nouveau gérant de catégorie B la société
BDO Tax & Accounting, sise au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg dûment représentée par Monsieur Marc
THILL, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors
de l'assemblée devant approuver les comptes annuels au 31 décembre 2015.
4) Conformément à l'article 13 des statuts il est décidé de proposer que les gérants suivants, nommés par une réso-
lution des associés du 21 décembre 2010, soient nommés comme gérants de catégorie A:
- Kim CRETEN, demeurant au 24, Hoogveld, B-9340 Lede
- Gerrit CALLAERTS, demeurant au 110,Stuivenbergvaart, B-2800 Mechlen
- Paul VANDERSTAPPEN, demeurant au 32, Builoogstraat, B-3360 Bierbeekk
La durée de leur mandat reste inchangée.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 26 septembre 2012.
Référence de publication: 2012126990/24.
(120167999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
MMB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 29.898.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution prise lors de la réunion du Conseil d'administration du 1
er
octobre 2012 que:
Le siège social de la société a été transféré au 10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012127068/11.
(120168225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
MIB BP Portfolio, Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 142.724.
Experta Corporate and Trust Services S.A., Luxembourg, en abrégé Experta Luxembourg, société anonyme, en sa
qualité d'agent domiciliataire, a dénoncé le siège social de la société à responsabilité limitée MIB BP Portfolio, 42, rue de
la Vallée, L-2661 Luxembourg, RCS Luxembourg B-142724, avec effet au 27/09/2012 et résilié la convention de domici-
liation.
125079
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 27/09/2012.
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Tanja Bernat / Isabelle Maréchal-Gerlaxhe
Référence de publication: 2012127060/14.
(120168303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Men Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 138.329.
<i>Extrait de la Réunion du Conseil d'Administration du 21 septembre 2012i>
Le Conseil d'administration à l'unanimité décide de déléguer la gestion journalière de la société à M. Fernand BECKER,
né le 19 avril 1956 à Wilrijk (Belgique) demeurant au 40, rue des Chartreux à B-1000 Bruxelles, lequel exercera son
activité sous la dénomination d'administrateur-délégué, M. Fernand BECKER pourra engager la société en toutes cir-
constances, sans limitation, par sa seule signature.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012127056/13.
(120168275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Identitag Secondary Opportunities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 4.276.691,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 161.954.
<i>Extrait de la résolution circulaire prise lors du conseil de gérance du 1 i>
<i>eri>
<i> octobre 2012i>
Conformément à la résolution circulaire prise lors du conseil de gérance, il a été décidé:
- De transférer avec effet au 1
er
octobre 2012, le siège social de la société du 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
au 3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
<i>Pour Identitag Secondary Opportunities S.à r.l.
i>Signatures
Référence de publication: 2012126958/16.
(120168023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Telenet Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 150.204.
Par résolution signée en date du 13 septembre 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Manfred Schneider, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au
mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
2. Nomination de Sandra Rolland, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au
mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2012.
Référence de publication: 2012127209/15.
(120168446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
125080
L
U X E M B O U R G
Risk & Reinsurance Solutions S.A. en abrégé "2RS", Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 94.494.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012127144/12.
(120168016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Liac, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8327 Olm, 8, rue de l'Indépendance.
R.C.S. Luxembourg B 20.507.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2012i>
L'Associée unique a adopté les résolutions suivantes:
1) L'Associée unique constate la vacance d'un poste de gérant, suite au décès de Monsieur Klaus-Peter WEINERT, en
date du 27 septembre 2011. Il ne sera pas pourvu au remplacement du mandat de Monsieur WEINERT.
2) Suite au décès de Monsieur Klaus-Peter WEINERT, en date du 27 septembre 2011, l'Assemblée ne compte plus
qu'un seul associé, à savoir l'épouse du défunt, Madame Liliane Josette APEL.
Il résulte d'un acte de notoriété du 28 octobre 2011 - numéro 39.767, établi par Maître Paul BETTINGEN, notaire de
résidence à Niederanven, que Madame APEL, aux termes d'un testament olographe, a été instituée légataire de tous les
biens qui composent la succession, partant aussi des parts sociales de la société LIAC, dont le défunt était le propriétaire.
Sur base de ce qui précède, la répartition des parts sociales s'établit désormais comme suit:
Désignation de l'associée unique:
Madame Liliane Josette APEL, née à Luxembourg, le 21 avril 1952, demeurant à L-8327 Olm,
rue de l'Indépendance 8: CINQ CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
En sa qualité de gérante unique, Madame Liliane Josette APEL, prénommée, déclare, par la signature du présent procès-
verbal, accepter la prédite cession au nom et pour compte de la société, le tout en vertu de l'article 1690 du Co de Civil.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 24 septembre 2012.
<i>Pour LIAC S.à r.l.
i>FIDUNORD S.à r.l.
Référence de publication: 2012127024/27.
(120168005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Rayshark, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 130.439.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 septembre 2012i>
1. Ont été ré-élus administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2018:
- Monsieur Pierre SIRI, 58, Avenida del Golf, 07 180 Santa Ponsa / Mallorca, Spain, Administrateur catégorie A
- Monsieur Eric LECLERC, 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Administrateur catégorie B
- Monsieur Christophe JASICA, 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Administrateur catégorie B
2. A été ré-élu commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2018:
- Monsieur Pascal FABECK, 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald,
125081
L
U X E M B O U R G
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012127148/18.
(120168343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Slif S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 13, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 116.280.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012127188/10.
(120168328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
ONC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5380 Uebersyren, 8, rue de Mensdorf.
R.C.S. Luxembourg B 171.671.
STATUTS
L'an deux mille douze, le quatre septembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Olimpio CARDOSO, entrepreneur de construction, né à Mata Mourisca Pombal (P), le 18 mai 1948,
demeurant à L-2440 Luxembourg, 45, rue Kneppchen, et
2.- Monsieur Olivio CARDOSO, ingénieur diplômé, né à Luxembourg, le 4 juin 1975, demeurant à L-6989 Hostert,
12, Chaussée St. Martin.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée qu'ils constituent par les présentes:
Titre I
er
. - Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée “ONC S.à r.l. (ci-après la "Société"), régie par les
lois y relatives, ainsi que par les présents statuts, (les "Statuts").
Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en valeur et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Schuttrange, (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.
125082
L
U X E M B O U R G
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales
de douze euros et cinquante cents (12,50 EUR) chacune, intégralement libérées.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 7. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par
lettre recommandée à ses co-associés.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
125083
L
U X E M B O U R G
Titre V. - Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les mille (1.000) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Olimpio CARDOSO, prédésigné cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2) Monsieur Olivio CARDOSO, prédésigné cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-5380 Uebersyren, 8, rue de Mensdorf.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Olimpio CARDOSO, entrepreneur de construction, né à Mata Mourisca Pombal (P), le 18 mai 1948,
demeurant à L-2440 Luxembourg, 45, rue Kneppchen, et
- Monsieur Olivio CARDOSO, ingénieur diplômé, né à Luxembourg, le 4 juin 1975, demeurant à L-6989 Hostert, 12,
Chaussée St. Martin.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature conjointe des deux
gérants.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Olimpio CARDOSO, Olivio CARDOSO Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 septembre 2012. Relation GRE/2012/3344. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2012128271/125.
(120169080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2012.
Molko SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 119.096.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012127041/9.
(120167934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
125084
L
U X E M B O U R G
Mediflex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9780 Wincrange, 66B, route de Lullange.
R.C.S. Luxembourg B 117.592.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012127054/10.
(120167829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
P1 Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. JP Immo S.à r.l.).
Siège social: L-4275 Esch-sur-Alzette, 4, Place de la Paix.
R.C.S. Luxembourg B 138.572.
L'an deux mille douze, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Pascal Fernand LIETZ, employé privé, né le 20 juillet 1969 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4955 Ba-
scharage, 9, rue des Genêts.
2.- Monsieur Tom ERNZER, indépendant, né le 14 juin 1973 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-5775 Weiler-la-Tour,
9, rue Emil Marx.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée "JP IMMO S.à r.l." établie
et ayant son siège social à L-4380 Ehlerange, 67, route d'Esch, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 19 mai 2008, publié au Mémorial C numéro 1410 du 7 juin 2008, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 138572.
Ensuite les comparants, agissant en leur dite qualité, représentant l'intégralité du capital social, ont pris à l'unanimité
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Tom ERNZER, indépendant, né le 14 juin 1973 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-5775 Weiler-la-Tour, 9,
rue Emil Marx, déclare que Monsieur Jean-Claude MOSCHENI, électricien, né à Esch-sur-Alzette le 19 février 1971,
demeurant à L-4380 Ehlerange, 67, rue d'Esch, lui a cédé CINQUANTE (50) parts sociales qu'il détenait dans la pré-dite
société "JP IMMO S.à r.l.", aux termes d'une cession de parts sociales reçue sous seing privé en date du 27 septembre
2012, dont un exemplaire demeurera annexé aux présentes pour être enregistré.
La cession a été faite contre paiement d'un montant de UN EURO (€ 1,-) montant qui a été payé avant la signature
du présent acte et hors la présence du notaire, ce dont titre, quittance et décharge.
Le cessionnaire Monsieur Tom ERNZER, pré-nommé, entrera en jouissance des parts d'intérêts cédées et en sup-
portera toutes les charges et obligations à partir de ce jour, le cédant le subrogeant dans ses droits.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de changer la dénomination et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
" Art. 2. La société prend la dénomination de:
"P1 IMMO S.à r.l.".".
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-4380 Ehlerange, 67, rue d'Esch à L-4275 Esch-sur-
Alzette, 4, place de la Paix et de modifier en conséquence le 1
er
alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
"Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette."
Les autres alinéas de l'article 3 restent inchangés.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, le comparant a déclaré close la présente assemblée.
125085
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: LIETZ P., ERNZER T., Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28/09/2012. Relation: EAC/2012/12680. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 1
er
octobre 2012.
Référence de publication: 2012126995/53.
(120168082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Nei Aarbecht, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7351 Helmdange, 7, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 25.009.
Suite à une cession de parts entre associés, il résulte que la répartition des 500 parts se compose dorénavant comme
suit:
- Comité National de Défense Sociale A.s.b.l.
7, rue de l'Alzette
L-7351 Helmdange
N° RSCL: F679
Parts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Helmdange, le 31 août 2012.
Nei Aarbecht s.à r.l.
Référence de publication: 2012127079/18.
(120168054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Digit S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 17.599.
L'an deux mille douze, le treize septembre.
Par devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «DIGIT S.A.H», une société anonyme ayant
son siège social au 3, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 4 juin 1980, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 193 du 4 septembre 1980,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 17.599 (la "So-
ciété").
L'assemblée a été déclarée ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean Reuter, expert-comptable,
demeurant professionnellement à L-1445 Strassen.
Le président nomme comme secrétaire Virginie Pierru, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-2740
Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Georges Reuter, expert-comptable, demeurant professionnellement
à L-1445 Strassen.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 sur base du rapport du
commissaire aux comptes remplaçant Monsieur Georges REUTER.
2. Confirmation du mandat des trois administrateurs de la société: Monsieur Jean REUTER, Monsieur Jean-Paul
SPAUTZ et Monsieur Carlo MEIS.
3. Dissolution et mise en liquidation de la société.
125086
L
U X E M B O U R G
4. Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
5. Nomination du commissaire-vérificateur de la société et détermination de ses pouvoirs.
6. Nomination du réviseur externe de la société pour le contrôle des comptes.
7. Divers.
II. Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une
liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
III. Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés
ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.
IV. Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.
V. Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 sur base
du rapport du commissaire aux comptes remplaçant Monsieur Georges REUTER, expert-comptable, né le 19 février 1977
à Luxembourg, demeurant professionnellement au 3, rue Thomas Edison L-1445 Strassen.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale confirme le mandat des trois administrateurs de la société: Monsieur Jean REUTER, né le 17
juillet 1941 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 3, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Monsieur Jean-Paul
SPAUTZ, né le 1
er
février 1944 à Luxembourg, demeurant au 11, rue des Etats-Unis L-8316 Olm et Monsieur Carlo
MEIS, né le 15 décembre 1958 à Steinfort (Luxembourg), demeurant professionnellement au 3, rue Thomas Edison L-1445
Strassen.
Les mandats des administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2013.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale nomme Monsieur Jean REUTER, prénommé, comme liquidateur.
L'assemblée générale des actionnaires a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des
pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société,
quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.
Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment
en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.
Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision,
il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.
Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des actions émises par
la Société.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux associés des avances sur le boni de liquidation.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires
des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.
La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur,
pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.
L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre
les parties concernées.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide nomme Monsieur Georges REUTER, prénommé, comme commissaire-vérificateur à la liquidation
de la société.
Le commissaire-vérificateur aura la mission de contrôle le rapport du liquidateur avec ses annexes et de faire rapport
à l'assemblée, convoquée entre autres à ces fins.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée nomme la «Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable» en abrégé «CLERC»,
ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, représentée par Monsieur Jean-Jacques SOISSON, réviseur
125087
L
U X E M B O U R G
d'entreprises agréé, demeurant professionnellement à la même adresse, comme réviseur externe pour le contrôle des
comptes.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 14.30 heures.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille euros (1.000,- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire le présent acte.
Signé: J. REUTER, V. PIERRU, G. REUTER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 septembre 2012. Relation: LAC/2012/43596. Reçu 12.- € (douze Euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 01 octobre 2012.
Référence de publication: 2012127975/95.
(120168789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2012.
Invest Association Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 60.396.
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 13/09/2012i>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 25A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix présentes et représentées, révoque Monsieur Jean-Marc FABER de son
poste de commissaire aux comptes et nomme en remplacement la Fiduciaire Befac Expertises Comptables et Fiscales
(Luxembourg) S.àr.l enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B70868 et
siégeant au 25A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
L’assemblée, à l’unanimité des voix présentes et représentées accepte la nomination de Monsieur Jassem Anis ZIANE,
né le 07/03/1989 à Oran (Algérie) et demeurant à 6bis Rue Murat Miramar 31000 Oran (Algérie) en tant qu’administrateur
avec effet immédiat et pour une durée de six ans, en remplacement de Monsieur Walid ZIANE.
L’assemblée, à l’unanimité des voix présentes et représentées accepte de renouveler le mandat d’administrateur et
d’administrateur délégué de Monsieur Habib ZIANE, né le 28/09/1940 à Mechera (Algérie) et demeurant à 6bis Rue Murat
Miramar 31000 Oran (Algérie), pour une durée de six ans, et de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur
Mohamed ZIANE, né le 26/02/1973 à Oran (Algérie) et demeurant à 6bis Rue Murat Miramar 31000 Oran (Algérie), pour
une durée de six ans.
Le conseil d’administration sera composé comme suit:
- Monsieur Habib ZIANE, administrateur et administrateur-délégué.
- Monsieur Mohamed ZIANE, administrateur.
- Monsieur Jassem Anis ZIANE, administrateur.
Référence de publication: 2012126979/25.
(120168247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
International Machinery Trading Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 58.870.
Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012126975/10.
(120168321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
125088
1A Gérances S.à r.l.
Adonis S.A.
Adonis S.A.
A-Style S.A.
BHM & Oriental Fund SCA SICAV-SIF
Brysam Lux (Colombia) S.à r.l.
Bureau d'Assurances Kintzele Sàrl
Bureau Immobilier Goergen
C2I S.à r.l.
Ceryx S.A.
Circuit Foil Service S.à r.l.
Coller Epee S.à r.l.
Contel Group S.A.
DBP Design Build Property Holding S.A.
D'Haus vun der Natur
Digit S.A.H.
Exoworld Sàrl
Figupar S.A.
FinnAust Mining S.à r.l.
Identitag Secondary Opportunities S.à r.l.
International Machinery Trading Corporation S.A.
Invest Association Luxembourg S.A.
JP Immo S.à r.l.
Julienne Holdings S.à r.l.
Liac
Lux Concept Real Estate SCI
Luxindra Investment Corporation SA
Meat Co Maghreb S.à r.l.
Mediflex S.à r.l.
Men Invest
M&G Real Estate Finance 2 Co. S.à r.l.
MIB BP Portfolio
Mili Malo, S.à r.l.
MMB S.A.
Molko SA
Nei Aarbecht
ONC S.à r.l.
P1 Immo S.à r.l.
Parker Hannifin Europe S.à r.l.
Rayshark
RE German Office General Partners S.à r.l.
RE German Properties General Partners S. à r.l.
RE German Small Properties General Partners S.à r.l.
RE Mosse Zentrum General Partners S.à r.l.
Risk & Reinsurance Solutions S.A. en abrégé "2RS"
Sanderlux S.A.
Slif S.à r.l.
Solvadis Holding S.àr.l.
Teamlog Lux S.à r.l.
Telenet Finance S.à r.l.
The Isidor Company GmbH
Thetis S.A.
THIEL Romain
Transports - Déménagements «Beim Plënnermann S.à r.l.»
Transtrend Fund Alliance
Tyco Flow Control International Holding S.à r.l.
Union Consulting S.A.
Union Consulting S.A.
Union Retail REIT S.A.
Venusia Real Estate Investment S.A.