logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2181

3 septembre 2012

SOMMAIRE

10 Porte Neuve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104647

ACRON Lux Management S.à r.l.  . . . . . . .

104664

Arkess Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104650

BNP Paribas Focused Strategies Funds  . .

104642

Colruyt Gestion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104647

e-Novate International  . . . . . . . . . . . . . . . . .

104662

Ermitage Thematic Fund  . . . . . . . . . . . . . . .

104674

e-Traction Worldwide  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104662

Fortuna (Universal) SA Soparfi  . . . . . . . . . .

104676

Happy Family I S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104645

Lilac Holding Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

104644

L.O.F.H. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104659

Matterhorn Topco & Cy S.C.A. . . . . . . . . . .

104650

PHM Holdco 17 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104675

PHM Holdco 18 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104675

PHM Investment Holdings (USD) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104675

PHM Investment Sisterco (USD) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104675

PHM Investment (USD) 1 S.à r.l.  . . . . . . . .

104659

PHM Topco 18 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104659

Safinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104676

Samaya S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104678

Samot S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104679

Sanary Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

104679

SBRE Neighbourhood Centre  . . . . . . . . . . .

104679

SBRE Office  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104679

SBRE Senden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104680

SBRE West German Portfolio Luxco  . . . .

104680

Scalia s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104680

SDK Ungarn SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104675

Selected 4 You S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104680

Sharmut Fashion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104681

Shipbourne S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104680

Slainte S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104681

Smart Fact S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104681

Société J. Ama S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104682

Société Nouvelle (Luxembourg) Holding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104682

Sociolab International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

104682

Sonore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104685

SOPAF Asia S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104682

Sopalux Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104682

Sopalux Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104682

SOPARINTER GROUP Spf, S.A.  . . . . . . . .

104683

Soparlec Spf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104683

SORAMAT Spf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104683

Sound and Video Supply S.A. . . . . . . . . . . . .

104683

Spare Parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104684

Sphinx Luxco D S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104676

Stemma S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104684

Strada S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104684

Stroosseverkaf S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104685

Structurize S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104685

Swiss Life Immo-Arlon  . . . . . . . . . . . . . . . . .

104685

Synavic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104683

Tanarive Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

104684

TCA Event Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

104688

Techhol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104688

Teekay European Holdings S.à r.l.  . . . . . . .

104686

Teekay Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

104687

Tesa Participations R.H., S.à r.l.  . . . . . . . . .

104675

TetrArchitecture S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

104688

T.I.P. Technischer Industriebedarf Pickard

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104687

Transes International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

104686

Transes Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

104688

Tredief S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104681

Versopa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104688

104641

L

U X E M B O U R G

BNP Paribas Focused Strategies Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investis-

sement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.982.

In the year two thousand and twelve, on the seventh day of August.
Before us Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société d'investissement à capital variable BNP

Paribas Focused Strategies Funds (the "Company") having its registered office in L-2951 Luxembourg, 50, Avenue J.F.
Kennedy, incorporated by deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem on 28 February 2008, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number C - 793 on 2 April 2008, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 136.982. The articles of association of the
Company have been amended several times and for the last time by deed of the Maître Martine SCHAEFFER, notary
residing in Luxembourg, on 18 June 2009, published in the Mémorial, number C - 1400 on 21 July 2009.

The meeting was presided over by Mr. Laurent CLAIRET, private employee, professionally residing in L-5826 Hespe-

range, 33, rue de Gasperich.

The chairman appointed as secretary Mrs. Fabienne VERONESE, private employee, professionally residing in L-5826

Hesperange, 33, rue de Gasperich.

The meeting elected as scrutineer Mr. Arnaud PERAIRE, private employee, professionally residing in L-5826 Hespe-

range, 33, rue de Gasperich.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance

list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration

authorities.

II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that

the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted and
may validly deliberate on the agenda set out below:

1) Liquidation of the Company according to article 27 of the articles of association;
2) Discharge to the Directors;
3) Appointment of one or several liquidators and determination of their powers according to article 142 LSC;
4) Miscellaneous.
After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolution:

<i>First resolution

In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and according to article 27 of the articles of

association, the meeting resolved to dissolve and to put the Company into liquidation with immediate effect.

<i>Second resolution

The meeting resolved to grand discharge to the board of directors and to each directors in individually for the per-

formance of their mandate up to the date of the present extraordinary general meeting of shareholders held in order to
put the Company into liquidation, and in particular to:

- Mr. Marc RAYNAUD, professionally residing in F-75009 Paris, 14, rue Bergère;
- Mr. Philippe BOULENGUIEZ, professionally residing in F-75009 Paris, 14, rue Bergère;
- Mr. Samir CHERFAOUI, professionally residing in F-75009 Paris, 14, rue Bergère;
- Mr. Anthony FINAN, professionally residing in F-75009 Paris, 14, rue Bergère.

<i>Third resolution

As a consequence of the above taken resolution, the meeting resolved to appoint as liquidator:
- BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, a public limited company governed by the laws of Lu-

xembourg with registered office in L-5826 Hesperange, 33 rue de Gasperich, Grand Duchy of Luxembourg, inscribed in
the Trade and Companies Registry of Luxembourg, under number B 27.605.

The Liquidator shall have the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915,

on commercial companies, as amended.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the law of August 10, 1915, on commercial

companies, as amended, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

104642

L

U X E M B O U R G

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights,

preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the prefe-
rential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such

part of his power he will determine and for the period he will fix.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the members in cash or in kind to his willingness in the pro-

portion of their participation in the capital.

There being no further business on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges are borne by the Company as a result of the present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the persons hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same persons, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Hesperange by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,

first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mil douze, le septième jour d'août.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable

BNP Paribas Focused Strategies Funds (la «Société»), avec siège social à L-2951 Luxembourg, 50, Avenue J.F. Kennedy,
constituée suivant acte passé devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, le 28 février 2008, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association (le «Mémorial»), N° C - 793 le 2 avril 2008, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 136.982. Les statuts de la Société ont été modifiés
plusieurs fois et pour la dernière fois par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, le 18
juin 2009, publié au Mémorial, N° C - 1400 le 21 juillet 2009.

L'assemblée est présidée par M. Laurent CLAIRET, employé privé, demeurant professionnellement à L-5826 Hespe-

range, 33, rue de Gasperich.

Le président désigne comme secrétaire Mme. Fabienne VERONESE, employée privée, demeurant professionnellement

à L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

L'assemblée désigne comme scrutateur M. Arnaud PERAIRE, employé privé, demeurant professionnellement à L-5826

Hesperange, 33, rue de Gasperich.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux figurent sur la

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Cette liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront annexées au présent acte, pour être soumises aux

formalités de l'enregistrement

II. Il ressort de la liste de présence que les actions représentant tout le capital social sont représentées à cette assemblée

et  les  actionnaires  déclarent  être  dûment  informés  de  l'ordre  du  jour  de  sorte  que  la  présente  assemblée  générale
extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour décrit
ci-après:

1) Liquidation de la Société suivant l'article 27 des statuts de la Société;
2) Décharge des administrateurs;
3) Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs selon l'article 142 LSC;
4) Divers.

<i>Première résolution

Ayant approuvé ce qui précède, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
Conformément à la loi du 10 août 1915 et suivant l'article 27 des statuts de la Société, l'assemblée a décidé de dissoudre

et de mettre en liquidation la Société avec effet immédiat.

104643

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'assemblée a décidé d'accorder pleine et entière décharge au Conseil d'administration et à chaque administrateur

individuellement pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de la présente assemblée générale extraordinaire des
associés de la mise en liquidation de la société, à savoir à:

- Monsieur Marc RAYNAUD, demeurant professionnellement à F-75009 Paris, 14, rue Bergère;
- Monsieur Philippe BOULENGUIEZ, demeurant professionnellement à F-75009 Paris, 14, rue Bergère;
- Monsieur Samir CHERFAOUI, demeurant professionnellement à F-75009 Paris, 14, rue Bergère;
- Monsieur Anthony FINAN, demeurant professionnellement à F-75009 Paris, 14, rue Bergère.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée a décidé de nommer en tant que liquidateur:
- BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son

siège social au 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 27.605.

Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915

concernant la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droit

réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de son pouvoir qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux associés en numéraire ou en nature selon sa volonté en

fonction de leur participation au capital.

Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature sont payables par la Société en raison du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate qu'à la requête des personnes comparantes, cet acte a

été rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes personnes comparantes la version
anglaise fera foi en cas de divergence entre les textes français et anglais.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire soussigné par

leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: L. Clairet, F. Veronese, A. Peraire, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 9 août 2012. Relation: DIE/2012/9330. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 9 août 2012.

Référence de publication: 2012104261/146.
(120142446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.

Lilac Holding Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 849.747,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 131.967.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 23 juillet 2012

<i>Résolution:

L'assemblée précise qu'à partir du 23 juillet 2012 les catégories de gérants de la Société sont divisés comme suit:

<i>Gérants de classe A:

Mr. Jeffrey H. Hansen, demeurant à 451, Jackson Street, USA - 94111 - 1615 San Francisco, California

104644

L

U X E M B O U R G

Mr. Andrea Mandel-Mantello, demeurant à 451, Jackson Street, USA - 94111 - 1615 San Francisco, California

<i>Gérants de classe B:

Mrs. Hélène Mercier, demeurant à 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2012099478/20.
(120136739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Happy Family I S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.

Capital social: EUR 74.292.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 151.121.

En l'an deux mille douze, le dix Août.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

M. Franz Bondy, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 8 rue Philippe II L-2340 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de «HAPPY FAMILY S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social au 8 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg («Gérant») immatriculée au Registre de Commerce du Luxem-
bourg sous le numéro B149190,

agissant au nom et pour le compte du Gérant de «Happy Family I S.C.A.» (la «Société»), une société en commandite

par actions, société de titrisation, avec siège social au 8 rue Philippe II Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 151121 (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu
par le notaire Maître Henri HELLINCKX, en date du vingt-neuf décembre 2009, publié au Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Mémorial C, numéro 559 du 16 mars 2010 et modifiée en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Maître
Henri HELLINCKX en date du 11 avril 2012, publié au Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, numéro 1360
du 16 juin 2012

Une copie des Résolutions précitées restera, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire

instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant, agissant comme ci-avant, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:
1. La Société a été constituée sous le droit luxembourgeois suivant acte reçu le 29 décembre 2009 par Maître Hellinckx,

notaire  de  résidence  au  Grand-Duché  du  Luxembourg,  Luxembourg,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations, N° 559 du 16 mars 2010.

2. L'article 5 des Statuts a la teneur suivante:
La Société a un capital émis et entièrement souscrit de soixante et onze millions cinq cent quatre-vingt-douze mille

cinq cents euros (71.592.500,- EUR) représenté par sept millions cent cinquante-neuf mille deux cent quarante-neuf
(7.159.249) actions de commanditaire (dont 4.999 actions de commanditaire ont été émises lors de la constitution, dont
sept cent soixante-trois mille huit cent quatre-vingt-dix (763.890) actions de Commanditaire correspondent au compar-
timent «WATAMAR &amp; Cie», quatre million quatre cent quatre-vingt-trois mille (4.483.000) actions de commanditaire
correspondent au compartiment «IMMOGROUP» et un million neuf cent sept mille trois cent soixante (1.907.360) actions
de commanditaire correspondent au compartiment «SUCAFINA HOLDING» d'une valeur nominale de dix euros (10,-
EUR) chacune et une (1) action de commandité d'une valeur nominale de dix euros (10,-EUR) chacune.»

3. Conformément à l'article 5 des Statuts:
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cent millions d'euros (500.000.000,- EUR)

qui sera représenté par cinquante millions (50.000.000) d'actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des Actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

4. Le Gérant est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 29 décembre 2014, à augmenter en une ou

plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'Actions nouvelles, et rattachées
le cas échéant à un seul Compartiment, tel que visé à l'article 6. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites
avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides
ou immédiatement exigibles vis-à-vis de la Société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves dis-
ponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

104645

L

U X E M B O U R G

Le Gérant est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux Actionnaires antérieurs un

droit préférentiel de souscription des Actions à émettre. Le Gérant peut déléguer à une personne dûment autorisée, la
charge de recueillir les souscriptions et de recevoir paiement du prix des Actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.

Sans préjudice également du pouvoir de l'assemblée générale en ces matières, chaque fois que le Gérant aura fait

constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

5. Le Gérant, dans les Résolutions, a décidé d'augmenter, dans les limites du capital autorisé, d'augmenter le capital

social d'un montant de deux millions sept cents mille euros (2.700.000,- EUR) par l'émission de deux cent soixante-dix
mille  (270.000)  actions  nouvelles  de  commanditaire  d'une  valeur  nominale  de  dix  euros  (10,-  EUR)  chacune  dans  le
compartiment «IMMOGROUP» pour le porter de son montant actuel de soixante et onze millions cinq cent quatre-vingt-
douze mille cinq cents euros (71.592.500,- EUR) à soixante-quatorze millions deux cent quatre-vingt-douze mille cinq
cents (74.292.500,- EUR).

6. L'associé-commandité, la société «HAPPY FAMILY S.à.r.l.», propriétaire d'une action commanditaire et d'une une

action de commandité de la société «Happy Family I S.C.A.», décide de renoncer à son droit préférentiel de souscription
et admet Monsieur Abdallah Wahbé Tamari à la souscription des actions nouvelles.

7. Dans le cadre de l'augmentation de capital ci-dessus, une autorisation a été donnée à Monsieur Abdallah Wahbé

Tamari, né le 4 septembre 1922 à Jaffa, de nationalité libanaise, homme d'affaires, demeurant au 343, rue Georges Haimari,
Achrafieh-Beyrouth (Liban), pour souscrire les Nouvelles Actions précitées,

8. Les deux cent soixante-dix mille (270.000) actions nouvelles de commanditaire d'une valeur nominale de dix euros

(10,- EUR) sont destinées au souscripteur désigné dans les Résolutions à savoir Monsieur Abdallah Wahbé Tamari, né le
4 septembre 1922 à Jaffa, de nationalité libanaise, homme d'affaires, demeurant au 343, rue Georges Haimari, Achrafieh-
Beyrouth (Liban), (le «Souscripteur»).

9. Suite à cette augmentation de capital, le capital social de la société est fixé à soixante-quatorze millions deux cent

quatre-vingt-douze mille cinq cents euros (74.292.500,- EUR) correspondant à sept millions quatre cent vingt-neuf mille
deux cent quarante-neuf (7.429.249) actions de commanditaire d'une valeur nominal de dix euros (10,- EUR) chacune et
une action de commandité d'une valeur nominal de dix euros (10,- EUR).

10. À la suite de la réception par la Société de la Déclaration de souscription de M. Abdallah Wahbé Tamari, toutes

les Nouvelles Actions ayant été souscrites et libérées en espèces par le Souscripteur, la somme de deux millions sept
cents mille euros (2.700.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société, comme il en a été prouvé au Notaire instru-
mentant.

11 . La libération en numéraire d'un montant de deux millions sept cents mille euros (2.700.000,- EUR) à la Société

est porté au compte capital social de la Société.

12. Suite à l'augmentation du capital social de la Société et à la réduction du capital autorisé, le comparant a requis le

notaire instrumentant de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts pour avoir la teneur suivante:

«  Art. 5. Capital social. (1 

er

 alinéa).  La Société a un capital émis et entièrement souscrit soixante-quatorze millions

deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cents euros (74.292.500,-EUR), représenté par sept million quatre cent vingt-
neuf mille deux cent quarante-neuf (7.429.249) actions de commanditaire dont quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf (4.999) actions de commanditaire ont été émises lors de la constitution, dont sept cent soixante-trois mille huit cent
quatre-vingt-dix (763.890) actions de commanditaire correspondent au compartiment «WATAMAR &amp; Cie», quatre mil-
lions sept cent cinquante trois mille (4.753.000) actions de commanditaire correspondent au compartiment «IMMO-
GROUP» et un million neuf cent sept mille trois cent soixante (1.907.360) actions de commanditaire correspondent au
compartiment «SUCAFINA HOLDING» d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et une (1) action de
commandité d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions trois

cents mille euros (497.300.000,-EUR) qui sera représenté par quarante-neuf millions sept cent trente mille (49.730.000)
d'actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à deux mille huit cent cinquante euros (2.850,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par son nom,

prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le Notaire.

Signé: F. BONDY, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 août 2012. Relation: LAC/2012/38911. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

104646

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 27 août 2012.

Référence de publication: 2012110232/105.
(120149029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

Colruyt Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.485.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2012.

Référence de publication: 2012099139/10.
(120136741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

10 Porte Neuve, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 10, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 171.068.

STATUTS

L'an deux mille douze, le vingt-six juillet.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Mathias Pierre BASTIAN, indépendant, né à Pétange le 28 décembre 1947, demeurant à L-5551 Remich, 5

rue des Eglantiers,

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il

constitue par les présentes:

Titre I 

er

 - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  II est formé par les présentes entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront

propriétaires des actions ci-après créées une Société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société Anonyme adopte la dénomination "10 PORTE NEUVE".

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la commune par une résolution du conseil d'adminis-

tration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporai-
rement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société luxem-
bourgeoise.

Art. 3. Objet. La société a pour objet, autant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger l'acquisition, la vente, la

location de tous biens immobiliers et toutes prestations y afférentes. En outre, la société pourra exercer toute autre
activité commerciale à moins que celle-ci soit spécialement réglementée.

Elle pourra également effectuer toutes transactions sur immeubles, droits réels immobiliers et fonds de commerce,

acquisition, cession, opérations de location, de gestion immobilière, ainsi que toutes opérations financières, commerciales
et industrielles, mobilières et immobilières s'y rattachant directement ou indirectement.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale

et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter
ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-

104647

L

U X E M B O U R G

cières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social. La société pourra dans le cadre de son activité accorder
notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagements en faveur de tiers.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans

les mêmes conditions que pour la modification des présents statuts.

Titre II - Capital, Actions

Art. 5. Capital Social. La Société a un capital social de trente et un mille euros (31.000,-EUR) divisé en trente et une

(31) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,-EUR) chacune.

Art. 6. Actions. Les actions sont soit nominatives soit au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception des actions

pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

La Société pourra émettre des titres ou certificats nominatifs ou au porteur d'actions multiples.

Titre III - Administration - Surveillance

Art. 6. Administration. La société est administrée en cas d'un actionnaire unique par un administrateur unique ou par

un conseil d'administration ou en cas de pluralité d'actionnaires par un conseil d'administration, composé de trois mem-
bres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des
actionnaires. L'administration unique ou les membres du Conseil peuvent être réélus et révoqués à tout moment par
l'assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Procédure - Vote. En cas d'existence d'un conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs. Le

conseil d'administration pourra seulement valablement délibérer et prendre des décisions si la majorité de ses membres
est présente ou représentée par procurations, et si au moins deux administrateurs seront physiquement présents. Toute
décision prise par le conseil d'administration sera adopté à la simple majorité. Les procès-verbaux des réunions seront
signés par tous les administrateurs présents à la réunion.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer par le biais d'une conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de télécommunication permettant à différentes personnes de participer à la même réunion et de communiquer entre
eux. Une telle participation est à considérer comme étant égale à une présence physique. Une telle décision peut être
documentée sur un seul document ou sur plusieurs documents ayant le même contenu signé par tous les membres ayant
participé à la réunion.

Le Conseil d'administration peut prendre différentes décisions par des résolutions circulaires, si l'approbation est faite

par écrit, câble, télégramme, télex, Fax, Email ou tout autre moyen de communication agréé. Une telle décision peut être
documentée sur un seul document ou sur plusieurs documents ayant le même contenu signé par tous les membres ayant
participé à la réunion.

Art. 8. Pouvoirs. L'administrateur unique ou le cas échéant le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article
4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale.

L'administrateur unique ou le cas échéant le conseil d'administration est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. L'administrateur unique ou le cas échéant le conseil d'administration préparera une situation intérimaires des comp-

tes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 9. Représentation. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur

unique ou en cas d'existence d'un conseil d'administration par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

104648

L

U X E M B O U R G

signature  d'un  administrateur-délégué,  sans  préjudice  des  décisions  à  prendre  quant  à  la  signature  sociale  en  cas  de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Délégation de pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

Art. 11. Surveillance de la société. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires

ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre IV - Assemblée générale

Art. 12. Procédure - Vote. L'assemblée générale annuelle se réunit, le premier lundi du mois de mai à quinze heures,

dans la commune du siège social, ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour,

l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre V - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 13. Année sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Affectation des bénéfices. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortis-

sements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds
de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième (10%) du capital social,
mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit,
le fonds de réserve constitue moins de dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VI - Dissolution et Liquidation

Art. 15. Dissolution, Liquidation. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VII - Disposition générale

Art. 16. Loi applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se sou-

mettent  aux  dispositions  de  la  loi  luxembourgeoise  du  10  août  1915  sur  les  sociétés  commerciales  et  de  ses  lois
modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et sera clôturé au 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2013.

<i>Souscription et Libération

Les trois cent dix (310) actions ont été entièrement souscrites par l'actionnaire unique, prénommé, et intégralement

libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-EUR) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à neuf cent soixante-dix euros (970,-EUR).

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique, représentant la totalité du capital, a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et le nombre de commissaire aux comptes à un (1).
a) Est nommée administrateur unique de la société:
- Madame Annick BASTIAN, juriste, née le 20 Janvier 1972 à Luxembourg, demeurant à L-5551 Remich, 4, rue des

Eglantiers, laquelle aura tous pouvoirs pour engager valablement la société vis-à-vis des tiers par sa seule signature.

104649

L

U X E M B O U R G

b) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Emile STOFFEL, retraité, né le 6 septembre 1942 à Aspelt demeurant à L-5620 Mondorf-les-Bains, 1, rue

Docteur Kirpach.

Les mandats de l'administrateur unique, et du commissaire aux comptes expireront à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de l'année 2018.

2. Le siège social de la société est fixé à L-2227 Luxembourg, 10, Porte Neuve.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu par nom, prénom état et demeure par le notaire

instrumentant celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.-P. BASTIAN, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 01 août 2012. Relation: LAC/2012/36616. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

Luxembourg, le 27 août 2012.

Référence de publication: 2012110498/164.
(120149082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

Matterhorn Topco &amp; Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 165.824.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2012.

Référence de publication: 2012099502/10.
(120136742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Arkess Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.873.

In the year two thousand and twelve, on the twentieth of August.
Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ARKESS SICAV (hereafter referred to as the "Fund"),

a Société d'investissement à capital variable having its registered office in 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg B 125.873).

The meeting was opened at 3:00 p.m. under the chairmanship of Mrs. Cindy Joller, private employee, residing profes-

sionally in Luxembourg,

who appointed as Secretary Mrs. Laetitia Gorlini, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as Scrutineer Mr. Philippe Zamperini, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to record

that:

I. The agenda of the meeting was the following:
1. Replacement of any reference to the law of 20 December 2002 by reference to the law of 17 December 2010

concerning undertakings for collective investment (the "2010 Law") and implementing the so-called UCITS IV EU Directive
in articles 3, 5, 8 and 17 of the Articles of Incorporation;

2. Insertion of three new paragraphs at the end of article 12 of the Articles of Incorporation which shall read as follows:
A shareholder may participate at any meeting of shareholders by visioconférence or any other means of telecommu-

nication allowing to identify such shareholder. Such means must allow the shareholder to effectively act at such meeting
of shareholders, the proceedings of which must be retransmitted continuously to such shareholder.

By derogation to the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Fund is not required to send

the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the management report to the registered
shareholders at the same time as the convening notice to the annual general meeting. The convening notice shall indicate
the  place  and  practical  arrangements  for  providing  these  documents  to  the  shareholders  and  shall  specify  that  each
shareholder  may  request  that  the  annual  accounts,  as  well  as  the  report  of  the  approved  statutory  auditor  and  the
management report are sent to him.

104650

L

U X E M B O U R G

The convening notices to general meetings of shareholders may provide that the quorum and the majority at the

general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on
the fifth day prior to the general meeting (referred to as "Record Date"). The rights of a shareholder to attend a general
meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this
shareholder at the Record Date.

3. Insertion in Article 23 of the Articles of Incorporation of a new case of suspension of the Net Asset Value calculation

and of the issue, conversion and redemption of shares during any period when any Sub-Fund of the Fund is a feeder of a
master UCITS which is itself entitled to suspend the redemption or subscription of its shares, whether at its own initiative
or at the request of its competent authorities; the determination of the Net Asset Value of shares and the issue, re-
demption and conversion of shares shall be suspended within the same period of time as the master UCITS;

4. Update of article 29 (renamed 28) of the Articles of Incorporation in accordance with Chapter 8 of the 2010 Law

concerning mergers;

5. Insertion of a new article 29 in the Articles of Incorporation offering the possibility for one Sub-Fund of the Fund

to invest in one or more other Sub-Funds of the Fund according to article 181(8) of the 2010 Law;

6. Insertion of a new article 30 in the Articles of Incorporation on master-feeder structures as detailed in Chapter 9

of the 2010 Law;

7. Miscellaneous
a) Replacement of the terms "Company" and "Corporation" by the one of "Fund" in the Articles of Incorporation;
b) Replacement of the terms "class" and "sub-class" by the ones of "sub-fund" or "category" in the Articles of Incor-

poration, depending on the context;

c) Formal reorganization of the Articles of Incorporation.
II. The Shareholders were convened to the Meeting by letters containing the Agenda, sent to them by mail on 16 

th

July, 2012, and also published in the Luxemburger Wort, the Tageblatt and the Memorial on 16 

th

 July 2012 and 1 

st

 August

2012.

III. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the present shareholders, the proxies of the re-
presented shareholders, the bureau of the Meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.

IV. A first meeting of shareholders duly convened, was held on July 13, 2012, in order to decide on the same agenda.

This meeting could not take any decision, because the legal quorum of presence was not met.

V. That it appears from the attendance list, that out of 9.408,243 shares issued, 1 share is represented. The meeting

is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the afore cited agenda of the meeting of which
the shareholders have been informed before the meeting.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting decided to replace any reference to the law of 20 December 2002 by reference to the law of 17 December

2010 concerning undertakings for collective investment and implementing the so-called UCITS IV EU Directive in articles
3, 5, 8 and 17 of the Articles of Incorporation.

Article 3, Article 5, Article 8 and Article 17 of the Articles of Incorporation will henceforth read as follows:

Art. 3. Object. The exclusive object of the Fund is to place the funds available to it in transferable securities of any

kind, money market instruments and other permitted assets referred to in Part I of the law of 17 

th

 December 2010

regarding undertakings for collective investment, as amended (the "Law") with the purpose of spreading investment risks
and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Fund may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purpose to the full extent permitted by the Law.

Art. 5. Share Capital. The capital of the Fund shall be represented by fully paid-up shares of no par value and shall at

any time be equal to the total net assets of the Fund as defined in Article 24 hereof.

The minimum capital of the Fund shall be the minimum prescribed by Luxembourg law. The initial capital is 31'000

(EUR thirty-one thousand) divided into 31 (thirty-one) fully paid-up shares of no par value. The Board of Directors is
authorized without limitation to issue further shares to be fully paid at any time at the net asset value per share or at the
respective net asset value per share determined in accordance with Article 24 hereof without reserving the existing
shareholders a preferential right to subscription of the shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Fund or to any other duly

authorized person, the duty of accepting subscriptions for delivering and receiving payment for such new shares.

Such shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different Classes which may differ inter alia in their

fee structure, subscription and/or redemption procedures, minimum investment and/or subsequent holding requirements,

104651

L

U X E M B O U R G

type of target investors and distribution policy applying to them. The proceeds of the issue of each Class of shares shall
be invested pursuant to Article 3 hereof in transferable securities, money market instruments or other assets permitted
by law pursuant to the investment policy determined by the Board of Directors for the Sub-Funds (as defined hereinafter)
established in respect of the relevant Class or Classes of shares, subject to the investment restrictions provided by law
or determined by the Board of Directors.

The Board of Directors shall establish one or more portfolios of assets constituting each a sub-fund (each a «Sub-

Fund» and together the «Sub-Funds») within the meaning of Article 181 of the law of 17 December 2010 on UCIs (the
«2010 Law») for one Class of shares or for multiple Classes of shares. Each such pool of assets shall be invested for the
exclusive benefit of the relevant Sub-fund. The Board of Directors shall attribute a specific investment objective and policy,
specific investment restrictions and a specific denomination to each Sub-fund.

The Fund shall be considered as one single legal entity. However, with regard to third parties, in particular towards

the Fund's creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it. In respect of the
relationships between the shareholders, each Sub-Fund is treated as a separate entity.

The Board of Directors may create each Sub-Fund for an unlimited or limited period of time; in the latter case, the

Board of Directors may, at the expiry of the initial period of time, prorogue the duration of the relevant Sub-Fund once
or several times. At the expiry of the duration of a Sub-Fund, the Fund shall redeem all the shares in the relevant Class
(es) of shares, in accordance with Article 23 below, notwithstanding the provisions of Article 30 below.

At each prorogation of a Sub-Fund, the Registered Shareholders shall be duly notified in writing, by a notice sent to

their registered address as recorded in the register of shares of the Fund. The sales documents for the shares of the Fund
shall indicate the duration of each Sub-Fund and, if appropriate, its prorogation.

For the purpose of determining the capital of the Fund, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not

expressed in Euro, be translated into Euro and the capital shall be the total net assets of all the Sub-Funds.

In these Articles, any reference to a Class of shares might be construed as a reference to a Sub-Fund if the context so

requires.

Art. 8. Restriction on ownership. The Fund may restrict or prevent the ownership of shares in the Fund by any person,

firm or corporate body.

More specifically, the Fund may restrict or prevent the ownership of shares in the Fund by any "U.S. person", as defined

hereafter. Each such person, firm or corporate body is herein referred to as «Prohibited Person»).

For such purposes the Fund may:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry

or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such share by a Prohibited Person,

b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares

on, the Register of Shareholders to furnish it with any representations and warranties or any information, supported by
affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not, to what extent and under which
circumstances, beneficial ownership of such shareholder's shares rests or will rest in Prohibited Person and

c) where it appears to the Fund that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a

beneficial owner of shares or is in breach of its representations and warranties or fails to make such representations and
warranties as the Board of Directors may require, compulsorily purchase from any such shareholder all or part of the
shares held by such shareholder in the following manner:

1) The Fund shall serve a notice (hereinafter called the "Purchase Notice") upon the shareholder appearing in the

Register of Shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as aforesaid,
the price to be paid for such shares, and the place at which the purchase price in respect of such shares is payable. Any
such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to
such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Fund. The said shareholder shall thereupon
forthwith be obliged to deliver to the Fund the share certificate or certificates representing the shares specified in the
Purchase Notice. Immediately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such shareholder
shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and his name shall be removed as to such shares in the
Register of Shareholders.

2) The price at which the shares specified in any Purchase Notice shall be purchased (herein called "the Purchase

Price") shall be an amount equal to the per share Net Asset Value of shares in the Fund, determined in accordance with
Article 24 hereof.

3)  Payment  of  the  Purchase  Price  will  be  made  to  the  owner  of  such  shares,  except  during  periods  of  exchange

restrictions, and will be deposited by the Fund with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase
notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified
in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such Purchase
Notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Fund or its assets in respect
thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without
interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any funds receivable

104652

L

U X E M B O U R G

by a shareholder under this Article, but not collected within a period of five years from the date specified in the Purchase
Notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the Sub-fund relating to the relevant Class or Classes of Shares.

The Board of Directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and

to authorize such action on behalf of the Fund.

4) The exercise by the Fund of the powers conferred by this article shall not be questioned or invalidated in any case

on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of
any shares was otherwise than appeared to the Fund at the date of any purchase notice, provided that in such case the
said powers were exercised by the Fund in good faith; and

d) decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Fund.
Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" shall mean national, citizen or resident of the United States

of America or of any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction or persons who are normally
resident therein including the estate of any such person, or corporations, partnerships, trusts or any other association
created or organised therein.

The Board of Directors may, from time to time, amend or clarify the aforesaid meaning.
In addition to the foregoing, the Board of Directors may restrict the issue and transfer of shares of a Sub-Fund or a

Class of shares to institutional investors within the meaning of Article 174 of the Law ("Institutional Investor(s)"). The
Board of Directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares of a Sub-Fund
or Class of shares reserved for Institutional Investors until such time as the Fund has received sufficient evidence that
the applicant qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of shares of a Class of shares
reserved to Institutional Investors is not an Institutional Investor, the Board of Directors will convert the relevant shares
into shares of a Class of the relevant Sub-Fund or of another Sub-Fund which is not restricted to Institutional Investors
(provided that there exists such a Class and/or a Sub-Fund with similar characteristics) or compulsorily redeem the
relevant shares in accordance with the provisions set forth above in this Article. The Board of Directors will refuse to
give effect to any transfer of shares and consequently refuse for any transfer of shares to be entered into the Register of
Shareholders in circumstances where such transfer would result in a situation where shares of a Class restricted to
Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an Institutional Investor. In addition
to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Institutional Investor, and who holds
shares in a Class restricted to Institutional Investors, shall hold harmless and indemnify the Fund, the Board of Directors,
the other shareholders of the Fund and the Fund's agents for any damages, losses and expenses resulting from or con-
nected to such holding circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation
or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has
failed to notify the Fund of its loss of such status.

Art. 17. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks,

have power to determine the corporate and investment policy and the course of conduct of the management and business
affairs of the Fund.

The Board of Directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the in-

vestments of the Fund in accordance with Part I of the Law.

The Board of Directors may decide that investment of the Fund be made (i) in transferable securities and money

market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law, (ii) in transferable securities and
money market instruments dealt in on another market in a member state of the European Union which is regulated,
operated regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities and money market instruments
admitted to official listing in Eastern and Western Europe, Africa, the American continents, Asia, Australia and Oceania
or dealt in on another market in the countries referred to above, provided that such market is regulated, operates regularly
and is recognized and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities and money market instruments
provided that the terms of the issue include an undertaking that an application will be made for admission to official listing
on any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such listing is secured
within one year of the issue, as well as (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as
shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales
documents of the Fund.

The Board of Directors of the Fund may decide to invest under the principle of risk-spreading up to 100 % of the total

net assets of each Sub-Fund of the Fund in different transferable securities and money market instruments issued or
guaranteed by any member state of the European Union, its local authorities, a non-member state of the European Union,
as  acceptable  by  the  Luxembourg  supervisory  authority  and  disclosed  in  the  sales  documents  of  the  Fund  or  public
international bodies of which one or more of member states of the European Union are members, provided that in the
case where the Fund decides to make use of this provision the relevant Sub-Fund must hold securities from at least six
different issues and securities from any one issue may not account for more than 30 % of such Sub-Fund's total net assets.

The Board of Directors may decide that investments of the Fund be made in financial derivative instruments, including

equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Law and/or financial derivative
instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by

104653

L

U X E M B O U R G

Article 41 (1) of the Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Fund may
invest according to its investment objectives as disclosed in the sales documents of the Fund.

The Board of Directors may decide that investments of the Fund be made so as to replicate a certain stock or bond

index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority as having a sufficiently
diversified composition, is an adequate benchmark and is clearly disclosed in the sales documents of the Fund.

The Board of Directors will not invest more than 10% of the assets of a Sub-Fund in units of undertakings for collective

investments as defined in article 41 (1) e) of the Law unless otherwise provided specifically for a Sub-Fund in the sales
document of the Fund. For the purpose of the application of this investment limit, each Sub-Fund of a UCI with multiple
Sub-Funds within the meaning of Article 181 of the Law is to be considered as a separate issuer provided that the principle
of segregation of the obligations of the various compartments vis-à-vis third parties is ensured.

Investments made in units of UCIs other than UCITS may not in aggregate exceed 30% of the assets of the Fund.

<i>Second resolution

The Meeting decided to insert three new paragraphs in article 12 of the Articles of Incorporation which shall now

read as follows:

Art. 12. Convening of General Meetings. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors, pursuant to

notice setting forth the agenda sent by mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's
address in the Register of Shareholders. It may also be called upon the request of shareholders representing at least one
fifth of the Share capital.

Notice shall be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg and in a Luxembourg

newspaper to the extent required by Luxembourg law, and in such other newspapers as the Board of Directors may
decide.

A shareholder may participate at any meeting of shareholders by visioconference or any other means of telecommu-

nication allowing to identify such shareholder. Such means must allow the shareholder to effectively act at such meeting
of shareholders, the proceedings of which must be retransmitted continuously to such shareholder.

By derogation to the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Fund is not required to send

the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the management report to the registered
shareholders at the same time as the convening notice to the annual general meeting. The convening notice shall indicate
the  place  and  practical  arrangements  for  providing  these  documents  to  the  shareholders  and  shall  specify  that  each
shareholder  may  request  that  the  annual  accounts,  as  well  as  the  report  of  the  approved  statutory  auditor  and  the
management report are sent to him.

The convening notices to general meetings of shareholders may provide that the quorum and the majority at the

general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on
the fifth day prior to the general meeting (referred to as "Record Date"). The rights of a shareholder to attend a general
meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this
shareholder at the Record Date.

<i>Third resolution

The Meeting decided to update Article 23 of the Articles of Incorporation in order to add a new case of suspension

of the Net Asset Value calculation and of the issue, conversion and redemption of shares during any period when any
Sub-Fund of the Fund is a feeder of a master UCITS which is itself entitled to suspend the redemption or subscription of
its shares, whether at its own initiative or at the request of its competent authorities.

Article 23 will henceforth read as follows:

Art. 23. Suspension of the Net Asset Value calculation and of the issue, Conversion and Redemption of shares. For

the purpose of determination of the issue, redemption and conversion prices, the Net Asset Value of shares in the Fund
shall be determined as to the shares of each Class of shares by the Fund from time to time, but in no instance less than
twice monthly, as the Board of Directors by regulation may direct (every such day or time for determination of Net Asset
Value being referred to herein as a "Valuation Day"), provided that in any case where any Valuation Day would fall on a
day observed as a holiday by banks in Luxembourg or in any other place to be determined by the Board of Directors,
such Valuation Day shall then be the next bank business day following such holiday.

The Fund may suspend the determination of the Net Asset Value of shares of any particular Class and the issue and

redemption of its shares from its shareholders as well as conversion from and to shares of each Class during:

a) any period when any of the principal stock exchanges or organized markets on which any substantial portion of the

investments of the Fund attributable to such Sub-Fund from time to time are quoted or dealt in is closed otherwise than
for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended;

b) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposals or valuation of

assets owned by the Fund attributable to such Sub-Fund would be impracticable; or

104654

L

U X E M B O U R G

c) any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the

investments of such Sub-Fund or the current price or values on any stock exchange in respect of the assets attributable
to such Sub-Fund; or

d) any period when the Fund is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of

the shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments
or payments due on redemption of shares cannot in the opinion of the directors be effected at normal rates of exchange;
or

e) as soon as the decision to liquidate one or more Sub-Fund is taken or in the case of the Fund's dissolution; or
f) any period when any Sub-Fund of the Fund is a feeder of a master UCITS which is itself entitled to suspend the

redemption or subscription of its shares, whether at its own initiative or at the request of its competent authorities; the
determination of the Net Asset Value of shares and the issue, redemption and conversion of shares shall be suspended
within the same period of time as the master UCITS.

Any such suspension shall be publicized, if appropriate, by the Fund and shall be notified to shareholders requesting

purchase of their shares by the Fund at the time of the filing of the written request for such purchase as specified in Article
twenty-two hereof.

Such suspension as to any Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the Net Asset Value, the issue, redemption

and conversion of the shares of any other Sub-Fund.

Any request for subscription, redemption or conversion shall be irrevocable except in the event of a suspension of

the determination of the Net Asset Value per Share.

<i>Fourth resolution

The Meeting decided to update article 29 (renamed 28) of the Articles of Incorporation in accordance with Chapter

8 of the 2010 Law concerning mergers.

Article 28 will henceforth read as follows:

Art. 28. Dissolution, Liquidation, Merger. In the event of a dissolution of the Fund, liquidation shall be carried out by

one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation cor-
responding  to  each  Class  of  shares  shall  be  distributed  by  the  liquidators  to  the  holders  of  shares  of  each  Class  in
proportion of their holding of shares in such Class.

A Sub-Fund may be dissolved by compulsory redemption of shares of the Sub-Fund concerned, upon
a) a decision of the Board of Directors if the net assets of the Sub-Fund concerned have decreased below Euro 1

million or the equivalent in another currency during a certain period of time as disclosed in the prospectus of the Fund,
or if it is required by the interests of the shareholders concerned, or

b) the decision of a meeting of holders of shares of the relevant Sub-Fund. There shall be no quorum requirement and

decisions may be taken by a simple majority of the shares of the Sub-Fund concerned.

In such event the shareholders concerned will be advised and the net asset value of the shares of the relevant Sub-

Fund shall be paid on the date of the compulsory redemption. The relevant meeting may also decide that assets attributable
to the Sub-Fund concerned will be distributed on a prorata basis to the holders of shares of the relevant Sub-Fund which
have expressed the wish to receive such assets in kind.

A meeting of holders of shares of a Sub-Fund may decide to amalgamate such Sub-Fund with another existing Sub-

Fund  in  the  Fund  or  to  contribute  the  assets  (and  liabilities)  of  the  Sub-Fund  to  another  undertaking  for  collective
investment against issue of shares of such undertaking for collective investments to be distributed to the holders of shares
of Sub-Fund. If such amalgamation or contribution is required by the interests of the shareholders concerned, it may be
decided by the Board of Directors.

However, for any merger where the merging fund would cease to exist, the merger must be decided by a meeting of

shareholders of the merging fund deciding in accordance with the quorum and majority requirements provided by law.

Should the Fund cease to exist following a merger, the effective date of the merger must be recorded by notarial deed.
Insofar as a merger requires the approval of shareholders pursuant to the provisions above, only the approval of the

shareholders of the sub-fund concerned shall be required.

Any merger is subject to prior authorisation by the CSSF which shall be provided with specific information as described

in Article 67 of the Law, and, in particular, with the common draft terms of the proposed merger duly approved by the
merging fund and the receiving fund.

The common draft terms of the proposed merger shall set out particulars precisely listed in Article 69 of the Law

including but not limited to:

a) an identification of the type of merger and of the funds involved,
b) the background to and the rationale for the proposed merger,
c) the expected impact of the proposed merger on the shareholders of both the merging and the receiving fund,

104655

L

U X E M B O U R G

d) the criteria adopted for valuation of the assets and, where applicable, the liabilities on the date for calculating the

exchange ratio,

e) the calculation method of the exchange ratio,
f) the planned effective date of the merger,
g) the rules applicable to the transfer of assets and the exchange of shares, respectively, and
h) as the case may be, the Instruments of Incorporation of the newly constituted receiving fund.
In accordance with Article 70 of the Law, the depositaries of the merging and the receiving funds, insofar as they are

established in Luxembourg, must verify the conformity of the particulars with the requirements of the Law and the
Instruments of Incorporation of their respective fund.

In accordance with Article 71 of the Law, the merging fund established in Luxembourg shall entrust either an approved

statutory auditor or, as the case may be, and independent auditor.

A copy of the reports of the approved statutory auditor or, as the case may be, the independent auditor shall be made

available on request and free of charge to the shareholders of both the merging and the receiving fund and to their
authoritive competent authorities.

Shareholders of the merging and the receiving fund shall be provided with appropriate and accurate information on

the proposed merger so as to be able to make an informed judgment of the impact of the merger on their investment.

The decision shall be published upon the initiative of the Fund. The publication shall contain information about the

new Sub-Fund or the relevant undertaking for collective investment and shall be made at least thirty days before the last
date for requesting redemption or, as the case may be, conversion without any charge other than those retained by the
Fund to meet disinvestment costs . The shareholders right to request redemption or, as the case may be, conversion of
their shares shall become effective from the moment that the shareholders of the merging fund and those of the receiving
fund have been informed of the proposed merger in accordance with the above paragraph and shall cease to exist five
working days before the date for calculating the exchange ratio.

Once this period elapses, the decision to merge becomes binding on all shareholders who have not yet availed them-

selves of the above-mentioned facility.

For such Sub-Fund meetings, there shall be no quorum requirement and decisions may be taken by a simple majority

of the shares of the Sub-Fund concerned.

In case of an amalgamation with an unincorporated mutual fund (fonds commun de placement) or a foreign collective

investment undertaking, decisions of the Sub-Fund meeting of the Sub-Fund concerned shall be binding only for holders
of shares that have voted in favour of such amalgamation.

If following a compulsory redemption of all shares of one or more Sub-Funds payment of the redemption proceeds

cannot be made to a former shareholder, then the amount in question shall be deposited with the Caisse de Consignations
within 9 (nine) months following the decision of liquidation for the benefit of the person(s) entitled thereto until the
expiry of the period of limitation. The close of liquidation of one or more Sub-Funds or Classes shall in principle also take
place within 9 (nine) months from the Board of Directors' decision to liquidate the Sub-Funds or Classes.

If there have been created, as more fully described in Article 5 hereof, within the same Sub-Fund two or several Classes,

the dissolution rules set out above shall apply, mutatis mutandis, to such Classes of shares.

Where funds have designated a management company, legal, advisory or administrative costs associated with the

preparation of the merger shall not be charged to the merging or receiving fund, or to any of their shareholders.

Further details on cross-border as well as domestic funds/sub-funds mergers are disclosed in Chapter 8 of the 2010

Law.

In the event that the Board of Directors determines that it is required by the interests of the shareholders of the

relevant Sub-Fund or that a change in the economical or political situation relating to the Sub-Fund concerned has occurred
which would justify it, the reorganization of one Sub-Fund, by means of a division into two or more Sub-Funds, may be
decided by the Board of Directors. Such decision will be published in the same manner as described above and, in addition,
the publication will contain information in relation to the two or more new Sub-Funds. Such publication will be made
within one month before the date on which the reorganization becomes effective in order to enable the shareholders to
request redemption of their shares, free of charge before the operation involving division into two or more Sub-Funds
becomes effective.

<i>Fifth resolution

The Meeting decided to insert a new Article 29 in the Articles of Incorporation offering the possibility for one Sub-

Fund of the Fund to invest in one or more other Sub-Funds of the Fund according to article 181(8) of the 2010 Law;.

Article 29 will henceforth read as follows:

Art. 28. Investment in one or more other Sub-Funds of the Fund. Pursuant to Article 181 (8) of the Law, any sub-fund

of the Fund may subscribe, acquire and/or hold securities to be issued or issued by one or more sub-funds of the Fund
without the Fund being subject to the requirements of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,

104656

L

U X E M B O U R G

with respect to the subscription, acquisition and/or the holding by a company of its own shares, under the conditions
however that:

- the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this target Sub-Fund; and
- no more than 10% of the assets that the target Sub-Funds whose acquisition is contemplated may be invested in

shares of other target Sub-Funds of the Fund; and

- voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund

concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and

- in any event, for as long as these securities are held by the Fund, their value will not be taken into consideration for

the calculation of the net assets of the Fund for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed
by the 2010 Law; and

- there is no duplication of management, subscription or repurchase fees between those at the level of the Sub-Fund

of the Fund having invested in the target Sub-Fund, and this target Sub-Fund.

<i>Sixth resolution

The Meeting decided to insert of a new Article 30 in the Articles of Incorporation on master-feeder structures as

detailed in Chapter 9 of the 2010 Law.

Article 30 will henceforth read as follows:

Art. 30. Master-feeder structures. Subject to the respect of the provisions of the Law, the Fund or one of its sub-fund

may become either a feeder or a master Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities ("UCITS").

1. Scope and approval
A feeder UCITS is a UCITS, or any of its sub-funds, which has been approved to invest, by way of derogation, at least

85% of its assets in shares of another UCITS or any of its sub-funds (the "Master UCITS").

A feeder UCITS may hold up to 15% of its assets in one or more of the following:
a) ancillary liquid assets;
b) financial derivatives instruments, which may be used only for hedging purposes;
c) movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of its business, if the feeder UCITS is an

investment company.

A master UCITS is a UCITS, or one of its sub-funds, which:
a) has among its shareholders, at least one feeder UCITS;
b) is not itself a feeder UCITS; and
c) does not hold units of a feeder UCITS.
The investment of a feeder UCITS which is established in Luxembourg into a given master UCITS shall be subject to

the  prior  approval  of  the  Luxembourg  Supervisory  Authority,  the  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier
("CSSF").

The CSSF shall grant approval if the feeder UCITS, its depositary and its approved statutory auditor, as well as the

master UCITS, comply with all the requirements set out in Chapter 9 of the Law.

2. Common provisions for feeder and master UCITS
The master UCITS must provide the feeder UCITS with all documents and information necessary for the latter to

meet the requirement laid down in the Law. For this purpose, the feeder UCITS shall enter into an agreement with the
master UCITS.

That agreement shall be made available, on request and free of charge, to all shareholders.
In the event that both master and feeder UCITS are managed by the same management company, the agreement may

be replaced by internal conduct of business rules.

The master and the feeder UCITS shall take appropriate measures to coordinate the timing of their net asset value

calculation and publication, in order to avoid market timing in their units, preventing arbitrage opportunities.

If a master UCITS temporarily suspends the repurchase, redemption or subscription of its shares, whether at its own

initiative or at the request of its competent authorities, each of its feeder UCITS is entitled to suspend the repurchase,
redemption or subscription of its shares within the same period of time as the master UCITS.

If a master UCITS is liquidated, the feeder UCITS shall also be liquidated, unless the CSSF approves:
a) the investment of at least 85% of the assets of the feeder UCITS in shares of another master UCITS; or
b) the amendment of the Instruments of Incorporation of the feeder UCITS in order to enable it to convert into a

UCITS which is not a feeder UCITS.

Without prejudice to specific provisions regarding compulsory liquidation, the liquidation of a master UCITS shall take

place no sooner than three months after the master UCITS has informed all of its shareholders and the CSSF of the
binding decision to liquidate.

104657

L

U X E M B O U R G

If a master UCITS merges with another UCITS or is divided into two or more UCITS, the feeder UCITS shall be

liquidated, unless the CSSF grants approval to the feeder UCITS to:

a) continue to be a feeder UCITS of the master UCITS or another UCITS resulting from the merger or division of the

master UCITS;

b) invest at least 85% of its assets in units of another master UCITS not resulting from the merger or the division; or
c) amend its Instruments of Incorporation in order to convert into a UCITS which is not a feeder UCITS.
No merger or division of a master UCITS shall become effective, unless the master UCITS has provided all of its

shareholders and the CSSF with the information referred to, or comparable to that referred to, in Article 72 of the Law,
at least sixty days before the proposed effective date.

Unless the CSSF has granted approval pursuant to point a) above, the master UCITS shall enable the feeder UCITS to

repurchase or redeem all shares in the master UCITS before the merger or division of the master UCITS becomes
effective.

3. Depositaries and approved statutory auditors
If the master and the feeder UCITS have different depositaries and/or approved statutory auditors, those depositaries

and/or approved statutory auditors must enter into an information-sharing agreement in order to ensure the fulfilment
of the duties of both depositaries and/or approved statutory auditors.

The feeder UCITS shall not invest in units of the master UCITS until such agreement has become effective.
The depositary of the master UCITS shall immediately inform the competent authorities of the master UCITS home

Member State, the feeder UCITS or, where applicable, the management company and the depositary of the feeder UCITS,
about any irregularities it detects with regard to the master UCITS, which are deemed to have a negative impact on the
feeder UCITS.

In its audit report, the approved statutory auditor of the feeder UCITS shall take into account the audit report of the

master UCITS. If the feeder and the master UCITS have different accounting years, the approved statutory auditor of the
master UCITS shall make an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS.

The approved statutory auditor of the feeder UCITS shall, in particular, report on any irregularities revealed in the

audit report of the master UCITS and on their impact on the feeder UCITS.

4. Compulsory information and marketing communications by the feeder UCITS
Specific information as detailed in the Law shall be disclosed in the feeder UCITS Prospectus and marketing commu-

nications.

5. Conversion of existing UCITS into feeder UCITS and change of master UCITS
A feeder UCITS, which already pursues activities as a UCITS, including those of a feeder UCITS of a different master

UCITS, must provide some information to its shareholders which benefit from a one month prior notice period to request
the repurchase or redemption of their shares without any charges other than those retained by the UCITS to cover
disinvestment costs.

6. Obligations and competent authorities
The feeder UCITS must monitor effectively the activity of the master UCITS. In performing that obligation, the feeder

UCITS may rely on information and documents received from the master UCITS, or, where applicable, its management
company, depositary and approved statutory auditor, unless there is a reason to doubt their accuracy.

Where, in connection with an investment in the shares of the master UCITS, a distribution fee, commission or other

monetary benefit, is received by the feeder UCITS, its management company, or nay person acting on behalf of either
the feeder UCITS or the management company of the feeder UCITS, the fee, commission or other monetary benefit
must be paid into the assets of the feeder UCITS.

Any master UCITS established in Luxembourg shall immediately inform the CSSF of the identity of each feeder UCITS,

which invest in its shares. If the feeder is established in another Member State, the CSSF shall immediately inform the
competent authorities of the feeder UCITS home Member State of such investment.

The master UCITS shall not charge subscription or redemption fees for the investment of the feeder UCITS into its

shares or the disinvestment thereof.

The master UCITS must ensure the timely availability of all information that is required in accordance with the Law,

and any other laws, regulations and administrative provisions applicable in Luxembourg, Community law provisions, as
well  as  the  Instruments  of  Incorporations  of  the  UCITS  to  the  feeder  UCITS  or,  where  applicable,  its  management
company, and to the competent authorities, the depositary and the approved statutory auditor of the feeder UCITS.

Further details on master-feeder structures may be found in Chapter 9 of the Law.

<i>Seventh resolution

The Meeting decided to amend the Articles of Incorporation so that:
a) The term "Company" and "Corporation" be replaced by the one of "Fund";
b) The terms "Class" and "Sub-Class" be replaced by the ones of "Sub-Funds" or "Category", depending on the context;
c) The Meeting finally decided to formally reorganize the Articles of Incorporation.

104658

L

U X E M B O U R G

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

<i>Fees

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company, as a result of this

document are estimated at EUR 1750.-.

The documents having been read to the Meeting, the members of the bureau of the Meeting, all of whom are known

to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with Us, the Notary, the present
original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Signé: C. Joller, L. Gorlini, P. Zamperini, et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 août 2012. LAC/2012/39618. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2012.

Référence de publication: 2012110566/497.
(120149842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

PHM Investment (USD) 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PHM Topco 18 S.à r.l.).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 169.748.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2012.

Référence de publication: 2012099596/11.
(120136740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

L.O.F.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Schmiede/Huldange, 3, Op d'Schmett.

R.C.S. Luxembourg B 171.102.

STATUTS

L'an deux mil douze, le vingt et un août.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange,

ONT COMPARU:

1) Monsieur HARDY François, né à Libramont le 10 juin 1981, de nationalité belge, indépendant, domicilié et demeurant

à B-6660 HOUFFALIZE Avenue de la Gare, 19

2) Madame OTTO Leslie, née à Bastogne le 24 juin 1982, de nationalité belge, indépendante, domiciliée et demeurant

à B-6660 HOUFFALIZE Avenue de la Gare, 19

Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme

qu'elles déclarent constituer par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de «L.O.F.H. S.A.».

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Troisvierges. Par simple décision du conseil d'administration, la

société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Lu-
xembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente, l'import et l'export de tous types de matières textiles, total look homme

et femme, prêt à porter dans leur sens le plus large et de tous leurs dérivés ainsi que le service à façon y afférent. Elle
pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires
et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elles s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle peut ac-

104659

L

U X E M B O U R G

complir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rappor-
tant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise. Elle peut emprunter et donner garantie
sous toutes les formes.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,00€), représenté par cents (100) actions

d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310,-€) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, sous réserve telles que prévues par les disposition légales.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, l'administrateur restant de la catégorie a le droit d'y pourvoir provi-

soirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Cependant, si la société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des

actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué
par la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Chaque référence contenue dans les présents statuts et faite au conseil d'administration est une référence à l'admi-

nistrateur unique pour le cas où il n'existe qu'un seul actionnaire et aussi longtemps que la société ne dispose que d'un
seul actionnaire.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. Sous
réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un ver-
sement d'acomptes sur dividendes.

Le conseil d'administration doit désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut

être conférée à un administrateur présent. Le premier Président du Conseil d'Administration sera par exception nommé
par l'assemblée générale extraordinaire suivant la constitution de la société.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d'Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaire/administrateurs ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale

des actionnaires.

La société se trouve engagée à l'égard de tiers:
a. par la signature individuelle de l'administrateur unique pour le cas où il n'existe qu'un seul actionnaire
b. par la signature individuelle de chaque administrateur pour le cas où la société est gérée par un conseil d'adminis-

tration.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mai à 10.00 heures du matin

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

104660

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 12. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.

<i>Souscription et Libération

Les actions sont intégralement souscrites comme suit:

1) Monsieur HARDY François, né à Libramont le 10 juin 1981, de nationalité belge, indépendant,
domicilié et demeurant à B-6660 HOUFFALIZE Avenue de la Gare, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 actions

2) Madame OTTO Leslie, née à Bastogne le 24 juin 1982, de nationalité belge, indépendante, domiciliée
et demeurant à B-6660 HOUFFALIZE Avenue de la Gare, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 actions

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 actions

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000,-€), laquelle somme

est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Les parties comparantes déclarent avoir connaissance des dispositions légales régissant les actions non entièrement

libérées.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille six cent cinquante
(1.650,-) euros.

Toutefois, à l'égard du notaire instrumentant toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes recon-

naissent  être  solidairement  et  indivisiblement  tenues  du  paiement  des  frais,  honoraires  et  dépenses  relatives  aux
présentes.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée:
- Monsieur HARDY François, né à Libramont le 10 juin 1981, de nationalité belge, indépendant, domicilié et demeurant

à B-6660 HOUFFALIZE Avenue de la Gare, 19

- Madame OTTO Leslie, née à Bastogne le 24 juin 1982, de nationalité belge, indépendante, domiciliée et demeurant

à B-6660 HOUFFALIZE Avenue de la Gare, 19

- La société de droit belge NUITS NOBLES SPRL, ayant sont siège social à B-6660 Houffalize (Belgique), 19, avenue

de la Gare, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous les numéro BCE 0867.446.947

ayant comme représentant permanent Madame OTTO Leslie, née à Bastogne le 24 juin 1982, de nationalité belge,

indépendante, domiciliée et demeurant à B-6660 HOUFFALIZE Avenue de la Gare, 19

Est nommé administrateur-délégué pour une durée indéterminée:
Monsieur HARDY François, né à Libramont le 10 juin 1981, de nationalité belge, indépendant, domicilié et demeurant

à B-6660 HOUFFALIZE Avenue de la Gare, 19

104661

L

U X E M B O U R G

La société est engagée en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle d'un

administrateur.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de SIX ans:
Monsieur HARDY Jean-Marie demeurant à 4, Rue du Parc L-8380 KLEINBETTINGEN
4.- Le siège social est établi à Centre Commercial «KNAUF CENTER», 3, Op d'Schmett, L-9964 Schmiede/Huldange.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. HARDY, L. OTTOK. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 août 2012. Relation: EAC/2012/11149. Reçu soixante-quinze euros 75.-

<i>Le Receveur

 (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, LE 28 août 2012.

Référence de publication: 2012111288/148.
(120150363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.

e-Novate International, Société en Commandite par Actions,

(anc. e-Traction Worldwide).

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 95.204.

In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of July.
Before Maître Roger Arrendsdorff, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of e-Traction Worldwide, a partnership

limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
95.204 (the "Company"). The Company was incorporated pursuant to a deed enacted by Maître Paul Frieders, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 17 July 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 947 on 15 September 2003.

The Meeting is presided by Me Vivian Walry, attorney-at-law in Luxembourg, with professional address in 70, route

d'Esch, L-1470 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Me Katarina Birosova, attorney-at-law in Luxembourg, with professional address

in 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Me Vivian Walry, prenamed.
The chairman requests the notary to act that:
I. The names of the shareholders and the number of shares held by them are indicated in an attendance list signed by

the present shareholders, by the proxies of the shareholders represented and by the members of the Meeting; such
attendance list as well as the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the appearing parties and
the undersigned notary, will remain attached to the original of this deed for registration purposes.

II. It appears from the said attendance list that one (1) participating management share of a par value of seventeen euro

thirty cent (EUR 17.30) and eight thousand five hundred thirty-three (8.533) ordinary shares with a par value of seventeen
euro thirty cent (EUR 17.30) each, representing more than 50% of the capital, are present or represented at the Meeting.
The Meeting was duly convened in accordance with the Company's articles of association and is therefore validly con-
stituted and may validly resolve on its agenda.

III. The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Change of the name of the Company into e-Novate International;
2. Subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company;
3. Granting of discharge to Mr. Adrianus Johannes Heinen and Mrs. Karin Heinen-Kruizinga.
After consideration of the foregoing, the Meeting takes the following resolutions, unanimously:

<i>First resolution

The Meeting decides to change the name of the Company into e-Novate International.

104662

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Meeting decides to amend article 1 of the Company's articles of

association so as to read as follows:

Art. 1. Name and Form. There is hereby established between the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter issued, a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name of e-
Novate International.

e-Novate International shall be referred to in these articles of association as the "Partnership". All documents drafted

by the Partnership and destined to third parties, such as letters, invoices or publications, must bear the registered name
of the Partnership followed by "Société en commandite par actions", the address of the registered office of the Partnership
and the initials R. C. S. followed by the number under which the Partnership is registered with the Luxembourg company
register."

<i>Third resolution

Subject to Auction Completion, the Meeting decides to grant Mr. Adrianus Johannes Heinen and Mrs. Karin Heinen-

Kruizinga full discharge regarding the due performance of their duties as members of supervisory board of the Company.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

deed are estimated at approximately seven hundred twenty-five euros (EUR 725,-).

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows and understands English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le treizième jour du mois de juillet.
Par devant Maître Roger Arrensdorff, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire Assemblée») des actionnaires de e-Traction Worldwide, une société

en commandite par actions, ayant son siège social au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.204 (la Société). La
Société a été constituée suivant un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg le 17 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 947, le 15
septembre 2003.

L'Assemblée est présidée par Me Vivian Walry, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 70, route d'Esch,

L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Me Katarina Birosova, Avocat, avec adresse professionnelle au 70, route d'Esch,

L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Me Vivian Walry, prénommé. Le président demande au notaire d'acter que:
I. Les noms des actionnaires et le nombre d'actions détenues par eux sont inscrits dans une liste de présence signée

par des actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les membres de l'Assemblée; cette
liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés signée «ne varietur» par les parties comparantes
et le notaire soussigné resteront annexées à l'original de cet acte.

II. Il apparaît de ladite liste de présence qu'une part de gérant commandité d'une valeur nominale de dix-sept euros et

trente cents (EUR 17.30) et huit mille cinq cent trente-trois (8.533) actions d'une valeur nominale de dix-sept euros et
trente cents (EUR 17.30) chacune représentant plus de la moitié du capital, sont présentes ou représentées à l'Assemblée.
L'Assemblée a été dûment convoquée conformément aux statuts de la Société et est donc valablement constituée et peut
valablement décider sur son ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Changement de la dénomination de la Société en e-Novate International;
2. Modification consécutive de l'article 1 des statuts de la Société;
3. Décharge à M. Adrianus Johannes Heinen and Mme Karin Heinen-Kruizinga.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Assemblée, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la Société en e-Novate International.

104663

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

En conséquence des déclarations précédentes, l'Assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société pour

lui donner la teneur suivante;

«  Art. 1 

er

 . Dénomination et Forme.  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires

par la suite des actions ci-après créées, une société en commandite par actions sous la dénomination d'e-Novate Inter-
national.

Dans les présents statuts, la société en commandite par actions e-Novate International sera désignée comme la Société.

Tous les documents dressés par la Société et destinés à des tiers, comme par exemple des lettres, des factures ou
publications, doivent contenir la dénomination sociale de la Société suivie de la mention société en commandite par
actions, l'adresse du siège social de la Société et les initiales R.C.S. suivi du numéro sous lequel la société en commandite
par actions est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés»

<i>Troisième résolution

Sous réserve de l'accomplissement des enchères, l'assemblée décide d'accorder décharge pleine et entière à M. Adria-

nus Johannes Heinen et à Mme Karin Heinen-Kruizinga dans le cadre de leur mandat de membres du conseil de surveillance
de la société.

<i>Frais

Les frais, coûts, taxes et charges, sous quelque forme que ce soir, devant être payés par la Société en tant que résultat

de cet acte sont estimés approximativement à sept cent vingt-cinq euros (EUR 725,-).

A la suite de laquelle le présent acte a été rédigé à Luxembourg, au jour qu'en tête en début de ce document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent

acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français; le
texte anglais fera foi.

Lecture ayant été faite de ce document aux personnes comparantes, qui sont connues du notaire par leurs noms de

famille, prénoms, états civils et résidence, lesdites personnes signent ensemble avec nous, notaire, l'original du présent
acte.

Signé: VALRY, BIROSOVA, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2012. Relation: LAC/2012/33438. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivré aux fins de la publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2012.

Référence de publication: 2012098951/121.
(120136657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

ACRON Lux Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 170.549.

In the year two thousand and twelve, on twentieth day of July.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

“ACRON Lux Invest S.à r.l.”, a limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office

at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under Luxembourg law
on 3 November 2011, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 164.659,
whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21 December
2011 and whose last amendments of the articles of incorporation took place on 2 March 2012 and were published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 26 March 2012,

here represented by Mr Christian Lennig, Rechtsanwalt, professionally residing in L-1011 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 12 July 2012, under private seal, which, initialled ne varietur by the proxy

holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities. Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacity, has requested the
notary to draw up the following articles of incorporation of a limited liability company (société à responsabilité limitée),
governed by the relevant laws and the present articles of incorporation:

104664

L

U X E M B O U R G

Preliminary Title - Definitions

In these Articles of Incorporation, the following shall have the respective meaning set out below:

"Law of 10 August 191 5"

the Luxembourg law of 10 August 1915 relating to commercial companies, as
amended from time to time

"Law of 13 February 2007"

the Luxembourg law of 13 February 2007" relating to specialised investment funds,
as the same may be amended from time to time

"Articles of Incorporation"

the articles of incorporation of the Company, as the same may be amended from
time to time

"Bank Business Day"

each day upon which the banks are open for business in Luxembourg

"Board"

In case of plurality of Managers the board of Managers of the Company

"Manager"

The manager or in case of plurality of managers, a manager appointed to the Board
or as the case may be a member of the Board

"Share(s)"

means the shares issued by the Company and any share issued in exchange for those
shares or by way of conversion or reclassification, and any share representing or
deriving from those shares as a result of any increases in or reorganization or
variation of the capital of the Company

"Shareholder"

means a holder of Shares.

ARTICLES OF INCORPORATION

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by the present and all persons and entities who may become Shareholders in the future

a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of ACRON Lux Management S.à r.l. (hereinafter
referred to as the "Company").

Art. 2. The Company’s corporate object is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,

financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences,
to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances
or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The  Company  may,  in  particular,  act  as  general  partner  (associé  gérant  commandité)  of  "ACRON  Real  Estate

Portfolio" (the "Fund"), a Luxembourg investment company with variable capital - specialised investment fund governed
by Luxembourg laws and incorporated under the legal form of a partnership limited by shares (société en commandite
par actions) and of any other undertakings for collective investment established under the form of partnerships limited
by shares.

The Company shall carry out any activities connected with its status of general partner of the Fund or of any other

undertakings for collective investment established under the form of partnerships limited by shares. The Company can
perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly with all areas as described
above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. Branches

or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Manager or in case of plurality
of Managers, by resolution of the Board, after having received Shareholders consent.

In the event that the Manager or in case of plurality of Managers, the Board, determines that extraordinary political

or military developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office abroad, will remain a Luxembourg company.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The Company’s capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred

(100) Shares of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-) each. The one hundred (100) Shares have all been fully
paid in cash.

The capital may be increased or reduced by a resolution of the single Shareholder or by resolution of the Shareholders

of the Company adopted in accordance with Article 20 hereof.

Shares will only be issued in registered form and will be inscribed in the register of Shares, which is held by the Company

or by one or more persons on behalf of the Company. Such register of Shares shall set forth the name of each Shareholder,
his residence or elected domicile, the number and class of Shares held by him. In case of a single Shareholder, the Shares
held by the single Shareholder are freely transferable.

104665

L

U X E M B O U R G

In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law of 10 August 1915.

Title III. Shareholder meetings

Art. 6. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company shall represent the entire body of

Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of Company.

Art. 7. In case of a single Shareholder, the single Shareholder assumes all powers conferred to the Shareholders’

meeting. Any resolutions to be taken by the single Shareholder may be taken in writing. In case of plurality of Shareholders,
the provisions of Article 8 will apply to any resolution to be taken by a meeting of Shareholders. Each Share is entitled
to one vote.

A Shareholder may be represented (at any meeting of Shareholders) by another person, which does not need to be a

Shareholder and which may be a Manager. The proxy established to this effect may be in writing or by cable, telegram,
facsimile or e-mail transmission.

Art. 8. If legally required or if not so required upon the decision of the Manager or in case of plurality of Managers,

the Board, annual general meetings of Shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law,
in Luxembourg at the registered office of the Company, or such other place in Luxembourg as may be specified in the
notice of the meeting. Such annual general meetings may be held abroad if, in the judgement of the Manager or in case
of plurality of Managers, the Board, exceptional circumstances so require.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Board, may convene other meetings of Shareholders to be held

at such place and time as may be specified in the respective notices of meetings.

The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Shareholders of

the Company, unless otherwise provided herein.

Except as otherwise required by law or provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will

be passed by simple majority of the votes cast by those Shareholders present and voting.

The general meeting of Shareholders shall be called by the Manager or in case of plurality of Managers, the Board, by

notices containing the agenda and which will be published as required by law. The Manager or in case of plurality of
Managers, the Board, will prepare the agenda, except if the meeting takes place due to the written request of Shareholders
provided for by law; in such case the Manager or in case of plurality of Managers, the Board, may prepare an additional
agenda.

If all of the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The matters dealt with by the meeting of Shareholders are limited to the issues contained in the agenda which must

contain all issues prescribed by law as well as to issues related thereto, except if all the Shareholders agree to another
agenda. In case the agenda should contain the nomination of Managers or of the auditor, the names of the eligible Managers
or of the auditors will be inserted in the agenda.

Title IV. Administration

Art. 9. The Company shall be managed by one or more Manager(s). If several Managers have been appointed, they will

constitute a Board. The Manager(s) need not be Shareholders of the Company.

The Manager(s) shall be elected by the general meeting of Shareholders for a period as determined by such general

meeting of Shareholders and until their successors are elected and take up their functions. Upon expiry of its mandate,
a Manager may seek reappointment. The Manager(s) mandate may be revoked at any time with or without a reason by
the general meeting of Shareholders.

Art. 10. The Board shall choose from among its members a chairman.
The chairman shall preside at all meetings of the Board but in his absence or incapacity to act, the Managers present

may appoint anyone of their number to act as chairman for the purposes of the meeting. The Manager or in case of
plurality of Managers, the Board may also choose a secretary, who need not be a Manager and who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Board, may from time to time appoint officers of the Company,

including a managing director, a general manager and any assistant managers or other officers considered necessary for
the operation and management of the Company. Officers need not be Managers or Shareholders of the Company. The
officers appointed, unless otherwise stipulated herein, shall have the powers and duties given to them by the Manager or
in case of plurality of Managers, the Board.

The Board shall meet upon call by the chairman, or any two Managers, at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice, containing an agenda which sets out any points of interest for the meeting, of any meeting of the Board

shall be given to all Managers at least eight (8) Bank Business Day prior to the beginning of such meeting, except in
circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.

104666

L

U X E M B O U R G

This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, facsimile or e-mail transmission of each Manager.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the Board.

Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing, in writing or by telegram, facsimile or e-mail trans-

mission, another Manager as his proxy.

Any Manager who is not physically present at the location of a meeting may participate in such a meeting of the Board

by remote conference facility or similar means of communication equipment, whereby all persons participating in the
meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.

The Board can deliberate or act validly only if at least two Managers are present or represented at a meeting of the

Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented. In case of a deadlock,
the chairman shall have the casting vote.

Resolutions signed by all Managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such

signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters,
telegrams, facsimile or e-mail transmissions.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro

tempore who presided at such meeting or by any two Managers.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman or by any two Managers or by a Manager together with the secretary or the alternate secretary.

Art. 11. The Manager or in case of plurality of Managers, the Board, shall have power to determine the course and

conduct of the management and business affairs of the Company.

It is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the interests of the

Company. All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Incorporation to the general meeting of
Shareholders fall within the competence of the Manager or in case of plurality of Managers, the Board.

Art. 12. The Company shall be bound by the sole signature of its single Manager, or in case of plurality of Managers,

by the joint signature of any two Managers of the Company, or by the joint signature of any person(s) to whom such
signatory authority has been delegated by the Manager or in case of plurality of Managers, by the Board, together with
one Manager.

Art. 13. The Manager or in case of plurality of Managers, the Board, may delegate its powers to conduct the daily

management and affairs of the Company, including the right to sign on behalf of the Company, and its powers to carry
out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Company or to other persons, which at
their turn may delegate their powers if they are authorised to do so by the Manager or in case of plurality of Managers,
the Board.

Art. 14. No contract or other transaction which the Company and any other company or firm might enter into shall

be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or officers of the Company is interested in
such other company or firm by a relation, or is a director, officer or employee of such other company or legal entity.

In the event that any Manager or officer of the Company may have any personal interest in any contract or transaction

of the Company other than that arising out of the fact that he is a Manager, officer or employee or holder of securities
or other interests in the counterparty, such Manager or officer shall, in case of plurality of Managers, make known to the
Board such personal interest and shall not consider or vote upon any such contract or transaction. Such contract or
transaction, and such Manager’s or officer’s personal interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting
of Shareholders.

Art. 15. The Company may indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against

expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of
which the Company is a shareholder or a creditor and which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Title V. Accounting, Distributions

Art. 16. The operations of the Company and its financial situation as well as its books shall be supervised by one or

more auditor(s) qualifying as réviseur d'enterprises agréé(s). The auditor(s) shall be elected by the Shareholders at the
annual general meeting of Shareholders for a period which shall end on the day of the following annual general meeting
of Shareholders which decides upon the appointment of its (their) successor(s).

Art. 17. The accounting year of the Company shall begin on 1st January and shall terminate on 31 December of each

year.

104667

L

U X E M B O U R G

Art. 18. From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
capital of the Company as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time in accordance with
Article 5 hereof.

The general meeting of Shareholders shall decide each year how the remainder of the annual net profit shall be allocated

and may declare dividends from time to time or instruct the Manager or in case of plurality of Managers, the Board, to
do so.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Board, may within the conditions set out by law unanimously

resolve to pay out interim dividends.

Title VII. Winding up, Liquidation

Art. 19. In the event of a winding-up of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators.

Liquidators may be physical persons or legal entities and are named by the meeting of Shareholders deciding such winding-
up and which shall determine their powers and their compensation.

Title VIII. Amendments

Art. 20. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to

the respect of the quorum and majority requirements provided by Luxembourg law.

Art. 21. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law

of 10 August 1915 and the Law of 13 February 2007.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31

December 2012.

<i>Subscription and Payment

The capital of the Company is subscribed as follows:
“ACRON Lux Invest S.à r.l.”, above named, subscribes for one hundred (100) Shares, resulting in a total payment in

cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

Evidence of the above payment was given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately

thousand euro.

<i>General Meeting of Shareholders

The above named party representing the entire subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting,

passed the following resolutions:

- The following are elected as Managers for an unlimited duration:
* Mr Cristian Federico Canis (Chairman of the Board), professionally residing at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

* Mr Jean Wantz, professionally residing at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg; and

* Mr Peer Bender, professionally residing at Mörsenbroicher Weg 181, D-40470 Düsseldorf, Germany.
- The following is elected as independent auditor for a term to expire at the close of the annual general meeting of

Shareholders which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2012:

«BDO Audit S.A.», 2, avenue Charles de Gaulle, L-1203 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (RCS Luxembourg,

section B number 147 570 ).

- The registered office of the Company is set at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the above named

person, this deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing person, in
case of divergence between the English and the German versions, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the notary by her surname,

name, civil status and residence, said proxy holder signed together with us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden englischen Textes.

Im Jahre zweitausendzwölf, am zwanzigsten Juli.

104668

L

U X E M B O U R G

Vor Uns Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in SASSENHEIM, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

„ACRON Lux Invest S.à r.l.“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in

121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet unter Luxemburger Recht am
3. November 2011, registriert beim Registre de Commerce et des Sociétés unter der Nummer B 164.659, deren Satzung
im  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  am  21.  Dezember  2011  veröffentlicht  wurde  und  deren  letzte
Satzungsänderung am 2. März 2012 stattgefunden hat, welche am 26. März 2012 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations veröffentlicht wurde,

hier vertreten durch Herrn Christian Lennig, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in L-1011 Luxemburg,
aufgrund einer am 12. Juli 2012 in Luxemburg, privatschriftlich erteilten Vollmacht, die von der Erschienenen und dem

unterzeichnenden Notar "ne varietur" unterzeichnete Vollmacht bleibt dieser Urkunde beigefügt und ist zusammen mit
dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.

Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienene hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung (articles

of incorporation) einer den einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu Protokoll zu nehmen:

Einleitender Titel - Definitionen

In dieser Satzung haben die folgenden Begriffe, die ihnen im Folgenden jeweils zugeordnete Bedeutung:

"Gesetz vom 10. August 1915" Das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in

seiner jeweils geltenden Fassung;

"Gesetz vom 13. Februar 2007" Das luxemburgische Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte

Investmentfonds in seiner jeweils geltenden Fassung;

"Satzung"

Die vorliegende Satzung in seiner jeweils geltenden Fassung;

"Geschäftstag"

Ein voller Tag, an dem die Banken in Luxemburg für die üblichen Geschäfte geöffnet
sind;

"Rat der Geschäftsführung"

Sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der
Gesellschaft;

"Geschäftsführer"

Der Geschäftsführer, oder sofern mehrere bestellt sind, einer der gemäß dieser
Satzung zum Mitglied des Rates der Geschäftsführung bestellten Geschäftsführer
bzw. ein Mitglied des Rates der Geschäftsführung;

"Gesellschaftsanteil(e)"

Die von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile sowie im Tausch gegen solche Anteile
oder aufgrund einer Umwandlung oder Reklassifizierung ausgegebene Anteile sowie
Anteile, die aufgrund von Kapitalerhöhungen, Umwandlungen oder Reklassifizierung
oder Veränderungen des Kapitals für diese Anteile stehen oder aus ihnen
hervorgehen; und

"Gesellschafter"

Ein Inhaber von Anteilen.

SATZUNG

Abschnitt I. Name, Zweck, Dauer, Sitz

Art. 1. Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen ACRON Lux Management S.à r.l.
(nachstehend "Gesellschaft" genannt) gegründet.

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist es, Beteiligungen in jedweder Form an Handels-, Industrie-, Finanz-oder anderen

Unternehmen, seien es Luxemburgische oder ausländische, zu erwerben; Wertpapiere und Rechte durch Beteiligungen,
Einbringung, Zeichnung, den Erwerb von Betrieben oder Optionen, Übertragungen oder auf andere Art zu erwerben und
namentlich Patente und Lizenzen zu erwerben, zu verwalten und zu entwickeln; Unternehmen, an denen die Gesellschaft
eine Beteiligung hält, jedwede Unterstützung, Darlehen, Vorteile oder Garantien zu gewähren und schließlich jede Maß-
nahme durchzuführen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck verbunden ist.

Die  Gesellschaft  darf  insbesondere  als  Komplementärin  (associé  gérant  commandité)  des  "ACRON  Real  Estate

Portfolio" (der "Fonds") fungieren, einer Luxemburgischen Fondsgesellschaft mit variablem Kapital spezialisierter Invest-
mentfonds nach den Gesetzen Luxemburgs und gegründet in der Rechtsform einer partnership limited by shares (société
en commandite par actions), sowie jedes anderen Organismus für gemeinsame Anlagen der in Form einer partnership
limited by shares errichtet wurde.

Die Gesellschaft soll alle Tätigkeiten, die mit ihrer Stellung als Komplementärin des Fonds oder eines anderen Orga-

nismus für gemeinsame Anlagen in Form einer société en commandite par actions ausführen.

Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, technischen oder finanziellen Tätigkeiten ausführen, die direkt oder indirekt

mit allen oben beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erfüllung ihres Zweckes zu fördern.

Art. 3. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

104669

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Niederlassungen oder Büros

können aufgrund eines Beschlusses des Geschäftsführers oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, aufgrund
eines Beschlusses des Rates der Geschäftsführung gegründet werden, wobei solche Beschlussfassungen unter dem Vor-
behalt der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafter stehen.

Für den Fall, dass ein Geschäftsführer, oder sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung

befindet oder befinden, dass außergewöhnliche politische oder militärische Umstände eingetreten sind oder unmittelbar
bevorstehen, die die üblichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz stören oder die Kommunikation zwischen dem
Sitz und im Ausland ansässigen Personen erschweren könnten, kann der Sitz vorübergehend solange ins Ausland verlagert
werden, bis die außergewöhnlichen Umstände nicht mehr vorherrschen. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlagerung ihres Sitzes ins
Ausland eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht bleibt.

Abschnitt II. Kapital, Gesellschaftsanteile

Art. 5. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) festgelegt und in einhundert

(100) Gesellschaftsanteile mit einem Wert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) je Anteil aufgeteilt.

Die einhundert (100) Gesellschaftsanteile sind vollständig eingezahlt.
Das Kapital kann aufgrund eines gemäß Artikel 20 dieser Satzung getroffenen Beschlusses des Alleingesellschafters

oder der Gesellschafter der Gesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.

Gesellschaftsanteile werden nur als Namensanteile ausgegeben und sind ins Anteilsregister einzutragen, das von der

Gesellschaft oder von einer oder mehreren Personen im Namen der Gesellschaft geführt wird. In diesem Anteilsregister
wird der Name des Gesellschafters, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort, die Nummer und die Klasse der
von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile vermerkt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, sind die von dem Alleingesellschafter gehaltenen Gesellschafts-

anteile frei übertragbar.

Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsan-

teile gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 übertragen werden.

Abschnitt III. Gesellschafterversammlungen

Art. 6. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter der Gesellschaft gilt als Vertretung sämtlicher

Gesellschafter der Gesellschaft. Sie verfügt über größtmögliche Befugnisse, mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
verbundene Handlungen anzuordnen, durchzuführen oder zu bewilligen.

Art. 7. Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, stehen diesem sämtliche der Gesellschafterversammlung

übertragenen Befugnisse zu. Von dem Alleingesellschafter zu fassende Beschlüsse können schriftlich gefasst werden.

Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, gelten die Bestimmungen von Artikel 8 für sämtliche von einer

Gesellschafterversammlung zu fassenden Beschlüsse.

Jeder Gesellschaftsanteil gewährt eine Stimme.
Ein Gesellschafter kann sich (auf Gesellschafterversammlungen) von einer anderen Person vertreten lassen, die kein

Gesellschafter sein muss und ein Geschäftsführer sein kann. Eine zu diesem Zweck gewährte Vollmacht kann schriftlich,
per Telegramm, per Fernschreiben, per Fax oder E-Mail erteilt werden.

Art. 8. Sofern kraft Gesetz erforderlich oder, andernfalls, aufgrund einer Entscheidung des Geschäftsführers oder,

sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, des Rates der Geschäftsführung, werden die jährlichen Gesellschafterver-
sammlungen der Gesellschaft gemäß luxemburgischem Recht am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder einem anderen,
in der Einladung zur Versammlung genannten Ort abgehalten. Solche jährlichen Gesellschafterversammlungen können im
Ausland abgehalten werden, wenn der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der
Geschäftsführung dies aufgrund des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände für erforderlich hält.

Der Geschäftsführer, oder sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung, können wei-

tere Gesellschafterversammlungen einberufen, die an den in den jeweiligen Einladungen genannten Orten und zu den
darin ebenfalls genannten Zeiten abgehalten werden.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung gelten im Hinblick auf die Fristen für Einladungen zu

Gesellschafterversammlungen und deren Beschlussfähigkeit die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Bestimmungen dieser Satzung sind auf einer ordnungs-

gemäß einberufenen Gesellschafterversammlung zu fassende Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen der anwesenden und sich an der jeweiligen Abstimmung beteiligenden Gesellschafter zu fassen.

Die jährlichen Gesellschafterversammlungen sind von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer

bestellt  sind,  vom  Rat  der  Geschäftsführung  durch  Versendung  von  Einladungen  einzuberufen,  die  die  Tagesordnung
enthalten und die gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu veröffentlichen sind.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung wird die Ta-

gesordnung erstellen, es sei denn, eine Versammlung findet auf schriftliches Verlangen der Gesellschafter gemäß den

104670

L

U X E M B O U R G

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen statt; in einem solchen Fall kann der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere
Gesellschafter bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung eine weitere Tagesordnung erstellen.

Sofern bei einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie

über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann eine Versammlung ohne vorherige Einladung oder
Veröffentlichung abgehalten werden.

Die Angelegenheiten, die von einer Gesellschafterversammlung behandelt werden, sind auf die in der Tagesordnung

genannten Punkte zu beschränken, wobei alle gesetzlich vorgeschriebenen und mit diesen zusammenhängende Punkte zu
behandeln sind, es sei denn, alle Gesellschafter einigen sich auf eine andere Tagesordnung. Sofern die Bestellung von
Geschäftsführern oder eines Abschlussprüfers auf der Tagesordnung steht, sind die Namen der zur Wahl stehenden
Geschäftsführer oder Abschlussprüfer in die Tagesordnung aufzunehmen.

Abschnitt IV. Verwaltung

Art. 9. Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Geschäftsführern geführt. Sofern mehrere

Geschäftsführer bestellt sind, bilden sie einen Rat der Geschäftsführung.

Der bzw. die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
Der bzw. die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung für einen von dieser bestimmten Zeitraum

gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und ihr Amt übernehmen. Nach Ablauf seiner Amtszeit kann sich ein Ge-
schäftsführer wieder zur Wahl stellen.

Der bzw. die Geschäftsführer können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne die Angabe von

Gründen ihres Amtes enthoben werden.

Art. 10. Der Rat der Geschäftsführung ernennt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.
Der Vorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Versammlungen der Geschäftsführer der Gesellschaft. Sofern der Vor-

sitzende bei einer Versammlung abwesend oder nicht handlungsfähig ist, können die Geschäftsführer aus ihrer Mitte einen
Vorsitzenden für die Zwecke der jeweiligen Versammlung ernennen.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann einen

Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Führung des Protokolls von Versammlungen des Rates
der Geschäftsführung und von Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann jeweils

Bevollmächtigte („Officers“) der Gesellschaft ernennen, einschließlich eines Managing Directors, eines General Managers,
eines Assistant Managers oder sonstiger Bevollmächtigte, die im Hinblick auf den Betrieb und die Verwaltung der Ge-
sellschaft  für  erforderlich  gehalten  werden.  Bevollmächtigte  müssen  keine  Geschäftsführer,  oder  Gesellschafter  der
Gesellschaft sein. Die ernannten Bevollmächtigte haben die ihnen von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Ge-
schäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.

Der Rat der Geschäftsführung versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern an

dem in der jeweiligen Einladung genannten Ort.

Sämtlichen Geschäftsführern ist mindestens acht (8) Geschäftstage vor Beginn einer solchen Versammlung eine schrift-

liche Einladung zusammen mit einer Tagesordnung zu übermitteln, in der sämtliche Geschäftsordnungspunkte aufgeführt
sind. Von dieser Frist kann in dringenden Ausnahmefällen abgewichen werden, in denen die näheren Umstände in der
Einladung auszuführen sind. Auf eine Einladung kann verzichtet werden, sofern sämtliche Geschäftsführer einer solchen
Verfahrensweise schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zustimmen. Für einzelne Versammlungen, deren Zeit und
Ort vorab durch Gesellschafterbeschluss festgelegt worden sind, ist keine weitere Einladung erforderlich.

Geschäftsführer können sich bei Versammlungen des Rates der Geschäftsführung vertreten lassen, indem sie einen

anderen Geschäftsführer schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zu ihrem Vertreter ernennen.

Geschäftsführer, die an einem Versammlungsort nicht physisch anwesend sind, können an einer Versammlung des

Rates der Geschäftsführung per Konferenzschaltung oder auf einem ähnlichen Kommunikationsweg teilnehmen, wobei
sich alle Teilnehmer einer solchen Versammlung gegenseitig hören können müssen, und eine Teilnahme an einer solchen
Versammlung kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.

Eine Versammlung der Geschäftsführer der Gesellschaft kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens

zwei Geschäftsführer bei einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse
sind mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer zu fassen. Im Falle eines Patts hat der
Vorsitzende die entscheidende Stimme.

Von sämtlichen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse sind genauso gültig und wirksam wie bei einer ordnungs-

gemäß  einberufenen  und  abgehaltenen  Versammlung  gefasste  Beschlüsse.  Solche  Unterschriften  können  auf  einem
einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen eines Beschlusses gezeichnet sein und können per Brief, Tele-
gramm, Fax oder E-Mail erfolgen.

Das Protokoll von Versammlungen der Geschäftsführer der Gesellschaft ist von dem Vorsitzenden oder, sofern dieser

abwesend ist, von dem stellvertretenden, nur für die jeweilige Versammlung ernannten Vorsitzenden oder von zwei
Geschäftsführern zu unterzeichnen.

104671

L

U X E M B O U R G

Kopien von oder Auszüge aus solchen Protokollen, die gegebenenfalls in Gerichtsverfahren oder bei anderen Gele-

genheiten vorgelegt werden, sind von dem Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäftsführer
gemeinsam mit dem Sekretär oder dem stellvertretenden Sekretär zu unterzeichnen.

Art. 11. Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung ist

befugt, die Richtung und Art der Geschäftsführung und der Geschäfte der Gesellschaft festzulegen.

Der Geschäftsführer bzw. der Rat der Geschäftsführung ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um

sämtliche im Interesse der Gesellschaft stehenden Verwaltungshandlungen und -verfügungen vorzunehmen. Sämtliche
Befugnisse, die nicht kraft Gesetzes oder gemäß dieser Satzung ausdrücklich der jährlichen Gesellschafterversammlung
zugewiesen sind, werden vom Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Ge-
schäftsführung ausgeübt.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers verpflichtet oder, sofern

mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern der Gesellschaft,
oder durch die gemeinsame Unterschrift einer Person oder mehrerer Personen, auf die ein solches Zeichnungsrecht
durch den Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch den Rat der Geschäftsführung
übertragen worden ist, zusammen mit mindestens einem Geschäftsführer.

Art. 13. Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann

seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich des Rechts, für die Gesellschaft zu
zeichnen, sowie seine Befugnisse, Handlungen zur Förderung der Unternehmenspolitik und des Gesellschaftszwecks vor-
zunehmen,  an  Bevollmächtigte  der  Gesellschaft  oder  andere  Personen  übertragen,  die  wiederum  berechtigt  sind,
Untervollmachten zu erteilen, sofern sie von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind,
vom Rat der Geschäftsführung hierzu ermächtigt worden sind.

Art. 14. Verträge oder andere Transaktionen der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder einem anderen

Unternehmen  bleiben  unberührt  und werden  nicht unwirksam,  wenn einer oder mehrere der  Geschäftsführer oder
Bevollmächtigte der Gesellschaft aufgrund persönlicher Beziehungen ein Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder
diesem anderen Unternehmen hat oder haben oder dort Geschäftsführer oder Bevollmächtigter oder Mitarbeiter ist
oder sind.

Falls ein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft möglicherweise aus anderen Gründen als aufgrund

des Umstands, dass er Geschäftsführer, Bevollmächtigter, Mitarbeiter oder Inhaber von Wertpapieren oder sonstigen
Beteiligungen des anderen Unternehmens ist, ein persönliches Interesse an einem Vertrag oder einer Transaktion der
Gesellschaft hat, wird der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, den Rat
der Geschäftsführung von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und von einer Beteiligung an Beschlussfas-
sungen hinsichtlich eines solchen Vertrags oder einer solchen Transaktion absehen. Die jeweils nächste Gesellschafter-
versammlung  ist  von  einem  solchen  Vertrag  oder  einer  solchen  Transaktion  und  dem  persönlichen  Interesse  des
betreffenden Geschäftsführers oder Bevollmächtigten zu unterrichten.

Art. 15. Die Gesellschaft kann einen Geschäftsführer oder Bevollmächtigter, seine Erben, Testamentsvollstrecker oder

Nachlassverwalter für angemessene Kosten schadlos halten, die diesem oder diesen in Zusammenhang mit einem An-
spruch, einer Klage oder einem Verfahren entstanden sind, die möglicherweise auf der jetzigen oder früheren Tätigkeit
des Betreffenden als Geschäftsführer oder Bevollmächtigte für die Gesellschaft oder für eine andere Gesellschaft beruhen,
sofern dies verlangt wird, deren Gesellschafter oder Gläubiger die Gesellschaft ist, wenn der Betreffende insoweit keinen
anderen Schadloshaltungsanspruch hat; dies gilt nicht, wenn der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte wegen grober
Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird; wird ein Vergleich geschlossen, erfolgt die Schadloshaltung nur
bezüglich solcher vom Vergleich erfassten Punkte, bezüglich derer – laut Auskunft eines Rechtsberaters gegenüber der
Gesellschaft – keine Pflichtverletzung der schadlos zu haltenden Person vorliegt. Das vorstehende Recht auf Schadlos-
haltung schließt andere, dem Geschäftsführer oder Bevollmächtigten möglicherweise zustehende Rechte nicht aus.

Abschnitt V. Buchhaltung, Ausschüttung von Dividenden

Art. 16. Die Geschäfte der Gesellschaft, ihre finanzielle Situation sowie ihre Bücher werden von einem (oder mehreren)

Abschlussprüfer(n) überwacht, bei denen es sich um reviseur d'enterprises agréé(s) handelt. Der Abschlussprüfer (oder
die  Abschlussprüfer)  wird  von  den  Gesellschaftern  bei  der  jährlichen  Gesellschafterversammlung  für  einen  Zeitraum
bestimmt, der am Tage der nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung endet, die über die Bestellung des Nachfolgers
oder der Nachfolger entschieden wird.

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 18. Von dem Jahresüberschuss der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die gesetzlich vorgeschriebenen

Reserven eingestellt. Diese Zuführung von Geldern endet, sobald und solange die Reserven bei zehn Prozent (10 %) des
Kapitals der Gesellschaft gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder dem gegebenenfalls gemäß Artikel 5 dieser Satzung herau-
foder herabgesetzten Betrag liegen.

104672

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich über die Verwendung des Jahresüberschusses; sie kann ggf. Divid-

enden festsetzen oder den Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, den Rat der Geschäfts-
führung anweisen, dies zu tun.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann im ge-

setzlich vorgesehenen Rahmen einstimmig die Ausschüttung von Interimdividenden beschließen.

Abschnitt VII. Auflösung, Liquidation

Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Bei

den Liquidatoren kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, die von der Gesellschafterversammlung
bestellt werden, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren bestimmt.

Abschnitt VIII. Änderungen

Art. 20. Diese Satzung kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung geändert werden, wenn diese beschlussfähig

ist und die nach luxemburgischem Recht erforderlichen Mehrheiten erreicht werden.

Art. 21. Alle Fragen, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 und dem

Gesetz vom 13. Februar 2007 zu beantworten.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.

<i>Zeichnung und Zahlung

Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:
Die oben genannte ACRON Lux Invest S.à r.l., zeichnet einhundert (100) Gesellschaftsanteile gegen Bareinzahlung von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-).

Der Nachweis über diese Zahlung wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.

<i>Kosten

Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf tausend Euro.

<i>Gesellschafterversammlung

Als Inhaberin des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft fasst die oben genannte Partei in Ausübung der der

Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse:

- Die folgenden Personen werden für unbestimmte Zeit, als Geschäftsführer bestellt:
* Herr Cristian Federico Canis (Vorsitzender des Rats der Geschäftsführung), mit beruflicher Anschrift in 121, avenue

de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

* Herr Jean Wantz, mit beruflicher Anschrift in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg; und

* Herr Peer Bender, mit beruflicher Anschrift in Mörsenbroicher Weg 181, D-40470 Düsseldorf, Deutschland.
- Als unabhängiger Abschlussprüfer wird für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafter-

versammlung, die über den Jahresabschluss zum 31 Dezember 2012:

*  «BDO  Audit  S.A.»,  2, avenue  Charles  de  Gaulle,  L-1203  Luxemburg,  Großherzogtum  Luxemburg  bestellt (RCS

Luxembourg, section B number 147570).

- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend

genannten Person die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung;
auf Wunsch der vorstehend genannten Person ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen Fassung
die englische Fassung maßgeblich.

Daraufhin wurde der vorstehende Akt in Luxemburg zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.
Nachdem der Text dem Bevollmächtigten der Erschienenen vorgelesen wurde, dessen Vor- und Nachname, Status

und Wohnsitz dem Notar bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von dem Bevollmächtigten der
Erschienenen gemeinsam mit Uns Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: R. ADOLPHS, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 29. Dezember 2010. Relation: EAC/2010/16904. Erhalten fünfundsiebzig Euro

(75.- EUR).

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2012098989/517.
(120136686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

104673

L

U X E M B O U R G

Ermitage Thematic Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 136.799.

In the year two thousand and twelve, on the eighteenth day of the month of July.
Before Maître Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared :

Me Laetitia Chaniol, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as a special proxy of Ermitage Global Wealth

Management Strategies Fund Limited, a company established under the laws of Jersey, having its registered office at 1 

st

Floor, 47 The Esplanade, St Helier, Jersey JE1 9LB and registered with the Jersey Financial Services Commission in Jersey
under number 98206, by virtue of a proxy given under private seal dated 13 July 2012 which, after having been signed ne
varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be registered
together therewith, being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Ermitage Thematic Fund,a société d'investis-
sement  à  capital  variable  –  fonds  d'investissement  spécialisé  established  under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of
Luxembourg, having its registered office at 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, registered with the Registre
de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 136.799, incorporated by deed of Maître Joëlle Baden,
notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 20 February 2008, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 655 of 17 March 2008 (the “Company”).

The proxyholder declared and requested the notary to record:
I. That the Sole Shareholder holds all the registered shares in issue in the Company, so that decisions can validly be

taken by it on the items below.

II. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. To put the Company into liquidation.
2. To appoint Deloitte Tax &amp; Consulting, represented by Mr Michael Martin as liquidator (the “Liquidator”) and to

define the powers and remuneration of the Liquidator.

3. To authorise the Liquidator to effect payment of the liquidation proceeds in cash or in kind subject to the consent

of the beneficiaries thereof.

Consequently, the following resolutions have been passed:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to put the Company into liquidation, effective on the date of this notarial deed.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to appoint Deloitte Tax &amp; Consulting,a société à responsabilité limitée, having its

registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, represented by Mr Michael Martin residing at 560, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg as Liquidator.

The largest powers and especially those determined by articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on

commercial companies, as amended, are granted to the Liquidator by the Sole Shareholder. The Liquidator may execute
the acts and operations specified by article 145 without any special authorisation of the Sole Shareholder even in the case
where it is normally required by law.

The Liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
The Liquidator may, under its own responsibility, delegate for certain determined operations, the whole or part of its

powers to one or more proxies.

The Liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered

by chartered accountants.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to authorise the Liquidator to effect payment of the liquidation proceeds in cash or in

kind, subject to the consent of the beneficiaries thereof.

The undersigned notary who understands and speaks English, records that the present deed is worded in English.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
After having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.

Signé: L. CHANIOL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35337. Reçu douze euros (12,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

104674

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 août 2012.

Référence de publication: 2012099228/59.
(120136676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

PHM Investment Holdings (USD) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PHM Holdco 17 S.à r.l.).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 168.089.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2012.

Référence de publication: 2012099598/11.
(120136733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Tesa Participations R.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 80.668.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 12 juillet 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions,

a déclaré closes pour absence d'actifs les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée:
TESA PARTICIPATIONS R.H. S.à r.l., dont le siège social à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey, a été dénoncé

en date du 15 juillet 2005.

Pour extrait conforme
Me Anthony BRAESCH
<i>Avocat à la Cour

Référence de publication: 2012099740/17.
(120136343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

PHM Investment Sisterco (USD) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PHM Holdco 18 S.à r.l.).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 169.750.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2012.

Référence de publication: 2012099599/11.
(120136736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

SDK Ungarn SA, Société Anonyme.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.

R.C.S. Luxembourg B 132.183.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012099690/10.
(120136250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

104675

L

U X E M B O U R G

Sphinx Luxco D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 137.765,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 163.925.

Les comptes annuels pour la période du 30 septembre 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2012.

Référence de publication: 2012099668/11.
(120136114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Safinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 66.330.

Il résulte des décisions prises par l’assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 20 juin 2012 que:
- la démission de Maître Philippe STROESSER en tant qu’Administrateur de la Société est acceptée.
- Madame Colette AMOS, Administrateur de société, née le 14/09/1933 à Grenoble (France), demeurant à F-75 116

Paris, 26, rue Dufrenoy

* Madame Anne-Marie AMOS, épouse CHANINE, Administrateur de société, née le 24/08/1959 à Neuilly-sur-Seine

(France), demeurant à F-92100 Boulogne-Billancourt, 12, avenue Charles de Gaulle

* Monsieur Eric AMOS, Administrateur de société, né le 26/07/1958 à Neuilly-sur-Seine, demeurant à F-33000 Bor-

deaux, 58, rue de la Course

sont nommés en tant qu’Administrateurs de la Société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale se tenant en 2017.
- Madame Colette AMOS est nommée en tant qu’Administrateur-délégué de la Société jusqu’à l’issue de l’assemblé

générale se tenant en 2017.

Luxembourg, le 20 juin 2012

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2012099674/22.
(120136458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Fortuna (Universal) SA Soparfi, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1540 Luxembourg, 36, rue Benjamin Franklin.

R.C.S. Luxembourg B 170.541.

STATUTS

L'an deux mil douze, le six juillet.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

- Monsieur Marco PICCO, administrateur de société, demeurant à L-5821 Howald, 10, rue de l'Ermitage,
Lesquels comparants, ont requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent con-

stituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: FORTUNA (UNIVERSAL) SA SOPARFI.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement

par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la dispa-
rition desdits événements.

104676

L

U X E M B O U R G

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à l'objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension ou le développement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions de

trente et un euros (EUR 31,-) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son

sein mais qui peut être administrée par un administrateur unique dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Ils
sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs et dans le cas d'une société

anonyme unipersonnelle par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne à ce
déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier pour finir le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 10 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

- Marco PICCO, préqualifié, mille parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Total: mille parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, de sorte que le capital social au

montant de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

104677

L

U X E M B O U R G

<i>Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ HUIT CENT CINQUANTE EUROS (850.- EUR).

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2013.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-

dinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1). Est nommé aux fonctions d'admi-

nistrateur:

- Monsieur Marco PICCO, administrateur de société, demeurant à L-5821 Howald, 10, rue de l'Ermitage.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
- La société G.S.L. FIDUCIAIRE S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-4281 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland,

immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 134.601,

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.

<i>Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-1540 Luxembourg, 36, rue Benjamin Franklin.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des

présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: PICCO, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2012. Relation: LAC/2012/32046. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signe): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivré aux fins de la publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2012.

Référence de publication: 2012099275/112.
(120136580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Samaya S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 43, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 131.518.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

104678

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 1 

er

 août 2012.

SAMAYA
Société anonyme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012099677/13.
(120135779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Samot S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 62.602.

Le bilan de la société au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012099678/12.
(120136430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

SBRE Neighbourhood Centre, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.129.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SBRE Neighbourhood Centre
SGG S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012099682/13.
(120136822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Sanary Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 107.042.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SANARY INVESTMENTS S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012099679/11.
(120136635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

SBRE Office, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.125.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SBRE Office
SGG S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012099683/13.
(120136791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

104679

L

U X E M B O U R G

SBRE Senden, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.127.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SBRE Senden
SGG S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012099684/13.
(120136611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

SBRE West German Portfolio Luxco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 119.533.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SBRE West German Portfolio Luxco
SGG S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012099685/13.
(120136563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Shipbourne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 72.831.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2012

Messieurs Freddy Bracke, Michel Jadot, Jozef Adriaens et Gary Walker sont renommés administrateurs.
La société BDO AUDIT S.A., réviseur d'entreprises agréé, est renommée réviseur aux comptes.
Les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Pour extrait conforme
Michel Jadot / Freddy Bracke
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012099698/14.
(120136744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Scalia s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 69, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 81.860.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012099686/9.
(120135813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Selected 4 You S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

R.C.S. Luxembourg B 162.795.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

104680

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2012099693/10.
(120135830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Sharmut Fashion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 111.303.

Monsieur Joseph WINANDY, Monsieur Koen LOZIE et la société COSAFIN S.A., représentée par Monsieur Jacques

BORDET ont démissionné de leur mandat d'administrateur de la société en date du 31 juillet 2012 avec effet immédiat.

FIDUPAR
Signatures

Référence de publication: 2012099696/11.
(120136630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Tredief S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 46.185.

<i>Extrait des délibérations portant de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du

<i>2 juillet 2012, de manière extraordinaire

<i>Décisions:

L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:
- de reconduire Messieurs Marc Muller, Jean-Pierre HIGUET et Alain NOULLET dans leurs mandats d’administrateurs

et DATA GRAPHIC S.A. dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires qui se tiendra en l’année 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012099761/17.
(120136036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Slainte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2738 Luxembourg, 13, rue Paul Wilwertz.

R.C.S. Luxembourg B 41.039.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le gérant

Référence de publication: 2012099702/10.
(120136537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Smart Fact S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 122.835.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2012099703/10.
(120136014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

104681

L

U X E M B O U R G

Société J. Ama S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4106 Esch-sur-Alzette, 23, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 81.343.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>La gérance

Référence de publication: 2012099705/10.
(120135833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Fa-

milial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 61.855.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012099706/10.
(120136593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Sociolab International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 30A, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 157.819.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012099708/9.
(120136817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Sopalux Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 25.173.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27/07/2012.

Sopalux Holding S.A.
Représentée par Stéphane HEPINEUZE
<i>Administrateur

Référence de publication: 2012099715/13.
(120136153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

SOPAF Asia S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 117.339.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012099714/9.
(120136282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Sopalux Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 25.173.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

104682

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27/07/2012.

Sopalux Holding S.A.
Représentée par Stéphane HEPINEUZE
<i>Administrateur

Référence de publication: 2012099716/13.
(120136154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

SOPARINTER GROUP Spf, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 31.667.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012099717/9.
(120136763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Soparlec Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 30.482.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012099719/9.
(120136759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

SORAMAT Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 31.010.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012099721/9.
(120136761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Sound and Video Supply S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 21.297.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2012099722/11.
(120136083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Synavic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 104.382.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SYNAVIC S.A.

Référence de publication: 2012099733/10.
(120136900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

104683

L

U X E M B O U R G

Spare Parts, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5730 Aspelt, 49A, rue de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 153.145.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2012099724/11.
(120137064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Stemma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 155.963.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour STEMMA S.à r.l.
Fideco Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012099725/12.
(120136905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Strada S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 69, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 81.708.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012099726/9.
(120135812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Tanarive Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 107.844.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique prises le 20 Juillet 2012

L'unique Associé de Tanarive Propertles S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Sjors van der Meer, né le 31 Octobre 1978 à Utrecht (Pays Bas), avec adresse profes-

sionnelle, au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 20
juillet 2012,

- de nommer Xavier De Cillia né le 11 Avril 1978 à Nice (France), avec adresse professionnelle au 2-8 Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 20 juillet 2012.

Le Conseil de Gérance se compose comme suit:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA.
Xavier De Cillia
Christelle Ferry

Luxembourg, le 20 Juillet 2012.

Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2012099736/22.
(120136719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

104684

L

U X E M B O U R G

Stroosseverkaf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3542 Dudelange, 65, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 30.116.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2012099727/13.
(120136889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Structurize S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 152.842.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012099728/9.
(120136001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Swiss Life Immo-Arlon, Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 23, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 84.344.

Le Bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012099732/9.
(120136188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Sonore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 133.658.

L'an deux mille douze.
Le vingt-six juin.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SONORE S.A., ayant son

siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 133658, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 7 novembre 2007, publié au Mémorial C numéro 2914 du 14 décembre 2007,

ayant un capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions avec une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée, demeurant professionnellement à L-1219

Luxembourg, 17, rue Beaumont.

La présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio FERNANDES,

employé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

104685

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution et mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:
Monsieur Robert REGGIORI, expert-comptable, né à Metz (France), le 15 novembre 1966, demeurant profession-

nellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la

loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette auto-
risation est normalement requise.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille cinquante euros, sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sophie ERK, Antonio FERNANDES, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juin 2012. Relation GRE/2012/2323. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012099712/55.
(120135910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Teekay European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 672.500,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 100.276.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2012.

Référence de publication: 2012099737/10.
(120136112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Transes International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 93.976.

Les comptes annuels au 31.12.11 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012099743/9.
(120136245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

104686

L

U X E M B O U R G

Teekay Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.301.500,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 100.277.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2012.

Référence de publication: 2012099738/10.
(120136113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

T.I.P. Technischer Industriebedarf Pickard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 19, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 139.648.

Im Jahre zweitausendzwölf, Den dritten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo GOEDERT, mit Amtswohnsitz in Grevenmacher,

Ist erschienen:

Frau Annette Maria FIEDLER, geborene Blau, selbstständig, geboren in Lorscheid (D) am 22. Februar 1961, wohnhaft

in D-54317 Thomm, 4, Ringstrasse,

- hier vertreten durch Herrn Wolfgang Matthias QUINT, Geschäftsführer, geboren zu Thomm (D), am 03. Juli 1958

(Identitätsnummer 19580703 510), wohnhaft zu D-54668 Ernzen, 3, Theisstrasse, auf Grund einer Vollmacht unter Pri-
vatschrift, gegeben zu D-Thomm am 2. Juli 2012,

welche Vollmacht, nach „ne varietur" Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden,

Welche Komparentin, hier vertreten wie vorgangs erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beur-

kunden: Frau Annette FIEDLER, vorgenannt, ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
T.I.P. Technischer Industriebedarf Pickard S.ä r.l., mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg, eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 139648,

gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den zu Echternach residierenden Notar Henri BECK, am 20. Juni 2008,

veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1750 vom 16. Juli 2008,

zum letzten Mal abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 1. Februar 2012, ve-

röffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 683 vom 14. März 2012.

Die Gesellschafterin erklärt eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersucht den amtierenden Notar

folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Einziger Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg,

nach L-6633 Wasserbillig, 19, route de Luxembourg, zu verlegen, mit Wirkung zum 1. August 2012.

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

WORUEBER URKUNDE, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt,
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Woh-

nort bekannte Komparentin, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: W. M. QUINT, C. GOEDERT.
Enregistré à Grevenmacher, le 03 juillet 2012. Relation: GRE/2012/2367. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): R. PETER.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister, und

zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Grevenmacher, den 26. Juli 2012.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2012099735/40.
(120136734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

104687

L

U X E M B O U R G

TetrArchitecture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6757 Grevenmacher, 3, rue de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 74.734.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2012099741/13.
(120136908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Transes Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 93.994.

Les comptes annuels au 31.12.11 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012099744/9.
(120136246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

TCA Event Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 155.932.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2012099747/10.
(120135861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Techhol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.670.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012099752/9.
(120136829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Versopa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 114.312.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour VERSOPA S.A.
Signatures

Référence de publication: 2012099781/11.
(120135773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

104688


Document Outline

10 Porte Neuve

ACRON Lux Management S.à r.l.

Arkess Sicav

BNP Paribas Focused Strategies Funds

Colruyt Gestion S.A.

e-Novate International

Ermitage Thematic Fund

e-Traction Worldwide

Fortuna (Universal) SA Soparfi

Happy Family I S.C.A.

Lilac Holding Lux S.à r.l.

L.O.F.H. S.A.

Matterhorn Topco &amp; Cy S.C.A.

PHM Holdco 17 S.à r.l.

PHM Holdco 18 S.à r.l.

PHM Investment Holdings (USD) S.à r.l.

PHM Investment Sisterco (USD) S.à r.l.

PHM Investment (USD) 1 S.à r.l.

PHM Topco 18 S.à r.l.

Safinvest S.A.

Samaya S.A.

Samot S.A.

Sanary Investments S.à r.l.

SBRE Neighbourhood Centre

SBRE Office

SBRE Senden

SBRE West German Portfolio Luxco

Scalia s.à.r.l.

SDK Ungarn SA

Selected 4 You S.à r.l.

Sharmut Fashion S.A.

Shipbourne S.A.

Slainte S.à r.l.

Smart Fact S.A.

Société J. Ama S.à.r.l.

Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A.

Sociolab International S.à r.l.

Sonore S.A.

SOPAF Asia S.àr.l.

Sopalux Holding S.A.

Sopalux Holding S.A.

SOPARINTER GROUP Spf, S.A.

Soparlec Spf S.A.

SORAMAT Spf S.A.

Sound and Video Supply S.A.

Spare Parts

Sphinx Luxco D S.à r.l.

Stemma S.à r.l.

Strada S.à r.l.

Stroosseverkaf S.à r.l.

Structurize S.à r.l.

Swiss Life Immo-Arlon

Synavic S.A.

Tanarive Properties S.à r.l.

TCA Event Holding S.à r.l.

Techhol S.A.

Teekay European Holdings S.à r.l.

Teekay Luxembourg S.à r.l.

Tesa Participations R.H., S.à r.l.

TetrArchitecture S.à r.l.

T.I.P. Technischer Industriebedarf Pickard S.à r.l.

Transes International S.A.

Transes Investments S.A.

Tredief S.A.

Versopa S.A.