This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 778
23 mars 2012
SOMMAIRE
ARN Investment Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37344
Cocalos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37321
Financom Venture S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
37320
G.O. II - Luxembourg Alfamar S.à r.l. . . . .
37344
Goya Airports S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37324
HC Holdings II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37331
Honeywell Luxembourg Finance S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37342
International Transatlantic Trading Servi-
ces S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37319
Intex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37319
Irman Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37319
ISDC Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37319
Islali Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37320
Italian Food Participations S.A. . . . . . . . . . .
37320
Japie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37322
Kharma Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .
37319
Kinove Luxembourg Coinvestment SCA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37298
Kronospan Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
37322
Lakey Corp S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37322
Lanz Lux LED S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37314
LA Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37323
LA Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37323
Lavipharm Group Holding . . . . . . . . . . . . . .
37323
Leverage Union for Techniques & Experti-
se Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37320
Lhasa S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37328
Ligustika Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37329
Linedata Services Luxembourg SA . . . . . .
37343
Lorentzen & Stemoco & Sobelnord . . . . . .
37328
Luxfaq Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37329
Luxnova S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37323
Luxtanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37314
Marinella S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37330
Marmor und Granit International A.G. . . .
37339
Mayriwa S.A.- SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37340
M.B.&A. s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37329
McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37324
McKey Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . .
37330
McKey Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
37338
MD2L S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37328
Meadows Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
37340
MGV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37340
Models et Design S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37341
Mold-Masters Luxembourg Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37339
Nabony S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37344
Nageldesignstudio LA BELLE-MAIN S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37341
Naja Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37342
Naja Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37341
Naxos Capital Managers S.àr.l. . . . . . . . . . .
37342
Naxos Capital Managers S.àr.l. . . . . . . . . . .
37322
New Chemicals Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
37343
New Specialty Chemicals Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37343
Nexeo Solutions Luxembourg Holding Co.
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37330
NIFE Carlo Seccomandi . . . . . . . . . . . . . . . .
37323
NIFE Carlo Seccomandi . . . . . . . . . . . . . . . .
37338
Pacific Road Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
37340
Pancunia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37338
Paris Nursing 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37329
Rigatte SA, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37341
Sitronics Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37321
White Fleet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37339
37297
L
U X E M B O U R G
Kinove Luxembourg Coinvestment SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 166.469.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-third day of December.
Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
(i) Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-
porated under the laws of Luxembourg, with a share capital of EUR 2,000,000.-, having its registered office at 15, Rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 160.655;
(ii) Lucas Flynn, having his professional address at Rhône, 40 Bruton Street, 5
th
Floor, London, W1J 6QZ, Great-
Britain; and
(iii) Claus von Hermann, having his professional address at Triton Beteiligungsberatung GmbH, Schillerstrasse 20, 60313
Frankfurt am Main, Germany,
Each of them represented by Me Marc FRANTZ, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy; such proxies,
signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of
registration.
The following articles of incorporation of a company have then been drawn up:
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., as the unlimited partner
(associé commandité) and the limited shareholder(s) (actionnaire(s) commanditaire(s)) a company (the "Company") in
the form of a partnership limited by shares ("société en commandite par actions") governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").
The Company will exist under the name of “Kinove Luxembourg Coinvestment SCA”.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Manager.
In the event that, in the view of the Manager, extraordinary political, economic or social developments occur or are
imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Manager.
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or
in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.
The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other
kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.
The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets
in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants
or other share subscription rights.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders, voting with the quorum and
majority rules set by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be, for any amendment of the Articles
of Incorporation and pursuant to article 32 of the Articles of Incorporation. The consent of the Manager shall be required
in respect of such liquidation.
37298
L
U X E M B O U R G
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at forty-eight thousand six hundred eleven point twelve
euro (EUR 48,611.12) divided into four million eight hundred sixty-one thousand twelve (4,861,012) class A shares (the
“Class A Shares”), which shall be held by the limited shareholder(s) (actionnaire(s) commanditaire(s)) and one hundred
(100) class B shares (the “Class B Shares”), which shall be held by the unlimited partner (associés commandité), in
representation of its unlimited partnership interest in the Company. Each issued share of each class has a nominal value
of one euro cent (EUR 0.01) and is fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Incorporation or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
The Class A Shares and the Class B Shares shall be issued in the form registered shares only.
The Class A Shares may only be transferred subject to the terms of these Articles of Incorporation and/or any sha-
reholders' agreement that may be entered into from time to time between the Company and its shareholders.
The Class B Shares may only be transferred subject to the shareholders (i) approving this transfer in compliance with
the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment
of the Articles of Incorporation and (ii) determining, as appropriate, which person(s) shall act as Manager(s) of the Com-
pany after the relevant transfer. The Articles of incorporation will be amended accordingly.
Any Transfer of Class A Shares and Class B Shares in breach of the Articles of Incorporation and/or any shareholders'
agreement to which the Company is a party from time to time shall be unenforceable against the Company.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must
be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.
A shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be kept at the registered office. The register
will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class of shares held, the
indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder
will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely
for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the registered shares will result from
the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders' register may be
delivered to the shareholders upon their request. The Company may issue multiple registered share certificates.
Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders' register by a declaration of transfer entered
into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well
as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any corres-
pondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee, provided always that such
transfer is made in accordance with the terms of these Articles of Incorporation and/or any shareholders' agreement that
may be entered into from time to time between the Company and its shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions adopted by the
general meeting of shareholders.
Art. 7. Increase and reduction of Capital. The issued and/or authorised capital of the Company may be increased or
reduced one or several times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the
quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment
of the Articles of Incorporation.
The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders
first of the same class, then to the other shareholders in proportion to the part of the capital which those shareholders
are holding. The Manager shall determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised.
This period may not be less than thirty (30) days.
Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority
rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of
Incorporation may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Manager to do so.
Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own Class A Shares, but not its Class B Shares. The
acquisition and holding of its own Class A Shares will be in compliance with the conditions and limits established by the
Laws and, if applicable, any shareholders' agreement that may be entered into from time to time between the Company
and its shareholders.
37299
L
U X E M B O U R G
Chapter III. - Manager, Supervisory board
Art. 9. Management. The Company shall be managed by Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., (the "Manager"), in its
capacity as unlimited partner and holder of Class B Shares of the Company.
The Manager may be removed at any time subject to the provisions of these Articles of Incorporation and/or any
shareholders' agreement that may be entered into from time to time between the Company and its shareholders, and,
if following such removal, there remains no other Manager, the Manager must be immediately replaced by a new manager,
who must be an unlimited partner, by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with
the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amend-
ment of these Articles of Incorporation.
The Manager to be removed shall have a veto right in its capacity as unlimited partner of the Company on any resolution
relating to its removal and/or replacement.
The holder of Class A Shares, in their capacity as limited partners, shall neither participate in nor interfere with the
management of the Company.
Art. 10. Powers of the Manager. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or
useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of share-
holders or to the Supervisory Board are in the competence of the Manage(.
Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager may delegate the daily management of
the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more persons or com-
mittees of its choice.
The Manager may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or committees of its choice.
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Manager (acting, in case the Manager
is a legal entity, through one or more duly authorised signatories, such as designated by the Manager at its sole discretion).
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to
whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures
or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the Manager, within the limits
of such special power.
Art. 12. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the general meeting of shareholders, the Manager may
receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be
reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager in relation with such management of the Company
or the pursuit of the Company's corporate object.
Art. 13. Conflicts of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the mere fact that the Manager (or any one of its directors, managers, officers or
employees), the officers or employees of the Company or the members of the Supervisory Board have a personal interest
in, or is a director, manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any
person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage
in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from
considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 14. Liability of the Manager - Indemnification. The Manager shall be jointly and severally liable with the Company
for all liabilities of the Company which cannot be met out of the Company's assets.
The limited shareholders shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity whatsoever
other than exercising their rights as shareholders in general meetings or otherwise, and, consequently, they shall only be
liable for payment to the Company up to the nominal value of each share (and share premium if any) in the Company
owned by them.
The Company shall indemnify any Manager (or any one of its directors, managers, officers or employees), the officers
or employees of the Company or the members of the Supervisory Board and, if applicable, their successors, heirs,
executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action,
suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been manager, (or director, manager,
officer or employee of the Manager), or officers or employees of the Company or members of the Supervisory Board,
or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which
he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be
provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal
counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indem-
nification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation
may be entitled.
37300
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Dissolution - Incapacity of the Manager. In case of dissolution or legal incapacity of the Manager or where for
any other reason it is impossible for the Manager to act, the Company will not be automatically dissolved.
In that event, and in the absence of another Manager, the Supervisory Board shall designate one or more administrators,
who need not be shareholders themselves, until such time as the general meeting of shareholders shall convene for
purposes of appointing a new Manager.
Within fifteen (15) calendar days of their appointment, the administrator(s) shall convene the general meeting of
shareholders in the manner provided for by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws.
The administrators' duties consist in performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time as the
general meeting of shareholders referred to here above shall convene.
The administrators are responsible only for the execution of their mandate.
Art. 16. Supervisory Board. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated
accounts must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation,
including more in particular its books and accounts, shall be reviewed by a Supervisory Board.
The Supervisory Board shall be composed of not less than three members, who need not be shareholders themselves.
The members of the Supervisory Board and/or the approved statutory auditors will be appointed by the general
meeting of shareholders, which will determine their number and the duration of their mandate which may not exceed
six (6) years. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of the general meeting of shareholders, save in such cases where the approved statutory auditor may, as a matter of the
Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.
The remuneration of the members of the Supervisory Board (if any) shall be set by the general meeting of shareholders.
In the fulfilment of its duties, the Supervisory Board may be assisted by an approved statutory auditor who shall be
appointed or removed by the general meeting of shareholders.
Art. 17. Advisory Powers of the Supervisory Board. In addition to its statutory audit functions, the Supervisory Board
may be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine from time to time or as set out in any
shareholders agreement entered into from time to time between the Company and its shareholders.
Art. 18. Meetings of the Supervisory Board. The Supervisory Board shall appoint from among its members a chairman
(the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Supervisory Board himself and who
will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Supervisory Board (the “Secretary”).
The Supervisory Board will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Supervisory Board must be convened
if any two (2) of its members so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Supervisory Board, except that in his absence the Supervisory Board
may appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by majority vote of the members present
or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'
written notice of meetings of the Supervisory Board shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Supervisory Board. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board.
The meetings of the Supervisory Board shall be held in Luxembourg or at such other place as the Supervisory Board
may from time to time determine.
Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing,
transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another member of the
Supervisory Board as his proxy. Any Member of the Supervisory Board may represent one or several members of the
Supervisory Board.
A quorum of the Supervisory Board shall be the presence or the representation of at least half (1/2) of the members
of the Supervisory Board holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Super-
visory Board present or represented at such meeting.
One or more members of the Supervisory Board may participate in a meeting by conference call, videoconference or
any other similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. The Supervisory
Board may determine any additional rules regarding the above in its internal regulations.
A written decision, signed by all the members of the Supervisory Board, is proper and valid as though it had been
adopted at a meeting of the Supervisory Board which was duly convened and held. Such a decision may be documented
in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
members of the Supervisory Board.
37301
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Minutes of Meetings of the Supervisory Board. The minutes of any meeting of the Supervisory Board will be
signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the members of the Supervisory Board as well as of the
minutes of the meeting of the Supervisory Board, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by
the Chairman and by the Secretary (if any) or by any two (2) members of the Supervisory Board acting jointly.
Chapter IV. - Shareholders
Art. 20. Powers of the General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall have such powers
as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws.
Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 21. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders will be held on the third Tuesday of May
at 2:00 p.m.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on
the next following business day.
Art. 22. Other General Meetings. The Manager or the Supervisory Board may convene general meetings of sharehol-
ders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened if shareholders
representing at least ten percent (10%) of the Company's capital so require.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Manager, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 23. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication)
of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant meeting. The agenda for a general meeting of shareholders
shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out
the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 24. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as his proxy holder. The Manager may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder to take
part in a general meeting of shareholders.
Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by videoconference or any other similar means of
telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority
computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation
in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.
Art. 25. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by a person designated by the Manager
or, in its absence, by the general meeting of shareholders.
The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general
meeting of shareholders.
The chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting.
Art. 26. Adjournment. The Manager may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four (4) weeks.
The Manager must adjourn a meeting if so required by shareholders representing at least twenty percent (20%) of the
Company's issued capital.
Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly
deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.
Art. 27. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they
vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of
shareholders.
The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt
another voting procedure.
37302
L
U X E M B O U R G
The shareholders are authorised to cast their vote by ballot papers («formulaires») expressed in the English language.
Any ballot paper (“formulaire”) shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by
special courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or
by fax at the fax number of the registered office of the Company.
Any ballot paper (“formulaire”) which does not bear any of the following indications is to be considered void and shall
be disregarded for quorum purposes:
- name and registered office and / or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares held by the relevant shareholder in the share capital of the Company and, if applicable, number
of shares of each class held by the relevant shareholder in the share capital of the Company;
- agenda of the general meeting;
- indication by the relevant shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares
for which the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and
- name, title and signature of the duly authorised representative of the relevant shareholder.
Any ballot paper (“formulaire”) shall be received by the Company no later than five (5) p.m. (Luxembourg time) on
the day on which banks are generally open for business in Luxembourg immediately preceding the day of the general
meeting of shareholders. Any ballot paper (“formulaire”) received by the Company after such deadline shall be disregarded
for quorum purposes.
A ballot paper (“formulaire”) shall be deemed to have been received:
(a) if delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an
internationally recognised courier company: at the time of delivery; or
(b) if delivered by fax: at the time recorded together with the fax number of the receiving fax machine on the trans-
mission receipt.
At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the
Company's Articles of Incorporation or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority
requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted, irrespective of the number
of shares represented, by a simple majority of votes cast, unless a higher majority is required under any shareholders'
agreement that may be entered from time to time between the Company and its shareholders, in which case such higher
majority shall apply.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for
the purpose of amending the Company's Articles of Incorporation or voting on resolutions whose adoption is subject to
the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least
one half (1/2) of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting
may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed resolutions to be adopted,
a two thirds (2/3) majority of the votes cast by the shareholders present or represented is required at any such general
meeting, unless a higher majority is required by the Laws or under any shareholders' agreement that may be entered
from time to time between the Company and its shareholders, in which case such higher majority shall apply.
Save as otherwise provided in the Articles of Incorporation, no resolution may be adopted by the shareholders without
the consent of the Manager.
Art. 28. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau
and may be signed by any shareholders or proxyholders, who so request.
Chapter V. - Financial year, financial statements, distribution of profits
Art. 29. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 30. Adoption of Financial Statements. The Manager shall prepare, for approval by the shareholders, annual statu-
tory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders for approval.
Art. 31. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”).
That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to
ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the
annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to
carry it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable
reserves or share premium, to the holders of Class A Shares and Class B Shares prorate to their stake in the issued
capital. Each share entitles to the same proportion in such distributions by class of share.
37303
L
U X E M B O U R G
Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager may pay out
an advance payment on dividends to the holders of Class A Shares and the holders of Class B Shares. The Manager fixes
the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 32. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be,
by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager or such other persons (who may
be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their powers
and their compensation.
After payment of or provision for all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liqui-
dation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the holders of Class A Shares and the holders of the Class B
Shares so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend
distributions.
Chapter VII. - Applicable law
Art. 33. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up,
(i) Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., duly represented as aforementioned, acting in his/her capacity as duly
authorised attorney-in-fact by virtue of the aforementioned proxy, declared to subscribe for four million eight hundred
sixty-one thousand ten (4,861,010) Class A Shares and one hundred (100) Class B Shares with a nominal value of one
euro cent (EUR 0.01) each.
Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. declared to make payment in full of the nominal value of:
- the Class A Shares, i.e. an aggregate amount of forty-eight thousand six hundred then euro and ten cents (EUR
48,610.10) with payment of a share premium in an amount of four million eight hundred twelve thousand three hundred
ninety-nine euro and ninety cents (EUR 4,812,399.90) by a contribution in kind consisting of an aggregate four million
eight hundred sixty-one thousand ten (4,861,010) shares in Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with a share capital of EUR
43,750,000.having its registered office at 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 160.558 (“Kinove Luxembourg
Holdings 2 S.à r.l.”) divided into four hundred eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class A shares, four hundred
eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class B shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one
(486,101) Class C shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class D shares, four hundred
eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class E shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one
(486,101) Class F shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class G shares, four hundred
eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class H shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one
(486,101) Class I shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class J shares, in Kinove Luxem-
bourg Holdings 2 S.à r.l.,
- the Class B Shares, i.e. an aggregate amount of one euro (EUR 1.-) with payment of a share premium in an amount
of ninety-nine euro (EUR 99.-) by a contribution in kind consisting of an aggregate one hundred (100) shares in Kinove
Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., divided into ten (10) Class A shares, ten (10) Class B shares, ten (10) Class C shares, ten
(10) Class D shares, ten (10) Class E shares, ten (10) Class F shares, ten (10) Class G shares, ten (10) Class H shares, ten
(10) Class I shares, ten (10) Class J shares in Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.,
(together the “Contribution 1”).
Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. declared that the Contribution 1 is free of any pledge or lien or charge, as
applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution 1 to the Company without
restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other
formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution 1 to the Company.
(ii) Lucas Flynn duly represented as aforementioned, acting in his/her capacity as duly authorised attorney-in-fact by
virtue of the aforementioned proxy, declared to subscribe for one (1) Class A Share with a nominal value of one euro
cent (EUR 0.01).
Lucas Flynn declared to make payment in full of the nominal value of such Class A Share, i.e. an amount of one euro
cent (EUR 0.01) with payment of a share premium in an amount of ninety-nine euro cent (EUR 0.99) by a contribution
in kind consisting of one (1) Class A share in Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l. (the “Contribution 2”).
Lucas Flynn declared that the Contribution 2 is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist
no impediments to the free transferability of the Contribution 2 to the Company without restriction or limitation and
37304
L
U X E M B O U R G
that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to per-
form a valid transfer of the Contribution 2 to the Company.
(iii) Claus von Hermann duly represented as aforementioned, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact
by virtue of the aforementioned proxy, declared to subscribe for one (1) Class A Share with a nominal value of one euro
cent (EUR 0.01).
Claus von Hermann declared to make payment in full of the nominal value of such Class A Share, i.e. an amount of
one euro cent (EUR 0.01) with payment of a share premium in an amount of ninety-nine euro cent (EUR 0.99) by a
contribution in kind consisting of one (1) Class A share in Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l. (the “Contribution 3”).
Claus von Hermann declared that the Contribution 3 is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that
there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution 3 to the Company without restriction or
limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities
necessary to perform a valid transfer of the Contribution 3 to the Company.
The appearing parties further stated that a report has been drawn up by Ernst & Young as authorized independent
auditor (réviseur d'entreprises agréé), having its registered office at 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, and
signed by Mr Jeannot WEYER on 23 December 2011, wherein the Contribution 1, the Contribution 2 and the Contri-
bution 3 (together the “Contributions”) are described and valued (the "Report”).
The conclusions of the Valuation Report read as follows:
“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 4,861,012 class A
shares and 100 class B shares with a nominal value of EUR 0.01 each to be issued with total related share premium of
EUR 4,812,500.88, hence total consideration amounting to EUR 4,861,112.-.”
The Report after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary will remain attached
to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
The undersigned notary states that the conditions provided for in articles 26 and 103 of the law of 10 August 1915
on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately three thousand five hundred euro (EUR
3,500.-).
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last
day of December of 2012.
<i>Resolutions of the general meeting of shareholdersi>
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to set at three the number of members of the Supervisory Board and
further resolved to elect the following for a period ending at the first annual general meeting of shareholders:
- Mr Jeffrey Curtis Malenky, born on 5 April 1955, in Pennsylvania (USA), with professional address at 7702 FM 1960
Rd E, Humble, TX 77346, USA;
- Mr Charles Edward Nield Herlinger, born on 5 November 1955, in Preston (United-Kingdom), with professional
address at HPC 010610 Rodenbacher Chaussée 4, 63457 Hanau-Wolfgang, Germany; and
- Mr Jacky Levell Clem, born on 30 August 1953, in Texas (USA), with professional address at HPC 010-610 Roden-
bacher Chaussée 4, 63457 Hanau-Wolfgang, Germany.
The undersigned notary, who knows and speaks English, stated that on request of the appearing parties, the present
deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same parties and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the undersigned notary
by his/her surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary this
original deed.
37305
L
U X E M B O U R G
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendelf, am dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard Delosch, mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
(i) Kinove Luxembourg 1 Holdings 1 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée), gegründet gemäß dem Luxemburger Gesetz, mit einem Gesellschaftskapital von zwei Millionen Euro (EUR
2.000.000,-), mit Gesellschaftssitz in 15, rue Edward Steichen, L2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, und
eingetragen beim Luxemburger Handels-und Firmenregister unter der Nummer B 160.655;
(ii) Lucas Flynn, beruflich wohnhaft in Rhône, 40 Bruton Street, 5th Floor, London, W1J 6QZ, Großbritannien; und
(iii) Claus von Hermann, beruflich wohnhaft in Triton Beteiligungsberatung GmbH, Schillerstrasse 20, 60313 Frankfurt
am Main, Deutschland,
alle vertreten durch Me Marc FRANTZ, Anwalt, wohnhaft in Luxembourg, kraft einer Vollmacht. Diese Vollmachten,
die vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, bleibt der vorliegenden notariellen
Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigefügt.
Daraufhin wurde die Satzung der Gesellschaft wie folgt festgestellt:
Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit zwischen Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., als Komplementär („associé
commandité“) und den Kommanditisten eine Gesellschaft (die "Gesellschaft") in der Form einer Kommanditgesellschaft
(„société en commandite par actions“) gegründet, die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und den Bestim-
mungen der vorliegenden Satzung (die „Satzung“) unterliegt.
Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen „Kinove Luxembourg Coinvestment SCA“
Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt
Luxemburg verlegt werden.
Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss der Geschäftsführung im Großherzogtum
Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
Sollte die Geschäftsführung der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder
gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft
am Gesellschaftssitz oder den Austausch mit dem Büro am Gesellschaftssitz beziehungsweise zwischen dem Büro am
Gesellschaftssitz und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen könnten, so kann die Gesellschaft den Gesell-
schaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen Ereignisse ins Ausland zu verlegen. Diese
vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der Gesellschaft, welche trotz der vorüber-
gehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unterliegt. Die genannten vorübergehenden
Maßnahmen sind von der Geschäftsführung zu beschließen und den hiervon betroffenen Dritten mitzuteilen.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Gesellschaftszweck umfasst den Erwerb, den Besitz und die Veräußerung von Betei-
ligungen an luxemburgischen und/oder ausländischen Gesellschaften und Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwick-
lung und Unternehmensführung solcher Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann den Gesellschaften und Unternehmen, die der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle
Unterstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und
Form.
Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche anderen beweglichen oder unbeweglichen
Vermögensgüter investieren.
Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und Anleihen, Schuldtitel oder jegliche Art von
Schuldverschreibungen und Optionsscheinen oder anderen Titel ausgeben, die das Recht auf Zeichnung von Aktien be-
inhalten.
Generell kann die Gesellschaft jede Tätigkeit ausführen, die für die Erfüllung und Entwicklung ihres Unternehmens-
zweckes dienlich oder notwendig erscheint.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann aufgelöst werden durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung mit dem nach dem
Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichem Quorum und den erforderlichen Mehrheiten
gefasst wird und in Übereinstimmung mit Artikel 32 dieser Satzung. Dieser Beschluss erfordert die Zustimmung durch
die Geschäftsführung.
Kapitel II. - Kapital, Aktien
Art. 5. Ausgegebenes Kapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt achtundvierzigtausendsechshundertelf
Euro und zwölf Cent (EUR 48.611,12) und ist in vier Millionen achthunderteinundsechzigtausendeinhundertzwölf
37306
L
U X E M B O U R G
(4.861.112) Aktien der Kategorie A (die „Aktien der Kategorie A“), die von den Kommanditisten („actionnaires com-
manditaires“) gehalten werden und hundert Aktien der Kategorie B (die „Aktien der Kategorie B“), die von dem
Komplementär gehalten werden und deren unbeschränkte Haftung in der Gesellschaft widerspiegeln. Jede ausgegebene
Aktie jeder Kategorie hat einen Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) und ist vollständig eingezahlt.
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Aktien mit denselben Rechten und
Pflichten ausgestattet.
Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf dem alle Emissions-
aufgelder, die auf eine Aktie eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung von
Aktien, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten,
zur Auszahlung an den/die Gesellschafter in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage bereitzu-
stellen, verwendet werden.
Art. 6. Aktien. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.
Die Aktien der Kategorie A und die Aktien der Kategorie B werden in Form von Namensaktien ausgeben.
Die Aktien der Kategorie A sind übertragbar in Übereinstimmung der Gesellschaftssatzung oder jeder Gesellschaf-
tervereinbarung, welche von Zeit zu Zeit zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern besteht.
Die Aktien der Kategorie B können nur mit Zustimmung der Gesellschafter übertragen werden; der entsprechende
Gesellschafterbeschluss muss (i) in Übereinstimmung mit den nach der Satzung oder den auf eine Satzungsänderung
anwendbaren Gesetzesvorschriften erforderlichen Quorum- und Mehrheitsregeln gefasst werden und (ii) gegebenenfalls
bestimmen, welche Person(en) nach der Übertragung die Funktion als Mitglied(er) der Geschäftsführung ausführen soll
(en). Die Satzung wird entsprechend abgeändert.
Jede Übertragung von Aktien der Kategorie A und Aktien der Kategorie B in Widerspruch mit der Gesellschaftssatzung
und/oder einer möglichen Gesellschaftervereinbarung welcher die Gesellschaft angehört, ist der Gesellschaft gegenüber
unwirksam.
Gegenüber der Gesellschaft ist jede Aktie unteilbar.
Die Miteigentümer, die Nießbraucher und die bloßen Eigentümer von Aktien sowie die Pfandgläubiger und die Pfand-
schuldner von Aktien müssen durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden, der unter ihnen ernannt wird oder
nicht.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register über die Namensaktien geführt, das von jedem Aktionär eingesehen werden
kann. Dieses Aktienregister enthält Angaben über die genaue Bezeichnung jedes Aktionärs und über die Anzahl und die
Kategorie der jeweils gehaltenen Aktien, über die auf jede Aktie geleisteten Zahlungen sowie über die Daten der Über-
tragungen von Aktien. Jeder Aktionär muss der Gesellschaft mittels eingeschriebenen Briefs seine Adresse und jede
Änderung derselben mitteilen. Die Gesellschaft darf sich für jegliche Zwecke auf die ihr zuletzt mitgeteilte Adresse ver-
lassen. Das Eigentum an den Namensaktien bestimmt sich nach den Eintragungen in dem Aktienregister. Den Aktionären
werden auf Verlangen Zertifikate ausgestellt, die die Eintragungen des Aktienbuches wiedergeben. Die Gesellschaft kann
Namenszertifikate, welche Eintragungen betreffend mehrere Aktien darstellen, ausstellen.
Jede Übertragung von Namensaktien wird im Aktienregister durch eine datierte und vom Übertragenden und Über-
tragungsempfänger oder seinem Vertreter unterzeichnete Übertragungserklärung sowie in Übereinstimmung mit den in
Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Luxemburgs über die Forderungsübertragung festgelegten Regeln eingetragen.
Ferner darf die Gesellschaft jede Übertragung, auf die in jeglicher Art in Korrespondenz oder in jedem anderen Dokument
Bezug genommen wird und die die Zustimmung vom Übertragenden und Übertragungsempfänger enthält, zur Kenntnis
nehmen und in das Aktienregister eintragen, vorausgesetzt dass eine solche Übertragung in Übereinstimmung mit der
Gesellschaftssatzung und/oder jeder Gesellschaftervereinbarung, welche von Zeit zu Zeit zwischen der Gesellschaft und
ihren Gesellschaftern besteht, vollzogen wird.
Das Eigentum an einer Aktie beinhaltet zugleich implizit das Einverständnis mit der Satzung und mit den von der
Hauptversammlung wirksam angenommenen Beschlüssen.
Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das ausgegebene und/oder das genehmigte Kapital der Gesellschaft
kann einmalig oder mehrfach durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung mit den nach der
Satzung oder den auf eine Satzungsänderung anwendbaren Gesetzesvorschriften erforderlichen Quorum- und Mehr-
heitsregeln gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
Die neuen, mittels Geldeinlage einzuzahlenden Aktien werden den vorhandenen Aktionären, und zwar zunächst den
Aktionären der gleichen Kategorie und dann den übrigen Aktionären, in dem Verhältnis, in dem sie am Gesellschaftskapital
beteiligt sind, bevorzugt angeboten. Die Geschäftsführung wird den Zeitraum bestimmen, innerhalb dessen das Vorzugs-
recht bei der Aktienzeichnung ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf dreißig (30) Tage nicht unterschreiten.
Unbeschadet des Vorstehenden, kann die Hauptversammlung, die in Übereinstimmung mit den nach der Satzung oder
den auf eine Satzungsänderung anwendbaren Gesetzesvorschriften erforderlichen Quorum- und Mehrheitsregeln ab-
stimmt, das Vorzugsrecht bei der Aktienzeichnung begrenzen oder ausschließen oder die Geschäftsführung hierzu
ermächtigen.
37307
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Erwerb von eigenen Aktien. Die Gesellschaft darf ihre eigenen Aktien der Kategorie A, aber nicht ihre Aktien
der Kategorie B erwerben. Der Erwerb und der Besitz der eigenen Aktien der Kategorie A vollzieht sich in Überein-
stimmung mit den durch die Gesetze festgelegten Bedingungen und Begrenzungen und gegebenenfalls jeder Gesellschaf-
tervereinbarung, welche von Zeit zu Zeit zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern besteht.
Kapitel III. - Geschäftsführung, Aufsichtsrat
Art. 9. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. (der „Geschäftsführer“),
in seiner Eigenschaft als Komplementär und Inhaber der Aktien der Kategorie B der Gesellschaft vertreten.
Der Geschäftsführer kann jeder Zeit abberufen werden unter Berücksichtigung der Gesellschaftssatzung und/oder
jeder Gesellschaftervereinbarung, welche zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern besteht. Wenn in Folge
einer solchen Abberufung kein weiterer Geschäftsführer im Amt bleibt, muss der Geschäftsführer sofort durch einen
neuen Geschäftsführer ersetzt werden, der ein Komplementär sein muss, und der durch einen Beschluss der Hauptver-
sammlung, der in Übereinstimmung mit den nach der Satzung oder den auf eine Satzungsänderung anwendbaren
Gesetzesvorschriften erforderlichen Quorum- und Mehrheitsregeln gefasst wird.
Der zu ersetzende Geschäftsführer hat ein Vetorecht hinsichtlich seiner Eigenschaft als Komplementär der Gesellschaft
bezüglich irgendeines Beschlusses das seine Abberufung und/oder Ersetzung betrifft.
Die Aktionäre der Kategorie A, in ihrer Eigenschaft als Kommanditisten, dürfen weder an der Geschäftsführung der
Gesellschaft teilnehmen noch sich in diese einmischen.
Art. 10. Befugnisse des Geschäftsführers. Der Geschäftsführer hat die weitest gehenden Befugnisse, um alle zur Er-
reichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich der Hauptversammlung oder dem Auf-
sichtsrat übertragen haben, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung.
Art. 11. Vertretung der Gesellschaft – Übertragung von Befugnissen. Die Geschäftsführung kann die tägliche Ge-
schäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft innerhalb der täglichen Geschäftsführung an eine
oder mehrere Personen oder Gremien seiner Wahl übertragen.
Die Geschäftsführung kann einer oder mehreren Personen oder Gremien ihrer Wahl andere spezielle Befugnisse oder
Vollmachten übertragen oder diese mit dauernden oder zeitweisen Funktionen ausstatten.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers (der im Falle
einer juristischen Person durch einen oder mehrere Vertreter handelt, die von dem Geschäftsführer ernannt wird).
Die Gesellschaft wird außerdem gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift oder durch die alleinige Un-
terschrift derjenigen Person vertreten, der die tägliche Verwaltung der Gesellschaft übertragen worden ist, oder durch
die gemeinschaftliche oder die alleinige Unterschrift derjenigen Person, denen von der Geschäftsführung eine besondere
Zeichnungsvollmacht übertragen wurde, aber immer nur im Rahmen dieser besonderen Zeichnungsvollmacht.
Art. 12. Geschäftsführungsbezüge und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung, können
die Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus können ihnen
sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des Gesellschaftszweckes getätigt
wurden, zurückerstattet werden.
Art. 13. Interessenkonflikte - Entschädigungen. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft
und einer anderen Gesellschaft oder einer anderen Firma wird in seiner Wirksamkeit durch die bloβe Tatsache beeinflusst,
dass der Geschäftsführer (oder einer seiner Geschäftsführer, Angestellten oder Arbeitnehmer), die Arbeitnehmer oder
Angestellten der Gesellschaft oder die Mitglieder des Aufsichtsrates ein persönliches Interesse an der anderen Gesellschaft
oder Firma haben oder ein Geschäftsführungsmitglied, Aktionär, Mitglied, Anteilseigner, Angestellter oder Arbeitnehmer
der anderen Gesellschaft oder Firma ist. Jede Person, die in der zuvor beschriebenen Weise mit einer Gesellschaft oder
einer Firma verbunden ist und mit denen die Gesellschaft vertraglich oder in anderer Weise in Geschäftsbeziehungen
treten wird, soll nicht alleine wegen dieser Verbindung an der Abstimmung oder der Vornahme anderer Handlungen in
Bezug auf einen solchen Vertrag oder sonstigen Geschäftstätigkeit gehindert sein.
Art. 14. Haftung der Geschäftsführer - Entschädigungen. Der Geschäftsführer ist gemeinsam und einzeln mit der Ge-
sellschaft verantwortlich für alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die nicht aus den Aktiva der Gesellschaft beglichen
werden können.
Die Kommanditisten sollen mit Ausnahme ihrer Funktion als Gesellschafter im Rahmen von Generalversammlungen
in keiner Weise für die Gesellschaft handeln und folglich gegenüber der Gesellschaft nur bis zum Betrag des Nennwertes
jeder von ihnen gehaltenen Aktie (und gegebenenfalls der Ausgabeprämie) haften.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer,(oder jeden seiner Geschäftsführer, Verwaltungsräte, Angestellten oder
Mitarbeiter), die Angestellten oder Mitarbeiter der Gesellschaft oder die Mitglieder des Aufsichtsrates und gegebenenfalls
dessen Erben, Nachlassverwalter und Vermögensverwalter, von Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechts-
streits oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführungsmitglied, Aufsichtsratsmitglied
oder früheres Geschäftsführungsmitglied oder Aufsichtsratsmitglied oder als Bevollmächtigter der Gesellschaft als Partei
teilnimmt, angefallen sind. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere Gesellschaft an der die
37308
L
U X E M B O U R G
Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er nicht zur Freistellung
berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er endgültig wegen grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft verurteilt
werden soll. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen gewährt, bei denen die
Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass die freizustellende Person keine Pflichtver-
letzung begangen hat. Das vorgenannte Recht zur Freistellung schließt keine anderen Rechte aus zu denen die gemäß
diesem Artikel zu entschädigenden Personen berechtigt sind.
Art. 15. Auflösung – Handlungsunfähigkeit der Geschäftsführer. Im Falle der Auflösung oder rechtlichen Handlungs-
unfähigkeit der Geschäftsführer oder wenn die Geschäftsführer aus welchen Gründen auch immer nicht handeln können,
wird die Gesellschaft nicht automatisch aufgelöst.
In diesem Fall, und wenn kein anderer Geschäftsführer vorhanden ist, bestimmt der Aufsichtsrat einen oder mehrere
Verwalter, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, bis die Generalversammlung einen neuen Geschäftsführer ernennt.
Innerhalb von fünfzehn (15) Kalendertagen nach ihrer Ernennung sollen der/die Verwalter eine Generalversammlung
nach den Bestimmungen der Satzung oder der Gesetze einberufen.
Die Pflichten der Verwalter bestehen darin dringende Geschäfte auszuführen und Geschäfte der ordentlichen Ver-
waltung bis zu führen bis die Hauptversammlung zusammentritt.
Die Verwalter sind für die Ausführung ihres Mandats verantwortlich.
Art. 16. Aufsichtsrat. Außer in den Fällen in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresabschlüsse
und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft der Ge-
sellschaft und dessen finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und Konten durch den Aufsichtsrat geprüft.
Der Aufsichtsrat setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammen, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates und/oder der zugelassene Wirtschaftsprüfer werden durch die Hauptversammlung
ernannt, die ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, festlegt. Sie können
wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Angabe von Gründen, durch einen Beschluss der Haupt-
versammlung abberufen werden außer in Fällen, in denen der zugelassene Wirtschaftsprüfer aufgrund zwingender
gesetzlicher Vorschriften nur aus schwerwiegendem Grund oder in gegenseitigem Einverständnis abberufen werden kann.
Die Entlohnung der Mitglieder des Aufsichtsrates wird gegebenenfalls durch die Hauptversammlung festgelegt.
Zur Erfüllung seiner Verpflichtungen kann der Aufsichtsrat einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer, der durch die Haupt-
versammlung ernannt wird, hinzuziehen.
Art. 17. Beratende Funktion des Aufsichtsrates. Zusätzlich zu seinen statutarischen Prüfungsfunktionen kann der Auf-
sichtsrat durch die Geschäftsführung zu solchen Fragen konsultiert werden, die der Geschäftsführer von Zeit zu Zeit
festlegt oder wie in jeder Gesellschaftervereinbarung, welche von Zeit zu Zeit zwischen der Gesellschaft und ihren Ge-
sellschaftern besteht, festgelegt wurde.
Art. 18. Sitzungen des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat ernennt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden (der „Vor-
sitzende“). Der Aufsichtsrat kann ebenso einen Schriftführer ernennen, der nicht Mitglied des Aufsichtsrats sein muss
und der für die Protokollführung während der Sitzungen des Aufsichtsrats verantwortlich ist (der „Schriftführer“).
Der Aufsichtsrat tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Sitzung des Aufsichtsrats muss auf
Wunsch zweier (2) seiner Mitglieder einberufen werden.
Der Vorsitzende steht allen Sitzungen des Aufsichtsrats vor, es sei denn, dass der Aufsichtsrat wegen der Abwesenheit
des Vorsitzenden ein anderes Mitglied als Vorsitzenden auf Zeit durch Mehrheitswahl durch die anwesenden oder ver-
tretenen Mitglieder des Aufsichtsrats in dieser Sitzung ernannt hat.
Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorher erteilter Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen
des Aufsichtsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit gewähr-
leistendes Kommunikationsmedium einberufen. Jedes dieser Einberufungsschreiben soll Ort und Zeit der Sitzung sowie
die Tagesordnung und die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann
schriftlich durch ein Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium auf die Benachrichtigung verzichten. Für
Sitzungen, deren Ort und Zeit in einem zuvor angenommenen Beschluss des Aufsichtsrats festgelegt worden sind, ist
keine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.
Die Aufsichtsratssitzungen finden in Luxemburg oder an jedem anderen Ort, den der Aufsichtsrat hierfür bestimmt
hat, statt.
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sich bei den Sitzungen des Aufsichtsrats durch ein anderes Mitglied vertreten
lassen, indem es dieses hierzu schriftlich bevollmächtigt; die Bevollmächtigung kann durch jedes die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmedium übertragen werden. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann ein oder mehrere
Mitglieder vertreten.
Die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Anzahl der Auf-
sichtsratsmitglieder. Beschlüsse werden per Mehrheitsentscheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen
Mitglieder gefasst.
37309
L
U X E M B O U R G
Ein oder mehrere Aufsichtsratsmitglieder können an einer Sitzung durch eine Telefonkonferenzschaltung, Videokon-
ferenz oder durch ähnliche, gleichzeitige und gegenseitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellende
Mittel teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der tatsächlichen Anwesenheit in einer Sitzung gleich gestellt. Der Auf-
sichtsrat kann weitere Regeln in dieser Hinsicht in ihrem internen Reglement festlegen.
Eine von allen Aufsichtsratsmitgliedern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ord-
nungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Aufsichtsratssitzung gefasst worden wäre. Diese Entscheidung kann in einem
einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts festgehalten sein die jeweils von einem
oder mehreren Aufsichtsratsmitgliedern unterzeichnet werden.
Art. 19. Protokolle der Aufsichtsratssitzungen. Die Protokolle der Geschäftsführungssitzungen werden von dem Vor-
sitzenden und gegebenenfalls dem Schriftführer unterzeichnet. Jede erteilte Vollmacht bleibt dem Protokoll beigefügt.
Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-
weitig übermittelt werden, werden durch den Vorsitzenden und gegebenenfalls den Schriftführer oder gemeinsam durch
zwei (2) Mitglieder der Geschäftsführung unterzeichnet.
Kapitel IV. - Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 20. Befugnisse der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung besitzt die ihr nach der Satzung und nach den
Gesetzen zukommenden Befugnisse.
Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre.
Art. 21. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird am dritten Dienstag des Monats
Mai um 14:00 Uhr abgehalten.
Fällt dieser Tag auf einen Tag, an dem Banken in Luxemburg allgemein nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am
nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten.
Art. 22. Weitere Hauptversammlungen. Die Geschäftsführung oder der Aufsichtsrat können zusätzlich zu der Jahres-
hauptversammlung weitere Hauptversammlungen einberufen. Diese Versammlung ist einzuberufen, wenn es eine Anzahl
von Aktionären, die mindestens ein Zehntel (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten, so verlangt.
Hauptversammlungen sowie die Jahreshauptversammlung werden am Gesellschaftssitz oder an einem anderen Ort im
Großherzogtum Luxemburg abgehalten und können außer Landes abgehalten werden, wenn dies nach dem endgültigen
Urteil der Geschäftsführung durch Umstände höherer Gewalt angebracht ist.
Art. 23. Einberufungsschreiben zur Hauptversammlungen. Die Aktionäre treten auf Einberufungsschreiben, (das er-
forderlichenfalls auch veröffentlicht wird) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung oder den Gesetzen
zusammen.
Das an die Aktionäre versandte Einberufungsschreiben gibt den Ort und die Zeit sowie die Tagesordnung und die Art
der zu behandelnden Geschäftspunkte der jeweiligen Hauptversammlung an. Die Tagesordnung einer Hauptversammlung
muss, sofern angebracht, die vorzunehmenden Änderungen in der Satzung beschreiben und, soweit erforderlich, den
Wortlaut der Änderungen ausführen, die Auswirkungen auf Gesellschaftszweck und -form der Gesellschaft haben.
Sind alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, über die Tagesordnung
der Versammlung ordnungsgemäß unterrichtet zu sein, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten
werden.
Art. 24. Teilnahme und Vertretung. Alle Aktionäre besitzen bei jeder Hauptversammlung ein Teilnahme-und Rederecht.
Ein Aktionär kann sich durch schriftliche erteilte Vollmacht, die durch eine die Schriftlichkeit wahrende Übertragungs-
weise übermittelt wurde, bei jeder Hauptversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst Aktionär sein muss,
vertreten lassen. Die Geschäftsführung kann alle Bedingungen, die zur Teilnahme eines Aktionärs an einer Hauptver-
sammlung erfüllt sein müssen, aufstellen.
Aktionäre, die an einer Generalversammlung durch Videokonferenz oder ähnliche Telekommunikationsmedien, die
ihre Identifizierung erlauben, teilnehmen, werden für die Feststellung des Quorums und der Mehrheitsverhältnisse als
anwesend angesehen. Solche Telekommunikationsmethoden müssen alle technischen Erfordernisse erfüllen, die konti-
nuierlich die tatsächliche Teilnahme an der Versammlung und ihrer Beratung sicherstellen.
Art. 25. Verfahren. Eine von der Geschäftsführung, oder in deren Abwesenheit von der Hauptversammlung, bestimmte
Person steht jeder Hauptversammlung vor.
Der Vorsitzende der Hauptversammlung ernennt einen Schriftführer.
Die Hauptversammlung wird aus den anwesenden oder vertretenen Aktionären einen (1) Stimmenzähler wählen.
Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden zusammen den Vorstand der Hauptversammlung.
Art. 26. Vertagung. Die Geschäftsführung kann jede Hauptversammlung für vier Wochen vertagen. Die Geschäftsfüh-
rung ist zur Vertagung verpflichtet, wenn es die Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des von der Gesellschaft
ausgegebenen Kapitals vertreten, so verlangen.
Eine derartige Vertagung macht automatisch jeden zuvor angenommenen Beschluss gegenstandslos.
37310
L
U X E M B O U R G
Die so vertagte Hauptversammlung hat dieselbe Tagesordnung wie die ursprünglich angesetzte. Die im Hinblick auf
die ursprünglich einberufene Hauptversammlung ordnungsgemäß hinterlegten Aktien und Vollmachten behalten ihre
Gültigkeit auch für die vertagte Versammlung.
Art. 27. Abstimmung. Eine Anwesenheitsliste, die die Namen der Aktionäre und die Anzahl ihrer zur Abstimmung
berechtigenden Aktien angibt, wird von den Aktionären oder von ihren Vertretern vor der Eröffnung der Hauptver-
sammlung unterzeichnet.
Die Hauptversammlung darf nur über solche Punkte beraten und abstimmen, die auf der Tagesordnung aufgeführt sind.
Die Abstimmungen finden per Handzeichen oder durch Namensaufruf statt, falls nicht die Hauptversammlung be-
schlossen hat, ein anderes Abstimmungsverfahren anzunehmen.
Die Aktionäre dürfen ihre Stimmen durch Stimmzettel („formulaires“), die in englischer Sprache abgefasst sind, abge-
ben.
Jeder Stimmzettel („formulaire“) kann persönlich gegen Empfangsbekenntnis übergeben, durch Einschreiben oder
durch Kurierdienst mittels eines international anerkannten Kurierdienstes am Gesellschaftssitz der Gesellschaft über-
bracht oder durch Fax an die Faxnummer des Gesellschaftssitzes übermittelt werden.
Jeder Stimmzettel („formulaire“), der nicht alle der folgenden Angaben enthält, wird als ungültig betrachtet und zur
Bestimmung des Quorums nicht mitgezählt:
- Name und Geschäftssitz bzw. Wohnsitz des jeweiligen Aktionärs;
- Anzahl der von dem jeweiligen Aktionär am Gesellschaftskapital insgesamt gehaltenen Aktien und, gegebenenfalls,
die Anzahl der Aktien jeder Kategorie die von dem jeweiligen Aktionär am Gesellschaftskapital gehalten werden;
- Tagesordnung der Versammlung;
- Angabe durch den jeweiligen Aktionär mit Bezug auf die vorgeschlagenen Beschlüsse, der Anzahl der Aktien mit
deren Stimme sich der Aktionär enthält, dafür oder dagegen stimmt; und
- Name, Titel und Unterschrift des ordnungsgemäß ernannten Vertreters des jeweiligen Aktionärs.
Jeder Stimmzettel („formulaire“) muss der Gesellschaft bis spätestens 17 Uhr Luxemburgischer Zeit an dem Tag
unmittelbar vor dem Tag der Generalversammlung und an dem Banken üblicherweise ihre Geschäftstätigkeit ausüben,
übermittelt werden. Jeder Stimmzettel („formulaire“), der der Gesellschaft nach diesem Termin zugeht, wird für die
Zwecke des Quorums nicht berücksichtigt.
Ein Stimmzettel („formulaire“) wird wie folgt als zugegangen betrachtet:
(a) wenn er persönlich gegen Empfangsbekenntnis übergeben, durch eingeschriebenen Brief übersendet oder durch
speziellen Kurierdienst mit einer international anerkannten Kurierfirma überbracht wird: im Moment der Übergabe;
(b) wenn er durch Fax übermittelt wird: zum Zeitpunkt der Aufnahme zusammen mit der Faxnummer des empfan-
genden Faxgeräts auf der Empfangsbestätigung.
Bei jeder Hauptversammlung, mit Ausnahme der Hauptversammlungen, die zum Zwecke der Satzungsänderung oder
zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme den Quorum-oder Mehrheitserfordernissen einer Satzungsänderung
unterliegt, einberufen wurde, werden die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit und ungeachtet der Anzahl der vertretenen
Aktien angenommen, es sei denn, dass eine Gesellschaftervereinbarung zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaf-
tern eine höhere Mehrheit vorschreibt, in solchem Falle wendet sich die höhere Mehrheit an.
Bei jeder Hauptversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz zum Zwecke der Satzungs-
änderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme den Quorum-oder Mehrheitserfordernissen einer
Satzungsänderung unterliegt, einberufen wurde, entspricht das Quorum mindestens der Hälfte (1/2) aller ausgegebenen
und noch ausstehenden Aktien. Sollte dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht werden, kann eine
zweite Versammlung einberufen werden, welche keinem Quorumserfordernis unterliegt. In jeder Hauptversammlung ist
zur Annahme eines vorgeschlagenen Beschlusses eine Zwei-Drittel Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden
oder vertretenen Aktionäre erforderlich, es sei denn, dass das Gesetz oder eine Gesellschaftervereinbarung zwischen
der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern eine höhere Mehrheit vorschreibt, in solchem Falle wendet sich die höhere
Mehrheit an.
Außer wenn die Satzung etwas anderes vorschreibt bedarf jeder Beschluss der Hauptversammlung der Zustimmung
durch die Geschäftsführung.
Art. 28. Protokoll. Das Sitzungsprotokoll der Hauptversammlung wird vom Vorstand der Hauptversammlung unter-
zeichnet. Es kann auf Verlangen von jedem Aktionär oder Bevollmächtigtem eines Aktionärs unterzeichnet werden.
Kapitel V. - Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverteilung
Art. 29. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am ersten Dezember
eines jeden Jahres.
Art. 30. Annahme der Finanzberichte. Die Geschäftsführung bereitet in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Be-
stimmungen und den luxemburgischen Buchhaltungsvorschriften den Jahresabschluss und/oder den konsolidierten Jah-
37311
L
U X E M B O U R G
resabschluss zur Feststellung durch die Aktionäre vor. Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss
wird/werden der Hauptversammlung zur Feststellung vorgelegt.
Art. 31. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der
gesetzlich vorgesehenen Rücklage (die „gesetzliche Rücklage“) zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die ge-
setzliche Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmt die Hauptversammlung wie der verbleibende jährliche Rein-
gewinn verteilt werden soll indem sie diesen vollständige oder teilweise einer Rücklage oder Rückstellung zuweisen, auf
das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Aus-
gabeprämien an die Inhaber der Aktien der Kategorie A und die Inhaber der Aktien der Kategorie B ausschütten, wobei
jede Aktie in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.
Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestim-
mungen, kann die Geschäftsführung eine Abschlagsdividende an die Inhaber der Aktien der Kategorie A und die Inhaber
der Aktien der Kategorie B auszahlen. Die Geschäftsführung legt die Summe und das Datum einer solchen Abschlags-
zahlung fest.
Kapitel VI. - Auflösung, Abwicklung
Art. 32. Auflösung, Abwicklung. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung, der in Übereinstim-
mung mit den nach der Satzung oder den auf eine Satzungsänderung anwendbaren Gesetzen erforderlichen Quorum und
Mehrheiten gefasst worden ist, aufgelöst werden.
Wird die Gesellschaft aufgelöst, soll ihre Abwicklung von der Geschäftsführung oder jeder anderen von der Haupt-
versammlung ernannten (natürlichen oder juristischen) Person ausgeführt werden, deren Befugnisse und Vergütung von
der Hauptversammlung festgelegt werden.
Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-
quidationskosten wird der Reinerlös aus der Abwicklung an die Inhaber der Aktien der Kategorie A und die Inhaber der
Aktien der Kategorie B so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis den auf die Ausschüttung von Dividenden anwend-
baren Regeln entspricht.
Kapitel VII. - Anwendbares Recht
Art. 33. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, be-
stimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere nach dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915,
in seiner zuletzt geltenden Fassung.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Satzung ist somit festgesetzt
(i) Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., rechtmäßig vertreten wie oben beschrieben, handelnd in ihrer Eigenschaft
als rechtmäßige Vertreterin durch vorgenannte Vollmacht, erklärt sich bereit vier Millionen acht hunderteinundsechzig-
tausendzehn (4.861.010) Aktien der Kategorie A und einhundert (100) Aktien der Kategorie B mit einem Nennwert von
einem Eurocent (EUR 0.01) zu zeichnen.
Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. erklärt sich zur vollständigen Zahlung des Nennwerts:
- der Aktien der Kategorie A, d.h. ein Gesamtwert von achtundvierzigtausendsechshundertzehn Euro und zehn Eu-
rocent (EUR 48.610,10) zusammen mit der Zahlung einer Aktienprämie im Wert von vier Millionen achthundertzwölf-
tausenddreihundertneunundneunzig Euro und neunzig Eurocent (EUR 4.812.399,90) durch Sacheinlage bestehend aus vier
Millionen achthunderteinundsechzigtausendzehn (4.861.010) Aktien der Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet gemäß dem Luxemburger Gesetz, mit
einem Gesellschaftskapital von dreiundvierzig Millionen siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR 43.750.000,-), mit Ge-
sellschaftssitz in 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen im
Luxemburger Handels-und Firmenregister unter der Nummer B 160.558 („Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.“)
unterteilt in vierhundertsechsundachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie A, vierhundertsechsun-
dachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie B, vierhundertsechsundachtzigtausendeinhunderteine
(486.101) Aktie der Kategorie C, vierhundertsechsundachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie D,
vierhundertsechsundachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie E, vierhundertsechsundachtzigtausen-
deinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie F, vierhundertsechsundachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der
Kategorie G, vierhundertsechsundachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie H, vierhundertsechsun-
dachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie I, vierhundertsechsundachtzigtausendeinhunderteine
(486.101) Aktie der Kategorie J, der Gesellschaft Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.,
- der Aktien der Kategorie B, d.h. ein Gesamtwert von einem Euro (EUR 1,-) zusammen mit der Zahlung einer Akti-
enprämie im Wert von neunundneunzig Euro (EUR 99,-) durch Sacheinlage bestehen aus einem Gesamtwert von
einhundert (100) Aktien der Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., unterteilt in zehn (10) Aktien der Kategorie A, zehn
(10) Aktien der Kategorie B, zehn (10) Aktien der Kategorie C, zehn (10) Aktien der Kategorie D, zehn (10) Aktien der
Kategorie E, zehn (10) Aktien der Kategorie F, zehn (10) Aktien der Kategorie G, zehn (10) Aktien der Kategorie H, zehn
37312
L
U X E M B O U R G
(10) Aktien der Kategorie I, zehn (10) Aktien der Kategorie J, der Gesellschaft Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.,
bereit
(gemeinsam die „Einzahlung 1“).
Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. erklärt, dass die Einzahlung 1 frei von Pfand-oder Zurückbehaltungsrecht ist,
soweit anwendbar, und dass keine Hindernisse für die freie Übertragbarkeit der Einzahlung 1 ohne Einschränkung oder
Begrenzung an die Gesellschaft bestehen, und dass gültige Anweisungen gegeben worden sind, um alle notwendigen
Bekanntmachungen, Registrierungen oder andere Formalitäten durchzuführen, um eine gültige Übertragung der Einzah-
lung an die Gesellschaft zu gewährleisten.
(ii) Lucas Flynn, rechtmäßig vertreten wie oben beschrieben, handelnd in seiner Eigenschaft als rechtmäßiger Vertreter
durch vorgenannte Vollmacht, erklärt sich bereit eine (1) Aktie der Kategorie A mit einem Nennwert von einem Eurocent
(EUR 0.01) zu zeichnen,
Lucas Flynn erklärt sich zur vollständigen Zahlung des Nennwertes dieser Aktie der Kategorie A bereit, d.h. ein Betrag
von einem Eurocent (EUR 0.01) mit der Zahlung einer Aktienprämie im Wert von neunundneunzig Eurocent (EUR 0.99)
durch Sacheinlage bestehend aus einer (1) Aktie der Kategorie A der Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l. (die „Ein-
zahlung 2“).
Lucas Flynn erklärt dass die Einzahlung 2 frei von Pfand-oder Zurückbehaltungsrecht ist, soweit anwendbar, und dass
keine Hindernisse für die freie Übertragbarkeit der Einzahlung 2 ohne Einschränkung oder Begrenzung an die Gesellschaft
bestehen, und dass gültige Anweisungen gegeben worden sind, um alle notwendigen Bekanntmachungen, Registrierungen
oder andere Formalitäten durchzuführen, um eine gültige Übertragung der Einzahlung an die Gesellschaft zu gewährleisten.
(iii) Claus von Hermann, rechtmäßig vertreten wie oben beschrieben, handelnd in seiner Eigenschaft als rechtmäßiger
Vertreter durch vorgenannte Vollmacht, erklärt sich bereit eine (1) Aktie der Kategorie A mit einem Nennwert von
einem Eurocent (EUR 0.01) zu zeichnen,
Claus von Hermann erklärt sich zur vollständigen Zahlung des Nennwertes dieser Aktie der Kategorie A bereit, d.h.
ein Betrag von einem Eurocent (EUR 0.01) mit der Zahlung einer Aktienprämie im Wert von neunundneunzig Eurocent
(EUR 0.99) durch Sacheinlage bestehend aus einer (1) Aktie der Kategorie A der Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.
(die „Einzahlung 3“).
Claus Hermann erklärt dass die Einzahlung 3 frei von Pfand-oder Zurückbehaltungsrecht ist, soweit anwendbar, und
dass keine Hindernisse für die freie Übertragbarkeit der Einzahlung 3 ohne Einschränkung oder Begrenzung an die Ge-
sellschaft bestehen, und dass gültige Anweisungen gegeben worden sind, um alle notwendigen Bekanntmachungen,
Registrierungen oder andere Formalitäten durchzuführen, um eine gültige Übertragung der Einzahlung an die Gesellschaft
zu gewährleisten.
Die vorgenannten Parteien erklärten weiterhin dass ein Gutachten von ERNST & YOUNG, mit Gesellschaftssitz in 7,
Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, als unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) erstellt wur-
de, welches von Herrn Jeannot WEYER, am 23. Dezember 2011 unterzeichnet wurde, in welchem die Einzahlung 1, die
Einzahlung 2 und die Einzahlung 3 (zusammen die „Einzahlungen“) beschrieben und bewertet wurden (das „Gutachten“).
Die Zusammenfassung des Gutachtens lautet wie folgt:
„Basierend auf der von uns durchgeführten und wie oben beschriebenen Prüfung, ist uns nichts zugetragen worden,
was uns glauben lässt, dass der Wert der Sacheinlage nicht mindestens mit der Anzahl und dem Nennwert der 4.861.012
Aktien der Kategorie A und der 100 Aktien der Kategorie B mit einem Nennwert von EUR 0,01 übereinstimmt, welche
zusammen mit einer Aktienprämie von EUR 4.812.500,88 auszugeben sind, demzufolge einem Gesamtgegenwert in Höhe
von EUR 4.861.112,-“.
Das Gutachten nachdem es „ne varietur“ von dem Bevollmächtigen und dem Notar unterzeichnet wurde, bleibt der
vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigefügt.
Beweis für diese Zahlungen wurde dem unterzeichneten Notar überbracht welcher erklärt, dass die Voraussetzungen
von Artikel 26 und Artikel 103 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, wie abgeändert,
gewahrt wurden.
<i>Geschätzte Kosteni>
Die Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entste-
hen, werden auf ungefähr dreitausendfünfhundert Euro (EUR 3.500,-) geschätzt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2012.
<i>Außerordentliche Hauptversammlungi>
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.
37313
L
U X E M B O U R G
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung hat beschlossen, die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates auf drei festzulegen, und folgende
Personen für einen Zeitraum, der mit der nächsten ordentlichen Hauptversammlung endet, zu Mitgliedern des Aufsichts-
rates zu ernennen:
- Herr Jeffrey Curtis Malenky, geboren am 5. April 1955, in Pennsylvania (USA), beruflich wohnhaft in 7702 FM 1960
Rd E, Humble, TX 77346, USA;
- Herr Charles Edward Nield Herlinger, geboren am 5. November 1955, in Preston (Vereinigtes Königreich), beruflich
wohnhaft in HPC 010-610 Rodenbacher Chaussée 4, 63457 Hanau-Wolfgang, Deutschland; und
- Herr Jacky Levell Clem, geboren am 30. August 1953, in Texas (USA), beruflich wohnhaft in HPC 010-610 Roden-
bacher Chaussée 4, 63457 Hanau-Wolfgang, Deutschland.
Der unterzeichnende Notar, der Englischen spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten
Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Person und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.
Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg
aufgenommen wurde.
Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-
nenen Partei vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden
Notar, unterzeichnet.
Gezeichnet: M. Frantz, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 29 décembre 2011. Relation: RED/2011/2980. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
Für gleichlautende Abschrift, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, den 29. Dezember 2011.
Référence de publication: 2012013498/917.
(120016101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Luxtanne, Société Anonyme.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 143.367.
Les comptes annuels au 30.06.10 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012022023/9.
(120028246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Lanz Lux LED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 166.828.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend zwölf.
Den zweiten Februar.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1.- Herr Thorsten KLÄS, Unternehmensberater, beruflich wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue;
2.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts Ecopax Vermögensverwaltung GmbH, mit Sitz in
D-54317 Gutweiler, 44, Im obersten Garten, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wittlich unter der Num-
mer HRB 41231,
hier rechtsgültig vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herr Michael KLIPPEL, Unternehmensberater,
wohnhaft in D-54317 Gutweiler, 44, Im obersten Garten;
Welche Komparenten den handelnden Notar ersuchten die Satzungen einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie
folgt zu beurkunden:
Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „Lanz Lux LED S.A.“.
Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Mertert. Durch einfachen Beschluss des Vorstands mit Zus-
timmung des Aufsichtsrats können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland Filialen und Zweigstellen errichtet werden.
37314
L
U X E M B O U R G
Durch einfachen Beschluss des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats können sowohl in Luxemburg als auch im
Ausland Filialen und Zweigstellen errichtet werden. Durch einfachen Beschluss des Vorstands kann der Sitz der Gesell-
schaft innerhalb des Großherzogtums Luxemburg an einen beliebigen Ort verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit der Gesellschaft an die-
sem Sitz oder der Gesellschaft mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder
sozialer Art beeinträchtigt oder durch das Bevorstehen solcher Ereignisse gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz
provisorisch und bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.
Die Nationalität der Gesellschaft soll unbeeinflusst durch eine derartige provisorische Sitzverlegung luxemburgisch
bleiben.
Personen, welche in irgendeiner Weise befugt sind, die Gesellschaft in der laufenden Geschäftsführung rechtsverbind-
lich zu vertreten, sind auch befugt, diese Verlegung des Gesellschaftssitzes vorzunehmen und Dritten zur Kenntnis zu
bringen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die Dauer kann begrenzt werden durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre unter den für Sa-
tzungsänderungen geltenden Bedingungen, in dem Fall kann die Gesellschaft jedoch Verpflichtungen eingehen, die ihre
derart begrenzte Dauer überschreiten.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von LED-(light-emitting diode),
sowie Audioprodukten.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder
denselben fördern.
Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-
mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-
teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Großherzogtum Luxembourg wie auch im Ausland, aus-
zuführen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000,-) und ist aufgeteilt in ein
hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je DREI HUNDERT ZEHN EURO (€ 310,-).
Art. 6. Die Aktien sind Namensaktien. Auf Verlangen eines Aktionärs können seine Aktien mit Zustimmung der Ge-
sellschaft in Inhaberaktien umgewandelt werden.
Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das alle Aktionäre jederzeit Einsicht
nehmen können. Die Eintragung in das Register der Namensaktien umfasst folgende Angaben:
Die genaue Bezeichnung eines jeden Aktionärs, die Anzahl und Nummern seiner Aktien, die auf die Aktien geleisteten
Zahlungen sowie die Übertragungen der Aktien mit deren Daten oder die Umwandlung der Namensaktien in Inhabe-
raktien.
Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch Eintragung, in das Register begründet. Den Inhabern von Namensaktien
werden Bescheinigungen über die Eintragung ausgestellt.
Art. 7. Die Übertragung von Namensaktien erfolgt durch eine Übertragungserklärung, die in das Register eingetragen,
datiert und von den Parteien der Übertragung oder deren Bevollmächtigten unterzeichnet wird.
Die Übertragung von Namensaktien kann Dritten auch ohne Eintragung ins Aktienregister entgegengehalten werden,
wenn die Übertragungserklärung der Gesellschaft gerichtlich zugestellt worden ist oder die Gesellschaft die Übertragung
in einer notariellen Urkunde anerkennt.
Es ist der Gesellschaft anheimgestellt, eine Übertragung anzunehmen und ins Register einzutragen, welche aus dem
Schriftwechsel oder anderen die Übereinkunft des Abtretenden und des Übernehmers darlegenden Schriftstücken her-
vorgeht. Alle Urkunden, die sich auf die Übertragung von Namensaktien beziehen, werden dem Register als Anlage
beigefügt.
Art. 8. Die Rechte, die sich aus den Aktien ergeben, sind der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
Art. 9. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der Generalversammlung erhöht oder herabgesetzt werden,
aber nur wenn alle Aktionäre der Gesellschaft dieser Stammkapitalerhöhung uneingeschränkt zustimmen.
Die Generalversammlung kann folglich den Vorstand in ihrem Beschluss über eine Kapitalerhöhung ermächtigen, das
Gesellschaftskapital durch einfachen Beschluss mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach seinem Ermessen in dem Rahmen
zu erhöhen, den der Beschluss der Generalversammlung festlegt.
37315
L
U X E M B O U R G
Werden neue Aktien gegen Bareinzahlung ausgegeben, so steht jedem Aktionär ein Bezugsrecht auf Zuteilung neuer
Aktien zu, deren Anzahl seinem Anteil an dem bisherigen Gesellschaftskapital entsprechen muss. Die Generalversammlung
kann dieses Recht im Beschluss über die Kapitalerhöhung ganz oder zum Teil ausschließen.
III. Verwaltungsrat:
Art. 10. Ernennung, Zusammensetzung und Vakanz. Der Verwaltungsrat setzt sich aus mindestens drei Verwaltungs-
ratsmitgliedern zusammen.
Der Aufsichtsrat ernennt die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate. Die
Verwaltungsratsmitglieder werden auf höchstens sechs Jahre bestellt. Sie können wiedergewählt werden.
Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds während der vorgesehenen Amtsdauer frei, so steht den verbleibenden
Verwaltungsratsmitgliedern das Recht zu, die Stelle vorläufig zu besetzen. In diesem Falle hat der Aufsichtsrat für die
verbleibende Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds das neue Verwaltungsratsmitglied endgültig zu ernennen oder ein
anderes zu wählen.
Art. 11. Innere Organisation des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung und legt diese
dem Aufsichtsrat zur Billigung vor. In der Geschäftsordnung ist zugleich festzulegen, welche Geschäfte der Zustimmung
des Aufsichtsrats bedürfen.
Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und gegebenenfalls einen stellvertretenden Vorsi-
tzenden. Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser verhindert ist.
Die Verwaltungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen.
Verwaltungsratssitzungen sind einzuberufen, so oft es die Belange der Gesellschaft erfordern; eine Verwaltungsrats-
sitzung ist unverzüglich einzuberufen, sofern es zwei Verwaltungsratsmitglieder verlangen.
Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats ist es erforderlich, dass die Mehrheit der amtie-
renden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten ist.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch den Vorsitzenden der Sitzung unterschrieben.
Beschlüsse des Verwaltungsrats können einstimmig durch Brief, Telefon oder elektronische Kommunikation gefasst
werden. Sie sind unverzüglich zu protokollieren.
Art. 12. Aufgaben und Kompetenzen. Dem Verwaltungsrat obliegt die Geschäftsführung der Gesellschaft. Er besitzt
hierzu die umfassendsten Vollmachten einschließlich des Verfügungsrechts.
Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die
Satzung dem Aufsichtsrat oder der Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat kann auch Schuldverschreibungen und Schuldscheine ausgeben, hypothekarische oder andere Si-
cherheiten gewähren oder annehmen, die Löschung von Privilegien, Hypotheken und Auflösungsrechten bewilligen, im
Rahmen des Gesellschaftszwecks Grundstücke kaufen, veräußern oder belasten, Schulden nachlassen und über irgendwie
geartete Interessen der Gesellschaft Vergleiche und Kompromisse abschließen.
Art. 13. Vertretung. Die Gesellschaft wird durch zwei Verwaltungsratsmitglieder gemeinschaftlich oder durch Bevoll-
mächtigte nach Maßgabe ihrer Vollmacht vertreten.
IV. Aufsichtsrat:
Art. 14. Ernennung, Zusammensetzung und Vakanz. Der Aufsichtsrat setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern zu-
sammen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden durch die Generalversammlung bestimmt. Sie werden auf höchstens
sechs Jahre gewählt. Sie können wiedergewählt werden. Während ihrer Amtszeit können sie jederzeit durch die Gene-
ralversammlung abberufen werden.
Der Aufsichtsrat bestimmt einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die
Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser verhindert ist.
Sofern bei Abstimmungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats Stimmengleichheit besteht, gibt die Stimme des
Vorsitzenden den Ausschlag.
Der Aufsichtsrat wird durch seinen Vorsitzenden einberufen. Der Vorsitzende ist zur Einberufung verpflichtet, wenn
ein entsprechender Antrag mindestens zweier Aufsichtsratsmitglieder oder des Vorstandes vorliegt.
Wird die Stelle eines Aufsichtsratsmitglieds während der vorgesehenen Amtsdauer frei, so steht dem Aufsichtsrat das
Recht zu, die Stelle mit einem seiner Mitglieder vorläufig zu besetzen.
Art. 15. Aufgaben und Kompetenzen. Der Aufsichtsrat übt die permanente Kontrolle über die Tätigkeiten des Ver-
waltungsrats (Geschäftsführung) aus. Es ist dem Aufsichtsrat jedoch untersagt, sich hierbei in die Geschäftsführung
einzumischen.
Dem Aufsichtsrat steht das Recht zu, sämtliche zur Erfüllung dieser Aufgabe notwendigen Informationen einzufordern.
Hiervon umfasst ist das Recht Einsicht in Geschäftsbücher, Korrespondenz, Protokolle und sonstige Niederschriften der
Gesellschaft zu nehmen.
37316
L
U X E M B O U R G
Der Verwaltungsrat hat dem Aufsichtsrat mindestens alle drei Monate einen schriftlichen Bericht über den derzeitigen
und zu erwartenden Gang der Geschäfte vorzulegen.
Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, den Aufsichtsrat innerhalb angemessener Zeit von sämtlichen Geschehnissen zu
unterrichten, die von nicht unerheblichem Einfluss auf die Gesellschaft sein können.
Art. 16. Übertragung von Befugnissen. Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder inhaltlich bes-
timmte Aufgaben übertragen.
Dem Aufsichtsrat steht es frei Ausschüsse zu gründen, deren Zusammensetzung und Aufgabenbereich er festlegt und
die ihre Tätigkeit unter seiner Aufsicht ausüben. Den Ausschüssen dürfen keine Aufgaben zugewiesen werden welche
nach dem Gesetz oder nach der Satzung dem Aufsichtsrat selbst zugewiesen sind. Die Zuweisungen dürfen die Befugnisse
des Verwaltungsrats nicht beschränken.
V. Generalversammlung:
Art. 17. Einmal im Jahr findet eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am zweiten Donnerstag des Monats
März, um 10:00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in dem Einberufungsschreiben angegebenen Ort. Ist
dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die ordentliche Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag zur
selben Stunde statt.
Außerordentliche Generalversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die in der Einbe-
rufung festgelegt sind.
Art. 18. Die Einberufung zu Generalversammlungen erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes vom zehnten August neun-
zehnhundertfünfzehn betreffend die Handelsgesellschaften.
Eine förmliche Einberufung ist nicht erforderlich wenn alle Aktionäre anwesend oder rechtsgültig vertreten sind und
in Kenntnis der Tagesordnung die Eröffnung der Generalversammlung beschließen.
Art. 19. Sofern die Einberufungsbekanntmachung es vorsieht, muss jeder Inhaber von Namensaktien, um in der Ge-
neralversammlung das Stimmrecht ausüben zu können, spätestens bis zum Ablauf des sechsten Tages vor dem Versamm-
lungstag seine Teilnahme anmelden; Inhaberaktien müssen in diesem Fall bis zu dem vorgenannten Zeitpunkt bei der
Gesellschaft oder bei den in der Einberufungsbekanntmachung bezeichneten Stellen bis zur Beendigung der Generalver-
sammlung hinterlegt werden.
Art. 20. Jede Aktie gewährt eine Stimme unbeschadet anderslautender gesetzlicher Bestimmungen. Jeder Aktionär
kann sich in der Generalversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
Dieser muss im Besitz einer schriftlichen Vollmacht sein. Der Inhalt der Vollmacht kann vom Verwaltungsrat festgelegt
werden.
Art. 21. Soweit gesetzlich nicht anders bestimmt ist, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Art. 22. Die Generalversammlungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats, dessen Stellvertreter oder bei Ve-
rhinderung beider von einem von der Versammlung bestimmten Mitglied der Versammlung geleitet. Der Vorsitzende
bestellt einen Schriftführer und einen Stimmzähler. Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden,
dem Schriftführer und dem Stimmzähler unterzeichnet.
Anwesende Aktionäre und Vertreter von Aktionären unterzeichnen das Protokoll ebenfalls, wenn sie es verlangen.
VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung
Art. 23. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines
jeden Jahres.
Jedes Jahr hat der Verwaltungsrat für das vergangene Geschäftsjahr die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und
ein Inventar aufzustellen.
Art. 24. Über den nicht zur Bildung der gesetzlichen Rücklage benötigten Betrag des jährlichen Reingewinns verfügt
die ordentliche Generalversammlung.
Eine durch die Generalversammlung beschlossene Dividende ist an dem nächstfolgenden Bankarbeitstag zur Auszahlung
fällig sofern die Generalversammlung nichts abweichendes beschließt.
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Zwischendividenden unter Berücksichtigung der im Artikel 72-2 des Gesetzes vom
10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen auszuzahlen.
VII. Auflösung, Liquidation
Art. 25. Wird die Gesellschaft aufgelöst, so führt der Verwaltungsrat die Liquidation durch, falls die Generalversamm-
lung nicht einen oder mehrere andere Liquidatoren bestellt.
Das nach Begleichung aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Restvermögen wird unter die Aktionäre
entsprechend ihrem Anteil verteilt.
37317
L
U X E M B O U R G
VIII. Allgemeine Bestimmung
Art. 26. Soweit die Angelegenheiten der Gesellschaft in dieser Satzung nicht geregelt sind, gelten die Vorschriften des
Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn betreffend die Handelsgesellschaften.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endigt am 31. Dezember 2012.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2013 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Anteilhaber die ein hundert (100) Aktien wie folgt zu zeichnen:
1.- Herr Thorsten KLÄS, Unternehmensberater, beruflich wohnhaft in L-6630 Wasserbillig,
66-70, Grand-rue; fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts Ecopax Vermögensverwaltung GmbH,
mit Sitz in D-54317 Gutweiler, 44, Im obersten Garten, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Wittlich unter der Nummer HRB 41231, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
TOTAL: ein hundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sämtliche Aktien wurden bis zum Belaufe von fünfundzwanzig (25%) in bar eingezahlt; machend den Betrag von SIEBEN
TAUSEND SIEBEN HUNDERT FÜNFZIG EURO (€ 7.750,-), wie dies dem Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Die Aktien verbleiben Namensaktien bis zu ihrer gänzlichen Einzahlung.
<i>Erklärungi>
Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst
nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
Der amtierende Notar erklärt außerdem dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft obliegenden Gründungskosten irgendwelcher Art werden abgeschätzt auf ungefähr ein tausend
vier hundert Euro (1.400, EUR).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausse-
rordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie der Aufsichtsratsmitglieder wird auf jeweils drei und die Zahl der
Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden bestellt:
a) Herr Günter KLEE, Versicherungskaufmann, wohnhaft in D-55606 Oberhausen Bei Kirn, 1, Auf Rudert;
b) Herr Thorsten KLÄS, Unternehmensberater, wohnhaft in D54290 Trier, 54, Neustrasse;
c) Herr Michael KLIPPEL, Unternehmensberater, wohnhaft in D54317 Gutweiler, 44, Im obersten Garten;
3.- Zum Kommissar wird bestellt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung TAXolution Consulting S.à r.l, mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-
rue, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 149.181.
4.- Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden bestellt:
a) Herr Paul KAUTEN, selbständiger Unternehmer, wohnhaft in L8522 Beckerich, 6, Millewee;
b) Herr Marco DEMULLING, Diplom-Biologe, wohnhaft in L-8363 Greisch, 8, rue de l’Eglise;
c) Prof. Dr. Peter Michael HECK, Diplom-Geograf, wohnhaft in D66121 Saarbrücken, 84, Mainzer Strasse.
5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungskommissars enden bei Gelegenheit der jährlichen
Generalversammlung des Jahres 2017.
6.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6630 Wasserbillig, 6670, Grand-Rue.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Am Datum wie
eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: T. KLÄS, M. KLIPPEL, Henri BECK.
37318
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Echternach, le 9 février 2012. Relation: ECH/2012/226. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 15. Februar 2012.
Référence de publication: 2012021489/240.
(120027567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.
Kharma Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 142.036.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
D. FONTAINE
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012022015/11.
(120028012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
International Transatlantic Trading Services S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 95.626.
La FIDUCIAIRE DU KIEM S.à r.l., en sa qualité de domiciliataire, dénonce avec effet immédiat la convention de domi-
ciliation conclue avec la société anonyme INTERNATIONAL TRANSATLANTIC TRADING SERVICES S.A., ayant son
siège social au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 95626.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012021993/10.
(120028104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Intex S.A., Société Anonyme Soparfi.
R.C.S. Luxembourg B 66.721.
Le domicile de la société INTEX S.A., R.C.S. Luxembourg B n°66721, constituée le 16 octobre 1998 par-devant Maître
Joseph Elvinger Notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C N°927 du 22.12.1998, établi au 17, rue
Beaumont L - 1219 Luxembourg, a été dénoncé le 14.02.2012.
Luxembourg, le 14.02.2012.
MANACO S.A.
Signature
Référence de publication: 2012021995/12.
(120027651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Irman Lux S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.
R.C.S. Luxembourg B 80.596.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012022000/10.
(120027780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
ISDC Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J-P. Beicht.
R.C.S. Luxembourg B 74.929.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
37319
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012022001/10.
(120027779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Leverage Union for Techniques & Expertise Management, Société Anonyme.
Siège social: L-9706 Clervaux, 2B, route d'Eselborn.
R.C.S. Luxembourg B 145.637.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du jeudi 22 décembre 2011i>
L'Assemblée générale des actionnaires de la société, réunie en séance extraordinaire, prend acte:
a. de la démission de la société MS_Consult représentée par Monsieur Thierry Houben, à compter du 30/12/2011, en
qualité d'administrateur délégué de la société.
b. de la démission de Mademoiselle Stéphanie Delnoy, à compter du 30/12/2011, en qualité de Commissaire aux
comptes de la société.
c. de la nomination, à compter du 30/12/2011, en qualité d'administrateur et administrateur délégué de la société, de
Monsieur Pascal Pire domicilié rue de marteau 21, B-5537 Sosoye.
d. de la nomination, à compter du 30/12/2011, en qualité de Commissaire aux comptes de la société, de Madame Jenny
Lambillion domiciliée rue de marteau 21, B-5537 Sosoye.
Pour Extrait certifié conforme
<i>Pour MS_Consult
Président
i>Th. Houben
<i>Gérant Techniquei>
Référence de publication: 2012022030/22.
(120027668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Islali Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J-P. Beicht.
R.C.S. Luxembourg B 74.930.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012022002/10.
(120027782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Italian Food Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 156.301.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2012.
Référence de publication: 2012022003/10.
(120028028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Financom Venture S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 79.573.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 février 2012i>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Guy HORNICK de son mandat d’administrateur de catégorie B et de
Président du conseil d’administration.
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2015:
37320
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, administrateur de catégorie A.
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, administrateur de catégorie B.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration le 15 février 2012i>
Est nommé président du conseil d'administration, Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant
professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d’administrateur et tout renouvellement, démission
ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 15 février 2012.
Référence de publication: 2012023060/24.
(120029660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2012.
Sitronics Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 113.040.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 octobre 2011i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Evgeny Popov, avec adresse professionnelle au
PO-3, 35-141, RUS-Lubertsy, Russia, de Monsieur Evgeny Tarasov, avec adresse professionnelle au 2-7, Shkolnaya, RUS
Konobeevo, Voskresensky Rayon, Russia, de Monsieur Gilles Jacquet avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg, de Monsieur Pieter Van Nugteren avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey L-2163
Luxembourg et ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Grant Thornton Lux Audit S.A., anciennement Lux
Audit Révision Sàrl, ayant son siège social au 83 Pafebruch, L-8308 Capellen. Ces mandats se termineront lors de l’as-
semblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2011.
Luxembourg, le 14 février 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012022179/19.
(120027907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Cocalos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 122.567.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2012 que:
- Monsieur Bertrand MICHAUD, né le 21 Novembre 1961 à Paris (France), demeurant professionnellement au 3 rue
Belle-Vue L-1227 Luxembourg, de Madame Orietta RIMI, née le 29 septembre 1976 à Erice (Italie), demeurant profes-
sionnellement au 40 Avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg et Madame Valérie WESQUY, née le 6 mars 1968 à
Mont Saint Martin (France) et demeurant professionnellement au 19 Boulevard Grande Duchesse Charlotte L-1331
Luxembourg, ont été nommés administrateurs en remplacement des Messieurs Jean-Yves NICOLAS, Marc KOEUNE,
Michaël ZIANVENI et Sébastien GRAVIERE, démissionnaires.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.
- La société SER.COM Sàrl, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 19, Boulevard Grande Duchesse Charlotte,
a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de CeDerLux-Services S.à.r.l., démissionnaire.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.
- La siège de la société est établie au 38, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 février 2012.
Référence de publication: 2012022443/21.
(120029254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2012.
37321
L
U X E M B O U R G
Japie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 129.415.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012022005/10.
(120028118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Kronospan Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier.
R.C.S. Luxembourg B 46.483.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 janvier 2012i>
L’Assemblée Générale ratifie la démission de Monsieur Mathias KAINDL de sa fonction de président du conseil d’ad-
ministration présenté lors du conseil d’administration du 04 janvier 2012.
Par décision du conseil d’administration, Monsieur Ludwig A. SCHREIBLREITER remplacera Monsieur Mathias KAINDL
en tant que président du conseil d’administration avec effet au 04 janvier 2012.
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de la société BDO Audit ayant son siège social 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg aux fonctions de réviseur d'entreprises avec. Son mandat prendra fin à l'issue de l'As-
semblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2012.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012022018/17.
(120028387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Lakey Corp S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.411.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Eric Lechat / Justyna Bielasik
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012022019/13.
(120027692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Naxos Capital Managers S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 102.783.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2011:i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme comme Commissaire aux Comptes:
- Fiduciaire de Luxembourg S.A., avec siège social au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2016.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2012022070/14.
(120027836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
37322
L
U X E M B O U R G
NIFE Carlo Seccomandi, Société en Commandite simple.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 69.397.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 FEV. 2012.
<i>Pour: NIFE CARLO SECCOMANDI
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo
Référence de publication: 2012022084/15.
(120027988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Lavipharm Group Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 33.244.
Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26 Januar 2012 sind folgende Änderungen beschlossen worden:
Die Gesellschaft verlegt den Geschäftssitz.
Der neue Sitz befindet sich unter folgender Adresse:
1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg
<i>Für die Gesellschaft
i>Gabriela Zaleski
Référence de publication: 2012022029/13.
(120027731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Luxnova S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 103.798.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15.02.12.
Référence de publication: 2012022022/10.
(120027698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
LA Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9230 Diekirch, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 146.465.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 15.02.2012.
Signature.
Référence de publication: 2012022024/10.
(120027793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
LA Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9230 Diekirch, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 146.465.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
37323
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 15.02.2012.
Signature.
Référence de publication: 2012022025/10.
(120027794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.550,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 157.844.
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société en date du 13 février 2012i>
- La démission de Mme Charlotte Lahaije-Hultman en tant que gérant de classe B de la Société a été acceptée avec
effet au 13 février 2012.
- Monsieur Jean (John) Wantz, employé privé, né le 17 mai 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommé en tant que nouveau gérant de classe B de la Société avec
effet au 13 février 2012 et pour une durée indéterminée.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à r.l.
Mandatairei>
Référence de publication: 2012022045/17.
(120027778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Goya Airports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.018.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 163.774.
In the year two thousand and twelve, on the third of February.
Before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1.- Ferrovial Aeropuertos, S.A., a public limited liability company organized and existing under the laws of Spain, having
its registered office at Calle Principe De Vergara, 135, Madrid, 28002, Spain and registered with Commercial Registry of
Madrid, section 8 th , volume 15,650, and sheet number M-263.569;
2.- IFM Luxembourg No. 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-5365 Munsbach, 6C, rue
Gabriel Lippmann, having a share capital of ONE MILLION NINE HUNDRED FIFTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUN-
DRED EURO (EUR 1,957,500) and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number
B 151.630;
3.- Infinity Investments S.A., a public limited liability company (société anonyme) organized and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen, and
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 139.024;
4.- CPP Investment Board European Holdings S.à.r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1855 Luxem-
bourg, 47, avenue John F. Kennedy, having a share capital of FIVE HUNDRED TWELVE THOUSAND ONE HUNDRED
AND TWENTY FIVE EURO (EUR 512,125) and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
the number B 111.828.
The appearing parties are hereby represented as follows:
- the appearing companies sub 1, 2, and 4) by:
- Mr. Jean LAMBERT, master in economics, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert,
and
- Ms. Catherine PEUTEMAN, private employee, professionally residing in L2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert,
by virtue of three proxies given under private seal.
- the appearing company sub 3) by Ms. Sabina CRACIUNESCU, private employee, residing professionally at L-2540
Luxembourg, 13, rue Edward Steichen, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxies, signed “ne varietur” by the proxyholders of the appearing parties and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
37324
L
U X E M B O U R G
Such appearing parties, through their proxyholders, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties, represented as aforementioned, are the sole shareholders (the Shareholders) of the private
limited liability company (société à responsabilité limitée) established in Luxembourg under the name of Goya Airports
S.à r.l., having its registered office at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under the number B 163.774 (NIN 2011 2437 089) (the Company),
incorporated pursuant to a deed of the notary Francis KESSELER, residing in Esch-sur-Alzette, on the 29
th
of August
2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2822 of November 18, 2011.
II. The Company's share capital is set at EIGHTEEN THOUSAND EURO (EUR 18,000), represented by eighteen
thousand (18,000) shares with a nominal value of ONE EURO (EUR 1) each, attributed to the Shareholders as follows:
1.- Ferrovial Aeropuertos, S.A., prenamed, five thousand four hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,400
2.- IFM Luxembourg No. 2 S.à r.l., prenamed, four thousand two hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,200
3.- Infinity Investments S.A., prenamed, four thousand two hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,200
4.- CPP Investment Board European Holdings S.à.r.l., prenamed, four thousand two hundred shares . . . . . .
4,200
Total: eighteen thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,000
III. The agenda of the meeting is as follows:
1. Increasing of the share capital of the Company by the amount of ONE MILLION EURO (EUR 1,000,000) in order
to raise it from its present amount of EIGHTEEN THOUSAND EURO (EUR 18,000) to the amount of ONE MILLION
EIGHTEEN THOUSAND EURO (EUR 1,018,000) by creation and issue of one million (1,000,000) new shares with a
nominal value of ONE EURO (EUR 1) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares;
2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above;
3. Subsequent amendment to article 6.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share
capital increase specified in item 1. above;
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the regis-
tration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and
5. Miscellaneous.
IV. The Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders decide to increase the share capital of the Company by the amount of ONE MILLION EURO (EUR
1,000,000) in order to raise it from its present amount of EIGHTEEN THOUSAND EURO (EUR 18,000) to the amount
of ONE MILLION EIGHTEEN THOUSAND EURO (EUR 1,018,000) by creation and issue of one million (1,000,000) new
shares with a nominal value of ONE EURO (EUR 1) each, vested with the same rights and obligations as the existing
shares.
<i>Subscription – Paymenti>
Thereupon:
- three hundred thousand and one (300,001) new shares are subscribed by Ferrovial Aeropuertos, S.A., prenamed and
represented as stated above, and fully paid up by a contribution in cash in an amount of THREE HUNDRED THOUSAND
AND ONE EURO (EUR 300,001);
- two hundred thirty-three thousand three hundred thirty-three (233,333) new shares are subscribed by IFM Luxem-
bourg No. 2 S.à r.l., prenamed and represented as stated above, and fully paid up by a contribution in cash of the amount
of TWO HUNDRED THIRTY-THREE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY-THREE EURO (EUR 233,333);
- two hundred thirty-three thousand three hundred thirty-three (233,333) new shares are subscribed by Infinity In-
vestments S.A., prenamed and represented as stated above, and fully paid up by a contribution in cash in an amount of
TWO HUNDRED THIRTY-THREE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY-THREE EURO (EUR 233,333);
- two hundred thirty-three thousand three hundred thirty-three (233,333) new shares are subscribed by CPP Invest-
ment Board European Holdings S.à.r.l., prenamed and represented as stated above, and fully paid up by a contribution in
cash in an amount of TWO HUNDRED THIRTY-THREE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY-THREE EURO (EUR
233,333).
The contributions in cash, in an aggregate amount of ONE MILLION EURO (EUR 1,000,000) have to be entirely
allocated to the share capital account of the Company.
Proof of such contributions in cash has been given to the undersigned notary, who expressly states it, so that the
amount of ONE MILLION EURO (EUR 1,000,000) is as now available to the Company.
<i>Second resolutioni>
Pursuant to the aforementioned increase of the share capital, paragraph 6.1 of article 6 of the articles of association
of the Company is amended as follows:
37325
L
U X E M B O U R G
“ 6.1. Subscribed and Paid-up share capital. The Company's corporate capital is fixed at one million eighteen thousand
euro (EUR 1,018,000), represented by one million eighteen thousand (1,018,000) shares of one euro (EUR 1. -) each, all
fully subscribed and entirely paid up.”
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
and empower and authorize any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Shareholders
with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, the proxyholders of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille douze, le trois février.
Par-devant Nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Ferrovial Aeropuertos, S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois d'Espagne, ayant son siège
social au Calle Principe De Vergara, 135, Madrid, 28002, Espagne et enregistrée auprès du Registre Commercial de Madrid,
8e section, volume 15.650 et page numéro M-263.569;
2.- IFM Luxembourg No.2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand
Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, ayant un capital social d'UN
MILLION NEUF CENT CINQUANTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 1.957.500) et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.630;
3.- Infinity Investments S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois du Grand Duché de Luxembourg,
ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 13, Rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 139.024;
4.- CPP Investment Board European Holdings S.à.r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy, ayant
un capital social de CINQ CENT DOUZE MILLE CENT VINGT CINQ EUROS (EUR 512.125) et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 111.828.
Les parties comparantes sont ici représentées comme suit:
- les sociétés comparantes sub 1,2 et 4) par:
- Monsieur Jean LAMBERT, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg,
19, rue Eugène Ruppert, et
- Madame Catherine PEUTEMAN, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue
Eugène Ruppert,
en vertu de trois procurations données sous seing privé
- la société comparante sub
3) par Madame Sabina CRACIUNESCU, employee privée, demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg, 13,
rue Edward Steichen,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées “ne varietur” par les mandataires des parties comparantes et le notaire
instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Les parties comparantes, par leurs mandataires, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seuls associés (les Associés) de la société à
responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de Goya Airports S.à r.l., ayant son siège social à L-2453
Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 163.774 (NIN 2011 2437 089) (la Société),
constituée suivant acte reçu par le notaire Francis KESSELER, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 août
2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2822 du 18 novembre 2011.
II. Le capital social de la Société est fixé à DIX-HUIT MILLE EUROS (EUR 18.000), représenté par dix-huit mille (18.000)
parts sociales d'une valeur nominale d'UN EURO (EUR 1) chacune, attribuées aux Associés comme suit:
1.- Ferrovial Aeropuertos, S.A., préqualifiée, cinq mille quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.400
2.- IFM Luxembourg No.2 S.à r.l., préqualifiée, quatre mille deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.200
37326
L
U X E M B O U R G
3.- Infinity Investments S.A., préqualifiée, quatre mille deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.200
4.- CPP Investment Board European Holdings S.à.r.l., préqualifiée,
quatre mille deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.200
Total: dix-huit mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant à concurrence du montant d'UN MILLION D'EUROS
(EUR 1.000.000) pour le porter de son montant actuel de DIX-HUIT MILLE EUROS (EUR 18.000) au montant d'UN
MILLION DIX-HUIT MILLE EUROS (EUR 1.018.000) par la création et l'émission d'un million (1.000.000) de parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale d'UN EURO (EUR 1) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts
existantes;
2. Souscription et libération à l'augmentation du capital social mentionnée au point 1. ci-dessus;
3. Modification subséquente de l'article 6.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social
mentionnée au point 1. ci-dessus;
4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donné à chaque gérant, chacun agissant individuellement, de procéder, pour le compte de la Société, à l'enregistrement
des parts sociales nouvelles émises dans le registre des associés de la Société; et
5. Divers.
IV. Les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associées décident d'augmenter le capital social à concurrence du montant d'UN MILLION D'EUROS (EUR
1.000.000) pour le porter de son montant actuel de DIX-HUIT MILLE EUROS (EUR 18.000) au montant d'UN MILLION
DIX-HUIT MILLE EUROS (EUR 1.018.000) par la création et l'émission d'un million (1.000.000) de parts sociales nouvelles
d'une valeur nominale d'UN EURO (EUR 1) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts existantes.
<i>Souscription – Libérationi>
A cet effet,
- trois cent mille et une (300.001) nouvelles parts sociales ont été souscrites par Ferrovial Aeropuertos, S.A., préqualifié
et repésenté comme indiqué ci-dessus, et libérées par un apport en espèces d'un montant de TROIS CENT MILLE ET
UN EURO (EUR 300,001);
- deux cent trente-trois mille trois cent trente-trois (233.333) nouvelles parts sociales ont été souscrites par IFM
Luxembourg No.2 S.à r.l., préqualifié et représenté comme indiqué ci-dessus, et libérées par un apport en espèces d'un
montant de DEUX CENT TRENTE-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS (EUR 233,333);
- deux cent trente-trois mille trois cent trente-trois (233.333) nouvelles parts sociales ont été souscrites par Infinity
Investments S.A., préqualifié et représenté comme indiqué ci-dessus, et libérées par un apport en espèces d'un montant
de DEUX CENT TRENTE-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS (EUR 233,333);
- deux cent trente-trois mille trois cent trente-trois (233.333) nouvelles parts sociales ont été souscrites par CPP
Investment Board European Holdings S.à.r.l., préqualifié et représenté comme indiqué ci-dessus, et libérées par un apport
en espèces d'un montant de DEUX CENT TRENTE-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS (EUR 233,333).
Les apports en espèces, d'un montant total de UN MILLION D'EUROS (EUR 1.000.000) sont à entièrement allouer
au compte de capital social de la Société.
La preuve de ces apports en espèces a été rapportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, de sorte
que le montant total d'UN MILLION D'EUROS (EUR 1,000,000) est dès aujourd'hui à la libre disposition de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la prédite augmentation de capital, le paragraphe 6.1 de l'article 6 des statuts est modifié comme suit:
« 6.1. Capital souscrit et Libéré. Le capital social de la société est fixé à un million dix-huit mille euros (EUR 1.018.000),
représenté par un million dix-huit mille (1.018.000) parts sociales d'un euro (EUR 1) chacune, toutes entièrement sou-
scrites et libérées.»
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus
et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder au nom de la
Société à l'enregistrement de la part sociale nouvellement émise dans le registre des associés de la Société
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
37327
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, lesdits mandataires ont signé avec nous, le notaire,
l'original du présent acte.
Signé: J. LAMBERT, C. PEUTEMAN, S. CRACIUNESCU, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 09 février 2012. Relation: ECH/2012/229. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 15 février 2012.
Référence de publication: 2012021932/208.
(120027772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
MD2L S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 50, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg E 4.670.
<i>Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15.01.2012i>
1.- Cessions de parts sociales
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 15.01.2012, enregistré à Esch-sur-Alzette, A.C. en date du
15.01.2012 et signifié par l'huissier de Justice Josiane GLODEN d'Esch-sur-Alzette en date du 19.01.2012 que la répartition
des parts sociales de la MD2L sci susdite est dès lors la suivante:
1. Claude CROVISIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 parts
2. Patrick GESELLCHEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 parts
3. Jean-Claude STEFFEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 parts
<i>Pour la sci MD2L
i>Claude CROVISIER / Patrick GESELLCHEN
<i>Les gérantsi>
Référence de publication: 2012022056/18.
(120028197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Lorentzen & Stemoco & Sobelnord, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 86.271.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2011i>
<i>Conseil d'Administrationi>
L'Assemblée générale accepte la démission de MM. Ole Johan GJERPEN et Olivier GUERIN en leur qualité d'admi-
nistrateurs de la société et décide de nommer en leur remplacement jusqu'à l'assemblée générale de 2015 MM. Kristen
JAKOBSEN, demeurant à Uranienborg terrasse 20, N-0351 Oslo (Norvège) et Pierre HORDEQUIN, route d’Hermance
240, CH-1246 Corsier (Suisse).
Pour extrait sincère et conforme
Jean-Hugues ANTOINE
<i>Administrateur-Déléguéi>
Référence de publication: 2012022034/16.
(120027876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Lhasa S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 39, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 94.775.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012022031/10.
(120028451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
37328
L
U X E M B O U R G
Ligustika Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 133.679.
Le Comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012022032/9.
(120027744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Luxfaq Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 145.826.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012022040/9.
(120027625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Paris Nursing 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 576.475,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.991.
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 20 janvier 2012:
1. Démission de Madame Amy Maria Kelly de ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 20
janvier 2012.
2. Election de Monsieur Mark Fenchelle, né le 14 janvier 1962 à Londres, Royaume-Uni, demeurant professionnellement
8
th
Floor, 1 Knightsbridge Green, SW1X 7NE Londres, Royaume-Uni, en tant que Gérant de catégorie A pour une durée
indéterminée à partir du 20 janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Paris Nursing 1 S.à r.l.
Jean-Jacques Josset
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012022103/18.
(120028046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
M.B.&A. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 92.108.
EXTRAIT
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2012.
<i>La gérancei>
Référence de publication: 2012022041/12.
(120028015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
37329
L
U X E M B O U R G
McKey Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 155.686.
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société en date du 13 février 2012i>
- La démission de Mme Charlotte Lahaije-Hultman en tant que gérant de classe B de la Société a été acceptée avec
effet au 13 février 2012.
- Monsieur Jean (John) Wantz, employé privé, né le 17 mai 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommé en tant que nouveau gérant de classe B de la Société avec
effet au 13 février 2012 et pour une durée indéterminée.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour McKey Luxembourg Holdings S.à r.l.
Mandatairei>
Référence de publication: 2012022046/17.
(120027787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Nexeo Solutions Luxembourg Holding Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.056.780,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 154.695.
<i>Extrait des résolutions de l'associé uniquei>
En date du 16 février 2012, l'associé unique de la société a pris connaissance de la démission de Monsieur Stephen
Bowater en tant que gérant de classe A, et ce avec effet immédiat.
En cette même date, l'associé unique a décidé de nommer Monsieur Ross Jacob Crane, Chief Financial Officer, né le
28 février 1963 à Idaho aux Etats Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 9303 New Trails Drive, Suite 400,
the Woodlands, TX 77381, Texas, Etats Unis d'Amérique, en tant que gérant de classe A, et ce avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants de classe A:i>
- Johanna van Oort
- Monsieur Ross Jacob Crane
<i>Gérant de classe B:i>
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012023525/25.
(120030179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.
Marinella S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 90.113.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012022051/10.
(120028452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
37330
L
U X E M B O U R G
HC Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 166.682.
STATUTES
IN THE YEAR 2012, ON THE 27
th
DAY OF JANUARY.
Before, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mr Paul Berna, attorney at law, residing in Luxembourg, acting in the name and on behalf of:
Hutton Collins Mezzanine Partners L.P., a limited liability partnership governed by the laws of England and Wales,
having its registered office at 50 pall Mall, London SW1Y 5JH, England, and registered with the Companies House Register
under the number LP008072, represented by its general partner Hutton Collins Mezzanine GP Limited, a company go-
verned by the laws of England and Wales, having its registered office at 50 Pall Mall, London SW1Y 5JH, England, and
registered with the Companies House Register under number LP04267674,
by virtue of powers of attorney, given on 27
th
January 2012, and
Hutton Collins Capital Partners II L.P., a limited partnership governed by the laws of England and Wales, having its
registered office at 50 Pall Mall, London SW1Y 5JH, England, and registered with the Companies House Register under
number LP010985, represented by its general partner Hutton Collins GP II Limited, a company governed by the laws of
Scotland, having its registered office at 50 Lothian Road, Festival Square, EH3 9WJ Edinburgh, and registered with the
Companies House Register under number SC292122,
by virtue of powers of attorney, given on 27
th
January 2012.
Said proxies, after having been initialled ne varietur by the appearing party and by the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name and Duration. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
under the name of "HC Holdings II S.àr.l." (the Company).
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate object. The corporate objects of the Company are (i) the acquisition, holding and disposal, in any
form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg
and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by
sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments
of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and
receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership,
administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred
to in (i) and (ii) above).
The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreements and it may issue notes, bonds,
debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one
or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of
securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.
The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all of its assets.
The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and ins-
truments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The
corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not
inconsistent with the foregoing enumerated objects.
In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction
which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are
directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
37331
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary
general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to these articles of association (the
Articles).
The address of the registered office may be transferred within the municipality limits by simple resolution of the
manager(s).
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.
Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is set at GBP 12,000 (twelve thousand British pounds), re-
presented by 12,000 (twelve thousand) shares, having a nominal value of GBP 1 (one British Pound) each.
The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the extraordinary general meeting of the
shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders
will not bring the Company to an end.
Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-share-
holders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the
Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law), to acquire shares in its own
capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles.
Art. 8. Management. The Company is managed by one or more managers. In case of a plurality of managers, they will
constitute a board of managers. The managers need not to be shareholders. The majority of the members of the board
of managers shall always be resident in Luxembourg. The managers are appointed, and may be revoked and replaced at
any time ad nutum, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the
board of managers.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Written notices of any meeting
of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-
four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived
if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers. The meetings are held at the place, the day and the hour specified in
the convening notice, provided that all meetings shall be held in Luxembourg.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax
or telex another manager as his proxy, provided that a manager who is not resident in the UK for tax purposes may not
appoint a person who is resident in the UK for tax purposes as his proxy. A manager may represent more than one of
his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting. Managers may also cast their
vote by telephone confirmed in writing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority
of its members are present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions of the board of managers
are taken by a majority of the votes cast.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
In case of urgency only, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed
at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.
37332
L
U X E M B O U R G
The decisions of the board of managers will be recorded in minutes. No minutes of meetings of the Board of Managers
may be prepared in the UK.
Art. 10. Representation - Authorised signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company's objects.
All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the
scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality
of managers, by the joint signature of two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent's responsibilities and
his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as
such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.
Art. 12. General meetings of shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general meeting
of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number
of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Collective
decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the
provisions of the Law.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by
all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and
shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall
have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.
Art. 13. Financial year. The Company's accounting year begins on January first of each year and ends on December
thirty-first of the same year.
Art. 14. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the
board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 15. Appropriation of profits – Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The
manager or, in case of plurality of managers, the board of managers shall, subject to applicable law, have power to make
payable one or more interim dividends.
Art. 16. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders
deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
Art. 17. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remu-
neration.
Art. 18. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to
be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor (réviseur d'entreprises agréé
or cabinet de revision agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg
act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on accounting and financial accounts of companies
does not apply.
Art. 19. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no
specific provision is made in the Articles.
<i>Subscription and Paymenti>
All the shares of the Company have been subscribed as follows:
37333
L
U X E M B O U R G
Hutton Collins Mezzanine Partners L.P., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,060 shares
Hutton Collins Capital Partners II L.P., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,940 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000 shares
All the shares of the Company have been fully paid-up by means of a contribution in cash, so that the sum of GBP
12,000 (twelve thousand British Pounds), which is to be allocated to the nominal share capital account of the Company,
is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2012.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1.000.-.
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company
have herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers is set at 3 (three). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited
period of time:
(i) Peter Diehl, manager, born on the 21/03/1971 in Saarbrücken (Germany), professionally residing at 2-8, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
(ii) Damien Nussbaum, manager, born on the 08/10/1972 in Strasbourg (France), professionally residing at 2-8 avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg; and
(iii) Dominic James Barbour, Finance Director, born on the 15/08/1959 in Quimper (France), professionally residing
at 50 Pall Mall London SW1Y 5JH, United Kingdom.
2. the registered office is established at 2-8, Avenue Charles de Gaulle in 1653 Luxembourg, Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove
mentioned.
The document having been read to the appearing party, the appearing party signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE VINGT-SEPT JANVIER.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert, Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Paul Berna, avocat à la cour, résidant à Luxembourg, agissant au nom et pour le compte de:
Hutton Collins Mezzanine Partners L.P., une limited partnership, de droit anglais, ayant son siège social au 50 Pall Mall,
London SW1Y 5JH, Angleterre, et immatriculée au Companies House sous le numéro LP008072, représenté par son
general partner Hutton Collins Mezzanine GP Limited, une société de droit anglais, ayant son siège social au 50 Pall Mall,
London SW1Y 5JH, Angleterre, immatriculée au Companies House sous le numéro LP04267674,
en vertu d'une procuration donnée le 27 janvier 2012, et
Hutton Collins Capital Partners II L.P., une limited partnership de droit anglais et Wales, ayant son siège social au 50
Pall Mall, London SW1Y 5JH, Angleterre et immatriculée au Companies House sous le numéro LP010985, représenté
par son general partner Hutton Collins GP II Limited, une société de droit écossais, ayant son siège social au 50 Lothian
Road, Festival Square, EH3 9WJ Edinburgh, immatriculée au Companies House sous le numéro SC292122,
en vertu d'une procuration donnée le 27 janvier 2012.
Lesdites procurations, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter
les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit.
Art. 1
er
. Nom et Durée. Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "HC
Holdings II S.à r.l." (la Société).
La Société est constituée pour une durée illimitée.
37334
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Objet social. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que
ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange or de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou
instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds communs de pla-
cement luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité
de crédit, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le
développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les para-
graphes (i) et (ii) ci-dessus).
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle
peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants
et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toute autre société.
La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses
obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir,
céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.
La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),
opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des inves-
tissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.
Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération n'est pas limitative.
L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-
ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée générale
extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des présents statuts (les Statuts).
L'adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gérants.
La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 4. Capital. Le capital social souscrit est fixé à la somme de GBP 12.000 (douze mille livres sterling), représenté
par 12.000 (douze mille) parts sociales ayant une valeur nominale de GBP 1 (une livre sterling).
Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l'assemblée générale des associés
délibérant comme en matière de modifications des Statuts.
Art. 5. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes,
de l'actif ainsi que des bénéfices de la Société.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même
personne.
Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la
Société.
Art. 6. Cession des parts sociales. S'il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l'associé unique sont
librement cessibles aux tiers.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, que suite à
l'approbation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), racheter les parts sociales de son propre capital social.
37335
L
U X E M B O U R G
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en
vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant comme en matière de modifications des Statuts.
Art. 8. Gérance. La société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un
conseil de gérance. Les gérants n'ont pas besoin d'être des associés. La majorité des membres du conseil de gérance
doivent toujours résider au Luxembourg. Les gérants peuvent être nommés, révoqués ou remplacés à tout moment et
ad nutum par une décision adoptée par les associés détenant plus de la moitié du capital social.
Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du
conseil de gérance.
Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté dans les cas d'urgence, une
convocation écrite à toutes les réunions du conseil de gérance sera donnée à tous les gérants, par lettre, télégramme,
télécopie ou télex, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure de la dite réunion.
Les gérants peuvent renoncer à la convocation si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir
été dûment informés sur l'ordre du jour de la réunion. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions
tenues à une date et un endroit prévus lors d'une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du
conseil de gérance. Les réunions seront tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation, sauf que toutes les
réunions doivent se tenir à Luxembourg.
Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme mandataire un autre gérant par lettre, télécopie ou
tout autre moyen de télécommunication approprié, sauf qu'un gérant qui n'est pas un résident fiscal du Royaume-Uni ne
peut pas nommer comme mandataire un gérant qui est résident fiscal du Royaume-Uni. Un gérant peut représenter plus
d'un de ses collègues, à condition toutefois qu'au moins deux gérants participent à la réunion. Les gérants peuvent voter
par voie téléphonique, en confirmant ce vote par écrit. Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer
uniquement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les résolutions sont prises à la majorité des
voix exprimées.
Chaque gérant peut participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo conférence, ou par tout
autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent com-
muniquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.
En cas d'urgence seulement, les résolutions signées par tous les gérants sont valablement adoptées et engagent la
Société dans la même manière que les résolutions prises à une réunion de conseil de gérance dûment convoquée et tenue.
De telles signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur des copies multiples d'une résolution identique et
peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.
Les décisions du conseil de gérance seront documentées dans un procès-verbal. Aucun procès-verbal du conseil de
gérance ne sera préparé au Royaume-Uni.
Art. 10. Représentation - Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation
avec l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservées par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés sont de la
compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des
opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires hoc.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire
et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions perti-
nentes de ce mandat.
Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune
responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que
cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.
Art. 12. Assemblées générales des associés. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des
associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé a le droit d'assister aux assemblées générales des associés quel que soit
le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il
possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions portant modification des Statuts ou dissolution et liquidation de la Société ne pourront
être prises que par l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social,
sous réserve des dispositions de la Loi.
37336
L
U X E M B O U R G
Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par
écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises sur un
document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d'une as-
semblée générale des associés.
Art. 13. Année sociale. L'année sociale commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 14. Comptes sociaux. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil
de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.
Art. 15. Distribution des bénéfices – Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société
est affecté à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société.
Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu'ils détiennent dans la Société. Le gérant
unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a, sous réserve des dispositions légales applicables, le
pouvoir de faire payer un ou plusieurs dividendes intérimaires.
Art. 16. Dissolution. La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l'assemble générale des
actionnaires statuant comme en matière de changement des Statuts.
Art. 17. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 18. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société ne devra
faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises agréé ou un
cabinet de révision agréé doivent être nommés si l'exemption prévue par l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002
sur le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant
certaines autres dispositions légales n'est pas applicable.
Art. 19. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il en
est fait référence aux dispositions de la Loi.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sociales de la Société ont été souscrites comme suit:
Hutton Collins Mezzanine Partners L.P., susmentionné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,060 parts sociales
Hutton Collins Capital Partners II L.P., susmentionné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,940 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 parts sociales
Toutes les parts sociales de la Société ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme
de GBP 12,000 (douze mille livres sterling), qui sera affectée au compte de capital social nominal de la Société, se trouve
dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Dispositions Transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et prend fin le 31 décembre 2012.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.000.-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés représentant la totalité du capital souscrit de la Société
ont pris les résolutions suivantes:
1. le nombre de gérants est fixé à 3 (trois). Sont nommés par l'assemblée en tant que gérants de la Société pour une
période indéterminée:
(i) Peter Diehl, gérant, né le 21/03/1971 à Saarbrücken (A), résidant professionnellement au 2-8, Avenue Charles de
Gaulle à 1653 Luxembourg, Luxembourg;
(ii) Damien Nussbaum, gérant, né le 08/10/1972 à Strasbourg (F), résidant professionnellement au 2-8, Avenue Charles
de Gaulle à 1653 Luxembourg, Luxembourg; et
(iii) Dominic James Barbour, directeur financier, né le 15/08/1959 à Quimper (F), résidant professionnellement au 50
Pall Mall, London SW1Y 5JH, Royaume-Uni.
2. le siège social de la société est établi au 2-8, Avenue Charles de Gaulle à 1653 Luxembourg, Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
37337
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: P. BERNA, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert le 02 février 2012. Relation: RED/2012/201. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 03 février 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012018323/394.
(120022981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
NIFE Carlo Seccomandi, Société en Commandite simple.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 69.397.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 FEV. 2012.
<i>Pour: NIFE CARLO SECCOMANDI
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo
Référence de publication: 2012022085/15.
(120027989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Pancunia, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 166.760.
<i>Extrait de du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Société tenue le 7 février 2012i>
Le conseil d’administration de la Société a décidé de nommer Monsieur Paul Chambers, ayant son adresse profes-
sionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en tant que président du conseil d’administration et
administrateur-délégué de la Société, avec effet au 7 février 2012 et jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra
en 2017.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PANCUNIA
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012022112/15.
(120027725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
McKey Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 787.525,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 101.381.
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société en date du 13 février 2012i>
- La démission de Mme Charlotte Lahaije-Hultman en tant que gérant de catégorie B de la Société a été acceptée avec
effet au 13 février 2012.
- Monsieur Jean (John) Wantz, employé privé, né le 17 mai 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommé en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec
effet au 13 février 2012 et pour une durée indéterminée.
37338
L
U X E M B O U R G
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour McKey Luxembourg S.à r.l.
Mandatairei>
Référence de publication: 2012022047/17.
(120027799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Mold-Masters Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 130.205.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jorrit Crompvoets
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012022048/12.
(120028368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
White Fleet, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 111.381.
L'assemblée générale ordinaire du 8 février 2012 a décidé de renouveler les mandats de Madame Petra Reinhard Keller
et Messieurs Jean-Paul Gennari, Guy Reiter et Eduard von Kymmel en tant que membres du conseil d'administration de
White Fleet.
Par conséquent, le conseil d'administration se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2013:
- Petra Reinhard Keller, Membre du Conseil d'Administration
5, Kalanderplatz, CH-8045 Zurich
- Jean-Paul Gennari, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L -2180 Luxembourg
- Guy Reiter, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Eduard von Kymmel, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. a été réélu comme réviseur d'entreprises et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger
Référence de publication: 2012023647/25.
(120030042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.
Marmor und Granit International A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 64.960.
Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MARMOR UND GRANIT INTERNATIONAL A.G.
Alexis DE BERNARDI / Jean-Marc HEITZ
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012022052/12.
(120028253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
37339
L
U X E M B O U R G
Mayriwa S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 53.257.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012022053/10.
(120027848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Pacific Road Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 70.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 133.143.
<i>Extrait des résolutions écrites de l'Associé Unique de la Société en date du 13 décembre 2011i>
Il résulte des résolutions écrites de l'Associé Unique de la Société en date du 13 décembre 2011 les décisions suivantes
(traduction libre):
<i>Première Résolutioni>
«L'Associé Unique de la Société décide de révoquer Madame Alexandra Petitjean [...] du conseil de gérance de la
Société avec effet immédiat».
<i>Seconde Résolutioni>
«L'Associé Unique de la Société décide de nommer Madame Sharon Cailahan, née le 19 octobre 1966 à New York,
Etats-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que gérant
de la Société, avec effet immédiat et pour une durée illimitée.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2012.
Eric Lechat
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012022101/22.
(120027679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Meadows Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 132.616.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MEADOWS PROPERTIES S.A.
Référence de publication: 2012022058/10.
(120028143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
MGV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 106.205.
Les comptes annuels au 30 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012022063/10.
(120027719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
37340
L
U X E M B O U R G
Models et Design S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, 26, Wämperweeg.
R.C.S. Luxembourg B 130.336.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 16 février 2012i>
Transfert du siège social de la société de 43G Route de Weiswampach L-9980 Wilwerdange à 26 Wämperweeg L-9980
Wilwerdange
Fixation de l’adresse du siège social à 26 Wämperweeg L-9980 Wilwerdange
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012022064/12.
(120027980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Rigatte SA, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 130.851.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 novembre 2011i>
<i>Quatrième résolution:i>
L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Guy HORNICK et désigne à partir du 18 novembre
2011 Monsieur Gerdy ROOSE, né à Wevelgem (Belgique) le 14.02.1966, expert comptable, demeurant professionnelle-
ment au 2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son
mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.
L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Thierry FLEMING et désigne à partir du 18 novembre
2011 Monsieur Pierre LENTZ, né à Luxembourg le 22.04.1959, expert comptable, demeurant professionnellement au 2,
Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat pren-
dra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
L'assemblée prend note également du changement d'adresse professionnelle de la société AUDIEX S.A., anciennement
sise 57, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg et transférée 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RIGATTE SA, SPF
Société Anonyme - société de gestion de patrimoine familial
Référence de publication: 2012022144/22.
(120027800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Nageldesignstudio LA BELLE-MAIN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 10, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 152.977.
<i>Beschluss der Gesellschafterversammlung der Nageldesignstudio LA BELLE-MAIN S.à r.l.i>
Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und
beschliessen folgendes:
Der Gesellschaftssitz wird von 7, Grand Rue L-6630 Wasserbillig nach 10, route de Luxembourg L-6633 Wasserbillig
verlegt.
Référence de publication: 2012022067/12.
(120028244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Naja Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.510.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 160.092.
Les comptes annuels pour la période du 25 mars 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
37341
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2012.
Référence de publication: 2012022068/12.
(120027853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Honeywell Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 154.661.601,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 59.812.
EXTRAIT
Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associé unique en date du 6 janvier 2012:
1. Avec effet immédiat, la démission de Monsieur Marc FEIDER, de son mandat de gérant de catégorie B de la société,
a été acceptée.
2. Les personnes suivantes ont été nommées en tant que nouveaux gérants de catégorie B de la société, avec effet
immédiat et pour une période indéterminée:
- Monsieur Luc SUNNEN, né le 22 décembre 1961 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse pro-
fessionnelle au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Christophe FENDER, né le 10 juillet 1965 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse
professionnelle au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le siège social est transféré avec effet immédiat au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2012.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012023074/24.
(120029437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2012.
Naja Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.510.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 160.092.
Par résolutions signées en date du 10 janvier 2012, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat des gérants
suivants:
- NAJA PROPERTIES LTD, avec siège social au 3, New Street off Triq IL-Gizmin Swieqi, Block D, Malte
- Jean-Marc Ueberecken, avec adresse au 14, Rue Erasme, L-2082 Luxembourg
- René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume J. Kroll, L-1882 Luxembourg
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2012.
Référence de publication: 2012022069/17.
(120028432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Naxos Capital Managers S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 102.783.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
37342
L
U X E M B O U R G
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012022071/13.
(120027838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Linedata Services Luxembourg SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 52.843.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration tenue par voie circulaire le 6 février 2012i>
Fin de fonction de Monsieur Thierry SANTARELLI, au poste de Directeur Opérationnel de la société, avec effet au
31 décembre 2011.
Cooptation de la nomination de Monsieur Thierry SORET, né le 11 juillet 1960 à Paris (France), demeurant au 5, rue
Fréville Le Vingt, F-92310 Sèvres, France, au poste d'Administrateur de ta société. Son mandat arrivera à échéance lors
de l'Assemblée Générale Annuelle de 2012.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de !a prochaine Assemblée Générale Annuelle.
Conformément à l'article 11 des statuts, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité de:
- déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur
Thierry SORET, né le 11 juillet 1960 à Paris (France), demeurant au 5, rue Frévilie Le Vingt, F-92310 Sèvres, France.
Monsieur Thierry SORET portera le titre d'Administrateur-délégué de la société pour une durée indéterminée et
pourra engager la société par sa seule signature pour toutes les affaires relevant de la gestion journalière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
LINEDATA SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012023114/24.
(120029763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2012.
New Chemicals Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.784.
Le bilan au 31 Décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012022074/10.
(120027871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
New Specialty Chemicals Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 149.545.
Le bilan au 24 Novembre 2009 (date de constitution) - 31 Décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012022075/11.
(120027870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
37343
L
U X E M B O U R G
ARN Investment Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 153.741.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 10 janvier 2012i>
L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Jean-Luc Neyens. Eric Lobet, Christopher Wong, Oscar Wong, David Erskine et Riccardo
Millich, en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2013,
2. de réélire Ernst & Young SA, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2013.
Luxembourg, le 3 février 2012.
<i>Pour ARN INVESTMENT SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Corinne ALEXANDRE / Valérie GLANE
<i>- / Fondé de pouvoiri>
Référence de publication: 2012022272/20.
(120028182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
Nabony S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 151.106.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012022077/13.
(120027839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.
G.O. II - Luxembourg Alfamar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 118.517.
En date du 22 août 2011 l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- transfert du siège social de la société du 67 rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au 5 rue Guillaume Kroll L-1882
Luxembourg avec effet au 1
er
septembre 2011
- transfert de l'adresse professionnelle d'Emmanuel Mougeolle, gérant, du 67 rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au
5 rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg avec effet au 1
er
septembre 2011
- transfert de l'adresse professionnelle de Géraldine Schmit, gérant, du 67 rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au 5
rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg avec effet au 1
er
septembre 2011
Le siège social de l'associé G.O. II - LUXEMBOURG ALFAMAR HOLDING S.à r.l., est désormais au 5 rue Guillaume
Kroll L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2012.
Référence de publication: 2012023921/19.
(120030621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
37344
ARN Investment Sicav
Cocalos S.A.
Financom Venture S.A.
G.O. II - Luxembourg Alfamar S.à r.l.
Goya Airports S.à r.l.
HC Holdings II S.à r.l.
Honeywell Luxembourg Finance S.à r.l.
International Transatlantic Trading Services S.A.
Intex S.A.
Irman Lux S.A.
ISDC Finance S.A.
Islali Invest S.A.
Italian Food Participations S.A.
Japie S.A.
Kharma Management S.A.
Kinove Luxembourg Coinvestment SCA
Kronospan Luxembourg S.A.
Lakey Corp S.à r.l.
Lanz Lux LED S.A.
LA Services S.à r.l.
LA Services S.à r.l.
Lavipharm Group Holding
Leverage Union for Techniques & Expertise Management
Lhasa S.àr.l.
Ligustika Invest S.A.
Linedata Services Luxembourg SA
Lorentzen & Stemoco & Sobelnord
Luxfaq Holding S.A.
Luxnova S.A.
Luxtanne
Marinella S.A.
Marmor und Granit International A.G.
Mayriwa S.A.- SPF
M.B.&A. s.à r.l.
McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à r.l.
McKey Luxembourg Holdings S.à r.l.
McKey Luxembourg S.à r.l.
MD2L S.C.I.
Meadows Properties S.A.
MGV S.A.
Models et Design S.A.
Mold-Masters Luxembourg Holdings S.à r.l.
Nabony S.A.
Nageldesignstudio LA BELLE-MAIN S.à r.l.
Naja Properties S.à r.l.
Naja Properties S.à r.l.
Naxos Capital Managers S.àr.l.
Naxos Capital Managers S.àr.l.
New Chemicals Holdings S.à r.l.
New Specialty Chemicals Holdings S.à r.l.
Nexeo Solutions Luxembourg Holding Co. S.à r.l.
NIFE Carlo Seccomandi
NIFE Carlo Seccomandi
Pacific Road Holdings S.à r.l.
Pancunia
Paris Nursing 1 S.à r.l.
Rigatte SA, SPF
Sitronics Finance S.A.
White Fleet