logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 673

14 mars 2012

SOMMAIRE

AIMCo RE Subs (Luxembourg) II S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32271

Cambaceres France Holdings AREII (Lu-

xembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32271

Compass Invest International S.A.  . . . . . . .

32268

Cornwell S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32273

Cosmopar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32273

Cross Valorem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32270

CVM SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32282

Dandelon Development Company SA  . . .

32293

Deloitte Audit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32283

Doks S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32273

Doosan Heavy Industries European Hol-

dings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32293

Ecolab LUX 6 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32296

Eden Lux Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

32287

Elektro Bernd Elsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32304

Energy Ventures Investments SA  . . . . . . . .

32304

Enez Vaz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32303

Entre-Nous Création S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

32276

Ercy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32304

Esaress Holding Limited - Luxembourg

Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32303

EuroAccess  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32303

Exeter Business Centre Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32266

Fedelia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32291

Foggy Bay S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32268

Gasfin Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32270

Gazprombank Mortgage Funding 3 S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32258

GSO Capital Opportunities Fund II (Lu-

xembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32287

Island Group Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

32264

Item Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

32280

John Deere Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

32274

KeyDrive S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32294

LBREP III CBC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32294

L&V Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

32296

MP Kings Retail S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32291

Odin 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32266

Onex RSI Holdings Limited  . . . . . . . . . . . . .

32261

PACCOR Group Holdings S.à r.l.  . . . . . . . .

32264

PACCOR Pannunity Acquisition S.à r.l.  . .

32268

Pannunity Acquisition S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

32268

Persson & Co. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32279

Polykonzept S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32258

POLYKONZEPT société civile  . . . . . . . . . .

32258

Rhombus Bidco S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32297

Rinoraines S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32282

Stigma Funds (LUX)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32283

St-Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32281

Whitehall Street International Real Estate

SCA 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32304

Yoga For You A.s.b.l. Luxembourg  . . . . . .

32277

32257

L

U X E M B O U R G

Gazprombank Mortgage Funding 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 126.203.

Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 25 janvier 2012 que:
- le siège social de la Société est transféré à partir du 2 janvier 2012 au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- l'adresse professionnelle des administrateurs se trouve désormais au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Florence Rao
<i>Administrateur

Référence de publication: 2012017254/15.
(120021414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

Polykonzept S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. POLYKONZEPT société civile).

Siège social: L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière.

R.C.S. Luxembourg B 166.028.

Im Jahre zweitausendelf, den dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtswohnsitz in Niederanven.

Sind erschienen:

1° Die Familiengesellschaft bürgerlichen Rechts SCILO S.C.I. mit Sitz in L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière, einge-

tragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer E 2.255,

2° Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Fougères S.à r.l., mit Sitz in L-8398 Roodt, 1, Kareschbierg, eingetragen

im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 25.217;

beide hier vertreten durch Herrn Jean BOURG, Gesellchaftsverwalter, mit beruflicher Anschrift in L-8059 Bertrange,

3, Grevelsbarrière, Geschäftsführer der beiden Gesellschafter, alleinzeichnungsberechtigter.

Welche Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:
Die Erschienenen, handelnd und vertreten wie gesagt, erklären, dass sie die alleinigen Gesellschafter der Familienge-

sellschaft  bürgerlichen  Rechts  "POLYKONZEPT  S.C.I."  sind  mit  Sitz  in  L-8059  Bertrange,  3,  Grevelsbarrière,  RCS
Luxemburg E 2.944, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 5. Februar 1988,
veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C im Jahr 1988, Nummer 133.

In ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafter, erklären die Erschienene dem instrumentierenden Notar, sich zu einer

ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Tagesordnung:

<i>Tagesordnung

1.- Erhöhung vom Gesellschaftskapital um einhundertfünf Euro zweiunddreissig Cent (EUR 105,32), um dasselbe von

seinem  jetzigen  Stand  von  zwölftausenddreihundertvierundneunzig  Euro  achtundsechzig  Cent  (EUR  12.394,68.-)  auf
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) heraufzusetzen, ohne Ausgabe von neuen Anteile aber durch Erhöhung des
Nennwertes jedes Anteil um ihn auf zweihundertfünfzig Euro (EUR 250.-) zu bringen.

2.- Erweiterung des Gesellschaftszweckes und Abänderung von Artikel 1 der Satzung:

Art. 1. „Zweck der Gesellschaft sind die Dienstleistungen, Vermittlungen, Arbeiten und Beratungen im Zusammenhang

von Mobiliar-und Immobiliargütern, der Ankauf, die Aufwertung, die Organisation, die Direktion, die Überwachung und
die Kontrolle jeglicher Gütereinheiten sowie die Beteiligung an allen Betrieben und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann
alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder die Durchführung
desselben begünstigen oder erleichtern. Ausserdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb ihres Aufgabenbereiches, zu
allen Geschäften und Massnahmen zu schreiten, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig
und nützlich erscheinen.

Die  Gesellschaft  kann  sich  an  der  Gründung  und  Entwicklung  jeder  finanziellen,  industriellen  oder  kommerziellen

Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an
verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Ge-
sellschaften."

32258

L

U X E M B O U R G

3.- Umwandlung der Gesellschaftsform von einer Familiengesellschaft bürgerlichen Rechts in eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, Adoption einer neuen Satzung der umgewandelten Gesellschaft sowie Umänderung der Firmen-
bezeichnung von „POLYKONZEPT S.C.I." in „POLYKONZEPT S.à r.l.".

4. Ernennung von Frau Marie-Thérèse TERENS als alleinige Geschäftsführerin für eine unbestimmte Dauer.
5. Verschiedenes.
Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um einhundertfünf Euro zweiunddreissig Cent (EUR 105,32.-)

zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Stand von zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig
Cent (EUR 12.394,68.-) auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) heraufzusetzen, ohne Ausgabe von neuen An-
teile aber durch Erhöhung des Nennwertes jedes Anteil um ihn auf zweihundertfünfzig Euro (EUR 250.-) zu bringen.

Die Kapitalerhöhung ist integral gezeichnet und einbezahlt worden sowie dies dem instrumentierenden Notar nach-

gewiesen worden ist und der dies ausdrücklich bestätigt.

Nach dieser Erhöhung hat die Gesellschaft ein Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in

fünfzig (50) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von zweihundertfünfzig Euro (EUR 250.-) pro Anteil.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftszweck zu erweitern und dementsprechend Artikel 1 der Satzung ab-

zuändern wie folgt:

Art. 1. „Zweck der Gesellschaft sind die Dienstleistungen, Vermittlungen, Arbeiten und Beratungen im Zusammenhang

von Mobiliar-und Immobiliargütern, der Ankauf, die Aufwertung, die Organisation, die Direktion, die Überwachung und
die Kontrolle jeglicher Gütereinheiten sowie die Beteiligung an allen Betrieben und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann
alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder die Durchführung
desselben begünstigen oder erleichtern. Ausserdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb ihres Aufgabenbereiches, zu
allen Geschäften und Massnahmen zu schreiten, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig
und nützlich erscheinen.

Die  Gesellschaft  kann  sich  an  der  Gründung  und  Entwicklung  jeder  finanziellen,  industriellen  oder  kommerziellen

Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an
verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Ge-
sellschaften."

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst mit Wirkung auf dem heutigen Tage die Familiengesellschaft bürgerlichen Rechts „PO-

LYKONZEPT S.C.I." in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umzuwandeln. Ausserdem beschliesst die Versamm-
lung die Firmenbezeichnung der Gesellschaft umzuändern in „POLYKONZEPT S.à r.l.".

Aufgrund dieser Gesellschaftsformumwandlung von einer Familiengesellschaft bürgerlichen Rechts in eine Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, wurde keine neue Gesellschaft gegründet. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist die
Weiterführung der Familiengesellschaft bürgerlichen Rechts, wie diese bis heute bestanden hat, mit derselben juristischen
Person, und ohne dass eine Änderung innerhalb der Aktiva und Passiva der Gesellschaft stattgefunden hat.

Infolge der Gesellschaftsumwandlung beschliesst die Versammlung eine neue Satzung anzunehmen, welche wie folgt

dokumentiert wird:

Folgt der Text der Statuten der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in deutscher Sprache:

Art. 1. Die vorbenannten Erschienenen errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Be-

zeichnung " POLYKONZEPT S.à r.l.".

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Bertrange.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft sind die Dienstleistungen, Vermittlungen, Arbeiten und Beratungen im Zusammenhang

von Mobiliar-und Immobiliargütern, der Ankauf, die Aufwertung, die Organisation, die Direktion, die Überwachung und
die Kontrolle jeglicher Gütereinheiten sowie die Beteiligung an allen Betrieben und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann
alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder die Durchführung
desselben begünstigen oder erleichtern. Ausserdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb ihres Aufgabenbereiches, zu
allen Geschäften und Massnahmen zu schreiten, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig
und nützlich erscheinen.

Die  Gesellschaft  kann  sich  an  der  Gründung  und  Entwicklung  jeder  finanziellen,  industriellen  oder  kommerziellen

Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an

32259

L

U X E M B O U R G

verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Ge-
sellschaften."

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März eines jeden Jahres.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünfzig (50) Ge-

schäftsanteile mit einem Nennwert von zweihundertfünfzig Euro (EUR 250.-) pro Anteil.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen

und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Le-

benden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindes-

tens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden

von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Ums-

tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung

ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die,
in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum

Buchwert an den Nachfolger auszuzahlen.

Art. 12. Am 31. März eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den

Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn-und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern

ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaft erfüllt sind."

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Frau Marie-Thérèse TERENS, mit beruflicher Anschrift in L-8059 Bertrange, 3, Grevels-

barrière, als alleinigen Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer zu ernennen.

Die Gesellschaft wird durch die einzelne Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Umänderung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.

32260

L

U X E M B O U R G

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Jean Bourg, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 28 décembre 2011. LAC / 2011 / 58646. Reçu 75.-

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 9. Januar 2012.

Référence de publication: 2012006640/154.
(120006105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2012.

Onex RSI Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 9.809.153,12.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 141.515.

In the year two thousand and eleven, on the nineteenth day of December,
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Onex RSI Holdings Limited S.à r.l., a société à res-

ponsabilité limitée (private limited liability company) incorporated and organized under the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg, with a share capital of USD 11,035,297.26, having its registered office at 6C rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés
(Trade and Companies Register) under number B 141.515.

There appeared:

- Onex American Holdings Subco LLC, a company duly incorporated and validly existing under the laws of the state

of Delaware, the United States of America, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered with the Delaware Secretary of State,
Division of Corporations, under file number 3829004; and

- RSI Executive Investco LLC, a company duly incorporated and validly existing under the law of the state of Delaware,

the United States of America, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered with the Delaware Secretary of State, Division
of Corporations, under file number 4594008;

Here both represented by Mr. Régis Galiotto, residing professionally in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

by virtue of powers of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-

tration.

The 110,352,972,600 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting

can validly decide on all the items of the agenda of which Onex American Holdings Subco LLC and RSI Executive Investco
LLC have been duly informed.

<i>Agenda

1. Decrease of the share capital of the Company by an amount of USD 1,226,144.14 so as to reduce it from its current

amount of USD 11,035,297.26 to USD 9,809,153.12;

2. Approval of the Available Amount determined by the managers of the Company;
3. Redemption and cancellation of the 12,261,441,400 shares with a nominal value of USD 0.0001 each constituting

the Company's Class B Shares in accordance with article 10 of the articles of association of the Company;

4. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the decrease

of the share capital of the Company;

5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been unanimously taken:

<i>First resolution

It is resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of USD 1,226,144.14 (one million two

hundred twenty six thousand one hundred forty four US Dollars and fourteen cents) so as to reduce it from its current
amount of USD 11,035,297.26 (eleven million thirty-five thousand two hundred and ninety-seven US Dollars and twenty-
six cents) to USD 9,809,153.12 (nine million eight hundred and nine thousand one hundred and fifty-three US Dollars

32261

L

U X E M B O U R G

and twelve cents) by the redemption of a whole class of shares of the Company in accordance with article 10 of its articles
of association.

<i>Second resolution

It is resolved to approve the Available Amount (as defined under article 10 of the articles of association of the Company)

as determined by the board of managers of an amount of USD 21.649.059.- (twenty-one millions six hundred forty-nine
thousand fifty-nine US Dollars).

<i>Third resolution

All the conditions of article 10 of the articles of association of the Company being met, it is resolved to redeem all the

12,261,441,400 Class B Shares with a nominal value of USD 0.0001 (one hundredth of a cent of US Dollar) each and to
reimburse Onex American Holdings Subco LLC and RSI Executive Investco LLC proportionally to their respective sha-
reholdings in the Class B Shares, followed by the cancellation of all the 12,261,441,400 shares Class B Shares.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is resolved to amend article 6 of the articles of association of the

Company to read as follows:

“ Art. 6.Capital. The Company's share capital is set at USD 9,809,153.12 (nine million eight hundred and nine thousand

one hundred and fifty-three US Dollars and twelve cents).

It is divided into eight classes of shares consisting of:
- 12,261,441,400 (twelve billion two hundred sixty one million four hundred forty one thousand and four hundred)

class C shares (the "Class C Shares");

- 12,261,441,400 (twelve billion two hundred sixty one million four hundred forty one thousand and four hundred)

class D shares (the "Class D Shares");

- 12,261,441,400 (twelve billion two hundred sixty one million four hundred forty one thousand and four hundred)

class E shares (the "Class E Shares");

- 12,261,441,400 (twelve billion two hundred sixty one million four hundred forty one thousand and four hundred)

class F shares (the "Class F Shares");

- 12,261,441,400 (twelve billion two hundred sixty one million four hundred forty one thousand and four hundred)

class G shares (the "Class G Shares");

- 12,261,441,400 (twelve billion two hundred sixty one million four hundred forty one thousand and four hundred)

class H shares (the "Class H Shares");

-12,261,441,400 (twelve billion two hundred sixty one million four hundred forty one thousand and four hundred)

class I shares (the "Class I Shares");

- 12,261,441,400 (twelve billion two hundred sixty one million four hundred forty one thousand and four hundred)

class J shares (the "Class J Shares");

All these 98,091,531,200 shares have a nominal value of USD 0.0001 (one hundredth of a cent of US Dollar) each, and

are fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital."

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital decrease, have been estimated at about two thousand Euros (2,000.-euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le dix-neuvième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la Onex RSI Holdings Limited S.à r.l. une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,

32262

L

U X E M B O U R G

Grand-Duché  de  Luxembourg,  ayant  un  capital  social  de  11,035,297.26  USD  et  immatriculée  auprès  du  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.515.

Ont comparu:

- Onex American Holdings Subco LLC, une société de droit de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), ayant son

siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis
d'Amérique et immatriculée auprès du “Delaware Secretary of State, Division of Corporations” sous le numéro de dossier
3829004; et

- RSI Executive Investco LLC, une société de droit de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), ayant son siège

social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware
19808, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée auprès du “Delaware Secretary of State, Division of Corporations” sous
le numéro 4594008,

Toutes deux ici représentées par Mr Régis Galiotto, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce

dernier.

Les 110.352.972.600 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la

présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour, dont Onex American Holdings Subco LLC et RSI Executive Investco LLC ont été préalablement infor-
mées.

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de 1.226.144,14 USD afin de le réduire de 11.035.297,26

USD à 9.809.153,12 USD;

2. Approbation du Montant Disponible déterminé par les gérants de la Société;
3. Rachat et annulation de 12.261.441.400 parts sociales ayant une valeur nominale de 0,0001 USD chacune composant

les Parts Sociales de Classe B de la Société conformément à l'article 10 des statuts de la Société;

4. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter la réduction du capital social de

la Société;

5. Divers.
Après que l'agenda ait été approuvé par les associés, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de 1.226.144,14 USD (un million deux cent vingt-

six  mille  cent  quarante-quatre  dollars  américains  et  quatorze  cents)  afin  de  le  réduire  de  son  montant  actuel  de
11.035.297,26 USD (onze millions trente-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains et vingt-six cents)
à 9.809.153,12 (neuf millions huit cent neuf mille cent cinquante-trois dollars américains et douze cents) par le rachat de
la totalité d'une classe de parts de la Société conformément à l'article 10 de ses statuts.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'approuver le Montant Disponible (comme défini à l'article 10 des statuts de la Société) tel que déterminé

par les gérants à un montant de 21.649.059.- USD (vingt-et-un millions six cent quarante-neuf mille cinquante-neuf dollars
américains).

<i>Troisième résolution

L'ensemble des conditions de l'article 10 des statuts de la Société étant rempli, il est décidé de racheter l'ensemble

des 12.261.441.400 Parts Sociales de Classe B d'une valeur nominale de 0,0001 USD (un centième de centime de dollar
américain) chacune et de rembourser Onex American Holdings Subco LLC et RSI Executive Investco LLC proportion-
nellement à leur détention respective en Parts Sociales de Classe B, suivi de l'annulation de toutes les 12.261.441.400
Parts Sociales de Classe B.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin qu'il

soit lu comme suit:

“ Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à 9.809.153,12 (neuf millions huit cent neuf mille cent cinquante-trois dollars

américains et douze cents).

Il est composé de huit classes de parts sociales consistant en:
- 12.261.441.400 (douze milliard deux cent soixante et un million quatre cent quarante et un mille quatre cent) parts

sociales de classes C (les "Parts Sociales de Classe C");

32263

L

U X E M B O U R G

- 12.261.441.400 (douze milliard deux cent soixante et un million quatre cent quarante et un mille quatre cent) parts

sociales de classes D (les "Parts Sociales de Classe D");

- 12.261.441.400 (douze milliard deux cent soixante et un million quatre cent quarante et un mille quatre cent) parts

sociales de classes E (les "Parts Sociales de Classe E");

-12.261.441.400 (douze milliard deux cent soixante et un million quatre cent quarante et un mille quatre cent) parts

sociales de classes F (les "Parts Sociales de Classe F");

- 12.261.441.400 (douze milliard deux cent soixante et un million quatre cent quarante et un mille quatre cent) parts

sociales de classes G (les "Parts Sociales de Classe G");

- 12.261.441.400 (douze milliard deux cent soixante et un million quatre cent quarante et un mille quatre cent) parts

sociales de classes H (les "Parts Sociales de Classe H");

-12.261.441.400 (douze milliard deux cent soixante et un million quatre cent quarante et un mille quatre cent) parts

sociales de classes I (les "Parts Sociales de Classe I");

- 12.261.441.400 (douze milliard deux cent soixante et un million quatre cent quarante et un mille quatre cent) parts

sociales de classes J (les "Parts Sociales de Classe J");

Chacune des 98.091.531.200 parts sociales a une valeur nominale de 0,0001 USD (un centième de centime de dollar

américain) et est entièrement libérée.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité

d'associés, par une résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour
cent (75%) du capital social de la Société”.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison de la réduction de son capital, s'élève à environ deux mille Euros (2.000.-EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, le présent acte.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58983. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 janvier 2012.

Référence de publication: 2012014181/186.
(120016495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

PACCOR Group Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Island Group Holdings S.à r.l.).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 160.907.

In the year two thousand and twelve on the twentieth day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARS:

PACCOR International Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), established

and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161.812.

here represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, having his professional address at 101, rue Cents, L-1319 Lux-

embourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 19, 2012.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)

incorporated and existing in Luxembourg under the name of “Island Group Holdings S.à r.l.” (hereinafter, the Company),

32264

L

U X E M B O U R G

with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 160.907, established pursuant to a deed of the undersigned notary of May 5, 2011,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of July 29, 2011, number 1729, and which bylaws have
been lastly amended pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, dated October 31,
2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of December 13, 2011, number 3049.

II. The Company’s share capital is fixed at twenty-five million forty-four thousand one hundred seventy-eight Euro

(EUR 25.044.178,00) divided twenty-five million forty-four thousand one hundred seventy-eight (25.044.178) shares, with
a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

III. The sole shareholder resolves to change the name of the Company to “PACCOR Group Holdings S.à r.l.”
IV. Pursuant to the above change of name, article 4 of the Company’s articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

“ Art. 4. The Company shall bear the name “PACCOR Group Holdings S.à r.l.”.”
V. The sole shareholder resolves to transfer the registered seat of the Company from 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, to 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

VI. Pursuant to the above transfer of registered seat, article 5, first paragraph, of the Company’s articles of association

is amended and shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg”.”

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholder meeting are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1.200,00).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his name,

civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède :

L’an deux mille douze, le vingt janvier.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

PACCOR International Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au, 1B, Heienhaff, L1736 Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.812,

ici représenté par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 19 janvier 2012.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Le comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

«Island Group Holdings S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.907, constituée par
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1729 du 29 juillet 2011, et dont les statuts ont été modifiés dernièrement suivant acte de Maître Francis Kesseler,
notaire résidant à Esch/Alzette, en date du 31 octobre 2011, publié auprès du Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 3049 du 13 décembre 2011.

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq million quarante-quatre mille cent soixante-dix-huit Euro (EUR

25.044.178,00) divisé en vingt-cinq million quarante-quatre mille cent soixante-dix-huit (25.044.178) parts sociales d’une
valeur nominale d’un Euro (EUR 1,00) chacune.

III. L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société en «PACCOR Group Holdings S.à r.l.».
IV. Suite au changement de dénomination sociale, l’article 4 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

« Art. 4. La Société a comme dénomination «PACCOR Group Holdings S.à r.l.».»

32265

L

U X E M B O U R G

V. L’associé unique décide de changer l’adresse du siège social de la Société qui était auparavant situé au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, pour le transférer au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

VI. Suite au transfert de siège social, l’article 5, premier paragraphe, des statuts de la Société est modifié pour avoir

désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Senningerberg».»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents Euro (EUR 1.200,00).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. À la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3735. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 février 2012.

Référence de publication: 2012016643/94.
(120020635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

Exeter Business Centre Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 163.474.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d´administration tenu en date du 16 janvier 2012:

1. la nomination du gérant:
- Dominique YATES, avec adresse à 659 Prinsengracht, building C, NL-1016 HV Amsterdam, Pays-Bas, a été acceptée

avec effet au 20 decembre 2011;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012017216/14.
(120021138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

Odin 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 151.520.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of the month of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TBU-9 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 29, avenue

de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under
number B 118.122 (the “Sole Shareholder”) represented by Me Patrick Santer, maître en droit, residing in Luxembourg,
pursuant to a proxy dated 21 December 2011, being the Sole Shareholder of, and holding all the shares in issue in “Odin
1 S.A.” (the “Company”), a société anonyme having its registered office at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Lu-
xembourg, incorporated by deed of Me Carlo Wersandt on 19 February 2010, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations under number 691 of 1 April 2010 and registered with the Register of Trade and Companies of
Luxembourg under number B 151.520.

32266

L

U X E M B O U R G

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
(A) The Sole Shareholder is the holder of all of the thirty-one thousand (31,000) shares issued by the Company, each

with a nominal value of one Euro (€1.00).

(B) The Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.
(C) The Sole Shareholder approves the accounts of the Company for the financial year ended on 31 December 2010.
(D) The Sole Shareholder decides hereby to dissolve and liquidate the Company, to assume the function of the liqui-

dator, to acknowledge the state of the Company's assets and liabilities, to have all assets of the Company transferred to
itself and to assume the obligations of the Company which shall be paid out of such assets, and decides that thereby the
liquidation of the Company is closed.

(E) The Sole Shareholder decides to fully discharge the board of directors and statutory auditor of the Company for

the due performance of their duties up to this date and that the books and documents of the Company shall be lodged
during a period of at least five years at CIE Luxembourg S.à r.l., with registered office at 29, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 Luxembourg.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed

by a French translation; at the request of the appearing party, the English text shall prevail in case of any discrepancy
between the English and the French texts.

This document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his/her respective name,

first name, civil status and residence, the said person signed together this original deed with us, the notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TBU-9 S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 29, avenue de la Porte-Neuve,

L-2227  Luxembourg,  et  inscrite  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  of  Luxembourg  sous  numéro  B  118.122
(l'«Actionnaire Unique») représentée par Me Patrick Santer, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d'une
procuration délivrée le 21 décembre 2011, étant le seul actionnaire de et détenant la totalité des actions en émission de
«Odin 1 S.A.» (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Lu-
xembourg, constituée par acte de Maître Carlo Wersandt, le 19 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations («Mémorial»), numéro 691 du 1 

er

 avril 2010 et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro B 151.520.

La partie comparante a déclaré et a demandé au notaire d'instrumenter ce qui suit:
(A) L'Actionnaire Unique est le seul détenteur de toutes les trente et un mille (31.000) actions émises de la Société.
(B) L'Actionnaire Unique a parfaite connaissance des statuts et des états financiers de la Société.
(C) L'Actionnaire Unique approuve les comptes de la Société pour l'année sociale s'étant terminée au 31 décembre

2010.

(D) L'Actionnaire Unique décide par la présente de dissoudre et liquider la Société, d'assumer la fonction de liquidateur

et de prendre connaissance de l'état de tous les actifs et passifs de la Société, d'avoir tous les actifs de la Société transférés
à l'Actionnaire Unique et d'assumer les obligations de la Société résultant de ces actifs, et décide ainsi que la liquidation
de la Société est close.

(E) L'Actionnaire Unique décide de donner pleine et entière décharge au conseil d'administration et au commissaire

aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date des présentes et que les livres et documents
de la Société seront conservés pendant cinq ans à CIE Luxembourg S.à r.l. ayant son siège social au 29, avenue de la Porte-
Neuve, L-2227 Luxembourg.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée ci-dessus.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que (sur demande de la partie comparante), le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire instrumentant d'après ses

nom, prénom usuel, état et demeure, a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: P. SANTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/118. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signée): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

32267

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 2 février 2012.

Référence de publication: 2012016773/74.
(120020755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

Compass Invest International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 136.257.

Le siège social de la société a été transféré avec effet Immédiat, à l'adresse suivante:
65, Rue des Romains
L-8041 Strassen

Strassen, le 2 janvier 2012.

COMPASS INVEST INTERNATIONAL SA
Signature

Référence de publication: 2012017191/13.
(120021045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

Foggy Bay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 56.683.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 27 décembre 2011, que le siège social de la société a été

transféré du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, l'adresse professionnelle des personnes suivantes est désormais:
- Matthijs BOGERS, Administrateur: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Stéphane HEPINEUZE, Administrateur: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Mombaya KIMBULU, Administrateur: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
Le siège social de la société European Trust Services (Luxembourg) S.à r.l., Commissaire aux comptes, est également

désormais situé au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2012.

<i>Pour Foggy Bay S.A.
Mombaya KIMBULU
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012017647/21.
(120021161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

PACCOR Pannunity Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Pannunity Acquisition S.à r.l.).

Capital social: EUR 26.880,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 163.636.

In the year two thousand and twelve on the twentieth day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARS:

PACCOR International Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), established

and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161812.

here represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, having his professional address at 101, rue Cents, L-1319 Lu-

xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 19, 2012.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

32268

L

U X E M B O U R G

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)

incorporated and existing in Luxembourg under the name of “Pannunity Acquisition S.à r.l.” (hereinafter, the Company),
with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 163636, established pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in
Esch/Alzette, of September 26, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of November 15,
2011, number 2788, and which bylaws have been lastly amended pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, prenamed,
dated December 19, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is fixed at twenty-six thousand eight hundred eighty Euro (EUR 26,880.00) divided into

twenty-six thousand eight hundred eighty (26.880) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.

III. The sole shareholder resolves to change the name of the Company to “PACCOR Pannunity Acquisition S.à r.l.”
IV. Pursuant to the above change of name, article 4 of the Company's articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

“ Art. 4. The Company shall bear the name “PACCOR Pannunity Acquisition S.à r.l.”.”
V. The sole shareholder resolves to transfer the registered seat of the Company from 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, to 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

VI. Pursuant to the above transfer of registered seat, article 5, first paragraph, of the Company's articles of association

is amended and shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg”.”

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholder meeting are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.00).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his name,

civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt janvier.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

PACCOR International Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161812,

ici représenté par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle 101, rue Cents, L-1319 Lu-

xembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 19 janvier 2012.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

«Pannunity Acquisition S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163636, constituée par
acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire résidant à Esch/Alzette en date du 26 septembre 2011, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2788 du 15 novembre 2011, et dont les statuts ont été modifiés derniè-
rement suivant acte de Maître Francis Kesseler, précité en date du 19 décembre 2011, non encore publié auprès du
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt-six mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR 26.880,00) divisé en vingt-

six mille huit cent quatre-vingt (26.880) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

III. L'associé unique décide de changer l'adresse du siège social de la Société en «PACCOR Pannunity Acquisition S.à

r.l.».».

IV. Suite au changement de dénomination sociale l'article 4 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

« Art. 4. La Société a comme dénomination «PACCOR Pannunity Acquisition S.à r.l.».»

32269

L

U X E M B O U R G

V. L'associé unique décide de changer l'adresse du siège social de la Société qui était auparavant situé au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, pour le transférer au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

VI. Suite au transfert de siège social, l'article 5, premier paragraphe, des statuts de la Société est modifié pour avoir

désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Senningerberg».»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents Euro (EUR 1.200,00).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3730. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 février 2012.

Référence de publication: 2012016802/94.
(120020588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

Gasfin Investment S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 145.500,00.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 137.366.

Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat, à l'adresse suivante:
65, Rue des Romains
L-8041 Strassen

Strassen, le 2 janvier 2012.

GASFIN INVESTMENT SA
Signature

Référence de publication: 2012017271/14.
(120020883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

Cross Valorem, Société Anonyme.

Enseigne commerciale: X Valor.

Siège social: L-8544 Nagem, 5A, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 152.519.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 3 février 2012.

Référence de publication: 2012017195/11.
(120021496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

32270

L

U X E M B O U R G

Cambaceres France Holdings AREII (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AIMCo RE Subs (Luxembourg) II S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 155.173.

In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of January.
before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of AIMCo RE Subs (Luxembourg)

II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws
of Luxembourg, having its registered office at 76, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, having a share capital of
twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) and registered with the Luxembourg Commerce and Companies Re-
gister under number B 155.173 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine
Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on August 19, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 2137 on October 11, 2010. The articles of association of the Company (the Articles) have
been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on October
13, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2509 on November 19, 2010.

THERE APPEARED:

AIMCo RE Holdings (Luxembourg) II S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée), incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 76, avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.140 (the Sole Shareholder),

here represented by Aurore Perleau, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the name of the Company from "AIMCo RE Subs (Luxembourg) II S.à r.l." into "Cambaceres France

Holdings AREII (Luxembourg) S.à r.l.";

2. Subsequent amendment to article 1 of the Company's articles of association in order to reflect the change adopted

under item 1. above; and

3. Miscellaneous.
III. the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "AIMCo RE Subs (Luxembourg) II S.à r.l."

into "Cambaceres France Holdings AREII (Luxembourg) S.à r.l.".

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Articles, which

shall henceforth read as follows:

Art. 1. Name. The name of the company is "Cambaceres France Holdings AREII (Luxembourg) S.à r.l." (the Company).

The Company is a private limited liability company (société a responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law),
and these articles of association (the Articles)."

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation

to this deed are estimated at approximately EUR 1,500.-(one thousand five hundred euro).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

32271

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the representative of the appearing party, said representative signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le treizième jour de janvier.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de AIMCo RE Subs (Luxembourg)

II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont
le siège social est situé au 76, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.173
(la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le
19 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 11 octobre 2010 sous le numéro 2137. Les
statuts de la société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire
de résidence à Luxembourg, le 13 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 19 no-
vembre 2010 sous le numéro 2509.

A COMPARU:

AIMCo RE Holdings (Luxembourg) II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée par les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 76, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, ayant
un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 155.140 (l'Associé Unique),

ici représentée par Aurore Perleau, avocate, dont l'adresse professionnelle se situe à Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter que:
I. l'Associé Unique détient la totalité des parts dans le capital social de la Société;
II. l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination de la Société de «AIMCo RE Subs (Luxembourg) II S.à r.l.» en «Cambaceres France

Holdings AREII (Luxembourg) S.à r.l.»;

2. Modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société afin de refléter le changement adopté au point 1.

Ci-dessus; et

3. Divers.
III. l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société de «AIMCo RE Subs (Luxembourg) II S.à r.l.» en

«Cambaceres France Holdings AREII (Luxembourg) S.à r.l.».

<i>Deuxième résolution

En  conséquence  de  la  résolution  qui  précède,  l'Associé  Unique  décide  de  modifier  l'article  1  des  Statuts,  qui  est

désormais rédigé comme suit:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est «Cambaceres France Holdings AREII (Luxembourg) S.à r.l.» (la

Société). La Société est une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les
présents statuts (les Statuts).»

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du

présent acte sont estimés à environ EUR 1.500.- (mille cinq cents euros).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et
le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire

instrumentant, le présent acte

Signé: A. PERLEAU et H. HELLINCKX.

32272

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 janvier 2012. Relation: LAC/2012/2448. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 31 janvier 2012.

Référence de publication: 2012015214/113.
(120018629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.

Cornwell S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 83.024.

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du procès-verbal de la société anonyme Cornwell SA

Lors de l’assemblée générale du 2 février 2012 l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

CORNWELL SA, ayant son siège social à L-1636, Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au registre de commerce
de Luxembourg, section B, sous le numéro B83 024 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>1 

<i>ère

<i> résolution:

L’assemblée Générale accepte à l’unanimité la démission de Maître Philippe STROESSER, né le 30 octobre 1969 à Barr

(France) et demeurant professionnellement au 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg de son poste d’administrateur.

<i>2 

<i>ème

<i> résolution:

L’assemblée décide à l’unanimité de nommer en son remplacement Monsieur Joe THIELEN, né le 20 novembre 1958

à Luxembourg et demeurant au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, administrateur de la société jusqu’à l’assemblée
générale qui se tiendra en 2013.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2012017193/19.
(120020872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

Cosmopar S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 41.747.

Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat, à l'adresse suivante:
65, Rue des Romains
L-8041 Strassen

Strassen, le 2 janvier 2012.

COSMOPAR SA
Signature

Référence de publication: 2012017194/13.
(120020878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

Doks S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 114.293.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 janvier 2012

que:

Madame Orietta RIMI actuellement administrateur a été nommée président du conseil d’administration.
Le mandat de la société SER.COM S.à.r.l. (RCSL B117942), actuellement commissaire en charge du contrôle de nos

comptes domiciliée au 19, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg a été renouvelé.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’assemblée générale

qui se tiendra en 2016.

32273

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2012.

Référence de publication: 2012017207/17.
(120021299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

John Deere Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.515.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth of the month of November.
Before the undersigned Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

John Deere Luxembourg Investment S.à. r.l., a private limited liability company governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, under process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,

Here duly represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party representing the whole corporate capital requests the notary to act that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)

established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name John Deere Holding S.à r.l (hereinafter, the
Company), with registered office at 43, avenue J F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164.515, established pursuant to a deed of
the undersigned notary dated October 13, 2011, under process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, whose bylaws have been amended by two deeds of the undersigned notary dated October 31, 2011.

II. The Company's share capital is set at fifty five thousand and five Euro (EUR 55,005) represented by fifty five thousand

and five (55,005) shares in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of one Euro (EUR 1) to raise

it from its present amount of fifty five thousand and five Euro (EUR 55,005) to fifty five thousand and six Euro (EUR
55,006) by the creation and issuance of one (1) share with a nominal value of one Euro (EUR 1) (the “New Share”) and
vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

John Deere Luxembourg Investment S.à.r.l., prenamed, declares to subscribe the New Share and to fully pay it up in

a nominal amount of one Euro (EUR 1) together with a share premium in the amount of thirty three millions six hundred
forty eight thousand seven hundred fifty nine Euro (EUR 33.648.759) by contribution in kind for a total amount of thirty
three millions six hundred forty eight thousand seven hundred sixty Euro (EUR 33,648,760) consisting in the contribution
by John Deere Luxembourg Investment S.à. r.l, prenamed, to the Company, of its interests representing 99.99% of the
interests of John Deere International Investment (Nederland) C.V., a Dutch partnership, with registered office at Nari-
taweg 165, 1043 BW, Amsterdam, registered under number 24308881 and valuated at forty six millions four hundred
sixty three thousand three hundred fifty three United States Dollars (USD 46,463,353) being equivalent to thirty three
millions six hundred forty eight thousand seven hundred sixty Euro (EUR 33,648,760) at the exchange rate of 1 USD/
0.7242 EUR at the date of October 21, 2011 (the “Contributed Interests”).

<i>Evidence of the contribution's existence and value

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:
- a contribution declaration of John Deere International Investment (Nederland) C.V., prenamed, attesting that the

Contributed Interests are freely transferable, subject to the unanimous prior written consent of all the partners (direct
and indirect) of John Deere International Investment (Nederland) C.V. as stipulated in the articles of the partnership
agreement of John Deere International Investment (Nederland) C.V., especially article 10, paragraphs 2 and 11 (which
articles were amended by virtue of a notarial deed executed in Venlo, The Netherlands on November 28, 2011). The
consent required as mentioned before, is illustrated in a private instrument signed on November 28, 2011;

- a declaration from the managers of the Company.

<i>Effective implementation of the contribution

John Deere Luxembourg Investment S.à.r.l., prenamed, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Contributed Interests and possesses the power to dispose of them, they

being legally and conventionally freely transferable further to the consent mentioned above;

32274

L

U X E M B O U R G

- the contribution of the Contributed Interests is effective as from November 29, 2011, without qualification;
- all further formalities are in course in the jurisdictions of the location of the Contributed Interests, in order to duly

carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

V. Pursuant to the above increase of capital, article 5, first paragraph, of the Company's articles of association is

amended and shall henceforth read as follows:

Art. 5. “The subscribed share capital is set at fifty five thousand and six Euro (EUR 55,006) represented by fifty five

thousand and six (55,006) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.”

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately seven thousand Euro (EUR 7,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date first written above.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Am neunundzwanzigsten November zweitausend und elf,
ist vor dem unterzeichneten Notar, Maître Francis Kesseler, ansässig in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,

folgende Person erschienen:

John Deere Luxembourg Investment S.à.r.l., mit eingetragenem Sitz in 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg, gegründet wurde und besteht, deren Eintragung im Handels- und Gesellschaftsregister Lu-
xemburg, beantragt wurde und,

ordentlich vertreten durch Frau Sofia Afonso-Da Chao Conde, Privatangestellte, geschäftsansässig in 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Die erteilte Vollmacht, welche „ne varietur“ von der erschienenen Partei und dem unterzeichneten Notar paraphiert

wurde, bleibt als Anhang an die vorliegende Urkunde angefügt, um gleichzeitig bei den Registrierungsbehörden eingereicht
zu werden.

Die erschienene Partei, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ersucht den Notar, Folgendes zu beurkunden:
I. Die erschienene Person ist alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsa-

bilité limitée), die im Großherzogtum Luxemburg unter der Bezeichnung John Deere Holding S.à r.l. (nachfolgend die
Gesellschaft) mit eingetragenem Sitz in 43, avenue J F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, ge-
gründet wurde und besteht, deren Eintragung im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B
164.515 die gemäß einer Urkunde des unterzeichneten Notars vom 13. Oktober 2011 gegründet wurde. Die Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, wird derzeit
vorbereitet und ihre Satzung wurde durch eine Urkunde des unterzeichneten Notars vom 31. Oktober 2011 geändert.

II. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfundfünfzigtausendundfünf Euro (EUR 55.005,-), aufgeteilt in fünfund-

fünfzigtausendundfünf (55.005) eingetragene Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (1,- EUR).

III. Der alleinige Gesellschafter beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft von derzeit fünfundfünfzigtausendundfünf

Euro (EUR 55.005,-) um einen Euro (EUR 1) auf fünfundfünfzigtausendundsechs Euro (EUR 55.006,-) zu erhöhen. Dies
soll durch Schaffung und Ausgabe von einem (1) Anteil mit einem Nennwert von einem Euro (1 EUR) (der „Neue Anteil“)
geschehen, der mit denselben Rechten und Pflichten wie die vorhandenen Anteile ausgestattet ist.

<i>Zeichnung - Bezahlung

Die oben bezeichnete John Deere Luxembourg Investment S.à.r.l. erklärt den Neuen Anteil zu zeichnen und in Höhe

eines Nennwerts von einem Euro (EUR 1,-) zuzüglich eines Aufpreises in Höhe von dreiunddreissigmillionensechshun-
dertachtundvierzigtausendsiebenhundertneunund fünfzig Euro (EUR 33.648.759,-) durch eine Sacheinlage im Gesamtwert
von dreiunddreissigmillionensechshundertachtundvierzigtausendsiebenhundertsechszig Euro (EUR 33.648.760,-) vollstän-
dig einzuzahlen. Dazu legt die vorbezeichnete John Deere Luxembourg Investment S.à.r.l. die von ihr gehaltenen Anteile
(99,99%) an der John Deere International Investment (Nederland) C.V. ,mit eingetragenem Sitz in Naritaweg 165, 1043
BW, Amsterdam, eingetragen unter Nummer 24308881, und deren Wert mit sechsundvierzigmillionenvierhundertdrei-
undsechszigtausenddreihundertdreiundfünfzig US-Dollar (USD 46.463.353,-), dreiunddreissigmillionensechshundertach-

32275

L

U X E M B O U R G

tundvierzigtausendsiebenhundertsechszig  Euro  (EUR  33.648.760,-)  zu  einem  Wechselkurs  von  1  USD/0,7242  EUR
(Wechselkurs vom 21. Oktober 2011) angesetzt wird, (die „Eingebrachten Anteile“), als Sacheinlage ein.

<i>Nachweis über das Bestehen und den Wert der Einlage

Das Bestehen und der Wert der Sacheinlage wurden wie folgt nachgewiesen:
- eine Einlageerklärung der vorbezeichneten John Deere International Investment (Nederland) C.V., in der bescheinigt

wird, dass die Niederländisch Eingebrachten Anteile frei übertragbar sind nach erfolgter schriftlicher Zustimmung aller
(direkten und indirekten) Gesellschafter von John Deere International Investment (Nederland) C.V., wie festgeschrieben
im Gesellschaftsvertrag von John Deere International Investment (Nederland) C.V., insbesondere Artikel 10 Paragraph
2 und 11 (wirksam geändert durch notarielle Urkunde, ausgeführt in Venlo, Niederlande, am 28. November 2011). Die
zuvor erwähnte vorausgesetzte Übereinstimmung wird in einem Privatdokument, unterzeichnet am 28. November 2011,
dargestellt;

- eine Erklärung der Geschäftsleiter der Gesellschaft.

<i>Wirksame Umsetzung der Einlage

Die vorbezeichnete John Deere Luxembourg Investment S.à.r.l. erklärt, dass:
- sie alleinige und uneingeschränkte Eigentümerin der Eingebrachten Anteile und überdies befugt ist, diese zu veräußern,

da die Eingebrachten Anteile rechtlich und konventionell frei übertragbar sind bei vorliegender vorausgesetzter Über-
einstimmung, wie oben dargelegt;

- die Einbringung dieser Anteile ohne weitere Voraussetzungen ab dem 29. November 2011 uneingeschränkt wirksam

wird;

- alle weiteren Formalitäten bei den Gerichtsbarkeiten der Orte der Eingebrachten Anlagen beantragt wurden, um die

Übertragung ordnungsgemäß durchzuführen und zu formalisieren, damit diese überall und gegenüber Dritten wirksam
wird.

V. Aufgrund der vorstehend beschriebenen Kapitalerhöhung wird Artikel 5, 1. Absatz der Satzung der Gesellschaft

geändert und lautet ab sofort wie folgt:

Art. 5. „Das gezeichnete Stammkapital wird auf fünfundfünfzigtausendundsechs Euro (EUR 55.006,-) festgelegt, aufge-

teilt in fünfundfünfzigtausendundsechs (55.006) Anteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (1 EUR).“

<i>Kosten

Die Aufwendungen, Kosten, Vergütung oder Gebühren jeglicher Art, die der Gesellschaft infolge dieser Gesellschaf-

terversammlung entstehen, werden auf ungefähr siebentausend Euro (7.000,- EUR) geschätzt.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung der Versammlung standen, wurde diese daraufhin vertagt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf

Wunsch der erschienenen Person in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer Version in deutscher Sprache.
Auf Verlangen dieser erschienenen Person und bei Differenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist die
englische Version maßgebend.

DAHER wurde die vorliegende Urkunde in Esch-sur-Alzette am oben genannten Datum aufgesetzt.
Nachdem das Dokument dem Stimmrechtsinhaber der erschienenen Person verlesen wurde, dessen Nachname, Vor-

name, Familienstand und Wohnort dem Notar bekannt sind, hat er die vorliegende Originalurkunde gemeinsam mit uns,
dem Notar, unterschrieben.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 8 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16570. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012016662/151.
(120020637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

Entre-Nous Création S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8156 Bridel, 19, rue Lucien Wercollier.

R.C.S. Luxembourg B 89.435.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

32276

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012017220/10.
(120021029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

Yoga4You, Yoga For You A.s.b.l. Luxembourg, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1522 Luxembourg, 15A, rue Jules Fischer.

R.C.S. Luxembourg F 8.997.

STATUTS

Entre les soussignés:
1. BALIEU Anne -Marie, 23, rue Léo Moulin, L-2122 Luxembourg, fonctionnaire européen, nationalité belge, née le

02.10.1951 à Ixelles;

2. CORNETTE Chrescht, 5, rue de la Gare, L-8380 Kleinbettingen, professeur-ingénieur, nationalité luxembourgeoise,

né le, à 13.09.1961 à Steinfort;

3. ENTRINGER Michelle, 148, rue Michel Hülsemann, L-1743 Luxembourg, journaliste, nationalité luxembourgeoise,

née le 01.01.1969 à Marburg;

4. GRAF Gilbert, 15A, rue Jules Fischer, L-1522 Luxembourg, enseignant, nationalité luxembourgeoise, né le 15.02.1957

à Luxembourg;

5. KELLER Sabine, 68, rue des Eglantiers, L-1457 Luxembourg, ergothérapeute nationalité allemande, née le 17.01.1966

à Geilenkirchen;

6. REINERT-IRVING Morag, 57, boulevard Charles Simonis, L-2539 Luxembourg, fonctionnaire européen, nationalité

britannique, née le 05.02.1956 à Glasgow.

et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du

21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art.  1 

er

  .    L'association  porte  la  dénomination  de  YOGA  FOR  YOU  a.s.b.l.  Luxembourg.  Son  acronyme  est

YOGA4YOU.

Art. 2. L'association a pour objet:
- de promouvoir la pratique du yoga par l'organisation de cours, stages, conférences et séminaires;
- de regrouper des personnes intéressées à pratiquer, à enseigner et à propager les principes du yoga, sans préjugé de

culture, de race et de religion.

Art. 3. L'association a son siège social à Luxembourg, 15A, rue Jules Fischer. Le siège social peut être transféré à

n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.

II. Exercice social

Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

III. Membres

Art. 6. Peut devenir membre effectif de l'association tous les intéressés qui adhèrent aux présents statuts et qui sont

admis par le conseil d'administration.

Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association doit présenter une demande d'adhésion écrite

au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation
nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire
connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'admi-

nistration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas

acquitté de la cotisation dans le délai de trois mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.

Art. 9. Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration
- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatés par le conseil d'administration.

32277

L

U X E M B O U R G

Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'assemblée générale décide souverainement en

dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

IV. Assemblée générale

Art. 10. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe

de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'adminis-

tration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du
jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration

écrite.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire

ou par tout autre moyen approprié.

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée

générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

V. Administration

Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, élus par l'as-

semblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de un an. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, celui qui exerce

la fonction du président. Les autres membres du conseil d'administration ont la fonction d'administrateur.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'ad-

ministration sont rééligibles.

Art. 13. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil

d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 14. La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.

Art. 15. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs

à un de ses membres ou à un tiers.

IV. Contributions et Cotisations

Art. 16. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une

contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

Art. 17. La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée

générale.

VII. Mode d'établissement des comptes

Art. 18. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet

pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

VIII. Modification des statuts

Art. 19. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-

ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.

Art. 20. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

IX. Dissolution et Liquidation

Art. 21. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi

du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 22. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée

générale.

32278

L

U X E M B O U R G

X. Dispositions finales

Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre

aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Référence de publication: 2012017631/101.
(120020432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

Persson &amp; Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 107.198.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of December.
Before M 

e

 Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

Byggnads Aktiebolaget Broderna Persson, a company incorporated and governed by the laws of Sweden, with regis-

tered office at Döbelnsgatan 10, 29131 Kristianstad, Sweden, duly represented by Mr Max MAYER, employee, residing
professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a power of attorney delivered to him. Said power after
being signed "ne varietur" by the empowered and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

Such appearing party declares and requests, by its empowered the notary to act:
1.- That the limited liability company "Persson &amp; Co., S.à r.l.", with registered office à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel

Lippmann, Parc d'Activité Syrdall, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the
number 107.198, (hereinafter referred to as the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph
ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on the 24 

th

 of March 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, number 803 of the 13 

th

 of August 2005.

2.- That the corporate capital is set at twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) represented by two hundred (200)

sharequotas of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

3.- That the appearing party, represented as said before, is the sole owner of all the sharequotas of the Company.
4.- That the appearing party, represented as said before, acting as sole shareholder of the Company declares the

dissolution of the Company with immediate effect.

5.- That the appearing party, represented as said before, appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity

as liquidator of the Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any
declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.

6.- That the appearing party, represented as said before and in its capacity as liquidator of the Company declares that

it irrevocably undertakes to settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved company.

7.- That the appearing party, represented as said before, declares that it takes over all the assets of the Company, and

that it will assume any existing debt of the Company pursuant to section 6.

8.- That the appearing party, represented as said before, declares that the liquidation of the Company is closed and

that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

9.- That discharge is given to the management of the Company.
10.- That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at

the former registered office of the Company in L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

<i>Costs

The amount of costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and

charged to it by reason of the present deed is therefore estimated at EUR 800.-.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, Christian name, civil

status and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le trente décembre.

32279

L

U X E M B O U R G

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Byggnads Aktiebolaget Broderna Persson, une société constituée et régie suivant les lois suédoises, ayant son siège

social au Dobelnsgatan 10, 29131 Kristianstad, Suède, ici dûment représentée par Monsieur Max MAYER, employé, de-
meurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle
après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante déclare et requiert, par son mandataire le notaire instrumentant d'acter:
1.- Que la société à responsabilité limitée "Persson &amp; Co., S.à r.l.", avec siège social à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel

Lippmann, Parc d'Activité Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 107.198, (ci-après dénommée la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER,
notaire de résidence à Luxembourg, le 24 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
803 du 13 août 2005.

2.- Que le capital social est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,-) représenté par deux cents (200) parts sociales d'une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

3.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.
4.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant comme associée unique, prononce la dissolution

anticipée de la Société avec effet immédiat.

5.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins

pouvoirs d'établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui
est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent

et futur de la société dissoute.

7.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle

s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué à la section 6.

8.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que

tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres titres seront annulés.

9.- Que décharge est donnée à la gérance de la Société.
10.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien

siège social de la Société à L5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

à raison de cet acte, est dès lors évalué à 800,-EUR

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 05 janvier 2012. Relation GRE/2012/107. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 6 février 2012.

Référence de publication: 2012016815/94.
(120019756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

Item Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 67.042.

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 19 janvier 2012 a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Madame Eva Thurell, en tant que administrateur A, est acceptée avec effet immédiat.

32280

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Claes Thurell, avec adresse professionnelle au 2A Svanholmsvägen, SE-182 07 Stocksund, Suède, est élu

nouveau administrateur A de la société avec effet immédiat et ceux jusqu’à l'Assemblée Générale Annuelle de l’an 2018.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 2 février 2012.

Référence de publication: 2012017330/14.
(120020817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

St-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 59, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 98.643.

L'an deux mille douze.
Le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Monsieur Josua WUTZ, technicien en bâtiment, demeurant à L3448 Dudelange, 29, rue Dicks.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Qu'il est l'associé unique de la société à responsabilité limitée STLUX S.à r.l., avec siège social à L-8140 Bridel, 72, rue

de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 98.643 (NIN 2004
2400 514),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 janvier 2004, publié au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations numéro 227 du 25 février 2004, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 février 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 618 du 20 mars 2009;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 mars 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 1161 du 31 mai 2011.

Que le capital social de la société s'élève au montant de douze mille six cents Euros (€ 12.600,-), représenté par cent

vingt-six (126) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100,-) chacune.

<i>Cessions de parts sociales

Monsieur Josua WUTZ cède et transporte par les présentes sous la garantie de fait et de droit cent vingt-six (126)

parts sociales pour le montant de vingt-cinq mille Euros (€ 25.000,-) à la société à responsabilité limitée I.Q. INVEST S.à
r.l., avec siège social à L-3450 Dudelange, 59, rue du Commerce, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 152.231.

Est intervenue au présent acte:
La société à responsabilité limitée I.Q. INVEST S.à r.l., préqualifiée, représentée par son gérant unique Monsieur Josua

WUTZ, prénommé, lequel denier déclare accepter la prédite cession de parts sociales au nom de la société I.Q. INVEST
S.à r.l.

La société à responsabilité limitée I.Q. INVEST S.à r.l. est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir d'aujourd'hui

et elle a droit à partir de ce jour aux revenus et bénéfices dont ces parts seront productives et elle sera subrogée dans
tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Le cédant Monsieur Josua WUTZ déclare avoir reçu de la société à responsabilité limitée I.Q. INVEST S.à r.l. le montant

de vingt-cinq mille Euros (€ 25.000,-) avant la passation des présentes, ce dont quittance.

Monsieur Josua WUTZ, agissant en sa qualité de gérant de la société ST-LUX S.à r.l. déclare accepter au nom de la

société la prédite cession de parts sociales conformément à l'article 1690 du Code Civil avec dispense de signification.

Ensuite l'associée unique, la société à responsabilité limitée I.Q. INVEST S.à r.l., représentée comme dit ci-avant, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social de la société de Bridel à Dudelange et par conséquent de modifier

la première phrase de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (Première phrase). Le siège social est établi à Dudelange.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-3450 Dudelange, 59, rue du Commerce.

<i>Troisième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

32281

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS (€ 12.600,-), représenté par cent

vingt-six (126) parts sociales d’une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été attribuées à la société à responsabilité limitée I.Q. INVEST S.à r.l., avec siège social à

L-3450 Dudelange, 59, rue du Commerce, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 152.231.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. WUTZ, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 27 janvier 2012. Relation: ECH/2012/162. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 02 février 2012.

Référence de publication: 2012016921/63.
(120020001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

CVM SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 60.388.

Les comptes annuels au 31 août 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CVM SPF S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012017196/12.
(120021105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

Rinoraines S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 103.280.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement à Luxembourg le 7 février

<i>2012 à 10 heures

Il résulte dudit procès-verbal que les administrateurs suivants ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur avec

effet immédiat:

- Monsieur Gabriel JEAN, juriste, demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange
- CIRTERIA Sàrl, avec siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange
- PROCEDIA Sàrl, avec siège social au 10B me des Mérovingiens, L-8070 Bertrange
Les Administrateurs suivants remplacent les administrateurs démissionnaires:
- Madame Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 231 Val des

Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

- Monsieur Marc SCHMIT, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 231 Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg.

- Monsieur Fernand HEIM, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 231 Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg.

Les nouveaux Administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg en date du 7 février 2012

Il résulte dudit procès-verbal que la gestion journalière de la société a été déléguée à Madame Geneviève BLAUEN-

ARENDT, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 231 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg
en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Gabriel JEAN.

En qualité d'administrateur délégué, Madame Geneviève BLAUEN-ARENDT aura le pouvoir d'engager la Société par

sa seule signature dans le cadre des actes de gestion journalière.

32282

L

U X E M B O U R G

Il résulte également dudit procès-verbal que Madame Geneviève BLAUEN-ARENDT, demeurant professionnellement

au 231 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg a été nommée en tant que Présidente du Conseil d'Administration de
la Société à compter de ce jour en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Christophe BLONDEAU.

Luxembourg, le 7 février 2012.

<i>Pour RINORAINES S.A.

Référence de publication: 2012019102/33.
(120023527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 35.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 67.895.

La liste des signataires autorisés a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2012.

Référence de publication: 2012017198/11.
(120021215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

Stigma Funds (LUX), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 154.869.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand and eleven, on the nineteenth day of December,
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Stigma Funds (LUX) (the Meeting), a Luxembourg

investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable), incorporated in the form of a public
limited liability company (société anonyme) having its registered office at 41, Op Bierg, L-8217 Mamer, Grand Duchy of
Luxembourg, incorporated on 6 August 2010 pursuant to a notarial deed recorded by Maître Wersandt, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°1677
on 18 August 2010, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154869 (the
Company).

The Meeting is opened at 15:30 pm with Mrs.Solange Wolter-Schieres, employee, residing professionally in Luxem-

bourg as chairman. The chairman appoints François Leynen, residing professionally in Mamer, as secretary and scrutineer
of the Meeting. The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to hereafter as the Members of
the Bureau or as the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:
I. the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded in

an attendance list, which will remain attached to these minutes and which will be signed by the shareholders present at
the Meeting and the holders of powers of attorney who represent the shareholders who are not present and the Members
of the Bureau. The said list as well as the powers of attorney will remain attached to these minutes;

II. it appears from the attendance list that all the shares without par value representing the entire subscribed share

capital of the Company are present or duly represented at the Meeting. The shareholders present or represented declare
that they have had due notice of, and have been duly informed of the agenda prior to, the Meeting. The Meeting decides
to waive the convening notices. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on
the agenda, set out below;

III. the agenda of the Meeting is as follows:
(1) waiver of the convening notices;
(2) decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
(3) decision to appoint Fund Solutions, represented by Mr Christophe Cahuzac, with registered address at 2, rue des

Dahlias, L-1411 Luxembourg (the Liquidator), as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company;

(4) determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
(5) decision to instruct the Liquidator to realise at the best of his abilities and with regard to the circumstances all the

assets of the Company and to pay the debts of the Company;

(6) decision to instruct Deloitte S.A. (the auditor of the Company) to issue a report on the liquidation; and

32283

L

U X E M B O U R G

(7) acknowledgement that the Liquidator will convene an extraordinary general meeting of shareholders resolving on

the closing of the liquidation.

After deliberation the Meeting passed by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the subscribed share capital of the Company being present or represented at the present Meeting, the

Meeting waives the convening notices, the shareholders present or represented consider themselves as duly convened
and declare having knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation vo-

lontaire).

<i>Third resolution

The Meeting resolves to appoint Fund Solutions, represented by Mr Christophe Cahuzac, with registered address at

2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg (the Liquidator) as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the
Company.

The Liquidator has the widest powers to do everything, which is required for the liquidation of the Company and the

disposal of the assets of the Company under its sole signature.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg act

dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145

of the Companies Act 1915, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquidator may,
under its sole responsibility, delegate its powers for specific operations or tasks to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni

de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Companies Act 1915.

In case upon closing of the liquidation of the Company it would appear that the provisions made to cover estimated

costs exceed the actual accrued costs (the Excess Amounts), the Meeting instructs the Liquidator to distribute Excess
Amounts among all shareholders of the Company recorded in the register of shareholders as at the date of 23 November
2011 in order to ensure a fair and equal treatment amongst all shareholders of the Company.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to instruct the Liquidator to realise at the best of his abilities and with regard to the circumstances

all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to instruct Deloitte S.A. (the auditor of the Company) to issue a report on the liquidation.

<i>Eighth resolution

The Meeting acknowledges that the Liquidator will convene an extraordinary general meeting of shareholders resolving

on the closing of the liquidation, which shall be held, as soon as practicable after the Liquidator will have performed his
duties, with in substance the following agenda:

(1) waiver of the convening notices;
(2) Presentation and approval of the audited accounts of the Company for the period from January 1, 2011 to December

19, 2011, date of liquidation of the Company;

(3) presentation of the report of Fund Solutions, represented by Mr Christophe Cahuzac, with registered address at

2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg (the Liquidator), as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the
Company;

(4) presentation of the report of Deloitte S.A. on the liquidation of the Company;
(5) release (quitus) to the board of directors of the Company for all its duties during, and in connection with, the

financial year having started on 1 January 2011 and having ended on 19 December 2011, the date of the extraordinary
general meeting deciding to dissolve and liquidate the Company;

(6)  release  (quitus)  to  the  Liquidator,  as  liquidator  (liquidateur)  of  the  Company,  for  all  his  duties  during,  and  in

connection with, the liquidation of the Company;

(7) release (quitus) to Deloitte S.A., as auditor of the Company, for all its duties during, and in connection with, (i) the

financial year having started on 1 January 2011 and having ended on 19 December 2011, the date of the extraordinary
general meeting deciding to dissolve and liquidate the Company, and (ii) the liquidation of the Company;

(8) decision to close the liquidation of the Company; and

32284

L

U X E M B O U R G

(9)  decision  that  the  Company's  documents  and  books  shall  be  kept,  for  a  period  of  five  years  from  the  date  of

publication of the closing of the liquidation, at the following address: 41, Op Bierg, L-8217 Mamer, Grand-Duchy of
Luxembourg.

There being no further business on the agenda of the Meeting, the chairman adjourns the Meeting at 16 pm.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appearing

persons, this notarial deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appearing
persons, and in the case of discrepancy between the English and French versions, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le dix-neuvième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Stigma Funds (LUX) (l'Assemblée), une société

d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, organisée sous la forme d'une société anonyme, ayant son
siège social au 41, Op Bierg, L8217 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg, constituée le 6 août 2010 en vertu d'un acte
de Me Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié dans le Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n°1677 du 18 août 2010, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 154869 (la Société).

La  séance  est  ouverte  à  15H30  sous  la  présidence  de  Madame  Solange  Wolter-Schieres,  employée,  avec  adresse

professionnelle à Luxembourg. La présidente désigne comme secrétaire et scrutateur de l'Assemblée Monsieur François
Leynen, avec adresse professionnelle à Mamer, Grand-Duché de Luxembourg. Il est collectivement référé au président,
secrétaire et scrutateur ci-après comme aux Membres du Bureau ou au Bureau.

Le Bureau étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter que:
I. les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux

sont inscrits dans une liste de présence qui restera annexée aux présentes et sera signée par les actionnaires présents à
l'Assemblée, par les mandataires représentant les actionnaires non présents et par les Membres du Bureau. Ladite liste,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées aux présentes;

II. il ressort de la liste de présence que toutes les actions sans valeur nominale représentant l'entièreté du capital social

souscrit de la Société sont présentes ou dûment représentées à l'Assemblée. Les actionnaires présents ou représentés
déclarent avoir reçu une convocation dûment adressée et qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour avant l'As-
semblée. L'Assemblée décide de renoncer aux modalités de convocation. De ce fait, l'Assemblée est constituée selon les
règles et peut délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, mentionné ci-après;

III. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
(1) renonciation aux modalités de convocation;
(2) décision de dissoudre et liquider volontairement la Société;
(3) décision de nommer Fund Solutions, représentée par M. Christophe Cahuzac, ayant son siège social au 2, rue des

Dahlias, L-1411 Luxembourg (le Liquidateur), comme liquidateur de la Société en relation avec la liquidation volontaire
de la Société;

(4) détermination des pouvoirs à conférer au Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
(5) décision de charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société,

et de payer toutes les dettes de la Société;

(6) décision de charger Deloitte S.A. (le réviseur d'entreprises agréé de la Société) de la mission d'établir un rapport

sur la liquidation; et

(7) décision de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de la clôture de la liquidation de la Société.
Après délibération, l'Assemblée a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La  totalité  du  capital  social  souscrit  de  la  Société  étant  présente  ou  représentée  à  cette  Assemblée,  l'Assemblée

renonce aux modalités de convocation, les actionnaires présents ou représentés se considérant comme dûment convo-
qués et déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de dissoudre et liquider volontairement la Société.

32285

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer Fund Solutions, représentée par M. Christophe Cahuzac, ayant son siège social au 2,

rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg (le Liquidateur), comme liquidateur en relation avec la liquidation de la Société.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir sous sa seule signature tout acte nécessaire à la liquidation

de la Société et la réalisation de son actif.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et d'exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux

articles 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra
déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une
ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser discrétionnairement des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de

la Société conformément à l'article 148 de la Loi de 1915.

Si à la clôture de la liquidation de la Société il apparaît que les provisions prévues pour couvrir les frais estimés excèdent

les frais réellement engagés (les Montants Excédentaires), l'Assemblée charge le liquidateur de distribuer ces Montants
Excédentaires aux actionnaires de la Société repris au registre des actionnaires en date du 23 novembre 2011 de manière
à assurer que les actionnaires soient tous traités équitablement.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la

Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de charger Deloitte S.A. (le réviseur d'entreprises agréé de la Société) de la mission d'établir un

rapport sur la liquidation.

<i>Septième résolution

L'Assemblée reconnait que le Liquidateur convoquera une assemblée générale extraordinaire en vue de la clôture de

la liquidation de la Société qui se tiendra par devant notaire dès que possible une fois que le Liquidateur aura exécuté ses
devoirs, et dont l'ordre du jour sera, en substance, le suivant:

(1) renonciation aux modalités de convocation;
(2) présentation et approbation des comptes audités de la Société pour la période du 1 

er

 janvier 2011 au 19 décembre

2011, date de liquidation de la Société;

(3) présentation du rapport de Fund Solutions, représentée par M. Christophe Cahuzac, ayant son siège social au 2,

rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg (le Liquidateur) en sa qualité de liquidateur en rapport avec la liquidation de la
Société;

(4) présentation du rapport de Deloitte S.A. sur la liquidation de la Société;
(5) décharge (quitus) à accorder au conseil d'administration de la Société pour l'exécution de tous ses devoirs pendant,

et en relation avec, l'exercice social commencé le 1 

er

 janvier 2011 et clôturé le 19 décembre 2011, date de l'assemblée

générale extraordinaire ayant décidé de la dissolution et de la mise en liquidation la Société;

(6) décharge (quitus) à accorder au Liquidateur en sa qualité de liquidateur de la Société, pour l'exécution de tous ses

devoirs pendant et en relation avec la liquidation de la Société;

(7) décharge (quitus) à accorder à Deloitte S.A. en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société pour l'exécution

de tous ses devoirs pendant, et en relation avec, (i) l'exercice social commencé le 1 

er

 janvier 2011 et clôturé au 19

décembre 2011, date de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la dissolution et de la mise en liquidation la
Société et (ii) la liquidation de la Société;

(8) décision de clôture de la liquidation de la Société; et
(9) décision de déposer et conserver les livres et documents sociaux de la Société pendant cinq ans, à partir de la date

de publication de la clôture de liquidation à l'adresse suivante: 41 Op Bierg, L-8217 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des personnes com-

parantes, le présent acte notarié est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. Sur la demande des mêmes
personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, celles-ci ont signé ensemble avec le notaire

le présent acte.

32286

L

U X E M B O U R G

Signé: S. WOLTER-SCHIERES, F. LEYNEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58996. Reçu douze euros (12.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Référence de publication: 2012014984/204.
(120017470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Eden Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 158.562.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance du 24 janvier 2012

Le siège social de la société est transféré avec effet au 13 Janvier 2012 au:
18, Rue Robert Stümper, L – 2557 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012017211/12.
(120020963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

GSO Capital Opportunities Fund II (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 158.357.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of January.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch/Alzette.

THERE APPEARED:

GSO Capital Opportunities Fund II L.P., a limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, having

its registered office at c/o Walkers Corporate Services Limited, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY19005,
Cayman Islands, registered in the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under the number
WK-44604, acting through its general partner, GSO Capital Opportunities Associates II LLC, having its registered office
at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
USA,

here represented by:
Maître Sophie ARVIEUX, lawyer, residing professionally in L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Ste Zithe,
by virtue of a proxy given under private seal.
The proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as aforementioned, has requested the undersigned notary to record the following:
- The appearing party is the sole shareholder of the company GSO Capital Opportunities Fund II (Luxembourg) S.à

r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur, registered
with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 158357, incorporated pursuant to a deed
received by Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, dated 19 January 2011, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 799 dated 22 April 2011 (the "Company"). The articles of association of
the Company have not been amended since its incorporation.

- The Company's corporate capital is set at EUR 12,500.(twelve thousand five hundred Euro), represented by 12,500

(twelve thousand five hundred) shares of EUR 1.-(one Euro) each.

- The agenda is worded as follows:
1. Change of the currency of the share capital of the Company from EUR (Euro) to USD (United States Dollars) based

on the currency exchange rate applicable on 19 January 2011 as determined by the European Central Bank (i.e. USD
1.3506) with retroactive effect as from the date of incorporation of the Company (i.e. 19 January 2011).

2. Conversion of the 12,500 (twelve thousand five hundred) existing shares of EUR 1.-(one Euro) each into 33,765

(thirty-three thousand seven hundred sixty-five) shares of USD 0.50.(fifty cents) each.

3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company.
4. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of USD 8,117.50.-(eight thousand one hundred

seventeen United States Dollars and fifty cents) in order to raise it from its present amount of USD 16,882.50.-(sixteen

32287

L

U X E M B O U R G

thousand eight hundred eighty-two United States Dollars and fifty cents), represented by 33,765 (thirty-three thousand
seven hundred sixty-five) shares of USD 0.50.-(fifty cents) each, to USD 25,000.-(twenty-five thousand United States
Dollars) by the creation and issue of 16,235 (sixteen thousand two hundred thirty-five) new shares of USD 0.50.-(fifty
cents) each.

5. Subscription and payment in cash of the 16,235 (sixteen thousand two hundred thirty-five) new shares of USD 0.50.-

(fifty cents) each.

6. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company.
7. Conversion of the 50,000 (fifty thousand) existing shares of USD 0.50.- (fifty cents) into 25,000 (twenty-five thousand)

shares of USD 1.- (one United States Dollar) each.

8. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company.
9. Miscellaneous.
The sole shareholder of the Company then takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to change, with retroactive effect as from the date of incorporation of the Company

(i.e. 19 January 2011), the currency of the share capital of the Company from EUR (Euro) to USD (United States Dollars)
based on the currency exchange rate applicable on 19 January 2011 as determined by the European Central Bank being
EUR 1 = USD 1.3506, so that the share capital of the Company amounts, with retroactive effect as from 19 January 2011,
to USD 16,882.50 (sixteen thousand eight hundred eighty-two United States Dollars and fifty cents).

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to convert the 12,500 (twelve thousand five hundred) existing shares of EUR 1.(one

Euro) each into 33,765 (thirty-three thousand seven hundred sixty-five) shares of USD 0.50.-(fifty cents) each.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association

is amended and shall henceforth have the following wording:

Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at USD 16,882.50.-(sixteen thousand eight hundred eighty-

two United States Dollars and fifty cents), represented by 33,765 (thirty-three thousand seven hundred sixty-five) shares
of USD 0.50.-(fifty cents) each, all subscribed and fully paid-up."

<i>Fourth resolution

The corporate capital of the Company is increased by an amount of USD 8,117.50.-(eight thousand one hundred

seventeen United States Dollars and fifty cents) so as to raise it from its present amount of USD 16,882.50.-(sixteen
thousand eight hundred eighty-two United States Dollars and fifty cents), represented by 33,765 (thirty-three thousand
seven hundred sixty-five) shares of USD 0.50.-(fifty cents) each, to USD 25,000.-(twenty-five thousand United States
Dollars) by the creation and issue of 16,235 (sixteen thousand two hundred thirty-five) new shares of USD 0.50.(fifty
cents) each.

All the new shares have been entirely subscribed by GSO Capital Opportunities Fund II L.P., prenamed, represented

as stated above, and have been paid-up by contribution in cash for an amount of USD 8,117.50.-(eight thousand one
hundred  seventeen  United  States  Dollars  and  fifty  cents)  so  that  from  now  on  the  amount  of  USD  8,117.50.-(eight
thousand one hundred seventeen United States Dollars and fifty cents) is at the free and entire disposal of the Company,
as it has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolution, the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association

is amended and shall henceforth have the following wording:

Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at USD 25,000.-(twenty-five thousand United States Dollars),

represented by 50,000 (fifty thousand) shares of USD 0.50.-(fifty cents) each, all subscribed and fully paid-up."

<i>Sixth resolution

The sole shareholder resolves to convert the 50,000 (fifty thousand) existing shares of USD 0.50.-(fifty cents) into

25,000 (twenty-five thousand) shares of USD 1.-(one United States Dollar) each.

<i>Seventh resolution

As a consequence of the preceding resolution, the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association

is amended and shall henceforth have the following wording:

32288

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at USD 25,000.-(twenty-five thousand United States Dollars),

represented by 25,000 (twenty-five thousand) shares of USD 1.(one United States Dollar) each, all subscribed and fully
paid-up."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at € 1,200.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version; on the request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version shall prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-septième jour du mois de janvier.
Par-devant Nous Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette,

A COMPARU:

GSO Capital Opportunities Fund II L.P., une société de droit des Iles Cayman, établie et ayant son siège social à c/o

Walkers Corporate Services Limited, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, immatriculée
au Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands sous le numéro WK-44604, représentée par GSO
Capital Opportunities Associates II LLC, établie et ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Company, Cor-
poration Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis, son general partner,

ici représentée par:
Maître Sophie ARVIEUX, avocat, avec adresse professionnelle à L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Ste Zithe,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

La comparante, représentée ainsi qu'il a été dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- La comparante est l'associé unique de la société GSO Capital Opportunities Fund II (Luxembourg) S.à r.l., une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur, im-
matriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158357, constituée suivant
acte  reçu  par  Maître  Léonie  GRETHEN,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  en date du 19 janvier 2011,  publié  au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 799 du 22 avril 2011 (la «Société»). Les statuts de la Société
n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

- Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,(douze mille cinq cents euros), représenté par 12.500 (douze

mille cinq cents) parts sociales de EUR 1,- (un euro) chacune.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. Modification de la devise du capital social de la Société de EUR (euro) à USD (dollar américain) au taux de change

applicable le 19 janvier 2011 tel que déterminé par la Banque Centrale Européenne (c'est-à-dire USD 1.3506) avec effet
rétroactif à la date de constitution de la Société (c'est-à-dire le 19 janvier 2011).

2. Conversion des 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales existantes de EUR 1,-(un euro) chacune en 33.765

(trente-trois mille sept cent soixante-cinq) parts sociales de USD 0,50,- (cinquante cents) chacune.

3. Modification subséquente de l'alinéa premier de l'article 6 des statuts de la Société.
4. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de USD 8.117,50,-(huit mille cent dix-sept dollars amé-

ricains et cinquante cents) pour le porter de son montant actuel de USD 16.882,50,-(seize mille huit cent quatre-vingt-
deux dollars américains et cinquante cents), représenté par 33.765 (trente-trois mille sept cent soixante-cinq) parts
sociales de USD 0,50,-(cinquante cents) chacune, à USD 25.000,-(vingt-cinq mille dollars américains) par la création et
l'émission de 16.235 (seize mille deux cent trente-cinq) nouvelles parts sociales de USD 0,50,-(cinquante cents) chacune.

5. Souscription et libération en numéraire des 16.235 (seize mille deux cent trente-cinq) nouvelles parts sociales de

USD 0,50,-(cinquante cents) chacune.

6. Modification subséquente de l'alinéa premier de l'article 6 des statuts de la Société.
7. Conversion des 50.000 (cinquante mille) parts sociales de USD 0,50,-(cinquante cents) chacune en 25.000 (vingt-

cinq mille) parts sociales de USD 1,-(un dollar américain) chacune.

8. Modification subséquente de l'alinéa premier de l'article 6 des statuts de la Société.
9. Divers.
L'associé unique de la Société prend ensuite les résolutions suivantes:

32289

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'associé unique décide de modifier, avec effet rétroactif à la date de constitution de la Société (c'est-à-dire le 19 janvier

2011), la devise du capital social de la Société de EUR (euro) en USD (dollar américain) au taux de change applicable le
19 janvier 2011 tel que déterminé par la Banque Centrale Européenne (c'est-à-dire USD 1.3506), de sorte que le capital
social de la Société s'élève, avec effet rétroactif au 19 janvier 2011, à USD 16.882,50,-(seize mille huit cent quatre-vingt-
deux dollars américains et cinquante cents).

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de convertir les 12.500 (douze mille cinq cent) parts sociales existantes de EUR 1,-(un euro)

chacune en 33.765 (trente-trois mille sept cent soixante-cinq) parts sociales de USD 0,50,-(cinquante cents) chacune.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'alinéa 1 

er

 de l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir

la teneur qui suit:

« Art. 6. Capital. Le capital social de la Société est fixé à USD 16.882,50,-(seize mille huit cent quatre-vingt-deux dollars

américains), représenté par 33.765 (trente-trois mille sept cent soixante-cinq) parts sociales de USD 0,50,-(cinquante
cents) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de USD 8.117,50,-(huit mille cent dix-sept dollars américains

et cinquante cents) pour le porter de son montant actuel de USD 16.882,50,-(seize mille huit cent quatre-vingt-deux
dollars américains et cinquante cents), représenté par 33.765 (trente-trois mille sept cent soixante-cinq) parts sociales
de USD 0,50,(cinquante cents) chacune, à USD 25.000,-(vingt-cinq mille dollars américains) par la création et l'émission
de 16.235 (seize mille deux cent trente-cinq) nouvelles parts sociales de USD 0,50,- (cinquante cents) chacune.

Toutes  les  nouvelles  parts  sociales  ont  été  intégralement  souscrites  par  GSO  Capital  Opportunities  Fund  II  L.P.,

préqualifiée, représentée comme indiqué ci-dessus, et elles ont été libérées en numéraire pour un montant de USD
8.117,50,(huit mille cent dix-sept dollars américains et cinquante cents), de sorte que le montant de USD 8.117,50,-(huit
mille cent dix-sept dollars américains et cinquante cents) est à présent à la libre et entière disposition de la Société, ainsi
qu'il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'alinéa 1 

er

 de l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir

la teneur qui suit:

« Art. 6. Capital. Le capital social de la Société est fixé à USD 25.000,-(vingt-cinq mille dollars américains), représenté

par 50.000 (cinquante mille) parts sociales de USD 0,50,(cinquante cents) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.»

<i>Sixième résolution

L'associé unique décide de convertir les 50.000 (cinquante mille) parts sociales existantes de USD 0,50,-(cinquante

cents) chacune en 25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales de USD 1,(un dollar américain) chacune.

<i>Septième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'alinéa 1 

er

 de l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir

la teneur qui suit:

« Art. 6. Capital. Le capital social de la Société est fixé à USD 25.000,-(vingt-cinq mille dollars américains), représenté

par 25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales de USD 1,-(un dollar américain) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte, sont estimés à € 1.200,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, le mandataire a signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: S. Arvieux, Moutrier Blanche.

32290

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 janvier 2012. Relation: EAC/2012/1366. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 1 

er

 février 2012.

Référence de publication: 2012015982/200.
(120019097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2012.

Fedelia S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-3858 Schifflange, 2, rue Denis Netgen.

R.C.S. Luxembourg B 162.118.

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1 

er

 février 2012 les décisions suivantes:

- d’accepter, à compter du 1 

er

 février 2012, la cession de 66 parts sociales détenues par la société FLEURIS FINANCE

LIMITED, ayant son siège à OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola ILES VIERGES BRITANNIQUES à
Madame BOLIS ép. DALLAMICAUX Céline, domiciliée 7, Clos du Château à F-54650 SAULNES, pour le prix convenu
entre parties.

- d’accepter, à compter du 1 

er

 février 2012, la cession de 24 parts sociales détenues par la société FLEURIS FINANCE

LIMITED, prédite, à Monsieur DALLAMICAUX Frédéric, domicilié 7, Clos du Château à F-54650 SAULNES, pour le prix
convenu entre parties.

- d’accepter, à compter du 1 

er

 février 2012, la cession de 10 parts sociales détenues par la société FLEURIS FINANCE

LIMITED, susmentionnée, à Monsieur BARBONI Claude, demeurant 17a, rue Jean Moulin à F-54590 HUSSIGNY-GOD-
BRANGE, pour le prix convenu entre parties.

- d’accepter, à compter du 1 

er

 février 2012, la nomination de Monsieur DALLAMICAUX Frédéric, prédit, en tant que

gérant unique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 6 février 2012.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2012017819/23.
(120021923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.

MP Kings Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.501,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 159.704.

In the year two thousand and eleven, on the on the thirtieth of December.
Before Us, Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

MP Real Estate Invetsments W6 LLP, a limited liability partnership governed by the laws of United Kingdom, with

registered office at 10 Gloucester Place, Portman Square, London W1U 8EZ United Kingdom, registered with the Com-
panies House under number OC362425 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mrs Eleanor Lever, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy, which, after

having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for
the purpose of registration.

The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by MP Kings

Retail S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated 15 March 2011, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1321 of 17 June 2011, with registered office at 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg and registered with the Luxembourg Company Register under number B 159.704 (the
"Company").

The articles of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Blanche Moutrier on 29 April

2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 4 August 2011 under number 1779 (the
"Articles of Incorporation").

The appearing party declared to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

32291

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. To amend article 22 of the Articles of Incorporation of the Company so as to change the financial year of the

Company which currently runs from the first day of the month of January to the last day of the month of December, to
run from the first day of the month of April to the last day of the month of March of each year.

2. To change the first financial year of the Company so that it runs from 15 

th

 March 2011 to 31 

st

 March 2012.

3. Miscellaneous.
The appearing party, represented as above stated in its capacity of Sole Shareholder of the Company, then took the

following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 22 of the Articles of Incorporation of the Company so as to change

the financial year of the Company which currently runs from the first day of the month of January to the last day of the
month of December to the first day of the month of April to the last day of the month of March and which shall forthwith
read as follows:

Art. 22. Financial Year. "The Company's financial year begins on the first day of the month of April and ends on the

last day of the month of March every year."

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to change the first financial year of the Company so as it shall run from the 15 

th

 March

2011 to the 31 

st

 March 2012.

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

deed, are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English and the French
text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party's proxy holder, who is known to the notary by his/her surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le trente décembre.
Par devant Nous, Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),

A comparu:

MP Real Estate Invetsments W6 LLP, un limited liability partnership constituée selon le droit anglais, ayant son siège

social à 10 Gloucester Place, Portman Square, Londres W1U 8EZ, Royaume-Uni, enregistrée au Companies House sous
le numéro OC362425 (l"Associé Unique"),

représentée par Madame Eleanor Lever, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

qui, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux
fins de formalisation.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré qu'elle détient actuellement toutes les actions

émises par MP Kings Retail S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social à 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg) con-
stituée sous le droit luxembourgeois, par acte de Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, daté du 15
mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1321 du 17 juin 2011, et enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.704 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié de Maître Blanche Moutrier, ayant son

adresse professionnelle à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), le 29 avril 2011, publié dans le Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1779 le 4 août 2011 (les "Statuts").

La comparante a déclaré qu'elle reconnaît être entièrement informée des résolutions à prendre sur base de l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l'article 22 des Statuts de la Société afin de modifier l'année sociale qui est actuellement du 1 jour

du mois de janvier au dernier jour du mois de décembre au premier jour du mois d'avril au dernier jour du mois de mars.

2. Modification de la première année sociale de la Société faisant aller celle-ci du 15 mars 2011 au 31 mars 2012.

32292

L

U X E M B O U R G

3. Divers.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, en sa qualité d'Associé Unique de la Société, a pris les

décisions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 22 des Statuts de la Société afin de modifier l'année sociale qui va

actuellement du premier jour du mois de janvier au dernier jour du mois de décembre pour que celle-ci aille du premier
jour du mois d'avril au dernier jour du mois de mars, et qui doit donc dès à présent être lu comme suit:

Art. 22. Année Sociale. "L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois d'avril et finit le dernier jour

du mois de mars de chaque année"

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier la première année sociale de la Société faisant aller celle-ci du 15 mars 2011 au

31 mars 2012.

<i>Frais et Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de cet acte sont

estimés à environ mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire instrumentant, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, état

civil et demeure, ce mandataire a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Lever,GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2012. Relation: LAC/2012/505. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

<i>Le Receveur

 (signé): Frising.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Référence de publication: 2012014863/105.
(120017858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Doosan Heavy Industries European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 125.754.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Doosan Heavy Industries European Holdings S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012017199/11.
(120021185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

Dandelon Development Company SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 162.800.

Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat, à l'adresse suivante:
65, Rue des Romains
L-8041 Strassen

Strassen, le 2 janvier 2012.

DANDELON DEVELOPMENT COMPANY SA
Signature

Référence de publication: 2012017202/13.
(120020867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

32293

L

U X E M B O U R G

KeyDrive S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 4.133.437,00.

Siège social: L-1270 Luxembourg, 18, am Bongert.

R.C.S. Luxembourg B 157.525.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 27 Janvier 2012

En date du 27 janvier 2012, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Madame Kesia WILLIAMS en tant que membre de catégorie B et vice-président du conseil

de surveillance de la Société avec effet immédiat;

Le conseil de surveillance de la Société est désormais composé comme suit:
- Madame Natalia SUTUGNIA; membre de catégorie A
- Monsieur Ulrich KIEFER; membre de catégorie A
- Monsieur Horst SIFFRIN; membre de catégorie A et président
- d'accepter la démission de Monsieur Gregory J. MANRIQUEZ en tant que membre de catégorie B du directoire de

la Société avec effet immédiat.

Le directoire de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Alexander O. SIFFRIN; membre de catégorie A du directoire
- Monsieur Michael RIEDL; membre de catégorie B du directoire
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2012.

KeyDrive S.A.
Signatures

Référence de publication: 2012018372/25.
(120022982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.

LBREP III CBC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.012.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 129.781.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the seventh of December,
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) qualified as société

d'investissement en capital à risque (SICAR), incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office
at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
section B, under number 127.959 (the “Shareholder”),

Here represented by Flora Gibert, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under

private seal given by the Shareholder, which, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the un-
dersigned notary, will be registered with this minute.

The Shareholder, represented as stated here above, declared and requested the notary to enact:
1. that LBREP III CBC S.à r.l. (the “Company”) has been incorporated by deed of the undersigned notary dated 28

June 2007, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations under number 1822 dated 28 August
2007, and whose articles have been last amended pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, Notary in Junglinster (Grand-
duchy of Luxembourg) dated 20 July 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2059 of
21 September 2007;

2. that the subscribed share capital of the Company amounts currently to EUR 1,012,500.- (one million twelve thousand

five hundred Euro), represented by 810,000 (eight hundred and ten thousand) shares of EUR 1.25 (one Euro twenty-five
Cents) each, fully paid up;

3. that the Shareholder is the sole shareholder of the Company and holds all the 810,000 (eight hundred and ten

thousand) Company's shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five Cents) each;

4. that the Shareholder declares to have full knowledge of the articles of association and the financial situation of the

Company and approves the financial statements of the Company as of the date of dissolution of the Company;

32294

L

U X E M B O U R G

5. that the Shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution and liquidation of the Company;
6. that the Shareholder declares that all the known third party debts and liabilities of the Company have been paid and

settled;

7. that the Shareholder takes over and assumes personally all assets, liabilities and commitments known or unknown

of the dissolved Company and the liquidation of the Company is terminated without prejudice that it assumes all its
liabilities;

8. that the Company's share register be cancelled as a result of the dissolution of the Company;
9. that the Shareholder fully discharges the managers for their mandate up to this date; and
10. that the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at the offices of the dissolved

Company.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred Euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worked in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le sept décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, instrumentant.

A COMPARU

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR, une société à responsabilité limitée constituée en vertu du droit luxembourgeois,

qualifiée en société d'investissement en capital à risque (SICAR), ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre du Commerce et des Sociétés Lu-
xembourg sous le numéro B. 127.959, étant l'associé unique (l'"Associé") de la Société et agissant en cette capacité,

ici représentée par Flora Gibert, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé donnée par l'Associé, qui après voir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée à la présente.

L'Associé, représenté comme mentionné ci-dessus, a déclaré et requis du notaire d'acter:
1. que LBREP III CBC S.à r.l. (la «Société») a été constituée par acte notarié du notaire instrumentant date du 28 juin

2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 1822 daté du 28 août 2007, et
dont les statuts ont été amendés pour la dernière fois selon acte de Maître Jean Seckler, Notaire à Junglinster (Grand-
duché de Luxembourg) en date du 20 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
sous le numéro 2059 daté du 21 septembre 2007;

2. que le capital social souscrit de la Société se chiffre actuellement à la somme de EUR 1.012.500 (un million douze

mille cinq cents Euro), représenté par 810.000 (huit cent dix mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.25 (un
Euro vingt-cinq centimes) chacune, entièrement libérées;

3. que l'Associé est le seul associé de la Société et détient toutes les 810.000 (huit cent dix mille) parts sociales de la

Société d'une valeur nominale de EUR 1.25 (un Euro vingt-cinq centimes) chacune;

4. que l'Associé déclare avoir pleine connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et approuve les

rapports financiers de la Société à la date de sa dissolution;

5. que l'Associé déclare explicitement procéder à la dissolution et à la liquidation de la Société;
6. que l'Associé déclare que toutes les dettes et passifs à des tiers connus de la Société ont été payés et réglés;
7. que l'Associé prend en charge et assume personnellement les actifs, passifs et obligations, connus ou inconnus, de

la Société dissoute et la liquidation de la Société est clôturée étant entendu qu'il assume tous ses passifs;

8. que suite à la dissolution de la Société, son registre des parts sociales est annulé;
9. que l'Associé donne entière décharge aux gérants pour leur activité dans le cadre de leur mandat jusqu'à cette date;

et

10. que les livres et documents de la Société seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de la

Société dissoute.

32295

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges sous quelque forme incombant à la Société en raison des

présentes, est estimé approximativement à mille trois cents Euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est dressé

en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de cette même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Le document ayant été lu à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état civil et domicile,

la personne comparante a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 09 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54798. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, 19 décembre 2011.

Référence de publication: 2012017920/98.
(120021662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.

Ecolab LUX 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 166.024.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 20 janvier 2012:
que NDC LLC a transféré 12.500 parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 euro chacune à Ecolab NL 7 C.V., une

société en commandite, constituée et régie par le droit néerlandais immatriculée auprès du Handelsregister Kamer van
Koophandel, sous le numéro 54250692, ayant ses bureaux au 1601 West Diehl Road Naperville, 60563 Illinois, USA.

Désormais, l'associé unique de la Société est donc le suivant:
- Ecolab NL 7 C.V.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2012017210/19.
(120021340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

L&amp;V Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 8, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 149.657.

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2011, a approuvé la résolution suivante:

- que depuis le 1 

er

 janvier 2012, le siège social de la société a été transféré du 39, rue Goethe L-1637 Luxembourg

vers le 8, rue Beaumont L-1219 Luxembourg

Luxembourg, le 1 

er

 février 2012.

Pour extrait conforme
Natacha Hainaux

Référence de publication: 2012017365/14.
(120021430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

32296

L

U X E M B O U R G

Rhombus Bidco S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 166.522.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of January.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Rhombus Holdco S.à r.l.,a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg

and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of GBP 15,000, not yet
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,

here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies, given

under private seal in Luxembourg, on 20 January 2012.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing the appearing party and the notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the “Company”) which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of “Rhombus Bidco S.à r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of ma-
nagers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) represented by seven

hundred fifty (750) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of

32297

L

U X E M B O U R G

the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.

Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members

a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

32298

L

U X E M B O U R G

Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.

Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The seven hundred fifty (750) shares have been subscribed by Rhombus Holdco S.à r.l.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-)

is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of

December 2012.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164777, is appointed manager of the Company for an
indefinite period of time.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausenzwölf, den dreiundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

32299

L

U X E M B O U R G

Rhombus Holdco S.à r.l., eine société à responsablilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großher-

zogtums  Luxembourg,  mit  einem  Gesellschaftskapital  von  15.000  Britische  Pfund,  mit  Gesellschaftssitz  in  19,  rue  de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, deren Registrierung im luxemburgischen Handels-und Gesellschaftsregister noch ausste-
hend ist,

hier vertreten durch Frau Carole Noblet Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlichen Vollmachten,

ausgestellt in Luxemburg, am 20. Januar 2012.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  „Gesell-
schaft“) gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in-und ausländischen Gesellschaften und

die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-

leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Rhombus Bidco S.à r.l.“.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), aufgeteilt in siebenhundert-

fünfzig (750) Anteile mit einem Nennwert von je zwanzig Britische Pfund (GBP 20,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei

Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-

lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

C. Geschäftsführung

Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

32300

L

U X E M B O U R G

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei

Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei

Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-

lungen finden am Gesellschaftssitz statt.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

32301

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.

Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine

natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der gesellschaftsanteile

Die siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile wurden von Rhombus Holdco S.à r.l. vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2012.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

EUR 1.200,-geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels-und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäfts-
führer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C. NOBLET - H. HELLINCKX.

32302

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3747. Reçu soixante-quinze euros 75,00

EUR

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehren erteilt.
Luxemburg, den siebenundzwanzigsten Januar zweitausendundzwölf.
Référence de publication: 2012014218/322.
(120016947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Esaress Holding Limited - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 110.909.

<i>Extrait des résolutions prises par la Société en date du 26 janvier 2012

Il a été décidé de nommer Monsieur Bertrand de FAYS, né le 12 juillet 1981, à Bruxelles, Belgique, demeurant à B-6700

Arlon, 49, rue du Gazomètre, gérant de la Succursale avec effet au 1 

er

 février, 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012017213/11.
(120021436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

EuroAccess, Société Anonyme.

Siège social: L-5864 Fentange, 8A, rue Armand Rausch.

R.C.S. Luxembourg B 93.431.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue au siège social en date du 29 décembre

<i>2011.

L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a cessé d’exister à partir de ce jour.
L’Assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans

à l’ancien siège de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Pour extrait conforme
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2012017215/17.
(120021491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

Enez Vaz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 94.102.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ENEZ VAZ S.A. qui s'est tenue à

<i>Luxembourg, en date du 17 janvier 2012 à 10 heures.

L'assemblée décide:
L'assemblée accepte la nomination au poste d'administrateur Mr Olivier GRESSE, demeurant au 05, rue du Château

F-94000 Créteil jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017

La résolution ayant été adopté à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 17 janvier 2012.

<i>Pour la société
Mr François Legendre
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2012017219/17.
(120020810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

32303

L

U X E M B O U R G

Elektro Bernd Elsen, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6477 Echternach, 37, rue des Remparts.

R.C.S. Luxembourg B 98.889.

Laut Gesellschafterbeschluss wird der Sitz der Firma von 37, rue des Remparts , 6477 Echternach verlegt

Echternach, den 2.2.2012.

Référence de publication: 2012017217/9.
(120020950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

Energy Ventures Investments SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 158.004.

Le Siège social de la société a été transféré avec effet immédiat, à l'adresse suivante:
65, Rue des Romains
L-8041 Strassen

Strassen, le 2 janvier 2012.

ENERGY VENTURES INVESTMENTS SA
Signature

Référence de publication: 2012017218/13.
(120020869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

Ercy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 115.522.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le 12 janvier 2012

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de nommer Monsieur Robert CUYPERS en tant que Président du Conseil d'Administration.

Pour copie certifiée conforme
Signatures
<i>Président / Administrateur

Référence de publication: 2012017224/13.
(120021137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

Whitehall Street International Real Estate SCA 2008, Société en Commandite par Actions.

Capital social: USD 53.938,10.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 137.241.

Constituée par devant Me Jean Seckler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 Avril 2008, acte publié au

Mémorial C no 951

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Whitehall Street International Real Estate SCA 2008
Représenté par Whitehall Street International Real Estate 2008 S.à.r.l.
Représenté par Nicole Götz / Maxime Nino
<i>Gérant

Référence de publication: 2012020758/15.
(120026021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

32304


Document Outline

AIMCo RE Subs (Luxembourg) II S.à r.l.

Cambaceres France Holdings AREII (Luxembourg) S.à r.l.

Compass Invest International S.A.

Cornwell S.A.

Cosmopar S.A.

Cross Valorem

CVM SPF S.A.

Dandelon Development Company SA

Deloitte Audit

Doks S.A.

Doosan Heavy Industries European Holdings S.à r.l.

Ecolab LUX 6 S.à r.l.

Eden Lux Holding S.à r.l.

Elektro Bernd Elsen

Energy Ventures Investments SA

Enez Vaz S.A.

Entre-Nous Création S.à r.l.

Ercy S.A.

Esaress Holding Limited - Luxembourg Branch

EuroAccess

Exeter Business Centre Holdings S.à r.l.

Fedelia S.à r.l.

Foggy Bay S.A.

Gasfin Investment S.A.

Gazprombank Mortgage Funding 3 S.A.

GSO Capital Opportunities Fund II (Luxembourg) S.à r.l.

Island Group Holdings S.à r.l.

Item Development S.A.

John Deere Holding S.à r.l.

KeyDrive S.A.

LBREP III CBC S.à r.l.

L&amp;V Investments S.à r.l.

MP Kings Retail S.à r.l.

Odin 1 S.A.

Onex RSI Holdings Limited

PACCOR Group Holdings S.à r.l.

PACCOR Pannunity Acquisition S.à r.l.

Pannunity Acquisition S.à r.l.

Persson &amp; Co. S.à r.l.

Polykonzept S.à r.l.

POLYKONZEPT société civile

Rhombus Bidco S. à r.l.

Rinoraines S.A.

Stigma Funds (LUX)

St-Lux S.à r.l.

Whitehall Street International Real Estate SCA 2008

Yoga For You A.s.b.l. Luxembourg