logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 571

5 mars 2012

SOMMAIRE

Aleris Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

27402

Alter Domus Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

27372

Atlantas Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27364

Axa World Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27374

Bake Holdco 1 SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27362

Dalgarno S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27368

d'Amico International Shipping S.A.  . . . . .

27362

Delvino S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27384

Digital Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27365

Financière Joseph II SPF S.A. . . . . . . . . . . . .

27364

GE Financing (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . .

27389

GE Holdings Forint Luxembourg Sàrl  . . . .

27393

GE UK FINANCING (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27394

Hortense S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27365

ICG EFV Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

27406

INNCONA S.àr.l. & Cie. Cent quatre-

vingt-seizième (196.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . .

27401

Island Lux S.à r.l. & Partners S.C.A. . . . . . .

27396

Le Monterey S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27382

Motor Development International S.A.  . .

27366

MUGC/WA U.S. Credit BBB/BB Fund  . . .

27380

Nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27382

Noctron Soparfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27400

OI-Games 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27401

Oil Ressources S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27400

Omega Finances Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27395

Orkany S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27400

Palladium S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27399

Partners Group (Luxembourg) S.à r.l.  . . .

27387

Philos Asset Management . . . . . . . . . . . . . . .

27396

Philos Currency Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27396

Prahy Invest G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27393

Prahy Invest G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27395

Prahy Invest G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27395

Prahy Invest G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27395

Premier Tax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27393

Primus Equity Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

27394

Primus Equity Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

27395

Tuomi IT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27382

Tuomi IT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27380

Tuomi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27382

Tuomi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27380

Value Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27367

Victoria Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

27366

Victoria Real Properties S.C.  . . . . . . . . . . . .

27366

Weatherford Holding (Luxembourg) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27390

Zuma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27408

27361

L

U X E M B O U R G

Bake Holdco 1 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.021.

Messieurs les actionnaires sont priés de prendre note des modifications suivantes:

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 16 mars 2012 est reporté au <i>23 mars 2012 à 11.00 heures au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (OPF Partners

office), sans autre modification de l'ordre du jour tel qu'annoncé précédemment.

<i>Agenda:

1. Update on the situation of the former group Bake Holdco following to the enforcement that took place on 5 

th

January 2012 at the level of Bake Holdco 4,

2. Cash-Flow situation,
3. Necessity to raise credit or to file a petition for bankruptcy,
4. Acknowledgment of the obligation for the board of directors to file a petition of bankruptcy (compulsory obligation

of the commercial code if the two following cumulative conditions are met:
a) Inability to raise credit,
b) Inability to pay due debts.

Référence de publication: 2012026623/581/19.

d'Amico International Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 124.790.

<i>Convening notice of the Annual general meeting of shareholder to the holders of shares with Common Code 029069751 and ISIN

<i>Code LU0290697514

The ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company (hereinafter, the "Meeting") will be held at the registered address of the Company,

25C boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>4 April 2012 , at 11.00 a.m., to discuss and
resolve on the following:

<i>Agenda:

I. Consideration of the reports of the Company's Board of Directors and auditors ("réviseur d'entreprise agrées")

on the consolidated and statutory annual accounts of the Company as at 31 December 2011;

II. Consideration and approval of the consolidated annual accounts of the Company as at 31 December 2011 and of

the Company's statutory annual accounts as at 31 December 2011;

III. Approval of the allocation of results of the 2011 financial year;

IV. Discharge of the members of the Board of Directors for the year ended on 31 December 2011;

V. Consideration and approval of the amended shareholder's meeting regulation (the "Shareholder's Meetings Re-

gulation");

VI. Approval of Directors fees (tantièmes);

VII. Consideration on the Report of the Board of Director's on Remuneration (I section) and on the 2012 General

Remuneration Policy;

The Meeting shall validly deliberate regardless the percentage of the Company's corporate capital being represented.

Resolutions shall be adopted by a simple majority of the votes cast by the shareholders present or represented at the
Meeting.

Shareholders must notify the Company on the day of the Record Date (as defined hereafter) of their intention to

participate in the Meeting by sending a certificate (the "Certificate") indicating, inter alia, (i) the name and/or corporate
name and the registered address and/or domicile of the shareholder, (ii) a confirmation of participation in the Meeting
and (iii) a confirmation of the number of shares held by the shareholder after closing of the markets at the Record Date
(the "Shareholder's Details"). For shareholders holding their shares through an Intermediary, the Certificate being pre-
pared by the Intermediary with which the shares are held shall be sent to BNP Paribas Securities Services, Luxembourg
branch in its capacity as the duly mandated agent of the Company ("BNP Paribas") with copy to the Company exclusively
throughout Euroclear and Clearstream banking system. In that respect, Intermediaries are further requested to compul-
sory instruct Euroclear and Clearstream to further confirm to BNP Paribas all Shareholder's Details.

The rights of a shareholder to attend and speak at the general meeting and to vote in respect of his shares shall be

determined with respect to the shares held by the shareholder on 21 March 2012 at 24:00 hours Luxembourg time (the

27362

L

U X E M B O U R G

"Record Date"). Only those who are shareholders on that Record Date shall have the right to participate and vote at the
general meeting.

Shareholders present or represented are requested to bring a copy of the Certificate to the Meeting in order to

present it to the board of the Meeting.

Shareholders need not to be present at the Meeting in person. In accordance with the Company's Articles of Asso-

ciation, a shareholder at the Record Date may act at the Meeting by appointing another person who needs not to be a
shareholder himself subject to the production of the original of the executed proxy to the Meeting in order to present
it to the board of the Meeting. The proxy holder shall enjoy the same rights to speak and ask questions in the general
meeting as those to which the shareholder thus represented would be entitled. Each shareholder shall only be represented
by one proxy holder for a given general meeting of shareholders except that:

(i) if a shareholder has shares of the Company held in more than one securities account, he may appoint one proxy

holder per securities account for a given general meeting of shareholders;

(ii) a shareholder acting professionally for the account of other natural or legal persons may appoint each of these

natural or legal persons or third parties appointed by them.

A person acting as a proxy holder may hold a proxy from more than one shareholder without limitation as to the

number of shareholders so represented. Where a proxy holder holds proxies from several shareholders, it may cast
votes for a certain shareholder differently from votes cast for another shareholder.

Shareholders shall appoint a proxy holder in writing. Such appointment shall be notified by the shareholders to the

Company in writing by postal services or electronic means at the address of the Company indicated below by no later
than 5:00 p.m. Luxembourg time on 30 March 2012.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners

of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of shareholders.

Alternatively, in accordance with the Company's Articles of Association, a shareholder may cast his vote by a ballot

paper ("formulaire") expressed in the English language. Any ballot paper ("formulaire") shall be delivered by hand with
acknowledgment of receipt, by registered post, by special courier service using an internationally recognised courier
company, by email or by fax to BNP Paribas with copy to the Company no later than 5:00 p.m. Luxembourg time 30
March 2012.

Any ballot paper ("formulaire") which does not bear the mentions or indications required by the Company's articles

of Association is to be considered void and shall be disregarded for quorum purposes. In case a proposed resolution is
amended by the general meeting of shareholders, the votes expressed on such proposed resolution pursuant to the ballot
papers ("formulaires") received shall be void.

Shareholders who are not personally registered in the Company's share register may also vote by proxy or by ballot

paper.

To such effect, they must instruct the commercial bank, broker, dealer, custodian, trust company, accountholder,

professional securities depositary, financial institution or other qualified intermediary through which they hold their shares
(hereinafter, the "Intermediary") who handles the management of the Company's shares by using the proxy form or the
ballot paper form ("formulaires").

Intermediaries shall ensure that the signed and dated proxy forms with vote instructions be deposited in writing by

postal services or electronic means at the address of BNP Paribas with copy to the Company by no later than 5:00 p.m.
Luxembourg time on 30 March 2012. Beneficial owners of shares held through an Intermediary are urged to confirm the
deadline for receipt of their proxy forms with vote instructions to such Intermediary to ensure onward their delivery to
BNP Paribas by the relevant deadline.

Shareholders acknowledge that by sending their proxy forms with their voting instructions or their ballot paper form

("formulaires") they will be deemed to consent to having the relevant Intermediary, including but not limited to Euroclear
and Clearstream, provide all details concerning their identity to BNP Paribas and to the Company.

Relevant proxy forms and/or ballot papers forms ("formulaires") may be obtained, free of charge, at the registered

office of the Company, on the Company's website www.damicointernationalshipping.com (hereinafter, the "Website")
or at BNP Paribas.

In full compliance with the laws and regulations in force and applicable to the Company, the required supporting

documentation, the convening notice, the total number of shares and voting rights, the draft resolutions and the proxy
and ballot papers forms ("formulaires") are deposited and available to the public at the Company's registered office, at
Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), at Société de la Bourse de Luxembourg S.A. in its quality of O.A.M. and at
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) being also posted on the Website.

Shareholders may upon request obtain a copy of the full, unabridged text of the documents to be submitted to the

general meeting of shareholders and draft resolutions proposed to be adopted by the general meeting by electronic means
at the address of the Company indicated below or by postal services at the registered office of the Company.

In accordance with the Company's Articles of Association, shareholders holding individually or collectively at least five

(5) % of the share capital of the Company: (a) have the right to put items on the agenda of the general meeting; and (b)

27363

L

U X E M B O U R G

have the right to table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of a general meeting. Those
rights shall be exercised upon requests of the shareholders in writing submitted to the Company by postal services or
electronic means at the addresses of the Company indicated below. The requests shall be accompanied by a justification
or a draft resolution to be adopted in the general meeting and shall include the electronic or mailing address at which
the Company can acknowledge receipt of these requests. The requests from the shareholders shall be received by the
Company at the latest on 13 March 2012.

In accordance with the Company's Articles of Association, shareholders shall have the right to ask questions at the

general meeting related to items on the agenda of the general meeting. The Company shall answer the questions put to
it by shareholders. The right to ask questions and the obligation of the Company to answer are subject to the measures
to be taken by the Company to ensure the identification of shareholders, the good order of general meetings and their
preparation as well as the protection of confidentiality and business interests of the Company.

The contact details of the Company are as follows:
Company
d'Amico International Shipping S.A.
25 C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: + 352 26 26 24 54, Email: ir@damicointernationalshipping.com
Attention: Mr. Marco FIORI, C.E.O. / Mrs. Anna FRANCHIN, Investor Relations Manager

The details of the centralising bank mandated by the Company are as follows:
BNP Paribas Securities Services Branch Luxembourg
Corporate Trust Services
33 rue de Gasperich - Howald - Hesperange, L - 2085 Luxembourg
Tel:+ 352 2696 2518/2407 Fax: + 352 2696 9757, Email: lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com
Attention: Lux ost domiciliees, Sabrina Deversenne / Rudolf VOIGTLANDER

Luxembourg, 5 March 2012.

<i>The Board of Directors .

Référence de publication: 2012027865/267/121.

Financière Joseph II SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 44.785.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>23 mars 2012 à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

<i>Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012027866/660/15.

Atlantas Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 33.188.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg le <i>22 mars 2012 à 14h30, avec l'Ordre du Jour suivant :

<i>ORDRE DU JOUR

1. Compte rendu d'activité du conseil d'administration pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011.
2. Rapport du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011.
3. Adoption des comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2011.
4. Accumulation du résultat de l'exercice se terminant le 31 décembre 2011 de tous les compartiments de la Société.

27364

L

U X E M B O U R G

5. Décharge aux administrateurs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011.
6. Renouvellement du mandat des administrateurs sortants.
7. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé.
8. Divers.

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour cette assemblée et que les décisions seront prises

à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

Chaque action a un droit de vote.
Tout actionnaire peut voter par mandataire. A cette fin, des procurations sont disponibles au siège social de la Société

et seront envoyées aux actionnaires sur demande.

Afin d'être valables, les procurations dûment signées par les actionnaires devront être envoyées au siège social de la

Société afin d'être reçues le jour précédant l'assemblée à 17 heures au plus tard.

Les propriétaires d'actions au porteur, désirant participer à cette assemblée, devront déposer leurs actions cinq jours

ouvrables avant l'assemblée au siège social de la Société.

Les actionnaires désireux d'obtenir le rapport annuel révisé au 31 décembre 2011 peuvent s'adresser au siège social

de la Société ou télécharger ledit rapport à l'état de projet sur le site www.groupedr.eu.

<i>Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012027876/755/30.

Hortense S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 54.641.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>16 mars 2012 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du

jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver

les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2009.

- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle

du Commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2009.

- Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2009 et du compte de profits et pertes y relatif; affectation du résultat.
- Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31

décembre 2009.

- Démission de deux administrateurs, décharge aux administrateurs et nomination de leurs remplaçants.
- Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012023304/45/21.

Digital Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 66.323.

The shareholders of DIGITAL FUNDS are invited to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the company that will take place at its registered office on <i>14 March 2012 at 11.00 a.m. with the following

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the annual accounts as of 30 September 2011
3. Decision on the allocation of the results
4. Discharge to be given to the members of the Board of Directors and to the Auditor
5. Statutory elections
6. Auditor's mandate
7. Miscellaneous
The latest version of the Annual Report is available free of charge during normal office hours at the registered office

of the Company in Luxembourg.

27365

L

U X E M B O U R G

In order to participate in the Annual General Meeting, the shareholders need to deposit their shares at the latest at

16.00 (Luxembourg time) five days prior to the Annual General Meeting with the Custodian Bank, UBS (Luxembourg)
S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg or at any other appointed paying agent. The majority at the annual
general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) five
days prior to the Annual General Meeting (referred to as "record date"). There will be no requirement as to the quorum
in order for the Annual General Meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions
will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the Annual General Meeting,
each share entitles to one vote. The rights of the shareholders to attend the Annual General Meeting and to exercise the
voting right attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the record date.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented by the chairman of the Annual General Meeting,

please return a proxy, dated and signed by fax and/or mail at the latest five days prior to the Annual General Meeting
(the "record date") to the attention of the Company Secretary at UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, fax number +352 441010 6249. Proxy forms may be obtained by simple request
at the same address.

The proxy form will only be valid if it includes the shareholder's and his/her/its legal representative's first name, surname

and number of shares held at the record date and official address and signature as well as voting instructions. Incomplete
or erroneous proxy forms or proxy forms, which do not comply with the formalities described therein, will not be taken
into account.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2012024675/755/38.

Motor Development International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 38.747.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 mars 2012 à 10.00 heures au siège de la société à Luxembourg, L-1212, 17, rue des Bains.

<i>Ordre du jour:

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l'exercice 2010.
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l'exercice 2011.
- Approbation des comptes annuels 2010 et 2011.
- Affectation des résultats.
- Décharge aux organes sociaux.
- Elections statutaires.
- Divers.

Luxembourg, le 13 février 2012.

<i>Pour le Conseil d'Administration .

Référence de publication: 2012020243/535/18.

Victoria Real Properties S.C., Société Civile.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg E 4.621.

Victoria Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 33, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 148.789.

L'an deux mille onze, le vingt-neuf décembre.
Par devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Francesca Costantini, avocate, demeurant à L-7463 Pettingen 12, rue du Château, prise en sa qualité de gérante

de Victoria Real Properties S.C., une société civile ayant son siège social 45, boulevard Grande Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro E 4621 (ci-après désignée la «Société Absorbante»), constituée sous seing privé le 22 novembre
2011, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 2908 du 29 novembre
2011, en vertu des pouvoirs à elle conférés par la Société Absorbante.

Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter les déclarations et cons-

tatations suivantes:

27366

L

U X E M B O U R G

- qu'aux termes d'un projet commun de fusion établi sous forme notariée, suivant acte du notaire soussigné en date

du 24 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 2908 du 29 novembre 2011 le
«Projet Commun de Fusion»), la Société comme société absorbante (la «Société Absorbante») et Victoria Real Estate
S.A., une société anonyme ayant son siège social au 33, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand Duché du Luxem-
bourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.789 (ci-après
désignée la «Société Absorbée» et collectivement les «Sociétés Fusionnantes»), constituée suivant acte de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg du 19 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations No 2203 du 11 novembre 2009, dont les statuts n'ont pas été modifiés, ont projeté de fusionner;

- qu'aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication du

Projet Commun de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d'une assemblée générale
extraordinaire de la Société Absorbante, afin de décider de l'approbation de la fusion;

- que la fusion est devenue définitive et a entraîné de plein droit la transmission universelle, entre les Sociétés Fusion-

nantes, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante à la date du présent
constat, c'est-à-dire le 29 décembre 2011, soit un mois calendaire après la publication du Projet Commun de Fusion au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

- que suite à la fusion intervenue, la Société Absorbée a cessé d'exister;
- que suite encore à l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, les actions de la Société Absorbée

sont annulées et les livres et documents de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal de cinq (5) ans
au siège de la Société Absorbante: 45, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché du
Luxembourg;

- qu'au jour de la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la fusion deviendra

définitive à l'égard des tiers;

- qu'en sa qualité de gérante unique de la Société Absorbante et en application de l'article 10 des statuts de la Société

Absorbante publiés au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations No 2908 du 29 novembre 2011 et des
décisions prises par l'assemblée des associés de la Société Absorbante également publiées au Mémorial Recueil Spécial
des Sociétés et Associations No 2908 du 29 novembre 2011, Madame Francesca Costantini dispose de tous pouvoirs
pour le dépôt du Projet Commun de Fusion du 24 novembre 2011 et du présent Constat de Fusion auprès d'un notaire
italien et plus spécialement des pouvoirs les plus étendus aux fins de la publicité dans tout registre public immobilier en
Italie ainsi que pour tout autre acte nécessaire aux fins de finaliser l'opération de fusion de la Société Absorbante avec la
société Absorbée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à 850,-EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire soussigné par son nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé:, F. COSTANTINI, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2012. Relation: LAC/2012/648. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 18 janvier 2012.

Référence de publication: 2012011375/62.
(120012954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Value Invest, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion coordonné au 1 

er

 février 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2012.

IPConcept Fund Management S.A.

Référence de publication: 2012012359/10.
(120014478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.

27367

L

U X E M B O U R G

Dalgarno S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 110.879.

In the year two thousand and twelve, on the tenth of February,
before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,

is held:

an extraordinary general meeting of shareholders of DALGARNO S.A. (the “Company”), a société anonyme having

its registered office in L-1746 Luxembourg 1, rue Joseph Hackin, recorded with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 110.879, incorporated pursuant to a notarial deed dated 15 September 2005, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 108 of 17 January 2006.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated

27 January 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened at 11.10 a.m. with Mrs Françoise Rollin, private employee, L-1746 Luxembourg 1, rue Joseph

Hackin, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Anne-Lies Van Den Eeckhaut, private employee, L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph

Hackin.

The meeting elects as scrutineer Mr François Mayet, private employee, L1746 Luxembourg 1, rue Joseph Hackin.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of EUR 50,000 (fifty thousand euro) so as to bring

it from its present amount of EUR 331,000 (three hundred thirty-one thousand euro), represented by 33,100 (thirty-
three thousand one hundred) shares with a nominal value of EUR 10 (ten euro) each, up to the amount of EUR 381,000
(three hundred eighty-one thousand euro) through the issue of 5,000 (five thousand) new shares with a nominal value of
EUR 10 (ten euro) each, each having the same rights and obligations than the existing shares.

Subscription and full payment of 5.000 new shares by payment in cash by BGL BNP PARIBAS with head office in L-2951

Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy and registered at RCS Luxembourg under the number B 6.481.

2. Amendment of the 1 

st

 paragraph of article 5 of the articles of incorporation in order to reflect the planned corporate

capital increase.

3. Amendment of the 1 

st

 sentence of the 1 

st

 paragraph of article 7 in order to create Class A and Class B directors

and of the 12 

th

 paragraph of article 8 and the 3 

rd

 paragraph of article 11 of the articles of incorporation in order to give

them the following wording:

Art. 7. 1 

st

 sentence &amp; paragraph.  “The Company shall be managed by the Board of Directors of at least three (3)

members divided into one or more A directors and one or more B directors, either shareholder or not, who are appointed
for a term which may not exceed six (6) years, by a General Meeting.”

Art. 8. 12 

th

 paragraph.  “The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its

members are present or represented including at least one Class A and one Class B director”.

Art. 11. 3 

rd

 paragraph.  “The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of one A director

and one B director in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.”.

4. Resignation of Mrs Liliane Poitiers and Mr Nicholas Ogden as directors of the Company. Discharge to be granted.
5. Appointment of Class A and Class B Directors.
II.- That the present or represented sole shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number

of its shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxy of the represented shareholder will also remain annexed to the present deed after having been initialled

ne varietur by the persons appearing.

III.- That the whole share capital being represented at the present meeting, no convening notices were necessary, the

shareholder represented declaring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

The general meeting then takes the following resolutions:

27368

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution:

The general meeting resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 50,000 (fifty

thousand euro) so as to bring it from its present amount of EUR 331,000 (three hundred thirty-one thousand euro),
represented by 33,100 (thirty-three thousand one hundred) shares with a nominal value of EUR 10 (ten euro) each, up
to the amount of EUR 381,000 (three hundred eighty-one thousand euro) through the issue of 5,000 (five thousand) new
shares with a nominal value of EUR 10 (ten euro) each, having the same rights and obligations than the existing shares.

<i>Subscription and Payment

The sole shareholder BGL BNP PARIBAS, a société anonyme with registered office in L-2951 Luxembourg, 50, avenue

J.F. Kennedy and recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 6.481,

here represented by Mr François Mayet, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxemburg, on 8 February 2012, which will remain attached hereto,
declares to subscribe all the 5,000 (five thousand) new shares and to fully pay them up in cash for a total amount of

EUR 50,000 (fifty thousand euro), so that the said amount is as of now available to the Company, as it has been proved
to the undersigned notary.

<i>Second resolution:

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting resolves to amend the 1 

st

 paragraph of article 5

of the articles of incorporation so as to give it henceforth the following wording:

“The corporate capital is set at three hundred eighty-one thousand euro (EUR 381,000) represented by thirty-eight

thousand one hundred (38,100) shares with a nominal value of ten euro (EUR 10) each.”

<i>Third resolution:

The general meeting resolves to amend the 1 

st

 sentence of the 1 

st

 paragraph of article 7 in order to create Class A

and Class B directors and the 12 

th

 paragraph of article 8 as well as the 3 

rd

 paragraph of article 11 of the articles of

incorporation in order to give them henceforth the following wording:

Art. 7. 1 

st

 sentence &amp; Paragraph.  “The Company shall be managed by the Board of Directors of at least three (3)

members divided into one or more A directors and one or more B directors, either shareholder or not, who are appointed
for a term which may not exceed six (6) years, by a General Meeting.”

Art. 8. 12 

th

 paragraph.  “The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its

members are present or represented including at least one Class A and one Class B director”.

Art. 11. 3 

rd

 paragraph.  “The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of one A director

and one B director in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.”.

<i>Fourth resolution:

The general meeting resolves to accept the resignation of Mrs Liliane Poitiers and Mr Nicholas Ogden as directors of

the Company.

The general meeting decides to grant full discharge to the said directors for the execution of their mandate up to this

date.

<i>Fifth resolution:

The general meeting resolves to appoint the following persons as class A and class B directors of the Company:

<i>Class A directors:

- Mr Pascal HOBLER, born on March 24, 1968, in Metz, France, having his professional address at 50, avenue JF Kennedy,

L-2951 Luxembourg,

- Mr Patrick SABIA, born on March 6, 1975, in Montegnee, Belgium, having his professional address at 50, avenue JF

Kennedy, L-2951 Luxembourg,

- Mr Christophe BRECHIGNAC, born on December 28, 1973, in Paris, France, having his professional address at 50,

avenue JF Kennedy, L-2951 Luxembourg.

<i>Class B directors:

- Mr Yvan JUCHEM, born on December 8, 1960, in Luxembourg, having his professional address at 50, avenue JF

Kennedy, L-2951 Luxembourg,

- Mr Simon CRITCHLOW, born on September 29, 1955, in Carshalton, United Kingdom, having his professional

address at 50, avenue JF Kennedy, L2951 Luxembourg.

Their mandate will expire with the annual general meeting called to approve the accounts as at 31 December 2017.

27369

L

U X E M B O U R G

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at two thousand euro (EUR 2,000).

Whereupon, the present deed is drawn up in Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, at the date named at the beginning

of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing persons,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le dix février,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DALGARNO S.A. (la „Société“), ayant son

siège social à L-1746 Luxembourg 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 110.879 constituée suivant acte notarié en date du 15 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 108 du 17 janvier 2006.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 27 janvier 2012, en cours de publication

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte à 11.10 heures sous la présidence de Madame Françoise Rollin, employée privée, L-1746

Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne-Lies Van Den Eeckhaut, employée privée, L-1746 Luxembourg, 1, rue

Joseph Hackin.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Mayet, employé privé, L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph

Hackin.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 50.000 (cinquante mille euros) pour le porter

de son montant actuel de EUR 331.000 (trois cent trente et un mille euros) représenté par 33.100 (trente-trois mille
cent) actions à EUR 381.000 (trois cent quatre-vingt-un mille euros) par l'émission de 5.000 (cinq mille) actions nouvelles
d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription et libération intégrale des 5.000 actions nouvelles par paiement en espèces par BGL BNP PARIBAS avec

siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy et inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 6.481.

2. Modification du 1 

er

 alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social.

3. Modification de la 1 

ère

 phrase du 1 

er

 alinéa de l'article 7 afin de créer des administrateur de catégories A et B,

ainsi que du 12 alinéa de l'article 8 et le 3e alinéa de l'article 11 des statuts de la Société pour leurs donner la teneur
suivante:

Art. 7. 1 

ère

 phrase du 1 

er

 alinéa.  “La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3)

membres au moins divisés en un ou plusieurs administrateurs de classe A et un ou plusieurs administrateurs de classe B,
actionnaires ou non, élus par l'Assemblée Générale pour un terme ne pouvant dépasser six (6) ans.”

Art. 8. 12 

e

 alinéa.  “Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement et statuer que si la majorité de ses

membres et présente ou représentée incluant au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B.”

Art. 11. 3 

e

 alinéa.  “La Société sera engagée en toutes circonstances vis à vis des tiers par la signature conjointe d'un

administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B ou par la signature conjointe ou l'unique signature de toute
(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs auront été confiés par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites
de ces pouvoirs.”.

4. Démission de Madame Liliane Poitiers et de Monsieur Nicholas Ogden comme administrateurs de la Société. Dé-

charge à accorder.

5. Nomination d'administrateurs de classes A et B.
II.- Que l'actionnaire unique présent ou représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre

d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le

27370

L

U X E M B O U R G

mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, l'actionnaire représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 50.000 (cinquante mille

euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 331.000 (trois cent trente et un mille euros) représenté par 33.100
(trente-trois mille cent) actions à EUR 381.000 (trois cent quatre-vingt-un mille euros) par l'émission de 5.000 (cinq mille)
actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

<i>Souscription et Libération

L'actionnaire unique BGL BNP PARIBAS, une société anonyme avec siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F.

Kennedy et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6.481,

ici représentée par Monsieur François Mayet, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 février 2012,
déclare souscrire les 5.000 (cinq mille) actions nouvelles et les libérer intégralement en espèces pour un montant total

de EUR 50.000 (cinquante mille euros) de sorte que ledit montant est dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire soussigné

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le 1 

er

 alinéa de l'article 5 des

statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-un mille euros (EUR 381.000) représenté par trois-huit mille cent

(38.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.»

<i>Troisième résolution:

6. L'assemblée générale décide de modifier la 1 

ère

 phrase du 1 

er

 alinéa de l'article 7 afin de créer des administrateurs

de catégories A et B, ainsi que le 12e alinéa de l'article 8 et le 3e alinéa de l'article 11 des statuts de la Société pour leurs
donner désormais la teneur suivante:

Art. 7. 1 

ère

 phrase du 1 

er

 alinéa.  “La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3)

membres au moins divisés en un ou plusieurs administrateurs de classe A et un ou plusieurs administrateurs de classe B,
actionnaires ou non, élus par l'Assemblée Générale pour un terme ne pouvant dépasser six (6) ans.”

Art. 8. 12 

e

 alinéa.  “Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement et statuer que si la majorité de ses

membres et présente ou représentée incluant au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B.”

Art. 11. 3 

e

 alinéa.  “La Société sera engagée en toutes circonstances vis à vis des tiers par la signature conjointe d'un

administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B ou par la signature conjointe ou l'unique signature de toute
(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs auront été confiés par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites
de ces pouvoirs.”

<i>Quatrième résolution:

L'assemblée  générale  décide  d'accepter  la  démission  de  Madame  Liliane  Poitiers  et  de  Monsieur  Nicholas  Ogden

comme administrateurs de la Société.

Pleine et entière décharge leur est accordée pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Cinquième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer comme administrateurs des classes A et B les personnes suivantes:

<i>Administrateur de classe A:

- Monsieur Pascal HOBLER, né le 24 mars 1968 à Metz, France, avec adresse professionnelle au 50, avenue JF Kennedy

à L-2951 Luxembourg,

27371

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Patrick SABIA, né le 6 mars 1975 à Montegnee, Belgium, avec adresse professionnelle au 50, avenue JF

Kennedy à L-2951 Luxembourg,

<i>Administrateur de classe B:

- Monsieur Yvan JUCHEM, né le 8 décembre 1960 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 50, avenue JF

Kennedy à L-2951 Luxembourg,

- Monsieur Simon CRITCHLOW, né le 29 septembre 1955 à Carshalton, Royaume Uni, avec adresse professionnelle

au 50, avenue JF Kennedy à L-2951 Luxembourg.

- Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes clôturés au 31 décembre

2017.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont approximativement estimés à la somme de deux mille euros
(EUR 2.000).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. ROLLIN, A.-L. VAN DEN EECKHAUT, F. MAYET et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 février 2012. LAC / 2012 / 7092. Reçu soixante quinze euros € 75,

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 21 février 2012.

Référence de publication: 2012025311/234.
(120033002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.

Alter Domus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.752.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.477.

In the year two thousand and twelve, on the sixteenth of February.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, acting as the representative of the

board of managers (the “Board of Managers”) of Alter Domus Holding S.à r.l. (the "Absorbing Company"), a société à
responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg trade
register B 136.477 and having a share capital of Euro 31,752,500 incorporated pursuant a deed on February 11, 2008,
published in Memorial C, under number 710 on March 21, 2008.

Pursuant to a resolution taken at the meeting of the Board of Managers held in Luxembourg on December 27, 2011

(the “Minutes of the Meeting of the Board of Managers”),

A copy of the Minutes of the Meeting of the Board of Managers, initialled ne varietur by the proxyholder of the

Absorbing Company and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities,

Such appearing party, acting ès dites qualités, has required the undersigned notary to record the following:
1. The Absorbing Company holds one hundred per cent (100%) of the shares of Alter Domus S.à r.l. (the "Absorbed

Company", and together with the Absorbing Company referred to as the "Merging Companies"), a société à responsabilité
limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg trade register B
65.509 and having a share capital of EUR 375,000, incorporated pursuant a deed of the notary incorporated on July 17,
1998, published in Mémorial C number 727 on October 8, 1998.

2. The boards of managers of each of the Merging Companies have adopted the Merger Proposal on December 27,

2011, which has been notarized pursuant to a deed of the undersigned notary on December 28, 2011 and published,

27372

L

U X E M B O U R G

pursuant to article 262 of the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended (the “Law"), in the

Mémorial n° 121 of January 16, 2012.

3. The documents, provided for by article 267, paragraph 1, a) and b) of the Law, have been at the disposal of the

shareholders of the Merging Companies at their registered office one month prior to the date of this meeting.

4. No objections to the merger have been received between the date of publication of the merger project and the

date of this meeting.

5. The merger takes effect from today's date with accounting effect on January 1 

st

 , 2011.

6. The Absorbed Company is merged by contribution of all its assets and liabilities to the Absorbing Company without

any restriction or limitation.

7. As a result of the merger, the Absorbed Company ceased to exist by dissolution without liquidation and all its shares

are cancelled.

<i>Certificate of merger fulfilment

The undersigned notary certifies that:
- the Merger has been made in compliance with all laws and regulations applicable in the Grand Duchy of Luxembourg,
- all formalities, bailment or publications relating thereto have been lawfully and completely fulfilled,
- the Merger is final as from the date hereof by virtue of article 272 of the Law, and that it will be binding on third

parties as from the date of its publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in compliance with
article 273 (1) of the Law.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the Absorbing Company, who is known to the notary by their

Surname, Christian names, civil status and residences, the proxy holder signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le seize février.
Par-devant, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, agissant en qualité de man-

dataire au nom et pour compte du conseil de gérance (le “Conseil de Gérance”) de Alter Domus Holding S.à r.l., (la
«Société absorbante»), une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant sont siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, im-
matriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.477 ayant un capital social
de EUR 31 752 500, constituée suivant acte du 11 février 2008, publié au Mémorial sous le numéro 710 le 21 mars 2008.

En vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré lors de la réunion du Conseil de Gérance tenue le 27 décembre 2011 à

Luxembourg (le “Procès-Verbal du Conseil de Gérance”),

Ledit Procès-Verbal du Conseil de Gérance, signé ne varietur par le mandataire de la Société Absorbante et le notaire

instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,

Laquelle comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses décla-

rations et constations:

1. La Société Absorbante détient cent pour-cent (100%) des actions d'Alter Domus S.à r.l. (la «Société Absorbée» et

désignée collectivement avec la Société Absorbante comme les «Sociétés Fusionnantes»), une société anonyme, consti-
tuée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant sont siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 65.509 ayant un capital social de EUR 375.000, constituée suivant acte du 17 juillet 1998, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le “Mémorial”) sous le numéro 727 le 8 octobre 1998.

2. Les conseils de gérance respectifs de chacune des Sociétés Fusionnantes ont adopté le Projet de Fusion en date du

27 décembre 2011, lequel a été établi sous forme d'acte notarié par le notaire soussigné en date du 28 décembre 2011
et publié, conformément à l'article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
"Loi"), au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°121 du 16 janvier 2012.

3. Les documents requis par l'article 267, paragraphe 1, a) et b) de la Loi, ont été tenus à disposition des actionnaires

des Sociétés Fusionnantes à leur siège social durant un mois précédant la date de cette assemblée.

27373

L

U X E M B O U R G

4. Aucune objection à l'encontre de la fusion n'a été communiquée entre la date de publication du projet de fusion et

la date de ce jour.

5. La fusion prend effet à la date de ce jour avec effet comptable au 1 

er

 janvier 2011.

6. La Société Absorbée est absorbée avec apport de tous ses actifs et passifs par la Société Absorbante, sans aucune

restriction ni limitation.

7. Comme conséquence à la fusion, la Société Absorbée a cessé d'exister par dissolution sans liquidation et toutes ses

parts sont annulées.

<i>Certificat de réalisation définitive de la fusion

Le notaire instrumentant certifie que:
- la Fusion a été régulièrement réalisée en conformité des lois et des règlements en vigueur au Grand-Duché de

Luxembourg,

- que toutes les formalités, dépôts ou publications y relatives ont été régulièrement accomplies,
- la Fusion a acquis un caractère définitif à compter de ce jour en vertu de l'article 272 de la Loi, et qu'elle sera

régulièrement opposable aux/tiers à compter de la date de sa publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, conformément à l'article 273 (1) de la Loi.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture donnée au mandataire de la Société Absorbante, connu du notaire par ses prénoms, nom, état civil

et domicile, le mandataire a signé avec Nous, Notaire instrumentant, le présent procès-verbal.

Signé: A. BRAQUET, H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 février 2012. Relation: LAC/2012/7856. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 février 2012.

Référence de publication: 2012025204/111.
(120032993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.

Axa World Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 63.116.

In the year two thousand twelve, on the seventh day of February.
There  was  held  an  extraordinary  meeting  of  the  shareholders  of  AXA  World  Funds  (the  "Company"),  having  its

registered office in Luxembourg, initially incorporated on December 24, 1996 under the number B 63 116, and published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of January 27, 1997, number 32. The articles of incorporation of
the Company have been amended pursuant to several notarial deeds since its incorporation, and were last amended
pursuant to a notarial deed of Me Henri Hellinckx, public notary residing in Luxembourg, dated 25 March 2008 and
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 7 May 2008.

The meeting is opened at 2 p.m. at 15 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, under the chair of Mrs. Catherine Muller,

legal advisor, residing professionally in Luxembourg,

who appointed as secretary Mrs. Cécile Leroy, bank employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Candice Mayembo, bank employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
The Agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1) Amendment of the articles of incorporation of the Company (the “Articles”) in order to reflect the following

amendments and updates:

a) In accordance with the terminology used in the law of 5 April 1993 on the financial sector as amended, update all

references to a “registrar and transfer agent” by references to a “registrar agent” in the Articles;

b) Further to the entry into force of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the

“Law of 2010”), update of all references to the “Law of 2002” by references to the “Law of 2010” and as a consequence
thereof amend Article 3 as follows:

27374

L

U X E M B O U R G

“ Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in the transferable securities of all

types  and  all  other  liquid  financial  permitted  assets  with  the  purpose  of  spreading  investment  risks  and  affording  its
shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by the law of 17 

th

 December 2010 relating to undertakings

for collective investment or any legislative replacements or amendment thereof (the “Law of 2010”).”

c) Amendment of Article 4 in order to provide for the possibility for the board of directors of the Company (“the

“Board”) to transfer permanently the registered office of the Company within the same municipality, or from a municipality
to another municipality within the Grand Duchy of Luxembourg if, and to the extent permitted by Luxembourg law and
practice relating to commercial companies;

d) Amendment to Article 5 in order to (i) explicitly set out that the Board has the possibility to issue in relation to

any Sub-Fund classes of shares defined by reference to currency of denomination, type of investors, distribution channel
and underlying investment objectives (in addition to what is already set forth in the Articles) and (ii) provide for the
possibility for the Board to amend the rights attached to any class of shares of the Company so as to include them in any
other existing class of shares, in the event that the value of the assets of any class of shares within a sub-fund has decreased
to, or has not reached an amount determined by the Board to be the minimum level for such class to be operated in an
economically efficient manner or as a matter of rationalisation;

e) Amendment to Article 11 in compliance with the law of 10 August 1915 concerning commercial companies as

amended in order to provide that resolutions at meetings of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of the votes validly cast, regardless of the portions of capital represented, and that abstentions and nihil vote
shall not be taken into account;

f) Amendment to Article 13 as to specify that in the event an elected director of the Company is a legal entity, a

permanent individual representative thereof should be designated as member of the Board, as further detailed in the
Articles;

g) Further to the entry into force of the Law of 2010, amendment to Article 16 as to provide for the possibility for

the Company to resort to master-feeder structures, as well as to cross-holdings between sub-funds of the Company,
under the conditions detailed in the Articles and Prospectus / Hong Kong Offering Memorandum (the “Prospectus /
HKOM”);

h) Amendment to Article 18 as to clarify the conditions under which every director or officer of the Company and

his personal representatives shall be indemnified and secured harmless out of the assets of the relevant sub-fund(s) of
the Company against all losses incurred by him in the conduct of the Company business;

i) Amendment to Articles 20 and 21 as to (i) replace the reference to an “auditor” by a reference to an “authorised

auditor”, (ii) to provide that in the case of an in specie distribution further to a redemption request in the Company, the
auditor of the Company shall deliver an audit report only if applicable, and in accordance with applicable laws and (iii) to
provide that all redeemed shares within the Company may be cancelled;

j) Amendment to Article 22 as to provide that the Company may suspend temporarily the determination of the net

asset value in a relevant class of shares of the Company and the issue, redemption and conversion of the shares of said
class  following  the  suspension  of  the  calculation  of  the  net  asset  value  per  share/unit,  the  issue,  redemption  and/or
conversion of shares/units at the level of a master fund in which a sub-fund of the Company invests in its quality as feeder
fund of such master fund;

k) Amendment to Article 23 as (i) to update the cross-references within said Article, (ii) be in conformity with the

wording used in the Prospectus / HKOM and (iii) to modify the paragraph relating to the recourse to swing pricing
mechanisms within the Company;

l) Amendment to Article 24 as to provide that in case of contribution in kind to the Company, a report shall be prepared

by the authorized auditor of the Company only if applicable, and to refer to such report as a “valuation report”;

m) Amendment to Article 29 as to update the merger procedure as modified by the Law of 2010, and to provide that

in the event of liquidation of the Company or of any sub-fund thereof, assets which will not have been distributed to their
beneficiaries will be deposited with the custodian of the Company for a period of 9 months in compliance with Luxembourg
regulatory practice;

n) Amendment to Article 31 as to show the change from the Law of 2002 to the Law of 2010.
2) Miscellaneous
1. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to these minutes;

2. That an extraordinary general meeting of the shareholders with the same agenda was held on 2 January 2012. This

first meeting not being regularly constituted and all the shares being registered shares, a second convening notice setting
forth the agenda of the present meeting was sent to each of the registered shareholders of the Company on 9 January
2012;

27375

L

U X E M B O U R G

3. That according to the attendance list, out of 132,557,402 shares in issue, 3,682,977 shares are present or repre-

sented;

4. That pursuant to article 67 (2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the second

meeting may validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented;

5. That the present meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting (hereinafter the “General Meeting”), after deliberation, took the following resolution:

<i>First resolution

In accordance with the terminology used in the law of 5 April 1993 on the financial sector as amended, the General

Meeting decides to update all references to a “registrar and transfer agent” by references to a “registrar agent” in the
Articles.

<i>Second resolution

Further to the entry into force of the Law of 2010, the General Meeting decides to update all references to the “Law

of 2002” by references to the “Law of 2010” in the Articles.

As a consequence thereof the General Meeting decides to amend Article 3 as follows:

“ Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in the transferable securities of all

types  and  all  other  liquid  financial  permitted  assets  with  the  purpose  of  spreading  investment  risks  and  affording  its
shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by the law of 17 

th

 December 2010 relating to undertakings

for collective investment or any legislative replacements or amendment thereof (the “Law of 2010”).”

<i>Third resolution

The General Meeting decides to add a second paragraph under Article 4 to be read as follows:
“The Board may further decide to transfer permanently the registered office of the Company within the same muni-

cipality, or from a municipality to another municipality within the Grand Duchy of Luxembourg, if and to the extent
permitted by Luxembourg law and practice relating to commercial companies.”

<i>Fourth resolution

The General Meeting decides to add a new last paragraph under Article 5 to be read as follows:
“In the event that for any reason the value of the net assets of any class of Shares within a Sub-Fund has decreased to,

or has not reached, an amount determined by the Directors to be the minimum level for such class of Shares, to be
operated in an economically efficient manner or as a matter of economic rationalisation, the Directors may decide to
amend the rights attached to any class of Shares so as to include them in any other existing class of Shares and redesignate
the Shares of the class or classes concerned as Shares of another class. Such decision will be subject to the right of the
relevant Shareholders to request, without any charges, the redemption of their Shares or, where possible, the conversion
of those Shares into Shares of other classes within the same Sub-Fund or into Shares of same or other classes within
another Sub-Fund.”

<i>Fifth resolution

The General Meeting decides to amend the third paragraph of Article 11 to be read as follows:
“Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by a simple majority vote of the shareholders validly cast, regardless of the portion of capital
represented. Abstentions and nihil vote shall not be taken into account. A corporation may execute a proxy under the
hand of a duly authorised officer.”

<i>Sixth resolution

The General Meeting decides to add a new paragraph under the second paragraph of Article 13 to be read as follows:
“In the event an elected director is a legal entity, a permanent individual representative thereof should be designated

as member of the Board. Such individual is submitted to the same obligations than the other directors. Such individual
may only be revoked upon appointment of a replacement individual.”

<i>Seventh resolution

The General Meeting decides to amend the fourth paragraph of Article 16 to be read as follows:
“In compliance with the requirements set forth by the Law of 2010 and detailed in the prospectus, in particular as to

the type of markets on which the assets may be purchased or the status of the issuer or of the counterparty, each Sub-
Fund may invest in:

(i) transferable securities or money market instruments;

27376

L

U X E M B O U R G

(ii) Shares or units of other undertakings for collective investment (“UCI”), including shares or units of a master fund

qualified as an undertakings for collective investment in transferable securities (“UCITS”);

(iii) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are

maturing in no more than 12 months;

(iv) financial derivatives instruments;
(v) Shares issued by one or several other Sub-Funds of the Company under the conditions provided for by the Law

of 2010 and the prospectus.”

<i>Eighth resolution

The General Meeting decides to amend Article 18 so as to be read as follows:
“Every Director or officer of the Company and his personal representatives shall be indemnified and secured harmless

out of the assets of the relevant Sub-Fund(s) against all actions, proceedings, costs, charges, expenses, losses, damages
or liabilities (“Losses”) incurred or sustained by him in or about the conduct of the Company business or affairs or in the
execution or discharge of his duties, powers, authorities or discretions, including Losses incurred by him in defending
(whether successfully or otherwise) any civil proceedings concerning the Company in any court whether in Luxembourg
or elsewhere. No such person shall be liable: (i) for the acts, receipts, neglects, defaults or omissions of any other such
person; or (ii) by reason of his having joined in any receipt for money not received by him personally; or (iii) for any loss
on account of defect of title to any property of the Company; or (iv) for the insufficiency of any security in or upon which
any money of the Company shall be invested; or (v) for any loss incurred through any bank, broker or other agent; or
(vi) for any loss, damage or misfortune whatsoever which may happen in or arise from the execution or discharge of the
duties, powers, authorities, or discretions of his office or in relation thereto, unless the same shall happen through his
own gross negligence or wilful misconduct against the Company.”

<i>Ninth resolution

The General Meeting decides to amend Article 20 so as to be read as follows:
“The general meeting of shareholders of the Company shall appoint an authorised auditor (réviseur d'entreprises

agréé) who shall carry out the duties prescribed by the Law of 2010.”

<i>Tenth resolution

The General Meeting decides to amend the sixth paragraph of Article 21 to be read as follows:
“In case of redemption requests on any Valuation Date for more than 10 per cent of the number of Shares relating to

any Sub-Fund, the Company may elect to sell assets of that Sub-Fund representing, as nearly as practicable, the same
proportion of the Sub-Fund's assets as the Shares for which redemption applications have been received compared to
the total of Shares then in issue. If the Company exercises this option, then the amount due to the shareholders who
have applied to have their Shares redeemed, will be based on the net asset value per Share calculated after such sale or
disposal. Payment will be made forthwith upon the completion of the sales and the receipt by the Company of the proceeds
of sale in a freely convertible currency. At the shareholder's request, the Company may elect to make an in specie
distribution, having due regard to all applicable laws and regulations and to all shareholders' interest. In the case of an in
specie distribution the auditor of the Company shall if applicable deliver an audit report in accordance with applicable
laws.”

The General Meeting further decides to add a new last paragraph under Article 21 to be read as follows:
“All redeemed Shares may be cancelled.”

<i>Eleventh resolution

The General Meeting decides to insert a new item under the second paragraph of Article 22 to be read as follows:
“(f) following the suspension of the calculation of the net asset value per share/unit, the issue, redemption and/or the

conversion of shares/units at the level of a master fund in which a Sub-Fund invests in its quality as feeder fund of such
master fund;”

and as a result to change the numbering of former item (f) to (g).

<i>Twelfth resolution

Under Article 23, the General Meeting decides to amend items (2), (3) and (4) of section A.” The assets of the Company

shall be deemed to include:” and to add a new item (5) under this section to be read as follows:

“(2) Transferable Securities listed or traded on any Regulated Market, stock exchange in an Other State or Other

Regulated Market will be valued at the closing price on such markets. If a security is listed or traded on several markets,
the closing price at the market which constitutes the main market for such securities, will be determining;

(3) Transferable Securities not listed or traded on any Regulated Market, stock exchange in an Other State or Other

Regulated Market will be valued at their last available market price;

(4) Transferable Securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in (2) and/or

(3) is not representative of the fair market value, will be valued prudently, and in good faith on the basis of their reasonably

27377

L

U X E M B O U R G

foreseeable sales prices. As far as collateralised debt obligations are concerned and insofar the price quotation is not
representative of the fair market value, collateralised debt obligations will be valued at their Net Asset Value as transmitted
to the investment manager by the arranging bank of each collateralised debt obligation in which the Company has invested;

(9) Units of UCITS and/or other UCIs will be evaluated at their last available net asset value per unit. Open-ended

funds will be valued at the actual net asset value for such shares or units as of the relevant Valuation Day, or based on
the market value under the condition that this valuation reflects the most adequate price. If the latter is not the case,
funds shall be valued at the estimated net asset value as of such Valuation Day, or if no such estimated net asset value is
available they shall be valued at the last available actual or estimated net asset value provided that if events have occurred
which may have resulted in a material change in the net asset value of such shares or units since the date on which such
actual or estimated net asset value was calculated, the value of such shares or units may be adjusted in order to reflect,
in the reasonable opinion of the Directors, such change.”

The General Meeting further decides to replace the fourth paragraph of Article 23 relating to swing pricing mechanisms

by the following two new paragraphs:

“Subscriptions or redemptions in a Sub-Fund or Share Class can create dilution of the Sub-Fund's or the Share Class's

assets if shareholders subscribe or redeem at a price that does not necessarily reflect the real dealing and other costs
that arise when the Investment Manager buys or sells assets to accommodate net subscription or net redemption. In
order to protect the interest of the existing shareholders of a Sub-Fund or a Share Class, a swing pricing mechanism may
be adopted.

If the net subscriptions and redemptions based on the last available Net Asset Value on any Valuation Day exceed a

certain threshold of the value of a Sub-Fund or a Share Class on that Valuation Day, as determined and reviewed on a
periodic basis by the Management Company, the asset value may be adjusted respectively upwards or downwards to
reflect the dealing and other costs that may be deemed to be incurred in buying or selling assets to satisfy net daily
transactions. The Management Company may apply a swing pricing mechanism across any Sub-Fund or Share Class. The
extent of the price adjustment will be set by the Management Company to reflect estimated dealing and other costs and
will not exceed 2% of the Net Asset Value.”

The General Meeting finally decides to amend item (b) of section B. “The liabilities of the Company shall be deemed

to include:” of Article 23 as follows:

“(b) the fees of the Custodian, the Management Company, the Investment Managers if any, placement agents, Registrar

Agent, Domiciliary and Administrative Agent, Paying Agent, listing agent; other operational costs including, but not limited
to, costs of buying and selling underlying securities, government charges, registration with Regulatory Authorities, legal
and auditing fees, interest, reporting expenses, publication of offering and redemption prices, distribution of interim and
annual reports, postage, telephone and telex; reasonable marketing and promotional expenses;”

<i>Thirteenth resolution

The General Meeting decides to amend the second paragraph of Article 24 to be read as follows:
“The Issue Price may, upon approval of the Board, and subject to all applicable laws, namely if applicable with respect

to a valuation report prepared by the auditor of the Company confirming the value of any assets contributed in kind, be
paid  by  contributing  to  the  Company  securities  acceptable  to  the  Board,  consistent  with  the  investment  policy  and
investment restrictions of the Company and the relevant Sub-Fund.”

<i>Fourteenth resolution

The General Meeting decides to amend Article 29 so as to be read as follows:
“In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each Sub-Fund shall
be distributed by the liquidators to the holders of Shares in proportion of their holding of Shares. The operations of
liquidation will be carried out pursuant to the Law of 2010. After the liquidation period, the unclaimed assets will be
deposited with the Caisse de Consignation to the benefit of the shareholders.

In the event that for any reason the value of the total net assets in any Sub-Fund or the value of the net assets of any

class of Shares within a Sub-Fund has decreased to, or has not reached, an amount determined by the Board to be the
minimum level for such Sub-Fund, or such class of Shares, to be operated in an economically efficient manner or in case
of a substantial modification in the political, economic or monetary situation or as a matter of economic rationalisation,
the Board may decide to redeem all the Shares of the relevant class or classes at the Net Asset Value per Share (taking
into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) calculated on the Valuation Day at which
such decision shall take effect. The Company shall serve a notice to the holders of the relevant class or classes of Shares
prior to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the reasons and the procedure for the
redemption operations: registered shareholders shall be notified in writing; the Company shall inform holders of bearer
Shares by publication of a notice in newspapers to be determined by the Board, unless these shareholders and their
addresses are known to the Company. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment
between the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or of the class of Shares concerned may continue to request

27378

L

U X E M B O U R G

redemption or conversion of their Shares free of charge (but taking into account actual realisation prices of investments
and realisation expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, the general meeting of shareholders

of any one or all classes of Shares issued in any Sub-Fund will, in any other circumstances, have the power, upon proposal
from the Board, to redeem all the Shares of the relevant class or classes and refund to the shareholders the Net Asset
Value of their Shares (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) calculated on
the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general
meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and
voting at such meeting.

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited

with the Custodian for a period of nine months thereafter; after such period, the assets will be deposited with the Caisse
de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.

The Board may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 2010) of the Company or of one

of the Sub-Funds, either as receiving or absorbed UCITS or Sub-Fund, subject to the conditions and procedures imposed
by the Law of 2010, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders,
as follows:

The Board may decide to proceed with a merger of the Company, either as receiving or absorbed UCITS, with:
- another Luxembourg or foreign UCITS (the “New UCITS”); or
- a sub-fund thereof,
and, as appropriate, to redesignate the Shares of the Company concerned as Shares of this New UCITS, or of the

relevant sub-fund thereof as applicable.

In case the Company involved in a merger is the receiving UCITS (within the meaning of the Law of 2010), solely the

Board will decide on the merger and effective date thereof.

In case the Company involved in a merger is the absorbed UCITS (within the meaning of the Law of 2010), and hence

ceases to exist, the general meeting of the shareholders has to approve, and decide on the effective date of such merger
by a resolution adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes cast at such meeting.

The Board may further decide to proceed with a merger of any Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund,

with:

- another existing Sub-Fund within the Company or another sub-fund within a New UCITS (the “New Sub-Fund”); or
- a New UCITS,
and, as appropriate, to redesignate the Shares of the Sub-Fund concerned as Shares of the New UCITS, or of the New

Sub-Fund as applicable.

Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraphs the general meeting of the share-

holders may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 2010) of the Company or of one of the
Sub-Funds, either as receiving or absorbed UCITS or Sub-Fund subject to the conditions and procedures imposed by the
Law of 2010, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders, as
follows:

The general meeting of the shareholders may decide to proceed with a merger of the Company, either as receiving

or absorbed UCITS, with:

- a New UCITS; or
- a new sub-fund thereof,
The merger decision shall be adopted by the general meeting of the shareholders with no quorum requirement at a

simple majority of the votes validly cast.

The general meeting of the shareholders of a Sub-Fund [or of the Company] may also decide to proceed with a merger

of the relevant Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:

- any New UCITS; or
- a New Sub-Fund.
by a resolution adopted with no quorum requirement at a simple majority of the votes validly cast at such meeting.
In any of the above merger scenarios, shareholders will be entitled to request, without any charge other than those

retained by the Company or the Sub-Fund to meet disinvestment costs, the repurchase or redemption of their Shares,
or, where possible, to convert them into units or shares of another UCITS pursuing a similar investment policy and
managed by the same Management Company or by any other company with which the Management Company is linked
by common management or control, or by substantial direct or indirect holding, in accordance with the provisions of the
Law of 2010.

Any cost associated with the preparation and the completion of the merger shall neither be charged to the Company

nor to its shareholders.”

27379

L

U X E M B O U R G

<i>Fifteenth resolution

The General Meeting acknowledges that item n) of the agenda is already covered by the second resolution and that

Article 31 shall therefore be amended accordingly.

There being no further business of the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English.

Whereupon, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Signé: C. Muller, C. Leroy, C. Mayembo, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 février 2012. Relation: LAC/2012/6582. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur

 (signé): I. Thill.

Référence de publication: 2012025843/320.
(120034194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.

MUGC/WA U.S. Credit BBB/BB Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion de MUGC/WA U.S. CREDIT BBB/BB FUND a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2012.

MUGC LUX MANAGEMENT S.A.

Référence de publication: 2012025500/10.
(120033340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.

Tuomi S.A., Société Anonyme,

(anc. Tuomi IT S.A.).

Siège social: L-6689 Mertert, Zone Industrielle Fausermillen.

R.C.S. Luxembourg B 112.690.

Im Jahre zweitausendelf, den achten September.
Vor Notar Paul BETTINGEN, mit Amtssitze zu Niederanven.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft TUOMI IT S.A., mit Sitz in L-6757 Grevenmacher, 2a, Rue de la Moselle, eingetragen im Handels-
register Luxemburg unter der Nummer B 112.690, gegründet durch Urkunde des amtierenden Notars, am 9. Dezember
2005, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 566, Seite 27141 vom 17. März 2006, letztmalig abgeändert durch Notar
Roger Arrendsdorff, mit damaligem Amtssitz zu Bad-Mondorf, am 6. August 2007, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
2561, Seite 122907 vom 10. November 2007.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Arja Roos, Kauffrau, wohnhaft in Philipp-Loosen-Strasse 7, D-54295 Trier.
Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Axel Krone, Kauffmann, wohnhaft in Ostallee 29, D-54290 Trier.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Arja Roos, vorbenannt.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigten Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.

Etwaige Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem ins-

trumentierenden Notar “ne varietur“ unterzeichnet, bleiben gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1.- Umbenennung der Gesellschaft in „TUOMI S.A.“, und Abänderung von Artikel 1.

27380

L

U X E M B O U R G

2.- Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-6689 Mertert, Zone Industrielle Fausermillen, und Abänderung von Artikel

2, Absatz 1 der Satzungen.

3.- Niederlegung des Mandats des Herrn Helmut Haag als Verwaltungsratsmitglied.
4.- Ernennung von zwei neuen Verwaltungsratsmitgliedern Herr Axel Krone und Herr Prof. Dr. Michael Brucksch.
5.- Abberufung des Kommissars Herr Ingo Erb.
6.- Ernennung eines neuen Kommissars LUDWIG Consult S.àr.l.
7.- Verschiedenes.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Gesellschaft umzubenennen in „TUOMI S.A.“ und dementsprechend Abänderung

von Artikel 1 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 1. „Es besteht eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "TUOMI S.A.".

<i>Zweiter Beschluss

Die  Generalversammlung  beschliesst  den  Gesellschaftssitz  von  L6757  Grevenmacher,  2a,  Rue  de  la  Moselle  nach

L-6689 Mertert, Zone industrielle Fausermillen zu verlegen und dementsprechend Artikel 2, Absatz 1 der Satzungen
abzuändern wie folgt:

Art. 2. (Absatz eins). „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mertert-Wasserbillig.“

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Niederlegung des Mandats von Herrn Helmut Haag als Verwaltungsratsmitglied an und

erteilt Entlastung für die Ausübung seines Mandats.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung ernennt:
- Herrn Axel Krone, Kauffmann, geboren am 2. April 1959 in Trier, wohnhaft in D-54290 Trier, 29, Ostallee;
- Herrn Prof. Dr. Michael Brucksch, Diplom-Ingenieur, geboren am
2. November 1958 in Bielefeld-Gadderbaum (Deutschland), wohnhaft in D51429 Bergisch-Gladbach, 11a, Löhe;
zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern. Die Mandate sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen

Generalversammlung im Jahre 2017.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Niederlegung des Mandats von Herrn Helmut Haag als Kommissar an und erteilt Entlas-

tung für die Ausübung seines Mandats.

<i>Sechster Beschluss

Die Versammlung ernennt:
- Ludwig Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée mit Sitz zu L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill

eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 48.947;

zum neuen Kommissar. Sein Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2017.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

<i>Bevollmächtigung

Der Erschienene erteilt hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, in seinem

Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Die Kosten, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf tausend Euro (EUR

1.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort, bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Arja Roos, Axel Krone, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 22 septembre 2011. LAC/2011/41879. Reçu 75,- EUR.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Für gleichlautende Kopie ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27381

L

U X E M B O U R G

Senningerberg, den 14. Dezember 2011.

Référence de publication: 2012018043/80.
(120021672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.

Tuomi S.A., Société Anonyme,

(anc. Tuomi IT S.A.).

Siège social: L-6689 Mertert, Zone Industrielle Fausermillen.

R.C.S. Luxembourg B 112.690.

Im Jahre zweitausendzwölf, den dreissigsten Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Herr Jean-Pierre DIAS, Privatbeamter, mit beruflicher Anschrift in Senningerberg,
welcher den unterzeichnenden Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:
Am 8. September 2011 (Repertorium Nummer 39.293) wurde durch den unterzeichnenden Notar das Protokoll der

ausserordentlichen Generalversammlung der Aktiengesellschaft TUOMI S.A. (vormals: TUOMI IT S.A.), mit Sitz in L-6689
Mertert, Zone Industrielle Fausermillen (vormals: L-6757 Grevenmacher, 2a, rue de la Moselle), eingetragen im Handels-
register zu Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 112.690, aufgestellt.

Besagte Urkunde wurde einregistriert in Luxemburg A.C. am 22. September 2011, Referenz LAC/2011/41879.
Der Unterzeichnende hat festgestellt, dass im fünften Beschluss ein materieller Fehler unterlaufen ist in Bezug auf die

Niederlegung des Mandats des Kommissars, welches nicht Herr Helmut Haag, sondern Herr Ingo ERB ist.

Somit ersucht der Unterzeichnende, handelnd in Ausführung der ihm durch die Aktiengesellschaft TUOMI S.A. (vor-

mals TUOMI IT S.A.) vorbenannt,erteilte Befugnis gemäss Bevollmächtigung, welche in der vorbezeichneten Urkunde
vom 8. September 2011 erteilt wurde, die Berichtigung des fünften Beschlusses vorzunehmen wie folgt:

<i>Falsche Version:

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Niederlegung des Mandats von Herrn Helmut Haag als Kommissar an und erteilt Entlas-

tung für die Ausübung seines Mandats.

<i>Berichtigte Version:

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Niederlegung des Mandats von Herrn Ingo ERB als Kommissar an und erteilt Entlastung

für die Ausübung seines Mandats.

Die übrigen Angaben der Urkunde bleiben unverändert.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 30 janvier 2012. LAC/2012/4693. Reçu 12,- EUR.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

Für gleichlautende Kopie ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 3. Februar 2012.

Référence de publication: 2012018044/40.
(120021672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.

Le Monterey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 13, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 106.152.

Nika, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 13, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 56.878.

L'an deux mille douze, le quatorze février.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

27382

L

U X E M B O U R G

A comparu:

Monsieur Christoph RIES, commerçant, né à Luxembourg le 15 juillet 1983, demeurant à 29, rue d'Olm, L-8281 Kehlen,
Agissant en tant que mandataire de:
1) "LE MONTEREY S.à.r.l..", ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 13, Avenue Monterey, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 106152, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph
ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 20 janvier 2005, publié au Mémorial C Recueil Spécial des
Sociétés et Associations numéro 573 du 14 juin 2005, (la «Société Absorbante»),

En vertu d'une procuration lui conférée par décision du conseil de gérance prise en sa réunion du 27 juillet 2011, dont

une copie après, après avoir été paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être formalisée avec lui.

2) "NIKA" une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 13, Avenue Monterey,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 56878, constituée suivant acte reçu
par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Hesperange le 25 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 44 du 31 juin 1997, (la «Société Absorbée»),

En vertu d'une procuration lui conférée par décision du conseil de gérance prise en sa réunion du 27 juillet 2011, dont

une copie après, après avoir été paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant de constater que:
1. La Société Absorbante détient cent pour-cent (100%) des parts de la Société Absorbée.
2. Le Conseil de gérance de la Société Absorbée et de la Société Absorbante (ensemble les “Sociétés Fusionnantes”)

ont adopté un projet de fusion en date du 8 août 2011, qui a été publié conformément aux dispositions de l'article 262
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la “Loi”) au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 3178 le 24 décembre 2011.

3. Les documents requis par l'article 267, paragraphe 1, a) et b) de la Loi (c.-à-d. le projet de fusion, les rapports de

gestion et les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux des Sociétés Fusionnantes), ont été tenus à disposition
des associés des Sociétés Fusionnantes à leur siège social durant un mois précédant la date de cette assemblée.

4. Aucune objection à l'encontre de la fusion n'a été communiquée entre la date de publication du projet de fusion et

la date de cette assemblée.

5. Le Conseil de gérance de la Société Absorbante a constaté l'effet de la fusion.
6. La fusion prend effet à partir d'aujourd'hui et la publication au Mémorial Recueil des sociétés et Associations avec

effet comptable de manière rétroactive au 1 

er

 janvier 2011.

7. La Société Absorbée est absorbée avec apport de tous ses actifs et passifs par la Société Absorbante, sans aucune

restriction ni limitation.

8. Suite à la fusion, la Société Absorbée a cessé d'exister par dissolution.
Ensuite ceci exposé, le comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les décisions suivantes:
1. Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société Absorbée pour l'exercice de son mandat jusqu'à la

date des présentes.

2. Les documents et pièces comptables de la Société Absorbée resteront conservés pendant la période légale au siège

social de la Société Absorbante.

<i>Déclaration

Conformément à l'article 271 (2) de la LSC, le notaire soussigné (i) déclare avoir vérifié et certifie l'existence et la

validité, en droit luxembourgeois, des actes légaux et des formalités imposées à la Société Absorbante afin de rendre la
fusion valable, (ii) confirme que la fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée prendra effet à la date de
publication de la présente assemblée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de cet acte sont

estimés à 900,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire instru-

mentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. RIES, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 février 2012. Relation: LAC/2012/7284. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros)

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27383

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 23 février 2012.

Référence de publication: 2012024970/67.

(120032013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2012.

Delvino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 110.880.

In the year two thousand and twelve, on the tenth of February,

before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,

is held

an extraordinary general meeting of shareholders of DELVINO S.A. (the “Company”), a société anonyme having its

registered office in L-1746 Luxembourg 1, rue Joseph Hackin, recorded with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 110.880, incorporated pursuant to a notarial deed dated 15 September 2005, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 78 of 12 January 2006.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated

27 January 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened at 11.00 a.m. with Mrs Françoise Rollin, private employee, L-1746 Luxembourg 1, rue Joseph

Hackin, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Anne-Lies Van Den Eeckhaut, private employee, L-1746 Luxembourg 1, rue Joseph

Hackin.

The meeting elects as scrutineer Mr François Mayet, private employee, L1746 Luxembourg 1, rue Joseph Hackin.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Amendment of the 1 

st

 sentence of the 1 

st

 paragraph of article 7 in order to create Class A and Class B directors

and of the 12 

th

 paragraph of article 8 and the 3 

rd

 paragraph of article 11 of the articles of incorporation in order to give

them the following wording:

Art. 7. 1 

st

 sentence &amp; Paragraph.  “The Company shall be managed by the Board of Directors of at least three (3)

members divided into one or more A directors and one or more B directors, either shareholder or not, who are appointed
for a term which may not exceed six (6) years, by a General Meeting.”

Art. 8. 12 

th

 paragraph.  “The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its

members are present or represented including at least one Class A and one Class B director”.

Art. 11. 3 

rd

 paragraph.  “The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of one A director

and one B director in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.”;

2. Resignation of Mr Nicholas Ogden and Mrs Liliane Poitiers as directors of the Company. Discharges to be granted.

3. Appointment of Class A and Class B Directors.

II.- That the present or represented sole shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number

of its shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxy of the represented shareholder will also remain annexed to the present deed after having been initialled

ne varietur by the persons appearing.

III.- That the whole share capital being represented at the present meeting, no convening notices were necessary, the

shareholder represented declaring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda. The general meeting then takes the following resolutions:

27384

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution:

The general meeting resolves to amend the 1 

st

 sentence of the 1 

st

 paragraph of article 7 in order to create Class A

and Class B directors and the 12 

th

 paragraph of article 8 as well as the 3 

rd

 paragraph of article 11 of the articles of

incorporation of the Company in order to give them henceforth the following wording:

Art. 7, 1 

st

 sentence &amp; Paragraph.  “The Company shall be managed by the Board of Directors of at least three (3)

members divided into one or more A directors and one or more B directors, either shareholder or not, who are appointed
for a term which may not exceed six (6) years, by a General Meeting.”

Art. 8. 12 

th

 paragraph.  “The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its

members are present or represented including at least one Class A and one Class B director”

Art. 11. 3 

rd

 paragraph.  “The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of one A director

and one B director in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.”

<i>Second resolution:

The general meeting resolves to accept the resignation of Mr Nicholas Ogden and Mrs Liliane Poitiers as directors of

the Company.

The general meeting decides to grant full discharge to the said directors for the execution of their mandate up to this

date.

<i>Third resolution:

The general meeting resolves to appoint the following persons as class A and class B directors of the Company:

<i>Class A directors:

- Mr Pascal HOBLER, born on March 24, 1968, in Metz, France, having his professional address at 50, avenue JF Kennedy,

L-2951 Luxembourg,

- Mr Patrick SABIA, born on March 6, 1975, in Montegnee, Belgium, having his professional address at 50, avenue JF

Kennedy, L-2951 Luxembourg,

- Mr Christophe BRECHIGNAC, born on December 28, 1973, in Paris, France, having his professional address at 50,

avenue JF Kennedy, L-2951 Luxembourg.

<i>Class B directors:

- Mr Yvan JUCHEM, born on December 8, 1960, in Luxembourg, having his professional address at 50, avenue JF

Kennedy, L-2951 Luxembourg,

- Mr Simon CRITCHLOW, born on September 29, 1955, in Carshalton, United Kingdom, having his professional

address at 50, avenue JF Kennedy, L-2951 Luxembourg.

Their mandate will expire with the annual general meeting called to approve the accounts as at 31 December 2017.
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

Whereupon, the present deed is drawn up in Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, at the date named at the beginning

of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing persons,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le dix février,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DELVINO S.A. (la „Société“), ayant son

siège social à L-1746 Luxembourg 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 110.880 constituée suivant acte notarié en date du 15 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 78 du 12 janvier 2006.

27385

L

U X E M B O U R G

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 27 janvier 2012, en cours de publication

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Françoise Rollin, employée privée, L-1746

Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne-Lies Van Den Eeckhaut, employée privée, L-1746 Luxembourg, 1, rue

Joseph Hackin.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Mayet, employé privé, L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph

Hackin.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la 1ère phrase du 1 

er

 alinéa de l'article 7 afin de créer des administrateurs de classes A et B ainsi

que du 12 

e

 alinéa de l'article 8 et le 3 

e

 alinéa de l'article 11 des statuts de la Société afin de leurs donner la teneur

suivante:

Art. 7. 1 

ère

 phrase, alinéa 1.  “La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3)

membres au moins divisés en un ou plusieurs administrateurs de classe A et un ou plusieurs administrateurs de classe B,
actionnaires ou non, élus par l'Assemblée Générale pour un terme ne pouvant dépasser six (6) ans.”

Art. 8. 12 

e

 alinéa.  “Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement et statuer que si la majorité de ses

membres et présente ou représentée incluant au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B.”

Art. 11. 3 

e

 alinéa.  “La Société sera engagée en toutes circonstances vis à vis des tiers par la signature conjointe d'un

administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B ou par la signature conjointe ou l'unique signature de toute
(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs auront été confiés par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites
de ces pouvoirs.”;

2. Démission de Monsieur Nicholas Ogden et Madame Liliane Poitiers comme administrateurs de la Société. Décharge

à accorder.

3. Nomination d'administrateurs de classes A et B.
II.- Que l'actionnaire unique présent ou représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre

d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le
mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, l'actionnaire représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide de modifier la 1 

ère

 phrase du 1 

er

 alinéa de l'article 7 afin de créer des administrateurs

de classes A et B ainsi que le 12 

e

 alinéa de l'article 8 et le 3e alinéa de l'article 11 des statuts de la Société afin de leurs

donner désormais la teneur suivante:

Art. 7. 1 

ère

 phrase, Alinéa 1.  “La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3)

membres au moins divisés en un ou plusieurs administrateurs de classe A et un ou plusieurs administrateurs de classe B,
actionnaires ou non, élus par l'Assemblée Générale pour un terme ne pouvant dépasser six (6) ans.”

Art. 8. 12 

e

 alinéa.  “Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement et statuer que si la majorité de ses

membres et présente ou représentée incluant au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B.”

Art. 11. 3 

e

 alinéa.  “La Société sera engagée en toutes circonstances vis à vis des tiers par la signature conjointe d'un

administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B ou par la signature conjointe ou l'unique signature de toute
(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs auront été confiés par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites
de ces pouvoirs.”

27386

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée  générale  décide  d'accepter  la  démission  de  Monsieur  Nicholas  Ogden  et  de  Madame  Liliane  Poitiers

comme administrateurs de la Société.

Pleine et entière décharge leur est accordée pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer comme administrateurs des classes A et B les personnes suivantes:

<i>Administrateur de classe A:

- Monsieur Pascal HOBLER, né le 24 mars 1968 à Metz, France, avec adresse professionnelle au 50, avenue JF Kennedy

à L-2951 Luxembourg,

- Monsieur Patrick SABIA, né le 6 mars 1975 à Montegnee, Belgique, avec adresse professionnelle au 50, avenue JF

Kennedy à L-2951 Luxembourg,

- Monsieur Christophe BRECHIGNAC, né le 28 décembre 1973 à Paris, France, avec adresse professionnelle au 50,

avenue JF Kennedy à L-2951 Luxembourg.

<i>Administrateur de classe B:

- Monsieur Yvan JUCHEM, né le 8 décembre 1960 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 50, avenue JF

Kennedy à L-2951 Luxembourg,

- Monsieur Simon CRITCHLOW, né le 29 septembre 1955 à Carshalton, Royaume Uni, avec adresse professionnelle

au 50, avenue JF Kennedy à L-2951 Luxembourg.

- Leurs mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes clôturés au 31 décembre

2017.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont approximativement estimés à la somme de mille cinq cents
euros (EUR 1.500).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. ROLLIN, A.-L. VAN DEN EECKHAUT, F. MAYET et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 février 2012. LAC / 2012 / 7091. Reçu soixante quinze euros € 75,

<i>Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 27 février 2012.

Référence de publication: 2012025906/181.
(120033411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.

Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.635.000,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 107.523.

In the year two thousand and twelve, on the 10 of February,
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,
Was  held  an  Extraordinary  General  Meeting  of  the  Sole  Shareholder,  “Partners  Group  Holding  AG”,  a  company

incorporated and existing under the laws of Switzerland and having its registered office at Zugerstrasse 57, CH-6341
Baar-Zug, Switzerland, inscribed in the Handelsregister of the Kanton Zug under the number CH-170.3.021.159.3, hereby
duly represented by Solange Wolter, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given to her
under private seal.

The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and by the undersigned notary will remain

attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, through its mandatory, declared and requested the notary to act:

27387

L

U X E M B O U R G

That the appearing party is the sole actual partner of “Partners Group (Luxembourg) S.à r.l.”, a company incorporated

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, dated April 27, 2005, Lu-
xembourg trade register B 107 523, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number
433 of May 11, 2005, and whose articles of association have been modified:

- by deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, on the 1 July 2005, published in the Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, number 1273 of 25 November 2005;

- by deed of the Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, on the 17 June 2008, published in the Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1777 of 18 July 2008;

- by deed of the Maître Jean SECKLER, prenamed, on the 17 June 2009, published in the Mémorial C, Recueil Spécial

des Sociétés et Associations, number 1457 of 28 July 2009;

- by deed of the undersigned notary, on the 14 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des

Sociétés number 343 of 8 February 2012. That the appearing party has taken the following resolution:

<i>Sole resolution:

The sole shareholder resolves to amend article 2 of the articles of incorporation as follows:

“ Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and act as «commandité» of Luxembourg «sociétés en commandite par actions». The Company may carry
out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
The Company may provide intra-group domiciliation services.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.”

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le dix février.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Avait lieu une Assemblée Générale Extraordinaire du actionnaire unique “Partners Group Holding A.G.”, ayant son

siège social à Zugerstrasse 57, CH6341 Baar-Zug, Suisse, immatriculé dans le Handelsregister Kanton Zug avec le numéro
CH-170.3.021.159.3, représentée par Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire et le notaire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Que  la  comparante  est  la  seule  et  unique  associée  actuelle  de  “Partners  Group  (Luxembourg)  S.à  r.l.”,  société  à

responsabilité limitée, ayant son siège social à 55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 27 avril 2005, imma-
triculé au Registre de Commerce et des Sociétés numéro B 134 852, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 433 du onze mai 2005, et dont les statuts ont été modifiés:

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du premier juillet 2005, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1273 du 25 novembre 2005.

- suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 juillet 2005, publié au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1777 du 18 juillet 2008.

27388

L

U X E M B O U R G

- suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, prénommé, en date du 17 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1457 du 28 juillet 2009.

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial

des Sociétés et Associations, numéro 343 du 8 février 2012,

et que la comparante a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique:

L'associé décide de modifier l'article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante :

« Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et
autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son por-
tefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et agir en tant que «commandité»
de sociétés en commandite par actions luxembourgeoises. La Société peut exercer son activité par l'intermédiaire de
succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de

certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)

à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient
la  Société,  prendre  toute  mesure  de  contrôle  et  de  surveillance  et  effectuer  toute  opération  qu'elle  juge  utile  dans
l'accomplissement et le développement de ses objets.

La Société peut rendre des services de domiciliation intra-groupe.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par ses noms, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 février 2012. Relation: LAC/2012/7822. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 28 février 2012.

Référence de publication: 2012026110/109.
(120034135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.

GE Financing (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.925,00.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 56.197.

EXTRAIT

Suite aux résolutions des associés de GE FINANCING (LUXEMBOURG) S.à r.l. (la “Société”) en date du 20 février

2012, il a été décidé d'accepter la démission de:

- monsieur Boris Eric Pierre HENRY, Gérant B, avec effet du 1 

er

 février, 2012;

- monsieur Ernst Frederik KRAAIJ, Gérant B, avec effet du 20 février, 2012;
- monsieur Gaurav AGRAWAL, Gérant A, avec effet du 20 février, 2012;
étant donné que le mandat de monsieur Thomas LAFARGUE, Gérant B, a expiré le 1 

er

 juin 2011, de rayer le nom du

monsieur Thomas LARFARGUE du dossier concernant la Société, déposé auprès le Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg,

et de nommer avec effet du 20 février, 2012:

27389

L

U X E M B O U R G

- monsieur Augustin Pierre Jules Joseph LAURENT, ayant son adresse au 2, rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Grand-

duché de Luxembourg en tant que “Gérant A”, jusqu'à l'assemblée générale des associés de la société qui se tiendra en
l'année 2013.

Par conséquence, le conseil de gérance de la Société, en date du 20 février, 2012, se compose comme suit:
- monsieur Teunis Chr. AKKERMAN, Gérant A;
- monsieur Augustin Pierre Jules Joseph LAURENT, Gérant A
- madame Lesly JAPLIT, Gérant B;
- monsieur Philippe REIBEL, Gérant B;
- monsieur Robert MALITZ, Gérant B.

<i>Pour GE FINANCING (LUXEMBOURG) S.à r.l.
S.Th. Kortekaas
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012026773/30.
(120034836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.

Weatherford Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 112.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.704.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-third day of December.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Weatherford (G.B.) LLP, a limited liability partnership, having its registered office at Weatherford Centre, Southerhead

Road, Altens Industrial Estate, Aberdeen, AB12 3LF, Scotland, registered with the Companies House under number
SO300401 (the “Sole Shareholder”);

hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5 rue Zénon

Bernard L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.

Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder, acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated herein above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Weatherford Holding (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability

company “société à responsabilité limitée”, having its registered office at 67, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 103.704 (the “Company”), which has been incorporated pursuant to a deed enacted by Maître Joseph Elvinger,
notary  residing  in  Luxembourg,  on  28  September  2004  published  in  the  “Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations” (the “Memorial C”) number 12, dated 6 January 2005.

The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed enacted by Maître

Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 13 December 2006, published in the Memorial C number 707, dated
25 April 2007.

II.- That the 2,240 (two thousand two hundred forty) shares of a nominal value of GBP 50 (fifty Pounds Sterling) each,

representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Dissolution and liquidation of the Company;
3. Appointment of Weatherford (G.B.) LLP as liquidator of the Company for the liquidation period and determination

of the powers of the liquidator; and

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder of the Company, the following resolutions were taken:

<i>First resolution

It was resolved that the Sole Shareholder waives its right to prior notice of the current meeting, acknowledges having

been sufficiently informed of the agenda for the meeting, confirms that it considers the meeting validly convened and

27390

L

U X E M B O U R G

therefore agrees to deliberate and vote upon all the items on the agenda. It was further unanimously resolved that all the
relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within sufficient period of time in order to
allow it to carefully examine each document.

<i>Second resolution

It was resolved, in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the “Law”) to

declare the voluntary dissolution of the Company and to put it into liquidation.

<i>Third resolution

It was resolved to appoint the Sole Shareholder as liquidator of the Company (the "Liquidator").
It was resolved to grant the following powers to the Liquidator:
The Liquidator shall be fully empowered as per Articles 144 to 151 of the Law.
He shall notably be empowered to represent the Company during and in the course of the liquidation process, to

dispose of all the assets, to discharge all the liabilities and to distribute (in whole or in part) the net assets of the Company
to the Sole Shareholder in kind or in cash at any time during the liquidation process.

He may carry out any act provided for in Article 145 of the Law without the need for prior approval of the Sole

Shareholder, including contribute or distribute the assets of the Company to other companies.

He may distribute an advance payment on the liquidation proceeds to the Sole Shareholder, provided that the Company

has sufficient funds and liquid assets to settle its liabilities.

He may deal with, with or without payment, all intangible, privileged, secured or mortgaged rights, actions in termi-

nation, transcription, seizure, opposition or other encumbrances.

The Liquidator may in particular, without limiting the generality of the above, sell, exchange or alienate any and all

movable property and/or rights of the Company, if the occasion arises.

The Liquidator is exempt from drawing up an inventory and can refer to the accounts of the Company instead.
He may freely delegate specified and determined tasks and for a limited period part of his powers to one or more

representatives on his own responsibility.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

There being no further business for the meeting to consider, the same was thereupon closed.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Esch-sur-Alzette  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, such proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-troisième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire public résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gné.

A comparu:

Weatherford (G.B.) LLP, une société ayant son siège social sis au Weatherford Centre, Southerhead Road, Altens

Industrial Estate, Aberdeen, AB12 3LF, Ecosse et enregistrée auprès du registre de commerce «Companies House» sous
le numéro B SO300401 (l'«Associé Unique»),

ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au 5 rue

Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.

Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le

notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante, ainsi représentée, a requis le notaire soussigné d'enregistrer ce qui suit:
I.- La partie comparante est l'associé unique de Weatherford Holding (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social sis au 67, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le matricule B 103.704
(la «Société»), constituée par acte notarié reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, du 28 sep-

27391

L

U X E M B O U R G

tembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro 12, en date du 6 janvier
2005.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié reçu par Maître Henri Hellinckx,

notaire résidant à Luxembourg, du 13 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 707, en date du 25 avril 2007.

II.- Que les 2,240 (deux mille deux cent quarante) parts sociales d'une valeur nominale de 50 GBP (50 livres sterling

britanniques) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée
peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont l'Associé Unique reconnaît expressément
avoir été dûment informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Dissolution et liquidation de la Société;
3. Nomination de Weatherford (G.B.) LLP, en tant que liquidateur de la Société pour la période de liquidation et

détermination des pouvoirs du liquidateur; et

4. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique de la Société, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Il a été décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente

assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, confirme qu'il considère l'assemblée valablement
convoquée et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en
outre décidé que toute la documentation pertinente produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de
l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il a été décidé, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), de

déclarer la liquidation volontaire de la Société et d'ouvrir la liquidation de la Société.

<i>Troisième résolution

Il a été décidé de nommer l'Associé Unique en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).
Il a été décidé de conférer les pouvoirs suivants au Liquidateur:
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 151 de la Loi.
Il sera notamment habilité à représenter la Société durant la procédure de liquidation, à vendre tous les actifs, à

s'acquitter des dettes de la Société, et à distribuer (en tout ou partie) les actifs nets de la Société à l'Associé Unique, en
espèces ou en nature, à tout moment au cours de la procédure de liquidation.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans autorisation préalable de l'Associé Unique, y compris

apporter ou distribuer les actifs de la Société à d'autres sociétés.

Il peut distribuer une avance sur boni de liquidation à l'Associé Unique, à condition que la Société dispose de fonds et

de liquidités suffisants pour régler ses dettes.

Il peut traiter, avec ou sans paiement, tous les droits incorporels, privilèges, gages ou hypothèques, actions résolutoires,

transcriptions, saisies, oppositions ou tout autre empêchement.

Le Liquidateur peut en particulier, sans que l'énumération suivante ne soit limitative, vendre, échanger ou aliéner tous

biens mobiliers et/ou droits de la Société, le cas échéant.

Le Liquidateur est exempté de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société à la place.
Il peut librement déléguer, sous sa propre responsabilité, des tâches spécifiques et déterminées et pour un temps

limité, partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en rapport avec le présent acte, s'élèvent à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été ajournée.

A la suite de quoi le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette au jour cité en tête de ce document.
Lecture ayant été faite aux comparants, ils ont signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que, sur demande des comparants ci-dessus, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kesseler.

27392

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 janvier 2012. Relation: EAC/2012/89. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Référence de publication: 2012010596/152.
(120011709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Prahy Invest G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 65.624.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRAHY INVEST G.m.B.H.

Référence de publication: 2012013625/10.
(120016351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Premier Tax, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 147.687.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 09 janvier 2012

<i>Résolutions

- Monsieur Luc Lesire, administrateur de la société Premier Tax S.A. est rayé de la société.
- Monsieur David Moscato, né le 12 février 1976 à Marostica, Italie, demeurant professionnellement à L-1331 Luxem-

bourg, 59 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, sera nommé comme administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui
se tiendra en 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012013629/14.
(120015870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

GE Holdings Forint Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: HUF 3.600.000,00.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 150.405.

EXTRAIT

Suite aux résolutions de l'associé unique de GE Holdings Forint Luxembourg S.à r.l. (la “Société”) en date du 20 février

2012, il a été décidé d'accepter la démission de:

- monsieur Gaurav AGRA WAL, Gérant A, avec effet du 20 février, 2012;
- monsieur Ernst Frederik KRAAIJ, Gérant A, avec effet du 20 février, 2012;
- monsieur Boris Eric Pierre HENRY, Gérant B, avec effet du 1 

er

 février, 2012,

étant donné que le mandat de monsieur Thomas LAFARGUE, Gérant B, a expiré le 1 

er

 juin 2011, de rayer le nom du

monsieur Thomas LARFARGUE du dossier concernant la Société, déposé auprès le Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg,

et de nommer avec effet du 20 février, 2012:
- monsieur Augustin Pierre Jules Joseph LAURENT, ayant son adresse au 2, rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Grand-

duché de Luxembourg en tant que “Gérant A”, jusqu'à l'assemblée générale des associés de la société qui se tiendra en
l'année 2013.

Par conséquence, le conseil de gérance de la Société, en date du 20 février, 2012, se compose comme suit:
- monsieur Teunis Chr. AKKERMAN, Gérant A;
- monsieur Augustin Pierre Jules Joseph LAURENT, Gérant A;
- madame Lesly JAPLIT, Gérant B;
- monsieur Philippe REIBEL, Gérant B;
- monsieur Stephen PARKS, Gérant B.

27393

L

U X E M B O U R G

<i>Pour GE Holdings Forint Luxembourg S.à r.l.
S.Th. Kortekaas
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012026774/30.
(120034838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.

GE UK FINANCING (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 200.300,00.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 67.038.

EXTRAIT

Suite aux résolutions de l'associé unique de GE UK FINANCING (Luxembourg) S.à r.l. (la “Société”) en date du 20

février 2012, il a été décidé d'accepter la démission de:

- monsieur Ernst Frederik KRAAIJ, avec effet du 20 février, 2012;
- monsieur Gaurav AGRAWAL, avec effet du 20 février, 2012;

- monsieur Boris Eric Pierre HENRY, avec effet du 1 

er

 février, 2012,

étant donné que le mandat de monsieur Thomas LAFARGUE, Gérant, a expiré le 1 

er

 juin 2011, de rayer le nom du

monsieur Thomas LARFARGUE du dossier concernant la Société, deposé auprès le Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg,

et de nommer avec effet du 20 février, 2012:
- monsieur Augustin Pierre Jules Joseph LAURENT, ayant son adresse au 2, rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Grand-

Duché de Luxembourg en tant que gérant, jusqu'à l'assemblée générale des associés de la Société qui se tiendra en l'année
2013.

Par conséquence, le conseil de gérance de la Société, en date du 20 février, 2012, se compose comme Suit:
- monsieur Teunis Chr. AKKERMAN;
- monsieur Augustin Pierre Jules Joseph LAURENT;
- madame Lesly JAPLIT;
- monsieur Philippe REIBEL;
- monsieur Robert MALITZ.

<i>Pour GE UK FINANCING (Luxembourg) S.à r.l.
S. Th. Kortekaas
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012026775/30.
(120034831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.

Primus Equity Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 138.992.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26.01.2012.

<i>Pour: PRIMUS EQUITY GROUP S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Ana-Paula Duarte

Référence de publication: 2012013632/15.
(120016296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

27394

L

U X E M B O U R G

Primus Equity Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 138.992.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26.01.2012.

<i>Pour: PRIMUS EQUITY GROUP S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Ana-Paula Duarte

Référence de publication: 2012013633/15.
(120016297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Prahy Invest G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 65.624.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRAHY INVEST G.m.B.H.

Référence de publication: 2012013626/10.
(120016352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Prahy Invest G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 65.624.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRAHY INVEST G.m.B.H.

Référence de publication: 2012013627/10.
(120016353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Prahy Invest G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 65.624.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRAHY INVEST G.m.B.H.

Référence de publication: 2012013628/10.
(120016354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Omega Finances Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 26, rue Alphonse München.

R.C.S. Luxembourg B 145.257.

Les  comptes  annuels  du  01.01.2010  au  31.12.2010  ont  été  déposés  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012013596/11.
(120016105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

27395

L

U X E M B O U R G

Philos Currency Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 144.870.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 8 décembre 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société d'investissement à capital variable sous
forme de société anonyme PHILOS CURRENCY FUND S.A., ayant eu son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue
J.F. Kennedy.

Les frais ont été mis à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Me Marthe FEYEREISEN
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2012013600/17.
(120015885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Philos Asset Management, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.

R.C.S. Luxembourg B 144.869.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 8 décembre 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée PHILOS ASSET
MANAGEMENT s.àr.l., ayant eu son siège social à L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.

Les frais ont été mis à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Me Marthe FEYEREISEN
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2012013599/15.
(120015886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Island Lux S.à r.l. &amp; Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 154.930.

In the year two thousand and eleven, on the nineteenth day of December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of “Island Lux S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.” a partnership

limited by shares (société en commandite par actions) with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register” under number B 154930 (hereinafter, the Company),
incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
dated August 5, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on October 4, 2010 under
number 2070, and whose bylaws have been last amended by a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-
sur-Alzette dated October 31, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is chaired by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, having her professional address at 5,

rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and scrutineer Miss Claudia ROUCKERT, employee, with professional address

at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders are represented by virtue of three (3) proxies given under private seal on December 15, 2011,

and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary and scrutineer and
the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the

Company, presently set at five hundred twenty-four thousand five hundred one Euro (EUR 524.501,00) are present or
represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

27396

L

U X E M B O U R G

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the Company's share capital by an amount of one hundred fifty-one thousand eight hundred eighty Euro

(EUR 151.880,00) in order to raise it from its present amount of five hundred twenty-four thousand five hundred one
Euro (EUR 524.501,00) to six hundred seventy-six thousand three hundred eighty-one Euro (EUR 676.381,00) by creation
and issuance of one hundred fifty-one thousand eight hundred eighty (151.880) new ordinary shares, all with a nominal
value of one Euro (EUR 1,00) each (hereinafter referred to as the New Shares).

2. Waiver of the preferred subscription right and approval of the subscription of the New Shares by Neuheim Lux

Group Holding V, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the
laws of Luxembourg, having its registered office at 1B rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, with a share capital of four
million seven hundred forty-seven thousand eighty-three Euro (EUR 4.747.083,00) and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 137498, and full payment of the New Shares by payment in cash in the
total amount of one hundred fifty-one thousand eight hundred eighty Euro (EUR 151.880,00).

3. Subsequent amendment of the first paragraph of the article 5 of the Company's articles of association, to give it

henceforth the following content:

“ Art. 5. The share capital is set at six hundred seventy-six thousand three hundred eighty-one Euro (EUR 676.381,00)

represented by six hundred seventy-six thousand three hundred eighty (676.380) ordinary shares (hereinafter, the Or-
dinary Shares) and one (1) management share (hereinafter, the Management Share) with a nominal value of one Euro
(EUR 1,00) each.”

IV. The shareholders, after deliberation, unanimously take the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the Company's share capital by an amount of one hundred fifty-one thousand eight

hundred eighty Euro (EUR 151.880,00) in order to raise it from its present amount of five hundred twenty-four thousand
five hundred one Euro (EUR 524.501,00) to six hundred seventy-six thousand three hundred eighty-one Euro (EUR
676.381,00) by creation and issuance of one hundred fifty-one thousand eight hundred eighty (151.880) new ordinary
shares, all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

<i>Second resolution

The existing shareholders declare to waive their preferred subscription right and the meeting resolves to approve the

subscription by Neuheim Lux Group Holding V, prenamed, and the full payment of the New Shares, in the amount of
one hundred fifty-one thousand eight hundred eighty Euro (EUR 151.880,00) by payment in cash.

<i>Subscription - Payment

Neuheim Lux Group Holding V, prenamed, here represented by Ms. Sofia DaChao Conde, jurist, having her profes-

sional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal on December 15, 2011, resolves to subscribe for the New Shares and to pay the subscription price
by payment in cash in the total amount of one hundred fifty-one thousand eight hundred eighty Euro (EUR 151.880,00).

The amount of one hundred fifty-one thousand eight hundred eighty Euro (EUR 151.850,00) has been fully paid up in

cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary, who expressly acknowledges
it.

<i>Third resolution

Following the above resolutions, the meeting resolves to amend the first paragraph of the article 5 of the Company's

articles of association, to give it henceforth the following content:

“ Art. 5. The share capital is set at six hundred seventy-six thousand three hundred eighty-one Euro (EUR 676.381,00)

represented by six hundred seventy-six thousand three hundred eighty (676.380) ordinary shares (hereinafter, the Or-
dinary Shares) and one (1) management share (hereinafter, the Management Share) with a nominal value of one Euro
(EUR 1,00) each.”

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the

above resolutions are estimated at two thousand Euro (EUR 2.000,00).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of

the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

27397

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the members of the bureau and to the proxy holder of the appearing persons, who

are known to the notary by their full name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le dix-neuf du mois de décembre.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions «Island Lux

S.à r.l &amp; Partners S.C.A.», une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 154930 (ci-après désignée la Société), constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence
à Luxembourg, le 5 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 4 octobre 2010 sous le
numéro 2070, et dont les statuts ont été dernièrement modifiés par un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 31 octobre 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse

professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et comme scrutateur Melle Claudia ROUCKERT, employée privée, ayant son

adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duché de Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés en vertu de trois (3) procurations données sous acte sous seing privé le

15 décembre 2011, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le
président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il apparaît de cette liste de présence que toutes les actions en circulation représentant la totalité du capital social

de la Société, établi à cinq cent vingt-quatre mille cinq cent un Euro (EUR 524.501,00), toutes entièrement libérées, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points
portés à son ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société a concurrence de cent cinquante et un mille huit cent quatre-vingt Euro

(EUR 151.880,00) pour le porter de son montant actuel de cinq cent vingt-quatre mille cinq cent un Euro (EUR 524.501,00)
à six cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt-un Euro (EUR 676.381,00) par la création et l'émission de cent
cinquante et un mille huit cent quatre-vingt (151.880) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune (les Nouvelles Actions).

2. Renonciation au droit préférentiel de souscription et approbation de la souscription des Nouvelles Actions par

Neuheim Lux Group Holding V, une société à responsabilité limitée établie et existant en vertu du droit Luxembourg,
ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duché du Luxembourg, dont le capital social s'élève
à quatre million sept cent quarante-sept mille quatre-vingt-trois Euro (EUR 4.747.083,00) et immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 137498, et la libération totale des Nouvelles
Actions par apport en numéraire d'un montant total de cent cinquante et un mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR
151.880,00).

3. Modification de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

“ Art. 5. Le capital social de la Société s'élève à six cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt-un Euro (EUR

676.381,00) représenté par six cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt (676.380) actions ordinaires (les Actions
Ordinaires) et une (1) action de commandité (l'Action de Commandité) d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune.”

IV. Les actionnaires, après avoir délibéré, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent cinquante et un mille huit cent

quatre-vingt Euro (EUR 151.880,00) pour le porter de son montant actuel de cinq cent vingt-quatre mille cinq cent un
Euro (EUR 524.501,00) à six cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt-un Euro (EUR 676.381,00) par la création
et l'émission de cent cinquante et un mille huit cent quatre-vingt (151.880) Nouvelles Actions d'une valeur nominale d'un
Euro (EUR 1,00) chacune.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires existants décident de renoncer à leur droit préférentiel de souscription et l'assemblée décide d'ap-

prouver la souscription par Neuheim Lux Group Holding V, précitée, et le paiement de toutes les Nouvelles Actions,
d'un montant de cent cinquante et un mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR 151.880,00), par apport en numéraire.

27398

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription - Libération

Neuheim Lux Group Holding V, précitée, ici représentées par Mme Sofia DaChao Conde, juriste, ayant son adresse

professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé le 15 décembre 2011, décide de souscrire aux Nouvelles Actions par paiement en numéraire
d'un montant total de cent cinquante et un mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR 151.880,00).

Le montant de cent cinquante et un mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR 151.880,00) a été intégralement libéré en

numéraire et est maintenant à la disposition de la Société, preuve de quoi a été donnée au notaire, qui le reconnaît
expressément.

<i>Troisième résolution

Suivant les résolutions ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner

désormais la teneur suivante:

“ Art. 5. Le capital social de la Société s'élève à six cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt-un Euro (EUR

676.381,00) représenté par six cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt (676.380) actions ordinaires (les Actions
Ordinaires) et une (1) action de commandité (l'Action de Commandité) d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune.”

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués à la somme de deux mille Euro (EUR 2.000).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des

personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus

du notaire par leur nom et prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18170. Reçu soixante-quinze euros

75,00€

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2012010251/167.
(120011845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Palladium S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.048.

Suite à une réunion du conseil d'administration en date du 2 août et à une assemblée générale ordinaire tenue ex-

traordinairement le 3 août 2011, les modifications suivantes ont été adoptées:

- Nomination d'un nouveau gérant:
* Monsieur Patrick Meunier, demeurant professionnellement au siège de la société, a été nommé gérant de la société

avec effet immédiat et ce, pour une durée illimitée, en remplacement de Madame Christine Gomes.

Pour extrait sincère et conforme
Palladium SARL
Patrick Meunier
<i>Gérant

Référence de publication: 2012013601/16.
(120015730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

27399

L

U X E M B O U R G

Noctron Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8140 Bridel, 66-68, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 109.585.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 15 décembre

2011 que:

- M. Frédéric TONHOFER, prénommé, a été réélu aux fonctions d’Administrateur et d’Administrateur-délégué de la

société. Son mandat prendra fin à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra en 2012.

- la société EURO INVEST MANAGEMENT S.A., ayant son siège social au 208, route de Longwy, L-1940 Luxembourg

et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 71 129, a été réélue aux
fonctions de Commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin à l’Assemblée Générale Annuelle des
Actionnaires qui se tiendra en 2012.

- La durée du mandat d’Administrateur de M. Chen CHENGYAO, prénommé, a été modifiée. Son mandat prendra fin

à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra en 2012.

- La durée du mandat d’Administrateur de M. Michael RYCHLIK, prénommé, a été modifiée. Son mandat prendra fin

à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2012.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2012013584/24.
(120016313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Oil Ressources S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.125.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OIL RESSOURCES S.A.
Signatures
<i>Membre A / Membre B

Référence de publication: 2012013594/12.
(120015780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Orkany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 100.525.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de la société Orkany S.à r.l., décidée par acte du notaire Maître Henri Hellinckx en date du 6 décembre

2011, a été clôturée lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 décembre 2011.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents à la clôture de la liquidation

et dont la remise n'aurait pu leur être faite seront déposées à la Caisse de Consignation de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2012.

Référence de publication: 2012013590/17.
(120016520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

27400

L

U X E M B O U R G

OI-Games 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 148.838.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 19 janvier 2012.

<i>Résolution:

Le Conseil nomme Monsieur Kurt Theo Eckart Vogler, employé privé, avec adresse professionnelle au 51, boulevard

JF Kennedy, L – 1855 Luxembourg comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Michel Thill. Il terminera
le mandat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Référence de publication: 2012013593/15.
(120015914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

INNCONA S.àr.l. &amp; Cie. Cent quatre-vingt-seizième (196.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 164.390.

<i>Gesellschafterbeschluss zur Vorlage beim Luxemburgischen Handelsregister

Name der Gesellschaft:
INNCONA S.àr.l. &amp; Cie. Cent quatre-vingt-seizième (196.) S.e.c.s.
eingetragen unter RCSL B 164390
5,Baachergaass
5444 SCHENGEN
Grand-Duché de Luxembourg
Name des Versammlungsleiters: Joachim Grote
Name des Protokollführers: Joachim Grote
Name der anwesenden Teilnehmer: Joachim Grote
Name der Teilnehmer, die durch Vollmachten vertreten sind: Annemarie Jehle-Terno
Der Versammlungsleiter stellt fest, dass
- die Gesellschafterversammlung wurde ordnungsgemäß einberufen,
- die Vollmachten für die Teilnehmer, die sich durch Vollmachten vertreten lassen, ordnungsgemäß erteilt worden

sind,

- 100% des stimmberechtigten Gesellschaftskapitals anwesend sind,
- die Abstimmung durch Handzeichen zu erfolgen hat.
Sodann hat die Gesellschafterversammlung ad Tagesordnungspunkt (TOP) 11 und 12 einstimmig (zu 100% des stimm-

berechtigten Kapitals) beschlossen:

TOP 11:
Kapitalherabsetzung der Gesellschaft zum 30.06.2010 von 175.100 € um 98.600 € auf 76.500 € zum Ausgleich der in

der Bilanz zum 30.06.2009 ausgewiesen Bilanzverlustes. Die Herabsetzung soll durch folgende Herabsetzung der Nenn-
beträge der einzelnen Geschäftsanteile durchgeführt werden:

a) Der Gesellschaftsanteil der INNCONA Management Sàrl in Höhe von 100 € wird auf 0 € herabgesetzt.
b) Der Geschäftsanteil des Kommanditisten wird von 175.000 € auf 76.500 € herabgesetzt.
TOP 12:
Im Falle des positiven Beschlusses gem. TOP 11 wird § Art. 3 des Gesellschaftsvertrages wie folgt geändert:
„Gesellschafter/Kommanditisten sind:
- INNCONA Management Sàrl mit Sitz in I-5444 Schengen mit einem Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 0 €.
- Der Kommanditist, die TEMTEX Management S.A. hat einen Kommanditanteil von 76.500 €.

<i>Der Versammlungsleiter / Der Schriftführer

Référence de publication: 2012013801/38.
(120015588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.

27401

L

U X E M B O U R G

Aleris Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 115.947.

In the year two thousand eleven, the thirtieth day of December, before Maître Martine Schaeffer, notary residing in

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Aleris Luxembourg S.àr.l., a Lu-

xembourg société à responsabilité limitée with registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 115.947 (the
Company).

The Company has been incorporated on April 7, 2006 pursuant to a deed of Maître Anja Holtz, notary residing in

Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch,
Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated July 5, 2006 under
number N° 1297. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated September
5, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° 2113 of November 13, 2006.

There appeared:

Aleris Holding Luxembourg S.àr.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 11-13, Bou-

levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Register of Commerce and
Companies of Luxembourg under number B 115.961 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1) Presentation of the draft terms of the merger providing for the absorption of the Company by Aleris Holding

Luxembourg S.àr.l., a Luxembourg private limited liability company (Société à responsabilité limitée), having its registered
office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Com-
merce and Companies of Luxembourg under number B 115.961;

2) Acknowledgement that the documents required by article 267 of the law of 10 August 1915 on commercial com-

panies, as amended (the Law) have been deposited at the registered office of the Company for due inspection by the
shareholder of the Company at least one month before the date hereof;

3) Approval of the draft terms of the merger and decision to carry out the merger by way of the absorption of the

Company;

4) (i) Dissolution without liquidation of the Company by way of transfer of all assets and liabilities of the Company to

Aleris Holding Luxembourg S.àr.l., prenamed, in accordance with the draft terms of merger and (ii) cancellation of all the
shares issued by the Company;

5) Acknowledgment (i) that from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated as having

being carried out on behalf of Aleris Holding Luxembourg S.àr.l. as from November 29, 2011 and (ii) that the merger will
take effect (a) between the merging companies on the date of the concurring general meetings of the shareholders of the
merging companies approving the merger and (b) vis-à-vis third parties after the publication of the minutes of the general
meetings of shareholders prescribed by article 9 of the Law;

6) Full and complete discharge granted to the members of the board of managers of the Company for the performance

of their respective mandates;

7) Determination of the place where the Company's corporate documents will be kept during the period of time

required by the Law;

8) Empowerment and authorisation of any lawyer and any employee of Loyens &amp; Loeff in Luxembourg, acting indivi-

dually as agent of the Company, with full power of substitution, to execute any documents and to perform any actions
and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger; and

9) Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

27402

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Sole Shareholder notes that the board of managers of the Company has presented to it the draft terms of the

merger dated November 25, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° -2923 of
November 30, 2011 (the Merger Proposal), in accordance with article 262 of the Law and providing for the absorption
of the Company by Aleris Holding Luxembourg S.àr.l., prenamed (the Absorbing Company or the Sole Shareholder),
whereby the merger shall be carried out by the transfer, further to the dissolution without liquidation, of all the assets
and liabilities, without any restriction or limitation, of the Company to the Absorbing Company.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder acknowledges that all the documents required by article 267 of the Law have been deposited

at the registered office of the Company for due inspection by the shareholder of the Company at least one month before
the date hereof.

A certificate attesting the deposit of the above mentioned documents, duly signed by an authorised representative of

the Company, shall remain annexed to the present deed.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the Merger Proposal and to carry out the merger by way of the absorption

of the Company by the Absorbing Company, in accordance with the conditions detailed in the Merger Proposal.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves, as a consequence of the preceding resolutions, (i) to dissolve the Company without

liquidation by way of transfer of all its assets and liabilities to the Absorbing Company in accordance with the Merger
Proposal and (ii) to cancel all the shares issued by the Company.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder acknowledges that (i) that from an accounting point of view, the operations of the Company

shall be treated as having being carried out on behalf of the Absorbing Company as from November 29, 2011 and (ii) that
the merger shall take effect (a) between the merging companies on the date of the concurring general meetings of the
shareholders of the merging companies approving the merger (the Effective Date) and (b) vis-à-vis third parties after the
publication of the minutes of the general meetings of shareholders prescribed by article 9 of the Law.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder further notes that the mandates of the members of the board of managers of the Company will

end on the Effective Date of the merger.

The Sole Shareholder resolves to grant full and complete discharge to the members of the board of managers of the

Company for the performance of their respective mandates until the Effective Date of the merger.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to keep the corporate documents of the Company at the registered office of the

Absorbing Company during the period of time required by the Law.

<i>Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to empower and authorise any lawyer and any employee of Loyens &amp; Loeff in Luxem-

bourg, acting individually as agent of the Company, with full power of substitution, to execute any documents and to
perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger.

<i>Declaration

The undersigned notary states in accordance with article 271 (2) of the Law having verified and certifies the existence

and legality of all acts and formalities incumbent to the Company and of the Merger Proposal.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Absorbing Company as a

result of the present deed, in accordance with the terms of the merger, are estimated at approximately EUR 1,200.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed

is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version shall prevail.

The document having been read to the appearing parties, the members of the Bureau signed together with the notary,

the present original deed.

27403

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le trentième jour de décembre, par devant Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Lu-

xembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Aleris Luxembourg S.àr.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 47 boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 115.947 (la Société).

La Société a été constituée le 7 avril 2006 suivant un acte de Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz, Grand-

Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, Grand-
Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1297 du 5 juillet 2006. Les statuts
de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 5 septembre 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, N° 2113 du 13 novembre 2006.

A comparu:

Aleris Holding Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.961 (l'Associé Unique),

ici représentée par Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-

parante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des
autorités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital de la Société.
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1) Présentation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la Société par Aleris Holding Luxembourg S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 47 boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 115.961;

2) Constatation que les documents tels que requis par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales, telle que modifiée (la Loi) ont été déposés au siège social de la Société pour inspection par l'associé de la
Société au moins un mois avant la date des présentes.

3) Approbation du projet de fusion et décision d'accomplir la fusion par absorption de la Société;
4) (i) Dissolution sans liquidation de la Société par voie de transfert de tous ses actifs et passifs à Aleris Holding

Luxembourg S.à r.l. conformément au projet de fusion et (ii) annulation de toutes les parts sociales émises par la Société;

5) Constatation (i) que d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme étant

réalisées au nom de Aleris Holding Luxembourg S.à r.l. à compter du 29 novembre 2011 et (ii) que la fusion prendra effet
(a) entre les sociétés qui fusionnent à la date des décisions concordantes des assemblées générales des associés des
sociétés qui fusionnent approuvant la fusion et (b) vis-à-vis des tiers après la publication du procès-verbal des assemblées
générales des associés conformément à l'article 9 de la Loi;

6) Décharge pleine et entière accordée aux membres du conseil de gérance de la Société pour l'accomplissement de

leurs mandats respectifs;

7) Détermination du lieu où les documents sociaux de la Société seront conservés pendant la période de temps exigée

par la Loi;

8) Pouvoir et autorité à tout avocat et tout employé de Loyens &amp; Loeff à Luxembourg, agissant individuellement comme

agent de la Société, avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter tous documents et d'accomplir toutes les actions
et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la fusion; et

9) Divers.
III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique constate que le conseil de gérance lui a présenté le projet de fusion daté du 25 novembre 2011,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. – 2923 du 30 novembre 2010 conformément à l'article
262 de la Loi et prévoyant l'absorption de la Société par Aleris Holding Luxembourg S.à r.l., précitée (la Société Absorbante
et l'Associé Unique), la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l'ensemble des
actifs et passifs, sans exception ni réserve, de la Société à la Société Absorbante (le Projet de Fusion).

27404

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique prend acte que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été déposés au siège social

de la Société pour inspection par l'associé de la Société au moins un mois avant la date des présentes.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents, signée par un représentant autorisé de la Société restera annexée

au présent acte.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'approuver le projet de fusion et d'accomplir la fusion par absorption de la Société par la

Société Absorbante, en conformité avec les conditions détaillées dans le Projet de Fusion.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide, en conséquence des résolutions précédentes, (i) de dissoudre sans liquidation la Société par

voie de transfert de tous ses actifs et passifs à la Société Absorbante conformément au Projet de Fusion et (ii) d'annuler
toutes les parts sociales émises par la Société.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique constate (i) que d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme

accomplies pour le compte de la Société Absorbante, à compter du 29 novembre 2011 et (ii) que la fusion prendra effet
(a) entre les sociétés qui fusionnent à la date des décisions concordantes des assemblées générales des associés des
sociétés qui fusionnent approuvant la fusion (la Date Effective) et (b) vis-à-vis des tiers après la publication du procès-
verbal des assemblées générales des associés conformément à l'article 9 de la Loi.

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique prend également acte que les mandats des membres du conseil de gérance de la Société pendront

fin à la Date Effective de la fusion.

L'Associé Unique décide de donner décharge pleine et entière aux membres du conseil de gérance de la Société pour

l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à la Date Effective de la fusion.

<i>Septième résolution

L'Associé Unique décide que tous les documents sociaux de la Société seront gardés au siège social de la Société

Absorbante pendant la période de temps requise par la Loi.

<i>Huitième résolution

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autorité à tout employé de Loyens &amp; Loeff à Luxembourg, agissant

individuellement comme agent de la Société, avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter tous documents et d'ac-
complir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la fusion.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité

des actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

Absorbante au titre du présent acte, conformément au projet de fusion, est estimé à approximativement EUR 1.200,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la demande de la même partie comparante en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du document faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé ensemble avec le notaire,

le présent acte.

Signé: V. Schmitt et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 janvier 2012. LAC/2012/1033. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2012.

Référence de publication: 2012010005/211.
(120012027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

27405

L

U X E M B O U R G

ICG EFV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 163.939.

In the year two thousand and eleven on the twenty-ninth day of December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

ICG Europe Fund V No. 1 Limited Partnership, a limited partnership incorporated under the laws of Jersey, having its

registered office at Liberté House, 19-23 La Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY and registered with the Companies
Registry of the Jersey Financial Services Commission (the “Jersey Registry”) under number 1377, acting by its general
partner ICG Europe Fund V GP Limited Partnership, a limited partnership incorporated under the laws of Jersey, having
its registered office at Liberté House, 19-23 La Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY and registered with the Jersey
Registry under number 1374, itself acting by its general partner ICG Europe Fund V GP Limited, a company incorporated
under the laws of Jersey, having its registered office at Liberté House, 19-23 La Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY
and registered with the Jersey Registry under number 107484,

hereinafter referred to as the “Sole Shareholder”,
here represented by Mrs. Petra Magerotte, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private

seal.

The said proxy after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. The Sole Shareholder own 100% of the share capital of ICG EFV Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, with registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Luxembourg, registered with the Trade and Company
Registry of Luxembourg under number B 163939, incorporated by deed of the undersigned notary on 1 September 2011,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2882 of 25 November 2011, page 138290
(the “Company”).

II. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the

basis of the following agenda:

<i>Agenda

a. Change of the financial year of the Company so that it begins of the first (1) of April and ends on the thirty-first (31)

of March of the following year;

b. Subsequent amendment of article 11.1 of the articles of association of the Company;
c. Miscellaneous.
The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to change the financial year of the Company so that it begins on the first (1) of April

of each year and ends on the thirty-first (31) of March of the following year.

The Sole Shareholder RESOLVES that the first financial year of the Company will end on 31 March 2012.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder RESOLVES to amend article 11.1 of the articles of

association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ 11.1. Fiscal year. The Company's fiscal year starts on the 1 

st

 of April and ends on the 31 

st

 of March of following

year, with the exception of the first year, which shall being on the date of the formation of the Company and shall terminate
on the 31 

st

 of March 2012.”

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

27406

L

U X E M B O U R G

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing and intervening parties, he signed together with

the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché du Luxembourg,

ONT COMPARU:

ICG Europe Fund V No. 1 Limited Partnership, un limited partnership constitué sous les lois de Jersey, ayant son siège

social au Liberté House, 1923 La Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY et enregistré auprès du Registre des Sociétés
de la Commission des Services Financiers de Jersey (Companies Registry of the Jersey Financial Services Commission -le
“Registre de Jersey”) sous le numéro 1377, agissant par l'intermédiaire de son general partner ICG Europe Fund V GP
Limited Partnership, un limited partnership constitué sous les lois de Jersey, ayant son siège social au Liberté House, 19-23
La Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY et enregistré auprès du Registre de Jersey sous le numéro 1374, lui-même
agissant par l'intermédiaire de son general partner ICG Europe Fund V GP Limited, une société constituée sous les lois
de Jersey, ayant son siège social au Liberté House, 19-23 La Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY et enregistrée auprès
du Registre de Jersey sous le numéro 107484,

ci-après l'«Associé Unique»
ici représenté par Mme Petra Magerotte, Avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous

seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant,

annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L' Associé Unique détient 100% du capital social de ICG EFV Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée,

ayant son siège social au 33, rue de Gasperich, L-5826 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Société du
Luxembourg sous le numéro B 163939, constituée par un acte du notaire soussigné le 1 septembre 2011, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2882 du 25 novembre 2011, page 138290 (la «Société»).

II. Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, reconnaît avoir été pleinement informé des résolutions à pren-

dre sur la base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

a. Changement de l'exercice social de la Société de telle façon que ledit exercice social commence le premier (1) avril

de chaque année et se termine le trente-et-un (31) mars de l'année suivante;

b. Modification subséquente de l'article 11.1 des statuts de la Société;
c. Divers.
L'Associé Unique a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique DÉCIDE de changer l'exercice social de la Société de telle façon que ledit exercice social commence

le premier (1) avril de chaque année et se termine le trente-et-un (31) mars de l'année suivante.

L'Associé Unique DÉCIDE que le premier exercice social de la Société se terminera le 31 mars 2012.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l'Associé Unique DÉCIDE de modifier l'article 11.1 des statuts de la Société qui aura désormais la

teneur suivante:

« 11.1. L'exercice social. L'année social commence le 1 

er

 avril et se termine le 31 mars de l'année suivante, à l'exception

de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 mars 2012.»

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à la charge de

la Société à raison des présentes sont évalués à environ MILLE TROIS CENTS EUROS (€ 1.300,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent procès-verbal en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, le mandataire des comparants a signé avec Nous notaire le présent procès-

verbal.

27407

L

U X E M B O U R G

Signé: Magerotte Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 janvier 2012. Relation: EAC/2012/371. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012011043/113.
(120012338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Zuma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 86.934.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Ernst Krister TÖRNING, industriel, demeurant à L-1219 Luxembourg, 16 rue Beaumont, ici représenté par

Monsieur Arsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'un pou-
voir sous seing- privé lui délivré à Luxembourg, le 12 octobre 2011, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par
son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lequel comparant ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- Qu’il existe une société anonyme sous la dénomination de «ZUMA S.A.», avec siège social à L-1219 Luxembourg,

17 rue Beaumont, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du
22 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1020 en date du 4 juillet 2002.

II.- Que le capital social souscrit et libéré intégralement est fixé à trente et un mille euros (31.000.- euros) représenté

par trois cent dix actions (310), de cent euros (100.- €) chacune.

III.- Que son mandant, Monsieur Ernst Krister TÖRNING, est devenu successivement propriétaire des trois cent dix

actions (310), et qu’il déclare expressément dissoudre et liquider la société à compter de ce jour, celle-ci ayant cessé
toute activité.

IV.- Que son mandant connaît parfaitement la situation financière et les statuts de la société.
V.- Que son mandant, actionnaire unique, se considérant comme liquidateur, déclare avoir réglé ou provisionné tout

le passif de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même
inconnus à ce jour.

VI.- Que son mandant donne décharge expresse aux administrateurs, administrateur-délégué et au commissaire aux

comptes pour l’exécution de leur mandat jusqu’à la date de l’acte notarié.

VII.- Qu’il remet au notaire les certificats des actionnaires de la société en sa possession pour destruction.
VIII.- Que partant la liquidation de la société est achevée.
IX.- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq (5) années au domicile de

l’actionnaire unique Monsieur Ernst Krister TÖRNING, actuellement demeurant à Luxembourg, 16 rue Beaumont.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à

sa charge à raison du présent acte, s'élèvent à la somme de HUIT CENTS EUROS (EUR 800.-).

DONT acte, fait est passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Kronshagen, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17656. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): THOMA.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2012.

Référence de publication: 2012012569/45.
(120014218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

27408


Document Outline

Aleris Luxembourg S.à r.l.

Alter Domus Holding S.à r.l.

Atlantas Sicav

Axa World Funds

Bake Holdco 1 SA

Dalgarno S.A.

d'Amico International Shipping S.A.

Delvino S.A.

Digital Funds

Financière Joseph II SPF S.A.

GE Financing (Luxembourg) S.à r.l.

GE Holdings Forint Luxembourg Sàrl

GE UK FINANCING (Luxembourg) S.à r.l.

Hortense S.A.

ICG EFV Luxembourg S.à r.l.

INNCONA S.àr.l. &amp; Cie. Cent quatre-vingt-seizième (196.) S.e.c.s.

Island Lux S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.

Le Monterey S.à r.l.

Motor Development International S.A.

MUGC/WA U.S. Credit BBB/BB Fund

Nika

Noctron Soparfi S.A.

OI-Games 2 S.A.

Oil Ressources S.A.

Omega Finances Sàrl

Orkany S.à r.l.

Palladium S.à r.l.

Partners Group (Luxembourg) S.à r.l.

Philos Asset Management

Philos Currency Fund

Prahy Invest G.m.b.H.

Prahy Invest G.m.b.H.

Prahy Invest G.m.b.H.

Prahy Invest G.m.b.H.

Premier Tax

Primus Equity Group S.A.

Primus Equity Group S.A.

Tuomi IT S.A.

Tuomi IT S.A.

Tuomi S.A.

Tuomi S.A.

Value Invest

Victoria Real Estate S.A.

Victoria Real Properties S.C.

Weatherford Holding (Luxembourg) S.à r.l.

Zuma S.A.