This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 67
10 janvier 2012
SOMMAIRE
1798 European Credit Opportunities Mas-
ter Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3201
1798 European Loan Master Fund . . . . . . .
3201
Allianz European Pension Investments . . .
3189
Allianz Global Investors Fund . . . . . . . . . . .
3189
Apta Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3193
BC Chime S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3215
BeLux Enterpises Consulting s.à r.l. . . . . . .
3208
Brasseur Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3215
C.I.I. Luxembourg, Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
3214
Clariden Leu Fund Management (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3215
Codic Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
3200
Creola S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3181
Cygnus Real Estate Fund . . . . . . . . . . . . . . . .
3204
Digital Investments S.C.A., SICAR . . . . . . .
3209
EFCO-Forodia Exploitation S.à r.l. . . . . . . .
3209
E/Shelter S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3197
Eurizon Riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3204
Euromel Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
3215
exceet Group SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3207
F&C Portfolios Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3175
Fivecom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3190
Giusa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3215
HAIG Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3197
HAIG Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3197
ING International Currency Management
Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3193
ING (L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3182
ING (L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3184
ING (L) Patrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3186
ING (L) Renta Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3183
LU GE III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3216
LU GE II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3216
Mantera S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3184
Min Asset Management S.A. . . . . . . . . . . . .
3207
Morsa Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3187
Muse Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3187
Najade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3184
navAXX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3208
Nordea Fund of Funds, SICAV . . . . . . . . . .
3187
Olympia SICAV Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3196
Opera - Participations 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
3216
Orco Germany S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3176
Orco Germany S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3170
Pareturn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3192
Pegasos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3195
Pegasos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3196
Pelham e-shelter Berlin S.à r.l. . . . . . . . . . .
3201
Pioneer CIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3204
Record Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3186
RP Rendite Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3188
SEB Multi-Manager Currency Defensive
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3209
Wiesen-Piront Constructions S.A. . . . . . . .
3209
Woodbridge International Holdings S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3204
WPA Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3204
Yucatan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3207
3169
L
U X E M B O U R G
Orco Germany S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 102.254.
A GENERAL MEETING
of the holders of the warrants (the "Warrantholders"), registered under ISIN code: XS0302626899 (the "OG War-
rants") as described under the Prospectus (as defined below) issued by the Company under the issue of the €
100,100,052.00 bonds registered under ISIN code: XS0302623953 (the "OG Bonds") with redeemable OG Warrants
attached on May 24, 2007 pursuant to a prospectus approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier
(the "CSSF") on May 24, 2007 (the "Prospectus"), will be held at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, on <i>January 27, 2012i> at 3:00 PM Central European time ("CET") (the "2012 Warrantholders Meeting"),
in order to consider and resolve on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the terms and conditions of the proposal to the holders of all the OG Bonds to substitute their OG
Bonds by Obligations Convertibles en Actions (the "OCA") to be issued by Orco Property Group S.A. ("OPG"),
a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies (the "RCS") under
number B 44996 ("OG Conversion"), and approval of all steps and actions in connection with the OG Conversion,
including but not limited to the entering into and performance of all the transactions, documents, agreements
contemplated, needed or useful in connection with the OG Conversion;
2. Miscellaneous.
Please refer to Annex A attached to the present notice and the Company's website at www.orcogermany.de for further
details pertaining to the proposed OG Conversion.
Please refer to Annex B attached to the present notice and the Company's website at www.orcogermany.de for further
details regarding the proposed terms and conditions of the OCA.
The 2012 Warrantholders Meeting shall not validly deliberate on the agenda mentioned above, unless at least one half
of the total number of the OG Warrants outstanding at the time of the 2012 Warrantholders Meeting is represented.
If such proportion of the total number of the OG Warrants is not met, a second meeting may be convened, by means
of notices published twice at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations and in two Luxembourg newspapers. The second meeting shall validly deliberate regardless
of the proportion of the OG Warrants represented.
At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least three quarters (3/4) of the votes
cast by the Warrantholders present or represented.
The Warrantholders participation form which is necessary to participate to the 2012 Warrantholders Meeting is at
the disposal of the Warrantholders from January 10, 2012 at the registered office of the Company upon request or
downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial interme-
diaries or to the relevant central registration bank.
Auditor's reports on review of interim financial information of the Company and of OPG, as at November 30, 2011,
are at the disposal of the Warrantholders from January 10, 2012 at the registered office of the Company upon request
or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de (OPG's board of directors report also on OPG's
website at www.orcogroup.com) or ultimately upon request to the financial intermediaries or to the relevant central
registration bank.
A report of the Company's board of directors, as well as a report of the OPG's board of directors, explaining the
reasons of the OG Conversion, are at the disposal of the Warrantholders from January 10, 2012 at the registered office
of the Company upon request or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon
request to the financial intermediaries or to the relevant central registration bank.
Copies of the Prospectus, the articles of association of the Company and the proposed terms and conditions of the
OG Conversion are available on the Company's website at www.orcogermany.de and at the registered office of the
Company upon request.
The board of directors of the Company would like to point out that for Warrantholders whose ownership is directly
or indirectly recorded in the warrant registry of the Company, the conditions for attendance or representation at the
2012 Warrantholders Meeting are as follows:
1. Conditions for personal attendance
(i) Warrantholders whose ownership is indirectly recorded in the warrant registry of the Company
Warrantholders whose ownership is indirectly recorded in the warrant registry of the Company and who elect to
attend the 2012 Bondholders Meeting in person must use their usual applicable contacting method for informing their
financial intermediary, with whom their OG Bonds are on deposit, accordingly. They must further request their financial
3170
L
U X E M B O U R G
intermediary, with whom their OG Bonds are on deposit, to send a Bondholders blocking certificate (the "Bondholders
blocking certificate") for their OG Bonds to the relevant central registration bank no later than 5 business days prior to
the 2012 Bondholders Meeting.
Such blocking certificate must indicate clearly the precise identity of the Bondholder, the number of OG Bonds being
blocked, the date such OG Bonds are being blocked, which must be no later than January 20, 2012 and a statement that
the relevant OG Warrants are registered in the local bank or brokers records in the holder's name and shall be blocked
until the close of the 2012 Warrantholders Meeting.
The Warrantholders must bring a copy of the Warrantholders blocking certificate to the 2012 Warrantholders Meet-
ing.
The Warrantholders shall also announce their intention to participate at the 2012 Warrantholders Meeting by com-
pleting, signing, dating and returning on no later than January 20, 2012 at the latest to the relevant central registration
bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol
or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique"), the Warrantholders participation form that can be obtained at the
registered office of the Company upon request or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de
or ultimately upon request to the financial intermediaries or the relevant central registration bank.
(ii) Warrantholders whose ownership is directly recorded in the warrant registry of the Company
Warrantholders whose ownership is directly recorded in the warrant registry of the Company, shall announce their
intention to participate to the 2012 Warrantholders Meeting by completing, signing, dating and returning on January 20,
2012, at the latest to the relevant central registration bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la
Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique") the War-
rantholders participation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or downloaded
from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries or the
relevant central registration bank.
2. Conditions for proxy voting or granting a mandate
(i) Warrantholders whose ownership is indirectly recorded in the warrant registry of the Company
Warrantholders whose ownership is indirectly recorded in the warrant registry of the Company and who are unable
to attend the 2012 Warrantholders Meeting in person, may give a voting instruction to a third party that the Warran-
tholder designates.
Prior to giving voting instructions to a proxy, this Warrantholder must a) have obtained and delivered to the relevant
central registration bank the Warrantholders blocking certificate described above (see "Conditions for personal atten-
dance"), and b) complete, sign and date the Warrantholders participation form that can be obtained at the registered
office of the Company upon request or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately
upon request to the financial intermediaries or the relevant central registration bank, indicating the name of the proxy.
The completed, signed and dated Warrantholders participation form must be returned to the relevant central regis-
tration bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe
Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique") no later than January 20, 2012, at the latest, in order to have
that name recorded on the registration list of the 2012 Warrantholders Meeting.
If a Warrantholder wishes to be represented by a proxy other than the Chairman of the 2012 Warrantholders Meeting,
then this holder must (a) have obtained and delivered to the relevant central registration bank the Warrantholders
blocking certificate described above (see "Conditions for personal attendance"), and (b) complete, sign and date the
Warrantholders participation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or down-
loaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries
or the relevant central registration bank, indicating the name of the proxy. The completed, signed and dated Warran-
tholders participation form must be returned to the relevant central registration bank or to the Company (C/O "Orco
Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, dépar-
tement juridique") no later than January 20, 2012, at the latest, in order to have that name recorded on the registration
list of the 2012 Warrantholders Meeting.
Warrantholders who have obtained the Warrantholders blocking certificate and have executed a Warrantholders
participation form but who wish to revoke such proxy may do so at any time by timely delivering a properly executed,
later dated participation form no later than January 20, 2012, at the latest, or by properly attending and voting in person
at the 2012 Warrantholders Meeting.
Simply attending the 2012 Warrantholders Meeting without voting will not revoke the proxy.
(ii) Warrantholders whose ownership is directly recorded in the warrant registry of the Company.
Warrantholders whose ownership is directly recorded in the warrant registry of the Company must complete, sign
and date the Warrantholders participation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request
or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial inter-
mediaries or the relevant central registration bank.
3171
L
U X E M B O U R G
The completed, signed and dated Warrantholders participation form must be returned to the relevant central regis-
tration bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe
Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique") no later than January 20, 2012, at the latest.
3. Request for information and central registration banks
Warrantholders looking for more information can do so by:
(i) contacting the Company's services directly:
* At the registered office of the Company - Legal Department
Tel.: +352 26 47 67 1
Fax.: +352 26 47 67 67
(ii) contacting one of the central registration banks :
* For OG Warrants that are included in the Clearstream Banking or Euroclear Bank system and that are admitted to
trading on the Euro MTF:
BNP Paribas Security Services - Lucie Maiore, Emmanuel Gérard
33 rue Gasperich Howald,
Hesperange L-2085, Luxembourg
Tel: +352 26 96 23 89, +352 26 96 62 445
lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com
Luxembourg, January 10, 2011.
<i>The Board of directors of the Com-i>
<i>pany.i>
Annex A:
PROPOSED TERMS AND CONDITIONS OF THE OG CONVERSION
Subject to compliance with Luxembourg laws and to the granting of all the regulatory approval (in particular the decision
from the CSSF confirming that in the context of the proposed OG Conversion, the Bondholders are not obliged to launch
a takeover bid), the OG Bonds will be converted for their total nominal amount and accrued interest (app. EUR 129.1
Million consisting of the nominal value, premium and coupon interest as at the maturity date) into OCA to be issued by
OPG on 31 January 2012 (the "Conversion Date") which are convertible as follows:
* OCA in an aggregate nominal amount of EUR 79,100,000 are converted into 19,250,010 newly issued ordinary shares
of OPG (ISIN LU0122624777, "OPG Shares") on or about 31 January 2012 (the "Upfront Conversion");
* OCA in an aggregate nominal amount of around EUR 50,000,000 convertible into shares of OG or OPG, as further
detailed below:
- Each OCA will bear an interest of 0.01% and shall have a maturity of 15 April 2012 or any subsequent date agreed
to by the holders of OCA at the relevant majority in a meeting of holders of OCA (the "Exchange Date");
- The holders of the OCA shall benefit from a lien on 55% of all shares issued by OG (ISIN LU0251710041, "OG
Shares"), including current OG Shares and the New OG Shares (as defined below)) held by OPG as collateral in a separate
securities account that will be pledged to the holders of OCA (a nantissement de compte d'instruments financiers or any
equivalent security under Luxemburg law), for the repayment in cash of such OCA in accordance with the provisions
below;
- If and provided that the OPG Bond Conversion Condition (as defined below) is met three business days prior to the
Exchange Date, the remaining OCA are converted into 54 OPG Shares per one OCA;
- if and provided the OPG Bond Conversion Condition is not met three business days prior to the Exchange Date
such remaining OCA will, at the option of OPG be (a) repaid in a cash amount of EUR 337.66 per one OCA or (b) in
case such cash amount is not paid by OPG and subject to a decision made by the holders of OCA (at a 50% plus 1 OCA
majority of all the OCA outstanding) to convert all of the remaining OCA into either (i) 54 OPG Shares per one OCA
or (ii) a number of OG Shares equivalent to 55% of the fully diluted capital of OG post equitization of the OG Bonds by
OPG. In the event no cash repayment is made by OPG, the election decision of the OCA holders in this case will not be
required by April 12th but can extend as necessary to allow for proper notice period, quorum, and majority decision.
The OG Shares pledged and held as collateral shall remain pledged until such election is made. No new OG Shares can
be issued during this time without 55% of those new shares also being added to the pledged collateral.
- OPG will prior to maturity of the OCA (subject to Luxembourg laws and the regulatory formalities, corporate
decisions and notice periods being complied with both at the level of OG and OPG) convert the EUR 129.1 Million
including the accrued coupons of OG Bonds into additional OG Shares based on the volume weighted average price of
OG Shares on the Frankfurt stock exchange over a period of 6 (six) months prior to the Conversion Date (the "New
OG Shares").
For the purposes of the OG Conversion, the "OPG Bond Conversion Condition" is met if 3 business days before the
Exchange Date, 65% of all OPG Bonds (as defined below, in terms of nominal value) have been converted into a combi-
nation of (i) OPG Shares at a value of EUR 6.40 (on the basis that up to 64,000,000 new OPG shares may be issued in
order to equitize 100% of 410,000,000 of nominal of OPG Bonds, to be reduced proportionally in accordance with the
3172
L
U X E M B O U R G
actual number of OPG Bonds equitized) or higher, or (ii) bonds issued by OPG with a coupon of 0.5% per annum with
a maturity in 2050.
This time frame can be extended at the request of OPG if the negotiations with the OPG Bondholders are well advanced
as of 1 April 2012 and provided that such extension is agreed by a decision of the holders of OCA (taken in accordance
with the quorum and majority provisions provided for by law in a meeting of holders of OCA convened to extend the
Exchange Date, i.e. the decision can only validly be taken if at least one half of the OCA outstanding are present or
represented at that meeting. If such proportion of the total number of the OCA is not met, a second meeting shall be
convened and such second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the OCA present or repre-
sented. At both meetings, decisions in order to be adopted must be approved by at least two third of the votes cast).
The OPG Bond Conversion Condition shall be met on the date when the substitution of the relevant OPG Bonds into
OPG Shares has been approved by the relevant bondholders' meetings, and warrantholders' meetings (as appropriate)
and the shareholders' meeting of OPG.
The total number of new OPG Shares issued as a result of the Upfront Conversion shall be 19,250,010. Furthermore,
an additional number of 7,996,158 OPG Shares may be issued on or around the Exchange Date subject to and in accor-
dance with the provisions described above.
The new OPG Shares issued as a result of the OG Conversion and the OPG Conversion shall be referred to as the
"New OPG Shares".
For the purposes of the OPG Bond Conversion Condition, the OPG Bonds means:
* EUR 50,272,605.30 bonds with subscription rights attached issued by OPG on 18 November 2005 (the "OPG Bonds
2010");
* CZK 300,000,000.00 bonds issued by OPG on 3 February 2006 (the "OPG Bonds 2011"). As of the date of this Term
Sheet EUR 11,631,934 of nominal OPG Bonds 2011 remain outstanding;
* EUR 24,169,193.39 bonds issued by OPG on 30 June 2005 (the "OPG Bonds 2012");
* EUR 149,999,928.00 convertible bonds issued by OPG on 1 June 2006 (the "OPG Bonds 2013");
* EUR 175,000,461.60 bonds with subscription rights attached issued by OPG on 28 March 2007 (the "OPG Bonds
2014").
(OPG Bonds 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 jointly as the "OPG Bonds", and the holders of the OPG Bonds as the
"OPG Bondholders").
Annex B:
SUMMARY OF THE PROPOSED TERMS AND CONDITIONS OF THE OCA
(Obligations Convertibles en Actions)
Context
Orco Property Group S.A. ("OPG"), a Luxembourg Société Anonyme having its registered office at 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered in Luxembourg with the Luxembourg register of com-
merce and companies (the "RCS") under the number B 44996, wishes to substitute all the EUR 100,100,052 five years
bonds with redeemable warrants attached thereto ("OG Bonds") issued on 30 May 2007 by Orco Germany S.A. ("OG"),
a Luxembourg Société Anonyme having its registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and registered in Luxembourg with the Luxembourg register of commerce and companies (the "RCS") under
the number B 102254, into OCA to be issued by OPG (the "Convertible Bonds") on 31 January 2012 (the "Conversion
Date"). The Convertible Bonds are convertible as follows:
- The Convertible Bonds in an aggregate nominal amount of EUR 79,100,000 are immediately converted into 19,250,010
OPG shares on or about 31 January 2012;
- The Convertible Bonds in an aggregate nominal amount of EUR 49,999,451.68 are later to the Conversion Date,
payable in cash or convertible into shares of OG or OPG, provided that the specific conditions detailed in the terms and
conditions of the Convertible Bonds are satisfied.
Orco Property Group has the following outstanding bonds (the "OPG Bonds"):
* EUR 50,272,605.30 bonds with subscription rights attached issued by OPG on 18 November 2005
* CZK 300,000,000.00 bonds issued by OPG on 3 February 2006
* EUR 24,169,193.39 bonds issued by OPG on 30 June 2005
* EUR 149,999,928.00 convertible bonds issued by OPG on 1 June 2006
* EUR 175,000,461.60 bonds with subscription rights attached issued by OPG on 28 March 2007
The main characteristics of the Convertible Bonds are set out in the following table:
Issuer of Con-
vertible Bonds
OPG
Share capital of
OPG
EUR 69,920,850.60 divided into 17,053,866 shares
3173
L
U X E M B O U R G
Legal form of
OPG
Public limited liability company, Société Anonyme, registered in Luxembourg with a Board of Directors
FTSE activity
segment
862-Real Estate Holding and Development
Number of OG
Bonds to be
converted
148,077
Number of
Convertible
Bonds to be is-
sued
148,077
Form of the
Convertible
Bonds
Registered form
Total nominal
amount of the
Convertible
Bonds
EUR 129,099,451.68
Issue Price of
Convertible
Bonds
EUR 871.84
Issuance Price of
Convertible
Bonds Payment
Exchange of one OG Bond against one Convertible Bond
Convertible
Bonds Payments
Issue of the Convertible Bonds in two payments:
- one corresponding to EUR 79,100,000 (the "First Payment")
- the second corresponding to EUR 49,999,451.68 (the "Second Payment")
Issue Date
31 January 2012
Maturity Date of
the First Pay-
ment
1 February 2012
Maturity Date of
the Second Pay-
ment
15 April 2012 (the "Maturity Date")
Gross Yearly
Coupon on the
Second Payment
0.01% paid on the Maturity Date
Bondholders
Conversion
Rights
- Mandatory conversion of the First Payment on the Issue Date
- Mandatory conversion of the Second Payment on the Maturity Date
Convertible
Bonds Conver-
sion Condition
for the Second
Payment
3 business days prior to the Maturity Date, 65% of all OPG Bonds (in terms of nominal value) have been
converted into a combination of (i) OPG shares at a value of EUR 6.40 (on the basis that up to 64,000,000
new OPG shares may be issued in order to equitize 100% of 410,000,000 of nominal of OPG bonds, to
be reduced proportionally in accordance with the actual number of OPG bonds equitized) or higher or
(ii) bonds issued by OPG, with a coupon of 0.5% per annum with a maturity in 2050
Exchange Parity
of the Converti-
ble Bonds
* For the First Payment:
EUR 79,100,000 are converted into 19,250,010 OPG shares, pursuant to the ratio of 1 OCA converted
in 130 OPG shares,
* For the Second Payment, one Convertible Bond carries entitlement to:
- If the Convertible Bonds Condition is met, 54 OPG new shares,
- If the Convertible Bonds Condition is not met :
(i) at the option of OPG, a reimbursement in cash of EUR 337.66 or
(ii) in case such cash amount is not paid by OPG and subject to a decision made by the holders of
Convertible Bonds of the Second Payment (at a 50% plus 1 Second Payment Convertible Bond majority
of all the Second Payment Convertible Bonds outstanding) to convert all of the remaining Second Pay-
ment Convertible Bonds into either:
(a) 54 shares of OPG per one Second Payment Convertible Bond or
(b) a number of OG shares equivalent to 55% of the fully diluted capital of OG post equitization of the
OG Bonds by OPG.
3174
L
U X E M B O U R G
Security
The holders of the Second Payment Convertible Bonds shall benefit from a lien on 55% of all shares
issued by OG (including current OG shares and the new OG shares) held by OPG as collateral in a
separate securities account that will be pledged to the holders of Second Payment Convertible Bonds
(a nantissement de compte d'instruments financiers or any equivalent security under Luxemburg law),
for the repayment in cash of such Second Payment Convertible Bonds.
Lock-up
100% of the new OPG shares will be register shares and be subject to a lock-up until the Maturity Date
of the Second Payment, after which they will be freed
Representation
of the Second
Payment Con-
vertible
Bondholders
The representative of the Convertible Bondholders is Mr Lionel BOTBOL
In addition to its general task of representation of the Second Payment Convertible Bondholders in
accordance with article 88 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, the representative
will:
- keep on behalf of the bondholders the Convertible Bonds not claimed by the initial OG bondholders
when issued and will ensure to transfer the relevant Convertible Bonds to the relevant bondholders
upon request;
- ensure that all Convertible Bonds not claimed by the initial OG bondholders will be converted on the
Issue Date or Maturity Date as appropriate, into new OPG shares or new OG shares (as further des-
cribed under the terms and conditions of the Convertible Bonds), will keep these new shares on behalf
of the relevant bondholders and transfer them to the relevant bondholders upon request.
Applicable Law Luxembourg Law
Restrictions on
transfer and ne-
gotiability of the
OCA
The Convertible Bonds are not transferable, not negotiable on the capital markets and cannot be offered
to the public.
The Convertible Bonds will neither be transferable between the Convertible Bondholders and are ex-
clusively linked to the position of holders of OG Bonds (i.e. intuitu personae).
The Convertible Bonds can only be payable in cash or converted into new OPG shares or new OG
shares as further provided in the terms and conditions of the Convertible Bonds.
Listing and ad-
mission to trad-
ing
The Convertibles Bonds will not be listed and/or admitted to trading on any stock exchange within the
European Economic Area nor on a stock exchange outside the European Economic Area.
Référence de publication: 2012004741/1273/323.
F&C Portfolios Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 25.570.
The shareholders of "F&C Portfolios Fund" (the "Company") are hereby invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company to be held at the registered office of the Company at 2-8, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg on Thursday, <i>26 January 2012i> at 11:30 a.m. (Luxembourg time) (the "Meeting") with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. To hear the report of the Board of Directors and the report of the Company's approved statutory auditor for the
financial year ended 30 September 2011;
2. To approve the audited annual accounts of the Company for the financial year ended 30 September 2011;
3. To approve the balance sheet, profit and loss accounts as of 30 September 2011 and allocate the net profits for
the financial year ended 30 September 2011 as proposed by the Board of Directors;
4. To grant discharge to the directors with respect to the performance of their duties during the financial year ended
30 September 2011;
5. To note the resignation of Dominic Sheridan from the Board of Directors effective 4 November 2011 and the co-
optation of Hugh Moir, in replacement of Dominic Sheridan, as a Director effective 22 November 2011;
6. To elect the following persons as Directors of the Company, each to hold office until the next annual general
meeting of shareholders to be held in 2013 and/or until his or her successor is duly elected:
Laurence Llewellyn, Jacques Elvinger, John Karachalios, João Santos and Hugh Moir;
7. To re-elect PricewaterhouseCoopers S.àr.l. as the approved statutory auditor of the Company until the next annual
general meeting to be held in 2013;
8. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The amount for distribution proposed by the Board of Directors is available upon request at the registered office of
the Company.
3175
L
U X E M B O U R G
<i>Voting:i>
Resolutions on the agenda of the Meeting are not subject to quorum or majority requirements and will be taken at
the majority of the votes cast. Each Share is entitled to one vote. Shareholders may vote in person or by proxy.
<i>Voting Arrangements:i>
Shareholders not able to attend this meeting in person are required to date, sign and return a proxy form by fax
(followed by mail) before close of business on 24 January 2012 to the Company at B.P. 403, L-2014 Luxembourg; fax
number +(00) 352 47 40 66 707.
Proxy forms can be obtained from the registered office of the Company.
<i>On behalf of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012005360/755/38.
Orco Germany S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 102.254.
A GENERAL MEETING
of the holders of the € 100.100.052,00 bonds (the "Bondholders"), registered under ISIN code: XS0302623953 (the
"OG Bonds") as described under the Prospectus (as defined below) issued by the Company with redeemable warrants
attached under ISIN code: XS0302626899 on May 24, 2007 pursuant to a prospectus approved by the Commission de
Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF") on May 24, 2007 (the "Prospectus"), will be held at 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>January 27, 2012i> at 2:00 PM Central European time ("CET") (the
"2012 Bondholders Meeting"), in order to consider and resolve on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the terms and conditions of the substitution of all OG Bonds by Obligations Convertibles en Actions
(the "OCA") to be issued by Orco Property Group S.A. ("OPG"), a Luxembourg société anonyme, having its
registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg register of commerce and companies (the "RCS") under number B 44.996 ("OG Conversion"), in-
cluding but not limited to, discussion and approval of the terms and conditions of the OCA (as such terms may be
amended), approval of all steps and actions, and entering into and performance of all the transactions, documents,
agreements contemplated, needed or useful in connection with the OG Conversion, after presentation to the
Bondholders of (i) interim accounting situations of the Company and of OPG, reviewed and certified by their
respective auditors and (ii) reports established by the boards of directors of OG and OPG, explaining the reasons
of the OG Conversion;
2. Delegation of power for implementation of the OG Conversion to the représentant de la masse, including, but not
limited to, the power and mandate to finalize the terms and conditions of the OCA and to negotiate and agree the
final terms and conditions of the OCA, subject to any non-substantial changes to such terms and conditions of the
OCA, as approved by the meeting, to sign the contribution and subscription agreement of the OCA, to receive
the OCA on behalf of the OG Bondholders and to redistribute the OCA to the Bondholders and/or to their
representative under the terms and conditions of the OCA, and power to perform and execute all steps and actions,
and entering into and performance of all the transactions, documents, agreements contemplated, needed or useful
in connection with the OG Conversion;
3. Miscellaneous.
Please refer to Annex A attached to the present notice and the Company's website at www.orcogermany.de for further
details pertaining to the proposed OG Conversion.
Please refer to Annex B attached to the present notice and the Company's website at www.orcogermany.de for further
details regarding the proposed terms and conditions of the OCA.
The 2012 Bondholders Meeting shall not validly deliberate on the agenda mentioned above, unless at least one half of
the total number of the OG Bonds outstanding at the time of the 2012 Bondholders Meeting is represented.
If such proportion of the total number of the OG Bonds is not met, a second meeting may be convened, by means of
notices published twice at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations and in two Luxembourg newspapers. The second meeting shall validly deliberate regardless of
the proportion of the OG Bonds represented.
At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two thirds (2/3) of the votes cast
by the Bondholders present or represented.
The Bondholders participation form which is necessary to participate to the 2012 Bondholders Meeting is at the
disposal of the Bondholders from January 10, 2012 at the registered office of the Company upon request or downloaded
from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries or to
the relevant central registration bank.
3176
L
U X E M B O U R G
The auditor's reports on review of interim financial information of the Company and of OPG, as at November 30,
2011, to be presented to the 2012 Bondholders Meeting are at the disposal of the Bondholders from January 10, 2012
at the registered office of the Company upon request or downloaded from the Company's website at
www.orcogermany.de (OPG's board of directors report also on OPG's website at www.orcogroup.com) or ultimately
upon request to the financial intermediaries or to the relevant central registration bank.
The report of the Company's board of directors, as well as the report of the OPG's board of directors, explaining the
reasons of the OG Conversion, to be presented to the 2012 Bondholders Meeting are at the disposal of the Bondholders
from January 10, 2012 at the registered office of the Company upon request or downloaded from the Company's website
at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries or to the relevant central registration
bank.
Copies of the Prospectus, the articles of association of the Company and the proposed terms and conditions of the
OG Conversion are available on the Company's website at www.orcogermany.de and at the registered office of the
Company upon request.
The board of directors of the Company would like to point out that for Bondholders whose ownership is directly or
indirectly recorded in the Bond registry of the Company, the conditions for attendance or representation at the 2012
Bondholders Meeting are as follows:
1. Conditions for personal attendance
(i) Bondholders whose ownership is indirectly recorded in the bond registry of the Company
Bondholders whose ownership is indirectly recorded in the bond registry of the Company and who elect to attend
the 2012 Bondholders Meeting in person must use their usual applicable contacting method for informing their financial
intermediary, with whom their OG Bonds are on deposit, accordingly. They must further request their financial inter-
mediary, with whom their OG Bonds are on deposit, to send a Bondholders blocking certificate (the "Bondholders
blocking certificate") for their OG Bonds to the relevant central registration bank no later than 5 business days prior to
the 2012 Bondholders Meeting.
Such blocking certificate must indicate clearly the precise identity of the Bondholder, the number of OG Bonds being
blocked, the date such OG Bonds are being blocked, which must be no later than January 20, 2012 and a statement that
the relevant OG Bonds are registered in the local bank or brokers records in the holder's name and shall be blocked
until the close of the 2012 Bondholders Meeting.
The Bondholders must bring a copy of the Bondholders blocking certificate to the 2012 Bondholders Meeting.
The Bondholders shall also announce their intention to participate at the 2012 Bondholders Meeting by completing,
signing, dating and returning on no later than January 20, 2012 at the latest to the relevant central registration bank or
to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol or Mrs.
Françoise de Jongh, département juridique"), the Bondholders participation form that can be obtained at the registered
office of the Company upon request or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately
upon request to the financial intermediaries or the relevant central registration bank.
(ii) Bondholders whose ownership is directly recorded in the bond registry of the Company
Bondholders whose ownership is directly recorded in the bond registry of the Company, shall announce their intention
to participate to the 2012 Bondholders Meeting by completing, signing, dating and returning on January 20, 2012, at the
latest to the relevant central registration bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique") the Bondholders partici-
pation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or downloaded from the
Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries or the relevant
central registration bank.
2. Conditions for proxy voting or granting a mandate
(i) Bondholders whose ownership is indirectly recorded in the bond registry of the Company
Bondholders whose ownership is indirectly recorded in the bond registry of the Company and who are unable to
attend the 2012 Bondholders Meeting in person, may give a voting instruction to a third party that the Bondholder
designates.
Prior to giving voting instructions to a proxy, this Bondholder must a) have obtained and delivered to the relevant
central registration bank the Bondholders blocking certificate described above (see "Conditions for personal attendance"),
and b) complete, sign and date the Bondholders participation form that can be obtained at the registered office of the
Company upon request or downloaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request
to the financial intermediaries or the relevant central registration bank, indicating the name of the proxy.
The completed, signed and dated Bondholders participation form must be returned to the relevant central registration
bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol
or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique") no later than January 20, 2012, at the latest, in order to have that
name recorded on the registration list of the 2012 Bondholders Meeting.
If a Bondholder wishes to be represented by a proxy other than the Chairman of the 2012 Bondholders Meeting, then
this holder must (a) have obtained and delivered to the relevant central registration bank the Bondholders blocking
3177
L
U X E M B O U R G
certificate described above (see "Conditions for personal attendance"), and (b) complete, sign and date the Bondholders
participation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or downloaded from the
Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries or the relevant
central registration bank, indicating the name of the proxy. The completed, signed and dated Bondholders participation
form must be returned to the relevant central registration bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue
de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique") no
later than January 20, 2012, at the latest, in order to have that name recorded on the registration list of the 2012
Bondholders Meeting.
Bondholders who have obtained the Bondholders blocking certificate and have executed a Bondholders participation
form but who wish to revoke such proxy may do so at any time by timely delivering a properly executed, later dated
participation form no later than January 20, 2012, at the latest, or by properly attending and voting in person at the 2012
Bondholders Meeting.
Simply attending the 2012 Bondholders Meeting without voting will not revoke the proxy.
(ii) Bondholders whose ownership is directly recorded in the bond registry of the Company.
Bondholders whose ownership is directly recorded in the bond registry of the Company must complete, sign and date
the Bondholders participation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or down-
loaded from the Company's website at www.orcogermany.de or ultimately upon request to the financial intermediaries
or the relevant central registration bank.
The completed, signed and dated Bondholders participation form must be returned to the relevant central registration
bank or to the Company (C/O "Orco Germany S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol
or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique") no later than January 20, 2012, at the latest.
3. Request for information and central registration banks
Bondholders looking for more information can do so by:
(i) contacting the Company's services directly:
* At the registered office of the Company - Legal Department
Tel.: +352 26 47 67 1
Fax.: +352 26 47 67 67
(ii) contacting one of the central registration banks :
* For OG Bonds that are included in the Clearstream Banking or Euroclear Bank system and that are admitted to
trading on the Euro MTF:
BNP Paribas Security Services - Lucie Maiore, Emmanuel Gérard
33, rue de Gasperich, Howald,
Hesperange L-2085, Luxembourg
Tel.: +352 26 96 23 89, +352 26 96 62 445
lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com
Luxembourg, January 10, 2011.
The Board of directors of the Company.
Annex A:
PROPOSED TERMS AND CONDITIONS OF THE OG CONVERSION
Subject to compliance with Luxembourg laws and to the granting of all the regulatory approval (in particular the decision
from the CSSF confirming that in the context of the proposed OG Conversion, Bondholders are not obliged to launch
a takeover bid), the OG Bonds will be converted for their total nominal amount and accrued interest (app. EUR 129.1
Million, consisting of the nominal value, premium and coupon interest as at the maturity date) into OCA to be issued by
OPG on 31 January 2012 (the "Conversion Date") which are convertible as follows:
* OCA in an aggregate nominal amount of EUR 79,100,000 are converted into 19,250,010 newly issued ordinary shares
of OPG (ISIN LU0122624777, "OPG Shares") on or about 31 January 2012 (the "Upfront Conversion");
* OCA in an aggregate nominal amount of around EUR 50,000,000 convertible into shares of OG or OPG, as further
detailed below:
- Each OCA will bear an interest of 0.01% and shall have a maturity of 15 April 2012 or any subsequent date agreed
to by the holders of OCA at the relevant majority in a meeting of holders of OCA (the "Exchange Date");
- The holders of the OCA shall benefit from a lien on 55% of all shares issued by OG (ISIN LU0251710041, "OG
Shares"), including current OG Shares and the New OG Shares (as defined below)) held by OPG as collateral in a separate
securities account that will be pledged to the holders of OCA (a nantissement de compte d'instruments financiers or any
equivalent security under Luxemburg law), for the repayment in cash of such OCA in accordance with the provisions
below;
- If and provided that the OPG Bond Conversion Condition (as defined below) is met three business days prior to the
Exchange Date, the remaining OCA are converted into 54 OPG Shares per one OCA;
3178
L
U X E M B O U R G
- If and provided the OPG Bond Conversion Condition is not met three business days prior to the Exchange Date
such remaining OCA will, at the option of OPG be (a) repaid in a cash amount of EUR 337.66 per one OCA or (b) in
case such cash amount is not paid by OPG and subject to a decision made by the holders of OCA (at a 50% plus 1 OCA
majority of all the OCA outstanding) to convert all of the remaining OCA into either (i) 54 OPG Shares per one OCA
or (ii) a number of OG Shares equivalent to 55% of the fully diluted capital of OG post equitization of the OG Bonds by
OPG. In the event no cash repayment is made by OPG, the election decision of the OCA holders in this case will not be
required by April 12th but can extend as necessary to allow for proper notice period, quorum, and majority decision.
The OG Shares pledged and held as collateral shall remain pledged until such election is made. No new OG Shares can
be issued during this time without 55% of those new shares also being added to the pledged collateral;
- OPG will prior to maturity of the OCA (subject to Luxembourg laws and the regulatory formalities, corporate
decisions and notice periods being complied with both at the level of OG and OPG) convert the EUR 129.1 Million
including the accrued coupons of OG Bonds into additional OG Shares based on the volume weighted average price of
OG Shares on the Frankfurt stock exchange over a period of 6 (six) months prior to the Conversion Date (the "New
OG Shares").
For the purposes of the OG Conversion, the "OPG Bond Conversion Condition" is met if 3 business days before the
Exchange Date, 65% of all OPG Bonds (as defined below, in terms of nominal value) have been converted into a combi-
nation of (i) OPG Shares at a value of EUR 6.40 (on the basis that up to 64,000,000 new OPG shares may be issued in
order to equitize 100% of 410,000,000 of nominal of OPG Bonds, to be reduced proportionally in accordance with the
actual number of OPG Bonds equitized) or higher, or (ii) bonds issued by OPG with a coupon of 0.5% per annum with
a maturity in 2050.
This time frame can be extended at the request of OPG if the negotiations with the OPG Bondholders are well advanced
as of 1 April 2012 and provided that such extension is agreed by a decision of the holders of OCA (taken in accordance
with the quorum and majority provisions provided for by law in a meeting of holders of OCA convened to extend the
Exchange Date, i.e. the decision can only validly be taken if at least one half of the OCA outstanding are present or
represented at that meeting. If such proportion of the total number of the OCA is not met, a second meeting shall be
convened and such second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the OCA present or repre-
sented. At both meetings, decisions in order to be adopted must be approved by at least two third of the votes cast).
The OPG Bond Conversion Condition shall be met on the date when the substitution of the relevant OPG Bonds into
OPG Shares has been approved by the relevant bondholders' meetings, and warrantholders' meetings (as appropriate)
and the shareholders' meeting of OPG.
The total number of new OPG Shares issued as a result of the Upfront Conversion shall be 19,250,010. Furthermore,
an additional number of 7,996,158 OPG Shares may be issued on or around the Exchange Date subject to and in accor-
dance with the provisions described above.
The new OPG Shares issued as a result of the OG Conversion and the OPG Conversion shall be referred to as the
"New OPG Shares".
For the purposes of the OPG Bond Conversion Condition, the OPG Bonds means:
* EUR 50,272,605.30 bonds with subscription rights attached issued by OPG on 18 November 2005 (the "OPG Bonds
2010");
* CZK 300,000,000.00 bonds issued by OPG on 3 February 2006 (the "OPG Bonds 2011"). As of the date of this Term
Sheet EUR 11,631,934 of nominal OPG Bonds 2011 remain outstanding;
* EUR 24,169,193.39 bonds issued by OPG on 30 June 2005 (the "OPG Bonds 2012");
* EUR 149,999,928.00 convertible bonds issued by OPG on 1 June 2006 (the "OPG Bonds 2013");
* EUR 175,000,461.60 bonds with subscription rights attached issued by OPG on 28 March 2007 (the "OPG Bonds
2014").
(OPG Bonds 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 jointly as the "OPG Bonds", and the holders of the OPG Bonds as the
"OPG Bondholders").
Annex B:
SUMMARY OF THE PROPOSED TERMS AND CONDITIONS OF THE OCA
(Obligations Convertibles en Actions)
Context
Orco Property Group S.A. ("OPG"), a Luxembourg Société Anonyme having its registered office at 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered in Luxembourg with the Luxembourg register of com-
merce and companies (the "RCS") under the number B 44.996, wishes to substitute all the EUR 100,100,052 five years
bonds with redeemable warrants attached thereto ("OG Bonds") issued on 30 May 2007 by Orco Germany S.A. ("OG"),
a Luxembourg Société Anonyme having its registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and registered in Luxembourg with the Luxembourg register of commerce and companies (the "RCS") under
the number B 102.254, into OCA to be issued by OPG (the "Convertible Bonds") on 31 January 2012 (the "Conversion
Date"). The Convertible Bonds are convertible as follows:
3179
L
U X E M B O U R G
- The Convertible Bonds in an aggregate nominal amount of EUR 79,100,000 are immediately converted into 19,250,010
OPG shares on or about 31 January 2012;
- The Convertible Bonds in an aggregate nominal amount of EUR 49,999,451.68 are later to the Conversion Date,
payable in cash or convertible into shares of OG or OPG, provided that the specific conditions detailed in the terms and
conditions of the Convertible Bonds are satisfied.
Orco Property Group has the following outstanding bonds (the "OPG Bonds"):
* EUR 50,272,605.30 bonds with subscription rights attached issued by OPG on 18 November 2005
* CZK 300,000,000.00 bonds issued by OPG on 3 February 2006
* EUR 24,169,193.39 bonds issued by OPG on 30 June 2005
* EUR 149,999,928.00 convertible bonds issued by OPG on 1 June 2006
* EUR 175,000,461.60 bonds with subscription rights attached issued by OPG on 28 March 2007
The main characteristics of the Convertible Bonds are set out in the following table:
Issuer of
Convertible
Bonds
OPG
Share capital
of OPG
EUR 69,920,850.60 divided into 17,053,866 shares
Legal form
of OPG
Public limited liability company, Société Anonyme, registered in Luxembourg with a Board of Directors
FTSE activity
segment
862 - Real Estate Holding and Development
Number of
OG Bonds to
be converted
148,077
Number of
Convertible
Bonds to
be issued
148,077
Form of the
Convertible
Bonds
Registered form
Total nominal
amount of the
Convertible
Bonds
EUR 129,099,451.68
Issue Price of
Convertible
Bonds
EUR 871.84
Issuance Price
of Convertible
Bonds Payment
Exchange of one OG Bond against one Convertible Bond
Convertible
Bonds Payments
Issue of the Convertible Bonds in two payments:
- one corresponding to EUR 79,100,000 (the "First Payment")
- the second corresponding to EUR 49,999,451.68 (the "Second Payment")
Issue Date
31 January 2012
Maturity Date
of the First
Payment
1 February 2012
Maturity Date
of the Second
Payment
15 April 2012 (the "Maturity Date")
Gross Yearly
Coupon on the
Second Payment
0.01% paid on the Maturity Date
Bondholders
Conversion
Rights
- Mandatory conversion of the First Payment on the Issue Date
- Mandatory conversion of the Second Payment on the Maturity Date
3180
L
U X E M B O U R G
Convertible
Bonds Conver-
sion Condition
for the Second
Payment
3 business days prior to the Maturity Date, 65% of all OPG Bonds (in terms of nominal value) have been
converted into a combination of (i) OPG shares at a value of EUR 6.40 (on the basis that up to 64,000,000
new OPG shares may be issued in order to equitize 100% of 410,000,000 of nominal of OPG bonds, to
be reduced proportionally in accordance with the actual number of OPG bonds equitized) or higher or
(ii) bonds issued by OPG, with a coupon of 0.5% per annum with a maturity in 2050
Exchange Parity
of the Convert-
ible Bonds
* For the First Payment:
EUR 79,100,000 are converted into 19,250,010 OPG shares, pursuant to the ratio of 1 OCA converted
in 130 OPG shares,
* For the Second Payment, one Convertible Bond carries entitlement to:
- If the Convertible Bonds Condition is met, 54 OPG new shares,
- If the Convertible Bonds Condition is not met:
(i) at the option of OPG, a reimbursement in cash of EUR 337.66 or
(ii) in case such cash amount is not paid by OPG and subject to a decision made by the holders of
Convertible Bonds of the Second Payment (at a 50% plus 1 Second Payment Convertible Bond majority
of all the Second Payment Convertible Bonds outstanding) to convert all of the remaining Second Pay-
ment Convertible Bonds into either:
(a) 54 shares of OPG per one Second Payment Convertible Bond or
(b) a number of OG shares equivalent to 55% of the fully diluted capital of OG post equitization of the
OG Bonds by OPG.
Security
The holders of the Second Payment Convertible Bonds shall benefit from a lien on 55% of all shares
issued by OG (including current OG shares and the new OG shares) held by OPG as collateral in a
separate securities account that will be pledged to the holders of Second Payment Convertible Bonds
(a nantissement de compte d'instruments financiers or any equivalent security under Luxemburg law),
for the repayment in cash of such Second Payment Convertible Bonds.
Lock-up
100% of the new OPG shares will be register shares and be subject to a lock-up until the Maturity Date
of the Second Payment, after which they will be freed
Representation
of the Second
Payment Con-
vertible Bond-
holders
The representative of the Convertible Bondholders is Mr Lionel BOTBOL
In addition to its general task of representation of the Second Payment Convertible Bondholders in
accordance with article 88 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, the representative
will:
- keep on behalf of the bondholders the Convertible Bonds not claimed by the initial OG bondholders
when issued and will ensure to transfer the relevant Convertible Bonds to the relevant bondholders
upon request;
- ensure that all Convertible Bonds not claimed by the initial OG bondholders will be converted on the
Issue Date or Maturity Date as appropriate, into new OPG shares or new OG shares (as further des-
cribed under the terms and conditions of the Convertible Bonds), will keep these new shares on behalf
of the relevant bondholders and transfer them to the relevant bondholders upon request.
Applicable Law Luxembourg Law
Restrictions on
transfer and ne-
gotiability of the
OCA
The Convertible Bonds are not transferable, not negotiable on the capital markets and cannot be offered
to the public.
The Convertible Bonds will neither be transferable between the Convertible Bondholders and are ex-
clusively linked to the position of holders of OG Bonds (i.e. intuitu personae).
The Convertible Bonds can only be payable in cash or converted into new OPG shares or new OG
shares as further provided in the terms and conditions of the Convertible Bonds.
Listing and
admission
to trading
The Convertibles Bonds will not be listed and/or admitted to trading on any stock exchange within the
European Economic Area nor on a stock exchange outside the European Economic Area.
Référence de publication: 2012004742/1273/329.
Creola S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 65.349.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>30 janvier 2012i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
3181
L
U X E M B O U R G
- Délibérations et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012005359/755/20.
ING (L), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 44.873.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of ING (L) will be held at the Head Office of the Company on Thursday <i>26 January 2012i> at 2.00 p.m.
with the following Agendas:
<i>Agenda:i>
A. ING (L)
1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of the Company;
2. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended 30 September 2011;
3. Allocation of the results of the Company for the financial year ended 30 September 2011;
4. Discharge of the Board of directors of the Company for the execution of their mandates during the financial year
ended 30 September 2011 and acknowledgement of the resignations;
5. Ratification of the co-optation of Mr André van den Heuvel as director of the Company with effect as of 1st
November 2011;
6. Appointment of Mr André van den Heuvel and renewal of the mandates of Mr David Suetens, Mr Dirk Buggenhout
and Mrs Maaike van Meer as directors of the Company until the annual general meeting which will be held in 2013;
7. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of the Company;
8. Miscellaneous.
B. ING (L) Renta Fund (Sicav merged into the Company on 29 April 2011)
1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of ING (L) Renta Fund;
2. Approval of the annual accounts of ING (L) Renta Fund for the financial year ended 31 March 2011;
3. Approval of the accounts of ING (L) Renta Fund for the period from 1st April 2011 to 29 April 2011;
4. Allocation of the results of ING (L) Renta Fund for the financial year ended 31 March 2011 and for the period from
1st April 2011 to 29 April 2011;
5. Discharge of the board of directors of ING (L) Renta Fund for the execution of their mandates during the financial
year ended 31 March 2011 and for the period from 1st April 2011 to 29 April 2011;
6. Ratification of the co-optation of Mr David Suetens as director of ING (L) Renta Fund in replacement of Mr Jonathan
Atack with effect as of 1st September 2010;
7. Ratification of the co-optation of Mr Dirk Buggenhout as director of ING (L) Renta Fund in replacement of Mr
David Eckert with effect as of 1st January 2011;
8. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of ING (L) Renta Fund;
9. Miscellaneous.
C. ING Index Linked Fund (Sicav merged into the Company on 27 May 2011)
1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of ING Index Linked Fund;
2. Approval of the annual accounts of ING Index Linked Fund for the financial year ended 31 March 2011;
3. Approval of the accounts of ING Index Linked Fund for the period from 1st April 2011 to 27 May 2011;
4. Allocation of the results of ING Index Linked Fund for the financial year ended 31 March 2011 and for the period
from 1st April 2011 to 27 May 2011;
5. Discharge of the board of directors of ING Index Linked Fund for the execution of their mandates during the
financial year ended 31 March 2011 and for the period from 1st April 2011 to 27 May 2011;
6. Ratification of the co-optation of Mr David Suetens as director of ING Index Linked Fund in replacement of Mr
Jonathan Atack with effect as of 1st September 2010;
7. Ratification of the co-optation of Mr Dirk Buggenhout as director of ING Index Linked Fund in replacement of Mr
David Eckert with effect as of 1st January 2011;
3182
L
U X E M B O U R G
8. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of ING Index Linked Fund;
9. Miscellaneous.
D. ING (L) Renta Fund II (Sicav merged into the Company on 17 June 2011)
1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of ING (L) Renta Fund II;
2. Approval of the annual accounts of ING (L) Renta Fund II for the financial year ended 31 March 2011;
3. Approval of the accounts of ING (L) Renta Fund II for the period from 1st April 2011 to 17 June 2011;
4. Allocation of the results of ING (L) Renta Fund II for the financial year ended 31 March 2011 and for the period
from 1st April 2011 to 17 June 2011;
5. Discharge of the board of directors of ING (L) Renta Fund II for the execution of their mandates during the financial
year ended 31 March 2011 and for the period from 1st April 2011 to 17 June 2011;
6. Ratification of the co-optation of Mr David Suetens as director of ING (L) Renta Fund II in replacement of Mr
Jonathan Atack with effect as of 1st September 2010;
7. Ratification of the co-optation of Mr Dirk Buggenhout as director of ING (L) Renta Fund II in replacement of Mr
David Eckert with effect as of 1st January 2011;
8. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of ING (L) Renta Fund II;
9. Miscellaneous.
E. ING (L) Selected Strategies (Sicav merged into the Company on 16 December 2011)
1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of ING (L) Selected Strategies;
2. Approval of the annual accounts of ING (L) Selected Strategies for the financial year ended 30 September 2011;
3. Allocation of the results of ING (L) Selected Strategies for the financial year ended 30 September 2011;
4. Discharge of the board of directors of ING (L) Selected Strategies for the execution of their mandates during the
financial year ended 30 September 2011 and acknowledgement of the resignations;
5. Ratification of the co-optation of Mr André van den Heuvel with effect as of 1st November 2011;
6. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of ING (L) Selected Strategies;
7. Miscellaneous
Registered shareholders will be admitted upon proof of their identity, provided they inform the Board of Directors
of their intention to attend the meeting at least five clear days prior to the meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012005361/755/77.
ING (L) Renta Cash, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 29.765.
Nous vous informons par la présente que
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
des actionnaires de ING (L) Renta Cash se tiendra au siège social de la Société le jeudi <i>26 janvier 2012i> à 10h30 pour
délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises indépendant;
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clôturé le 30 septembre 2011;
3. Affectation des résultats pour l'exercice clôturé le 30 septembre 2011;
4. Décharge du Conseil d'administration pour l'exécution de ses mandats pendant l'exercice clôturé le 30 septembre
2011 et reconnaissance des démissions;
5. Ratification de la cooptation de M. André van den Heuvel en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1
er
novembre 2011;
6. Nomination de M. André van den Heuvel et renouvellement des mandats de M. David Suetens, M. Dirk Buggenhout
et Mme Maaike van Meer en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2013;
7. Réélection de Ernst & Young en tant que réviseur d'entreprises indépendant de la Société;
8. Divers.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir cinq jours francs au moins
avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'assemblée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012005364/755/26.
3183
L
U X E M B O U R G
Najade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 139.029.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der NAJADE SA, welche am <i>26. Januar 2012i> um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden
Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2010
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2012001102/17.
Mantera S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 55.647.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 janvier 2012i> à 16.15 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2011.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012005365/1023/16.
ING (L), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 44.873.
Since the quorum required by law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, was not reached at
the previous Extraordinary General Meeting of the ING (L) SICAV (hereinafter "the Company") the shareholders of the
Company are invited to attend the
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
(hereinafter "the Meeting") which will be held on <i>16 February 2012i> at 2 p.m. CET at the registered office of the Company
with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. With effect from 20 February 2012, all references in the Articles of Incorporation to the Directive 85/611/EEC and
to the Law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment (hereinafter "the 2002 Law")
shall be replaced by respectively a reference to the Directive 2009/65/EC and to the Law of 17 December 2010
relating to undertakings for collective investments (hereinafter "the 2010 Law") and all references to specific articles
of the 2002 Law shall be replaced by the relevant articles of the 2010 Law.
2. With effect from 20 February 2012, amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows:
"The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the
total value of the net assets of the Company and its Sub-Funds. The minimum capital of the Company can not be
lower than the level provided for in Article 27 (1) of the Law of the seventeenth of December two thousand and
ten relating to undertakings for collective investment. In case where one or several Sub-Funds of the Company
3184
L
U X E M B O U R G
hold shares that have been issued by one or several other Sub-Funds of the Company, their value will not be taken
into account for the calculation of the net assets of the Company for the purpose of the determination of the above
mentioned minimum capital. Such minimum capital must be reached within a period of six months after the date
on which the Company has been authorised as an undertaking for collective investment under Luxembourg law."
3. With effect from 20 February 2012, amendment of Article 14 of the Articles of Incorporation by addition of a final
paragraph to read as follows: "If on a Valuation Day the consolidated issues and redemptions of all the categories
of shares of a Sub-Fund result in an increase or decrease of the Sub-Funds capital the board of Directors may decide
to adjust the net asset value. Such adjustment will have as a result an increase of the net asset value in case of an
increase of capital and a decrease of the net asset value in case of a decrease of capital."
4. With effect from 20 February 2012, amendment of Article 16 bullet point (g) of the Articles of Incorporation to
read as follows: "(g) to establish the exchange parities in the context of a contribution of assets, splits or any
restructuring operation, within, by one or more Sub-Funds;".
5. With effect from 20 February 2012, amendment of Article 16 of the Articles of Incorporation by addition of a bullet
point (h) to read as follows: "(h) in case of a merger of a Sub-Fund with another Sub-Fund of the Company or
another UCITS (or a Sub-Fund thereof), provided such suspension is in the interest of the shareholders;".
6. With effect from 20 February 2012, amendment of Article 16 of the Articles of Incorporation by addition of a bullet
point (i) to read as follows: "(i) in case of a feeder Sub-Fund of the Company, if the net asset calculation of the
master Sub-Fund or the master UCITS is suspended."
7. With effect from 20 February 2012, amendment of Article 20 paragraph (a) (1) of the Articles of Incorporation to
be read as follows: "(1) Transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated
market within the meaning of Directive 2004/39/EC on the Markets in Financial Instruments;"
8. With effect from 20 February 2012, amendment of Article 20 paragraph (a) of the Articles of Incorporation by
addition of a bullet point (10) to read as follows: "(10) a Sub-Fund which can, under the conditions provided for in
the law of seventeenth December two thousand and ten invest in the shares issued by one or several other Sub-
Funds of the Company."
9. With effect from 20 February 2012, amendment of Article 20 paragraph (a) of the Articles of Incorporation by
addition of a bullet point (11) to read as follows: "(11) a Sub-Fund which can be constituted as a feeder Sub-Fund
in a master UCITS or a master Sub-Fund of such UCITS."
10. With effect from 20 February 2012, amendment to the first paragraph of Article 25 of the Articles of Incorporation
to read as follows: "The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Com-
pany's registered office or at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, on
the fourth Thursday of January at 2 p.m. If this day is not a banking day in Luxembourg, the annual general meeting
shall be held on the next banking day. The annual general meeting may be held abroad if the board of directors,
acting with sovereign powers, decides that exceptional circumstances warrant this."
11. With effect from 20 February 2012, amendment to the fifth paragraph of Article 25 of the Articles of Incorporation
to read as follows: "It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the
share capital."
12. With effect from 20 February 2012, amendment to the sixth paragraph of Article 25 of the Articles of Incorporation
by addition of the following wording: "The convening notice for a general meeting can provide that the quorum
and the majority will be determined in accordance with the shares issued and in circulation the fifth day preceding
the general meeting at midnight (Luxembourg time) (the "registration date")."
13. With effect from 20 February 2012, amendment to the fifth paragraph of Article 27 of the Articles of Incorporation
to read as follows: "The board of directors may decide, in compliance with the procedures laid down in the law of
seventeenth December two thousand and ten, to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another Sub-Fund
within the Company or to another undertaking for collective investment organised under the provisions of Council
Directive 2009/65/EC, as amended, or to another Sub-Fund within such other undertaking for collective investment
(the "new Sub-Fund") and to redesignate the shares of the class or classes concerned as shares of the new Sub-
Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional
entitlement to shareholders). The shareholders of the Sub-Funds concerned will be notified in accordance with the
provisions of the law and, notably, in conformity with the CSSF Regulation 10-5 of the Commission de Surveillance
du Secteur Financier, as amended, at least one month before the effective date of the merger, in order to enable
shareholders to request redemption of their shares, free of charge, during such period, it being understood that
the merger will take effect five business days after the expiry of such notice period. Shareholders who have not
requested redemption will be transferred as of right to the new Sub-Fund."
14. With effect from 20 February 2012, amendment to the sixth paragraph of Article 27 of the Articles of Incorporation
to read as follows: "A merger that has a result that the Company ceases to exist needs to be decided at a general
meeting of shareholders. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which
shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.
The Meeting will validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the Com-
pany present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the
votes cast by the shareholders of the Company at the meeting. Each share is entitled to one vote.
3185
L
U X E M B O U R G
Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case Shareholders cannot attend the meeting they are
kindly asked to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal
Department of ING Investment Management Luxembourg S.A. at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg not later than
10 February 2012 at 5.00 p.m. Luxembourg time by fax (fax number ++ 352 26 19 68 40) followed by the original by
regular mail.
Luxembourg, on 10 January 2012.
<i>The Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2012005362/755/90.
ING (L) Patrimonial, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 24.401.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of ING (L) Patrimonial will be held at the Head Office of the Company on Thursday <i>26 Januaryi>
<i>2012i>
at 11.15 a.m. with the following Agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of the Company;
2. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended 30 September, 2011;
3. Allocation of the results of the Company for the financial year ended 30 September, 2011;
4. Discharge of the Board of directors of the Company for the execution of their mandates during the financial year
ended 30 September, 2011 and acknowledgement of the resignations;
5. Ratification of the co-optation of Mr André van den Heuvel as director of the Company with effect as of 1
st
November 2011;
6. Appointment of Mr André van den Heuvel and renewal of the mandates of Mr David Suetens, Mr Dirk Buggenhout
and Mrs Maaike van Meer as directors of the Company until the annual general meeting which will be held in 2013;
7. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of the Company;
8. Miscellaneous.
Registered shareholders will be admitted upon proof of their identity, provided they inform the Board of Directors
of their intention to attend the meeting at least five clear days prior to the meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012005363/755/25.
Record Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 118.963.
Les actionnaires sont invités à assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra dans les locaux sis au 3, rue Jean Piret à L-2965 Luxembourg, le jeudi <i>26 janvier 2012i> à 16 H 00 pour
délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2011
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir cinq jours francs au moins
avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'assemblée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012005367/755/20.
3186
L
U X E M B O U R G
Muse Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 98.866.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>9 février 2012i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915
2. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012005366/788/15.
Morsa Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 100.890.
The shareholders are hereby convened to the
ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
which will be held on Thursday, the <i>26th day of January 2012i> at 11 a.m. at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.
A first general meeting was held on December 19, 2011, the presence quorum required by article 67-1 of the amended
law of August 10, 1915 on commercial companies in order to deliberate validly on the dissolution of the company ac-
cording to article 100 of the same law, was not met. Therefore the present meeting may validly deliberate on the item
of the agenda regardless of the proportion of the capital represented.
<i>The board of directors.i>
Référence de publication: 2011174973/29/17.
Nordea Fund of Funds, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 66.248.
Notice is hereby given to the shareholders of Choice Emerging Market Equities and Choice International Equities ("the
Sub-funds"), two sub-funds of Nordea Fund of Funds, SICAV ("the Company"), that the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of each sub-fund shall be held at the Registered Office of the Company on <i>27 January 2012i> at respectively 11:00 and
11:30 CET (the "Meeting"), with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Liquidation of the Sub-fund
Nordea has been reviewing its product offering, the review has been focused on simplifying its offering within Global
and Emerging Market Equities. Based on this assessment, Nordea has taken the business decision to close down the Sub-
funds.
Shares in these Sub-funds will no longer be issued, redeemed or converted, and the price calculation suspended as
from the date of the Meeting provided that shareholders vote in favour of the liquidation. All assets and liabilities will be
realised and the net proceeds of the realisation will be distributed to the shareholders in proportion to their holding of
shares.
The resolutions on the agenda may be passed with a quorum of half of the issued capital and by a majority of two
thirds of the shares present or represented. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by
proxy. In case of lack of quorum at the first Meeting, a second Meeting will be convened, at the same address and with
3187
L
U X E M B O U R G
the same agenda. Decisions may be approved without quorum and at a majority of two thirds of the shares present or
represented at the second Meeting.
In order to vote at the Meeting, shareholders may be present in person provided that proof of the shareholder's
identity is given and that the shareholder has informed the Company, for organisational reasons, in writing, of his intention
to attend the Meeting by 25 January 2012, 17:00 CET at the latest (to Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg).
Shareholders not attending the Meeting in person are invited to send a completed and signed proxy form to arrive no
later than 25 January 2012, 17:00 CET (to Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg).
Proxy form can be obtained from the Registered Office of the Company.
The Meeting will be held in English language.
Luxembourg, 22 December 2011.
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2011175037/755/34.
RP Rendite Plus, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 94.920.
Hiermit wird mitgeteilt, dass die
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Anteilinhaber der RP Rendite Plus ("die Gesellschaft") am <i>20. Januar 2012i> um 11:45 Uhr MEZ am Gesellschaftssitz
6A, route de Trèves in 2633 Senningerberg, Luxemburg, stattfinden wird, um die folgenden Tagesordnungspunkte zu
erörtern und darüber abzustimmen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und der Abschlussprüfer sowie Verabschiedung des Jahresabs-
chlusses und der Verwendung der Erträge (ggf.) für das Geschäftsjahr bis 30. September 2011.
2. Entlastung des Verwaltungsrats von seiner Verantwortung für alle Maßnahmen, die im Rahmen seines Mandates
während des Geschäftsjahres bis 30. September 2011 ergriffen wurden.
3. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats für das zum 30. September 2011 abgelaufene Geschäftsjahr.
4. Wiederwahl der Herren Jean-Christoph Arntz, Herbert Wunderlich sowie Daniel Lehmann als Verwaltungsrats-
mitglieder.
5. Wiederwahl von KPMG Audit S.à r.l., Luxemburg, zum Abschlussprüfer.
6. Beschluss über sonstige Angelegenheiten, die ordnungsmäßig auf der Versammlung vorgebracht werden.
<i>Abstimmung:i>
Die Beschlüsse auf der Tagesordnung können ohne Quorum mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst
werden. Das Quorum sowie die Mehrheitsverhältnisse im Verhältnis zu den ausstehenden Anteilen werden per 15. Januar
2012, 24:00 Uhr ("Record Date"), bestimmt.
<i>Abstimmungsregelung:i>
Um an der Versammlung teilnehmen und dort abstimmen zu können, müssen Anteilinhaber der Transferstelle RBC
Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, bis
spätestens um 11:00 Uhr MEZ des 18. Januar 2012 eine Bescheinigung ihrer Depotbank oder ihres Finanzinstituts vorlegen,
aus der die Anzahl der Anteile hervorgeht, die der Anteilinhaber per Record Date hält.
Alle Anteilinhaber, die zur Teilnahme und Abstimmung berechtigt sind, können einen Stellvertreter beauftragen, der
in ihrem Namen abstimmt. Eine entsprechende Vollmacht ist nur gültig, wenn sie vom Ernennenden ordnungsgemäß
ausgefüllt und unterzeichnet ist oder, wenn der Ernennende eine Körperschaft ist, mit dessen Firmensiegel versehen ist
oder von einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Angestellten ausgestellt und bis spätestens um 11:00 Uhr MEZ des 18.
Januar 2012 bei der Transferstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360
Esch-sur-Alzette, Luxemburg, eingegangen ist.
Vollmachtsformulare erhalten registrierte Anteilinhaber bei der Transferstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A.,
Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg. Eine zum Stellvertreter ernannte Person
muss kein Anteilinhaber der Gesellschaft sein. Durch die Ernennung eines Stellvertreters ist ein Anteilinhaber nicht von
der Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen.
Senningerberg, Dezember 2011.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2011181120/755/41.
3188
L
U X E M B O U R G
Allianz European Pension Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 117.986.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of Allianz European Pension Investments ("the Company") will be held at its registered office at 6A,
route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg, at 11.15 a.m. CET on <i>20 January 2012i> for the purpose of considering
and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. To accept the Directors' and Auditor's reports and to adopt the financial statements as well as the use of income
(if any) for the year ended 30 September 2011.
2. To exonerate the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year
ended 30 September 2011.
3. To re-elect Dr. Thomas Wiesemann, Mr. Daniel Lehmann and Mr. Martyn Cuff as Directors.
4. To re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, as Auditor.
5. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.
<i>Votingi>
Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum by simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting. The quorum and majority requirements shall be determined in accordance to the shares outstanding on 15
January 2012 midnight CET (the "Record Date"). The voting rights of the Shareholders shall be determined by the number
of shares held at the record Date.
<i>Voting Arrangementsi>
Authorized to attend and vote at the meeting are shareholders who are able to provide a confirmation from their
depository bank or institution showing the number of shares held by the Shareholder as per the Record Date to the
Transfer Agent RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette,
Luxembourg, to arrive in Luxembourg by 11:00 a.m. on 18 January 2012.
Any shareholders entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint a proxy to vote on his/her
behalf. The proxy form, in order to be valid, must be duly completed and signed under the hand of the appointer or his/
her attorney or if the appointer is a corporation, under its common seal or under the hand of a duly authorised officer,
and sent to the Transfer Agent RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360
Esch-sur-Alzette, Luxembourg, to arrive in Luxembourg by 11:00 a.m. on 18 January 2012.
Proxy forms for use by registered shareholders can be obtained from the Transfer Agent RBC Dexia Investor Services
Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. A person appointed a proxy
need not be a shareholder of the Company. The appointment of a proxy will not preclude a shareholder from attending
the meeting.
Senningerberg, December 2011.
<i>The Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2011181114/755/39.
Allianz Global Investors Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 71.182.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of Allianz Global Investors Fund ("the Company") will be held at its registered office at 6A, route de
Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg, at 11.00 a.m. CET on <i>20 January 2012i> for the purpose of considering and
voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. To accept the Directors' and Auditor's reports and to adopt the financial statements as well as the use of income
(if any) for the year ended 30 September 2011.
2. To exonerate the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year
ended 30 September 2011.
3. To re-elect Mr. Thomas Wiesemann, Mr. Daniel Lehmann and Mr. George McKay as Directors.
4. To co-opt Mr. Jean-Christoph Arntz and Mr. Markus Nilles as Directors.
3189
L
U X E M B O U R G
5. To re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxemburg, as Auditor.
6. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.
<i>Votingi>
Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum by simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting. The quorum and majority requirements shall be determined in accordance to the shares outstanding on 15
January 2012 midnight CET (the "Record Date"). The voting rights of the Shareholders shall be determined by the number
of shares held at the Record Date.
<i>Voting Arrangementsi>
Authorized to attend and vote at the meeting are shareholders who are able to provide a confirmation from their
depository bank or institution showing the number of shares held by the Shareholder as per the Record Date to the
Transfer Agent RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette,
Luxembourg, to arrive in Luxembourg by 11:00 a.m. CET on 18 January 2012.
Any shareholders entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint a proxy to vote on his/her
behalf. The proxy form, in order to be valid, must be duly completed and signed under the hand of the appointer or his/
her attorney or if the appointer is a corporation, under its common seal or under the hand of a duly authorised officer,
and sent to the Transfer Agent RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360
Esch-sur-Alzette, Luxembourg, to arrive in Luxembourg by 11:00 a.m. on 18 January 2012.
Proxy forms for use by registered shareholders can be obtained from the Transfer Agent RBC Dexia Investor Services
Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. A person appointed a proxy
need not be a shareholder of the Company. The appointment of a proxy will not preclude a shareholder from attending
the meeting.
Senningerberg, December 2011
<i>The Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2011181115/755/40.
Fivecom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 69.638.
L'AN DEUX MILLE ONZE, LE SEIZE DECEMBRE.
Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
soussignée.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FIVECOM S.A. (la «Société»), une société
anonyme, ayant son siège social au 25, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B69.638, constituée à Luxembourg en date du 28 Avril 1999 suivant acte reçu
par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire lors de résidence à Sanem, publié au Mémorial C n°531 du 10 juillet 1999.
Le statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire Jean-Joseph Wagner, lors de
résidence à Sanem, en date du 1 décembre 2004, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
341 en date du 16 avril 2005, page 16.337.
L'assemblée est présidée par Monsieur Alessandro DI ROBERTO, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard
Royal à L-2449 Luxembourg,
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Massimiliano SELIZIATO, demeurant professionnellement au 5, place
du Théâtre à L-2613 Luxembourg,
et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alessandro DI ROBERTO, demeurant professionnellement au 25C,
Boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence signée
par le mandataire des actionnaires, par le bureau de l'assemblée et par le notaire. Cette liste et les procurations signées
ne varietur seront enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 5.000 (cinq mille) actions représentant l'intégralité du capital social de la
Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires déclarent avoir été préala-
blement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et renoncent aux exigences et formalités de convocation. L'assemblée
est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- Il n'existe ni pour la société absorbée ni pour la société absorbante de porteurs de titres autres que les actions
représentatives du capital social de ces deux sociétés. De même, ni la société absorbée ni la société absorbante n'ont
émis d'emprunts obligataires.
IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
3190
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jour:i>
1) Présentation du projet de fusion daté du 28 octobre 2011 prévoyant l'absorption de la société de droit néerlandais
dénommée «RETE EUROPA B.V.», ayant son siège statutaire Amsterdam, Pays Bas, inscrite au Registre de Commerce
de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 33203516 (ci-après nommée «la société absorbée») par,
FIVECOM S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B69.638, ci-après dénommée «la
société absorbante» ou «notre Société»,
la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de l'ensemble du patrimoine activement
et passivement sans exception ni réserve de la société absorbée à notre Société, ledit projet de fusion ayant été publié
au Mémorial C n°2697 du 7 novembre 2011, conformément à l'article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés telle
que modifiée;
2) Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés, telle
que modifiée.
3) Constatation que les formalités relatives à la fusion ont été accomplies auprès de la société absorbée, suivant les
lois des Pays-Bas.
4) Approbation du projet de fusion daté du 28 octobre 2011 publié au Mémorial C n°2697 du 7 novembre 2011 et
décision de réaliser la fusion par absorption de la société absorbée par notre Société, aux conditions prévues dans le
projet de fusion.
5) Constatation de la réalisation de la fusion.
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé
l'ordre du jour. Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix et par vote séparé, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée des associés constate que le conseil d'administration lui a présenté:
1. le projet de fusion daté du 28 octobre 2011 prévoyant l'absorption de la société dénommée «RETE EUROPA B.V.»,
besloten vennootschap, société de droit néerlandais, ayant son siège statutaire à Amsterdam, Pays Bas, inscrite auprès
du Registre de Commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 33203516, (ci-après nommée «la
société absorbée»), la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de l'ensemble du
patrimoine activement et passivement sans exception ni réserve de la société absorbée à notre Société, ledit projet de
fusion ayant été publié au Mémorial C n°2697 du 7 novembre 2011, conformément à l'article 262 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés telle que modifiée;
2. Les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices de la société absorbée et de la
société absorbante;
3. Un état comptable arrêté au 31 août 2011 de la société absorbée et de la société absorbante;
4. Les lettres émanant des actionnaires de la société absorbée et de la société absorbante datées du 27 octobre 2011
desquelles il résulte que ces derniers ont renoncé au rapport du conseil d'administration et au rapport des experts
indépendants tels que prévus à l'article 265 respectivement à l'article 266 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée;
5. Les déclarations émanant du conseil d'administration de la société absorbée et absorbante déclarant que les docu-
ments mentionnés sub 1) à 4) ont été tenus à la disposition des associés de la société absorbée et de la société absorbante,
aux sièges sociaux respectifs, pendant un mois au moins avant la date de la présente assemblée.
Une copie des documents susmentionnés, après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire sous-
signée, demeurera annexée au présent acte.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée, réunissant l'ensemble des actionnaires, déclare que tous les documents requis par l'article 267 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés telle que modifiée, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social de notre
Société, soit en original soit en copie.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée constate que les formalités relatives à la fusion ont été accomplies auprès de la société absorbée suivant
les lois des Pays-Bas, ceci sur le vu:
- d'un certificat du notaire Martijn Michiel van der Bie, de résidence à Amsterdam, attestant l'accomplissement par la
société absorbée des formalités lui incombant en vertu du droit néerlandais, dont une copie reste annexée au présent
acte.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée approuve le projet de fusion du 28 octobre 2011 dûment publié au Mémorial C n°2697 du 7 novembre
2011,
3191
L
U X E M B O U R G
et décide de réaliser la fusion par absorption de la société «RETE EUROPA B.V.» par notre Société, aux conditions
prévues par le projet de fusion.
Dans ce contexte, vu que la Société absorbante détient l'entièreté du capital de la Société absorbée, il n'y aura aucune
répartition à l'actionnaire de la société absorbée.
Il ne sera pas émis de nouvelles actions par la société absorbante et ainsi il n'y aura aucune indication par rapport à la
date d'émission et les droits attachés à de nouvelles actions, il ne sera réalisé aucun échange d'actions de la société
absorbante contre d'actions de la société absorbée, aucun rapport d'échange n'a été calculé et aucun expert n'a été
nommé en vue d'émettre un rapport sur le rapport d'échange.
La fusion aura pour conséquence que tous les actifs et passifs de la Société absorbée seront transférés à la Société
absorbante.
<i>Déclarationi>
En conformité avec l'article 271 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés telle que modifiée, le notaire soussignée
déclare avoir vérifié et certifié l'existence de la légalité des actes et formalités incombant à la société absorbante et du
projet de fusion, et que ledit projet de fusion a été adopté.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite à ce qui précède, l'assemblée de la société absorbante constate la réalisation de la fusion à la date de la tenue de
la présente assemblée générale approuvant la fusion sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés telle que modifiée.
En ces circonstances la fusion est réalisée et la société absorbée «RETE EUROPA B.V.» a cessé d'exister.
<i>Clôturei>
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société au
présent acte, est estimé à EUR 6.900,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. DI ROBERTO, M. SELIZIATO, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert le 19 décembre 2011. Relation: RED/2011/2776. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 20 décembre 2011.
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2011176511/122.
(110204527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Pareturn, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 47.104.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders (the “Meeting”) of PARETURN (the “Company”) will be held at the registered office of the Company
on Friday <i> 20 i>
<i>thi>
<i> January 2012 i> at 11 a.m., for the purpose of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the directors and of the auditor.
2. Approval of the annual accounts for the accounting year ended September 30, 2011.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended September
30, 2011.
5. Composition of the board of directors.
6. Election or re-election of the auditor for a term of one year.
7. Miscellaneous.
3192
L
U X E M B O U R G
The resolutions submitted to the Meeting do not require any quorum. They are adopted by the simple majority of the
shares present or represented at the Meeting.
In order to attend the Meeting, the holders of bearer shares are required to deposit their share certificates five working
days before the Meeting at the office of BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange, where forms of proxy are available.
<i>By order of the board of directors.i>
Référence de publication: 2011181119/755/25.
ING International Currency Management Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 40.811.
Nous vous informons par la présente que
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
des actionnaires de ING International Currency Management Fund se tiendra au siège social de la Société le mercredi
<i>18 janvier 2012i>
à 15h00 pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises indépendant;
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clôturé le 30 septembre 2011;
3. Affectation des résultats pour l'exercice clôturé le 30 septembre 2011;
4. Décharge du Conseil d'administration pour l'exécution de ses mandats pendant l'exercice clôturé le 30 septembre
2011 et reconnaissance des démissions;
5. Ratification de la cooptation de M. André van den Heuvel en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1
er
novembre 2011;
6. Nomination de M. André van den Heuvel et renouvellement des mandats de M. David Suetens, M. Dirk Buggenhout
et Mme Maaike van Meer en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2013;
7. Réélection de Ernst & Young en tant que réviseur d'entreprises indépendant de la Société;
8. Divers.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir cinq jours francs au moins
avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'assemblée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2011181125/755/26.
Apta Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 99.495.
L'AN DEUX MILLE ONZE, LE QUATORZE DECEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert en remplacement de son confrère
Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la minute.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois
dénommée “APTA FINANCE S.A.”, avec siège social à L-1528 Luxembourg, 11-13, Bd de la Foire, inscrite au R.C.S.
Luxembourg Section B99495,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 3 février 2004, publié au Mémorial C N°447 du 28 avril 2004,
et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 15 octobre 2010, publié au
Mémorial C N°2808 du 22 décembre 2010.
L'assemblée est présidée par Monsieur Leonardo MIOCCHI, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Giorgio BIANCHI, employé, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg,
et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Armand DE BIASE, employé, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
tous ici présents et acceptant.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
3193
L
U X E M B O U R G
I. Suivant la liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, tous les actionnaires, représentant l'en-
tièreté du capital social souscrit, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement
délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.
II. Qu'il résulte de la liste de présence que la totalité du capital est représentée, et qu'en conséquence l'assemblée est
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.
III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 13.735.890.- (Treize millions sept cent trente cinq
mille huit cent quatre-vingt-dix Euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 29.094.580.-(vingt-neuf millions
quatre-vingt-quatorze mille cinq cent quatre-vingt Euros) à EUR 42.830.470 (Quarante-deux millions huit cent trente
mille quatre cent soixante dix Euros) par la création et l'émission d'un million trois cent soixante-treize mille cinq cent
quatre-vingt-neuf (1.373.589) actions nouvelles d'une valeur nominale de Euro 10.- (dix Euro) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer entièrement par un actionnaire.
2. Souscription d'un million trois cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-neuf (1.373.589) actions nouvelles
par un ancien actionnaire de la société dans les proportions suivantes, savoir:
Monsieur Paolo Cavazza, à raison d'un million trois cent soixante treize mille cinq cent quatre-vingt-neuf (1.373.589)
actions nouvelles;
par l'apport en nature de 8.509 actions de la société anonyme de droit Suisse dénommée "HOLDING INTERNA-
TIONAL RESIDENCE SA", avec siège social à Lugano (Suisse), apport évalué à CHF 17.018.000.comme cela ressorts d'un
rapport d'un réviseur d'entreprises.
3. Renonciation de la part de l'autre actionnaire à l'augmentation de capital.
4. Modification afférente de l'article 5 des statuts.
5. Divers.
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé
l'ordre du jour. Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital à concurrence de EUR 13.735.890.- (Treize millions sept
cent trente cinq mille huit cent quatre-vingt-dix Euros),
pour le porter de son montant actuel de EUR 29.094.580.-(vingtneuf millions quatre-vingt-quatorze mille cinq cent
quatre-vingt Euros),
à EUR 42.830.470.-(quarante-deux millions huit cent trente mille quatre cent soixante dix Euros),
par la création et l'émission d'un million trois cent soixante treize mille cinq cent quatre-vingt-neuf (1.373.589) actions
nouvelles d'une valeur nominale de Euro 10.- (dix Euro) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer entièrement par un actuel actionnaire.
<i>Souscription - Libérationi>
Est alors intervenu aux présentes, un actionnaire existant, savoir, Monsieur Paolo Cavazza demeurant à VIA TESSERETE
44 A, Lugano (Suisse), représenté par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme, avec siège social à
Luxembourg, 19-21, bld du Prince Henri, elle même représentée par Monsieur Eduardo TUBIA et Monsieur Seijo AMINO
en vertu d'une procuration datée du 5 décembre 2011.
Le souscripteur, représenté comme il est dit ci-avant, déclare souscrire à la totalité des 1.373.589 (d'un million trois
cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-neuf) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10 (dix Euro)
chacune, qu'il libère intégralement comme suit:
par l'apport en nature de 8.509 actions de la société anonyme de droit Suisse dénommée "HOLDING INTERNA-
TIONAL RESIDENCE SA", avec siège social à Lugano (Suisse),
que ce dernier détient dans la susdite société à concurrence de 78%, apport évalué à CHF 17.018.000.-(dix-sept millions
zéro dix-huit mille Euros), tel que cela ressort d'un rapport d'un réviseur d'entreprises établi préalablement aux présentes
par le réviseur d'entreprises savoir: la société « H.R.T. Révision S.A.», société anonyme, avec siège social à Luxembourg,
RCS Luxembourg B51238,
lequel rapport établi conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983, conclut que:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de l'apport
de EUR 13.735.890.-ne correspond pas au moins à 1.373.589 nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 10 de APTA
FINANCE S.A. à émettre en contrepartie.
Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l'augmentation de capital de APTA FINANCE S.A. de EUR 13.735.890
et ne peut être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable.»
Lequel rapport, daté du 13 décembre 2011, demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux
formalités du timbre et de l'enregistrement.
3194
L
U X E M B O U R G
L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des un million
trois cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-neuf (1.373.589) actions nouvelles par le susdit souscripteur, dans
les proportions dont question ci-avant.
La preuve du transfert des actions de "HOLDING INTERNATIONAL RESIDENCE SA" à la société "APTA FINANCE
S.A." sera rapportée au notaire instrumentant par une confirmation de l'administrateur unique de "HOLDING INTER-
NATIONAL RESIDENCE SA" de procéder au transfert des titres faisant l'objet de l'apport dans les registres de la société
"HOLDING INTERNATIONAL RESIDENCE SA ».
<i>Renonciationi>
L'assemblée constate que l'autre actionnaire Madame Claudia Paponi a renoncé à son droit préférentiel de souscription
dans la Société tel que cela résulte d'une renonciation donnée par elle et datée du 5 décembre 2011.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précédent, de modifier le l'article 5 des statuts, pour lui
donner dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 42.830.470. (quarante-deux millions huit cent trente mille quatre
cent soixante dix Euros), représenté par 4.283.047 (quatre millions deux cent quatre-vingttrois mille quarante-sept)
actions d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune.
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l'actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
<i>Clôturei>
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.
<i>Déclaration - Evaluation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que
les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,
suite à l'augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 5.300,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms,
états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: L. MIOCCHI, G. BIANCHI, A. DE BIASE, E. TUBIA, S. AMINO, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 19 décembre 2011, LAC/2011/56547: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
- Pour expédition conforme délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Référence de publication: 2011178432/117.
(110208351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Pegasos, Fonds Commun de Placement.
SONDERREGLEMENT
Für den Fonds gilt das Sonderreglement, welches am 13. Dezember 2011 in Kraft trat. Das Sonderreglement wurde
beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 8. Dezember 2011.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Untershriften
Référence de publication: 2011170755/11.
(110198265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
3195
L
U X E M B O U R G
Pegasos, Fonds Commun de Placement.
ALLGEMEINES VERWALTUNGSREGLEMENT
Für den Fonds gilt das Allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 13. Dezember 2011 in Kraft trat. Das Verwal-
tungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 8. Dezember 2011.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Untershriften
Référence de publication: 2011170756/11.
(110198267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Olympia SICAV Lux, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 147.870.
L'an deux mille onze, le septième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu
Me Philippe Coulon, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de Olympia Capital Ma-
nagement S.A., une société anonyme de droit français, ayant son siège social au 21/25, rue Balzac, 75008, Paris, France et
enregistrée auprès du R.C.S. Paris sous le numéro B 379 217 516 ("l'Associé Unique"), en vertu d'une procuration délivrée
sous seing privé, le 30 novembre 2011, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui, étant l'associé unique de OLYMPIA SICAV
LUX une société anonyme de droit luxembourgeois ayant la forme d'une société d'investissement à capital variable –
fonds d'investissement spécialisé, ayant son siège social au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 147.870, constituée suivant acte reçu par Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 19 août 2009, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1765 du 12 septembre 2009 (la "Société"). Le mandataire a
déclaré et prié le notaire d'acter que:
I. L'Associé Unique détient toutes les trois cent dix (310) actions émises par la Société.
II. L'Associé Unique confirme avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour et avoir renoncé à une convo-
cation préalable de sorte que les décisions peuvent valablement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III. L'ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Nomination de KPMG Luxembourg S.à r.l. en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société pour l'audit de
la période du 1
er
janvier 2011 à la date de mise en liquidation de la Société.
2. Mise en liquidation de la Société.
3. Nomination de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., représentée par Monsieur Pierre-François Wéry en qualité de
liquidateur de la Société (le "Liquidateur"), détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération et nomination de KPMG
Luxembourg S.à r.l. en qualité de réviseur à la liquidation de la Société.
A la suite de quoi, les résolutions suivantes ont été adoptées.
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer KPMG Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, en qualité de réviseur d'entreprises agréé pour l'audit de la période du 1
er
janvier 2011 à la date de mise
en liquidation de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de mettre la Société en liquidation avec effet à la date de ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg, représentée par Monsieur Pierre-François Wéry en qualité de liquidateur de la Société (le "Liqui-
dateur"). L'Associé Unique décide aussi de nommer KPMG Luxembourg S.à r.l. en qualité de réviseur à la liquidation de
la Société.
3196
L
U X E M B O U R G
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus déterminés par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"). Le Liquidateur peut accomplir tous les actes et pro-
céder à toutes les opérations prévues à l'article 145 de la Loi sans autorisation spéciale de l'Associé Unique.
Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux documents comptables de la Société.
Le Liquidateur est autorisé à déléguer sous sa propre responsabilité certaines fonctions déterminées aux conditions
et pour la durée qu'il déterminera.
Le Liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus par des
réviseurs d'entreprises agréés.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, la
personne comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. COULON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56346. Reçu douze euros (12.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011179941/60.
(110209376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
HAIG Return, Fonds Commun de Placement.
SONDERREGLEMENT
Für den Fonds gilt das Sonderreglement, welches am 13. Dezember 2011 in Kraft trat. Das Sonderreglement wurde
beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 8. Dezember 2011.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Untershriften
Référence de publication: 2011170757/12.
(110198271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
HAIG Return, Fonds Commun de Placement.
ALLGEMEINES VERWALTUNGSREGLEMENT
Für den Fonds gilt das Allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 13. Dezember 2011 in Kraft trat. Das Verwal-
tungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 8. Dezember 2011.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Untershriften
Référence de publication: 2011170758/12.
(110198273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
E/Shelter S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 622.875,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 76.501.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND ELEVEN, ON THE 30
TH
DAY OF NOVEMBER.
Before us Maître Jacques DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Lux e-shelter 1, a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number
B162738,
3197
L
U X E M B O U R G
duly represented Miss Lauren HARRIS, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 30
th
of November
2011, in Luxembourg.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of E/SHELTER S.àr.l.,a société à responsabilité
limitée (a private limited liability company), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 76.501 (the "Company"), incorporated pursuant
to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, dated 29 May 2000, and
whose articles of association (the "Articles") were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on
25 October 2000 n°780 page 37426. The Articles were last amended pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit,
prenamed, dated 9 July 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 12 January 2002, n°
63 page 3016.
The appearing party representing the whole Company's share capital requires the notary to act the following resolu-
tions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of five hundred
ninety-two thousand eight hundred seventy-five euros (EUR 592,875.-) in order to raise it from its current amount of
thirty thousand euros (EUR 30,000.-) to six hundred twentytwo thousand eight hundred seventy-five euros (EUR
622,875.-) by issuing twenty-three thousand seven hundred fifteen (23,715) new shares (the "New Shares"), having the
same rights and obligations as the existing shares, with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each and to be
issued with a share premium of a total amount of fifty-eight million six hundred ninety-five thousand one hundred seven
euros (EUR 58,695,107.-) (the "Share Premium") by way of contribution in kind.
<i>Contribution in kindi>
The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to the ownership of the twenty-three thou-
sand seven hundred fifteen (23,715) New Shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, and issued with
a Share Premium for a total amount of fifty-eight million six hundred ninety-five thousand one hundred seven euros (EUR
58,695,107.-) for an aggregate total amount of fiftynine million two hundred eighty-seven thousand nine hundred eighty-
two euros (EUR 59,287,982) and to fully pay up such New Shares by a contribution in kind consisting of the Sole
Shareholder's limited partnership interest in E/Shelter GmbH & Co. KG, a limited liability company (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) incorporated and existing under the laws of Germany with its seat in Eschborn, registered with
the commercial register of the local court at Frankfurt am Main under HR A 45483 consisting of a compulsory contribution
(Pflichteinlage) of two hundred eighty-eight thousand seventeen euros and fifty-eight cents (EUR 288,017.58), and a liable
contribution (Hafteinlage) to be registered in the commercial register in the amount of seven million six hundred thirty-
six thousand nine hundred euros (EUR 7,636,900), which has a market value of fiftynine million two hundred eighty-seven
thousand nine hundred eighty-two euros (EUR 59,287,982), and which is to be allocated as follows:
- twenty-three thousand seven hundred fifteen (23,715) New Shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25.-)
each to the share capital of the Company and,
- a Share Premium for a total amount of fifty-eight million six hundred ninety-five thousand one hundred seven euros
(EUR 58,695,107.-)
Pursuant to a copy of a valuation report the managers of the Company have valued the contribution in kind at a total
amount of fifty-nine million two hundred eighty-seven thousand nine hundred eighty-two euros (EUR 59,287,982) which
is equal to the value of the New Shares and the Share Premium.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 4 of the Articles in order to reflect the decision taken under the
preceding resolution. Article 4 shall now read as follows:
"The Company's subscribed share capital is fixed at six hundred twenty-two thousand eight hundred seventy-five euros
(EUR 622,875.-) represented by twenty-four thousand nine hundred fifteen (24,915) ordinary shares having a nominal
value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share.
The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single partner or, as the case may be, by
decision of the partners' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles."
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 6,600.-.
3198
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française
L'AN DEUX MILLE ONZE, LE 30 NOVEMBRE
Par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A COMPARU:
Lux e-shelter 1, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg , immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B162738,
ici représentée par Mlle Lauren HARRIS, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing
privée, donnée à Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui auprès des autorités d'enregistrement.
La partie comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") de E/SHELTER S.àr.l., une société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 76 501 (la
"Société"), constituée par un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Hesperange, Grand-Duché du Luxembourg,
en date du 29 mai 2000, et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 780, page 37426 en date du 25 octobre 2000. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un
acte de Maître Gérard Lecuit, précité, en date du 9 juillet 2001, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, le 12 janvier 2002, numéro 63, page 3016.
La partie comparante représentant l'ensemble du capital social de la Société demande au notaire de prendre acte des
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq cent quatre-vingt douze mille
huit cent soixante-quinze euros (EUR 592.875,-) afin de porter son montant actuel de trente mille euros (EUR 30.000,-)
à six cent vingt-deux mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 622.875,-) par la création et l'émission de vingt-trois
mille sept cent quinze (23.715) nouvelles parts sociales ("Nouvelles Parts Sociales") ayant les mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et avec l'émission d'une
prime d'émission d'un montant total de cinquante-huit millions six cent quatre-vingt quinze mille cent sept euros (EUR
58.695.107,-) (la "Prime d'Emission") par apport en nature.
<i>Apport en naturei>
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à la propriété de vingt-trois mille sept cent
quinze (23.715) Nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, émises avec une
prime d'émission d'un montant total de cinquante-huit millions six cent quatre-vingt quinze mille cent sept euros (EUR
58.695.107), pour un montant total cumulé de cinquante-neuf millions deux cent quatre-vingt sept mille neuf cent quatre-
vingt deux euros (EUR 59.287.982,-), et de libérer intégralement ces Nouvelles Actions par un apport en nature, consistant
en la participation de l'Associé Unique dans E/shelter GmbH & Co. KG, société à responsabilité limitée de droit allemand
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung), ayant son siège social à Mergenthalerallee 79-81, 65760 Eschborn, Allemagne,
et enregistrée auprès du Registre du Commerce de la Cour locale de Frankfurt/Main sous le numéro HRA 45483, composé
d'un "Pflichteinlage" de deux cent quatre-vingt huit mille dix-sept euros et cinquante huit centimes (EUR 288.017,58), et
d'un "Hafteinlage" à enregistrer au registre de commerce pour le montant de sept millions six cent trente-six mille neuf
cents euros (EUR 7.636.900), qui a une valeur en bourse estimée à cinquante-neuf millions deux cent quatre-vingt sept
mille neuf cent quatre-vingt deux euros (EUR 59.287.982,-), et qui est alloué comme suit:
- vingt-trois mille sept cent quinze (23.715) Nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, au capital social de la Société;
- la somme de cinquante-huit millions six cent quatre-vingt quinze mille cent sept euros (EUR 58.695.107,-) au compte
de prime d'émission de la Société.
Suivant copie d'un rapport d'évaluation les gérants de la Société ont évalué l'apport en nature à un montant de cin-
quante-neuf millions deux cent quatre-vingt sept mille neuf cent quatre-vingt deux euros (EUR 59.287.982,-) ce qui est
égal à la valeur des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission.
3199
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des Statuts afin de refléter les décisions prises à la résolution précédente.
L'article 4 sera dorénavant rédigé comme suit:
"Le capital social souscrit est fixé à six cent vingt-deux mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 622.875,-) représenté
par vingt-quatre mille neuf cent quinze (24.915) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires") ayant chacune
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par
décision de l'assemblée des associés délibérant de la même manière que celle prévue pour la modification des Statuts."
<i>Coûtsi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement EUR 6.600,-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande de la personne comparante, le
présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de cette même personne, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Sur quoi le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.
Après que lecture de l'acte a été faite au mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom,
prénom, statut marital, lieu de résidence, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: L. HARRIS, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 6 décembre 2011, LAC/2011/54194: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- Pour expédition conforme délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Luxembourg, le 23 décembre 2011
Référence de publication: 2012000484/148.
(110212062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Codic Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 58.352.
L'an deux mil onze, le huit décembre.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme CO-
DIC LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 4, Avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, en vertu d'un
pouvoir lui conféré par le conseil d'administration en date du 27 septembre 2011. Une copie conforme de ladite résolution
se trouve annexée au projet de fusion notarié dont question ci-après. Le projet de fusion a été enregistré à Redange/
Attert le 27 octobre 2011, Relation: RED/2011/2255.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
1. Par acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 octobre 2011, les conseils d'administration de la société anonyme
CODIC LUXEMBOURG S.A. («la société absorbante») et des sociétés anonymes K2A S.A., K2B S.A., K2C S.A., K2D
S.A., K2E S.A., K2F S.A. («les sociétés absorbées») ont établi un projet commun de fusion aux termes duquel la société
anonyme CODIC LUXEMBOURG S.A. absorbe les sociétés anonymes K2A S.A., K2B S.A., K2C S.A., K2D S.A., K2E S.A.,
K2F S.A. Conformément à ce projet commun de fusion, la fusion devient définitive à défaut de convocation d'une as-
semblée générale par un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins cinq pour cent des
actions du capital souscrit ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, un mois après la publication au Mémorial du projet
commun de fusion. Ledit projet commun de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2698 du 7 novembre 2011.
2. Le comparant déclare qu'une telle assemblée générale n'a pas été requise et que dès lors la fusion entre la société
absorbante et les sociétés absorbées est devenue effective à partir de ce jour et les sociétés K2A S.A., K2B S.A., K2C
S.A., K2D S.A., K2E S.A., K2F S.A. ont donc définitivement cessé d'exister.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. PONSARD, C. DELVAUX.
3200
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Redange/Attert, le 09 décembre 2011. Relation: RED/2011/2705. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 15 décembre 2011.
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2011172361/37.
(110200635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
1798 European Credit Opportunities Master Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investisse-
ment Spécialisé,
(anc. 1798 European Loan Master Fund).
Le règlement de gestion modifié de 1798 European Credit Opportunities Master Fund (anciennement 1798 European
Loan Master Fund) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
«The amended management regulations of 1798 European Credit Opportunities Master Fund (formerly 1798 European
Loan Master Fund) were deposited with the Registre de commerce et des sociétés.
For publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.»
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Référence de publication: 2011177751/14.
(110207185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Pelham e-shelter Berlin S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 135.150,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 127.450.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND ELEVEN, ON THE 30
TH
DAY OF NOVEMBER.
Before us Maître Jacques DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Lux e-shelter 1, a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B
162.738,
duly represented by Miss Lauren HARRIS, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 30
th
of
November 2011 in Luxembourg
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Pelham e-shelter Berlin S.àr.l.,a société à
responsabilité limitée (a private limited liability company), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 25C, boulevard Royal, L2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 127 450 (the "Company"), incor-
porated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated
04 April 2007, and whose articles of association (the "Articles") were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations on 25 June 2007 n°1257 page 60298.
The appearing party representing the whole Company's share capital requires the notary to act the following resolu-
tions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of one hundred
twenty-two thousand six hundred fifty euros (EUR 122,650.-) in order to raise it from its current amount of twelve
thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to one hundred thirty-five thousand one hundred fifty euros (EUR 135,150.-)
by issuing four thousand nine hundred six (4,906) new shares (the "New Shares"), having the same rights and obligations
as the existing shares, with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each and to be issued with a share premium
of a total amount of twelve million one hundred forty-two thousand three hundred sixty-two euros (EUR 12,142,362.-)
(the "Share Premium") by way of contribution in kind.
3201
L
U X E M B O U R G
<i>Contribution in kindi>
The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to the ownership of the four thousand nine
hundred six (4,906) New Shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, and issued with a Share Premium
for a total amount of twelve million one hundred forty-two thousand three hundred sixtytwo euros (EUR 12,142,362.-)
for an aggregate total amount of twelve million two hundred sixty-five thousand twelve euros (EUR 12,265,012) and to
fully pay up such New Shares by a contribution in kind consisting of the Sole Shareholder's limited partnership interest
in e-shelter Berlin GmbH & Co. KG, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated and
existing under the laws of Germany with its seat in Eschborn, registered with the commercial register of the local court
at Frankfurt am Main under HR A 45487 consisting of a compulsory contribution (Pflichteinlage) of one thousand two
hundred ten euros and ninety-one cents (EUR 1,210.91), and a liable contribution (Hafteinlage) to be registered in the
commercial register in the amount of four hundred seventy-four euros (EUR 474.-), which has a market value of twelve
million two hundred sixty-five thousand twelve euros (EUR 12,265,012), and which is to be allocated as follows:
- four thousand nine hundred six (4,906) New Shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each to the
share capital of the Company and,
- a Share Premium for a total amount of twelve million one hundred forty-two thousand three hundred sixty-two
euros (EUR 12,142,362.-).
Pursuant to a copy of a valuation report the managers of the Company have valued the contribution at a total amount
of twelve million two hundred sixty-five thousand twelve euros (EUR 12,265,012) which is equal to the value of the New
Shares and the Share Premium.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 4 of the Articles in order to reflect the decision taken under the
preceding resolution. Article 4 shall now read as follows:
"The share capital is fixed at one hundred thirty-five thousand one hundred fifty euros (EUR 135,150.-) represented
by five thousand four hundred six (5,406) ordinary shares (the "Ordinary Shares") with a nominal value of twenty-five
Euros (EUR 25.-) per share.
The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single partner or, as the case may be, by
decision of the partners' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles."
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 5,100.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L'AN DEUX MILLE ONZE, LE TRENTE NOVEMBRE.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A COMPARU:
Lux e-shelter 1, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché of Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.738,
ici représentée par Mlle Lauren HARRIS, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing
privée, donnée à Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui auprès des autorités d'enregistrement.
La partie comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") de Pelham e-shelter Berlin S.àr.l., une société à res-
ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
B127450 (la "Société"), constituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché
du Luxembourg, en date du 4 avril 2007, et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n°1257 page 60298 en date du 25 juin 2007.
3202
L
U X E M B O U R G
La partie comparante représentant l'ensemble du capital social de la Société demande au notaire de prendre acte des
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent vingt-deux mille six cent
cinquante euros (EUR 122.650,-) afin de porter son montant actuel de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) à cent
trente-cinq mille cent cinquante euros (EUR 135.150,-) par la création et l'émission de quatre mille neuf cent six (4.906)
nouvelles parts sociales ("Nouvelles Parts Sociales") ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes,
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et avec l'émission d'une prime d'émission d'un montant
total de douze millions cent quarante-deux mille trois cent soixante-deux euros (EUR 12.142.362,-) (la "Prime d'Emission")
par apport en nature.
<i>Apport en naturei>
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à la propriété de quatre mille neuf cent six
(4.906) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, émises avec une prime
d'émission d'un montant total de douze millions cent quarante-deux mille trois cent soixante-deux euros (EUR
12.142.362,-), pour un montant total cumulé de douze millions deux cent soixante-cinq mille douze euros (EUR
12.265.012,-), et de libérer intégralement ces Nouvelles Actions par un apport en nature consistant en la participation
de l'Associé Unique dans e-shelter Berlin GmbH & Co. KG, société à responsabilité limitée de droit allemand (Gesellschaft
mit beschränkter Haftung), ayant son siège social à Mergenthalerallee 79-81, 65760 Eschborn, Allemagne, et enregistrée
auprès du Registre du Commerce de la Cour locale de Frankfurt/Main sous le numéro HRA 45787E/, composé d'un
"Pflichteinlage" de mille deux cent dix euros et quatre-vingt onze centimes (EUR 1.210,91-), et d'un "Hafteinlage" à en-
registrer au registre de commerce pour le montant de quatre cents soixante quatorze euros (EUR 474.-), qui a une valeur
en bourse estimée à douze millions deux cent soixantecinq mille douze euros (EUR 12.265.012,-), et qui est alloué comme
suit:
- quatre mille neuf cent six (4.906) Nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, au capital social de la Société;
- la somme de douze millions cent quarante-deux mille trois cent soixante-deux euros (EUR 12.142.362,-) au compte
de prime d'émission de la Société.
Suivant copie d'un rapport d'évaluation les gérants de la Société ont évalué l'apport en nature à un montant de douze
millions deux cent soixante-cinq mille douze euros (EUR 12.265.012,-) ce qui est égal à la valeur des Nouvelles Parts
Sociales et de la Prime d'Emission.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des Statuts afin de refléter les décisions prises à la résolution précédente.
L'article 4 sera dorénavant rédigé comme suit:
"Le capital social souscrit est fixé à cent trente-cinq mille cent cinquante euros (EUR 135.150,-) représenté par cinq
mille quatre cent six (5,406) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires") ayant chacune une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-).
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par
décision de l'assemblée des associés délibérant de la même manière que celle prévue pour la modification des Statuts."
<i>Coûtsi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement EUR 5.100,-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande de la personne comparante, le
présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de cette même personne, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Sur quoi le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.
Après que lecture de l'acte a été faite au mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom,
prénom, statut marital, lieu de résidence, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: L. HARRIS, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 6 décembre 2011, LAC/2011/54195: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
Pour expédition conforme délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Référence de publication: 2012000830/143.
(110212061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
3203
L
U X E M B O U R G
Pioneer CIM, Fonds Commun de Placement.
The amended management regulations with respect to the fund Pioneer CIM have been filed with the Luxembourg
Trade and Companies Register.
Le règlement de gestion modifié concernant le fonds commun de placement Pioneer CIM a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Pionner Asset Management S.A.
Signature
Référence de publication: 2012002595/13.
(120001002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Cygnus Real Estate Fund, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Cygnus Real Estate Fund coordonné a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Cygnus Real Estate Management Company S.à r.l.
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Nathalie Lett / Marie-Laurence ...
Référence de publication: 2012003619/12.
(120002877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Eurizon Riserva, Fonds Commun de Placement.
<i>CLÔTURE DE LIQUIDATIONi>
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société de gestion Eurizon Capital S.A. tenu le 24 octobre
2011 que le fonds commun de placement de droit luxembourgeois EURIZON RISERVA a été mis en liquidation avec effet
immédiat. La clôture de la susdite liquidation est également intervenue le 24 octobre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
EURIZON CAPITAL S.A.
Jérôme DEBERTOLIS
Référence de publication: 2012004070/7255/11.
WPA Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.020.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 87.600.
Woodbridge International Holdings S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 1.061.041.859,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 66.196.
In the year two thousand and eleven, on the twenty third day of December,
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
Mr. Tom LOESCH, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting in his capacity as a special attorney-in-fact of:
the board of managers of WPA Holdings S.à.r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg,
with a share capital of one million twenty thousand dollars of the United-States of America (USD 1,020,000.-), having its
registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 87.600 (hereinafter referred to as “Absorbed Company”)
and incorporated following a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, of 31 May 2002, published in
3204
L
U X E M B O U R G
the Memorial C number 1190 of 8 August 2002, which articles of association have been amended for the last time following
a deed of Maître Frank Baden, of 7 June 2002, published in the Memorial C number 1266 of 30 August 2002,
by virtue of the authority conferred on him by resolutions of the board of managers of the Absorbed Company adopted
on 16 September 2011; and the board of directors of Woodbridge International Holdings S.A., a société anonyme go-
verned by the laws of Luxembourg, with a share capital of one billion sixty-one million forty-one thousand eight hundred
fifty-nine dollars of the United-States of America (USD 1,061,041,859.-), having its registered office at 3, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 66.196 (hereinafter referred to as “Absorbing Company”) and incorporated following a deed of
Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of maître Frank Baden, notary residing in
Luxembourg, of 18 August 1998, published in the Memorial C number 844 of 19 November 1998, which articles of
association have been amended for the last time following a deed of Maître Paul Decker of 6 June 2007, published in the
Memorial C number 1757 of 20 August 2007,
by virtue of the authority conferred on him by resolutions of the board of directors of the Absorbing Company adopted
on 16 September 2011
excerpts of the minutes of the meetings of the board of managers of the Absorbed Company and of the board of
directors of the Absorbing Company, after having been signed ne varietur by the appearing person and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Said appearing person, acting in such capacity, has requested the undersigned notary to record the following declara-
tions and statements:
- that in accordance with the joint merger proposal in notarial form recorded in a deed of the undersigned notary on
28 October 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2776 of 15 November 2011
(the “Joint Merger Proposal”), the Absorbing Company, as absorbing company and the Absorbed Company, as absorbed
company, proposed to merge under the procedure of a simplified merger by absorption provided for under articles 278
and seq. of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Merger”);
- that no shareholder of the Absorbing Company required, during the period of one (1) month following the publication
of the Joint Merger Proposal in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, an extraordinary general meeting
of the Absorbing Company, to be convened in order to resolve on the approval of the Merger;
- that the Absorbing Company acknowledges that the Merger becomes effective on the date hereof, being more than
one calendar month after the day of publication of the Joint Merger Proposal in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations and that the Merger entails ipso jure the universal transfer of all assets and liabilities of the Absorbed
Company to the Absorbing Company on the date hereof;
- that as a result of the Merger, the Absorbed Company has been dissolved without liquidation, the shares of the
Absorbed Company have been cancelled and the books and documents of the Absorbed Company are kept during the
legal period (five (5) years) at the registered office of the Absorbing Company.
- that as a result of the Merger, the Absorbing Company is persisting as legal entity;
- that on the day of publication of this deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Merger will
become effective vis-à-vis third parties.
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-
mately 2.100,- EUR.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version and that at the request of the appearing person and in case of divergences between
the two versions, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with his notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-trois décembre,
Par devant nous Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
M
e
Tom LOESCH, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial:
du conseil de gérance de WPA Holdings S.à.r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois,
avec un capital social de un million vingt mille dollars des États-Unis d'Amérique (USD 1.020.000,), ayant son siège social
au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-87.600 (ci-après la «Société Absorbée») et constituée par acte de Maître
Frank Baden, notaire résidant à Luxembourg, en date du 31 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1190 du 8 août
3205
L
U X E M B O U R G
2002, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Frank Baden, en date du 7 juin 2002, publié
au Mémorial C numéro 1266 du 30 août 2002,
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les résolutions du conseil de gérance de la Société Absorbée adoptées
le 16 septembre 2011; et
du conseil d'administration de Woodbridge International Holdings S.A., une société anonyme régie par le droit lu-
xembourgeois, avec un capital social de un milliard soixante-et-un millions quarante-et-un mille huit cent cinquante-neuf
dollars des États-Unis d'Amérique (USD 1.061.041.859,-), ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B-66.196 (ci-après la «Société Absorbante») et constituée par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à
Sanem, agissant en remplacement de maître Frank Baden, notaire résidant à Luxembourg, en date du 18 août 1998, publié
au Mémorial C numéro 844 du 19 novembre 1998, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de
Maître Paul Decker, en date du 6 juin 2007, publié au Mémorial C numéro 1757 du 20 août 2007,
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les résolutions du conseil d'administration de la Société Absorbante
adoptées le 16 septembre 2011.
Les extraits du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance de la Société Absorbée et du procès-verbal de la
réunion du conseil d'administration de la Société Absorbante, après avoir été signés «ne varietur» par la personne qui
comparaît et par le notaire soussigné, resteront attachés au présent acte pour être déposés en même temps pour en-
registrement.
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné d'acter les déclarations et constatations
suivantes:
- que conformément au projet commun de fusion établi sous forme notariée suivant acte du notaire soussigné en date
du 28 octobre 2011, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2776 du 15 novembre 2011
(le «Projet Commun de Fusion»), la Société Absorbante, en tant que société absorbante, et la Société Absorbée, en tant
que société absorbée, ont projeté de fusionner conformément à la procédure de fusion par absorption simplifiée régie
par les articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Fusion»);
- qu'aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant une période d'un (1) mois suivant la publication
du Projet Commun de Fusion dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations qu'une assemblée générale ex-
traordinaire de la Société Absorbante soit convoquée en vue de se prononcer sur l'approbation de la Fusion;
- que la Société Absorbante constate que la Fusion devient effective à la date des présentes qui se situe plus d'un mois
après le jour de la publication du Projet Commun de Fusion dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et
que la Fusion entraîne de plein droit la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société
Absorbée à la Société Absorbante à la date des présentes;
- que suite à la Fusion, la Société Absorbée a été dissoute sans liquidation, les actions de la Société Absorbée ont été
annulées et les livres et documents de la Société Absorbée sont conservés pendant la période légale (cinq (5) ans) au
siège social de la Société Absorbante;
- que suite à la Fusion, la Société Absorbante continue d'exister en tant que personne morale;
- qu'au jour de publication du présent acte dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la Fusion deviendra
effective vis-à-vis des tiers.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à 2.100,-EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente que le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande de la comparante et en cas de divergences entre les
deux versions, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire soussigné par son nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé:, T. LOESCH, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58529. Reçu 75,-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003414/129.
(120002308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
3206
L
U X E M B O U R G
exceet Group SE, Société Européenne.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 148.525.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Référence de publication: 2011167259/10.
(110194058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Min Asset Management S.A., Société Anonyme,
(anc. Yucatan S.A.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 130.345.
EN L'ANNEE DEUX MILLE ONZE, LE VINGT-HUIT DECEMBRE.
Par-devant nous, Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MIN ASSET MANAGEMENT S.A., inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 130.345, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, constituée par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, le 26 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association le 14 septembre 2007, numéro
1.983, à la page 95.164.
L'assemblée s'est ouverte à 14h10 sous la présidence de Me Max WELBES, avocat à la Cour, résidant professionnel-
lement au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, qui a nommé Me Robert GOEREND, avocat, résidant professionnellement
au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg en tant que secrétaire de cette assemblée générale extraordinaire.
Celle-ci a nommé Me Marie-Astrid WILLEMS, Rechtsanwältin, résidant professionnellement au 3, rue Goethe, L-1637
Luxembourg en tant que scrutateur.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président déclare et le notaire acte que:
1. Les actionnaires représentés, ainsi que le nombre respectif des actions qu'ils détiennent, figurent sur une liste de
présence qui restera annexée aux présentes minutes. Les procurations des actionnaires représentés, paraphées «ne
varietur», seront soumises aux formalités de l'enregistrement ensemble avec cet acte;
2. Au vu de cette liste de présence, il ressort que tous les actionnaires sont représentés;
3. Tous les actionnaires ont déclarés renoncer aux formalités de convocation; et,
4. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est ainsi valablement constituée.
L'ordre du jour est le suivant:
1. Changement de la monnaie de référence d'euro en francs suisse.
2. Conversion du capital social en francs suisse, au taux de change différent déterminé lors de la clôture des marchés
de change du jour bancaire précédant le jour auquel se tient l'assemblée générale extraordinaire et modification subsé-
quente de l'article 5 des statuts de la Société
3. Modification de l'objet de la Société à l'article 4 comme suit:
«L'objet de la Société est d'agir en qualité d'actionnaire gérant commandité de MIN S.C.A.,FIS (la «SICAF-FIS») et de
MIN Woodgate S.C.A., SICAV-FIS (la «SICAVFIS») et, en cette qualité, la Société peut gérer la SICAF-FIS ainsi que la
SICAV-FIS et leurs actifs respectifs et décider, notamment, des objectifs, politiques et restrictions d'investissement et de
l'organisation de la gestion et des affaires de la SICAF-FIS et de la SICAV-FIS, conformément à la loi luxembourgeoise du
13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés telle que modifiée de temps en temps, leurs statuts et documents
d'émission. La Société peut aussi conclure des contrats de gestion d'investissement et de conseil d'investissement et tout
autre contrat qu'elle estime nécessaire, utile ou conseillé pour l'exécution de ses fonctions.» .
Après délibération, les actionnaires, y compris l'associé gérant commandité, ont pris les résolutions suivantes à l'una-
nimité:
<i>Première résolutioni>
L'actionnaire unique décide de changer la monnaie de référence de la société d'euro en francs suisse.
<i>Deuxième résolutioni>
L'actionnaire unique décide de modifier la devise du capital du capital social exprimé en euros en en francs suisse au
taux de change en date du 22 décembre 2011, soit un taux de change 1,2210 francs suisse pour un 1 euro et de supprimer
la désignation de la valeur nominale des actions donc de convertir le montant du capital social de trente et un mille euros
(EUR 31.000,-) en un montant de trente-sept mille huit cent cinquante et un francs suisse (CHF 37.851) représenté par
3207
L
U X E M B O U R G
mille (1.000) actions sans désignation d'une valeur nominale. La différence résultant de l'application du cours de change
au 28 décembre 2011 et le cours de change applicable à la date du présent acte (savoir EUR 1,00 = CHF 1,2195), soit la
somme de 47 EUR est transférée à un compte de réserve spécial, duquel, il ne pourra être disposé, qu'en observant les
règles de l'article 69-3 de la loi sur les sociétés commerciales comme en matière de réduction de capital.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la résolution précédente, l'actionnaire unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 comme
suit:
«Le capital social est fixé à trente-sept mille huit cent cinquante et un francs suisse (CHF 37.851) représenté par mille
(1.000,-) actions sans désignation d'une valeur nominale chacune, toutes intégralement libérées. Les actions peuvent être
nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.».
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'objet de la Société et partant l'article 4 des statuts qui se lira
dorénavant comme suit:
«L'objet de la Société est d'agir en qualité d'actionnaire gérant commandité de MIN S.C.A.,FIS (la «SICAF-FIS») et de
MIN Woodgate S.C.A., SICAV-FIS (la «SICAVFIS») et, en cette qualité, la Société peut gérer la SICAF-FIS ainsi que la
SICAV-FIS et leurs actifs respectifs et décider, notamment, des objectifs, politiques et restrictions d'investissement et de
l'organisation de la gestion et des affaires de la SICAF-FIS et de la SICAV-FIS, conformément à la loi luxembourgeoise du
13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés telle que modifiée de temps en temps, leurs statuts et documents
d'émission. La Société peut aussi conclure des contrats de gestion d'investissement et de conseil d'investissement et tout
autre contrat qu'elle estime nécessaire, utile ou conseillé pour l'exécution de ses fonctions.».
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou toute autre charge qui seront supportés par la société au titre de cette as-
semblée générale des actionnaires sont estimés à approximativement EUR 1.500.-.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne souhaitant prendre la parole, le Président déclare l'assemblée générale
des actionnaires close à 14h30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du
bureau, tous connus du notaire soussigné par noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.
Signé: M. WELBES, R. GOEREND, M.-A. WILLEMS, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert le 30 décembre 2011. Relation: RED/2011/3009. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 02 janvier 2012.
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012003846/84.
(120003278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
navAXX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 161.049.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Référence de publication: 2011167260/10.
(110194037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
BLEC s.à r.l., BeLux Enterpises Consulting s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 153.807.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63100 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
3208
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011167304/10.
(110194349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
SEB Multi-Manager Currency Defensive, Fonds Commun de Placement.
On 4 January 2012, the board of SEB Asset Management S.A. acting as Management Company of SEB Multi-Manager
Currency Defensive (hereafter "the Fund") has decided in accordance with Article 14 of the Management Regulations
(General Section) to put the Fund into liquidation effective as of 20 January 2012.
No new units are issued, redemptions remain possible under consideration of the equal treatment of the unitholders.
The calculation of the net asset value will be suspended as from 20 January 2012.
SEB Asset Management S.A. will bear all the costs relating to the liquidation.
Mr Rudolf Kömen as representative of the Management Company is appointed as liquidator of the Fund.
SEB Asset Management S.A.
Référence de publication: 2012005368/755/12.
EFCO-Forodia Exploitation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4580 Differdange, rue de Hussigny.
R.C.S. Luxembourg B 143.719.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 6 décembre 2011.
<i>Pour EFCO-FORODIA EXPLOITATION S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.
Référence de publication: 2011167388/12.
(110193973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Digital Investments S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société
d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 157.181.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011167377/11.
(110194093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Wiesen-Piront Constructions S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 85.748.
L'an deux mille onze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de “WIESEN-PIRONT CONSTRUC-
TIONS S.A.”, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social
à L-8140 Bridel, 88, route de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 85748, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à
Junglinster, en date du 28 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 743 du 15
mai 2002.
L'assemblée est présidée par Madame Alexia UHL, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling.
La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement
à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à
L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
3209
L
U X E M B O U R G
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'objet social, en y ajoutant l'alinéa suivant:
"Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes."
2. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le dernier mardi du mois de juin
à 11.00 heures;
3. Modification du régime de signature statutaire des administrateurs comme reproduit dans ci-après dans les articles
13 des statuts refondus;
4. Refonte complète des statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et notamment avec les dispositions de la loi du 25 août 2006, intro-
duisant, entre autres, la société anonyme unipersonnelle avec un administrateur unique;
5. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide:
- de modifier l'objet social en y ajoutant l'alinéa suivant.
"Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.";
- de modifier la date de l'assemblée générale annuelle, de sorte qu'elle se tiendra dans l'avenir le dernier mardi du mois
de juin à 11.00 heures;
- de modifier le régime de signature statutaire des administrateurs et d'adopter en conséquence pour lui la teneur
comme reproduite dans ci-après dans l'article 13 des statuts refondus; et
- de refondre complètement les statuts, afin de les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et notamment avec les dispositions de la loi du 25 août 2006,
introduisant, entre autres, la société anonyme unipersonnelle avec un administrateur unique.
Lesdits STATUTS auront désormais la teneur suivante:
I. Nom, Durée, Objet, Siège social
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de “WIESEN-PIRONT CONSTRUCTIONS S.A.” (la
"Société"), régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").
Art. 2. La durée la de Société est illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet la coordination de travaux concernant la construction de maisons unifamiliales et de
résidences ainsi que leur commercialisation.
Elle pourra en outre avoir comme objet l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation et la mise en valeur de
biens immobiliers, par location, vente, échange et généralement de toute autre manière, ainsi que l'exercice de toutes
activités accessoires, de quelque nature qu'elles soient, pouvant être utiles à la réalisation effective de l'objet social.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Kopstal, (Grand-Duché de Luxembourg).
3210
L
U X E M B O U R G
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple
décision du conseil d'administration.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-
semblée des actionnaires.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille deux cents Euros (31.200,- EUR), divisé en six cent vingt-
quatre (624) actions de cinquante Euros (50,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des Statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce
registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société
n'a qu'un seul administrateur, par cet administrateur.
La Société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Les actions au porteur porteront les
indications prévues par l'article 41 de la Loi et seront signées par deux (2) administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul
administrateur, par cet administrateur.
La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite.
Une copie certifiée conforme de l'acte conférant à cet effet délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil
d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. Assemblées générales des actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le dernier mardi du mois de juin à 11.00 heures au
siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par courrier électronique,
par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme son mandataire.
L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo, conférences téléphoniques ou tout autre moyen de télécommu-
nication est autorisée et les actionnaires utilisant ces technologies seront présumés être présents et seront autorisés à
voter par vidéo, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication. Après délibération, les votes pourront
aussi être exprimés par écrit ou par télécopie, télégramme, télex, téléphone ou tout autre moyen de télécommunication,
étant entendu que dans ce dernier cas le vote devra être confirmé par écrit. Tout actionnaire peut aussi voter par
correspondance, en retournant un formulaire dûment complété et signé (le "formulaire") envoyé par le conseil d'admi-
nistration, l'administrateur unique ou deux administrateurs, suivant le cas et contenant les mentions suivantes en langue
anglaise et française:
a) le nom et l'adresse de l'actionnaire;
3211
L
U X E M B O U R G
b) le nombre d'actions qu'il détient;
c) chaque résolution sur laquelle un vote est requis;
d) une déclaration par laquelle l'actionnaire reconnaît avoir été informé de la/des résolution(s) pour lesquelles un vote
est requis;
e) une case pour chaque résolution à considérer;
f) une invitation à cocher la case correspondant aux résolutions que l'actionnaire veut approuver, rejeter ou s'abstenir
de voter;
g) une mention de l'endroit et de la date de signature du formulaire;
h) la signature du formulaire et une mention de l'identité du signataire autorisé selon le cas; et
i) la déclaration suivante: "A défaut d'indication de vote et si aucune case n'est cochée, le formulaire est nul. L'indication
de votes contradictoires au regard d'une résolution sera assimilée à une absence d'indication de vote. Le formulaire peut
être utilisé pour des assemblées successives convoquées le même jour. Les votes par correspondance ne sont pris en
compte que si le formulaire parvient à la Société deux jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Un actionnaire ne
peut pas adresser à la Société à la fois une procuration et le formulaire. Toutefois, si ces deux documents parvenaient à
la Société, le vote exprimé dans le formulaire primera.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.
IV. Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-
naires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un action-
naire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
3212
L
U X E M B O U R G
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit,
par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur
comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification.
Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du
conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut
à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est
réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer
le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont
de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle
de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes
circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.
V. Surveillance de la Société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire.
L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs
rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent
(10%) du capital social.
Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde
des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de
provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la
Loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
3213
L
U X E M B O U R G
Des dividendes peuvent également être payés sur bénéfices reportés d'exercices antérieurs. Les dividendes seront
payés en euros ou par distribution gratuite d'actions de la Société ou autrement en nature selon la libre appréciation des
administrateurs, et peuvent être distribués à tout moment à déterminer par le conseil d'administration.
Le paiement de dividendes sera fait aux actionnaires à l'adresse indiquée dans le registre des actions. Aucun intérêt ne
sera dû par la Société sur dividendes distribués mais non revendiqués.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de
quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée confirme les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes
actuellement en fonction et décide de prolonger leurs mandats, de sorte à ce que lesdits mandats prendront fin à l'issue
de l'assemblée générale annuelle de 2017.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide en outre de conférer à l'administrateur-délégué, Monsieur Maurice ELZ le pouvoir de signature
suivant:
"Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la seule signature
de l'administrateur délégué, y compris les actes d'achat, de vente ou d'échange d'immeubles, les actes de mainlevée avant
ou après paiement, les actes de postposition et les actes d'emprunt ou d'ouverture de crédit, avec ou sans garantie
hypothécaire, y compris la stipulation de la voie parée conformément aux dispositions de l'article 879 et suivants du
Nouveau Code de Procédure Civile (ancien article 71 de la loi du 2 janvier 1889) sur la saisie immobilière."
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille deux cent cinquante
euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. UHL, M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2011. LAC/2011/58573. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012004054/282.
(120002453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
C.I.I. Luxembourg, Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 85.415.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63127 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
3214
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011167333/10.
(110194387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Clariden Leu Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 159.463.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011167336/10.
(110194075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
BC Chime S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 23.215,00.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 148.705.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Référence de publication: 2011167314/11.
(110194008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Brasseur Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 150.009.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Référence de publication: 2011167311/10.
(110194251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Euromel Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 66.900.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
STRATEGO INTERNATIONAL SARL
<i>Commissairei>
Référence de publication: 2011167395/11.
(110194483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Giusa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.
R.C.S. Luxembourg B 163.517.
Les statuts coordonnés au 24/11/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
3215
L
U X E M B O U R G
Redange-sur-Attert, le 6/12/2011.
Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2011166776/12.
(110193783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
LU GE II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 158.388.
<i>Extrait des décisions prises par l’actionnaire unique en date du 5 décembre 2011i>
1) M. Jason Alan Bennett, né en Californie (Etats-Unis d’Amérique), le 11 août 1973, demeurant à 53, Corso Buenos
Aires, 20124 Milan (Italy), a été démissionné comme gérant avec effet au 5 décembre 2011.
2) Le nombre des gérants a été diminué de deux (2) à un (1).
3) La société à responsabilité limitée Panattoni Luxembourg Directorship Sàrl est devenu gérant unique.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
LU GE II Sàrl
Panattoni Luxembourg Directorship Sàrl
<i>Gérant
i>Représenté par Olivier Marbaise
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011166876/19.
(110193829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
LU GE III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.000.
<i>Extrait des décisions prises par l’actionnaire unique en date du 5 décembre 2011i>
1) M. Jason Alan Bennett, né en Californie (Etats-Unis d’Amérique), le 11 août 1973, demeurant à 53, Corso Buenos
Aires, 20124 Milan (Italy), a été démissionné comme gérant.
2) Le nombre des gérants a été diminué de deux (2) à un (1).
3) La société à responsabilité limitée Panattoni Luxembourg Directorship Sarl est devenue gérant unique.
Luxembourg, le 6 décembre 2011.
LU GE III Sarl
Panattoni Luxembourg Directorship Sarl
<i>Gérant
i>Représenté par Olivier Marbaise
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011166877/19.
(110193828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Opera - Participations 2, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 100.610.
<i>Rectificatif du 1 i>
<i>eri>
<i> dépôt au 15 septembre 2011 Référence: L110148452i>
Les statuts coordonnés suivant l'acte n°62575 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011166943/11.
(110193804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
3216
1798 European Credit Opportunities Master Fund
1798 European Loan Master Fund
Allianz European Pension Investments
Allianz Global Investors Fund
Apta Finance S.A.
BC Chime S.à r.l.
BeLux Enterpises Consulting s.à r.l.
Brasseur Immo S.A.
C.I.I. Luxembourg, Sàrl
Clariden Leu Fund Management (Luxembourg) S.A.
Codic Luxembourg S.A.
Creola S.A.
Cygnus Real Estate Fund
Digital Investments S.C.A., SICAR
EFCO-Forodia Exploitation S.à r.l.
E/Shelter S.à.r.l.
Eurizon Riserva
Euromel Investments S.A.
exceet Group SE
F&C Portfolios Fund
Fivecom S.A.
Giusa S.à r.l.
HAIG Return
HAIG Return
ING International Currency Management Fund
ING (L)
ING (L)
ING (L) Patrimonial
ING (L) Renta Cash
LU GE III S.à r.l.
LU GE II S.à r.l.
Mantera S.A., SPF
Min Asset Management S.A.
Morsa Capital S.A.
Muse Investment S.A.
Najade S.A.
navAXX S.A.
Nordea Fund of Funds, SICAV
Olympia SICAV Lux
Opera - Participations 2
Orco Germany S.A.
Orco Germany S.A.
Pareturn
Pegasos
Pegasos
Pelham e-shelter Berlin S.à r.l.
Pioneer CIM
Record Fund
RP Rendite Plus
SEB Multi-Manager Currency Defensive
Wiesen-Piront Constructions S.A.
Woodbridge International Holdings S.A.
WPA Holdings Sàrl
Yucatan S.A.