logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1578

15 juillet 2011

SOMMAIRE

ABAKUS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75713

Algodeal Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

75718

Allcorp S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75729

Alpha Investimenti Sicav . . . . . . . . . . . . . . . .

75729

Aviva Investors Investment Solutions  . . . .

75712

Aviva Investors Investment Solutions  . . . .

75707

Babalou Shipping Company S.A.  . . . . . . . .

75737

BlackRock Global Investment Series  . . . . .

75712

COBRA Automotive Technologies S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75730

Conception et Réalisations de Bâtiments

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75730

COSCO Ports (Greece) S.à r.l.  . . . . . . . . . .

75730

Delilah S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75744

Diane Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

75719

Do Absolute Return  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75713

Do Aktien Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75713

Doks S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75731

Dynamic Opportunities SICAV  . . . . . . . . . .

75730

East&West Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

75731

Edene Lux Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

75718

ERE III Twenty S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75714

Europa Titanium S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

75735

Exile Holdings (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . .

75719

Fourb International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

75731

Gagfah S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75732

GROUPE OPEN PSF Luxembourg  . . . . . .

75736

Hoche Besso Courtage S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

75737

ILP III S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75732

Moon Stone International Investment S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75732

Mortgage Backed Investments S.A.  . . . . . .

75729

Navarac Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

75733

Nuova Era S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75719

Opensys S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75715

OPG 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75714

PEF Gamma Investment S.à r.l.  . . . . . . . . .

75732

PEF Gerrards Cross Investment S.à r.l.  . .

75733

PEF Iota Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

75734

PEF MB Plaza Investment S.à r.l.  . . . . . . . .

75734

PEF Russia Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

75735

PEF Theta Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

75735

PEF Whittington House Investment S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75736

PIN H. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75737

Platina International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

75744

P&P Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75731

Profilo Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75716

Santa Barbara Properties S.à r.l.  . . . . . . . .

75734

SCM PE IV General Partner S.à r.l.  . . . . . .

75698

Signet Luxembourg Finance S.à r.l.  . . . . . .

75744

StarCap SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75733

Taurus Invest FCP-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75713

WFL Invest FCP-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75713

75697

L

U X E M B O U R G

SCM PE IV General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 161.491.

STATUTES

In the year two thousand and eleven,
on the twenty-sixth day of the month of May.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

“SCM Strategic Capital Management AG”, a Swiss public limited company (Aktiengesellschaft) whose registered office

is at Kasernenstrasse 77b, CH-8004 Zurich, Switzerland,

here represented by Mr Tobias Lochen, Rechtsanwalt, professionally residing in L-1011 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Zurich, Switzerland, on 20 May 2011.
The proxy given, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary shall

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a société à responsabilité limitée governed by the relevant laws and the present articles of incorporation.

<i>Definitions

The following terms shall have the meaning as set out hereafter whenever used herein with initial capital letters:
"1915 Law" means the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to

time,

"2007 Law" means the Luxembourg law dated 13 February 2007 on specialised investment funds, as amended from

time to time;

"Articles" means the present articles of incorporation;
"Business Day" means any day, other than a Saturday or Sunday, when banks in Luxembourg are open for the trans-

action of normal business;

"Euro"  or  "EUR"  means  the  lawful  currency  of  the  European  Union  member  States  that  have  adopted  the  single

currency in accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union;

"Board" means in case of plurality of Managers the board of Managers of the Company;
"Manager" means the manager or in case of plurality of managers, a manager appointed to the Board in accordance

with these Articles or as the case may be a member of the Board;

"Share(s)" means the shares issued by the Company and any share issued in exchange for those shares or by way of

conversion or reclassification, and any shares representing or deriving from those shares as a result of any increases in
or reorganization or variation of the capital of the Company; and

"Shareholder" means a holder of Shares.

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by the present and all persons and entities who may become Shareholders in the future

a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “SCM PE IV General Partner S.à r.l.” (he-
reinafter referred to as the "Company").

Art. 2. The Company’s corporate object is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,

financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences,
to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances
or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company may, in particular, act as general partner (associé gérant commandité) of "SCM International Private

Equity Select IV" (the "SICAV"), a Luxembourg investment company with variable capital -specialised investment fund
governed by Luxembourg laws and incorporated under the legal form of a partnership limited by shares (société en
commandite par actions) and of any other undertakings for collective investment established under the form of part-
nerships limited by shares.

The Company shall carry out any activities connected with its status of general partner of the SICAV or of any other

undertakings for collective investment established under the form of partnerships limited by shares.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly with all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited duration.

75698

L

U X E M B O U R G

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. Branches

or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Manager or in case of plurality
of Managers, by resolution of the Board, after having received Shareholders consent.

In the event that the Manager or in case of plurality of Managers, the Board, determines that extraordinary political

or military developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office abroad, will remain a Luxembourg company.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The Company’s capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred

(100) Shares of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-) each.

The one hundred (100) Shares have all been fully paid in cash.
The capital may be increased or reduced by a resolution of the single Shareholder or by resolution of the Shareholders

of the Company adopted in accordance with Article 20 hereof.

Shares will only be issued in registered form and will be inscribed in the register of Shares, which is held by the Company

or by one or more persons on behalf of the Company. Such register of Shares shall set forth the name of each Shareholder,
his residence or elected domicile, the number and class of Shares held by him.

In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the 1915 Law.

Title III. Shareholder meetings

Art. 6. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company shall represent the entire body of

Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of Company.

Art. 7. In case of a single Shareholder, the single Shareholder assumes all powers conferred to the Shareholders’

meeting. Any resolutions to be taken by the single Shareholder may be taken in writing.

In case of plurality of Shareholders, the provisions of Article 8 will apply to any resolution to be taken by a meeting of

Shareholders.

Each Share is entitled to one vote.
A Shareholder may be represented (at any meeting of Shareholders) by another person, which does not need to be a

Shareholder and which may be a Manager. The proxy established to this effect may be in writing or by cable, telegram,
facsimile or e-mail transmission.

Art. 8. If legally required or if not so required upon the decision of the Manager or in case of plurality of Managers,

the Board, annual general meetings of Shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law,
in Luxembourg at the registered office of the Company, or such other place in Luxembourg as may be specified in the
notice of the meeting. Such annual general meetings may be held abroad if, in the judgement of the Manager or in case
of plurality of Managers, the Board, exceptional circumstances so require.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Board, may convene other meetings of Shareholders to be held

at such place and time as may be specified in the respective notices of meetings.

The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Shareholders of

the Company, unless otherwise provided herein.

Except as otherwise required by law or provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will

be passed by simple majority of the votes cast by those Shareholders present and voting.

The general meeting of Shareholders shall be called by the Manager or in case of plurality of Managers, the Board, by

notices containing the agenda and which will be published as required by law.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Board, will prepare the agenda, except if the meeting takes place

due to the written request of Shareholders provided for by law; in such case the Manager or in case of plurality of Managers,
the Board, may prepare an additional agenda.

If all of the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The matters dealt with by the meeting of Shareholders are limited to the issues contained in the agenda which must

contain all issues prescribed by law as well as to issues related thereto, except if all the Shareholders agree to another
agenda. In case the agenda should contain the nomination of Managers or of the auditor, the names of the eligible Managers
or of the auditors will be inserted in the agenda.

75699

L

U X E M B O U R G

Title IV. Administration

Art. 9. The Company shall be managed by one or more Manager(s). If several Managers have been appointed, they will

constitute a Board.

The Manager(s) need not be Shareholders of the Company.
The Manager(s) shall be elected by the general meeting of Shareholders for a period as determined by such general

meeting of Shareholders and until their successors are elected and take up their functions. Upon expiry of its mandate,
a Manager may seek reappointment.

The Manager(s) mandate may be revoked at any time with or without a reason by the general meeting of Shareholders.
In case of plurality of Managers and in the event of a vacancy in the office of a Manager because of death, retirement

or otherwise, the remaining Managers may meet and may elect, by majority vote, a Manager to fill such vacancy until the
next general meeting of Shareholders.

Art. 10. The Board shall choose from among its members a chairman.
The chairman shall preside at all meetings of the Board but in his absence or incapacity to act, the Managers present

may appoint anyone of their number to act as chairman for the purposes of the meeting.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Board may also choose a secretary, who need not be a Manager

and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Board, may from time to time appoint officers of the Company,

including a managing director, a general manager and any assistant managers or other officers considered necessary for
the operation and management of the Company. Officers need not be Managers or Shareholders of the Company. The
officers appointed, unless otherwise stipulated herein, shall have the powers and duties given to them by the Manager or
in case of plurality of Managers, the Board.

The Board shall meet upon call by the chairman, or any two Managers, at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice, containing an agenda which sets out any points of interest for the meeting, of any meeting of the Board

shall be given to all Managers at least three (3) Business Days prior to the beginning of such meeting, except in circums-
tances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This
notice may be waived by the consent in writing or by telegram, facsimile or e-mail transmission of each Manager. Separate
notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the Board.

Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing, in writing or by telegram, facsimile or e-mail trans-

mission, another Manager as his proxy.

Any Manager who is not physically present at the location of a meeting may participate in such a meeting of the Board

by remote conference facility or similar means of communication equipment, whereby all persons participating in the
meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.

The Board can deliberate or act validly only if at least two Managers are present or represented at a meeting of the

Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented. In case of a deadlock,
the chairman shall have the casting vote.

Resolutions signed by all Managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such

signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters,
telegrams, facsimile or e-mail transmissions.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro

tempore who presided at such meeting or by any two Managers.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman or by any two Managers or by a Manager together with the secretary or the alternate secretary.

Art. 11. The Manager or in case of plurality of Managers, the Board, shall have power to determine the course and

conduct of the management and business affairs of the Company.

It is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the interests of the

Company. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the Manager or in case of plurality of Managers, the Board.

Art. 12. The Company shall be bound by the sole signature of its single Manager, or in case of plurality of Managers,

by the joint signature of any two Managers of the Company, or by the joint signature of any person(s) to whom such
signatory authority has been delegated by the Manager or in case of plurality of Managers, by the Board, together with
one Manager.

Art. 13. The Manager or in case of plurality of Managers, the Board, may delegate its powers to conduct the daily

management and affairs of the Company, including the right to sign on behalf of the Company, and its powers to carry
out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Company or to other persons, which at

75700

L

U X E M B O U R G

their turn may delegate their powers if they are authorised to do so by the Manager or in case of plurality of Managers,
the Board.

Art. 14. No contract or other transaction which the Company and any other company or firm might enter into shall

be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or officers of the Company is interested in
such other company or firm by a relation, or is a director, officer or employee of such other company or legal entity.

In the event that any Manager or officer of the Company may have any personal interest in any contract or transaction

of the Company other than that arising out of the fact that he is a Manager, officer or employee or holder of securities
or other interests in the counterparty, such Manager or officer shall, in case of plurality of Managers, make known to the
Board such personal interest and shall not consider or vote upon any such contract or transaction. Such contract or
transaction, and such Manager’s or officer’s personal interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting
of Shareholders.

Art. 15. The Company may indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against

expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of
which the Company is a unitholder or a creditor and which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Title V. Accounting, Distributions

Art. 16. The operations of the Company and its financial situation as well as its books shall be supervised by one or

more auditor(s) qualifying as réviseur d'enterprises agréé(s). The auditor(s) shall be elected by the Shareholders at the
annual general meeting of Shareholders for a period which shall end on the day of the following annual general meeting
of Shareholders which decides upon the appointment of its (their) successor(s).

Art. 17. The accounting year of the Company shall begin on 1 

st

 January and shall terminate on 31 December of each

year.

Art. 18. From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
capital of the Company as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time in accordance with
Article 5 hereof.

The general meeting of Shareholders shall decide each year how the remainder of the annual net profit shall be allocated

and may declare dividends from time to time or instruct the Manager or in case of plurality of Managers, the Board, to
do so.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Board, may within the conditions set out by law unanimously

resolve to pay out interim dividends.

Title VII. Winding up, Liquidation

Art. 19. In the event of a winding-up of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators.

Liquidators may be physical persons or legal entities and are named by the meeting of Shareholders deciding such winding-
up and which shall determine their powers and their compensation.

Title VIII. Amendments

Art. 20. These Articles may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the respect of

the quorum and majority requirements provided by Luxembourg law.

Art. 21. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law and the 2007

Law.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31

December 2011.

<i>Subscription and Payment

The capital of the Company is subscribed as follows:
“SCM Strategic Capital Management AG”, above named, subscribes for one hundred (100) Shares, resulting in a total

payment of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

Evidence of the above payment was given to the undersigned notary.

75701

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The expenses which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately

thousand euro.

Resolutions of the sole shareholder
The above named party, as sole shareholder and representing as such the entire subscribed capital and exercising the

powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

(i) The following are elected as Managers for a term to expire at the close of the annual general meeting of Shareholders

which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2011:

- Mr Andreas Demmel, professionally residing at 6, rue Philippe II, L-2349 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

(Chairman); and

- Dr Stefan Hepp, professionally residing at Kasernenstrasse 77b, CH-8004 Zurich, Switzerland;
- Mr Mirko Dietz, professionally residing at 6, rue Philippe II, L-2349 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
(ii) The following is elected as independent auditor for a term to expire at the close of the annual general meeting of

Shareholders which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2011:

“PricewaterhouseCoopers S.à r.l.”, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (R.C.S. Lu-

xembourg, section B number 65 477).

(iii) The registered office of the Company is set at 6, rue Philippe II, L-2349 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the above named

person, this deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing person, in
case of divergence between the English and the German versions, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by name, surname,

status and residence, said proxy holder signed together with Us notary the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden englischen Textes.

Im Jahre zweitausendelf,
am sechsundzwanzigsten Mai.
Vor Uns Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

„SCM Strategic Capital Management AG“, eine schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in Kasernenstrasse 77b, CH-8004

Zürich, Schweiz,

hier vertreten durch Herrn Tobias Lochen, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in L-1011 Luxemburg,
aufgrund einer am 20. Mai 2011 in Zürich, Schweiz erteilten Vollmacht.
Die von der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" gezeichnete Vollmacht bleibt dieser Urkunde

beigefügt und ist zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.

Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienene hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung (articles

of incorporation) einer den einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu Protokoll zu nehmen.

<i>Definitionen

Die folgenden Begriffe haben, wen sie mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben sind, die ihnen jeweils zugeordnete

Bedeutung:

"Gesetz von 1915" ist das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils

geltenden Fassung;

"Gesetz von 2007" ist das luxemburgische Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in seiner

jeweils geltenden Fassung;

"Satzung" ist die vorliegende Satzung;
"Geschäftstag" ist ein Tag, außer Samstag und Sonntag, an dem die Banken in Luxemburg für die üblichen Geschäfte

geöffnet sind;

"Euro" oder "EUR" ist die gesetzliche Währung derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gemäß dem

Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union die gemeinsame
Währung eingeführt haben;

"Rat der Geschäftsführung" ist, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Ge-

sellschaft;

"Geschäftsführer" ist der Geschäftsführer, oder sofern mehrere bestellt sind, einer der gemäß dieser Satzung zum

Mitglied des Rates der Geschäftsführung bestellten Geschäftsführer bzw. ein Mitglied des Rates der Geschäftsführung;

75702

L

U X E M B O U R G

"Gesellschaftsanteil(e)" sind die von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile sowie im Tausch gegen solche Anteile oder

aufgrund einer Umwandlung oder Reklassifizierung ausgegebene Anteile sowie Anteile, die aufgrund von Kapitalerhö-
hungen, Umwandlungen oder Reklassifizierung für diese Anteile stehen oder aus ihnen hervorgehen; und

"Gesellschafter" ist ein Inhaber von Anteilen.

Abschnitt I. Name, Zweck, Dauer, Sitz

Art. 1. Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen „SCM PE IV General Partner S.à
r.l.“ (nachstehend "Gesellschaft" genannt) gegründet.

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist es, Beteiligungen in jedweder Form an Handels-, Industrie-, Finanz-oder anderen

Unternehmen, seien es Luxemburgische oder ausländische, zu erwerben; Wertpapiere und Rechte durch Beteiligungen,
Einbringung, Zeichnung, den Erwerb von Betrieben oder Optionen, Übertragungen oder auf andere Art zu erwerben und
namentlich Patente und Lizenzen zu erwerben, zu verwalten und zu entwickeln; Unternehmen, an denen die Gesellschaft
eine Beteiligung hält, jedwede Unterstützung, Darlehen, Vorteile oder Garantien zu gewähren und schließlich jede Maß-
nahme durchzuführen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck verbunden ist.

Die Gesellschaft darf insbesondere als Komplementärin (associé gérant commandité) des "SCM International Private

Equity Select IV" (die "SICAV") fungieren, einer Luxemburgischen Fondsgesellschaft mit variablem Kapital -spezialisierter
Investmentfonds nach den Gesetzen Luxemburgs und gegründet in der Rechtsform einer partnership limited by shares
(société en commandite par actions), sowie jedes anderen Organismus für gemeinsame Anlagen der in Immobilien in-
vestiert und in Form einer partnership limited by shares errichtet wurde.

Die Gesellschaft soll alle Tätigkeiten, die mit ihrer Stellung als Komplementärin der SICAV oder eines anderen Orga-

nismus für gemeinsame Anlagen in Form einer société en commandite par actions, der in Immobilien investiert, ausführen.

Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, technischen oder finanziellen Tätigkeiten ausführen, die direkt oder indirekt

mit allen oben beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erfüllung ihres Zweckes zu fördern.

Art. 3. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Niederlassungen oder Büros

können aufgrund eines Beschlusses des Geschäftsführers oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, aufgrund
eines Beschlusses des Rates der Geschäftsführung gegründet werden, wobei solche Beschlussfassungen unter dem Vor-
behalt der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafter stehen.

Für den Fall, dass ein Geschäftsführer, oder sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung

befindet oder befinden, dass außergewöhnliche politische oder militärische Umstände eingetreten sind oder unmittelbar
bevorstehen, die die üblichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz stören oder die Kommunikation zwischen dem
Sitz und im Ausland ansässigen Personen erschweren könnten, kann der Sitz vorübergehend solange ins Ausland verlagert
werden, bis die außergewöhnlichen Umstände nicht mehr vorherrschen. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlagerung ihres Sitzes ins
Ausland eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht bleibt.

Abschnitt II. Kapital, Gesellschaftsanteile

Art. 5. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt und in einhundert

(100) Gesellschaftsanteile mit einem Wert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) je Anteil aufgeteilt.

Die einhundert (100) Gesellschaftsanteile sind vollständig eingezahlt.
Das Kapital kann aufgrund eines gemäß Artikel 20 dieser Satzung getroffenen Beschlusses des Alleingesellschafters

oder der Gesellschafter der Gesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.

Gesellschaftsanteile werden nur als Namensanteile ausgegeben und sind ins Anteilsregister einzutragen, das von der

Gesellschaft oder von einer oder mehreren Personen im Namen der Gesellschaft geführt wird. In diesem Anteilsregister
wird der Name des Gesellschafters, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort, die Nummer und die Klasse der
von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile vermerkt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, sind die von dem Alleingesellschafter gehaltenen Gesellschafts-

anteile frei übertragbar.

Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsan-

teile gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes von 1915 übertragen werden.

Abschnitt III. Gesellschafterversammlungen

Art. 6. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter der Gesellschaft gilt als Vertretung sämtlicher

Gesellschafter der Gesellschaft. Sie verfügt über größtmögliche Befugnisse, mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
verbundene Handlungen anzuordnen, durchzuführen oder zu bewilligen.

Art. 7. Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, stehen diesem sämtliche der Gesellschafterversammlung

übertragenen Befugnisse zu. Von dem Alleingesellschafter zu fassende Beschlüsse können schriftlich gefasst werden.

75703

L

U X E M B O U R G

Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, gelten die Bestimmungen von Artikel 8 für sämtliche von einer

Gesellschafterversammlung zu fassenden Beschlüsse.

Jeder Gesellschaftsanteil gewährt eine Stimme.
Ein Gesellschafter kann sich (auf Gesellschafterversammlungen) von einer anderen Person vertreten lassen, die kein

Gesellschafter sein muss und ein Geschäftsführer sein kann. Eine zu diesem Zweck gewährte Vollmacht kann schriftlich,
per Telegramm, per Fernschreiben, per Fax oder E-Mail erteilt werden.

Art. 8. Sofern kraft Gesetz erforderlich oder, andernfalls, aufgrund einer Entscheidung des Geschäftsführers oder,

sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, des Rates der Geschäftsführung, werden die jährlichen Gesellschafterver-
sammlungen der Gesellschaft gemäß luxemburgischem Recht am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder einem anderen,
in der Einladung zur Versammlung genannten Ort abgehalten. Solche jährlichen Gesellschafterversammlungen können im
Ausland abgehalten werden, wenn der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der
Geschäftsführung dies aufgrund des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände für erforderlich hält.

Der Geschäftsführer, oder sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung, können wei-

tere Gesellschafterversammlungen einberufen, die an den in den jeweiligen Einladungen genannten Orten und zu den
darin ebenfalls genannten Zeiten abgehalten werden.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung gelten im Hinblick auf die Fristen für Einladungen zu

Gesellschafterversammlungen und deren Beschlussfähigkeit die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Bestimmungen dieser Satzung sind auf einer ordnungs-

gemäß einberufenen Gesellschafterversammlung zu fassende Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen der anwesenden und sich an der jeweiligen Abstimmung beteiligenden Gesellschafter zu fassen.

Die jährlichen Gesellschafterversammlungen sind von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer

bestellt  sind,  vom  Rat  der  Geschäftsführung  durch  Versendung  von  Einladungen  einzuberufen,  die  die  Tagesordnung
enthalten und die gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu veröffentlichen sind.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung wird die Ta-

gesordnung erstellen, es sei denn, eine Versammlung findet auf schriftliches Verlangen der Gesellschafter gemäß den
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen statt; in einem solchen Fall kann der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere
Gesellschafter bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung eine weitere Tagesordnung erstellen.

Sofern bei einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie

über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann eine Versammlung ohne vorherige Einladung oder
Veröffentlichung abgehalten werden.

Die Angelegenheiten, die von einer Gesellschafterversammlung behandelt werden, sind auf die in der Tagesordnung

genannten Punkte zu beschränken, wobei alle gesetzlich vorgeschriebenen und mit diesen zusammenhängende Punkte zu
behandeln sind, es sei denn, alle Gesellschafter einigen sich auf eine andere Tagesordnung. Sofern die Bestellung von
Geschäftsführern oder eines Abschlussprüfers auf der Tagesordnung steht, sind die Namen der zur Wahl stehenden
Geschäftsführer oder Abschlussprüfer in die Tagesordnung aufzunehmen.

Abschnitt IV. Verwaltung

Art. 9. Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Geschäftsführern geführt. Sofern mehrere

Geschäftsführer bestellt sind, bilden sie einen Rat der Geschäftsführung.

Der bzw. die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
Der bzw. die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung für einen von dieser bestimmten Zeitraum

gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und ihr Amt übernehmen. Nach Ablauf seiner Amtszeit kann sich ein Ge-
schäftsführer wieder zur Wahl stellen.

Der bzw. die Geschäftsführer können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne die Angabe von

Gründen ihres Amtes enthoben werden.

Sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, sowie für den Fall, dass der Posten eines Geschäftsführers aufgrund des

Todes, der Eintritts in den Ruhestand eines Geschäftsführers oder aus anderen Gründen vakant wird, können sich die
verbleibenden Geschäftsführer versammeln und mit einfacher Mehrheit einen Geschäftsführer wählen, der eine solche
Vakanz bis zur nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung ausfüllt.

Art. 10. Der Rat der Geschäftsführung ernennt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.
Der Vorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Versammlungen der Geschäftsführer der Gesellschaft. Sofern der Vor-

sitzende bei einer Versammlung abwesend oder nicht handlungsfähig ist, können die Geschäftsführer aus ihrer Mitte einen
Vorsitzenden für die Zwecke der jeweiligen Versammlung ernennen.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann einen

Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Führung des Protokolls von Versammlungen des Rates
der Geschäftsführung und von Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann jeweils

Bevollmächtigte („Officers“) der Gesellschaft ernennen, einschließlich eines Managing Directors, eines General Managers,

75704

L

U X E M B O U R G

eines Assistant Managers oder sonstiger Bevollmächtigte, die im Hinblick auf den Betrieb und die Verwaltung der Ge-
sellschaft  für  erforderlich  gehalten  werden.  Bevollmächtigte  müssen  keine  Geschäftsführer,  oder  Gesellschafter  der
Gesellschaft sein. Die ernannten Bevollmächtigte haben die ihnen von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Ge-
schäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.

Der Rat der Geschäftsführung versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern an

dem in der jeweiligen Einladung genannten Ort.

Sämtlichen Geschäftsführern ist mindestens drei (3) Tage vor Beginn einer solchen Versammlung eine schriftliche

Einladung zusammen mit einer Tagesordnung zu übermitteln, in der sämtliche Geschäftsordnungspunkte aufgeführt sind.
Von dieser Frist kann in dringenden Ausnahmefällen abgewichen werden, in denen die näheren Umstände in der Einladung
auszuführen sind. Auf eine Einladung kann verzichtet werden, sofern sämtliche Geschäftsführer einer solchen Verfah-
rensweise schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zustimmen. Für einzelne Versammlungen, deren Zeit und Ort vorab
durch Gesellschafterbeschluss festgelegt worden sind, ist keine weitere Einladung erforderlich.

Geschäftsführer können sich bei Versammlungen des Rates der Geschäftsführung vertreten lassen, indem sie einen

anderen Geschäftsführer schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zu ihrem Vertreter ernennen.

Geschäftsführer, die an einem Versammlungsort nicht physisch anwesend sind, können an einer Versammlung des

Rates der Geschäftsführung per Konferenzschaltung oder auf einem ähnlichen Kommunikationsweg teilnehmen, wobei
sich alle Teilnehmer einer solchen Versammlung gegenseitig hören können müssen, und eine Teilnahme an einer solchen
Versammlung kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.

Eine Versammlung der Geschäftsführer der Gesellschaft kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens

zwei Geschäftsführer bei einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse
sind mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer zu fassen. Im Falle eines Patts hat der
Vorsitzende die entscheidende Stimme.

Von sämtlichen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse sind genauso gültig und wirksam wie bei einer ordnungs-

gemäß  einberufenen  und  abgehaltenen  Versammlung  gefasste  Beschlüsse.  Solche  Unterschriften  können  auf  einem
einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen eines Beschlusses gezeichnet sein und können per Brief, Tele-
gramm, Fax oder E-Mail erfolgen.

Das Protokoll von Versammlungen der Geschäftsführer der Gesellschaft ist von dem Vorsitzenden oder, sofern dieser

abwesend ist, von dem stellvertretenden, nur für die jeweilige Versammlung ernannten Vorsitzenden oder von zwei
Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Kopien von oder Auszüge aus solchen Protokollen, die gegebenenfalls in Gerichtsverfahren oder bei anderen Gele-

genheiten vorgelegt werden, sind von dem Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäftsführer
gemeinsam mit dem Sekretär oder dem stellvertretenden Sekretär zu unterzeichnen.

Art. 11. Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung ist

befugt, die Richtung und Art der Geschäftsführung und der Geschäfte der Gesellschaft festzulegen.

Der Geschäftsführer bzw. der Rat der Geschäftsführung ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um

sämtliche im Interesse der Gesellschaft stehenden Verwaltungshandlungen und -verfügungen vorzunehmen. Sämtliche
Befugnisse, die nicht kraft Gesetzes oder gemäß dieser Satzung ausdrücklich der jährlichen Gesellschafterversammlung
zugewiesen sind, werden vom Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Ge-
schäftsführung ausgeübt.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers verpflichtet oder, sofern

mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern der Gesellschaft,
oder durch die gemeinsame Unterschrift einer Person oder mehrerer Personen, auf die ein solches Zeichnungsrecht
durch den Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch den Rat der Geschäftsführung
übertragen worden ist, zusammen mit mindestens einem Geschäftsführer.

Art. 13. Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann

seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich des Rechts, für die Gesellschaft zu
zeichnen, sowie seine Befugnisse, Handlungen zur Förderung der Unternehmenspolitik und des Gesellschaftszwecks vor-
zunehmen,  an  Bevollmächtigte  der  Gesellschaft  oder  andere  Personen  übertragen,  die  wiederum  berechtigt  sind,
Untervollmachten zu erteilen, sofern sie von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind,
vom Rat der Geschäftsführung hierzu ermächtigt worden sind.

Art. 14. Verträge oder andere Transaktionen der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder einem anderen

Unternehmen  bleiben  unberührt und  werden  nicht  unwirksam,  wenn einer oder mehrere der  Geschäftsführer oder
Bevollmächtigte der Gesellschaft aufgrund persönlicher Beziehungen ein Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder
diesem anderen Unternehmen hat oder haben oder dort Geschäftsführer oder Bevollmächtigter oder Mitarbeiter ist
oder sind.

Falls ein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft möglicherweise aus anderen Gründen als aufgrund

des Umstands, dass er Geschäftsführer, Bevollmächtigter, Mitarbeiter oder Inhaber von Wertpapieren oder sonstigen
Beteiligungen des anderen Unternehmens ist, ein persönliches Interesse an einem Vertrag oder einer Transaktion der

75705

L

U X E M B O U R G

Gesellschaft hat, wird der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, den Rat
der Geschäftsführung von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und von einer Beteiligung an Beschlussfas-
sungen hinsichtlich eines solchen Vertrags oder einer solchen Transaktion absehen. Die jeweils nächste Gesellschafter-
versammlung  ist  von  einem  solchen  Vertrag  oder  einer  solchen  Transaktion  und  dem  persönlichen  Interesse  des
betreffenden Geschäftsführers oder Bevollmächtigten zu unterrichten.

Art. 15. Die Gesellschaft kann einen Geschäftsführer oder Bevollmächtigter, seine Erben, Testamentsvollstrecker oder

Nachlassverwalter für angemessene Kosten schadlos halten, die diesem oder diesen in Zusammenhang mit einem An-
spruch, einer Klage oder einem Verfahren entstanden sind, die möglicherweise auf der jetzigen oder früheren Tätigkeit
des Betreffenden als Geschäftsführer oder Bevollmächtigte für die Gesellschaft oder für eine andere Gesellschaft beruhen,
sofern dies verlangt wird, deren Anteilinhaber oder Gläubiger die Gesellschaft ist, wenn der Betreffende insoweit keinen
anderen Schadloshaltungsanspruch hat; dies gilt nicht, wenn der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte wegen grober
Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird; wird ein Vergleich geschlossen, erfolgt die Schadloshaltung nur
bezüglich solcher vom Vergleich erfassten Punkte, bezüglich derer – laut Auskunft eines Rechtsberaters gegenüber der
Gesellschaft – keine Pflichtverletzung der schadlos zu haltenden Person vorliegt. Das vorstehende Recht auf Schadlos-
haltung schließt andere, dem Geschäftsführer oder Bevollmächtigten möglicherweise zustehende Rechte nicht aus.

Abschnitt V. Buchhaltung, Ausschüttung von Dividenden

Art. 16. Die Geschäfte der Gesellschaft, ihre finanzielle Situation sowie ihre Bücher werden von einem (oder mehreren)

Abschlussprüfer(n) überwacht, bei denen es sich um reviseur d'enterprises agréé(s) handelt. Der Abschlussprüfer (oder
die  Abschlussprüfer)  wird  von  den  Gesellschaftern  bei  der  jährlichen  Gesellschafterversammlung  für  einen  Zeitraum
bestimmt, der am Tage der nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung endet, die über die Bestellung des Nachfolgers
oder der Nachfolger entschieden wird.

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 18. Von dem Jahresüberschuss der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die gesetzlich vorgeschriebenen

Reserven eingestellt. Diese Zuführung von Geldern endet, sobald und solange die Reserven bei zehn Prozent (10 %) des
Kapitals der Gesellschaft gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder dem gegebenenfalls gemäß Artikel 5 dieser Satzung herauf-
oder herabgesetzten Betrag liegen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich über die Verwendung des Jahresüberschusses; sie kann ggf. Divid-

enden festsetzen oder den Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, den Rat der Geschäfts-
führung anweisen, dies zu tun.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann im ge-

setzlich vorgesehenen Rahmen einstimmig die Ausschüttung von Interimdividenden beschließen.

Abschnitt VII. Auflösung, Liquidation

Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Bei

den Liquidatoren kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, die von der Gesellschafterversammlung
bestellt werden, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren bestimmt.

Abschnitt VIII. Änderungen

Art. 20. Diese Satzung kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung geändert werden, wenn diese beschlussfähig

ist und die nach luxemburgischem Recht erforderlichen Mehrheiten erreicht werden.

Art. 21. Alle Fragen, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind gemäß dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von

2007 zu lösen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.

<i>Zeichnung und Zahlung

Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:
Die oben genannte „SCM Strategic Capital Management AG“ zeichnet einhundert (100) Gesellschaftsanteile gegen

Barzahlung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-).

Der Nachweis über diese Zahlung wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.

<i>Kosten

Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf tausend euro.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Als einziger Gesellschafter und somit Inhaber des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft fasst die oben

genannte Partei in Ausübung der der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse:

75706

L

U X E M B O U R G

(i) Die folgenden Personen werden für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafterver-

sammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 berät, als Geschäftsführer bestellt:

- Herr Andreas Demmel, mit beruflicher Anschrift in 6, rue Philippe II, L-2349 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

(Vorsitzender); und

- Herr Dr. Stefan Hepp, mit beruflicher Anschrift in Kasernenstrasse 77b, CH-8004 Zürich, Schweiz;
- Herr Mirko Dietz, mit beruflicher Anschrift in 6, rue Philippe II, L-2349 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
(ii) Als unabhängiger Abschlussprüfer wird für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafter-

versammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 berät,

„PricewaterhouseCoopers S.à r.l.“, 400, route d'Esch, L-1471 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (R.C.S. Lu-

xemburg, Sektion B Nummer number 65 477), bestellt.

(iii) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 6, rue Philippe II, L-2349 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend

genannten Partei die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung;
auf Wunsch der vorstehend genannten Partei ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen Fassung
die englische Fassung maßgeblich.

Daraufhin wurde der vorstehende Akt in Luxemburg zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer mit Uns,

dem amtierenden Notar, gemeinsam die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. LOCHEN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 31 mai 2011. Relation: EAC/2011/7260. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): T. THOMA.

Référence de publication: 2011084786/517.
(110094890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Aviva Investors Investment Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 152.783.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of the month of June.
Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the sole shareholder here represented by Ms. Sinead

Browne,  via  a  power  of  attorney  granted  on  22  June  2011  of  "AVIVA  INVESTORS  INVESTMENT  SOLUTIONS",  a
company in the form of a public company limited by shares (société anonyme) qualifying as an investment company with
variable share capital (société d’investissement à capital variable) incorporated and existing under the laws of the Grand-
Duchy  of  Luxembourg  with  registered  office  at  34,  avenue  de  la  Liberté,  L-1930  Luxembourg,  Grand-Duchy  of
Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 152.783, incorpo-
rated pursuant to a deed passed before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on the twenty first day of
April 2010 (the “Company”). The articles of incorporation of the Company were published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), No 984, on 11 May 2010 on page 47189.

The articles of incorporation of the Company have not been amended since its incorporation.
The sole shareholder is duly represented, has been notified of the Meeting and has received all documentation and

information in connection with the items mentioned in the agenda prior to the Meeting. The meeting is thus regularly
constituted in accordance with the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and could validly resolve upon all the items
of the agenda.

The Meeting was presided by Ms. Elena Toshkova, private employee, having her professional address in Luxembourg.
The chairperson appointed as Scrutineer Ms. Sinead Browne, private employee, having her professional address in

Luxembourg.

The Meeting elected as Secretary Mr. Raymond Thill, private employee, having his professional address in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairperson declared and requested the undersigned

notary to state:

I. That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

<i>Sole resolution

To amend the articles of incorporation of the Company (the "Articles") as follows:
1. Amendment of article 2 in order to mention any replacement of the 2002 Law.
2. Amendment of article 3 which shall read as follows:

75707

L

U X E M B O U R G

“The exclusive object of the Company is to place the monies available to it in transferable securities and other permitted

assets with the purpose of spreading investment risks and affording Shareholders the results of the management of its
assets.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the 2002 Law (as from 1 

st

 July 2011, the reference

to the 2002 Law shall be deemed to be a reference to the law dated 17 

th

 December 2010 on undertakings for collective

investment (the “2010 Law”).

3. Replacement with effect as of 1 

st

 July 2011 of all references to the law dated 20 December 2002 with references

to the law dated 17 

th

 December 2010 implementing UCITS IV Directive (the “2010 Law”).

4. Amendment of article 4 to allow the Board to transfer the registered office of the Company outside the city of

Luxembourg to the extent allowed by Luxembourg law.

5. Amendment of last paragraph of article 8 so as to refer to article 174 of the 2010 Law instead of article 129 of the

2002 Law.

6. Amendment of articles 10, 11 and 12 in order to take advantage of certain flexibilities available under Luxembourg

law generally and the 2010 Law in particular, and relating to the convening and the holding of general meetings of sha-
reholders of the Company.

7. Amendment of article 14 in order to enable the chairman to call a meeting of the Board of Directors.
8. Amendment of article 16 in order to take advantage of inter alia flexibilities available under the 2010 Law and in

particular master-feeder structures and cross Fund investments.

9. Amendment of article 20 so as to refer to article 154 of the 2010 Law instead of article 113 of the 2002 Law.
10. Amendment of article 21 in order to (i) permit the Board of Directors to compulsory redeem the shares of

shareholders whose holding is less than the level determined by the Board of Directors and (ii) introduce some flexibilities
in the payment of redemption proceeds to redeeming shareholders (iii) amend the provisions applicable to mergers of
the Funds and of the Company in order to include new rules under the 2010 Law.

11.  Amendment  of  article  22  so  as  to  introduce  additional  scenarios  which  enable  the  Company  to  suspend  the

determination of the net asset value and the issue, redemption and conversion of shares in any Fund in compliance with
the 2010 Law.

12 Amendment of point 2(ii) of article 23 so as to clarify the application of mid-price for the valuation of listed securities

and of point 4(iv) to delete reference to launch dates.

13. Amendment of article 24 so as to reflect that dealing and transaction fees may be taken into account for the

determination of the subscription price.

14. Amendment of article 25 relating to (i) the availability of the annual accounts of the Company to shareholders (ii)

the convening of the annual general meeting of shareholders further to the 2010 Law changes;

15. Amendment of article 26 relating to the payment and distribution of dividends so as to clearly allow such distri-

butions to be made out of either revenue, capital gains or otherwise as may be permitted by the Luxembourg Law.

16. Amendment of article 27 so as to refer to article 146 of the 2010 Law instead of article 107 of the 2002 Law.
17. Amendment of article 29 so as to state that matters not governed by the articles of incorporation shall also be

determined in accordance with the 2010 Law.

II. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this

attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary as well as the proxies
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III That it appears from the attendance list that out of the 328,650 shares in issue, 328,650 shares are present or

represented at the present Meeting.

The present Meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on the agenda. After deliberation,

the Meeting resolved as follows:

<i>Sole resolution

The Meeting unanimously resolved to amend the Articles as follows:
1. Amendment of article 2 which shall read as follows:

Art. 2. “The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved and liquidated at any

time by a resolution of an Extraordinary General Meeting of Shareholders. Such a meeting must be convened if the net
asset value («Net Asset Value») of the Company becomes less than two-thirds of the minimum required by the Luxem-
bourg  law  of  20 

th

  December  2002  regarding  collective  investment  undertakings  or  any  legislative  re-enactment  or

amendment or replacement thereof («2002 Law»).”

2. Replacement with effect as of 1 

st

 July 2011 of all references to the law dated 20 December 2002 with references

to the law dated 17 

th

 December 2010 implementing UCITS IV Directive (the “2010 Law”).

75708

L

U X E M B O U R G

3. Amendment of article 3 which shall read as follows:

“ Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the monies available to it in transferable securities and other

permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording Shareholders the results of the management
of its assets.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the 2002 Law (as from 1 

st

 July 2011, the reference

to the 2002 Law shall be deemed to be a reference to the law dated 17 

th

 December 2010 on undertakings for collective

investment (the “2010 Law”).”

4. Amendment of article 4 by inserting an additional paragraph after the first paragraph which shall read as follows:
“If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may

transfer the registered office of the Company to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg.”

5. Amendment of part 4 (d) of article 8 which shall read as follows:
“(d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Company at any meeting

of Shareholders of the Company.

Whenever used in these Articles of Incorporation, the term «U.S. Person» shall mean U.S. persons (as defined under

United States federal securities, commodities and tax laws) or persons who are resident in the United States at the time
the Shares are offered or sold and the term «Institutional Investor» shall include any investor meeting the requirements
to qualify as an institutional investor for the purposes of article 129 of the 2002 Law (to be replaced by article 174 of the
2010 Law)”.

6. Amendment of article 10 by inserting an additional paragraph after the second paragraph which shall read as follows:
“If permitted by and under the conditions of the Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of

shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraphs, that date, time
or place to be decided by the Board of Directors and specified in the notice of the meeting.”

7. Amendment of article 11:
(i) by amending the third paragraph which shall read as follows:
“Each whole Share of whatever Fund or Class of Shares and regardless of the Net Asset Value per Share within the

Fund or Class of Shares, is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles of Incorporation and
by applicable Luxembourg laws and regulations. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing
another person as his proxy in writing.”

(ii) by inserting an additional paragraph after the last paragraph which shall read as follows:
“The convening notice of a general meeting of Shareholders may provide that the quorum and majority rules of such

meeting will be determined in respect of the Shares as issued at 12.00 p.m. Luxembourg time, 5 days preceding such
general meeting of Shareholders (the “Record Date”). The right of a Shareholder to attend a general meeting of Share-
holders and to exercise the voting rights attaching to his/its/her Shares shall be determined by reference to the Shares
held by this Shareholder as at the Record Date.”

8. Amendment of article 12 by inserting an additional paragraph after the last paragraph which shall read as follows:
“In case that all the Shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the

agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.”

9. Amendment of first paragraph of article 14 which shall read as follows:

“ Art. 14. The Board of Directors shall choose from among its members a chairperson, and may choose from among

its members one or more vice-chairpersons. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the Shareholders. The Board of
Directors shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.”

10. Amendment of article 16:
(i) by amending point 4 which shall read as follows:
“units of undertakings for collective investment in transferable securities («UCITS») authorised according to Council

Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating
to undertakings for collective investment in transferable securities, as amended («UCITS Directive») or (as from the 1

st

 July 2011 according to the European Parliament and Council Directive of 13 July 2009 on the coordination of laws,

regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (the
“UCITS IV Directive”)), including Shares of another Fund of the Company, under conditions set forth by Luxembourg
laws  and  regulations,  and/or  other  undertakings  for  collective  investment  («UCIs»)  within  the  meaning  of  Article  1,
paragraph (2) first and second indents of the UCITS Directive or within the meaning of Article 1, paragraph (2), indents

75709

L

U X E M B O U R G

(a) and (b) of the UCITS IV Directive, should they be situated in a Member State of the European Union or not, provided
that:

- such other UCIs are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the

Luxembourg regulator to be equivalent to that laid down in Community Law, and that cooperation between authorities
is sufficiently ensured;

- the level of protection for unit-holders in the other UCIs is equivalent to that provided for unit-holders in a UCITS,

and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, uncovered sales of transferable securities and
money market instruments are equivalent to the requirements of the UCITS Directive or, as from the 1 

st

 July 2011, the

UCITS IV Directive;

- the business of the other UCIs is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of

the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;

- no more than 10% of the UCITS’ or the other UCIs’ assets, whose acquisition is contemplated, can, according to

their constitutional documents, be invested in aggregate in units of other UCITS or other UCIs; and/or”

(ii) by amending the sixth paragraph of point 7 of article 16 which shall read as follows:
“The Company may further invest up to 100 per cent of the net assets of any Fund, in accordance with the principle

of risk spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, by
its local authorities or by a non-EU member State or by public international bodies of which one or more Member States
are members, provided the Company holds securities from at least six different issues and securities from one issue do
not account for more than 30 per cent of the total net assets of such Fund.”

(ii) by inserting an additional paragraph at the end of point 7 of article 16 which shall read as follows:
“As from 1 

st

 July 2011 and under the conditions set forth in the Luxembourg laws and regulations, the Board of

Directors may, at any time it deems appropriate and to the widest extent permitted by applicable laws and regulations,
but in accordance with the provisions set forth in the 2010 Law and in the prospectus of the Company, (i) create any
Fund qualifying either as a feeder UCITS Fund (i.e. investing at least 85% of its assets in another UCITS) or as a master
UCITS Fund, (ii) convert any existing Fund into a feeder UCITS Fund or (iii) change the master UCITS of any of its feeder
UCITS Funds.”

11. Amendment of article 20 which shall read as follows:

“ Art. 20. The general meeting of Shareholders shall appoint a «réviseur d’entreprises agréé» who shall carry out the

duties prescribed by article 113 of the 2002 Law (to be replaced by article 154 of the 2010 Law).”

12. Amendment of article 21:
(i) by inserting an additional paragraph after paragraph eight of article 21 which shall read as follows:
“The Board of Directors may, at any time, compulsorily redeem all Shares from Shareholders whose holding is less

than the level determined by the Board of Directors. In such case, the shareholder will receive a prior notice so as to be
able to increase his holding.”

(ii) by amending paragraph nine of article 21 which shall read as follows: “For the purpose of the above provisions,

conversions are considered as redemptions.

Whenever the Company shall redeem Shares, the price at which such Shares shall be redeemed by the Company shall

be the Net Asset Value per Share of the relevant Fund or Class (as determined in accordance with the provisions of
article 23 hereof) («Redemption Price») provided a written and irrevocable redemption request has been duly received
by the Company on the relevant Luxembourg Banking Day upon which redemptions or subscriptions will be accepted
(«Dealing Day») before the relevant redemption deadline, less any applicable redemption charge or fees, as may be decided
by the Board of Directors from time to time and described in the then current Prospectus and less such sum as the Board
of Directors may consider an appropriate provision for duties and charges.”

(iii) by amending paragraph twelve of article 21 which shall read as follows:
“The Company shall, if the Shareholder requesting redemption so accepts have the right to satisfy payment of the

Redemption Price by allocating to such Shareholder assets from the Fund equal in value to the value of the Shares to be
redeemed. The nature and type of such assets shall be determined on a fair and reasonable basis with due regard to all
applicable laws and regulations and will take into account the interests of the remaining Shareholders and the valuation
used shall be confirmed by a report of the Company’s auditor to the extent required by Luxembourg laws and regulations,
except where the redemption in kind exactly reflects the Shareholders’ prorata share of investments.”

(iv) by inserting two additional paragraphs before the last paragraph of article 21 which shall read as follows:
“As from 1 

st

 July 2011, the provisions set forth in the preceding paragraphs which are applicable to the mergers of

Funds and where appropriate, to the merger of the Company, shall no longer be applicable and the provisions on merger
of UCITS set forth in the 2010 Law and any implementing regulation shall apply. Thereupon, any merger of a Fund shall
be decided by the Board of Directors unless the Board of Directors decides to submit the decision for a merger to a
meeting of the Shareholders of the Fund concerned. No quorum is required for this meeting and decisions are taken by
the simple majority of the votes cast. In case of a merger of a Fund where, as a result, the Company ceases to exist, the

75710

L

U X E M B O U R G

merger shall be decided by a meeting of shareholders resolving in accordance with the quorum and majority requirements
for changing the Articles.

As from 1 

st

 July 2011, if a Fund qualifies as a feeder fund (as defined in article 16 above), the merger, split or liquidation

of its master fund triggers liquidation of such feeder Fund, unless the investment policy of such feeder Fund is amended
in compliance with Part I of the 2010 Law. Liquidation proceeds not claimed by the Shareholders at the close of the
liquidation of a Fund or Class will be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg on or around the termination
date. If not claimed, they shall be forfeited after 30 years.”

13. Amendment of article 22:
(i) by amending item (iii) which shall read as follows:
“(iii) during any breakdown of the means of communication or computation normally employed in determining the

price or value of any of the assets attributable to a Fund or the current price or value on any stock exchange”

(ii) by amending item (vi) which shall read as follows:
“(vi) in case of the Company’s liquidation or in the case a notice of termination has been issued in connection with

the liquidation of a Fund or a Class of Shares or, as from 1 

st

 July 2011, in connection with a merger of a Fund in compliance

with the 2010 Law and other applicable laws and regulations;”

(iii) inserting an additional paragraph (viii), which shall read as follows:
“(viii) As from 1 

st

 July 2011, during any period where the calculation of the net asset value of a UCITS or a sub-fund

of a UCITS in which a Fund invests at least 85% of its assets, is suspended”

14. Amendment of article 23:
(i) by amending point 2(ii) which shall read as follows:
“(ii) the value of all securities which are listed or traded on a official stock exchange or traded on any other regulated

market will be valued on the basis of the last available prices on the Product Business Day immediately preceding the
Valuation Day or on the basis of the last available prices on the main market on which the investments of the Funds are
principally traded provided that where these securities are quoted on any stock exchange operating on the basis of
separate bid and offer prices, mid-market valuations may, as the Board of Directors may decide, be applied. The Board
of Directors will approve a pricing service which will supply the above prices. If, in the opinion of the Board of Directors,
such prices do not truly reflect the fair market value of the relevant securities, the value of such securities will be deter-
mined in good faith by the Board of Directors either by reference to any other publicly available source or by reference
to such other sources as it deems in its discretion appropriate;”

(ii) by amending point 4(iv) which shall read as follows:
“ (iv) where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular portfolio,

such asset or liability will be allocated to all the Funds prorata to the Funds’ respective Net Asset Value;”

15. Amendment of the second paragraph of article 24 which shall read as follows:
“Whenever the Company shall offer Shares for subscription, the price per Share at which such Shares shall be offered

and sold, shall be the Net Asset Value per Share of the relevant Class of Shares («Issue Price») to which an upfront
subscription sales charge as the Board of Directors may from time to time determine, and as the maximum amount of
which shall be disclosed in the Company’s then current Prospectus («Upfront Subscription Sales Charge»), may be added
together with, as the case may be, such sum as the Board of Directors may consider as representing an appropriate
provision for duties and charge («Subscription Price»). The Net Asset Value per Share of each Class of Shares shall be
obtained by dividing the value of the total assets of each Fund allocable to such Class of Shares less the liabilities of such
Fund allocable to such Class of Shares by the total number of Shares of such Class of Shares outstanding on the relevant
Valuation Day, adjusted to the nearest cent as determined at the Company’s Administrator’s discretion. The Net Asset
Value per Share of each Class of Shares of a Fund may differ as a result of the different fees assessed on each Class of
Shares of such Fund or of other particular features.”

16. Amendment of the second paragraph of article 25 which shall read as follows:
“The accounts of the Company shall be expressed in euro or in respect of any Fund, in such other currency or

currencies as the Board of Directors may determine. Where there shall be different Funds as provided for in article 5
hereof, and if the accounts within such Funds are maintained in different currencies, such accounts shall be converted
into euro and added together for the purpose of determination of the accounts of the Company. The annual accounts,
including the balance sheet and profit and loss account and the directors’ report will be made available to the Shareholders
at the registered office of the Company and will be sent to the Shareholders upon request. The convening notice of the
annual general meeting will be sent to registered Shareholders and/or published prior to each annual general meeting in
accordance with the timeframe provided by Luxembourg laws and regulations and such notice will indicate where and
how  the  annual  accounts,  including  the  balance  sheet  and  profit  and  loss  account  and  the  directors’  report  may  be
obtained.”

17. Amendment of article 26:
(i) by amending the first paragraph which shall read as follows:

75711

L

U X E M B O U R G

“ Art. 26. The general meeting of Shareholders of each Fund shall, upon the proposal of the Board of Directors in

respect of each Fund, subject to any interim dividends having been declared or paid, determine if and to what extent
dividends will be paid in respect of the relevant Fund.”

(ii) by amending the third paragraph of article 26 which shall read as follows:
“Interim dividends may, at the discretion of the Board of Directors, be declared subject to such further conditions as

set forth by law, and be paid out on the Shares of any Fund upon decision of the Board of Directors and may include such
amounts whether representing revenue, capital gains or otherwise as may be permitted by law.”

18. Amendment of the last paragraph of article 27 so as to refer to article 146 of the 2010 Law instead of article 107

of the 2002 Law as follows:

“With the consent of the Shareholders expressed in the manner provided for by articles 67-1 and 142 of the 1915

Law, the Company may be liquidated and the liquidator authorised subject to giving one month’s prior notice to the
Shareholders and by a decision by majority vote of two thirds of the Company’s Shareholders to transfer all assets and
liabilities of the Company to a Luxembourg UCITS in exchange for the issue to the Shareholders in the Company of
shares of such UCITS in proportion to their shareholding in the Company. Otherwise any liquidation will entitle a sha-
reholder to a pro rata share of the liquidation proceeds corresponding to his Class of Shares. Moneys available for
distribution to Shareholders in the course of the liquidation that are not claimed by Shareholders will at the close of
liquidation be deposited at the Caisse des Consignations in Luxembourg pursuant to article 107 of the 2002 Law (to be
replaced by article 146 of the 2010 Law), where during 30 years they will be held at the disposal of the Shareholders
entitled thereto.”

19. Amendment of article 29 so as to state that matters not governed by the articles of incorporation shall also be

determined in accordance with the 2010 Law.

There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned Notary who understands and speaks English states that, at the request of the parties hereto, these

minutes are drafted in English only.

Done in Luxembourg on the day aforementioned.
And after reading of these minutes, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.
Signé: E. Toshkova, S. Browne, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juin 2011. LAC/2011/28961. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2011.

Référence de publication: 2011090560/289.

(110102154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2011.

Aviva Investors Investment Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 152.783.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2011.

Référence de publication: 2011090561/10.

(110102201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2011.

BlackRock Global Investment Series, Fonds Commun de Placement.

EXTRAIT

Le Règlement de Gestion de BlackRock Global Investment Series daté du 24 mai 2011 qui entrera en vigueur le 29

juillet 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

75712

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 30 mai 2011.

BlackRock Fund Management Company S.A.
<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2011094362/13.
(110107567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.

WFL Invest FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion de WFL Invest FCP-FIS modifié au 16 juin 2011 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HSBC Trinkaus Investment Managers SA
Signatures

Référence de publication: 2011095057/10.
(110107512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.

Taurus Invest FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion de Taurus Invest FCP-FIS modifié au 16 juin 2011 a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HSBC Trinkaus Investment Managers SA
Signatures

Référence de publication: 2011095058/10.
(110107518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.

Do Aktien Global, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Do Aktien Global modifié au 30 juin 2011 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HSBC Trinkaus Investment Managers SA
Signatures

Référence de publication: 2011095059/10.
(110107520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.

Do Absolute Return, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Do Absolute Return modifié au 30 juin 2011 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HSBC Trinkaus Investment Managers SA
Signatures

Référence de publication: 2011095060/10.
(110107528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.

ABAKUS, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de ABAKUS World Dividend Fund modifié au 15 juin 2011 a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HSBC Trinkaus Investment Managers SA
Signatures

Référence de publication: 2011095061/10.
(110107530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.

75713

L

U X E M B O U R G

OPG 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ERE III Twenty S.à r.l.).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 161.014.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth of June.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

“Europa Real Estate III S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée”, existing under Luxembourg law, established and

having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

represented by Mr Eric BIREN, company director, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg,

acting in his capacity as member of the board of managers of the Company, with individual signing power.
Such appearing party is the sole partner of “ERE III Twenty S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) a société à respon-

sabilité  limitée  having  its  registered  office  at  68-70,  boulevard  de  la  Pétrusse,  L-2320  Luxembourg,  Grand-Duchy  of
Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 161014, incorporated
pursuant to a notarial deed on 17 May 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to amend the company’s name into “OPG 1 S.à r.l.”.
As a consequence, article 4 of Articles of Incorporation is modified and now reads as follows:

Art. 4. The Company will have the name “OPG 1 S.à r.l.”.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le dix septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU

«Europa Real Estate III S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

représentée par Monsieur Eric BIREN, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 68-70 boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.
Laquelle  partie  comparante  est  l'associé  unique  de  «ERE  III  Twenty  S.à  r.l.»  (ci-après  la  “Société”),  une  société  à

responsabilité limitée ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161014,
constituée selon un acte notarié en date du 17 mai 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter la

résolution suivante:

<i>Résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la société en «OPG 1 S.à r.l.».
En conséquence, l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 4. La Société aura la dénomination ”OPG 1 S.à r.l.”.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

75714

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. BIREN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 juin 2011. Relation: EAC/2011/8498. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011096069/60.
(110109110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

Opensys S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 162.029.

STATUTS

L'an deux mille onze, le sept juillet.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Van Minh Pierre Nguyen, directeur, né à Vientiane (LAOS), le 13 mai 1964, demeurant à F-57070 Metz, 38,

rue des Trente Jours.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu'il déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

OPENSYS S. à r.l.

Art. 2. La société a pour objet, tant en tout endroit de l'Union Européenne que partout ailleurs dans le monde entier,

l'exploitation d'un commerce de: Négociation, suivi, réalisation de marchés de logiciels, matériels et/ou de prestations
de services informatiques.

Elle peut, tant en tout endroit de l'Union Européenne que partout ailleurs dans le monde entier, faire toutes opérations

commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son
objet social dans le but d'en favoriser la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, et, en vue de favoriser le développement de sa participation ainsi créée, elle peut en apporter tout
soutien financier ou même sa caution.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Foetz.

Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT VINGT-

CINQ (125) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois

quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

75715

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2011.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Monsieur Van Minh Pierre Nguyen, prénommé, CENT VINGT-CINQ PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . 125
TOTAL: CENT VINGT-CINQ PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de DOUZE MILLE CINQ

CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENTS EUROS (€ 900,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réunie en

assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

I. - Est nommé gérant de la société: Monsieur Van Minh Pierre Nguyen, prénommé.
II. - La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
III. - Le siège social de la société se trouve à: L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Nguyen, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 juillet 2011. Relation: EAC/2011/9199. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur (signé): Line Gerard.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011097738/73.
(110110703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2011.

Profilo Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.040.

L'an deux mille onze, le six juillet.
Pardevant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

BANCA PROFILO S.p.A C. so italia N.49 Milano (Italy),
ici représentée par Madame Mrs Florence WINFIELD -PILOTAZ, employée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 22 juin 2011.
La prédite procuration, signée par la comparante et par le notaire instrumentant, est restée annexée à un acte de

constitution de la société PROFILA SICAV, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 14, Boulevard Royal reçu par le notaire
soussignée en date du 27 juin 2011 et enregistré à Redange-sur-Attert, le 1 

er

 juillet 2011, RED/2011/1329.

La société comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant en sa qualité de constituant et actionnaire actuel de

la Société d'Investissement à Capital Variable, dénommée «PROFILO SICAV», constituée par acte du notaire soussigné
en date du 27 juin 2011,

déclare, que dans le susdit acte de constitution du 27 juin 2011, un point f) a été indiqué dans l’article 12 des statuts,

version anglaise conformérment à la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, de sorte
que l’article 12 des status a été érronément indiqué comme suit:

“ Art. 12. Suspension of the calculation of the net asset value, and of the issue and repurchase of shares
The Board of Directors is authorised to suspend temporarily the calculation of the net asset value of one or several

sub-funds, as well as the issue, the repurchase and the conversion of shares under the following circumstances:

a) for any period during which a market or stock exchange which is the main market or stock exchange on which a

substantial part of the Fund's investments is listed from time to time, is closed for periods other than regular holidays,
or when trading on such markets is subject to major restrictions, or suspended;

75716

L

U X E M B O U R G

b) when the political, economic, military, monetary or social situation, or Act of God or beyond the Fund's responsibility

or control, make the disposal of its assets impossible under reasonable and normal conditions, without being seriously
prejudicial to the interests of the shareholders;

c) during any breakdown in communications networks normally used to determine the value of any of the Fund's

investments or current price on any market or stock exchange;

d) whenever exchange or capital movement restrictions prevent the execution of transactions on behalf of the Fund

or in case purchase and sale transactions involving the Fund's assets cannot be effected at normal exchange rates;

e) as soon as a General Meeting is called during which the dissolution of the Fund shall be put forward;
f) in the case of a breakdown of the data processing system which would make the net asset value calculation impossible.
Under  exceptional  circumstances  that  may  adversely  affect  the  interest  of  shareholders  or  in  case  of  repurchase

applications exceeding 10% of a sub-fund's net assets, the Board of Directors of the Fund shall reserve the right to
determine the share price only after having carried out, as soon as possible, the necessary sales of transferable securities
on behalf of the sub-fund. In such case, subscription, repurchase and conversion applications outstanding shall be treated
on the basis of the net asset value thus calculated.

Subscribers and shareholders offering shares for repurchase or conversion shall be notified of the suspension of the

net asset value calculation. Pending subscription, repurchase and conversion applications may be withdrawn in writing
insofar as notification thereon be received by the Fund before the end of suspension.

Pending subscriptions, repurchases and conversions shall be taken into consideration on the first Valuation day im-

mediately following the end of suspension.“

alors que cette article 12 des statuts aurait du se lire comme suit:

“ Art. 12. Suspension of the calculation of the net asset value, and of the issue and repurchase of shares
The Board of Directors is authorised to suspend temporarily the calculation of the net asset value of one or several

sub-funds, as well as the issue, the repurchase and the conversion of shares under the following circumstances:

a) for any period during which a market or stock exchange which is the main market or stock exchange on which a

substantial part of the Fund's investments is listed from time to time, is closed for periods other than regular holidays,
or when trading on such markets is subject to major restrictions, or suspended;

b) when the political, economic, military, monetary or social situation, or Act of God or beyond the Fund's responsibility

or control, make the disposal of its assets impossible under reasonable and normal conditions, without being seriously
prejudicial to the interests of the shareholders;

c) during any breakdown in communications networks normally used to determine the value of any of the Fund's

investments or current price on any market or stock exchange;

d) whenever exchange or capital movement restrictions prevent the execution of transactions on behalf of the Fund

or in case purchase and sale transactions involving the Fund's assets cannot be effected at normal exchange rates;

e) as soon as a General Meeting is called during which the dissolution of the Fund shall be put forward;
Under  exceptional  circumstances  that  may  adversely  affect  the  interest  of  shareholders  or  in  case  of  repurchase

applications exceeding 10% of a sub-fund's net assets, the Board of Directors of the Fund shall reserve the right to
determine the share price only after having carried out, as soon as possible, the necessary sales of transferable securities
on behalf of the sub-fund. In such case, subscription, repurchase and conversion applications outstanding shall be treated
on the basis of the net asset value thus calculated.

Subscribers and shareholders offering shares for repurchase or conversion shall be notified of the suspension of the

net asset value calculation. Pending subscription, repurchase and conversion applications may be withdrawn in writing
insofar as notification thereon be received by the Fund before the end of suspension.

Pending subscriptions, repurchases and conversions shall be taken into consideration on the first Valuation day im-

mediately following the end of suspension.”

La société comparante déclare que tous les autres articles et rubriques dudit acte de constitution restent inchangés

et elle prie le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin sera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation française donnée à la représentante des sociétés comparantes, connue du notaire

instrumentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. WINFIELD -PILOTAZ, C. DELVAUX
Enregistré à Redange/Attert, actes civils le 6 juillet 2011, RED/2011/1390: Reçu douze Euros (EUR 12.-)

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

- Pour expédition conforme - délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

L110111188 déposé le 13 juillet 2011.

75717

L

U X E M B O U R G

Redange-sur-Attert, le 11 juin 2011.

Référence de publication: 2011098659/84.
(110112173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Algodeal Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 149.447.

<i>Extrait sincère et conforme des décisions prises sous seing privé le 28 octobre 2010

<i>Déclaration de cession de parts

Suite à la convention de transfert de parts datant du 28 octobre 2010, Monsieur Benjamin Filippi, domicilié au 38, rue

Jeanne Jugan, F-06130 Grasse, France, associé à hauteur de 24.970 parts d'une valeur nominale de 0,125 EUR chacune, a
cédé l'intégralité de ses parts à ses associés de la manière suivante:

- Azur Investments Holdings S.A., une société constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

siège social sis 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 98.391: 12.905 parts

- Atom Lux Invest S.A., une société constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social

sis 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 147.283: 4.258 parts

- Mounthagen S.A., une société constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis

412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 145.520: 3.256 parts

- Edoine Holding S.p.r.l., une société constituée selon le droit de Belgique, ayant son siège social sis 147, avenue

Brugmann,  1190  Bruxelles,  immatriculée  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Belgique,  sous  le  numéro
0893692276: 1.419 parts

- M. Jean-Christophe Allemand, domicilié au 10, rue d'Alsace, F-92300 Levallois-Perret, France: 2.552 parts
- M. David Gageot, domicilié au 16, cité de Trévise, F-75009 Paris, France: 290 parts
- M. Thierry d'Espalungue, domicilié au 43, rue Richer, F-75009, Paris, France: 290 parts
Les parties ont décidé expressément que le transfert de propriété des parts intégral prend effet au 28 octobre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ALGODEAL Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2011069356/30.
(110075760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2011.

Edene Lux Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 156.403.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat d'achat de parts sociales en date du 27 décembre 2010 entre la société Vacon Properties S.A.

et la société Stichting Baltic Perspective, une fondation néerlandaise, localisée à Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès
du Handelsregister van de Kamers van Koophandel d'Amsterdam sous le numéro 51573296 que Vacon Properties S.A.
a cédé la totalité de ses parts sociales dans la Société, soit 125 parts sociales, à Stichting Baltic Perspective avec effet au
27 décembre 2010.

Pour extrait conforme
P.A.L Management Services S.à rl.
Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011065883/18.
(110073191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

75718

L

U X E M B O U R G

Diane Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 68.768.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2011 que:
- L’assemblée accepte la démission d’Andrea DE MARIA en tant qu’administrateur de la société. L’assemblée décide

de pourvoir au remplacement de l’administrateur sortant en appelant Monsieur Vincent WILLEMS expert-comptable né
à Liège (Belgique) le 30 septembre 1975 et demeurent professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie L-1510 Lu-
xembourg. L’assemblée décide aussi de nommer Orietta RIMI, née le 29 septembre 1976 à Erice (Italie) et demeurant
professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2011.

Référence de publication: 2011066182/16.
(110074277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Nuova Era S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 75.207.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 18 novembre 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme NUOVA ERA SA, dont le siège social à L-1724 LUXEMBOURG, 19-21 Boulevard du Prince Henri,

a été dénoncé en date du 7 janvier 2005,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'Arrondissement de et

à Luxembourg, et liquidateur Me Pascale MILLIM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 10 décembre 2010 au greffe du tribunal de

commerce.

Pour extrait conforme
Me Pascale MILLIM
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011077561/20.
(110086206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2011.

Exile Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 160.631.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of April.
Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing at Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

The company EXILE RESOURCES INC., having its statutory seat in 1100 505 - 3 

rd

 Street SW, Calgary, Alberta T2P

3E6, registered with the Trade Register of Canada under corporation number 642966-1,

here represented by Mr Jean-Yves LHOMMEL, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of

a proxy given under private seal.

The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present

deed, in order to be recorded with it.

The appearing party represented as stated above has requested the undersigned notary, to state as follows the articles

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

75719

L

U X E M B O U R G

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the private limited liability company is "Exile Holdings (Luxembourg) S.à r.l." (the Company).

The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law),
and these articles of association (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered
office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the members, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. It may open branches in Luxembourg
and abroad.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may acquire participations
in loans and/or lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries,
affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favor of third parties to
secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may
further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several members.

II. Capital - Corporate units

Art. 5. Capital.
5.1. The corporate capital is set at twenty five thousand Euros (EUR 25,000.-), represented by one hundred (100)

corporate units in registered form, having a par value of two hundred and fifty Euros (EUR 250.-) each, all subscribed and
fully paid-up.

5.2. The corporate capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the members,

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Corporate units.
6.1. The corporate units are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per corporate unit. In case

of joint ownership on one or several corporate unit(s) the members shall designate one (1) owner by corporate unit.

6.2. Corporate units are freely transferable among members.
Where the Company has a sole member, corporate units are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one member, the transfer of corporate units (inter vivos) to third parties is subject

to the prior approval of the members representing at least three-quarters (3/4) of the corporate capital.

The transfer of corporate units by reason of death to third parties must be approved by the members representing

three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

75720

L

U X E M B O U R G

A corporate unit transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance

by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of members is kept at the registered office and may be examined by each member upon request.
6.4. The Company may redeem its own corporate units provided that the Company has sufficient distributable reserves

for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's corporate capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the members, which sets the

term of their office. The managers need not be members.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the members.

Art. 8. Board of managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed

of one or several category A manager(s) and one or several category B manager(s) (the Board).

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the member(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii) The Board may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who

need not be member(s) or manager(s) of the Company. The Board will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting

of the board of managers including at least one manager of the category A and one manager of the category B. Decisions
shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, including at least one vote of
a manager of the category A and one vote of a manager of the category B.

(vi) The resolutions of the meeting of the Board are taken in written form and reported on minutes. Such minutes are

signed by all the managers present.

(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held. The
meeting will be dated as at the date of the holding. The decision will also be valid as the date of the holding. The minutes
will be signed later by the manager participating to the Board by such means.

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any category A manager

and any category B manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with articles 8.1. (ii) and 8.3 (ii) of these Articles.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager.
9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be

read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

75721

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Member(s)

Art. 11. General meetings of members and Members circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the members are adopted at a general meeting of members (the General Meeting) or by way of

circular resolutions (the Members Circular Resolutions) in case the number of members of the Company is less or equal
to twenty-five.

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Members Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent

to all the members, in accordance with the Articles. Members Circular Resolutions signed by all the members are valid
and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each corporate unit entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The members are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or members

representing more than one-half (1/2) of the corporate capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all members at least eight (8) calendar days in advance of the

date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of
the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the members are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A member may grant a written power of attorney to another person, whether or not a member, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Members Circular Resolutions are passed by members

owning more than one-half (1/2) of the corporate capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the members are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Members Circular Resolutions by a majority
of the votes cast, regardless of the proportion of the corporate capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of members owning at least three-quarters

(3/4) of the corporate capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a member's commitment in the Company

require the unanimous consent of the members.

Art. 12. Sole member.
12.1. Where the number of members is reduced to one (1), the sole member exercises all powers conferred by the

Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the members and the General Meeting or to Members Circular Resolutions is

to be read as a reference to such sole member or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole member are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.

13.1. The financial year begins on the first (1 

st

 ) of September of each year and ends on the thirty-first (31) of August

of the next year.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and members towards the Company.

13.3. Each member may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Members

Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

13.5. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be

held each year on the third Tuesday of January each year at 3.00 pm at the registered office of the Company, and if such
day is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (i.e. a Business Day), on the
next following Business Day at the same time and place.

75722

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall

be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be members.

14.2. The operations of the Company are supervised by one or several independent auditor(s) (réviseur(s) d'entre-

prises), when so required by law.

14.3. The members appoint the statutory auditor (commissaire aux comptes), if any and independent auditor (réviseur

d'entreprises), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six
(6) years. The statutory auditor (commissaire aux comptes) and the independent auditor (réviseur d'entreprises) may be
reappointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the corporate
capital.

15.2. The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other available reserves (including share premium) are

available for distribution; and

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of

the interim accounts.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the members, adopted by one-half (1/2) of the

members holding threequarters (3/4) of the corporate capital. The members appoint one or several liquidators, who
need  not  be  members,  to  carry  out  the  liquidation  and  determine  their  number,  powers  and  remuneration.  Unless
otherwise decided by the members, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities
of the Company.

16.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the members in

proportion to the corporate units held by each of them.

VII. General provisions

Art. 17.
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Members

Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communica-
tion.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Members Circular Resolu-
tions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken
together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the members and the Company from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on August 31 

st

 , 2011.

<i>Subscription and Payment

The company EXILE RESOURCES INC., pre-named, subscribes all the one hundred (100) corporate units.
The amount of twenty five thousand Euros (EUR 25,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has

been given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

75723

L

U X E M B O U R G

<i>Resolutions of the sole member

Immediately after the incorporation of the Company, the member of the Company, representing the entire subscribed

capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as manager of the Company for an indefinite period:
a.- Mr Darren Moulds, born in Saskatoon (Canada), on January 18, 1976, residing at Apt 704 433 11 Avenue SE, Calgary,

Alberta T2G 0C7 (Canada), as category A manager of the Company.

b.- Mr Tony Henshaw, born in Leicester (United Kingdom), on April 9, 1954, residing at Cullen House, Camp End

Road, Weybridge, Surrey KT13 0NR, United Kingdom, as category A manager of the Company.

c.- Mr Hugo Neuman, born in Amsterdam (the Netherlands), on October 21, 1960, residing at 16, rue J.B. Fresez,

L-1542 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as category B manager of the Company.

2. The registered office of the Company is set at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le treize avril.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

La société EXILE RESOURCES INC., ayant son siège social à 1100 505 - 3 

rd

 Street SW, Calgary, Alberta T2P 3E6,

enregistrée auprès du registre de Commerce du Canada sous le numéro administratif 6429661,

ici représentée par M. Jean-Yves LHOMMEL, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante, représentée comme établit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société à responsabilité limitée est "Exile Holdings (Luxembourg) S.à r.l." (la

Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, et en
particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents
statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société

75724

L

U X E M B O U R G

ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. Elle peut créer des succursales à Luxembourg et à
l’étranger.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra acquérir des participations dans des prêts et/ou prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut
également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les
obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de
charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses
avoirs.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit,
le risque de change, de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000,-), représenté par cent (100) parts sociales sous forme

nominative, ayant une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (EUR 250,-) chacune, toutes souscrites et entière-
ment libérées.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale. En cas

d’indivision sur une ou plusieurs part(s) sociale(s) les associés désigneront un (1) propriétaire part par sociale.

6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil), composé

de un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et de un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B.

8.1 Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

(iii) Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le conseil de gérance détermine les respon-
sabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions
de son/leurs mandat(s).

75725

L

U X E M B O U R G

8.2 Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au

Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés,

comprenant au moins un gérant de catégorie A un gérant de catégorie B. Les décisions du Conseil sont valablement
adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents
ou représentés, comprenant au moins un vote d’un gérant de catégorie A et un vote de gérant de catégorie B. Les décisions
du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

(vi) Les résolutions de la réunion du Conseil sont prises par écrit et inscrites sur un procès-verbal. Ce procès-verbal

est signé par tous les gérants présents.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue. La réunion du Conseil sera datée à la date de sa tenue. Les résolutions seront également valables au
jour de la réunion. Le procès-verbal sera signé plus tard par le gérant participant au Conseil par de tels moyens.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3 Représentation
(i) La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de un gérant de

catégorie A et de un gérant de catégorie B, ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.1. (ii) and 8. 3 (ii) des Statuts.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique.
9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1 Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre d'associés est égal ou
moindre que vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

75726

L

U X E M B O U R G

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1 Si le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à

l'Assemblée Générale.

12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3 Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1 L'exercice social commence le premier (1 

er

 ) septembre et se termine le trente et un (31) août de l’année

suivante.

13.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle doit

se tenir chaque année le troisième mardi du mois de janvier à 15.00 heures au siège social de la Société, et si ce jour n'est
pas un jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un Jour Ouvrable), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et
au même lieu.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société sont

contrôlées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.

14.2 Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise, dans les cas prévus

par la loi.

14.3 Les associés devront nommer le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprise et déterminer leur nom-

bre,  leur  rémunération  et  la  durée  de  leur  mandat,  lequel  ne  pourra  dépasser  six  (6)  ans.  Le(s)  commissaire(s)  aux
comptes/ réviseur d'entreprise pourront être réélus.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  disponibles  (en  ce  compris  la  prime

d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; et

75727

L

U X E M B O U R G

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des

associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision
contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les
dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

Art. 17.
17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Réso-
lutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document,
qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés et la Société.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 août 2011.

<i>Souscription et Libération

La société EXILE RESOURCES INC., prénommée, souscrit toutes les cent (100) parts sociales.
Le montant de vingt cinq mille Euros (EUR 25.000,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire

instrumentant, qui le confirme expressément.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Résolutions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée unique de la Société, représentant l'intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a.- Monsieur Darren Moulds, né à Sakastoon (Canada), le 18 janvier 1976, demeurant à Apt 704 433 11 Avenue SE,

Calgary, Alberta T2G 0C7 (Canada), comme gérant de catégorie A de la Société.

b.- Monsieur Tony Henshaw, né à Leicester (Royaume Uni), le 9 avril 1954, demeurant à Cullen House, Camp End

Road, Weybridge, Surrey KT13 0NR, Royaume Uni, comme gérant de catégorie A de la Société.

c.- Monsieur Hugo Neuman, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 21 octobre 1960, demeurant à 16, rue J.B. Fresez, L-1542

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant de catégorie B de la Société.

2. Le siège social de la Société est établi au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

FAIT ET PASSÉ à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

75728

L

U X E M B O U R G

Signé: J.-Y. Lhommel, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 19 avril 2011. Relation: RED/2011/834. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 3 mai 2011.

Référence de publication: 2011060745/510.
(110067679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Allcorp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 155.159.

EXTRAIT

Sur base du contrat de vente de parts sociales signé en date du 2 septembre 2010, le conseil de gérance a accepté à

l'unanimité que les parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de EUR 1,-; seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé

Nombre

de parts

sociales

BECAP Fund LP
Heritage Hall
Le Marchant Street, St. Peter Port
Guernsey GY1 4HY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Référence de publication: 2011067783/19.
(110075990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Alpha Investimenti Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 74.023.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2011.

Référence de publication: 2011067784/10.
(110075894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Mortgage Backed Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 103.586.

<i>Rectificatif au dépôt fait au registre de commerce et des sociétés en date du 26.10.2004, référence L040086512

Lors de l'acte de constitution de la société anonyme Mortgage Backed Investments S.A., dressé par le notaire Gérard

LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 15 octobre 2004 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 103586,

le numéro de Registre de Commerce de l'administrateur MANACOR (Luxembourg) S.A., une société anonyme, ayant

son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy, a été indiqué erronément comme B 9.068 et,

le numéro de Registre de Commerce du commissaire aux comptes ERNST &amp; YOUNG S.A., une société anonyme

ayant son siège social à L-5365 Munsbach, Parc d'Activité Syrdall 7, a été indiqué erronément comme B 51.238,

alors que le numéro de Registre de Commerce de l'administrateur MANACOR (Luxembourg) S.A. est en fait B 9.098

et que celui du commissaire aux comptes ERNST &amp; YOUNG S.A. est en fait B 47.771.

Luxembourg, le 3 mai 2011.

<i>Pour Mortgage Backed Investments S.A.
Pour avis sincère et conforme
G. LECUIT

75729

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 mai 2011. Relation: LAC/2011/20794. Reçu douze euros (EUR 12,-)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2011.

Référence de publication: 2011068527/25.
(110075810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2011.

COBRA AT, COBRA Automotive Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 41.135.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 16 mai 2011.

Référence de publication: 2011067841/10.
(110075972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

C.R.B., Conception et Réalisations de Bâtiments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 62, rue du Dix Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 137.121.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2011.

Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2011067851/12.
(110076022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

COSCO Ports (Greece) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.124.

EXTRAIT

Monsieur Minjie XU, gérant de la Société, est domicilié depuis le 11 mai 2011 au Flat A, 40 

th

 Floor, Tower 1, The

Belcher's, 89 Pok Fu Lam Road, Hong Kong.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

<i>Pour Cosco Ports (Greece) S.a r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2011067857/15.
(110076045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Dynamic Opportunities SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 157.799.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 avril 2011

En date du 15 avril 2011, le Conseil d'Administration a décidé:
- d'accepter la démission, avec effet au 15 avril 2011, de M. Serge Weyland en qualité d'Administrateur,
-  de  coopter  Mme  Heike  Findeisen,  Caceis  Bank  Luxembourg,  5  Allée  Scheffer,  L  -  2520  Luxembourg  en  qualité

d'Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale prévue en 2011 en remplacement de M. Serge Weyland,
démissionnaire.

75730

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 17 mai 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Dynamic Opportunities SICAV
Caceis Bank Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011067880/17.
(110076034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Doks S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 114.293.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 16 mai 2011.

Référence de publication: 2011067877/10.
(110075936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

East&amp;West Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 140.846.

Statuts coordonnés déposés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 16 mai 2011.

Référence de publication: 2011067888/10.
(110075944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Fourb International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 54.056.

<i>Rectificatif du dépôt du 29 juillet 2009 (No L090116894)

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011067927/14.
(110076062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

P&amp;P Finance SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 69.561.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 18 novembre 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme P &amp; P FINANCE AG, dont le siège social à L-1750 Luxembourg, 62, Avenue Victor Hugo, a été

dénoncé en date du 15 octobre 2003,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'Arrondissement de et

à Luxembourg, et liquidateur Me Pascale MILLIM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 10 décembre 2010 au greffe du tribunal de

commerce.

75731

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Me Pascale MILLIM
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011077564/20.
(110086199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2011.

Gagfah S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 109.526.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011067932/9.
(110075978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

ILP III S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 127.503.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 16 mai 2011.

Référence de publication: 2011067977/11.
(110075963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Moon Stone International Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.073.

Par la présente, nous vous informons que nous démissionnons de notre mandat de Commissaire aux Comptes de la

Société Moon Stone International Investment S.A., avec effet au 9 avril 2010,

Luxembourg, le 9 avril 2010.

C.A.S. Services S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011068053/12.
(110076041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

PEF Gamma Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 128.623.

Il résulte de résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 12 mai 2011 que M. Rüdiger SCHWARZ,

né à Regensburg (Allemagne), le 27 avril 1973, ayant son adresse professionnelle au 15, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) a été nommé en qualité de gérant de la Société, avec effet au 16 mai 2011,
0h00 et pour une période indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est donc dorénavant composé comme suit:
- M. Oliver MAY, gérant;
- M. Jan Baldem MENNICKEN, gérant;
- M. Jobst BECKMANN, gérant; et
- M. Rüdiger SCHWARZ, gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2011.

Référence de publication: 2011068076/19.
(110076002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

75732

L

U X E M B O U R G

PEF Gerrards Cross Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 124.832.

Il résulte de résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 12 mai 2011 que M. Rüdiger SCHWARZ,

né à Regensburg (Allemagne), le 27 avril 1973, ayant son adresse professionnelle au 15, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) a été nommé en qualité de gérant de la Société, avec effet au 16 mai 2011,
0h00 et pour une période indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est donc dorénavant composé comme suit:
- M. Oliver MAY, gérant;
- M. Jan Baldem MENNICKEN, gérant;
- M. Jobst BECKMANN, gérant; et
- M. Rüdiger SCHWARZ, gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2011.

Référence de publication: 2011068077/19.
(110076001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Navarac Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 119.904.

Il résulte de cessions de parts sociales de la société intervenues en date du 2 mars 2011 que:
- 250 parts sociales détenues par Balchan Nominees Limited, Island House, Grande Rue, St Martin's, Guernsey GY4

6RU ont été transférées à AT Nominees Limited, 15, Union Street, St Helier, Jersey, JE1 1FG;

- 250 parts sociales détenues par Balchan Secretaries Limited, Island House, Grande Rue, St Martin's, Guernsey GY4

6RU ont été transférées à IFG Nominees (C.I.) Limited, 15, Union Street, St Helier, Jersey, JE1 1FG.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011068558/16.
(110075687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2011.

StarCap SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 72.359.

<i>Auszug Protokoll Ordentliche Generalversammlung StarCap SICAV

Die Ordentliche Generalversammlung vom 17. Mai 2011 der StarCap SICAV hat folgende Beschlüsse gefasst:
Für den Zeitraum bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2012 wurden folgende Personen als

Verwaltungsratsmitglieder wieder gewählt:

Herr Julien Zimmer (Vorsitzender)
Herr Peter Huber (Mitglied)
Herr Bernhard Singer (Mitglied)
Herr Holger Gachot (Mitglied)
Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.
Die Aktionäre beschließen einstimmig bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung PricewaterhouseCoopers

S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg als Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.

75733

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, 17. Mai 2011.

DZ PRIVATBANK S.A.
<i>Für StarCap SICAV
Vera Augsdörfer / Loris Di Vora

Référence de publication: 2011068630/22.
(110075600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2011.

PEF Iota Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 141.648.

Il résulte de résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 12 mai 2011 que M. Rüdiger SCHWARZ,

né à Regensburg (Allemagne), le 27 avril 1973, ayant son adresse professionnelle au 15, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) a été nommé en qualité de gérant de la Société, avec effet au 16 mai 2011,
0h00 et pour une période indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est donc dorénavant composé comme suit:
- M. Oliver MAY, gérant;
- M. Jan Baldem MENNICKEN, gérant;
- M. Jobst BECKMANN, gérant; et
- M. Rüdiger SCHWARZ, gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2011.

Référence de publication: 2011068078/19.
(110076000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

PEF MB Plaza Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 139.743.

Il résulte de résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 12 mai 2011 que M. Rüdiger SCHWARZ,

né à Regensburg (Allemagne), le 27 avril 1973, ayant son adresse professionnelle au 15, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) a été nommé en qualité de gérant de la Société, avec effet au 16 mai 2011,
0h00 et pour une période indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est donc dorénavant composé comme suit:
- M. Oliver MAY, gérant;
- M. Jan Baldem MENNICKEN, gérant;
- M. Jobst BECKMANN, gérant; et
- M. Rüdiger SCHWARZ, gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2011.

Référence de publication: 2011068080/19.
(110075998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Santa Barbara Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 119.910.

Il résulte de cessions de parts sociales de la société intervenues en date du 2 mars 2011 que:
- 250 parts sociales détenues par Balchan Nominees Limited, Island House, Grande Rue, St Martin's, Guernsey GY4

6RU ont été transférées à AT Nominees Limited, 15, Union Street, St Helier, Jersey, JE1 1FG;

- 250 parts sociales détenues par Balchan Secretaries Limited, Island House, Grande Rue, St Martin's, Guernsey GY4

6RU ont été transférées à IFG Nominees (CI.) Limited, 15, Union Street, St Helier, Jersey, JE1 1FG.

75734

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011068642/16.
(110075686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2011.

PEF Russia Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 128.626.

Il résulte de résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 12 mai 2011 que M. Rüdiger SCHWARZ,

né à Regensburg (Allemagne), le 27 avril 1973, ayant son adresse professionnelle au 15, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) a été nommé en qualité de gérant de la Société, avec effet au 16 mai 2011,
0h00 et pour une période indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est donc dorénavant composé comme suit:
- M. Oliver MAY, gérant;
- M. Jan Baldem MENNICKEN, gérant;
- M. Jobst BECKMANN, gérant; et
- M. Rüdiger SCHWARZ, gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2011.

Référence de publication: 2011068083/19.
(110075996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Europa Titanium S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 800.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 114.111.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des associés de la Société à Luxembourg en date du 11 mai 2011

Lors de l'assemblée générale des associés de la Société qui s'est tenue en date du 11 mai 2011, il a été décidé de:
1) réélire Monsieur Eric Biren, Monsieur Vincent Goy, Madame Zivana Krusic tous les trois demeurant profession-

nellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg et Monsieur Peter Cluff demeurant professionnelle-
ment au 136, Sloane Street, GB - SW1X 9AX, Londres, en leur qualité de gérants de la Société pour une période prenant
fin lors de l'assemblée générale des associés devant se tenir en 2012 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2011; et

2) réélire Deloitte S.A., société anonyme dont le siège social est sis au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg et

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895, aux fonctions de
réviseur d'entreprises de la Société, pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale des associés devant se
tenir en 2012 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 11 mai 2011.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2011068368/23.
(110075586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2011.

PEF Theta Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 141.650.

Il résulte de résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 12 mai 2011 que M. Rüdiger SCHWARZ,

né à Regensburg (Allemagne), le 27 avril 1973, ayant son adresse professionnelle au 15, boulevard Joseph II, L-1840

75735

L

U X E M B O U R G

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) a été nommé en qualité de gérant de la Société, avec effet au 16 mai 2011,
0h00 et pour une période indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est donc dorénavant composé comme suit:

- M. Oliver MAY, gérant;

- M. Jan Baldem MENNICKEN, gérant;

- M. Jobst BECKMANN, gérant; et

- M. Rüdiger SCHWARZ, gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2011.

Référence de publication: 2011068084/19.

(110075995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

PEF Whittington House Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 124.830.

Il résulte de résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 12 mai 2011 que M. Rüdiger SCHWARZ,

né à Regensburg (Allemagne), le 27 avril 1973, ayant son adresse professionnelle au 15, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) a été nommé en qualité de gérant de la Société, avec effet au 16 mai 2011,
0h00 et pour une période indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est donc dorénavant composé comme suit:

- M. Oliver MAY, gérant;

- M. Jan Baldem MENNICKEN, gérant;

- M. Jobst BECKMANN, gérant; et

- M. Rüdiger SCHWARZ, gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2011.

Référence de publication: 2011068085/19.

(110075994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

GROUPE OPEN PSF Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 66, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 69.399.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 décembre 2010 que:

- Décision a été prise de ratifier la démission de Monsieur Jean-Pierre Landrain, né le 28.10.1957 à Waremme (Belgique),

domicilié 45, avenue Constantin-de-Gerlache à B4000 Liège (Belgique), de son poste d'administrateur, à compter de la
date de l'assemblée générale.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
CODEJA s.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011069383/16.

(110075842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2011.

75736

L

U X E M B O U R G

PIN H. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 497.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 150.743.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17 mai 2011.

<i>Résolution:

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à

l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2011 comme suit:

<i>Commissaire aux comptes:

Fiduciaire Mevea Luxembourg Sàrl, 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg

PIN H. S.à r.l.
Société à Responsabilité Limitée
Signatures

Référence de publication: 2011068090/17.
(110075942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Babalou Shipping Company S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 87.633.

Le domicile de la société BABALOU SHIPPING COMPANY S.A.. R.C.S. Luxembourg B n°87633, constituée le 27 mai

2002  par-devant  Maître  Paul  BETTLNGEN,  Notaire  de  résidence  à  Niederanven,  publié  au  Mémorial  C  N°1201  du
12.08.2002, établi au 17, rue Beaumont L - 1219 Luxembourg, a été dénoncé le 17.05.2011.

Luxembourg, le 17.05.2011.

MANACO S.A.
Signature

Référence de publication: 2011068291/12.
(110075881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2011.

Hoche Besso Courtage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 160.646.

STATUTES

In the year two thousand and eleven.
On the twenty-fifth of March.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. BESSO LIMITED, a company having its registered office at 8-11 Crescent, London EC3N 2LY, United Kingdom,

registered in the Registrar of Companies for England and Wales under the number 00910680;

2. Mr Stephen Paul GREENE, born on January 29, 1948 in Carshalton (United Kingdom), having his professional address

at c/o Rankvale European Property Investors, Avenfield House, 118-127 Park Lane, London W1K 7AG, United Kingdom;

3. Mr Brian Stanley COOPER, born on October 5, 1943 in London (England), having his professional address at c/o

Rankvale European Property Investors, Avenfield House, 118-127 Park Lane, London W1K 7AG, United Kingdom;

4. Mr Aubrey GLASER and Mrs Carol GLASER as Co-Trustees of THE GLASER LIVING TRUST, having its United

Kingdom correspondence address at c/o Rankvale European Property Investors, Avenfield House, 118-127 Park Lane,
London W1K 7AG, United Kingdom;

5. HOCHE PARTNER TRUST SERVICES S.A., a public limited company having its registered office at 121, avenue de

la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B 110094.

All the appearing parties are here represented by Mr. Jean-Pascal CARUSO, private employee, with professional ad-

dress at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, by virtue of five proxies given under private seal.

Said proxies signed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed for the purpose of registration.

75737

L

U X E M B O U R G

Such proxy-holder, acting in the above stated capacities, has requested the above notary to draw up the articles of

incorporation of a limited liability company ("société à responsabilité limitée") which the prenamed parties hereby declare
to form:

Art. 1. Form. There is established a limited liability company ("société à responsabilité limitée") (the "Company")

governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10, 1915 on commercial companies,
as amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation")

Art. 2. Object. The object of the Company is insurance brokerage and any related operations or likely to promote

directly or indirectly its realization, as well as any similar or related activities in accordance with the provisions of the
modified insurance law of December 6 

th

 , 1991 or any subsequent law entering into force after incorporation.

The Company may hold interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings as well as the administration, deve-

lopment and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such

as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. Name. The name of the Company is HOCHE BESSO COURTAGE S.à r.l..

Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the management.
The management may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-

sented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (1.EUR) each, all fully paid up.

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by a decision of the single partner or

pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and Duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets

of the Company and to one vote at the general meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible insofar as the Company is concerned. Co-owners must be

represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares. If the Company is composed of one single partner, said single partner may transfer freely

its shares.

If the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.
In this same scenario, the shares may only be transferred amongst living persons to non-partners with the authorisation

of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company in accordance with Article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy or insolvency or any other similar

event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Managers. The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not.

75738

L

U X E M B O U R G

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation of
each manager.

Art. 14. Powers of the managers. The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administration,

management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls
within the object of the Company. They have the social signature and are empowered to represent the Company in court
either as plaintiff or defendant.

The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to

persons or agents chosen by the Manager(s).

Art. 15. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting

a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 16. Liability of the managers. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in

relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 17. Representation of the company. The Company will be bound towards third parties by the sole signature of

the manager or in case of plurality of managers, by the joint signature of any two (2) managers or by the joint signatures
or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, but only
within the limits of such power.

Art. 18. General meetings of partners. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the

powers granted by law to the general meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10 

th

 , 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of partners

or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the associates
by registered mail.

In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 19. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners, as the case may be, are

documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The
documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.

Art. 20. Financial year. The financial year begins on the 1 

st

 day of January of each year and ends on the 31 

st

 day of

December the same year.

Art. 21. Balance-sheet. Each year, on the 31 

st

 day of December, a general inventory of the assets and liabilities of the

Company and a balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact carrying
a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

Art. 22. Allocation of profits. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of

overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 23. Dissolution, Liquidation. In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or

several liquidators who may, but need not be partners, appointed by the single partner or the general meeting of partners,
who shall determine their powers and their compensation.

Art. 24. Matters not provided. All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be deter-

mined in accordance with the law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitory provision

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the 31 

st

 of December

2011.

75739

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and Payment

All the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed as follows:

1. BESSO LIMITED, prenamed, six thousand three hundred and seventy-five shares; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,375

2. Mr Stephen Paul GREENE, prenamed, one thousand four hundred and seventeen shares; . . . . . . . . . . . . .

1,417

3. Mr Brian Stanley COOPER, prenamed, one thousand four hundred and seventeen shares; . . . . . . . . . . . .

1,417

4. Mr Aubrey GLASER and Mrs. Carol GLASER as Co-Trustees of
THE GLASER LIVING TRUST, prenamed, one thousand four hundred and sixteen shares; . . . . . . . . . . . . . .

1,416

5. HOCHE PARTNER TRUST SERVICES S.A., prenamed,
one thousand eight hundred and seventy-five shares; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,875

Total: twelve thousand five hundred shares; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500

All the shares have been totally paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-

EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned
notary, who expressly attests thereto.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand one hundred Euro.

<i>Decisions of the partners

Immediately after the incorporation of the company, the partners representing the entire corporate capital and con-

sidering themselves duly convened, took the following resolutions:

<i>First resolution

The partners resolved to set at four the number of Managers and further resolved to appoint the following as Managers

for an unlimited duration, with the powers set forth in article fourteen (14) of the articles of incorporation of the Company:

- Mr Alain HEINZ, born on May 17, 1968 in Forbach (France), residing professionally at 121, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg;

- Mr Roddy CAXTON-SPENCER, born on July 5, 1959 in Hillingdon (United Kingdom), residing professionally at c/o

BESSO LIMITED, having its registered office at 8-11 Crescent, London EC3N 2LY, United Kingdom;

- Mr Stephen Paul GREENE, born on January 29, 1948 in Carshalton (United Kingdom), residing professionally at c/o

Rankvale European Property Investors, Avenfield House, 118-127 Park Lane, London W1K 7AG, United Kingdom;

- Mr David FIELD, born on July 1, 1969 in Wembley (United Kingdom), residing professionally at c/o BESSO LIMITED,

having its registered office at 8-11 Crescent, London EC3N 2LY, United Kingdom.

<i>Second Resolution

The partners resolved to appoint Mr Roddy CAXTON-SPENCER as Managing Director of the company with power

to bind the company by his sole signature.

<i>Third Resolution

The registered office shall be at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, first name, civil status and

residence, he signed together with the notary this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze.
Le vingt-cinq mars.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. BESSO LIMITED, une société ayant son siège social à 8-11 Crescent, Londres EC3N 2LY, Royaume-Uni, inscrite au

"Registrar of Companies for England and Wales" sous le numéro 00910680;

2. Monsieur Stephen Paul GREENE, né le 29 janvier 1948 à Carshalton (Royaume-Uni), ayant son adresse profesionnelle

à c/o Rankvale European Property Investors, Avenfield House, 118-127 Park Lane, Londres W1K 7AG, Royaume-Uni;

75740

L

U X E M B O U R G

3. Monsieur Brian Stanley COOPER, né le 5 octobre 1943 à Londres (Angleterre), ayant son adresse profesionnelle à

c/o Rankvale European Property Investors, Avenfield House, 118-127 Park Lane, Londres W1K 7AG, Royaume-Uni;

4. Monsieur Aubrey GLASER et Madame Carol GLASER comme Co-Trustees du THE GLASER LIVING TRUST, ayant

son adresse de correspondance pour le Royaume-Uni à c/o Rankvale European Property Investors, Avenfield House,
118-127 Park Lane, Londres W1K 7AG, Royaume-Uni;

5. HOCHE PARTNER TRUST SERVICES S.A., une société anonyme ayant son siège social au 121, avenue de la Faïen-

cerie, L-1511 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg numéro B 110094.

Tous les comparants sont ici représentés par Monsieur Jean-Pascal CARUSO, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en vertu de cinq procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations, signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une

société à responsabilité limitée que les parties pré-mentionnées déclarent constituer:

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article
1832 du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

Art. 2. Objet. La Société a pour objet toutes opérations de courtage en assurances et toutes opérations y relatives ou

pareilles pour promouvoir directement ou indirectement sa réalisation, de même que toutes activités similaires ou rela-
tives en conformité des prescriptions de la loi modifiée du 6 décembre 1991 ou de toute autre loi postérieure entrant
en vigueur après la constitution.

La Société a encore pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises

ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, y compris notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations ou d'instruments de dette

similaires.

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera

utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de HOCHE BESSO COURTAGE S.à r.l..

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée

générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.
La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à

l'étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par douze

mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune, toutes entièrement libérées.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision de

l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et Obligations attachées aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal

dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

75741

L

U X E M B O U R G

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.

Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d'un associé unique, ledit associé unique peut librement céder

ses parts.

Si la Société est composée d'une pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément

donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou

acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 12. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre évé-

nement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Les gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou par l'assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un

gérant, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Art. 14. Pouvoirs des gérants. Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'adminis-

tration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à
condition qu'elles rentrent dans l'objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société
en justice soit en demandant soit en défendant.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou

temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).

Art. 15. Evénements atteignant les gérants. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire

affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 16. Responsabilité des gérants. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.

Art. 17. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique

ou en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe ou la signature
individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seulement dans les
limites de ce pouvoir.

Art. 18. Assemblée générale des associés. Lorsque la société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les

pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ces cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi
du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou par

vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 19. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, seront établies

par écrit et consignée dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés,
ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.

Art. 20. Année sociale. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même

année.

Art. 21. Bilan. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire général de l'actif et du passif de la société

et un bilan résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication

desdits inventaire et bilan.

75742

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des

frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que

ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 24. Disposition générale.  Toutes  les  matières  qui  seraient  pas  régies  par  les  présents  statuts  seraient  régies

conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2011.

<i>Souscription et Libération

Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. BESSO LIMITED, prénommée, six mille trois cent soixante-quinze parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.375

2. Monsieur Stephen Paul GREENE, prénommé, mille quatre cent dix-sept parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . .

1.417

3. Monsieur Brian Stanley COOPER, prénommé, mille quatre cent dix-sept parts sociales; . . . . . . . . . . . . . .

1.417

4. Monsieur Aubrey GLASER et Madame Carol GLASER comme Co-Trustees du
THE GLASER LIVING TRUST, prénommé, mille quatre cent seize parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.416

5. HOCHE PARTNER TRUST SERVICES S.A., prénommée,
mille huit cent soixante-quinze parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.875

Total: douze mille cinq cents parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (12.500,- EUR), est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Evaluation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à mille cent euros.

<i>Résolutions des associés

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de fixer à quatre le nombre de Gérants et de nommer les personnes suivantes en tant que

Gérants pour une période indéterminée, avec les pouvoirs prévus à l'article quatorze (14) des statuts de la Société:

- Monsieur Alain HEINZ, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), demeurant professionnellement au 121, avenue de la

Faïencerie, L-1511 Luxembourg;

- Monsieur Roddy CAXTON-SPENCER, né le 5 juillet 1959 à Hillingdon (Royaume-Uni), demeurant professionnelle-

ment à c/o BESSO LIMITED, ayant son siège social à 8-11 Crescent, Londres EC3N 2LY, Royaume-Uni;

- Monsieur Stephen Paul GREENE, né le 29 janvier 1948 à Carshalton (Royaume-Uni), demeurant professionnellement

à c/o Rankvale European Property Investors, Avenfield House, 118-127 Park Lane, Londres W1K 7AG, Royaume-Uni;

- Monsieur David FIELD, né le 1 

er

 juillet 1969 à Wembley (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à c/o

BESSO LIMITED, ayant son siège social à 8-11 Crescent, Londres EC3N 2LY, Royaume-Uni.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de nommer Monsieur Roddy CAXTON-SPENCER comme gérant délégué de la société avec le

pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

<i>Troisième résolution

Le siège social est fixé à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire des com-

parants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même
mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

75743

L

U X E M B O U R G

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des comparants connu du notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, le même comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Jean-Pascal CARUSO, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 avril 2011. Relation GRE/2011/1335. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Ronny PETER.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 14 avril 2011.

Référence de publication: 2011060795/345.
(110067830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Platina International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 130.946.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 17 mai 2011.

Référence de publication: 2011068092/10.
(110076006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Signet Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 30.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 146.368.

EXTRAIT

En date du 14 décembre 2010, l'associé unique a pris la résolution suivante:
- La démission de M. Terry Lee Burman en tant que gérant de la société, est acceptée avec effet immédiat.
Suite à cette résolution de l'associé, le conseil de gérance est composé comme suit:
- M. Ronald Ristau, gérant,
- M. Mark Andrew Jenkins, gérant,
- M. Wim Rits, gérant,
- M. Ivo Hemelraad, gérant.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 17 mai 2011.

Référence de publication: 2011068107/18.
(110076005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Delilah S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 114.215.900,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 147.734.

Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance de la Société tenu en date du 27 mai 2011 que le siège social de la

Société a été transféré du 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 31 mai 2011.

<i>Pour la Société
Un Mandataire

Référence de publication: 2011075630/15.
(110084125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

75744


Document Outline

ABAKUS

Algodeal Luxembourg S.à r.l.

Allcorp S.à r.l.

Alpha Investimenti Sicav

Aviva Investors Investment Solutions

Aviva Investors Investment Solutions

Babalou Shipping Company S.A.

BlackRock Global Investment Series

COBRA Automotive Technologies S.A.

Conception et Réalisations de Bâtiments

COSCO Ports (Greece) S.à r.l.

Delilah S.à r.l.

Diane Investments S.A.

Do Absolute Return

Do Aktien Global

Doks S.A.

Dynamic Opportunities SICAV

East&amp;West Finances S.A.

Edene Lux Invest S.à r.l.

ERE III Twenty S.à r.l.

Europa Titanium S.à r.l.

Exile Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Fourb International S.A.

Gagfah S.A.

GROUPE OPEN PSF Luxembourg

Hoche Besso Courtage S.à r.l.

ILP III S.C.A., SICAR

Moon Stone International Investment S.A.

Mortgage Backed Investments S.A.

Navarac Properties S.à r.l.

Nuova Era S.A.

Opensys S.à r.l.

OPG 1 S.à r.l.

PEF Gamma Investment S.à r.l.

PEF Gerrards Cross Investment S.à r.l.

PEF Iota Investment S.à r.l.

PEF MB Plaza Investment S.à r.l.

PEF Russia Investment S.à r.l.

PEF Theta Investment S.à r.l.

PEF Whittington House Investment S.à r.l.

PIN H. S.à r.l.

Platina International S.A.

P&amp;P Finance SA

Profilo Sicav

Santa Barbara Properties S.à r.l.

SCM PE IV General Partner S.à r.l.

Signet Luxembourg Finance S.à r.l.

StarCap SICAV

Taurus Invest FCP-FIS

WFL Invest FCP-FIS