logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1387

27 juin 2011

SOMMAIRE

Ability Finance Luxembourg S.à r.l. . . . . . .

66569

ALESRAA Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

66571

Alexus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66576

Aperam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66535

Association des parents et des personnes

âgées d'origine espagnole  . . . . . . . . . . . . . .

66574

Black Tie Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66556

Cacyopee Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66570

Carlisle Management Company S.C.A. . . .

66553

CETP II Foundry S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

66562

Cinq2base S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66576

CS Taxis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66576

DB Advisors Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66552

DB Advisors Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66553

D & D S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66576

DS Care S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66534

Dubaian Investment Adviser S.à r.l. . . . . . .

66573

DWS Concept  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66567

DWS Dividende USA Direkt 2014  . . . . . . .

66552

DWS India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66551

DWS Shift 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66552

DWS Shift 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66552

DWS Shift 2017  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66552

Fiduciaire Eurolux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66570

Finateam Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66561

Fintad International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

66558

Fintad Securities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66558

GoldPort Stabilitätsfonds  . . . . . . . . . . . . . . .

66553

HEAREF Luxembourg Self Storage  . . . . . .

66560

Helikos SE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66530

Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66561

Hewlett-Packard Luxembourg Participa-

tions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66561

IRERE Luxembourg Self Storage  . . . . . . . .

66560

JRS SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66561

La Rose S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66553

LaSalle Nasu S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66562

Le Lys S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66555

Libra Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

66561

Mellinckrodt 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66540

Mirale Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66556

Nassou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66568

PAP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66569

Private Equity Portfolio 2007 ITM S.C.A.,

SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66541

Private Equity Portfolio 2007 S.C.A., SI-

CAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66541

Pylos Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66569

Rayburn Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

66573

Rayburn Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

66571

Residia Immobilier S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

66569

Rovi Technologies S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

66567

RSTM BVBA & Cie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66573

Rylux Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66574

Salalah Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66567

Smart Holding Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

66564

Terra Mundus Solar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

66568

UBS Fund Management (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66562

66529

L

U X E M B O U R G

Helikos SE, Société Européenne.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 148.525.

Notice is hereby given to the holders of Class A Warrants of Helikos SE (the "Company") that the board of directors

of the Company has resolved to cancel the SPECIAL MEETING OF THE CLASS A WARRANTHOLDERS initially sche-
duled to be held on July 1, 2011 at 11:00 (eleven) CEST in Luxembourg, that proxy and voting forms published and made
available in connection with the July 1, 2011 meeting are no longer valid and should no longer be used, that any proxy or
voting forms received in connection with the July 1, 2011 meeting will be deemed void and that a

SPECIAL MEETING OF THE CLASS A WARRANTHOLDERS

will be held on <i>July 21, 2011 at 11:00 (eleven) CEST. The meeting will be held at Hotel Le Royal, 12, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg. This meeting has been convened in lieu of the Special Meeting of Class A Warrantholders previously
scheduled for July 1, 2011, for which the convening notice has been cancelled.

At the special meeting, the Class A Warrantholders shall deliberate and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the proposed acquisition by a wholly-owned subsidiary of the Company of all the outstanding shares

of Exceet Group AG (the "Transaction") to which the amendment of the terms and conditions of the Class A
Warrants is subject;

2. Approval of amendments to the terms and conditions of Class A Warrants with effect on the day and immediately

prior to the time at which the Company, together with its direct subsidiaries, become the sole shareholders of
Exceet Group AG in particular providing the following:
- Increase of the Exercise Price per Class A Share from nine euro (EUR 9) to twelve euro (EUR 12);
- Amendment of the calculation formula that determines the number of Warrant Shares to be issued upon exercise
of Class A Warrants so that upon exercise each holder will receive a number of Warrant Shares to be issued by
the Issuer to the Warrantholder that is equal to the quotient derived from dividing (x) the product of the number
of Class A Warrants exercised, multiplied by the difference between the Fair Market Value on the date of exercise
of the relevant Class A Warrants and the Exercise Price of the Class A Warrants by (y) twice the Fair Market Value
on the date of exercise of the relevant Class A Warrants, with a maximum Fair Market Value of EUR 17;
- Entitlement of each Class A Warrant to a cash payment of EUR 0.625 per Class A Warrant upon the consummation
of the Transaction;
- Extension of the term of the Class A Warrants to five (5) years from consummation of the Transaction;
- Increase of the Redemption Trigger Price to seventeen euro (EUR 17).

Pursuant to clause 10.1 of the terms and conditions of the Class A Warrants, amendments of the terms and conditions

of the Class A Warrants require the written consent of the holders of a majority of the outstanding Class A Warrants.

The proposed amendments to the terms and conditions of the Class A Warrants are further subject to the approval

of the Transaction by an extraordinary general meeting of shareholders of the Company and the consummation of the
Transaction.

Documents
Copies of a proxy statement describing the proposed amendments, together with a supplement of the proxy statement

indicating  the  key  dates  in  connection  with  the  July  21,  2011  special  meeting  of  warrantholders,  as  well  as  relevant
information with respect to the proposed Transaction, the draft proposed amended terms and conditions of Class A
Warrants  and  other  the  documents  submitted  to  the  special  meeting  are  available  on  the  Company's  website
(www.helikosgroup.com).

Upon request, copies of the above-mentioned documents will be mailed to the Class A Warrantholders.

Number of Warrants outstanding
On the date of this convening notice, twenty million (20,000,000) Class A Warrants issued by the Company are

outstanding. Each Class A Warrant entitles the holder thereof to one vote.

Right to participate in the meeting
Each Class A Warrantholder who holds one or more Class A Warrants of the Company on July 21, 2011, the date of

this special meeting of warrantholders, and timely furnishes the certificate specified below, shall be admitted to participate
and vote in the special meeting of Class A Warrantholders.

Class A Warrantholders (whose Class A Warrants are held in book-entry form through the operator of a securities

settlement system or with a professional depositary or sub-depositary designated by such depositary) should receive
from such operator or depositary or sub-depositary a certificate certifying the identity of the account holder, the number
of their Class A Warrants recorded in their account and confirmation that transfers of such Class A Warrants are
temporarily blocked until the close of the special meeting of the warrantholders.

66530

L

U X E M B O U R G

To participate and vote in the special meeting of Class A Warrantholders shall submit a copy of such certificate via

their custodian bank by mail, by fax or by email by July 19, 2011 to the Centralizing Agent of the Company, being:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Attn.: TSS/GES, Post-IPO Services
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main Germany
Fax: +49/69 910-38794
Email: dct.tender-offers@db.com
Any Class A Warrantholder and/or proxyholder participating in the special meeting of Class A Warrantholders in

person shall carry proof of identity at such meeting.

Representation
In the event that any Class A Warrantholder appoints another person, warrantholder or not, as his proxy to vote on

his behalf, the proxy should be submitted to the Centralizing Agent of the Company by mail, by fax or by email no later
than on July 19, 2011.

Proxy forms provided on the website of the Company (www.helikosgroup.com) should be used and only signed proxy

forms will be taken into account. One person may represent more than one Class A Warrantholder.

Proof of ownership of Class A Warrants (see above section "Right to participate in the meeting") together with the

completed and executed proxy form must be submitted to the Centralizing Agent by July 19, 2011.

Voting
Each Class A Warrantholder may also vote in the special meeting through a voting form. The voting form may be

submitted by mail, fax or by email to the Centralizing Agent of the Company, no later than July 19, 2011 and should be
accompanied by proof of ownership of Class A Warrants (see above section "Right to participate in the meeting"). Only
voting forms provided by the Company on its website (www.helikosgroup.com) may be used and only signed and com-
pleted voting forms will be taken into account.

Language
The meeting will be held in English language.

June 22, 2011.

<i>For the board of directors of the Company.

Notice is hereby given to the shareholders of Helikos SE (the "Company") that the board of directors of the Company

has resolved to cancel the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS initially scheduled to be held
on July 1, 2011 at 12:00 (noon) CEST in Luxembourg, that proxy and voting forms, redemption notices and withdrawal
notices published and made available in connection with the July 1, 2011 EGM are no longer valid and should no longer
be used, that any proxy or voting form, redemption notice, withdrawal notice, or registration received in connection
with the July 1, 2011 EGM will be deemed void and will have no effect, and as a consequence, Class A Shares previously
tendered for redemption or for which a withdrawn notice was filed in connection with the July 1, 2011 EGM will be
returned to shareholders as soon as possible and will not be redeemed, and that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders will be held on <i>July 21, 2011 at 12:00 (noon) CEST. The meeting will be held at Hotel Le Royal, 12,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. This meeting has been convened in lieu of the extraordinary general meeting of
shareholders previously scheduled for July 1, 2011, for which the convening notice has been cancelled.
At the extraordinary general meeting, the shareholders shall deliberate and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Acknowledgement of the meeting of holders of Class A Warrants and presentation of the result;
2. Presentation and approval of the proposed business combination with Exceet Group AG (the "Transaction") con-

ditional upon [i] the approval of items 3 to 9 of the agenda and [ii] the Warrant Holder Approval;

3. Change of the name of the Company into "exceet Group SE" conditional upon [i] the approval of items 2 and 4 to

9 of the agenda and [ii] the Warrant Holder Approval and with effect as of the Consummation;

4. Creation of new classes of shares to be entitled "Class C1 Shares", "Class C2 Shares" and "Class C3 Shares",

determination of their rights, resolution that the Class C Shares shall conditionally convert into Class A Shares and
determination of the conditions of conversion, conditional upon [i] the approval of items 2 to 3 and 5 to 9 of the
agenda, and [ii] the Warrant Holder Approval and with effect as of the Consummation;

5. Amendment and determination of the rights of Class B Shares, resolution that the Class B Shares shall conditionally

convert into Class A Shares and determination of the conditions of conversion, conditional upon [i] the approval
of items 2 to 4 and 6 to 9 of the agenda, and [ii] the Warrant Holder Approval and with effect as of the Consum-
mation;

6. Acknowledgement of the supplementary special report of the board of directors, reduction of the authorized capital

and renewal of the authorization period: During the period of five years from the publication of the resolutions of

66531

L

U X E M B O U R G

this general meeting, the board of directors is authorized to issue shares regardless whether such shares are paid
for in cash or in kind, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into
shares within the limit of the authorized share capital, to such persons and on such terms as they shall see fit, and
specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe
to the shares issued conditional upon [i] the approval of items 2 to 5 and 7 to 9 of the agenda, and [ii] the Warrant
Holder Approval and with effect as of the Consummation;

7. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company in the form made available on the

website of the Company as from June 27, 2011 conditional upon [i] the approval of items 2 to 6 and 8 to 9 of the
agenda, and [ii] the Warrant Holder Approval and with effect as of the Consummation;

8. Acknowledgment of the resignation of directors, granting of discharge to such directors and appointment of new

directors, conditional [i] upon the approval of items 2 to 7 and 9 of the agenda, and [ii] the Warrant Holder Approval
and with effect as of immediately after the board meeting of the Company taking place on the date of the Con-
summation;

9. Granting of a proxy to the board of directors to confirm compliance with conditions for conversion, acknowledge

occurrence of the Consummation and make any statement, sign all documents, represent the shareholders in front
of a Luxembourg notary and do everything which is lawful, necessary or simply useful in view of the accomplishment
and fulfillment of the resolutions taken and the articles of association, conditional upon [i] the approval of items 2
to 8 of the agenda, and [ii] the Warrant Holder Approval and with effect as of the Consummation.

"Consummation" shall mean on the day of and immediately prior to the time at which the Company, together with its

direct subsidiaries, become the sole shareholders of Exceet Group AG.

"Warrant Holder Approval" shall mean the approval by the warrant holders of the amendment of the terms and

conditions of the Class A Warrants proposed in the special meeting of warrant holders convened for July 21, 2011.

Quorum and Majorities
Pursuant to the articles of association and the law, resolutions regarding (i) item 2 of the agenda will be passed at a

simple majority of the votes validly cast, only if a quorum of at least twenty-five percent (25%) of the Class A Shares is
present or represented, (ii) items 3, 4, 5, 6, 7 of the agenda will be passed at a majority of 2/3 of the votes validly cast for
each class of shares individually and only if a quorum of at least half of the share capital is present or represented for each
class of shares individually and (iii) items 8 and 9 of the agenda will be passed at a simple majority of the votes validly cast,
regardless of the portion of capital represented. Given that all resolutions are conditional upon the other resolutions
being taken, the general meeting may only deliberate and vote on any item of the agenda if a quorum of at least half of
the share capital is present or represented for each class of shares taken individually.

The approval of each resolution is subject to the approval of all other agenda items and the Warrant Holder Approval.
Pursuant to the articles of association, one or several shareholders representing at least five percent (5%) of the

Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of the extraordinary general
meeting by providing notice to the Company by registered letter to the attention of the board of directors, 115 avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg prior to July 18, 2011 at 12:00 (noon) (CEST) detailing their request and the addi-
tional items of the agenda. The Company will make any amended agenda available prior to the meeting.

Documents
Copies of a proxy statement describing the matters to be considered by the extraordinary general meeting, together

with a supplement to the proxy statement indicating the key dates in connection with the July 21, 2011 extraordinary
general meeting of shareholders, as well as other relevant information with respect to the proposed Transaction, the
draft resolutions of the general meeting as well as the documents submitted to the general meeting and the revised agenda,
if  any,  further  to  a  requested  adjunction  in  accordance  with  the  above,  will  be  available  on  the  Company's  website
(www.helikosgroup.com) as from June 27, 2011.

Upon request to info@helikosgroup.com, copies of the above-mentioned documents will be mailed to the sharehol-

ders.

Share Capital of the Company
The Company's issued share capital is set at four hundred thousand euro (EUR 400,000) represented by (i) twenty

million (20,000,000) redeemable class A shares, (ii) two million one hundred and five thousand two hundred and sixty-
four (2,105,264) redeemable class B1 shares, (iii) two million one hundred and five thousand two hundred and sixty-three
(2,105,263) redeemable class B2 shares, and (iv) two million one hundred and five thousand two hundred and sixty-three
(2,105,263) redeemable class B3 shares.

Each share entitles the holder thereof to one vote.

Right to participate in the meeting
Any shareholder who holds one or more shares of the Company on July 13, 2011 at 6:00 pm (CEST) (the "Record

Date"), and timely furnished the certificate specified below, shall be admitted to participate and vote in the general meeting
of shareholders.

66532

L

U X E M B O U R G

Class A Shareholders (whose Class A Shares are held in book-entry form through the operator of a securities sett-

lement system or with a professional depositary or sub-depositary designated by such depositary) should receive from
such operator or depositary or sub-depositary a certificate certifying the number of shares recorded in their account on
the Record Date.

To participate and vote in the extraordinary general meeting, Class A Shareholders shall submit a copy of the certificate

via their custodian bank by mail, by fax or by email to the Centralizing Agent in the period from July 13, 2011, 6:00 pm
(CEST), until July 19, 2011. Shareholders having validly tendered their Class A Shares for redemption by providing a
Redemption Notice to the Company and transferring the shares tendered for redemption to the special account of the
Company do not need to register separately for the EGM in respect of such shares (please refer to "Redemption process
of Class A Shares" below for more details).

To participate and vote in the extraordinary general meeting, Class B Shareholders shall submit a copy of their share

certificate(s) by mail, fax or by email in the period from July 13, 2011, 6:00 pm (CEST) until July 19, 2011, to the Centralizing
Agent of the Company, being:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Attn.: TSS/GES, Post-IPO Services
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
Fax: +49/69 910-38794
Email: dct.tender-offers@db.com
Any shareholder and/or proxyholder participating in the EGM in person shall carry proof of identity at the extraor-

dinary general meeting.

Representation
In the event that any shareholder appoints another person, shareholder or not, as his proxy to vote on his behalf, the

proxy should be submitted by mail, fax or by email to the Centralizing Agent of the Company no later than on July 19,
2011.

Proxy forms provided on the website of the Company (www.helikosgroup.com) should be used and only signed proxy

forms will be taken into account. One person may represent more than one shareholder. Shareholders having presented
a Redemption Notice do not need to provide a separate proxy (see section "Redemption process of Class A Shares"
below).

A  shareholding  proof  (see  above  section  "Right  to  participate  in  the  meeting")  together  with  the  completed  and

executed proxy form, if any, must be submitted from July 13, 2011, 6:00 pm (CEST) until July 19, 2011.

Voting
Each shareholder may also vote in the general meeting through a voting form. The voting form may be submitted by

mail, by fax or by email to the Centralizing Agent of the Company no later than on July 19, 2011 and should be accompanied
by a shareholding proof (see above section "Right to participate in the meeting"). Only voting forms provided by the
Company on its website (www.helikosgroup.com) may be used and only signed voting forms will be taken into account.

Redemption process of Class A Shares
Pursuant to the Company's Articles, the approval of the proposed Transaction requires in addition that less than 35%

of the Class A Shares have been validly tendered for redemption (the "35% Threshold").

In the event a Class A Shareholder wishes to exercise his redemption rights in accordance with the articles of asso-

ciation, such Class A Shareholder shall follow the following procedure:

a) a redemption notice shall be submitted via the relevant custodian bank by mail, fax or by e-mail to the Centralizing

Agent of the Company no later than 6:00 p.m. (CEST) on July 8, 2011. Only redemption notices provided by the Company
on its website (www.helikosgroup.com) may be used and only signed redemption notices will be taken into account;

b) the Class A Shares tendered for redemption shall be transferred not later than 6:00 pm (CEST) July 8, 2011 to a

special account of the Company being the following:

Account number: 100 8827883 01
Account name: Helikos SE Abwicklungsdepot für Aktienrückkauf-/Kaufoption
Name of Bank: Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
BIC-Code: DEUTDEFF
Clearstream Banking AG, Frankfurt, participant number: 7003
c) by submitting a redemption notice, a Class A Shareholder wishing to exercise his redemption rights grants a proxy

to Mr. Dirk Jan van Ommeren, C Director of the Company or in his absence Mr. Jean-Michel Ropert, C Director of the
Company, instructing that such shares shall be voted against all items of the agenda, unless and to the extent any Class
B Shareholder exercise his rights under the purchase option (as defined under d) below and in the articles of association)

66533

L

U X E M B O U R G

in respect of such Class A Shares to the Company, in which case such shares shall be voted in favor of the proposed
Transaction; and

d) by submitting a redemption notice, a Class A Shareholder wishing to exercise his redemption rights grants Oranje

Nassau Participaties B.V. (the "Wendel Shareholder") an option to purchase all or a portion of the Class A Shares tendered
for redemption, exercisable at any time on or prior to July 12, 2011 at the redemption price of ten point zero five six
two five euro (EUR 10.05625) per Public Share (subject to rounding).

For more detailed information with respect to the redemption price, please refer to the proxy statement available on

the website of the Company (www.helikosgroup.com).

A Class A Shareholder having submitted his redemption notice to the Company may withdraw such redemption notice

in respect of all or a portion of the Class A Shares tendered for redemption by delivering a withdrawal notice via the
relevant custodian bank by mail, fax or by email to the Centralizing Agent of the Company no later than on or prior to
July  12,  2011  at  6:00  pm  (CEST).  Only  withdrawal  notices  in  the  form  provided  by  the  Company  on  its  website
(www.helikosgroup.com) may be used and only signed withdrawal notices will be taken into account. In case a redemption
notice is withdrawn, the shares will be returned to the holder thereof as soon as practicable after the Record Date, will
not be subject to the purchase option and will not be redeemed. They will be disregarded for the purpose of the deter-
mination if the 35% Threshold has been met. To participate in the general meeting, shareholders having withdrawn their
Redemption Notice do not need to register for the general meeting separately, but need to provide a new form of proxy
or voting form as described before in the case they are not intending to attend the general meeting in person.

Redemptions of Class A Shares are subject to the approval and consummation of the Transaction (including all reso-

lutions proposed to the extraordinary shareholders' meeting). If the Transaction is not consummated, the tendered Public
Shares will be returned to the shareholders having tendered them for redemption, unless having been purchased under
the purchase option described above.

Purchase option of Class B Shareholders
In the event the Wendel Shareholder wishes to exercise its option to purchase all or a portion of the Class A Shares

a dissenting shareholder has tendered for redemption, it shall submit an option notice by mail, fax or by e-mail to the
Centralizing Agent of the Company at any time on or prior to July 12, 2011.

The purchase price per Class A Share pursuant to the option is equal to the redemption price of EUR 10.05625 per

Public Share (subject to rounding) referred to under "Redemption process of Class A Shares".

Class A Shares for which a valid withdrawal notice has been timely received will not be subject to the purchase option

of the Class B Shareholders.

The transfer of title of the Public Shares for which the Purchase Option is exercised will only become effective if the

Transaction is approved by the EGM. If the Transaction is approved, the Wendel Shareholder will purchase the Public
Shares for which the option was exercised even if the Transaction is not consummated.

Language
The meeting will be held in English language.

Luxembourg, June 22, 2011.

<i>For the board of directors of the Company .

Référence de publication: 2011087166/250/263.

DS Care S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 135.455.

Les actionnaires sont conviés à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires devant se tenir le <i>13 juillet 2011 à 14.30 heures au siège social de la société avec l'agenda suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion de DS Care S.A.
2. Lecture du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2010
3. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2010
4. Affectation du résultat
5. Décharge donnée au commissaire aux comptes et aux administrateurs
6. Election statutaire - renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
7. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011082547/6654/18.

66534

L

U X E M B O U R G

Aperam, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.908.

The shareholders of Aperam, société anonyme (the "Company") are invited to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders and the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders on Tuesday <i>12 July 2011 at 10.00 a.m. at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, Grand-Duchy

of Luxembourg (at the registered office of ArcelorMittal) in order to deliberate on the following matters:

<i>Agenda and Proposed Resolutions

<i>of the

<i>Ordinary General Meeting of Shareholders

<i>and the

<i>Extraordinary General Meeting of Shareholders:

ORDINARY GENERAL MEETING

1. Presentation of the management report of the Board of Directors and the report of the independent company

auditor on the annual accounts of the parent company prepared in accordance with the laws and regulations of the
Grand-Duchy of Luxembourg (the "Parent Company Accounts") for the financial period from 1 January to 25 January
2011.
Due to the complexity of the Spin-Off (scission partielle d'une branche d'activité) which was preceded by a multi-
jurisdictional reorganisation of ArcelorMittal's entire stainless and specialty steels businesses, the operating entities
of which are predominantly based in France, Belgium and Brazil, and the related accounting and tax consequences
of the Spin-Off, the Board of Directors of Aperam has decided to close its financial year started on 1 January 2011
on the date on which the Spin-Off became effective, i.e., 25 January 2011.

2. Acknowledgment of derogation to prepare, publish and submit for approval consolidated financial statements for

the financial period from 1 January to 25 January 2011 and approval of the Parent Company Accounts for the
financial period from 1 January to 25 January 2011
Draft resolution (Resolution I)
The General Meeting understands and approves the fact that consolidated accounts for the financial period from
1 January 2011 to 25 January 2011 will not be prepared, published and submitted for approval to the shareholders,
considering that (i) Aperam was essentially a pure holding entity until 25 January 2011, (ii) such consolidated ac-
counts would not provide relevant information to shareholders and investors in addition to the 2010 financial
report published by the Company on 7 June 2011 and (iii) such consolidated accounts would be excessively cum-
bersome and costly to prepare.
The General Meeting, after having reviewed the management report of the Board of Directors and the report of
the independent auditor, approves the Parent Company Accounts for the financial period from 1 January to 25
January 2011 in their entirety, with a resulting loss for Aperam as parent company of the Aperam group of USD
442,434 (established in accordance with the laws and regulations of the Grand-Duchy of Luxembourg.

3. Allocation of results and determination of compensation for the members of the Board of Directors

Draft resolution (Resolution II)
The General Meeting, upon the proposal of the Board of Directors, acknowledges that the results to be allocated
and distributed amount to USD 2,054,721,483, and that no allocation to the legal reserve is required.
The General Meeting, upon the proposal of the Board of Directors, sets the amount of the directors' compensation
to be allocated to the directors in relation to the period starting with the composition of the Board on 6 December
2010 until 25 January 2011 at USD 67,159.
On this basis, the General Meeting, upon the proposal of the Board of Directors, decides to allocate the results of
the Company based on the Parent Company Accounts for the financial period 1 January to 25 January 2011 as
follows:

In U.S. dollars

Loss for the financial period from 1 January to 25 January 2011

(442,434)

Profit brought forward (Report à nouveau)

2,055,163,917

Results to be allocated and distributed

2,054,721,483

Release of reserve for treasury shares*

59,032,548

Allocation to the legal reserve

-

Directors' compensation (comprised of a fixed annual fee) since the composition of the
Board on 6 December 2010 until 25 January 2011

(67,159)

66535

L

U X E M B O U R G

Profit carried forward

2,113,686,872

* As the Company does not own any treasury shares as at 25 January 2011, the amount of USD 59,032,548 of
reserve for treasury shares will be transfered to other reserves as from the next financial period onwards.
P.M. the dividend related to the period will be included in the dividend related to the remainder of the year at the
next allocation of results.

4. Discharge of the directors

Draft resolution (Resolution III)
The General Meeting decides to grant discharge to the directors in relation to the financial period from 1 January
to 25 January 2011.

5. Election of a new director

On 9 May 2011 the Board of Directors decided to co-opt Ms. Laurence Mulliez as member of the Board of Directors
as from 10 May 2011 to fill the vacancy created by Ms. Sylvie Ouziel's resignation which was effective 10 May 2011.
The tabled proposal is to confirm the election of Ms. Laurence Mulliez (45) as member of the Board of Directors
of the Company. Ms. Laurence Mulliez is CEO of Eoxis since 2010. Privately held Eoxis produces energy from
renewable sources. Ms. Mulliez was previously CEO of Castrol Industrial Lubricants and Services at BP from 2007
to 2009 and held various positions in BP starting in 1999, including Head of Strategy for Gas, Power and Renewable
Energy. Ms. Laurence Mulliez will be member of the Audit and Risk Committee, the Transition Committee and the
Sustainability, Performance and Strategy Committee.
Draft resolution (Resolution IV)
The general meeting elects Ms. Laurence Mulliez as director for a mandate that will automatically expire on the
date of the general meeting of shareholders to be held in 2014.

6. Decision to authorise a Restricted Share Unit Plan and a Performance Share Unit Plan 2011

Background
The Restricted Share Unit Plan ("RSU Plan") and the Performance Share Unit Plan (the "PSU Plan") are designed
to enhance the long-term performance of the Company and to retain key employees. The two Plans are intended
to complete Aperam's program of annual performance-related bonuses, the reward system for short-term per-
formance and achievements.
The main objective of the RSU Plan is to provide a retention incentive to the eligible employees. The main objective
of the PSU Plan is to be an effective performance-enhancing scheme based on the achievement of the Company's
strategy. Both Plans are intended to promote the alignment of interests between the Company's shareholders and
eligible employees by allowing them to participate in the success of the Company.
The Restricted Share Unit Plan
It is proposed that, for the period from this General Meeting to the annual general meeting of shareholders to be
held in 2012 a maximum of seventy thousand (70,000) Restricted Share Units (each, a "RSU") of the Company may
be allocated to qualifying employees under the RSU Plan (the " 2011 RSU Cap").
The RSU are subject to "cliff vesting" after three years contingent upon the continued active employment of the
employee with the Aperam group. The RSU Plan is targeted at the 30 most senior managers across the Aperam
group.
The Performance Share Unit Plan
It is proposed that, for the period from this General Meeting to the annual general meeting of shareholders to be
held in 2012, a maximum of 20,000 Performance Share Units (each, a "PSU") of the Company may be potentially
allocated to qualifying employees under the PSU Plan (the "2011 PSU Cap"). The employees eligible to participate
in the PSU Plan are a sub-set of the group of employees eligible to participate in the RSU Plan and they will receive
part of their grant in RSUs and part in PSUs. Each PSU may give right to up to two (2) shares of the Company.
The 2011 RSU Cap and the 2011 PSU Cap together represent a maximum of 110,000 shares of the Company.
The PSU Plan will provide for "cliff vesting" after three years of the qualifying employee's continued active employ-
ment  with  the  Aperam  group.  Awards  under  the  PSU  Plan  will  be  subject  to  the  fulfillment  of  cumulative
performance criteria over a three-year period from the date of PSU grant.
The allocation of RSUs and PSUs to eligible employees under the RSU Plan and the PSU Plan will be reviewed by
the Board of Directors' Remuneration, Nomination &amp; Corporate Governance Committee, comprised of three
independent directors, which makes a recommendation to the full Board of Directors. The Committee will also
decide the criteria for granting PSUs and make its recommendation to the Board of Directors. These criteria will
be based on the principle of rewarding for performance upon the achievement of clear and measurable metrics for
shareholder value creation. Performance criteria under consideration are Return On Capital Employed and Total
Cost of Employment per ton of steel produced. The actual achievement or non achievement of the targets would
be validated at the moment when the actual vesting of the PSU takes place in 2014 and would be reported in the
Annual Report published in 2015.
Draft resolution (Resolution V)
The General Meeting authorises the Board of Directors to:
(a) issue (i) up to 70,000 (seventy thousand) RSUs corresponding to up to 70,000 of the Company's fully paid-up
ordinary  shares  (the  "2011  RSU  Cap")  under  the  RSU  Plan  as  described  above,  and  (ii)  up  to  20,000  (twenty
thousand) PSUs corresponding to up to 40,000 (forty thousand) of the Company's fully paid-up ordinary shares

66536

L

U X E M B O U R G

(the "2011 PSU Cap") under the PSU Plan as described above, which may in each case be newly issued shares or
shares held in treasury, such authorisation to be valid from the date of this General Meeting until the annual general
meeting of shareholders to be held in 2012,
(b) adopt any necessary rules to implement the RSU Plan and the PSU Plan, including specific performance targets
per business unit and any administrative measures and conditions for specific situations, as the Board of Directors
may consider appropriate,
(c) decide and implement any increase in the 2011 RSU Cap and the 2011 PSU Cap by the additional number
necessary to preserve the rights of the holders of RSU or PSU in the event of a transaction impacting the Company's
share capital, and
(d) do or cause to be done all such further acts and things as the Board of Directors may determine to be necessary
or advisable in order to implement the content and purpose of this resolution.
The General Meeting acknowledges that the 2011 RSU Cap and the 2011 PSU Cap together represent a maximum
of 110,000 (one hundred and ten thousand) shares, representing less than 0.15% of the Company's current issued
share capital on a diluted basis.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

• Background

Bill of Law 6128, which transposes into Luxembourg law the European Directive 2007/36/EC on the exercise of
certain rights of shareholders in listed companies, was adopted by the Luxembourg parliament on May 20, 2011
(the "Law"). The Law is expected to become applicable on the first day of the second month following the Law's
publication in the Mémorial C.
The purpose of the proposed amendments to the Company's articles of association is to anticipate certain changes
to the Company's articles required by the Law.
Draft First Resolution
The general meeting of shareholders amends Article 6.4 of the Articles of Incorporation of the Company, so that
the second paragraph of Article 6.4 shall be re-written as follows:
"Only until such date when the Luxembourg law transposing Directive 2007/36/EC of 11 July 2007 on the exercise
of certain rights of shareholders in listed companies ("Bill of Law 6128") shall be applicable, no entry shall be made
in the register of shareholders and no notice of a transfer shall be recognised by the Company during the period
starting on the fifth (5 

th

 ) working day before the date of a general meeting of shareholders and ending at the close

of that general meeting, unless the Company establishes a shorter blocking period. Starting on the date on which
Bill of Law 6128 shall be applicable, the record date for purposes of determining which shareholders are entitled
to vote at a general shareholders' meeting shall be the fourteenth (14th) calendar day at midnight prior to the date
of the meeting."
The general meeting of shareholders amends Article 13 of the Articles of Incorporation of the Company so that
the following paragraphs are added at the end of Article 13:
"Shareholders holding at least 5% (five percent) of the Company's share capital may request the addition of one or
more items to the agenda of the general shareholders' meeting or table draft resolutions for items included or to
be included on the agenda. The Company must have received the request at the latest on the twenty-second (22

nd

 ) day prior to the general shareholders' meeting.

Shareholders may send questions to the Company to be answered during the general shareholders' meeting pro-
vided they are received by the Company at the latest on the tenth (10 

th

 ) calendar day prior to the date of the

meeting."

IMPORTANT:
The Ordinary General Meeting will validly deliberate on its agenda regardless of the number of shareholders present

and of the number of shares represented, and the resolutions will be adopted by a simple majority of the votes validly
cast by shareholders present or represented.

The Extraordinary General Meeting will validly deliberate on the sole resolution on its agenda only if at least 50% of

the issued share capital is present or represented (the "Quorum") on the first call and will validly be adopted only if
approved by at least 2/3 of the votes cast at the Extraordinary General Meeting. If the Quorum is not reached on the
first call, the Board of Directors of the Company will convene a second Extraordinary General Meeting at which no
Quorum will be required.

Each share is entitled to one vote.

<i>Conditions for Attendance or Representation

<i>at the Ordinary General Meeting and the Extraordinary General Meeting

A copy of the documentation related to the General Meeting is available at the registered office of the Company and

on the Company's website www.aperam.com under "Investors" - "General Meeting 12 July 2011". The documents re-
quired by Article 73 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, will be available
from the publication date of this convening notice at the registered office of the Company. Shareholders may obtain free

66537

L

U X E M B O U R G

of charge a hard copy of Aperam's statutory accounts for the period 1 January to 25 January 2011 at the Company's
registered office or by e-mail by sending a request to contact@aperam.com.

For shareholders whose ownership is directly or indirectly recorded in the Company's local Dutch shareholders'

register or directly in the Luxembourg shareholders' register (the "European Shares") and for holders of shares whose
ownership is directly or indirectly recorded in the Company's New York shareholders' register (the "New York Shares"),
the conditions for attendance or representation at the General Meeting are as follows:

1. Conditions for personal attendance
(i) Holders whose ownership is indirectly recorded (shares held in clearing)
- Holders of European Shares whose ownership is indirectly recorded, through a clearing system, in the Company's

local Dutch shareholders' register or in the local Luxembourg shareholders' register and who elect to attend the General
Meeting in person must ask their financial intermediary (bank or other financial institution or intermediary) with whom
the shares are on deposit to send a blocking certificate (the "blocking certificate") for their shares to the relevant Cen-
tralisation Agent who must receive it no later than 5.00 pm Central European Time ("CET") on 6 July 2011.

The blocking certificate must indicate clearly the identity of the owner of the Aperam shares, the number of shares

blocked, the date from which such shares are blocked, which must be no later than 7 July 2011, and a statement that the
relevant shares are registered in the local bank or broker's records in the holder's name and will remain blocked until
the close of the General Meeting.

As soon as the Centralisation Agent has received the blocking certificate, an attendance card will be sent to the relevant

shareholder.

- Holders of New York Shares whose ownership is indirectly recorded, through a clearing system, in the Company's

New York shareholders' register and who elect to attend the General Meeting in person must have their financial inter-
mediary (bank or other financial institution or intermediary) or its agent with whom their shares are on deposit issue a
proxy to them which confirms that they are authorised to attend and vote at the General Meeting.

In addition to issuing a proxy, the financial intermediary must complete and return a New York Share blocking request

to Citi. This blocking request must be received by Citi no later than 10.00 am Eastern Standard Time ("EST") on 1 July
2011. The holders of New York Shares must bring the proxy received from their financial intermediary to the General
Meeting, which will serve as an attendance card for the General Meeting. The New York Shares blocking request will
result in the relevant shares being placed into a designated blocked account at The Depository Trust Company for a
period to commence no later than 7 July 2011 and to last until the completion of the General Meeting.

The parent company accounts for the financial year from 1 January to 25 January 2011 are available on request from

Citi or in downloadable form on the Company's website www.aperam.com under "Investors" - "General Meeting 12 July
2011".

- Holders of European Shares and New York Shares who wish to attend the General Meeting in person must bring

their attendance card and a proof of their identity (in the form of either a non-expired identity card or a passport) to the
General Meeting. In order for the General Meeting to proceed in a timely and orderly manner, shareholders are requested
to arrive on time. The doors will open at 8.30 a.m. and the General Meeting will start promptly at 10.00 a.m.

(ii) Holders whose ownership is directly recorded
Holders of European Shares and New York Shares whose ownership is directly recorded in one of the Company

shareholders' registers are invited to announce their intention to participate at the General Meeting by completing, signing,
dating and returning the proxy form available in English or French from the Centralisation Agent and on the Company's
website www.aperam.com under "Investors" - "General Meeting 12 July 2011" to:

- Holders of European Shares
BNP Paribas Securities Services - Corporate Trust Services
CTS - Assemblée Centralisée
Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex, France
Tel.: + 33 1 57 43 83 02; Fax: + 33 1 55 77 95 01 or +33 1 40 14 58 90
- Holders of New York Shares
Citibank Shareholder Services
P.O. Box 43077
Providence, Rhode Island 02940-3077
United States of America
Tel.: 1-877-CITI-ADR (toll free) (U.S. only): Tel.: + 1 781-575-4555 (International). Fax: 1-201-324-3284.
Email: Citibank@shareholders-online.com
The proxy form in English or French can also be downloaded from the Company's website www.aperam.com under

"Investors" - "General Meeting 12 July 2011". The proxy form must be received by BNP Paribas Securities Services (for

66538

L

U X E M B O U R G

European Shares) or Citi (for New York Shares) no later than on 5.00 pm CET on 6 July 2011 for European Shares and
10:00 am EST on 1 July 2011 for New York Shares.

2. Conditions for proxy voting or appointing a proxy
(i) Holders whose ownership is indirectly recorded
- European Shares
Holders of European Shares whose ownership is indirectly recorded in the Company's local Dutch shareholders'

register or in the local Luxembourg shareholders' register and who are unable to attend the General Meeting in person
may give voting instructions to the Company Secretary, Mr. Laurent Beauloye, or to any other person designated by
them.

Prior to giving voting instructions to the Company Secretary, holders of European Shares must have obtained and

delivered to the Centralisation Agent the completed, dated and signed proxy form and the blocking certificate described
above (see "Conditions for personal attendance"). The proxy form may be obtained from the relevant Centralisation
Agent or downloaded from the Company's website www.aperam.com under "Investors" - "General Meeting 12 July 2011".

The completed, signed and dated proxy form must be received together with the blocking certificate by the relevant

Centralisation Agent no later than 5.00 pm CET on 6 July 2011.

A holder of European Shares who wishes to be represented by a proxy other than the Company Secretary must have

obtained and delivered to the relevant Centralisation Agent the blocking certificate described above (see "Conditions for
personal attendance"). In addition, the person appointed as proxy must bring to the General Meeting the completed,
dated  and  signed  proxy  form  obtained  from  the  relevant  Centralisation  Agent  or  downloaded  from  the  Company's
website. The completed, signed and dated proxy form must be returned together with the blocking certificate to the
relevant Centralisation Agent no later than 5.00 pm CET on 6 July 2011.

Holders of European Shares who have obtained the blocking certificate and have executed a proxy but who wish to

revoke such proxy may do so by timely delivering a properly executed later-dated proxy to the relevant Centralisation
Agent no later than 5.00 pm CET on 6 July 2011 or by attending and voting in person at the General Meeting.

- New York Shares
The holders of New York Shares whose ownership is indirectly recorded in the Company's New York shareholders'

register and who are unable to attend the General Meeting in person must follow the voting procedures and instructions
received from their financial intermediary or its agents. In addition, they must instruct their financial intermediary to
complete and return a New York Share blocking request to Citi. This blocking request must be received by Citi no later
than 10:00 am EST on 1 July 2011. The share blocking request will result in the shares being placed into a designated
blocked account at The Depository Trust Company for a period to commence no later than on 7 July 2011 and to last
until the completion of the General Meeting.

The holders of New York Shares must contact their financial intermediary regarding the procedures to change or

revoke their voting instructions.

In either case, simply attending the General Meeting without voting will not revoke the proxy.
- Persons designated as a proxy by holders of European Shares or New York Shares and who wish to attend the

General Meeting in person must bring their proxy card and a proof of their identity (in the form of either a non-expired
identity card or a passport) to the General Meeting. In order for the General Meeting to proceed in a timely and orderly
manner, proxy holders are requested to arrive on time. The doors will open at 8.30 a.m. and the General Meeting will
start promptly at 10.00 a.m.

(ii) Holders whose ownership is directly recorded (including participants in the ArcelorMittal Employee Share Purchase

Programs 2008, 2009 and 2010 who obtained Aperam shares (the "ESPP"))

- The holders of European Shares who received them through the ESPP must complete, sign and date the proxy form

(available in English or French) which can be obtained by contacting:

BNP Paribas Securities Services, Corporate Trust Services
CTS - Assemblée Centralisée
Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex, France
Tel.: + 33 1 57 43 83 02; Fax: + 33 1 55 77 95 01 or + 33 1 40 14 58 90
The same form can also be downloaded from the Company's website www.aperam.com, under "Investors" - "General

Meeting 12 July 2011".

The completed, signed and dated proxy form must be received by the Centralisation Agent no later than 5.00 pm CET

on 6 July 2011.

- The holders of New York Shares whose ownership is directly recorded in the Company's New York shareholders'

register must complete, sign and date the U.S. proxy card (available in English only). The ESPP participants residing in the
United States of America and in Canada hold New York Shares. The completed, signed and dated U.S. proxy card must
be received by Citi (contact details are provided below) no later than 10:00 am EST on 1 July 2011.

66539

L

U X E M B O U R G

3. Request for information and contact details of Centralisation Agents
Shareholders requiring more information may do so by:
* Contacting the Centralising Agents:
- For European Shares included in the Euroclear Nederland system and admitted to trading on NYSE Euronext (Ams-

terdam, Paris), the Centralisation Agent is:

BNP Paribas Securities Services, Corporate Trust Services
CTS - Assemblée Centralisée
Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex, France
Tel.: + 33 1 57 43 83 02 ; Fax: + 33 1 55 77 95 01 or + 33 1 40 14 58 90
- For European Shares included in the Clearstream Banking or Euroclear Bank system and admitted to trading on the

Luxembourg Stock Exchange's regulated market, the Centralisation Agent is:

BNP Paribas Securities Services
Corporate Trust Services - Corporate Action
33, rue de Gasperich
L - 2085 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
Tel.: +352 26 96 2389 / 62455 / 2407; Fax: + 352 26 96 97 57
- For New York Shares traded over the counter, the Centralisation Agent is:
Citi
Citibank Shareholder Services
P.O. Box 43077
Providence, Rhode Island 02940-3077
United States of America
Tel.: 1-877-CITI-ADR (toll free) (U.S. only): Tel.: + 1 781-575-4555 (International). Fax: 1-201-324-3284.
Email: Citibank@shareholders-online.com
• Contacting the Company's Investor Relations department:
Tel.: +352 27 36 27 36; Fax: +352 27 36 27 200
E-mail: contact@aperam.com

Luxembourg, 10 June 2011.

<i>For the Board of Directors
(The Chairman)

Référence de publication: 2011079618/1075/327.

Mellinckrodt 1, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 153.466.

Im Einklang mit den Artikeln 15 und 23 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Inves-

tissement à capital variable) Mellinckrodt 1 wurde die

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre auf Beschluss des Verwaltungsrates vertagt und findet nunmehr am <i>7. Juli 2011 um 11.00 Uhr am Sitz

der Gesellschaft, 1C, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach, statt.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr zum 31. Dezember 2010.

3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres

2012.

6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2012.
7. Verschiedenes.

66540

L

U X E M B O U R G

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden

oder die Anteile bis spätestens zum 1. Juli 2011 bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die
Sperrung der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Munsbach, im Juni 2011.

<i>Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011083010/2501/25.

Private Equity Portfolio 2007 ITM S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque,

(anc. Private Equity Portfolio 2007 S.C.A., SICAR).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 123.672.

Im Jahre zweitausend und elf, den 22. Februar.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, sind die Aktionäre der Private

Equity Portfolio 2007 S.C.A., SICAR (die "Gesellschaft") mit Sitz in 18, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, einge-
tragen im Handelsregister Luxemburgs unter der Nummer B 123672, zu einer außerordentlichen Generalversammlung
(die „Außerordentliche Generalversammlung“) zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde am 21. Dezember 2006 gemäß notarieller Urkunde von dem Notar Maître Joseph Elvinger,

ansässig in Luxemburg, gegründet. Die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 66 vom 29. Januar 2007 veröffentlicht. Die Satzung wurde das letzte Mal am 23. April 2008 gemäß notarieller
Urkunde des unterzeichnenden Notars geändert, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer
1255 vom 23. Mai 2008 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um 11.30 Uhr unter dem Vorsitz von Julia Blunck, Rechtsanwältin, ansässig in Luxemburg,

eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zum Sekretär Jennifer Burr Juristin, ansässig in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Marcel Bartnik, Rechtsanwalt, ansässig in Luxemburg.
Die Vorsitzende ersucht den Notar Folgendes zu beurkunden:
I. Die persönlich anwesenden Aktionäre oder deren bevollmächtigten Vertreter, sowie die jeweilige Anzahl der Aktien

gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären oder deren bevollmächtigten Vertre-
tern, dem Vorsitzenden, dem Sekretär und dem Stimmzähler, sowie dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Die
Anwesenheitsliste und die von den bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar "ne varietur" gezeichneten
Vollmachten bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen registriert zu werden.

II. Für die in der Tagesordnung vorgesehene Satzungsänderung wird gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10.

August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner letztgültigen Fassung; ein Anwesenheitsquorum von 50% des Gesell-
schaftskapitals gefordert; die Beschlüsse sind entsprechend der Tagesordnung mit einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen
Stimmen zu fassen.

III. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1.  Umsetzung  der  Verschmelzung  des  bisherigen  Komplementärs  der  Gesellschaft,  „Private  Equity  Portfolio  2007

Coordination S.à r.l.“, mit der „Institutional Trust Management Company S.à r.l.“ sowie die hieraus resultierende Be-
zeichnungsänderung  der  Gesellschaft  und  der  Änderung  des  Komplementärs  der  Gesellschaft,  sowie  entsprechende
Anpassung der jeweiligen Artikel der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) wie nachstehendaufgeführt.

2. Einführung der Möglichkeit der Bildung von verschiedenen Teilvermögen innerhalb der Gesellschaft, die im Verhältnis

der Aktionäre untereinander als eigenständiges Vermögen mit spezifischen Vermögensmassen, einer jeweils spezifischen
Anlagepolitik und ggfs. sonstiger unterschiedlicher spezifischer Merkmale (z.B. eine unbestimmte oder bestimmte Laufzeit,
unterschiedliche Ausschüttungsmodalitäten, Währung) gelten.

3. Anpassung der Satzung an Neuerungen in der Verwaltungspraxis der Aufsichtsbehörde und an das Gesetz vom 24.

Oktober 2008 (das „SICAR Änderungsgesetz“) sowie die aktuellste Fassung des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915“) und Korrektur redaktioneller Ungenauigkeiten.

4. Als Folge der vorhergehenden Tagesordnungspunkte, Änderung im Wesentlichen der folgenden Artikel der Satzung

im Rahmen einer kompletten Neufassung der gesamten Satzung, ohne Änderung des Gesellschaftszwecks:

- Artikel 1 Absatz 1 (Name): Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft (aufgrund des Komplementärwechsels).
- Artikel 2 Absatz 2 (Gesellschaftssitz): Streichung des Begriffs "sozialer Ereignisse" mangels Definition.
- Artikel 3 (Dauer): Änderung der Laufzeit der Gesellschaft.
- Artikel 5 (Haftung): Änderung des Komplementärs der Gesellschaft.
- Artikel 6 (Bestimmung der Anlageziele sowie der Anlagepolitik): Zusammenfassung von Artikel 6 und dem bisherigen

Artikel 19 (Anlageziele, Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen), wegen Inhaltsgleichheit.

66541

L

U X E M B O U R G

-  Artikel  7  (Kapital):  Anpassung  des  Artikels  an  das  SICAR-Änderungsgesetz  (Mindestkapital)  und  Einfügung  einer

Beschreibung der Teilvermögen.

- Artikel 8 (Aktien und Aktienzertifikate): Sprachliche Anpassung des Artikels wegen Einführung der Teilvermögen und

Präzisierung, dass Aktien der Gesellschaft nur an sachkundige Anleger übertragen werden können.

- Artikel 10 (Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien): Streichung des Satzes „oder den Interessen der Gesell-

schaft in einer anderen Art und Weise schadet“ mangels Definition, sowie Präzisierung zur Beschränkung der Eigen-
tumsrechte und Präzisierung des Rücknahmepreises im Falle eines Zwangsrückkaufs.

- Artikel 11 (Ausgabe von Aktien): Sprachliche Präzisierung.
- Artikel 12 (Verzug): Präzisierung des Rücknahmepreises und der Vorgehensweise im Falle eines Nettoinventarwerts

von Null.

- Artikel 13 (Rücknahme von Aktien): Präzisierung des Rücknahmepreises und der Vorgehensweise im Falle eines

Nettoinventarwerts von Null, Einführung von Regelungen zum Umtausch von Aktien verschiedener Teilvermögen und
Streichung des Satzes „oder den Interessen der Gesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet“ mangels Definition.

- Artikel 14 (Berechnung des Nettovermögenswerts): Ausdrückliche Nennung der Referenzwährung, Einfügung einer

Beschreibung der Teilvermögen, Präzisierung der Bewertungsregeln und Anpassung an das SICAR-Änderungsgesetz.

- Artikel 15 (Verwaltung der Vermögenswerte): Streichung des Artikels, da die bisherigen Investmentprogramme durch

Teilvermögen ersetzt werden.

- Neuer Artikel 15 / Bisheriger Artikel 16 (Aussetzung der Nettovermögenswertberechnung): Einführung der Mö-

glichkeit bei Versagen technischer Einrichtungen die Berechnung des Nettovermögenswertes auszusetzen und Streichung
des Begriffs „aus irgendeinem Grund“ mangels Definition.

- Neuer Artikel 16 / Bisheriger Artikel 17 (Komplementär): Änderung des Komplementärs und Einfügung einer Re-

gelung zum Wechsel/ zur Abberufung des Komplementärs.

- Neuer Artikel 17 / Bisheriger Artikel 18 (Befugnisse des Komplementärs): Korrektur redaktioneller Ungenauigkeiten

und Präzisierung hinsichtlich der Personen, an die der Komplementär die tägliche Geschäftsführung sowie die Ausführung
der täglichen Anlagepolitik übertragen kann.

- Bisheriger Artikel 19 (Anlageziele, Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen): Streichung des Artikels wegen Inhalts-

gleichheit zu Artikel 6.

- Neuer Artikel 21 / Bisheriger Artikel 23 (Hauptversammlung): Anpassung der Einberufungsmöglichkeit von Haupt-

versammlungen durch die Aktionäre an das Gesetz von 1915 und Erläuterung des Vorgehens bei Aufgabe des Status der
Gesellschaft als SICAR.

- Einfügung eines neuen Artikel 22 (Hauptversammlung der Aktionäre in einem Teilvermögen oder einer Aktienklasse):

Einführung von Hauptversammlungen pro Teilvermögen/Aktienklasse.

- Neuer Artikel 23 / Bisheriger Artikel 24 (Geschäftsjahr): Präzisierung des Beginnes und des Ende des Geschäftsjahres.
- Neuer Artikel 24 / Bisheriger Artikel 25 (Jahresbericht): Präzisierung radaktioneller Ungenauigkeiten.
- Neuer Artikel 26 / Bisheriger Artikel 27 (Ausschüttungen): Streichung des Betrags des Mindestkapitals und Verweis

in dieser Hinsicht auf Artikel 7 (a) der Satzung.

- Neuer Artikel 27 / Bisheriger Artikel 28 (Auflösung und Liquidation der Gesellschaft): Präzisierung redaktioneller

Ungenauigkeiten und Einfügung einer Regelung zum Wechsel/ zur Abberufung des Komplementärs.

- Einfügung eines neuen Artikel 28 (Auflösung und Verschmelzung von Teilvermögen): Einfügung von Vorschriften zur

Auflösung und Verschmelzung von Teilvermögen.

- Einfügung eines neuen Artikel 29 (Interessenwahrung/Interessenkonflikte): Einfügung einer Vorschrift im Hinblick auf

die Interessenwahrung und Interessenkonflikte.

IV. Da das gesamte Gesellschaftskapital anwesend bzw. vertreten ist und sämtliche persönlich anwesenden Aktionäre

oder deren bevollmächtigten Vertreter erklären, bereits vor der außerordentlichen Generalversammlung Kenntnis von
der Tagesordnung gehabt zu haben, war die Versendung einer offiziellen Einladung zu der Außerordentlichen General-
versammlung entbehrlich.

V. Dementsprechend ist die gegenwärtige Außerordentliche Generalversammlung beschlussfähig und kann über die

Tagesordnungspunkte entscheiden.

Nach Beratung fasst die Außerordentliche Generalversammlung folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, die Verschmelzung des bisherigen Komplementärs der Ge-

sellschaft „Private Equity Portfolio 2007 Coordination S.à r.l.“ mit der „Institutional Trust Management Company S.à r.l.“
sowie die hieraus resultierende Bezeichnungsänderung der Gesellschaft und der Änderung des Komplementärs umzuse-
tzen und die dementsprechenden Artikel der Satzung im Rahmen einer Neufassung der Satzung zu aktualisieren.

66542

L

U X E M B O U R G

<i>Zweiter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, die Möglichkeit der Bildung von verschiedenen Teilvermögen

innerhalb der Gesellschaft, die im Verhältnis der Aktionäre untereinander als eigenständiges Vermögen mit spezifischen
Vermögensmassen, einer jeweils spezifischen Anlagepolitik und ggfs. sonstiger unterschiedlicher spezifischer Merkmale
(z.B. eine unbestimmte oder bestimmte Laufzeit, unterschiedliche Ausschüttungsmodalitäten, Währung) gelten, einzu-
führen.

<i>Dritter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, die Satzung an Neuerungen in der Verwaltungspraxis der Auf-

sichtsbehörde und an das SICAR-Änderungsgesetz sowie die aktuellste Fassung des Gesetzes von 1915 anzupassen sowie
redaktionelle Ungenauigkeiten zu korrigieren.

<i>Vierter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, als Folge der vorhergehenden Beschlüsse, die entsprechenden

Artikel  der  Satzung  im  Rahmen  einer  kompletten  Neufassung  der  gesamten  Satzung  einzuführen,  ohne  den  Gesell-
schaftszweck zu ändern.

Die neugefasste Satzung lautet wie folgt:
Private Equity Portfolio 2007 - ITM S.C.A., SICAR
Geänderte Satzung vom 22. Februar 2011

Art. 1. Name. Hiermit wird zwischen vorbenannten Parteien und denjenigen, die in Zukunft Inhaber auszugebender

Aktien (die „Aktien“) werden, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KgaA) in der Form einer Investmentgesellschaft
zur Anlage in Risikokapital (société d‘investissement en capital à risque, SICAR) unter dem Namen Private Equity Portfolio
2007 - ITM S.C.A., SICAR (die „Gesellschaft“) gegründet.

Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital.

Art. 2. Gesellschaftssitz.  Der  Sitz  der  Gesellschaft  befindet  sich  in  Luxemburg-Stadt,  Großherzogtum  Luxemburg.

Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder sonstige Büros können durch Beschluss des Komplementärs sowohl
im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden. Innerhalb ein und derselben Gemeinde kann der
Sitz durch einfachen Beschluss des Komplementärs verlegt werden.

Sollten nach Ansicht des Komplementärs außergewöhnliche politische oder wirtschaftliche Ereignisse vorliegen oder

bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die ungestörte Kommunikation
zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigen, so kann bis zur vollständigen Behebung dieser ungewöhnlichen
Umstände der Sitz zeitweilig ins Ausland verlegt werden; diese provisorische Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung
auf die Zugehörigkeit der Gesellschaft zu Luxemburg; letztere bleibt ungeachtet einer solchen zeitweiligen Sitzverlegung
eine Luxemburger Gesellschaft.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 4. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft ist die Anlage der ihr zur Verfügung stehenden Gelder in

Risikokapital im weitesten Sinne von Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage
in Risikokapital.

Die Gesellschaft kann die ihr zur Verfügung stehenden Gelder auch in andere gesetzlich zulässige und im Einklang mit

der Satzung stehenden Vermögenswerten anlegen.

Überdies kann die Gesellschaft solche Maßnahmen ergreifen und solche Geschäfte durchführen, die sie für die Erfüllung

und Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks für angebracht erachtet und die im Sinne des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über
die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital in seiner weitesten Auslegungs-möglichkeit zulässig sind.

Art. 5. Haftung. Die Institutional Trust Management Company S.à r.l. ist Komplementär der Gesellschaft (der „Kom-

plementär“).  Als  solches  ist  er  Geschäftsführer  (gérant)  und  Aktionär  der  Gesellschaft.  Er  hält  eine  Aktie  -  die
„Komplementärsaktie“ -, die nicht übertragbar ist und weder zu Dividendenzahlungen noch zu Kapitalrückführungen
berechtigt. Der Komplementär haftet persönlich und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die nicht
aus deren Vermögen bezahlt werden können.

Die Kommanditaktionäre (im Folgenden die „Aktionäre“) haben keinerlei Vertretungsbefugnisse im Zusammenhang

mit der Gesellschaft. Einzig im Rahmen der Hauptversammlung können die Aktionäre ihre Aktionärsrechte ausüben. Sie
haften Dritten gegenüber nur in der Höhe ihrer Einlage.

Art. 6. Bestimmung der Anlageziele sowie der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen. Im Einklang mit dem Inhalt

des Verkaufsprospektes und den Bestimmungen vorliegend anwendbarer Gesetze und Rechtsvorschriften bestimmt der
Komplementär nach Gründung der Gesellschaft (bzw. einzelner Teilvermögen) durch Beschluss sowohl die Anlageziele,
die Anlagepolitik und die Anlagebeschränkungen derselbigen, als auch die Art und Weise der diesbezüglichen Geschäfts-
führung und Geschäftstätigkeiten.

66543

L

U X E M B O U R G

Der Komplementär kann die Anlageziele, die Anlagepolitik oder die Anlagebeschränkungen der Gesellschaft (bzw.

einzelner Teilvermögen) nur mit Zustimmung sämtlicher Aktionäre der Gesellschaft (bzw. des jeweiligen Teilvermögens)
und im Wege der Beschlussfassung ändern. Das vorbenannte Zustimmungsverfahren wird im Verkaufsprospekt benannt
und näher beschrieben.

Art. 7. Kapital.
(a) Das Kapital der Gesellschaft wird durch Aktien ohne Nennwert verkörpert und entspricht zu jeder Zeit dem

Gesamtwert des Nettovermögens der Gesellschaft gemäß Artikel 14 dieser Satzung. Das gezeichnete Mindestkapital der
Gesellschaft, erhöht um den Ausgabeaufschlag, liegt gemäß den gesetzlichen Vorschriften bei einer Million Euro (EUR
1.000.000,-), und ist innerhalb von zwölf (12) Monaten nach Zulassung der Gesellschaft als Investmentgesellschaft zur
Anlage in Risikokapital gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts zu erreichen.

(b) Das Gründungskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist in 30 Komman-

ditaktien ohne Nennwert und 1 Aktie, die durch den Komplementär gehalten wird, eingeteilt. Bei der Gesellschaftsgrün-
dung wurden die Aktien vollständig eingezahlt.

(c) Der Komplementär kann im Einklang mit den Bestimmungen und entsprechend den Anforderungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften sowie des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft
zur Anlage in Risikokapital jederzeit beschließen, dass die Aktien der Gesellschaft verschiedenen zu errichtenden Anla-
gevermögen (die „Teilvermögen“) angehören, welche wiederum in unterschiedlichen Währungen notiert sein können.
Jedes  Teilvermögen  gilt  als  im  Verhältnis  der  Aktionäre  untereinander  als  eigenständiges  Vermögen  mit  spezifischen
Vermögensmassen, einer jeweils spezifischen Anlagepolitik und ggfs. Sonstiger unterschiedlicher spezifischer Merkmale
(z.B. eine unbestimmte oder bestimmte Laufzeit, unterschiedliche Ausschüttungsmodalitäten, Währung). Zu den Einzel-
heiten wird auf den Verkaufsprospekt und die dortige Beschreibung der jeweiligen Teilvermögen verwiesen. Die Rechte
und Pflichten der Aktionäre eines Teilvermögens sind von denen der anderen Aktionäre getrennt. Im Verhältnis zu Dritten
haften die Vermögenswerte eines Teilvermögens lediglich für solche Verbindlichkeiten, die diesem Teilvermögen zu-
zuordnen sind. Der Komplementär kann ausserdem bestimmen, dass innerhalb eines Teilvermögens eine oder mehrere
Aktienklassen mit unterschiedlichen Merkmalen ausgegeben werden. Deren Merkmale, Modalitäten und Bedingungen
werden durch den Komplementär bestimmt und in den Verkaufsprospekt mit aufgenommen.

(d) Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit der Gesamtheit des Nettovermögens der Gesellschaft. Das Ge-

sellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch die Gesellschaft oder des Rückkaufs von Aktien
durch die Gesellschaft erhöhen oder vermindern.

Art. 8. Aktien und Aktienzertifikate. Die Kommanditaktien (nachfolgend die „Aktien“) sind ausschließlich sachkundigen

Anlegern im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risiko-
kapital vorbehalten.

Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.
Für die Aktien wird ein Aktionärsregister am Firmensitz der Gesellschaft geführt. Dieses Register enthält den Namen

eines jeden Aktionärs, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien an der Gesellschaft bzw. den
jeweiligen Teilvermögen sowie ggf. das Datum der Übertragung jeder Aktie. Die Eintragung im Aktionärsregister wird
durch eine oder mehrere vom Komplementär bestimmte Person(en) unterzeichnet.

Aktienzertifikate zu Aktien werden lediglich auf Antrag und Kosten des Aktionärs ausgestellt. Es wird dem Aktionär

jedoch immer eine Bestätigung der Eintragung im Aktionärsregister zugestellt. Beantragte Aktienzertifikate werden binnen
eines Monats nach Zeichnung ausgestellt, vorausgesetzt, dass alle Zahlungen der gezeichneten Aktien eingegangen sind.
Aktienzertifikate werden durch zwei vom Komplementär bestimmte und bevollmächtigte Personen unterzeichnet.

Falls ein Aktionär Aktien der Gesellschaft nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so

muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Anleger im Sinne des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentge-
sellschaft zur Anlage in Risikokapital sein.

Die Übertragung einer Aktie wird durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die in das Aktionärsregister einge-

tragen,  datiert  und  durch  den  Käufer,  den  Veräußerer  oder  durch  sonstige  hierzu  vertretungsberechtigte  Personen
unterschrieben wird, sowie durch Einreichung des Aktienzertifikates, falls ausgegeben, durchgeführt. Die Gesellschaft
kann auch andere Urkunden akzeptieren, die in ausreichender Weise die Übertragung belegen.

Aktien der Gesellschaft können nur an sachkundige Anleger im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2004 übertragen

werden, sofern der jeweilige Erwerber voll und ganz die restlichen Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft übernimmt.

Werden Aktien an der Gesellschaft jedoch im Sicherungsvermögen eines deutschen Versicherungsunternehmens ge-

führt, darf das betreffende Versicherungsunternehmen über diese Aktien nur bei vorheriger schriftlicher Zustimmung des
gemäß § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes („VAG“) bestellten Treuhänders für das Sicherungsvermögen
oder  seines  Stellvertreters  verfügen,  oder  (im  Falle  von  Niederlassungen  von  Versicherungsunternehmen  mit  Sitz
außerhalb des EWR) gemäß § 110 VAG nur mit Zustimmung der zuständigen deutschen Aufsichtsbehörde.

Jeder  Inhaber  von  Aktien  muss  der  Gesellschaft  seine  Adresse  zwecks  Eintragung  im  Aktionärsregister  mitteilen.

Weicht diese von der Adresse seiner Administration ab, kann er zusätzlich eine Versandadresse benennen. Alle Mittei-
lungen  und  Ankündigungen  der  Gesellschaft  zugunsten  von  Inhabern  von  Aktien  können  rechtsverbindlich  an  die

66544

L

U X E M B O U R G

entsprechende Adresse gesandt werden. Der Aktionär kann jederzeit schriftlich bei der Gesellschaft die Änderung seiner
Adresse im Register beantragen.

Sofern ein Aktionär keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das

Aktionärsregister eingetragen wird. Die Adresse des Aktionärs wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft sein,
bis der Aktionär der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt.

Aktien werden nur ausgegeben, nachdem die Zeichnung angenommen und die Zahlung, wie im Verkaufsprospekt näher

erläutert, eingegangen ist.

Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Aktionär pro Aktie an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes oder

eines Nießbrauchs kann die Gesellschaft die Ausübung der mit dem Aktienbesitz verbundenen Reche bis zu dem Zeitpunkt
suspendieren,  zu  dem  eine  Person  angegeben  wird,  die  die  gemeinschaftlichen  Besitzer  oder  die  Begünstigten  und
Nießbraucher gegenüber der Gesellschaft vertritt. Sofern eine Einigung auf einen solchen Stellvertreter nicht innerhalb
von 2 Monaten gelingt, gilt die im Alphabet zuerst genannte Person automatisch als Stellvertreter gegenüber der Gesell-
schaft.

Die Gesellschaft kann Aktienbruchteile bis zur dritten Dezimalzahl ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimmrecht,

berechtigen aber zur Teilnahme an den Ausschüttungen der Gesellschaft auf einer pro rata Basis.

Art. 9. Verlust oder Zerstörung von Aktienzertifikaten. Kann ein Aktionär gegenüber der Gesellschaft in überzeugen-

der  Form  nachweisen,  dass  ein  Aktienzertifikat  über  eine  ihm  gehörende  Aktie  abhanden  gekommen  oder  zerstört
worden ist, wird die Gesellschaft auf seinen Antrag ein Ersatzzertifikat ausgeben. Diese Ausgabe unterliegt den von der
Gesellschaft aufgestellten Bedingungen, mit inbegriffen eine Entschädigung, eine Urkundenüberprüfung oder Urkunden-
forderung,  die  durch  eine  Bank,  einen  Börsenmakler  oder  eine  andere  Partei  zur  Zufriedenheit  der  Gesellschaft
unterschrieben sein muss. Mit der Ausgabe eines neuen Aktienzertifikates, auf dem vermerkt ist, dass es sich um ein
Duplikat handelt, verliert das Originalzertifikat jede Gültigkeit.

Verstümmelte oder beschädigte Aktienzertifikate können durch die Gesellschaft gegen neue Aktienzertifikate ausge-

tauscht werden. Die verstümmelten oder beschädigten Aktienzertifikate sind an die Gesellschaft zurückzugeben und
werden von derselben sofort für ungültig erklärt.

Die Gesellschaft ist nach eigenem Ermessen berechtigt, vom Aktionär Ersatz in angemessener Höhe für solche Kosten

zu verlangen, die durch die Ausgabe und Eintragung eines neuen Aktienzertifikates oder durch die Annullierung und
Zerstörung des Originalaktienzertifikates entstanden sind.

Art. 10. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien. Aktien an der Gesellschaft sind sachkundigen Anlegern im Sinne

des Artikels 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital vorbehalten.
Des weiteren wird die Gesellschaft nach eigenem Ermessen den Besitz ihrer Aktien durch bestimmte Anleger einschrän-
ken oder verbieten, wenn sie der Ansicht ist, dass ein solcher Besitz:

- zu Lasten der Interessen der übrigen Aktieninhaber oder der Gesellschaft geht; oder
- einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; oder
- bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird.
Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft:
(a) die Ausgabe von Aktien verweigern, wenn es offenkundig ist, dass diese Ausgabe zur Folge haben würde, den

Aktienbesitz auf eine andere Person zu übertragen, die nicht berechtigt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen,

(b) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer Person, der es nicht erlaubt ist,

Aktien der Gesellschaft zu besitzen (wie etwa Personen, welche keine sachkundigen Anleger im Sinne des Gesetzes vom
15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital darstellen), entweder allein oder zusammen mit
anderen Personen gehalten werden,

(c) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer oder mehreren Personen zu einem

solchen Anteil gehalten werden, der die Anwendbarkeit der Steuergesetze oder sonstige Gesetze anderer Länder als
Luxemburg zur Folge hat,

(d) bei Aktionärsversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, das Stimm-

recht aberkennen. In den Fällen b) und c) wird folgendes Verfahren angewandt:

i. Die Gesellschaft wird dem Aktionär, der die Aktien besitzt, eine Benachrichtigung (im Folgenden „Rückkaufsbena-

chrichtigung“ genannt) zusenden. Die Rückkaufsbenachrichtigung gibt die zurückzukaufenden Aktien, den zu bezahlenden
Rückkaufspreis und den Ort, wo dieser Preis zu bezahlen ist, an. Die Rückkaufsbenachrichtigung kann dem Aktionär durch
Einschreibebrief an seine benannte Versandadresse oder an die im Aktienregister eingetragene Adresse zugesandt werden.
Der betroffene Aktionär ist verpflichtet, der Gesellschaft ohne Verzögerung das oder die Zertifikate zurückzugeben, die
die in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern. Mit Büroschluss des in der Rückkaufsbenachrich-
tigung angegebenen Tages ist der Aktionär nicht mehr Besitzer der in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien.
Die Aktienzertifikate, die die entsprechenden Aktien verkörpern, werden annulliert.

ii. Der Preis, zu dem die in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien zurückgekauft werden (im folgenden

“Rückkaufspreis“ genannt), entspricht dem zuletzt berechneten Nettovermögenswert der ausgegeben Aktien, so wie
dieser am Tag der Rückkaufsbenachrichtigung gemäß Artikel 14 der vorliegenden Satzung festgesetzt wird. Für den Fall,

66545

L

U X E M B O U R G

dass jedoch der zuletzt berechnete Nettovermögenswert bei Null Euro oder niedriger liegen sollte, wird der Rücknah-
mepreis 1 (einen) Cent pro Aktie betragen.

iii. Der Rückkaufspreis wird dem Besitzer dieser Aktien durch die Gesellschaft bei einer in Luxemburg oder anderswo

ansässigen Bank, welche in der Rückkaufsbenachrichtigung angegeben wurde, hinterlegt. Diese Bank wird den Rückkaufs-
preis dem betroffenen Aktionär gegen Rückgabe der eventuell ausgegeben Aktienzertifikate, die die in der Rückkaufsbe-
nachrichtigung  aufgeführten  Aktien  verkörpern,  auszahlen.  Nach  Hinterlegung  des  Rückkaufspreises  gemäß  diesen
Bedingungen, können Personen, die an den in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien interessiert sind, keine
Ansprüche auf diese Aktien geltend machen oder rechtliche Schritte gegen die Gesellschaft unternehmen. Hiervon aus-
genommen  ist  das  Recht  des  sich  als  rechtmäßiger  Besitzer  der  Aktien  ausweisenden  Aktionärs,  den  hinterlegten
Rückkaufspreis gegen Rückgabe des oder der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, wie zuvor erläutert, ausgezahlt
zu bekommen.

iv. Unter der Bedingung, dass die Gesellschaft in gutem Glauben ist, kann sie die ihr in diesem Artikel zugestandenen

Befugnisse auch dann ausüben, wenn nicht eindeutig nachweisbar ist, in wessen Besitz sich die Aktien befinden.

Art. 11. Ausgabe von Aktien. Die Zeichnung von Aktien kann sowohl für bestehende als auch für potentielle Aktionäre

einem  oder  mehreren  bestimmten  Zeichnungszeitpunkt(en)  oder  Zeichnungszeitra(ä)um®  unterworfen  (j®(r)  eine
„Zeichnungsperiode“) werden. Sie werden durch den Komplementär festgelegt und im Verkaufsprospekt sowohl genannt
als auch ausführlich beschrieben.

Der Ausgabepreis der Aktien ist gänzlich oder teilweise bis zum Ablauf der Zeichnungsperiode(n), auf die Weise zu

entrichten, wie sie der Komplementär bestimmt und im Verkaufsprospekt genannt und ausführlich beschrieben hat.

Der Komplementär ist berechtigt zusätzliche Zeichnungsbedingungen zu bestimmen, wie beispielsweise das Erreichen

von Mindestzeichnungsbeträgen innerhalb der Zeichnungsperiode(n), die Zahlung von Verzugszinsen oder das Bestehen
von Eigentumsbeschränkungen. Diese Bedingungen werden im Verkaufsprospekt genannt und ausführlich beschrieben.

Bestehende Aktionäre verfügen im Verhältnis zu der Anzahl ihrer Aktien und im Verhältnis zu neuen Aktionären, über

ein Vorrecht zur Zeichnung neu ausgegebener Aktien.

Der Komplementär kann jedem Mitglied der Geschäftsleitung, jedem Direktor oder Generalbevollmächtigten sowie

jedem anderen ordnungsgemäß hierzu Ermächtigten die Aufgabe übertragen, Zeichnungsanträge auf den Aktienpreis neu
auszugebender Aktien entgegenzunehmen, sowie die Aktien an die entsprechenden Zeichner auszuliefern.

Die Gesellschaft kann, im Einklang mit den gesetzlichen Bedingungen des Luxemburger Rechts, welche insbesondere

ein Bewertungsgutachten durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zwingend vorsehen, Aktien gegen Lieferung von
Wertpapieren ausgeben, unter der Bedingung, dass diese Wertpapiere der Anlageziel- und -strategie der Gesellschaft
entsprechen.  Sämtliche  Gebühren  und  Kosten  im  Zusammenhang  mit  der  Ausgabe  von  Aktien  gegen  Lieferung  von
Wertpapieren sind von den betreffenden Aktionären zu tragen.

Der Komplementär behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder je-

derzeit, ohne vorherige Mitteilung, die Ausgabe von Aktien auszusetzen. Der Komplementär kann die Häufigkeit der
Aktienausgabe limitieren.

Art. 12. Verzug. Leistet ein Aktionär die Zahlung einer Rate nicht bei der im Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher

bestimmten Fälligkeit, kommt er ohne das Erfordernis einer Mahnung ab Fälligkeit in Verzug. Unbeschadet sonstiger
gesetzlicher Rechtsfolgen schuldet der säumige Aktionär für die Dauer des Verzugs Verzugszinsen wie sie im Verkaufs-
prospekt näher beschrieben sind.

Leistet ein Aktionär auf eine nach Eintritt des Verzuges abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung innerhalb einer

Frist von 4 Wochen nach Zustellung dieser Aufforderung nicht den rückständigen Betrag zuzüglich aufgelaufener Ver-
zugszinsen,  können  die  Aktien  durch  schriftliche  Erklärung  des  Komplementärs  eingezogen  werden  In  diesem  Falle
schuldet die Gesellschaft als Abfindung 50% des zuletzt berechneten Nettovermögenswertes der bis dahin geleisteten
Zahlungen, gemindert um bereits erfolgte Ausschüttungen. Für den Fall, dass jedoch der zuletzt berechneten Nettover-
mögenswert bei Null Euro oder niedriger liegen sollte, gilt diesbezüglich das in Artikel 13 dieser Satzung für zwangsweise
Rücknahmen Geregelte entsprechend. Die Abfindung reduziert sich um einen etwaigen weitergehenden Schaden der
Gesellschaft, z. B. aus eingetretenem Verzug der Gesellschaft mit eingegangenen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den
Zielobjekten. Die Abfindung wird pro rata zu den von der Gesellschaft an die anderen Aktionäre vorgenommenen Aus-
schüttungen gezahlt, jedoch frühestens dann, wenn feststeht, dass kein derartiger Schaden entstanden ist. Die Abfindung
wird nicht verzinst; ein Anspruch auf die Stellung von Sicherheiten besteht nicht.

Art. 13. Rücknahme und Umtausch von Aktien. Die Rücknahme von Aktien auf einseitige Anfrage des Aktionärs ist

nicht vorgesehen.

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft des geschlossenen Typs; sie ist dementsprechend berechtigt ein einseitiges Ver-

langen des Aktionärs auf Rücknahme von Aktien zurückzuweisen.

Der Komplementär wird aber eine zwangsweise Rücknahme der Aktien eines Aktionärs beschließen, wenn er der

Ansicht ist, dass (i) der Besitz von Aktien des betreffenden Aktionärs zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre
oder der Gesellschaft bzw. eines Teilvermögens geht oder (ii) einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg
oder im Ausland mit sich ziehen kann (wie z.B., dass es sich bei dem betreffenden Aktionär nicht um einen sachkundigen

66546

L

U X E M B O U R G

Anleger handelt) oder (iii) bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxem-
burg  steuerpflichtig  wird  Der  Rücknahmepreis  entspricht  stets  dem  zuletzt  berechneten  Nettovermögenswert  des
betreffenden Teilvermögens am Tag der zwangsweisen Rücknahme. Für den Fall, dass jedoch der zuletzt berechnete
Nettovermögenswert bei Null Euro oder niedriger liegen sollte, wird der Rücknahmepreis 1 (einen) Cent pro Aktie
betragen.

Des Weiteren kann der Komplementär beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile der Gesellschaft zurückzukaufen,

um auf diese Weise den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten der Gesellschaft an die Aktionäre auszuzahlen
(sog. freiwillige Rücknahme). Die Entscheidung zum Rückkauf ist verbindlich für alle Aktionäre und gilt verhältnismäßig
(pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital der Gesellschaft. Der Rücknahmepreis entspricht stets dem zuletzt berechneten
Nettovermögenswert des betreffenden Teilvermögens am Tag der freiwilligen Rücknahme. Für den Fall, dass jedoch der
zuletzt berechneten Nettovermögenswert bei Null Euro oder niedriger liegen sollte, wird zunächst keine Rücknahme der
Aktien erfolgen. Die Aktien werden vielmehr erst nach Verkauf genügender Vermögenswerte und nach Eingang der
entsprechenden Mittel zurückgenommen, dies unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre.

Die von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien des Kapitals werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert. Der

Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig Bankarbeitstage nach dem letzten Tag der Berechnung des Rück-
nahmepreises ausbezahlt.

Der Umtausch von Aktien eines Teilvermögens in Aktien eines anderen Teilvermögens ist nicht möglich.

Art. 14. Berechnung des Nettovermögenswerts. Der Nettovermögenswert pro Aktie (der „Nettovermögenswert“)

wird durch die Zentralverwaltungsstelle und unter der Verantwortung des Komplementärs an jedem Bewertun-stag -
definiert in dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft - und auf Anfrage des Aktionärs berechnet und in der Referenzwährung
der Gesellschaft, d.h. in Euro, und entsprechend den Bestimmungen des Verkaufsprospektes, ausgedrückt.

Der Nettovermögenswert pro Aktie innerhalb eines jeden Teilvermögens wird in Euro ausgedrückt und wird für jedes

Teilvermögen dadurch bestimmt, dass das Nettovermögen, d.h. die Summe der Aktiva minus der Verbindlichkeiten des
entsprechenden Teilvermögens, durch die Zahl der sich am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieses Teil-
vermögens geteilt wird. Der Nettovermögenswert der Aktie wird auf die zweite Dezimalzahl abgerundet.

Im Falle von Dividendenzahlungen, Kapitalrückführungen, Aktienausgabe- und -rückkäufen wird das Nettovermögen

jedes Teilvermögens wie folgt angepasst:

- falls eine Dividende je Aktie ausgezahlt wird oder Kapital zurückgeführt wird, verringert sich der Nettovermögens-

wert des Teilvermögens um den Betrag der Dividendenausschüttung bzw. Kapitalrückführung;

- falls Aktien ausgegeben oder zurückgekauft werden, erhöht oder vermindert sich das Nettovermögen des Teilver-

mögens um den erhaltenen oder eingezahlten Betrag.

Die Aktiva jedes Teilvermögens beinhalten:
- alle flüssigen Mittel einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
- alle ausstehenden Forderungen einschließlich Zinsforderungen auf Konten und Depots sowie Erträge aus verkauften,

aber noch nicht gelieferten Vermögenswerten;

- alle Vermögenswerte, die zugunsten eines Teilvermögens gehalten werden oder erworben wurden;
- sämtliche sonstigen Vermögenswerte einschließlich im Voraus bezahlter Ausgaben.
Die Aktiva werden gemäß Artikel 5 (3) des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in

Risikokapital  auf  Grundlage  des  nach  billigem  Ermessen  bestimmten  Wertes  bewertet.  Vornehmlich  wird  der  wahr-
scheinliche  Veräußerungswert,  der  nach  den  Grundsätzen  von  Treu  und  Glauben  zu  ermitteln  ist,  herangezogen.
Dementsprechend finden die nachfolgenden Regeln Anwendung:

- Im Rahmen der Teilvermögen wird der Wert der Anteile an Private Equity, Venture Capital und Private Equity Real

Estate Zielobjekten wird an Hand der letzten der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Berichte und gemäß den Richt-
linien der jeweiligen Private Equity oder Venture Capital Verbände bzw. Private Equity Real Estate Verbände bestimmt.
Im Zweifelsfall werden EVCA Richtlinien zugrunde gelegt.

- Die Anteile an Geldmarkt-und/oder Rentenfonds werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis

bewertet.

- Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, voraus-

bezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem
jeweiligen vollen zeitanteiligen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden
kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Anschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen
Wert zu erhalten.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Maßgabe der vorstehenden Regeln als undurch-

führbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien
konsequent anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen, dies unter Anwendung des
Marktwert-(fair value) und Vorsichtsprinzips sowie des Prinzips von Treu und Glauben.

66547

L

U X E M B O U R G

Vermögenswerte,  welche  nicht  in  Euro  (Referenzwährung)  ausgedrückt  sind,  werden  in  Euro  umgerechnet  zum

Wechselkurs am betreffenden Bewertungstag. Der Nettovermögenswert pro Aktie ist an jedem Bankarbeitstag am Sitz
der Gesellschaft erhältlich.

Die Verbindlichkeiten jedes Teilvermögens umfassen:
- sämtliche Kredite und Forderungen gegen das Teilvermögen;
- angefallene und zu zahlende Kosten (einschließlich Kosten für die zentrale Verwaltungsstelle, Beratungskosten, Kosten

für die Depotbank);

- sämtliche bekannte und definierbare gegenwärtige und zukünftige Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsverp-

flichtungen aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und festgelegte, aber noch nicht gezahlte Dividenden des Teilver-
mögens;

- vom Komplementär genehmigte und angenommene Verpflichtungen des Teilvermögens;
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten des Teilvermögens.

Art. 15. Aussetzung der Nettovermögenswertberechnung. Der Komplementär ist ermächtigt, die Berechnung des

Nettovermögenswertes der Aktien in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

- wenn aufgrund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der Gesellschaft fallen,

eine normale Verfügung über das Nettovermögen unmöglich wird, ohne die Interessen der Aktionäre schwerwiegend zu
beeinträchtigen;

- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder das Versagen technischer Einrichtungen der Wert

eines beträchtlichen Teils des Nettovermögens nicht bestimmt werden kann;

- wenn Einschränkungen des Devisen-oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung der Gesell-

schaft verhindern;

- wenn eine Hauptversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die Gesellschaft zu liquidieren.
Die Aussetzung der Berechnung der Nettovermögenswerte wird den Aktionären per Post an die im Aktionärsregister

eingetragenen Adressen mitgeteilt.

Art. 16. Komplementär. Die Gesellschaft wird von der Institutional Trust Management Company S.à r.l als Komple-

mentär geführt.

Der Komplementär ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach Luxemburger

Recht. Der Komplementär besitzt die umfassende Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, soweit das Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften oder die Satzung der Gesellschaft nicht ausdrücklich bestimmte Befugnisse der
Hauptversammlung vorbehält.

Der Komplementär ist für die Ausführung der Anlagepolitik der Gesellschaft umfassend verantwortlich.
Der Komplementär kann, mit Ausnahme der in Artikel 27 beschriebenen Fälle nicht durch die Hauptversammlung

abberufen und/oder ersetzt werden.

Art. 17. Befugnisse des Komplementärs. Der Komplementär verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs-

und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der im Verkaufsprospekt näher
beschriebenen Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Hauptversammlung vorbe-

halten sind, können durch den Komplementär getroffen werden.

Der Komplementär kann, unter seiner Überwachung und Verantwortung, die tägliche Geschäftsführung sowie die

Ausführung der täglichen Anlagepolitik der Gesellschaft auf eine oder mehrere, natürliche oder juristische Personen
übertragen. Diese Personen werden namentlich im Verkaufsprospekt benannt. Die Handlungs-und/oder Vertretungsbe-
fugnis,  sowie  die  Befugnis  wiederum  Unterbevollmächtigte  einzusetzen,  wird  durch  Beschluss  des  Komplementärs
festgesetzt.

Der Komplementär kann auch schriftliche oder notariell beurkundete Spezialvollmachten erteilen.
Der Komplementär kann Dienstleistungsverträge im Namen und für Rechnung der Gesellschaft abschließen.
Unbeschadet solcher Übertragungen, Bevollmächtigungen und Verträge bleibt der Komplementär für die Überwachung

der übertragenen Aufgaben verantwortlich.

Art. 18. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch den Komplementär oder

durch einen oder mehrere Bevollmächtigte, die dieser bestimmt, verpflichtet.

Art. 19. Haftung und Freistellung. Die Gesellschaft stellt den Komplementär, seine Geschäftsführer, (leitenden) An-

gestellten, Gremienmitglieder und Beauftragten (zusammen die „Freistellungsberechtigten“) voll umfänglich von jeder
Haftung frei, die den Freistellungsberechtigten aus ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft erwachsen können. Die Freistellung
umfasst  auch  die  Kosten  der  Rechtsverfolgung  und  Rechtsverteidigung.  Die  Freistellung  hat  auf  erstes  Anfordern  zu
erfolgen. Ein Anspruch auf Freistellung ist hinsichtlich des Komplementärs ausgeschlossen, wenn dieser vorsätzlich oder
fahrlässig und hinsichtlich der übrigen Freistellungsberechtigten, wenn diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt
haben. Bei Meinungsverschiedenheiten darüber, ob ein Freistellungsberechtigter vorsätzlich oder (grob) fahrlässig gehan-

66548

L

U X E M B O U R G

delt  hat,  hat  der  Freistellungsberechtigte  Anspruch  auf  Freistellung  bis  zur  rechtskräftigen  Entscheidung  über  die
Meinungsverschiedenheit; wird Vorsatz oder (grobe) Fahrlässigkeit festgestellt, hat der betreffende Freistellungsberech-
tigte die empfangenen Leistungen zurückzugewähren.

Die Gesellschafter der Gesellschaft haften für diese Freistellungsverpflichtung bis zur Höhe der von der Gesellschaft

empfangenen Ausschüttungen.

Art. 20. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer

Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor„(die "Depotbank") abschließen.

Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies gemäß den anwendbaren

gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist.

Sowohl die Depotbank als auch die Gesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit

dem Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der Komplementär alle Anstrengungen unternehmen, um inne-
rhalb  von  zwei  Monaten  mit  Genehmigung  der  zuständigen  Aufsichtsbehörde  eine  andere  Bank  zur  Depotbank  zu
bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Ak-
tionäre ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

Art. 21. Hauptversammlung. Die Hauptversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Sie

hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen,
auszuführen oder zu genehmigen. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft, unter der Voraussetzung, dass
der Komplementär diese Beschlüsse genehmigt, es sei denn vorliegende Satzung würde dieses Genehmigungserfordernis
ausdrücklich nicht verlangen.

Die Hauptversammlung tritt auf Einladung des Komplementärs zusammen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren,

zusammentreten.

Die jährliche Hauptversammlung wird jeweils am 21. Juni um 11:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen

in der Einladung angegebenen Ort abgehalten und zum ersten Mal im Jahre 2008. Ist dieser Tag ein Feiertag, findet die
Gesellschafterversammlung am ersten Bankarbeitstag vor dem 21. Juni statt.

Die Einladung zu den Hauptversammlungen enthält die Tagesordnung und wird per Einschreiben wenigstens acht Tage

vor der Hauptversammlung an jeden Aktionär und an dessen in dem Aktionärsregister eingetragene Adresse versandt.
Der Zugang der Einladung an die Aktionäre muss auf der Versammlung nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung
wird von dem Komplementär vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Versammlung auf schriftlichen

Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Komplementär jedoch eine zusätzliche Tagesordnung vor-

bereiten können.

Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die

Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Hauptversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.

Der Komplementär kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an

einer Hauptversammlung erfüllt werden müssen.

Auf der Hauptversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind

(die  Tagesordnung  wird  sämtliche  gesetzlich  erforderlichen  Vorgänge  enthalten)  sowie  Vorgänge,  welche  zu  solchen
Vorgängen gehören.

Gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts und dieser Satzung, ist jede Aktie, unabhängig von der Aktienklasse,

zu einer Stimme berechtigt.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung aufgrund schriftlicher Vollmacht durch eine andere Person, welche

kein Aktionär sein muss, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung, werden die Beschlüsse im Rahmen

der Hauptversammlung durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Soweit Beschlüsse der Hauptversammlung die Modifizierung der vorliegenden Satzung zum Gegenstand haben, bedarf

es (i) eines Anwesenheitsquorums von fünfzig Prozent (50%) des Kap-tals -falls dieses Quorum bei einer ersten Ver-
sammlung jedoch nicht erreicht wird, bedarf es bei der nachfolgenden Versammlung dieses Quorums nicht-mehr -und in
jedem Fall (ii) einer Zustimmungsmehrheit von mindestens Zwei-Dritteln (2/3) der anwesenden oder vertretenen Ak-
tionäre. Unbeschadet dessen muss ein Beschluss der Hauptversammlung, der die Aufgabe des Status der Gesellschaft als
SICAR im Sinne des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital zur Folge hat,
einstimmig von allen Aktionären gefasst und zuvor von der Commission de Surveillance du Secteur Financier genehmigt
werden.

Art. 22. Hauptversammlung der Aktionäre in einem Teilvermögen oder einer Aktienklasse. Die Aktionäre eines Teil-

vermögens  können  zu  jeder  Zeit  eine  Hauptversammlung  abhalten,  um  über  Vorgänge  zu  entscheiden,  welche
ausschließlich dieses Teilvermögen betreffen. Darüber hinaus können die Aktionäre einer Aktienklasse zu jeder Zeit
Generalversammlungen im Hinblick auf alle Fragen, welche diese Aktienklasse betreffen, abhalten. Die relevanten Bes-
timmungen in Artikel 21 sind auf solche Hauptversammlungen analog anwendbar.

66549

L

U X E M B O U R G

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts und dieser Satzung.

Aktionäre können persönlich handeln oder sich aufgrund einer Vollmacht durch eine andere Person, welche kein Aktionär
sein muss, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden Beschlüsse der Hauptversamm-

lung eines Teilvermögens oder einer Aktienklasse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre
gefasst.

Art. 23. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines

jeden Jahres.

Art. 24. Jahresbericht. Die Gesellschaft veröffentlicht ihren Jahresbericht jeweils innerhalb von drei (3) Monaten nach

Ende des entsprechenden Geschäftsjahres. Der Jahresbericht enthält gemäß Artikel 24 (2) des Gesetzes vom 15. Juni
2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital die Bilanz, die Gewinnund Verlustrechnung, einen Bericht
über die Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie alle wesentlichen Informationen, die es dem Anleger
ermöglichen, sich in vollständiger Sachkenntnis ein Urteil über die Entwicklung der Geschäftstätigkeit und Geschäftser-
gebnisse der Gesellschaft zu bilden.

Art. 25. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschafts-

prüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Hauptversammlung ernannt und von der Gesellschaft bezahlt
wird.

Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 26. Ausschüttungen.  Die  Verwendung  des  Bilanzgewinns  wird  von  der  Hauptversammlung  auf  Vorschlag  des

Komplementärs festgelegt.

Erlöse werden grundsätzlich zunächst reinvestiert und später ausgeschüttet.
Der Komplementär kann Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen beschließen. Es

bedarf keiner Beschlussfassung der Hauptversammlung.

Ausschüttungen werden in Euro zu einem Zeitpunkt ausbezahlt, wie dies der Komplementär zu gegebener Zeit bes-

timmt.

Die Zahlung von Ausschüttungen erfolgt an die Adressen der Aktionäre, die im Namensregister vermerkt sind und an

die dort ggf. hinterlegte Bankverbindung. Der Komplementär kann verschiedene Eigenkapitalkonten einrichten, um die
steuerliche Klassifizierung der Ausschüttungen nach deutschem Recht widerspiegeln zu können. Um diesen Zweck zu
erreichen, kann er Regeln definieren, die z.B. bei jeder Ausschüttung und/oder Zwischenausschüttung festlegen, welches
Konto jeweils angesprochen werden soll.

Der Komplementär kann unbare Ausschüttungen an der Stelle von Barausschüttungen innerhalb der Voraussetzungen

und Bedingungen, wie sie vom Komplementär festgelegt werden, beschließen.

Ferner kann der Komplementär im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und nach freiem Ermessen jederzeit

Kapitalrückführungen beschließen.

Bei der Vornahme von Ausschüttungen ist zu beachten, dass das Kapital der Gesellschaft keinesfalls den in Artikel 7

(a) dieser Satzung genannten Betrag unterschreiten darf.

Art. 27. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Haupt-

versammlung und vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse, wie sie für Satzungsänderungen gemäß
dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften gelten, aufgelöst und liquidiert werden.

Eine automatische Auflösung und anschliessende Liquidation der Gesellschaft erfolgt für den Fall, dass die Rechtsfä-

higkeit des Komplementärs endet, der Komplementär liquidiert wird oder sich eine andere Situation ereignet, die ihn
daran hindert, die Gesellschaft zu führen und nach außen zu vertreten (z.B. ein Insolvenzverfahren eröffnet wird), es sei
denn die Hauptversammlung bestellt einen neuen Komplementär unter Einhaltung des für Satzungsänderungen vorgese-
henen Anwesenheitsquorums und Zustimmungserfordernisses, wie sie in Artikel 21 dieser Satzung beschrieben sind. Ein
Zustimmungserfordernis des Komplementärs besteht in diesem Zusammenhang nicht.

Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen

sein können und die ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt und von der Hauptversammlung ernannt wer-
den müssen. Letztere beschließt auch über die Befugnisse und eventuelle Vergütung der Liquidatoren.

Der Netto-Liquidationserlös der Gesellschaft wird von den Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem

Aktienbesitz an der Gesellschaft verteilt.

Wird die Gesellschaft liquidiert, so erfolgt die Liquidation in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.

Diese Bestimmungen spezifizieren die Schritte, die unternommen werden müssen, um die Aktionäre an der Verteilung
der Liquidationserlöse teilhaben zu lassen und sehen die Hinterlegung bei der Caisse de Consignation für alle Beträge,
die bei Abschluss der Liquidation von den Aktionären nicht eingefordert wurden, vor. Beträge, die dort innerhalb der
gesetzlichen Fristen nicht eingefordert werden, verfallen gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts.

Art. 28. Auflösung und Verschmelzung von Teilvermögen. Der Komplementär kann beschliessen, ein oder mehrere

Teilvermögen zusammenzulegen, oder einen oder mehrere Teilvermögen aufzulösen, indem die betroffenen Aktien ent-

66550

L

U X E M B O U R G

wertet werden und den betroffenen Aktionären der Nettovermögenswert der Aktien dieses oder dieser Teilvermögen
zurückerstattet wird. Sofern jedoch die Gesellschaft nur (noch) aus einem einzigen Teilvermögen bestehen sollte, be-
deutet die Auflösung und Liquidation dieses Teilvermögens die zwangsläufige Auflösung und Liquidation der Gesellschaft,
mit der Folge, dass einzig die Hauptversammlung gemäß Artikel 28 dieser Satzung befugt ist, einen Auflösungs-und Liqui-
dationsbeschluss zu fassen.

Der Komplementär ist befugt, einen der vorgenannten Beschlüsse zu fassen
- im Falle einer wesentlichen Änderung der sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Lage in den Ländern, in denen

Anlagen für das jeweilige Teilvermögen getätigt werden oder in denen die Aktien dieses Teilvermögens vertrieben werden,
oder

- sofern der Wert der Vermögenswerte des jeweiligen Teilvermögens derart fällt, dass eine wirtschaftlich effiziente

Verwaltung dieses Teilvermögens nicht mehr gewährleistet werden kann, oder

- im Rahmen einer Rationalisierung.
Der Liquidationserlös, der von einem Aktionär nach Abschluss der Liquidation nicht eingefordert wurde, wird bei der

Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt; nach 30 Jahren verfällt der Liquidationserlös.

Der Beschluss des Komplementärs, die Verschmelzung eines oder mehrerer Teilvermögen mit einem oder mehreren

anderen Teilvermögen der Gesellschaft, wird den betroffenen Aktionären mitgeteilt.

Art. 29. Interessenwahrung/Interessenskonflikte. Der Komplementär - sowie etwaige Anlageberater der Teilvermögen

 beraten bei der Auswahl von Kapitalanlagen auch andere Gesellschaften und Dachfonds mit ähnlichen Investitionskrite-
rien. Für den Fall, dass entweder (i) diese anderen Gesellschaften und Dachfonds und/oder (ii) der Komplementär, der
Initiator oder vorbenannte Anlageberater, sowie (iii) eines der Teilvermögen selbst beabsichtigen, in dasselbe Vehikel zu
investieren, kann ein Interessenskonflikt entstehen, der wie folgt zu lösen ist: Das betroffene Teilvermögen wird nur dann
investieren, wenn es dem Komplementär bzw. dem Anlageberater gelingt, im Verhältnis zu den anderen Investoren,
marktübliche Konditionen auszuhandeln. Marktüblich bedeutet in diesem Zusammenhang beispielsweise, dass die Betei-
ligungen auf Basis im Wesentlich gleicher Zeichnungs-und Vertragsunterlagen erfolgen können. Zugunsten der Teilver-
mögen bestehen keine gesonderten Absprachen über die Zuteilung von Beteiligungsmöglichkeiten

Sofern der Komplementär davon Kenntnis erhält, dass einer der Aktionäre eines Teilvermögens an einem Vehikel

unmittelbar (oder direkt) beteiligt ist, in welches dasselbe Teilvermögen wünscht zu investieren oder Ggfs. bereits in-
vestiert ist, wird der Komplementär unverzüglich eine Hauptversammlung des betroffenen Teilvermögens einberufen,
welche darüber abzustimmen hat, ob eine Investition getätigt oder nicht getätigt wird bzw. ob das Teilvermögen eine
bereits getätigte Investition behalten oder vielmehr versuchen soll, eine solche rückgängig zu machen oder sich ihrer
durch Übertragung auf Dritte oder sonstige Weise zu entledigen.

Von dieser Regelung ausgenommen sind jedoch mittelbare (oder indirekte) Beteiligungen eines Aktionärs an einem

solchen Vehikel. Diese mittelbaren (oder indirekten) Beteiligungen können dadurch entstehen, dass der betroffene Ak-
tionär  eines  Teilvermögens  gleichzeitig  auch  Aktionär  anderer  Gesellschaften  und  Dachfonds  ist,  welche  wiederum
ihrerseits in das relevante Vehikel investieren.

Art. 30. Anwendbares Recht. In dieser Satzung nicht geregelte Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft
zur Anlage in Risikokapital einschließlich der Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort ergreift, wird die Außerordentliche Gene-

ralversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung des Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. BLUNCK, J. BURR, M. BARTNIK und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mars 2011. Relation: LAC/2011/10025. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. Mai 2011.

Référence de publication: 2011064282/609.
(110071968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

DWS India, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von

Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

66551

L

U X E M B O U R G

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011076586/10.
(110084565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

DWS Shift 2017, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011076587/10.
(110084568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

DWS Shift 2016, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011076588/10.
(110084572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

DWS Shift 2015, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011076589/10.
(110084575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

DWS Dividende USA Direkt 2014, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011076590/10.
(110084576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

DB Advisors Invest, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011076591/10.
(110084577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

66552

L

U X E M B O U R G

DB Advisors Invest, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011076592/10.
(110084591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

GoldPort Stabilitätsfonds, Fonds Commun de Placement.

Le  règlement  de  gestion  de  GoldPort  Stabilitätsfonds  coordonné  au  1 

er

  .  juin  2011  a  été  déposé  au  registre  de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 . juin 2011.

DJE Investment S.A.
Signature

Référence de publication: 2011078557/11.
(110087341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Carlisle Management Company S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 144.257.

Le règlement de gestion consolidé de Luxembourg Life Fund, signé en date du 1 

er

 avril 2011 a été enregistré et déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CACEIS Bank Luxembourg
<i>Agent administratif de Luxembourg Life Fund
FRANCE COLAS / Sylvie Becker
<i>- / Deputy Manager

Référence de publication: 2011082661/14.
(110092065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.

La Rose S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 44.802.

L'an deux mille onze, le seize mai.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LA ROSE S.A., SPF" (R.C.S

Luxembourg numéro B 44.802), ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte
reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 août 1993, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations ( le «Mémorial») numéro 501 du 23 octobre 1993, et dont les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 mai 2010, publié au Mémorial
numéro

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain RENARD, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Kalliopi FOURNARI, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Elise BELEY, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

66553

L

U X E M B O U R G

II.- Il ressort de la liste de présence que les QUATRE CENT CINQUANTE (450) actions représentant l'intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social de EURO 1.066.000,- (un million soixante-six mille euros) pour le réduire de son montant

actuel de EURO 1.116.000,- (un million cent seize mille euros) à EURO 50.000,-(cinquante mille euros) par rembourse-
ment aux actionnaires sans annulation d'actions.

2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social est fixé à EURO 50.000,-(cinquante mille euros) représenté par 450 (quatre cent cinquante) actions

sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.»

3. Réduction subséquente du montant actuellement alloué à la réserve légale au montant requis par la loi de EURO

5.000 (cinq mille euros) représentant 10% du nouveau capital social et allocation du surplus de la réserve légale au compte
résultats reportés.

4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de UN MILLION SOIXANTE-SIX MILLE EUROS (EUR

1.066.000,-) pour le ramener de son montant actuel de UN MILLION CENT SEIZE MILLE EUROS (EUR 1.116.000,-) à
CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000,-) par remboursement du montant à due concurrence aux actionnaires exi-
stants au prorata de leur participation actuelle dans le capital social de la Société sans annulation d'actions.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs nécessaires au conseil d'administration de la Société pour procéder aux

écritures comptables qui s'imposent et au remboursement aux actionnaires actuels, étant entendu que ledit rembourse-
ment ne peut avoir lieu que trente (30) jours après la publication du présent acte au Mémorial C, conformément aux
dispositions de l'article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article cinq des statuts de la société pour lui donner do-

rénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 50.000,-(cinquante mille euros) représenté par 450 (quatre cent cinquante) actions

sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées».

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide ensuite de réduire le compte de la réserve légale de cent onze mille six cents euros (EUR 111.600,-)

à cinq mille euros (EUR 5.000,-) pour refléter la réduction du capital social et d'en affecter le montant au compte des
résultats reportés.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés sans nul préjudice à la somme de EUR 1.600,

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. RENARD – K. FOURNARI – E. BELEY – H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 mai 2011. Relation: LAC/2011/24085. Reçu soixante-quinze euros 75,00

EUR

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt.-

Luxembourg, le dix-sept juin de l'an deux mille onze.

Référence de publication: 2011084676/72.
(110095162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

66554

L

U X E M B O U R G

Le Lys S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 44.804.

L'an deux mille onze, le seize mai.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LE LYS S.A., SPF" (R.C.S

Luxembourg numéro B 44.804), ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte
reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 août 1993, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations ( le «Mémorial») numéro 501 du 23 octobre 1993, et dont les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 mai 2010, publié au Mémorial
numéro

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain RENARD, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Kalliopi FOURNARI, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Elise BELEY, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il ressort de la liste de présence que les QUATRE CENT CINQUANTE (450) actions représentant l'intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social de EURO 1.066.000,- (un million soixante-six mille euros) pour le réduire de son montant

actuel de EURO 1.116.000,-(un million cent seize mille euros) à EURO 50.000,- (cinquante mille euros) par rembourse-
ment aux actionnaires sans annulation d'actions.

2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social est fixé à EURO 50.000,- (cinquante mille euros) représenté par 450 (quatre cent cinquante) actions

sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.»

3. Réduction subséquente du montant actuellement alloué à la réserve légale au montant requis par la loi de EURO

5.000 (cinq mille euros) représentant 10% du nouveau capital social et allocation du surplus de la réserve légale au compte
résultats reportés.

4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de UN MILLION SOIXANTE-SIX MILLE EUROS (EUR

1.066.000,-) pour le ramener de son montant actuel de UN MILLION CENT SEIZE MILLE EUROS (EUR 1.116.000,-) à
CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000,-) par remboursement du montant à due concurrence aux actionnaires exi-
stants au prorata de leur participation actuelle dans le capital social de la Société sans annulation d'actions.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs nécessaires au conseil d'administration de la Société pour procéder aux

écritures comptables qui s'imposent et au remboursement aux actionnaires actuels, étant entendu que ledit rembourse-
ment ne peut avoir lieu que trente (30) jours après la publication du présent acte au Mémorial C, conformément aux
dispositions de l'article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article cinq des statuts de la société pour lui donner do-

rénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 50.000,-(cinquante mille euros) représenté par 450 (quatre cent cinquante) actions

sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées».

66555

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide ensuite de réduire le compte de la réserve légale de cent onze mille six cents euros (EUR 111.600,-)

à cinq mille euros (EUR 5.000,-) pour refléter la réduction du capital social et d'en affecter le montant au compte des
résultats reportés.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés sans nul préjudice à la somme de EUR 1.600,-.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé A. RENARD – K. FOURNARI – E. BELEY – H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 mai 2011. Relation: LAC/2011/24086. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le dix-sept juin de l'an deux mille onze.

Référence de publication: 2011084682/72.
(110095338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Black Tie Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Mirale Finance S.à r.l.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 157.838.

In the year two thousand eleven on the fourteenth day of June,
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "MIRALE FINANCE S. à r .l.", a "société à responsabilité

limitée", having its registered office at L-2086 Luxembourg, 412 F route d'Esch incorporated by deed enacted on 28
December 2010, published in the Memorial C number 329 on the 18 February 2011, inscribed at trade register Luxem-
bourg section B number 157838

The meeting is composed by the sole member, "Change Capital (Guernsey) II Limited", a corporation existing under

the Laws of Guernsey having its registered seat at 1 Royal Plaza, Royal Avenue, Guernsey, GY12HL, St Peter Port, Channel
Islands, here represented by Bassem Pierre Daher, professionnally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under
private seal.

Which proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the notary shall remain attached to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the

law of August 10 

th

 , 1915 on "sociétés à responsabilité limitée".

The sole shareholder has requested the undersigned Notary to take act of the resolutions taken on the bases of the

following agenda:

1. Modification of the company name to “Black Tie Luxco Sarl” and subsequent modification of Article 1 of the Articles

of Incorporation;

2. Modification of the par value of the shares and subsequent modification of Article 4 of the Articles of Incorporation;
3. Resignation of a manager and discharge;
4. Appointment of new managers as well as of the Chairman of the Board;
5. Miscellaneous.

<i>First resolution:

The sole member decides to amend the name of the Company into “Black Tie Luxco S. à r.l.” and to amend accordingly

the article 1 of the articles of incorporation.

<i>Second resolution:

The sole member, exercising the powers of the meeting, decides to amend the number and the nominal value of the

shares and to amend subsequently the article 4 of the articles of incorporation as follows:

66556

L

U X E M B O U R G

“The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented

by 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand) shares having a nominal value of EUR 0.01 (One Euro Cent)
per share. .”

<i>Third resolution:

The Sole Shareholder takes act of the resignation of Ms Antonella Graziano, as manager of the Company and gives

her full discharge for her mandate.

<i>Fourth resolution:

The Sole Shareholder appoints as new managers of the Company the following persons:

<i>Category A Manager:

- Mr. Andrew WOOD, born in Huddersfield (GB) on the 20 June 1971, with professional address at SW3 5AW London

College House, 272 King's Road (GB),

<i>Category B Managers:

- Mr. Jean-Claude BUFFIN, born in Charleroi (Belgium) on the 20 January 1961, with professional address at 412F

route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

- Mr. Philippe STANKO, born in Wittlich (Germany) on the 15 January 1977, with professional address at 412F route

d'Esch, L-2086 Luxembourg,

Mr. Andrew Wood is appointed as Chairman of the Board of Managers.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français:

L'an deux mille onze, le quatorze juin,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Mirale Finance S.

àr .l.", ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412 F route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 157838, constituée suivant acte reçu le 28 décembre 2010, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C numéro 329 du 18 février 2011.

L'assemblée est composée de l'associé unique, "Change Capital (Guernsey) II Limited", une société régie par les lois

de Guernsey ayant son siège social au 1 Royal Plaza, Royal Avenue, Guernsey, GY12HL, St Peter Port, Iles Anglo-Nor-
mandes,  ici  représentée  par  Bassem  Pierre  Daher,  demeurant  professionnellement  à  Luxembourg,  en  vertu  d'une
procuration sous seing privé qui restera ci-annexée, paraphée ne varietur.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte

pour être enregistrée en même temps.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées.

L'associé unique a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions qu'il a prises sur la base de l'ordre du

jour suivant:

1. Modification de la dénomination sociale en «Black Tie Luxco S. à r.l.» et modification subséquente de l'article 1 

er

des statuts.

2. Modification de la valeur nominale des parts et modification de l'article 4 des statuts.
3. Démission du gérant et décharge.
4. Nomination de nouveaux gérants et d'un Président du Conseil de Gérance.
5. Divers.

<i>Première résolution:

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale en «Black Tie Luxco S. à r.l.» et de modifier en conséquence

l'article 1 

er

 des statuts.

66557

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution:

L'associé unique, décide de modifier le nombre et la valeur nominale des parts et de modifier en conséquence l'article

4 des statuts:

«Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 1.250.000

(un million deux cent cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un cent d'euros) chacune.»

<i>Troisième résolution:

L'associé unique prend acte de la démission de ses fonctions de gérant de Madame Antonella Graziano, et lui consent

décharge pour l'exercice de son mandat.

<i>Quatrième résolution:

L'associé unique décide de nommer aux fonctions de gérants les personnes suivantes:

<i>Gérant de catégorie A:

- Monsieur Andrew WOOD, né à Huddersfield (GB) le 20 juin 1971, avec adresse professionnelle au SW3 5AW

London College House, 272 King's Road (GB),

<i>Gérants de catégorie B:

- Monsieur Jean-Claude BUFFIN, né à Charleroi (Belgique) le 20 janvier 1961, avec adresse professionnelle au 412F

route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

- Monsieur Philippe STANKO, né à Wittlich (Allemagne) le 15 janvier 1977, avec adresse professionnelle au 412F route

d'Esch, L-2086 Luxembourg,

Monsieur Andrew Wood est nommé Président du Conseil de Gérance.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, le mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: B. P. DAHER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 juin2011. Relation: LAC/2011/27574. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 20 juin 2011.

Référence de publication: 2011086279/116.
(110096858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Fintad International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 39.700.

Fintad Securities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 51.269.

PROJET DE FUSION

L'an deux mille onze, le six juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

Ont comparu:

1) La société à responsabilité limitée FINTAD INTERNATIONAL S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-1219

Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B39.700, représentée par son gérant actuellement en fonctions Monsieur Luigi AGARINI, ce dernier étant ici représenté
par Monsieur Vincent ALLENO, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte Neuve, en vertu d'une procuration établie à Milan initialement le 6 janvier 2010, et confirmé le 27 octobre 2010.

2) La société anonyme FINTAD SECURITIES S.A., en liquidation, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg,

23, rue Beaumont, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B51.269, repré-
sentée par son liquidateur actuellement en fonctions Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, demeurant profession-
nellement à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, comparant en personne.

66558

L

U X E M B O U R G

Lesquelles comparantes ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter les termes et conditions d'un projet

de fusion, à établir par les présentes entre les sociétés précitées par application des articles 271 (1), 278 et 279 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en la forme notariée, projet dont la teneur est la suivante:

1. Description de la fusion. La société à responsabilité limitée FINTAD INTERNATIONAL S.àr.l., détenant la totalité

des actions émises et en circulation de la société anonyme FINTAD SECURITES S.A., entend fusionner conformément
aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-
après désignée la «Loi») avec la société anonyme FINTAD SECURITES S.A., par absorption de cette dernière,

2. Modalités de la fusion. Description des sociétés qui fusionnent:
2.1 La société absorbante
La société ci-avant qualifiée FINTAD INTERNATIONAL S.àr.l., a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître

André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 février 1992, publié au Mémorial,
Série C n°350 du 14 août 1992. La Société changea de forme sociale pour adopter celle d'une société à responsabilité
limitée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire alors de résidence à Remich, en date du 22 décembre
2006, publié au Mémorial, Série C n°676 du 21 avril 2007. Les statuts furent modifiés plusieurs fois et en dernier lieu par
acte de Maître Martine Schaeffer, notaire alors de résidence à Remich, en date du 12 février 2007, publié au Mémorial C
n°679 du 23 avril 2007 (ci-après dénommée FINTAD INTERNATIONAL S.àr.l. ou la «société absorbante»).

2.2 La société absorbée
La société ci-avant qualifiée FINTAD SECURITES S.A., a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux,

alors notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, en date du 12 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 422 du 1 

er

 septembre 1995. Les statuts furent modifiés plusieurs fois et en dernier lieu par acte de Maître

André Jean Joseph Schwachtgen en date du 13 janvier 2003, publié au Mémorial C n°143 du 12 février 2003. La société
fut mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire alors de résidence à Remich, en date du
22 décembre 2006, publié au Mémorial, Série C n°340 du 9 mars 2007 (ci-après dénommée FINTAD SECURITES S.A.
ou «la société absorbée»).

La société absorbante a été constituée sous forme de société anonyme avant de changer de forme sociale pour adopter

celle d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, la société absorbée ayant été constituée et existant
sous la forme de société anonyme de droit luxembourgeois. Leur fusion est conforme à la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»), notamment par l'ajout de l'article 257.

3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme

accomplies pour le compte de la société absorbante est fixée à la date à laquelle la fusion deviendra effective.

4. Les deux sociétés n'ont pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux. De plus aucun titre autre que des actions ou

parts sociales n'est actuellement émis.

5.  Aucun  avantage  particulier  n'est  attribué  aux  membres  des  conseils  d'administration  ou  aux  commissaires  aux

comptes, respectivement au gérant de la société FINTAD INTERNATIONAL S.àr.l.

6. Information des associés. Tous les propriétaires des parts sociales de FINTAD INTERNATIONAL S.àr.l. ont le droit,

pendant un mois au moins avant que la fusion ne prenne effet entre les parties, de prendre connaissance, au siège social
de cette société, des documents indiqués à l'article 267 (1) a), b) et c) de la Loi, à savoir: le projet de fusion, les comptes
annuels ainsi que les rapports de gestion du dernier exercice clôturé au 31 mars 2011. Une copie intégrale ou, s'ils le
désirent, partielle de ces documents peut être obtenue par tout propriétaire des parts sociales sans frais et sur simple
demande.

7. Un ou plusieurs propriétaires des parts sociales de la société absorbante disposant seul ou ensemble d'au moins 5%

(cinq pourcent) des parts sociales du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le même délai comme indiqué ci-
avant  au  point  6)  la  convocation  d'une  assemblée  générale  de  la  société  absorbante  appelée  à  se  prononcer  sur
l'approbation de la fusion. L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

8. Prise d'effet de la fusion. A défaut de convocation d'une assemblée et à défaut de rejet du projet de fusion par celle-

ci, la fusion deviendra définitive un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (la «Date Effective»), et entraînera de plein droit les effets prévus par la Loi.

9. Effets de la fusion.
9.1. Le mandat du liquidateur de la société absorbée prend fin à la Date Effective. Décharge entière est accordée au

liquidateur de la société absorbée pour tous devoirs et actes accomplis jusqu'au jour de la Date Effective.

9.2. Entre les sociétés qui fusionnent, la fusion aura effet à la Date Effective de telle manière que tous les actifs et tous

les passifs de la société absorbée seront censés être transférés à la société absorbante à cette même date.

9.2.1. La société absorbante deviendra propriétaire des biens qui lui ont été apportés par la société absorbée dans

l'état où ceux-ci se trouvent à la Date Effective sans droit de recours contre la société absorbée pour quelque raison que
ce soit.

66559

L

U X E M B O U R G

9.2.2. La société absorbante acquittera à compter de la Date Effective tous impôts, contributions, taxes et redevances,

primes d'assurance et toutes autres dettes, tant ordinaires qu'extraordinaires, qui grèveront ou pourront grever la pro-
priété des biens apportés.

9.2.3. La société absorbante exécutera tous contrats et tous engagements de quelque nature que ce soit de la société

absorbée tels que ces contrats et engagements existent à la Date Effective.

9.2.4. La société absorbante assumera toutes les obligations et dettes de quelque nature que ce soit de la société

absorbée à compter de la Date Effective.

9.2.5. Les droits et créances compris dans le patrimoine de la société absorbée sont transférés de plein droit à la

société absorbante avec toutes les garanties tant réelles que personnelles qui y sont attachées. La société absorbante sera
ainsi subrogée, sans qu'il y ait novation, dans les droits réels et personnels de la société absorbée en relation avec tous
les biens et contre tous les débiteurs sans exception.

10. Ainsi par l'effet de la fusion toutes les actions émises par la société absorbée, dissoute par résolutions d'une

assemblée générale extraordinaire de ses associés du 22 décembre 2006, seront annulées.

11. La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la

cession de tous les avoirs et obligations par la société absorbée à la société absorbante. Y sont comprises les formalités,
procédures, conditions et les publications qui sont prévues par les lois et règlements des pays étrangers dans lesquels
des biens patrimoniaux sujets à absorption sont situés. Dans toute la mesure exigée par la loi ou jugée nécessaire ou
utile, des documents de transfert appropriés seront signés par les sociétés qui fusionnent. La société absorbée apportera
par son liquidateur tout son concours en vue de réaliser le transfert des actifs et passifs transmis par elle au profit de la
société absorbante, son unique actionnaire.

12. Le coût de l'opération de fusion sera supporté par la société absorbante. La société absorbante acquittera le cas

échéant les impôts dus par la société absorbée au titre des exercices non encore imposés définitivement.

13. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal de cinq années au siège de

la société anonyme INTERCORP S.A. établie à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

<i>Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et

faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

<i>Constatation

Le notaire soussigné déclare attester de la conformité aux dispositions légales du présent projet de fusion, confor-

mément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénoms usuels, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: V. Alleno, C. Geiben et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juin 2011. LAC/2011/27470. Reçu douze euros (12,- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial; Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2011.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2011086470/117.
(110096843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

IRERE Luxembourg Self Storage, Société à responsabilité limitée,

(anc. HEAREF Luxembourg Self Storage).

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 141.111.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 21 avril 2011.

Référence de publication: 2011055765/11.
(110062698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

66560

L

U X E M B O U R G

JRS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 149.836.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2011.

Référence de publication: 2011055770/10.
(110062313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

Libra Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.558.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2011.

Référence de publication: 2011055784/10.
(110062554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

Finateam Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 81.112.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le lundi 7 mars 2011 et d'une

réunion du conseil d'administration du même jour que les modifications suivantes ont été apportées:

- Renouvellement des mandats des organes sociaux:
* Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
* Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Houbert a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
* Le mandat d'administrateur de Madame Anna Meunier De Meis a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
* Le mandat de commissaire aux comptes de la société MRM Consulting S.A a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
- Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué:
* Le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
Les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra

en 2017.

Pour extrait sincère et conforme
FINA TEAM GESTION SA
Patrick Houbert
<i>Administrateur

Référence de publication: 2011062125/23.
(110069892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 88.847.

Hewlett-Packard Luxembourg Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 79.826.

La  fusion  par  absorption  telle  qu'envisagée  entre  Hewlett-Packard  Luxembourg  Enterprises  S.à  r.l.,  une  société  à

responsabilité limitée ayant son siège social à 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.847, agissant en tant que société absorbante et Hewlett-
Packard Luxembourg Participations S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 75, Parc d'Activités,
L-8308 Capellen, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.826,

66561

L

U X E M B O U R G

agissant en tant que société absorbée, dans l'acte notarié de projet de fusion du 8 mars 2011, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du 18 mars 2011, numéro 509, a été réalisée avec effet au 19 avril 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2011.

Max Kremer.

Référence de publication: 2011056272/19.
(110062280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

LaSalle Nasu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 154.107.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 21 avril 2011.

Référence de publication: 2011056300/10.
(110063008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.210.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 27 avril 2011

Sont élus au Conseil d'Administration
- Mr Andreas Schlatter, président et membre du conseil d'administration, Gessnerallee 3-5, CH-8001 Zurich, Suisse,

jusqu'à l'assemblée générale en 2012

- Mr Tim Blackwell, membre du conseil d'administration, 44 rue Washington F-75008 Paris, France, jusqu'à l'assemblée

générale en 2012

- Mr Mario Cueni, membre du conseil d'administration, 3-5 Gessnerallee, CH-8001 Zurich, Suisse, jusqu'à l'assemblée

générale en 2012

- Mr Christian Eibel, membre du conseil d'administration, Gessnerallee 3-5, CH-8001 Zurich, Suisse, jusqu'à l'assemblée

générale en 2012

- Mr Gilbert Schintgen, membre du conseil d'administration, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxem-

bourg, jusqu'à l'assemblée générale en 2012

- Mr Martin Thommen, membre du conseil d'administration, Brunngässlein 12, CH-4052 Bâle, Suisse, jusqu'à l'assem-

blée générale en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 mai 2011.

<i>Pour: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Benjamin Wacker / Michaela Imwinkelried
<i>Associate Director / Executive Director

Référence de publication: 2011064443/27.
(110071833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

CETP II Foundry S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 159.566.

In the year two thousand and eleven, on the fourteenth of March.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-AIzette (Luxembourg).

There appeared:

- CETP II Participations S.à r.l. SICAR, a Luxembourg private limited liability company submitted to the SICAR Law

regime, having its registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, and registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 130.698 ("CETP II P"), and

- CETP II Co-Invest S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 2, Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg ("CETP II CI"),

66562

L

U X E M B O U R G

all here represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, with professional address at 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch/Alzette, by virtue of two proxies dated March 13, 2011.

The said proxies, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

I. CETP II P and CETP II CI are the sole shareholders of CETP II Foundry S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

with registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade and
Companies Register pending (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary in
Esch-sur-Alzette, dated February 24, 2011, not published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations yet,
and which articles of association have been last amended pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary in Esch-
sur-Alzette, dated March 9, 2011, not published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations yet.

II. CETP II P and CETP II CI are acting in their said capacity and representing the entire share capital of the Company.
III. The Company's share capital is fixed at seven hundred thirty-nine thousand five hundred nineteen British Pounds

(GBP 739.519,00) represented by seventy-three million nine hundred fifty-one thousand nine hundred (73.951.900) shares
of one penny of a British Pound (GBP 0,01) each.

IV. The shareholders resolve to increase the Company's share capital by an amount of ninety-five thousand six hundred

seventy-nine British Pounds (GBP 95.679,00) to bring it from its present amount of seven hundred thirty-nine thousand
five hundred nineteen British Pounds (GBP 739.519,00) to eight hundred thirty-five thousand one hundred ninety-eight
British Pounds (GBP 835.198,00) by creation and issuance of nine million five hundred sixty-seven thousand nine hundred
(9.567.900) new ordinary shares (the "New Shares"), all with a nominal value of one penny of a British Pound (GBP 0,01)
each.

V. CETP II CI declared to entirely waive its preferential right to subscribe for New Shares to the benefit of CETP II P.

<i>Intervention - Subscription - Payment

CETP II P, prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe for the nine million five hundred sixty-seven

thousand nine hundred (9.567.900) New Shares, with a nominal value of one penny of a British Pound (GBP 0,01) each,
and fully pays them up by contribution in cash in the total amount of ninety-five thousand six hundred seventy-nine British
Pounds (GBP 95.679,00), which is at the disposal of the Company.

VI. As a consequence of the above resolutions, the shareholders resolve to amend Article 6 of the articles of incor-

poration of the company which shall henceforth read as follows:

Art. 6. The share capital of the Company is fixed at eight hundred thirty-five thousand one hundred ninety-eight

British  Pounds  (GBP  835.198,00)  represented  by  eighty-three  million  five  hundred  nineteen  thousand  eight  hundred
(83.519.800) shares of one penny of a British Pound (GBP 0,01) each.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the

present deed are estimated approximately at one thousand five hundred Euro (EUR 1.500,00).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,

civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le quatorze mars
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch sur Alzette.

Ont comparu:

- CETP II Participations S.à r.l. SICAR, une société à responsabilité limitée existant sous le régime de la loi SICAR,

ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.698 ("CETP II P"), et

- CETP II Co-Invest S.à r.l.,., une société à responsabilité limitée , ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg ("CETP II CI"),

ici représentées par Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch/Alzette, en vertu de deux procurations données le 13 mars 2011.

Les procurations signées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

66563

L

U X E M B O U R G

I. CETP II P and CETP II CI sont les seuls associées de la société CETP II Foundry S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (la «Société»), constituée par acte de
Maître Francis Kesseler en date du 24 février 2011, en cours de publication au Mémorial C, Recueil de Sociétés et
Associations, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte de Maître Francis Kesseler en date du 9
mars 2011, en cours de publication au Mémorial C, Recueil de Sociétés et Associations.

II. CETP II P and CETP II CI agissent en leur qualité susmentionnée et représentent l'intégralité du capital de la Société.
III. Le capital social de la Société est fixé à sept cent trente-neuf mille cinq cent dix-neuf Livres Sterling (GBP 739.519,00)

représenté par soixante-treize million neuf cent cinquante et un mille neuf cents (73.951.900) parts sociales d'une valeur
nominale d'un centième de Livre Sterling (GBP 0,01) chacune.

IV. Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société de quatre-vingt-quinze mille six cent soixante-dix-

neuf Livres Sterling (GBP 95.679,00) afin de le porter de sa valeur actuelle sept cent trente-neuf mille cinq cent dix-neuf
Livres Sterling (GBP 739.519,00) à huit cent trente-cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit Livres Sterling (GBP 835.198,00)
par création et émission de neuf millions cinq cent soixante-sept mille neuf cents (9.567.900) nouvelles parts sociales d'un
centième de Livre Sterling (GBP 0,01) chacune (les «Nouvelles Parts»).

V. CETP II CI déclare renoncer à l'exercice de son droit préférentiel de souscrire de Nouvelles Parts au bénéfice de

CETP II P.

<i>Intervention - Souscription - Libération

CETP II P, susmentionnée, agissant par son mandataire, déclare souscrire les neuf millions cinq cent soixante-sept mille

neuf cents (9.567.900) Nouvelles Parts d'une valeur nominale d'un centième de Livre Sterling (GBP 0,01) chacune et de
les libérer entièrement par apport en numéraire d'un montant total de quatre-vingt-quinze mille six cent soixante-dix-
neuf Livres Sterling (GBP 95.679,00), lequel montant est à la disposition de la Société.

VI. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, les associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6

des statuts de la Sociétés afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à huit cent trente-cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit Livres Sterling (GBP 835.198)

représenté par quatre-vingt-trois million cinq cent dix-neuf mille huit cents (83.519.800) parts sociales d'une valeur no-
minale d'un centième de Livre Sterling (GBP 0,01 chacune).».

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison du présent acte à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500,00).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes connue du notaire par ses nom et prénom, état

et demeure, elle a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 mars 2011. Relation: EAC/2011/3591. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011056200/112.
(110063461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

Smart Holding Group S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 152.230.

In the year two thousand and eleven, on the fifteenth day of March.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of “Smart Holding Group S.A.”, a Luxembourg public

limited liability company (société anonyme) having its registered office at 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on 19 March

66564

L

U X E M B O U R G

2010, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 971 dated 8 May 2010, and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 152.230 (the “Company”).

The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address at

5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Miss Sophie HENRYON, private employee, with professional address at 5, rue

Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg and the meeting elects as scrutineer Miss Claudia
ROUCKERT, private employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-
Duchy of Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

That list and proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed hereto to be
registered with the present deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 310 (three hundred ten) shares with a nominal value of EUR 100 (one

hundred Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda, of which the shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Waiving of notice right;
2. Split and conversion of each of the shares of the Company, having a current nominal value of EUR 100 (one hundred

Euros) into 100 (one hundred) shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;

3. Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect such

action; and

4. Miscellaneous.
After approval of the above statements, the shareholders of the Company passed the following resolutions:

<i>First resolution:

The shareholders of the Company unanimously resolve to waive their right to the prior notice of the current meeting;

the  shareholders  of  the  Company  acknowledge  being  sufficiently  informed  on  the  agenda  and  consider  being  validly
convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The shareholders of the Company
further unanimously resolve that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the
shareholders of the Company within a sufficient period of time in order to allow them to carefully examine each document.

<i>Second resolution:

The shareholders of the Company unanimously resolve to split and convert each share of the Company, having a

current nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, into 100 (one hundred) shares having a nominal value EUR
1 (one Euro) each.

As a result, the share capital of the Company of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro), formerly divided into 310

(three hundred ten) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, is now composed of 31,000 (thirty-
one thousand) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

<i>Third resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, the shareholders of the Company unanimously resolve to amend the

first paragraph of article 5 of the Company’s articles of association so as to read as follows:

“ Art. 5. The Company’s share capital is set at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro), represented by the 31,000

(thirty-one thousand) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.”

No other amendment is to be made to this article.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand two hundred euro (€
1,200.-).

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.

In faith of which, we, the undersigned notary, set our hand and seal in Esch-sur-Alzette, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The documents having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

66565

L

U X E M B O U R G

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le quinzième jour du mois de mars.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire public résidant à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Smart Holding Group S.A.», une société ano-

nyme  régie  par  les  lois  du  Grand-Duché  de  Luxembourg,  ayant  son  siège  social  sis  au  24,  rue  des  Genêts,  L-1621
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence
à Junglinster, le 19 mars 2010, publié au “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” numéro 971 du 8 mai 2010,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.230 (la «Société»).

L’assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.

Le  président  a  nommé  en  qualité  de  secrétaire  Mademoiselle  Sophie  HENRYON,  employée  privée,  avec  adresse

professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg et l’assemblée a désigné
comme scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.

Le président requiert le notaire d’acter ce que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux sont indiqués sur la liste de

présence. Cette liste de présence et les procurations signées par les comparants resteront annexées au présent acte.

II.- Il émane de la liste de présence, que les 310 (trois cent dix) actions de la Société ayant une valeur nominale de 100

EUR (cent euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assem-
blée peut valablement se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour sur lesquels les actionnaires reconnaissent
expressément avoir été dûment et préalablement informés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Division et conversion de chacune des parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale actuelle de 100 EUR

(cent euro) en 100 (cent) actions, ayant une valeur nominale de 1 EUR (1 euro) chacune;

3. Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter cette action; et
4. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

Les actionnaires de la Société décident à l’unanimité de renoncer à leur droit de recevoir la convocation préalable

afférente à la présente assemblée; les actionnaires de la Société reconnaissent avoir été suffisamment informés de l’ordre
du jour et considèrent être valablement convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les
points portés à l’ordre du jour. Les actionnaires de la Société reconnaissent en outre unanimement que toute la docu-
mentation produite lors de l’assemblée a été mise à leur disposition dans un délai suffisant afin de leur permettre un
examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Les actionnaires de la Société décident à l’unanimité de diviser et convertir chacune des actions de la Société, ayant

une valeur nominale actuelle de 100 EUR (cent euro) chacune, en 100 (cent) actions ayant une valeur nominale de 1 EUR
(1 euro) chacune.

En conséquence, le capital social de la Société de 31.000 EUR (trente-et-un mille euro), précédemment divisé en 310

(trois cent dix) actions de la Société ayant une valeur nominale de 100 EUR (cent euro) chacune, est maintenant composé
de 31.000 (trente-et-un mille) actions ayant une valeur nominale de 1 EUR (1 euro) chacune.

<i>Troisième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, les actionnaires de la Société décident à l’unanimité de modifier le premier

paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000 EUR (trente-et-un mille euro), représenté par 31.000 (trente-et-un mille)

actions d’une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune.»

Aucune autre modification n’a été faite à cet article.

<i>Estimation des coûts

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge relativement au présent acte ont été estimés à environ mille deux cents euros (€ 1.200,-).

Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne souhaitant prendre la parole, l’assemblée a été clôturée.

En foi de quoi, nous, le notaire soussigné, établissons et apposons signature à Esch-sur-Alzette, à la date figurant au

commencement de ce document.

66566

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la requête des personnes comparantes ci-dessus

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes
et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Le document ayant été lu au mandataire, ladite personne signa avec nous, le Notaire, le présent acte original.
Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 mars 2011. Relation: EAC/2011/3755. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011056406/130.
(110063225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

DWS Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 160.062.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Karine REUTER
<i>Notaire

Référence de publication: 2011056556/11.
(110063097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

Rovi Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1531 Luxembourg, 6-10, rue de la Fonderie.

R.C.S. Luxembourg B 160.216.

<i>Extrait des résolutions écrites de l’associé unique de la Société datées du 27 avril 2011

L’associé unique de la Société a révoqué Monsieur Philippe Thieriot de ses fonctions de gérant de la Société avec effet

au 27 avril 2011.

L’associé unique de la Société a décidé de nommer Monsieur Rolf Hartley, dont l’adresse professionnelle se situe au

6-10, rue de la Fonderie, L-1531 Luxembourg en tant que gérant de la Société à compter du 27 avril 2011 pour une durée
indéterminée.

En conséquence de ces changements, le conseil de gérance de la Société se compose dès lors de la manière suivante:
- Mark Alloy, gérant;
- Stephen Yu, gérant; et
- Rolf Hartley, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le compte et au nom de Rovi Technologies S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2011063745/21.
(110071612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Salalah Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 132.119.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 1 

<i>er

<i> avril 2011

<i>Résolutions:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de transférer le siège social au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

66567

L

U X E M B O U R G

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011056643/14.
(110063096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

Terra Mundus Solar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 145.276.

<i>Auszug aus den Beschlüssen des Alleingesellschafters vom 5. Mai 2011

Mit Datum vom 5. Mai 2011 wurden vom Alleingesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Anzahl der Mitglieder der Geschäftsführung wird mit sofortiger Wirkung auf drei festgesetzt, davon zwei Class

A-Directors und ein Class B-Director.

2. Das Mitglied der Geschäftsführung
- Herr Robin Naudin ten Cate, Class B-Director, geschäftsansässig in 15, rue Edward Streichen, 2540 Luxemourg
wird mit sofortiger Wirkung vom Amt des Geschäftsführers abberufen.
3. Das Mandat von Herrn Reinhard Siess, geb. 15.04.1951 in D-Hamburg, geschäftsansässig in 10 Rémy Oliver Street,

Port Louis, Republic of Mauritius, als Class A-Director wird geändert zum Class B-Director mit sofortiger Wirkung und
auf unbestimmte Dauer.

4. Als neue Mitglieder der Geschäftsführung werden mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Dauer bestellt:
- Herr Volker Becker, geb. 10.07.1970 in D-Wadern, wohnhaft in Johannisstraße 4, D-66620 Nonnweiler, Deutschland,

zum Class A-Director,

- Herrn Christian Gradel, geb. 20.04.1964 in D-Gelsenkirchen-Buer, geschäftsansässig in Möhlstraße 2, D-81675 Mün-

schen, zum Class A-Director,

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 11. Mai 2011.

Für gleichlautenden Auszug
Volker Becker
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2011064612/27.
(110072469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

Nassou, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 44.221.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 7 avril 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, déclare closes par liquidation les opérations de liquidation de la société anonyme
NASSOU S.A., dont le siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, a été dénoncé en date du 17 août
2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Yuri AUFFINGER
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011056618/17.
(110063095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

66568

L

U X E M B O U R G

Ability Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 126.021.

<i>Extrait des résolutions du gérant unique

Mr Andreas PANAYIOTOU, agissant dans ses fonctions de gérant unique ("Gérant") de la Société,
assumant, conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 des statuts de la Société tous les pouvoirs attribués

au(x) gérant(s) et/ou au conseil de gérance,

décide:

2. Transfert du siège social à Luxembourg
Le Gérant décide de transférer le siège de la Société à 25 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Pour extrait conforme
Andreas PANAYIOTOU / Maître Patrick GOERGEN
<i>- / Avocat à la Cour

Référence de publication: 2011063870/21.
(110070867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

PAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 122.907.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PAP S.A.

Référence de publication: 2011057290/10.
(110064286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Pylos Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 125.877.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 avril 2011

1. CHANGEMENT DE L’ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Le siège social de la société est transféré du 48 Boulevard Grande Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg au 24

avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, et ce à compter du 15 avril 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2011057300/13.
(110064608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Residia Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 223, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 122.039.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

66569

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 27 avril 2011.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011057302/14.
(110064513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Fiduciaire Eurolux, Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 34.752.

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire et de la réunion du Conseil d’administration tenues le 11 mai 2011 à

Luxembourg que:

Les mandats d’administrateurs confiés à:
- Monsieur Alhard von KETELHODT
- Monsieur Romain ZIMMER
- La société EUROPEAN AUDIT SàRL, représentée par Monsieur Alhard von KETELHODT né le 27 mai 1961 à

Bochum (D) et domicilié professionnellement 196, rue de Beggen à L-1220 Luxembourg

ont été renouvelés pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale devant se tenir en 2017.
Monsieur Alhard von KETELHODT, né le 27 mai 1961 à Bochum (D) demeurant professionnellement au 196, rue de

Beggen à L-1220 Luxembourg a été reconduit dans ses fonctions de président du conseil d’administration et de délégué
à la gestion journalière.

Le mandat de Commissaire aux comptes confié à Mademoiselle Carla DOS SANTOS a également été reconduit pour

la même période.

Référence de publication: 2011064816/20.
(110072757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

Cacyopee Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 151.298.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2011.

L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg.
L’Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission de deux administrateurs, à savoir:
- Mademoiselle Michèle SCHMIT, administrateur, née le 23 mai 1979 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié profes-

sionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg

- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement

au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg

L’Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer deux administrateurs, à savoir:
- la société LUXGLOBAL MANAGEMENT S.à r.l avec siège social sis au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.893.

- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur de société, né le 22 mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié

professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2017.
Les administrateurs M. Claude ZIMMER et M. Marc THEISEN sont domiciliés professionnellement au 42-44, avenue

de la gare, L-1610 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.

La société Zimmer &amp; Partners S.à.r.l., commissaire aux comptes, à changer de forme juridique devenant une Société

Anonyme.

La société Zimmer &amp; Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg.

Extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011064725/27.
(110072660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

66570

L

U X E M B O U R G

Rayburn Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 112.489.

La version abrégée des comptes annules au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2011057304/12.
(110064603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

ALESRAA Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 108.197.

In the year two thousand and eleven, on the thirty-first day of the month of January.
Before Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary

residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

there appeared:

Maître Varlérie Kopéra, maître en droit, residing in Luxembourg, on behalf of Vuksan S.A, a société anonyme incor-

porated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 36, rue Gabriel Lippmann L-1943 Luxembourg, and
registered with the Luxembourg Trade and company registry under number B98.240,

by virtue of a proxy hereto attached, being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Alesraa Luxembourg S.à

r.l (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 36, rue Gabriel Lippmann L-1943
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and company registry under number B 108.197, and incorporated
by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg of 12 May 2005, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C992 on 5 October 2005, amended for the last time by
deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg of 22 August 2006, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C 2068 on 6 November 2006 (the "Articles").

The appearing party declared and requested the notary to record that:
1. The Sole Shareholder holds all five hundred (500) shares in issue in the Company so that decisions can validly be

taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions were to be passed are as follows:

<i>Agenda

1. Modification of the corporate objects of the Company which shall be read as follows:
"The corporate objects of the Company are (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, directly

or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the
acquisition by purchase, subscription or in any other manner and the transfer by sale, exchange or in any other manner
of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and contracts thereon or
related thereto and (iii) the ownership, administration, development and management of a porfolio (including, among
other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).

The Company may borrow in any form and may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt securities.

The Company may grant loans (whether subordinated or unsubordinated) or other forms of financing to any company.
It may also lend funds (including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities) to its subsidiaries and
affiliated companies (including upstream and cross stream).

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all its assets.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction

which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects provided the
Company will not enter into operations or transactions that would result in it being engaged in an activity that would be
subject to license requirements or that would be a regulated activity of the financial sector".

2. Miscellaneous
After consideration of the above the Sole Shareholder took the following resolution:

66571

L

U X E M B O U R G

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolved to modify the corporate objects of the Company so as to read as indicated in the

agenda and consequently to amend article 2 of the articles of association of the Company.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le trente et unième jour du mois de janvier.
Par devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri

Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Maître Valérie Kopéra, maître en droit, résidant à Luxembourg, pour le compte de Vuksan S.A, une société anonyme

ayant son siège social 36, rue Gabriel Lippmann L-1943 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.98240,

En vertu d'une procuration ci-jointe, étant l'associé unique (l' "Associé Unique") de Alesraa Luxembourg S.à r.l (la

"Société"), une société anonyme ayant son siège social 36, rue Gabriel Lippmann L-1943 Luxembourg et immatriculée
auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.108.197, constituée suivant un acte
reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg en date du 12 mai 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro C992 du 5 octobre 2005, et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par Me Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg en date du 22 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro C2068 du
6 novembre 2006 (les "Statuts"). La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1. L'Associé Unique détient toutes les cinq cents (500) parts sociales en émission dans la Société de sorte que des

décisions peuvent être valablement prises sur tous les points à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l'objet social de la Société afin qu'il se lise comme suit:

Art. 2. La Société a pour objets sociaux (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et

par tous moyens, directement ou indirectement, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière et l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières ou instru-
ments financiers de toutes espèces, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession,
l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment des actifs tels que ceux définis
aux points (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission de notes, obligations, certificats

de créance et titres représentatifs de dette de toute espèce. La Société peut accorder des prêts (subordonnés ou non
subordonnés) ou d'autres formes de financement à toute société. Elle peut également prêter des fonds (y compris ceux
résultant des emprunts et/ou de l'émission de titres représentatifs de dette) à ses filiales et sociétés affiliées (y compris
ascendantes et latérales).

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre
nantir, céder, grever de charges ou créer toutes sûretés sur toute ou partie de ses avoirs.

D'une manière générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute

opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de ses objets
sociaux, à condition que la Société ne participe pas à des opérations ou des transactions qui auraient pour résultat que
la Société soit engagée dans une activité pour laquelle un agrément serait nécessaire ou qui serait considérée comme
étant une activité réglementée du secteur financier."

2 divers
Après considération de ce qui précède l'Associé Unique a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Associé Unique a décidé de modifier l'objet social de la Société afin qu'il se lise tel que figurant à l'ordre du jour et

de modifier en conséquence l'article 2 des Statuts de la Société.

66572

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent acte la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. KOPERA et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 février 2011. Relation: LAC/2011/6032. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056147/110.
(110063168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

Rayburn Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 112.489.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2009 a été déposée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2011057305/12.
(110064605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

RSTM BVBA &amp; Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 129.359.

Il est porté à la connaissance de tiers que la société RealSTart Managament BVBA, Associé commandité de la société

émargée a changé son siège social et est désormais domiciliée au Drukkerijstraat 22/2101, 2000 Antwerpen (Belgique).

Il est également porté à la connaissance de tiers que la dénomination exacte de la société RealSTart Managament BVBA

est RealStart Management BVBA.

Pétange, le 20 avril 2011.

Référence de publication: 2011057308/12.
(110064279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Dubaian Investment Adviser S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 132.168.

EXTRAIT

En date du 22 avril 2011 l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Enlever Mr. Andy Baert comme gérant de la société avec effet au 15 avril 2011;
- Sarah Butler, née à Salford (Grande-Bretagne), le 19 mars 1976, avec adresse professionnelle au Piccadilly Plaza, 26

th

 Floor City Tower, M1 4BD Manchester, est élue nouveau gérant de la Société avec effet au 15 avril 2011 et ce pour

une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011059076/16.
(110066550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2011.

66573

L

U X E M B O U R G

Rylux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 112, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 146.004.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre de démission datée du 20 avril. 2011 que Monsieur Frank SIMON né le 20 février 1970 à Thionville

et demeurant professionnellement 112 Rue du Canal à L-4051 Esch sur Alzette n'est plus Gérant de la société.

<i>Pour la Gérance
Signature

Référence de publication: 2011057311/12.
(110064359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

APPA asbl, Association des parents et des personnes âgées d'origine espagnole, Association sans but

lucratif.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 179, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg F 8.715.

STATUTS

<i>Membres fondateurs

Anllo García José, retraité, 179, route d'Esch, L-1471 Luxembourg;
Luque Mata Alfonso, retraité, 211, route de Luxembourg, L-3254 Bettembourg;
Raya Laredo Francisco, retraité, 28, rue du Curé, L-3221 Bettembourg
Tous de nationalité espagnole

Créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle

a été modifiée et les présents statuts.

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination «Association des Parents et des Personnes Âgées d'origine espagnole»

association sans but lucratif, en abrégé «APPA asbl».

Elle a son siège à L-1471 Luxembourg, route d'Esch, 179.
Le siège de l'association pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché sur simple décision de son Conseil

d'administration.

Art. 2. L'association a pour objet de:
- défendre le droit à un enseignement de qualité de la langue et de la culture espagnole à tous les niveaux au Grand-

Duché de Luxembourg, notamment pour les enfants et les jeunes de la communauté espagnole;

- diffuser et promouvoir la culture des différents peuples d'Espagne résidant au Grand-Duché;
- promouvoir des activités sociales, culturelles et récréatives pour les enfants, les adultes et les personnes âgées;
- promouvoir et favoriser les contacts interculturels entre les résidents espagnols et tous les autres résidants au

Luxembourg et dans la grande région afin de développer la compréhension et l'enrichissement culturel réciproque;

- analyser, suivre et promouvoir la discussion et l'intérêt autour des questions relatives aux personnes âgées issues de

la migration et promouvoir des activités en faveur de ces personnes et avec ces personnes;

- promouvoir et favoriser la participation sociale, civique et politique des membres de l'association et établir des

collaborations fructueuses avec d'autres groupements et associations ayant des buts similaires.

Art. 3. L'association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 4. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d'adminis-

tration à la suite d'une demande écrite et ou verbale.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite

au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire après le délai de 3 mois à compter du jour de l'échéance tout membre qui refuse de payer

la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l'association si, d'une manière quelconque, ils portent gravement atteinte

aux intérêts de l'association. A partir de la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration, jusqu'à la
décision définitive de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l'exclusion est
envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

66574

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'association et n'ont aucun

droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 250 euros.

Art. 9. L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d'administration

régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d'administration.

Art. 10. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, par courrier postal ou

par courrier électronique. La convocation doit contenir un ordre du jour.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d'un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l'ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.

Art. 12. L'assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l'association.

Art. 13. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre
des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 14. Les délibérations de l'assemblée sont consignées dans un registre qui pourra être consulté par les membres

et les tiers sur simple demande.

Art. 15. L'association est gérée par un conseil d'administration (Junte Directive) élu pour une durée de 2 années par

l'Assemblée Générale. Le conseil d'administration se compose d'un président et de 4 à 10 membres au maximum élus à
la majorité simple des voix présentes à l'assemblée générale.

Tout membre en règle avec les cotisations et ayant une ancienneté au sein de l'association de 3 ans pourra être candidat.

Art. 16. Le conseil d'administration qui se réunit sur convocation de son président ou à la demande de 3 administrateurs

ne peut valablement délibérer que si 3 membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité
simple des membres présents.

Art. 17. Le conseil d'administration gère les affaires et les avoirs de l'association. Il exécute les directives à lui dévolues

par l'assemblée générale conformément à l'objet de l'association.

Art. 18. Il représente l'association dans les relations avec les tiers. Pour que l'association soit valablement engagée à

l'égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.

Art. 19. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le rapport d'activités,

les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L'exercice budgétaire commence le 1 

er

 janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l'assemblée générale avec le rapport des réviseurs de caisse.

Afin d'examen, l'assemblée désigne deux réviseurs de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui d'ad-

ministrateur en exercice.

Art. 20. En cas de liquidation de l'association les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires ou, à

défaut, à une association de bienfaisance.

Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l'indication des modifications qui se sont produites et

ce au 31 décembre.

Art. 22. Les ressources de l'association comprennent notamment:
- les cotisations des membres,

66575

L

U X E M B O U R G

- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur,
- les revenus de l'association.

Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'à l'éventuel règlement interne en vigueur approuvé par
l'assemblée générale

Ainsi fait à Luxembourg, le 29 mars 2011.

Anllo García José / Luque Mata Alfonso / Raya Laredo Francisco
<i>Les membres fondateurs

Référence de publication: 2011056007/106.
(110062707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

Alexus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 151.048.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011061863/10.
(110068722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Cinq2base S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 118.752.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011061877/10.
(110069093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

CS Taxis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Docteur Klein.

R.C.S. Luxembourg B 99.052.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011061881/10.
(110068751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

D &amp; D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6990 Hostert, 10, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 58.696.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011061882/10.
(110068707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

66576


Document Outline

Ability Finance Luxembourg S.à r.l.

ALESRAA Luxembourg S.à r.l.

Alexus S.à r.l.

Aperam

Association des parents et des personnes âgées d'origine espagnole

Black Tie Luxco S.à r.l.

Cacyopee Immo S.A.

Carlisle Management Company S.C.A.

CETP II Foundry S.à r.l.

Cinq2base S.A.

CS Taxis S.à r.l.

DB Advisors Invest

DB Advisors Invest

D &amp; D S.à r.l.

DS Care S.A.

Dubaian Investment Adviser S.à r.l.

DWS Concept

DWS Dividende USA Direkt 2014

DWS India

DWS Shift 2015

DWS Shift 2016

DWS Shift 2017

Fiduciaire Eurolux

Finateam Gestion S.A.

Fintad International S.à r.l.

Fintad Securities S.A.

GoldPort Stabilitätsfonds

HEAREF Luxembourg Self Storage

Helikos SE

Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l.

Hewlett-Packard Luxembourg Participations S.à r.l.

IRERE Luxembourg Self Storage

JRS SICAV

La Rose S.A., SPF

LaSalle Nasu S.à r.l.

Le Lys S.A., SPF

Libra Luxembourg S.à r.l.

Mellinckrodt 1

Mirale Finance S.à r.l.

Nassou

PAP S.A.

Private Equity Portfolio 2007 ITM S.C.A., SICAR

Private Equity Portfolio 2007 S.C.A., SICAR

Pylos Luxembourg S.A.

Rayburn Property S.à r.l.

Rayburn Property S.à r.l.

Residia Immobilier S.à r.l.

Rovi Technologies S.à r.l.

RSTM BVBA &amp; Cie

Rylux Sàrl

Salalah Holdings S.A.

Smart Holding Group S.A.

Terra Mundus Solar S.à r.l.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.