logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2348

3 novembre 2010

SOMMAIRE

Admiral Institutional S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

112694

Aero Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

112696

Agence Heros S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112700

Aida Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112701

ANNA Real Estate 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

112684

ANNA Real Estate 4 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

112682

ANNA Real Estate 5 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

112679

ANNA Real Estate 6 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

112677

ANNA Real Estate 7 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

112675

ANNA Real Estate GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

112687

AutoArc Holding S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . .

112681

AXA Mezzanine II S.A., SICAR . . . . . . . . . .

112689

Barton's Reitplatzbau Sàrl  . . . . . . . . . . . . . .

112695

Boris XC 90 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112689

Credit Agricole Private Equity Luxem-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112695

D.P. Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112699

Exalog S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112690

Fairacre Properties (Lux) 5 S.à r.l.  . . . . . . .

112690

Falcon Mines S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112697

Final S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112691

Fintime S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112703

Funcom S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112690

GSLP I Offshore C (Brenntag) S.à r.l.  . . . .

112686

GSLP I Onshore (Brenntag) S.à r.l.  . . . . . .

112703

Huang Holding Company S.A. . . . . . . . . . . .

112695

Hyta Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112690

Hyta Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112691

IIF Int'l Debt Investments S.à r.l.  . . . . . . . .

112697

IIF Int'l Equity Investments S.à r.l.  . . . . . . .

112696

IIF LuxCo1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112697

IIF LuxCo2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112697

InterAtoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112692

J. Safra I.P. Holding Co.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

112704

Kamea International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

112704

Malcolm & Peter International Holding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112704

MD Mezzanine S.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . .

112691

MLAnna Real Estate 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

112684

MLAnna Real Estate 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

112682

MLAnna Real Estate 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

112679

MLAnna Real Estate 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

112677

MLAnna Real Estate 7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

112675

MLAnna Real Estate GP S.à r.l.  . . . . . . . . . .

112687

NSH Capital Funding (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112696

OCM Luxembourg Nordenia POF S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112663

OCM / Nordenia POF Luxembourg S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112663

Orion Finance III Luxembourg S.à r.l.  . . . .

112692

Orion Finance II Luxembourg S.à r.l.  . . . .

112691

Pentagon Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

112692

Same Day Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112693

Same Day Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112695

Shield Topco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112692

Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care

X S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112698

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka I Al-

pha S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112698

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka II

Beta S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112698

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka II

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112698

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka I S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112698

SPC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112700

SPE 2 Berlin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112658

Sunrise Global S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112692

Thema Production S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

112660

Transfroid Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

112702

Vasudevam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112695

Wallbridge Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . .

112693

WSI Education S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112694

112657

L

U X E M B O U R G

SPE 2 Berlin, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 106.052.

In the year two thousand and ten, on the first of September.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Dynamique Résidentiel S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 104106, having its re-
gistered office at 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

here represented by Ms. Astrid Wagner, Avocat à la Cour and Mr. Jean-Marc Ueberecken, Avocat à la Cour, profes-

sionally residing in Luxembourg (hereinafter the “Proxyholder“), by virtue of a proxy given under private seal.

and
CB Richard Ellis SPE II Intermediate S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B
110774, having a share capital of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) and having its registered office at
35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

here represented by the Proxyholder, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxies, initialled ne varietur by the Proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of SPE 2 Berlin, a société à responsabilité limitée, incorporated pursuant

to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
on 27 January 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 4 June 2005, n°537, registered
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 106052, having a share capital of three million
euro (EUR 3,000,000) and its registered office at 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (hereinafter the “Com-
pany”). The articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx on 29 March 2005,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 20 August 2005, n°814.

The appearing parties representing the entire share capital of the Company requested the undersigned notary to enact

the following resolutions:

<i>First resolution

In compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (hereinafter the “Law 1915”),

the shareholders decide to dissolve the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the shareholders decide to appoint as liquidator, FISCALITE, COMPTA-

BILITE, GESTION, S.à r.l., en abrégé FISCOGES, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 61071 and having its registered office at 4, rue de Kleinbettingen, L-8362 Grass.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law 1915.
The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the Law 1915 without requesting the autho-

rization of the shareholders in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights,

preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the prefe-
rential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such

part of its powers it determines and for the period it will fix.

The liquidator may distribute the Company’s assets to the shareholders in cash or in kind to its willingness.
The shareholders resolve to approve the liquidator’s remuneration as agreed among the parties concerned.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of this deed are assessed to EUR 1,000.-

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

112658

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that this deed is worded in English,

followed by a French version. On request of the appearing persons and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will prevail.

The deed having been read to the Proxyholder acting in his hereabove stated capacities and known to the notary by

his name, first name, civil status and residence, said Proxyholder signed together with the notary this deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille dix, le premier septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

Dynamique Résidentiel S.A., une société anonyme, constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Lu-

xembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104106, ayant
son siège social au 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Astrid Wagner, avocat à la Cour et Monsieur Jean-Marc Ueberecken, avocat à la

Cour, résidant professionnellement à Luxembourg (ci-après le «Mandataire»),

en vertu d’une procuration sous seing privé,
et
CB Richard Ellis SPE II Intermediate S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant en vertu des

lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous
le numéro B 110774, ayant un capital social de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) et ayant son siège social au 35,
boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

ici représentée par le Mandataire, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Les procurations signées ne varietur par le Mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les comparantes sont les associés de SPE 2 Berlin, une société à responsabilité limitée, constituée conformément à

un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en date du 27 janvier 2005, publié le 4 juin 2005 dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°537, enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106052, ayant un capital de
trois millions d’euros (EUR 3.000.000) et ayant son siège social 35, boulevard Prince Henri L -1724 Luxembourg (ci-après
la «Société»). Les statuts ont été modifiés par acte de Maître Hellinckx le 29 mars 2005 publié le 20 août 2005 dans le
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°814.

Les comparantes, représentant l’intégralité du capital social de la Société, ont requis le notaire soussigné d'instrumenter

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi de 1915»),

les associés décident de dissoudre la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, les associés décident de nommer comme liquidateur FISCALITE, COMP-

TABILITE, GESTION, S.à r.l., en abrégé FISCOGES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existent
selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 61071 et ayant son siège social au 4, rue de Kleinbettingen, L-8362 Grass.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la Loi de 1915.
Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l’article 145 de la Loi de 1915, sans demander l’autorisation de

l’assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique ; renoncer à tous les

droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes
les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur n’a pas à faire l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l’étendue et la durée.

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux associés en numéraire ou en nature selon sa volonté.
Les associés décident d’approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

112659

L

U X E M B O U R G

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à EUR 1,000.-

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la demande des comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Et après lecture faite au Mandataire, agissant en cette qualité comme dit ci-avant et connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit Mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. WAGNER, J.-M. UEBERECKEN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 septembre 2010. Relation: LAC/2010/38813. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129157/122.
(100146681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Thema Production S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 41, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 93.164.

In the year two thousand and ten, on the twenty-seventh of July.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of Thema Production S.A., a société anonyme, having its registered office

at Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 93164, incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed of Maître Frank Baden, notary,
residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on the 17 

th

 of April 2003, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations on the 20 

th

 of May 2003, number 541 and the Articles of Incorporation of which have been

amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary of the 11 

th

 March 2010, published in the Memorial

C, Recueil des Sociétés et Associations on the 29 

th

 April 2010, number 892 (the "Company").

The meeting is opened with Mrs Dina GORENKO, private employee, residing professionally in Luxembourg, being in

the chair,

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Annick BRAQUET, private employee, residing professionally

in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman then declared and further requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is worded as follows:

<i>Agenda

Amendment of Article 6 of the Articles of Incorporation as follows:
“The shares of the Company are freely transferable between shareholders .
The transfer of shares to a third party shall be subject to the following conditions:
Shares to be transferred must in priority be offered to the other shareholders by notice to be given to the board of

directors of the Company and to be forwarded by the board of directors to the various shareholders within five (5)
business days of its receipt.

The offer must contain the amount of shares offered, the identity of the third party and the agreed price.
The shareholders shall have the right to exercise their pre-emption rights during a period of six (6) weeks as of the

date of the dispatch of the formal notification by the board of directors.

In case the preemption rights are exercised for a number of shares exceeding the offer, the number of shares that

each shareholder shall receive shall be reduced proportionally to his initial request.

If the amount of shares offered exceeds the amount of shares for which a preemption right is exercised or if the offered

shares are not purchased by the shareholders, the offering shareholder shall be free to sell all of the offered shares to
the third party under the terms initially notified to the board of directors”.

II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-

112660

L

U X E M B O U R G

sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

III. - That the present meeting has been duly convened by notice sent to the shareholders.
IV- That all the seven hundred and fifty (750) shares shares representing the entire share capital, are represented, so

that the meeting is regularly constituted and can therefore validly deliberate on the aforementioned agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Sole resolution:

The meeting resolves to amend Article 6 of the Articles of Incorporation as follows:

Art. 6. “The shares of the Company are freely transferable between shareholders.
The transfer of shares to a third party shall be subject to the following conditions:
Shares to be transferred must in priority be offered to the other shareholders by notice to be given to the board of

directors of the Company and to be forwarded by the board of directors to the various shareholders within five (5)
business days of its receipt.

The offer must contain the amount of shares offered, the identity of the third party and the agreed price.
The shareholders shall have the right to exercise their pre-emption rights during a period of six (6) weeks as of the

date of the dispatch of the formal notification by the board of directors.

In case the preemption rights are exercised for a number of shares exceeding the offer, the number of shares that

each shareholder shall receive shall be reduced proportionally to his initial request.

If the amount of shares offered exceeds the amount of shares for which a preemption right is exercised or if the offered

shares are not purchased by the shareholders, the offering shareholder shall be free to sell all of the offered shares to
the third party under the terms initially notified to the board of directors.”

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board and the proxyholders of the shareholders signed together with the
notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le vingt-sept juillet.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Thema Production S.A., société anonyme

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 93164 (la "Société"), constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Frank Baden,
notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 17 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations en date du 20 mai 2003, numéro 541. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu
par le notaire soussigné, en date du 11 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date
du 29 avril 2010, numéro 892.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Dina GORENKO, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président expose ensuite et prie encore le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

<i>Ordre du jour

Modification de l’article 6 des statuts. comme suit:
“Les actions peuvent être librement cédées entre actionnaires .
La cession d’actions à un tiers sera soumise aux conditions suivantes:
Les actions à céder seront en priorité offertes aux autres actionnaires, par notification donnée au conseil d’adminis-

tration qui communiquera cette notification aux autres actionnaires dans les cinq (5) jours ouvrables de sa réception.

112661

L

U X E M B O U R G

L’offre doit contenir le nombre d’actions offertes, l’identité du tiers et le prix d’achat convenu.
Les actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de préemption pendant une période de six (6) semaines à partir de

la date d’expédition de la notification formelle par le conseil d’administration.

Au cas où le droit de préemption est exercé pour un nombre d’actions supérieur à l’offre, le nombre d’actions que

chaque actionnaire recevra sera réduit proportionnellement à sa demande initiale.

Au cas où le nombre d’actions offertes excède le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé

ou si les actions offertes ne sont pas acquises par les actionnaires, l’actionnaire cédant aura le droit de céder toutes les
actions offertes au tiers aux conditions communiquées initialement au conseil d’administration.”

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

III.– Que la présente assemblée a été régulièrement convoquée au moyen de convocations envoyées à tous les ac-

tionnaires.

IV.- Que les 750 (sept cent cinquante) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente

assemblée, de sorte que celle-ci est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée,
sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend la résolution suivante:

<i>Résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts comme suit:

Art. 6. “Les actions peuvent être librement cédées entre actionnaires .
La cession d’actions à un tiers sera soumise aux conditions suivantes:
Les actions à céder seront en priorité offertes aux autres actionnaires, par notification donnée au conseil d’adminis-

tration qui communiquera cette notification aux autres actionnaires dans les cinq (5) jours ouvrables de sa réception.

L’offre doit contenir le nombre d’actions offertes, l’identité du tiers et le prix d’achat convenu.
Les actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de préemption pendant une période de six (6) semaines à partir de

la date d’expédition de la notification formelle par le conseil d’administration.

Au cas où le droit de préemption est exercé pour un nombre d’actions supérieur à l’offre, le nombre d’actions que

chaque actionnaire recevra sera réduit proportionnellement à sa demande initiale.

Au cas où le nombre d’actions offertes excède le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé

ou si les actions offertes ne sont pas acquises par les actionnaires, l’actionnaire cédant aura le droit de céder toutes les
actions offertes au tiers aux conditions communiquées initialement au conseil d’administration.”

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'Anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms,

prénoms usuels, état et demeure, les membres du bureau et les représentants d’actionnaires ont signé avec le notaire le
présent acte.

Signé: D. GORENKO, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juillet 2010. Relation: LAC/2010/33711. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129174/141.
(100146737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

112662

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg Nordenia POF S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. OCM / Nordenia POF Luxembourg S.C.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 114.638.

In the year two thousand and ten, on the fourth day of August.
Before us Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx,

notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depositary of the present deed,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of OCM/Nordenia POF Luxembourg

S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions) incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 114.638 (the Company),
incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on 21 Fe-
bruary 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1007 of 23 May 2006. The articles of
incorporation of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed
of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 30 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, n° 2514 of 6 November 2007.

The Meeting was opened at 11.15 am and chaired by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, with professional

address in Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appointed as secretary Mrs Lucie Ribeiro, private employee, with professional address in Luxembourg

(the Secretary).

Mrs Liliane Freichel, private employee, with professional address in Luxembourg was elected as scrutineer (the Scru-

tineer, and collectively with the Chairman and the Secretary, the Bureau).

The Bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. It appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that all the shares issued

by the Company (i.e. ninety-two thousand eight hundred and fifty-five (92,855) Class A Ordinary Shares) are present or
represented at the Meeting, so that the Meeting is regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda,
hereinafter reproduced.

II. that it results from (i) a balance sheet of the Company that, as of 31 March 2010 (the Balance Sheet) the net asset

value of the Company corresponds at least to the value of the share capital of the Company, and (ii) from a valuation
certificate dated as of the date hereof (the Valuation Certificate), that since the date of the Balance Sheet and as of the
date hereof, no material change in the business of the Company and the Company’s affairs has occurred which would
imply that the financial statements dated as per 31 March 2010 have become materially incorrect and do not give a true
and fair view of the Company’s situation as of the date hereof. A copy of the Balance Sheet and Valuation Certificate,
after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed for the purposes of registration.

III. The agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices;
2. Acknowledgement of the resignation of the members of the supervisory board of the Company with immediate

effect and vote of discharge;

3. Acknowledgement of the resignation of OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A. as sole manager (associé comman-

dité) of the Company with immediate effect and vote of discharge;

4. Change of the Company’s legal form from a partnership limited by shares (société en commandite par actions) into

a private limited liability company (société à responsabilité limitée) and acknowledgement that the net asset value of the
Company amounts to at least one hundred and sixteen thousand sixty-eight euro and seventy-five euro-cents (EUR
116,068.75), and decision to set the share capital of the Company at one hundred and sixteen thousand sixty-eight euro
and seventy-five euro-cents (EUR 116,068.75);

5. Amendment to article 1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“  Art. 1. Name.  The  name  of  the  company  is  “OCM  Luxembourg  Nordenia  POF  S.à  r.l.”  (the  “Company”).  The

Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”), and
these articles of incorporation (the “Articles”).”

6. Amendment to article 4 of the Articles which shall read as follows:
“The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments

112663

L

U X E M B O U R G

issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,

notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the
proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against

credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.”

7. Amendment, restatement and renumbering of the Articles in their entirety and, to the extent necessary, insertion

or change of headings in the Articles in order to reflect the change of legal form of the Company adopted under item 4.
above;

8. Appointment of the new managers of the Company with immediate effect; and
9. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration
of the above changes in the register of shareholders of the Company.

These facts having been exposed and recognized as true, the shareholders of the Company duly represented at the

Meeting (the Shareholders) unanimously resolve on the following:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to waive the convening notices, considering themselves as duly convened and having perfect

knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to accept the resignation of Compagnie de Révision, Ernst &amp; Young and Ernst &amp; Young Tax

Advisory Services as members of the supervisory board of the Company with immediate effect. The Shareholders further
resolve to grant them discharge for their activities as members of the supervisory board of the Company from the date
of their appointment until the date of their resignation.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to accept the resignation of OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A. as sole manager (associé

commandité) of the Company with immediate effect and to grant it discharge for its activities as sole manager of the
Company from the date of its appointment until the date of its resignation.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to change the legal form of the Company from a partnership limited by shares (société en

commandite par actions) into a private limited liability company (société à responsabilité limitée).

The Shareholders acknowledge and confirm that it results from the Balance Sheet and the Valuation Certificate that

the net asset value of the Company amounts at least to one hundred and sixteen thousand sixty-eight euro seventy-five
euro-cents (EUR 116,068.75) and resolve to set the share capital at one hundred and sixteen thousand sixty-eight euro
and seventy-five euro-cents (EUR 116,068.75).

The ninety-two thousand eight hundred and fifty-five (92,855) existing Class A Ordinary Shares having a nominal value

of one euro and twenty-five euro-cents (EUR 1.25) are exchanged against ninety-two thousand eight hundred and fifty-
five (92,855) ordinary shares of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with a nominal value
of one euro and twenty-five euro cents (EUR 1.25) per share.

The ninety-two thousand eight hundred and fifty-five (92,855) ordinary shares are hold by the shareholders as follows:
OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A., a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 53, avenue

Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
114.639, will hold one (1) ordinary share;

Mr. Gerard Kerins, born in New York, New York on 16 October 1947, residing at Wildfell, Manor Lane, Gerrards

Cross, Bucks, SL9 7NH, United Kingdom, will hold six hundred and sixty-five (665) ordinary shares;

OCM Luxembourg EPOF S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 116.601, will hold forty-six thousand ninety-four (46,094) ordinary shares;

112664

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg POF III S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 109.801, will hold forty-five thousand two hundred and sixty-three (45,263)
ordinary shares; and

OCM Luxembourg POF III A S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 110.180, will hold eight hundred and thirty-two (832) ordinary shares.

<i>Fifth resolution

As a result of the above, the Shareholders resolve to amend article 1 of the Articles and resolve that such article shall

have the wording as per article 1 of the amended and restated Articles adopted under the seventh resolution below.

<i>Sixth resolution

As a result of the above, the Shareholders resolve to amend article 4 of the Articles and resolve that such article shall

have the wording as per article 3 of the amended and restated Articles adopted under the seventh resolution below.

<i>Seventh resolution

As a result of the above, the Shareholders resolve to amend, restate and renumber the Articles in their entirety and,

to the extent necessary, insert or change any headings in the Articles, which will read henceforth:

I. Name – Registered office – Object – Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “OCM Luxembourg Nordenia POF S.à r.l.” (the “Company”). The Company

is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”), and these
articles of incorporation (the “Articles”).

Art. 2. Registered office.
2.1.The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered
office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders,
acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2.Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1.The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2.The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3.The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4.The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1.The Company is formed for an unlimited duration.

112665

L

U X E M B O U R G

4.2.The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital – Shares

Art. 5. Capital.
5.1.The share capital is set at one hundred and sixteen thousand sixty-eight euro and seventy-five euro-cents (EUR

116,068.75) represented by ninety-two thousand eight hundred and fifty-five (92,855) ordinary shares having a nominal
value of one euro and twenty-five euro-cents (EUR 1.25) each, all subscribed and fully paid up.

5.2.The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members appointed by a resolution of the single

shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The managers need not to be
shareholders.

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

112666

L

U X E M B O U R G

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10.Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any

two managers of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1.The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum – Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3. The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters (3/4) of the share capital.

13.4. Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the board of managers must prepare the balance

sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Company’s commitments and the debts of the mana-
gers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve,

until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular

allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the

Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of

the Company;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

112667

L

U X E M B O U R G

VI. Dissolution – Liquidation

16.1 The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.

VI. General provision

17.1. Notices and communications are made or waived and the circular resolutions of the managers as well as the

circular resolutions of the shareholders are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of
electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

meetings of the board of managers may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be
accepted by the board of managers.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the circular resolutions of the managers, the resolutions adopted by
the board of managers by telephone or video conference and the circular resolutions of the shareholders, as the case
may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute
one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Eighth resolution

The Shareholders resolve to appoint the following persons as new managers of the Company with immediate effect

and for an indefinite period:

- Szymon DEC, born on July 3, 1978 in Lodz, Poland, with business address at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;
- Hugo NEUMAN, born on October 21, 1960 in Amsterdam, The Netherlands, with private address 16, rue J.B. Fresez,

L-1724 Luxembourg;

- Jean-Pierre BACCUS, born on September 14, 1976 in Malmédy, Belgium, with business address at 53, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg;

- Martin David GRAHAM, born on December 7, 1978 in Glasgow, United Kingdom, with business address at 27,

Knightsbridge, London SW1X 7LY, England; and

- Justin BICKLE, born on January 11, 1971 in Plymouth, United Kingdom, with business address at 27, Knightsbridge,

London SW1X 7LY, England.

<i>Ninth resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

with power and authority to any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with
the registration of the above changes in the register of shareholders of the Company.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this

deed are estimated at approximately EUR 2,500.-.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing
parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with Us, the notary, this original notarial

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le quatre août.
Par devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx,

notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute,

112668

L

U X E M B O U R G

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de OCM/Nordenia POF Luxembourg

S.C.A., une société en commandite par actions constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 53,
avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.638, constituée suivant un acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

o

 1007 du 23 mai 2006 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour

la dernière fois suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 août 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n 

o

 2514 du 6 novembre 2007.

L'assemblée a été ouverte à 11.15 heures et présidée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, ayant son

adresse professionnelle à Luxembourg (le Président).

Le Président a nommé comme secrétaire Madame Lucie Riberio, employée privée, ayant son adresse professionnelle

à Luxembourg (le Secrétaire).

Madame Liliane Freichel, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg a été élu scrutateur (le

Scrutateur, et collectivement avec le Président et le Secrétaire, le Bureau)

Le Bureau constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Il ressort de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que toutes les actions émises par la

Société (soit quatre-vingt-douze mille huit cent cinquante-cinq Actions Ordinaires de Classe A) sont présentes ou re-
présentées à l’Assemblée de sorte que l’Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre
du jour, ci-après reproduit.

II. qu'il ressort (i) d’un bilan de la Société, qu'au 31 mars 2010 (le Bilan) la valeur d’inventaire nette de la Société

correspond au moins à la valeur du capital social de la Société, et (ii) d’un certificat d’évaluation daté à la date des présentes
(le Certificat d’Evaluation) que depuis la date du Bilan et à la date des présentes, aucun changement matériel dans l’activité
de la Société et les affaires de la Société n’a eu lieu qui impliquerait que l’état comptable au 31 mars 2010 ne soit devenu
matériellement incorrect et ne donne pas une vision exacte et correcte de la situation de la Société à la date des présentes.
Des copies du Bilan et du Certificat d’Evaluation, après avoir été signées ne varietur, par le mandataire agissant pour le
compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de
l’enregistrement.

III l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Constatation de la démission des membres du conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat et vote de

décharge;

3. Constatation de la démission de OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A. de ses fonctions d’associé commandité de

la Société avec effet immédiat et vote de décharge;

4. Modification de la forme juridique de la Société d’une société en commandite par actions en une société à respon-

sabilité limitée et constatation que la valeur d’inventaire nette de la Société s’élève à cent seize mille soixante-huit euros
et soixante-quinze centimes (EUR 116.068,75) et décision de fixer le capital social de la Société à cent seize mille soixante-
huit euros et soixante-quinze centimes (EUR 116.068,75);

5. Modification de l’article 1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la Société est “OCM Luxembourg Nordenia POF S.à r.l.” (la Société). La

Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), et par les présents statuts (les Statuts).».

6. Modification de l’article 4 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«L’objet de la Société est la prise, et le cas échéant, la vente de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger,

dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut
notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière, et le cas échéant, vendre, ou bien
céder, tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instru-
ments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle
peut participer à la création, au développement, à la gestion, au contrôle, à la vente, ou transfert de toute société ou
entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations, ou tout type de titres de participation
et instruments de dette. La Société peut prêter des fonds, en ce compris notamment, les revenus de tous emprunts à ses
filiales, sociétés affiliées et à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l’autorisation requise.

112669

L

U X E M B O U R G

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements,

et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres
risques.

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.»

7. Modification, refonte et nouvelle numérotation des Statuts dans leur intégralité et, dans la mesure du nécessaire,

insertion ou modification des titres dans les Statuts afin de refléter le changement de forme juridique de la Société adopté
au point 4. ci-dessus.

8. Nomination des nouveaux gérants de la Société avec effet immédiat;
9. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité

à tout gérant de la Société chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l’inscription des
changements ci-dessus dans le registre des associés de la Société.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts, les actionnaires de la Société, dûment représentés à l’Assemblée (les

Actionnaires), prennent à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Actionnaires décident de renoncer aux formalités de convocation, se considérant eux-mêmes comme dûment

convoqués et ayant une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires décident d’accepter la démission de Compagnie de Révision, Ernst &amp; Young et Ernst &amp; Young Tax

Advisory Services de leurs fonctions de membres du conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat. Les Ac-
tionnaires  décident  par  ailleurs  de  leur  accorder  décharge  pour  leurs  activités  en  tant  que  membres  du  conseil  de
surveillance de la Société depuis la date de leur nomination jusqu'à la date de leur démission.

<i>Troisième résolution

Les Actionnaires décident d’accepter la démission de OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A. en tant qu'associé com-

mandité de la Société avec effet immédiat et de lui accorder décharge pour ses activités en tant qu'associé commandité
de la Société depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de sa démission.

<i>Quatrième résolution

Les Actionnaires décident de transformer la forme juridique de la Société de société en commandite par actions en

société à responsabilité limitée.

Les Actionnaires reconnaissent et confirment qu'il ressort du Bilan et du Certificat d’Evaluation que la valeur d’inven-

taire  nette  de  la  Société  s’élève  à  au  moins  cent  seize  mille  soixante-huit  euros  et  soixante-quinze  centimes  (EUR
116.068,75) et décident de fixer le capital social de la Société à cent seize mille soixante-huit euros et soixante-quinze
centimes (EUR 116.068,75).

Les quatre-vingt-douze mille huit cent cinquante-cinq (92.855) Actions de Classe A existantes d’une valeur nominale

d’un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) sont échangées contre quatre-vingt-douze mille huit cent cinquante-cinq
(92.855) parts sociales ordinaires d’une société à responsabilité limitée d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq
centimes (EUR 1,25) par part sociale.

Les quatre-vingt-douze mille huit cent cinquante-cinq (92.855) parts sociales ordinaires sont détenues par les associés

comme suit:

OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 53,

avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 114.639,
détiendra une (1) part sociale ordinaire;

Mr. Gerard Kerins, né à New York, New York le 16 octobre 1947, domicilié à Wildfell, Manor Lane, Gerrards Cross,

Bucks, SL9 7NH, Royaume-Uni, détiendra six cent soixante-cinq (665) parts sociales ordinaires;

OCM Luxembourg EPOF S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
116.601, détiendra quarante-six mille quatre-vingt-quatorze (46.094) parts sociales ordinaires;

OCM Luxembourg POF III S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
109.801, détiendra quarante-cinq mille deux cent soixante-trois (45.263) parts sociales ordinaires; et

OCM Luxembourg POF III A S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 110.180, détiendra huit cent trente-deux (832) parts sociales ordinaires.

112670

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résolution

En conséquence de ce qui précède, les Actionnaires décident de modifier l’article 1 des Statuts et décident que cet

article aura la teneur de l’article 1 des Statuts modifiés et reformulés adoptés à la septième résolution ci-dessous.

<i>Sixième résolution

En conséquence de ce qui précède, les Actionnaires décident de modifier l’article 4 des Statuts et décident que cet

article aura la teneur de l’article 3 des Statuts modifiés et reformulés adoptés à la septième résolution ci-dessous.

<i>Septième résolution

En conséquence de ce qui précède, les Actionnaires décident de modifier, reformuler et renuméroter les Statuts dans

leur intégralité et, si nécessaire, d’insérer ou modifier les titres dans les Statuts qui auront désormais la teneur suivante:

I. Dénomination – Siège social – Objet– Durée

Dénomination. Le nom de la Société est “OCM Luxembourg Nordenia POF S.à r.l.” (la Société). La Société est une

société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), et par les présents statuts (les Statuts).

Siège social.

1.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

1.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l’étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires
d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de
nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège
social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Objet social.

3.1 L’objet de la Société est la prise, et le cas échéant, la vente de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger,

dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut
notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière, et le cas échéant, vendre, ou bien
céder, tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instru-
ments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle
peut participer à la création, au développement, à la gestion, au contrôle, à la vente, ou transfert de toute société ou
entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations, ou tout type de titres de participation
et instruments de dette. La Société peut prêter des fonds, en ce compris notamment, les revenus de tous emprunts à ses
filiales, sociétés affiliées et à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l’autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements, et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Durée.

4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n’est pas dissoute en raison du décès, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

112671

L

U X E M B O U R G

II. Capital – Parts sociales

Capital.
5.1. Le capital social est fixé à cent seize mille soixante-huit euros et soixante-quinze centimes (EUR 116.068,75)

représenté par quatre-vingt-douze mille huit cent cinquante-cinq (92.855) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale
d’un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, aux tiers.
En  cas de  pluralité d’associés,  la  cession de  parts  sociales  à  des non-associés  est  soumise  à  l’accord préalable  de

l’assemblée générale des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée

par cette dernière conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé qui le demande.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la

Loi.

III. Gestion – Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins deux membres qui seront nommés par réso-

lution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, qui fixera la durée de leur mandat. Les gérants ne sont
pas nécessairement associés.

7.2 Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opé-
rations conformes à l’objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un gérant

au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera men-
tionnée dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de

la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de
son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance de
la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou

représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

112672

L

U X E M B O U R G

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valables et exécutoires comme si une réunion du

conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document
unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe

de deux gérants de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.
12.3.Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme son mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1.Si le nombre d’associés ne dépasse pas vingt-cinq, les décisions des associés pourront être prises par résolution

circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou
courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

13.4. Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

V. Comptes annuels – Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le conseil de gérance doit préparer le bilan et les comptes

de résultats de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société, avec
une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est
le cas), et associés envers la Société.

14.3.Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Un montant de cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société sera affecté à la réserve légale jusqu'à

ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés aura pouvoir discrétionnaire de disposer du surplus. Elle pourra en particulier

attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment aux conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les acomptes sur dividendes est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés

de la Société;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividendes distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, les associés

doivent reverser l’excès à la Société.

VI. Dissolution – Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf

112673

L

U X E M B O U R G

décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions

circulaires des gérants ainsi que les résolutions circulaires des associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

conseil de gérance peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le conseil
de gérance.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales  pour  être  assimilées  à  des  signatures  manuscrites.  Les  signatures  des  résolutions  circulaires  des  gérants,  des
résolutions adoptées par le conseil de gérance par téléphone ou visioconférence et des résolutions circulaires des associés,
selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul
et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Huitième résolution

Les Actionnaires décident de nommer les personnes suivantes aux fonctions de nouveaux gérants de la Société avec

effet immédiat et pour une durée indéterminée:

-  Szymon  DEC,  né  le  3  juillet  1978  à  Lodz,  Pologne,  avec  adresse  professionnelle  au  53,  avenue  Pasteur,  L-2311

Luxembourg;

- Hugo NEUMAN, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, les Pays-Bas, avec adresse privée au 16, rue J.B. Fresez, L-1724

Luxembourg;

- Jean-Pierre BACCUS, né le 14 septembre 1976 à Malmédy, Belgique, avec adresse professionnelle au 53, avenue

Pasteur, L-2311 Luxembourg;

-  Martin  David  GRAHAM,  né  le  7  décembre  1978  à  Glasgow,  Royaume-Uni,  avec  adresse  professionnelle  au  27

Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Angleterre; et

- Justin BICKLE, né le 11 janvier 1971 à Plymouth, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 27 Knightsbridge,

Londres SW1X 7LY, Angleterre.

<i>Neuvième résolution

Les Actionnaires décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus

avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société
à l’inscription des changements ci-dessus dans le registre des associés de la Société

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en rapport

avec le présent acte sont estimés à environ EUR 2.500.-

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et
le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, elles ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. SIEBENALER, L. RIBEIRO, L. FREICHEL et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 août 2010. Relation: LAC/2010/35724. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129095/650.
(100147055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

112674

L

U X E M B O U R G

ANNA Real Estate 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MLAnna Real Estate 7 S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.651.

In the year two thousand and ten, on the sixteenth of September.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.744, here represented by Mr
Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and
established on September 15, 2010;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-

bourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.380, here represented by
Mr Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal
and established on September 15, 2010;

3) Colonia Real Estate AG, having its registered office at Zeppelinstrasse 4-8, D-50667 Köln and registered with the

German Trade and Companies Register under number HRB 54006, here represented by Mr Robert STRIETZEL, em-
ployee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and established on September
14, 2010.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as aforementioned, declared being the partners of MLAnna Real Estate 7 S.à r.l.

(the “Company”) having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg  Trade  and  Companies  Register  under  number  B  138.651  and  incorporated  by  deed  of  Maître  Henri
HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on May 9 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations on June 11 

th

 , 2008 under number 1445. The articles of incorporation have been amended for the last time

pursuant to a deed of the same notary, on March 12 

th

 , 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations on April 17 

th

 , 2009 under number 825.

The partners hold all the twelve thousand five hundred (12,500) shares without a par value of one euro (EUR 1) each,

representing the entire share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), so that the following resolutions
can valably be taken.

The partners requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The partners decide to accept the resignations of Mr Mark FENCHELLE and Mr John KATZ and to grant them entire

discharge for the execution of their mandates as of September 10 

th

 , 2010.

The partners decide to appoint as new manager as of September 10 

th

 , 2010 for an unlimited period:

Mr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, born in Bochum (Germany) on July 11 

th

 , 1975, professionally residing at

Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, as class A manager.

<i>Second resolution

The partners resolve to change the name of the Company from MLAnna Real Estate 7 S.à r.l. to “ANNA Real Estate

7 S.à r.l.” and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

“ Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "ANNA

Real Estate 7 S.à r.l." (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the
"Articles").”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

<i>Estimated cost

All costs and fees due as a result of the foregoing extraordinary general shareholders’ meeting are valued at one

thousand euro (EUR 1,000) and shall be charged to the Company.

112675

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a German translation, and that in case of any divergence between the English
and the German text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with us the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung

Im Jahre zweitausendzehn, am sechzehnten September.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen im

luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 131.744, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Ange-
stellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 15. September
2010 ;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen

im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 96.380, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, An-
gestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 15. September
2010 ;

3) Colonia Real Estate AG, mit Sitz in Zeppelinstrasse 4-8, D50667 Köln und eingetragen im deutschen Handelsregister

unter der Nummer HRB 54006, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Angestellter, mit beruflicher Anschrift
in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 14. September 2010.

Die vorgenannten, von dem Vertreter der Erschienenen „ne varietur“ und dem unterzeichneten Notar unterschrie-

bene Vollmachten, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienen, vertreten wie oben beschrieben, erklären, dass sie die Gesellschafter der MLAnna Real Estate 7 S.à

r.l. (die „Gesellschaft“) sind. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen
im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 138.651 und gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch
Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 9. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations am 11. Juni 2008 unter der Nummer 1445. Die Statuten der Gesellschaft wurden zum letzten
Mal abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 12. März 2009, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations am 17. April 2009 unter der Nummer 825.

Die Gesellschafter halten alle zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (1.-

EUR),  was  das  gesamte  Kapital  von  zwölftausendfünfhundert  Euro  (12.500.-EUR)  darstellt,  so  dass  die  folgenden
Beschlüsse gefasst werden können.

Die Gesellschafter haben den Notar gebeten folgende Beschlüsse zu fassen:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter nehmen die Rücktritte von Herrn Mark FENCHELLE und Herrn John KATZ an, und erteilen ihnen

volle Entlast für die Ausführungen ihrer Mandate bis zum 10. September 2010.

Die Gesellschafter ernennen folgende Person für unbestimmte Dauer und ab dem 10. September 2010 zum neuen

Geschäftsführer:

Herr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, geboren in Bochum (Deutschland), am 11. Juli 1975, mit beruflicher

Anschrift in Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, als Geschäftsführer der Klasse A.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Namen der Gesellschaft von MLAnna Real Estate 7 S.à r.l. in „ANNA Real Estate

7 S.à r.l.“ abzuändern und dementsprechend Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass er von nun an
wie folgt lauten wird:

« Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée') unter der Bezeichnung

„ANNA Real Estate 7 S.à r.l.“ (die „Gesellschaft") gegründet, die der Luxemburger Gesetzgebung unterliegt, insbesondere
dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Gesetz"), sowie gegenwärtiger
Satzung (die „Satzung").

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Abstimmung vorgesehen sind, wird die Versammlung geschlossen.

<i>Abschätzung der Kosten

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf

ungefähr eintausend Euro (1.000.-EUR).

112676

L

U X E M B O U R G

Der Unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und auch schreibt, fügt hiermit an, dass die erschienen

Personen eine deutsche Fassung der Satzungen der Englischen haben folgen lassen möchten.

Bei etwaigen Nichtübereinstimmungen der in die deutsche Sprache übersetzten Satzungen hat die englische Fassung

Vorrang.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Strietzel et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 septembre 2010. Relation: LAC/2010/41057. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129061/121.
(100146606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

ANNA Real Estate 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MLAnna Real Estate 6 S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.650.

In the year two thousand and ten, on the sixteenth of September.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.744, here represented by Mr
Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and
established on September 15, 2010;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-

bourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.380, here represented by
Mr Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal
and established on September 15, 2010;

3) Colonia Real Estate AG, having its registered office at Zeppelinstrasse 4-8, D-50667 Köln and registered with the

German Trade and Companies Register under number HRB 54006, here represented by Mr Robert STRIETZEL, em-
ployee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and established on September
14, 2010.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as aforementioned, declared being the partners of MLAnna Real Estate 6 S.à r.l.

(the “Company”) having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Lux-
embourg  Trade  and  Companies  Register  under  number  B  138.650  and  incorporated  by  deed  of  Maître  Henri  HEL-
LINCKX, notary residing in Luxembourg, on May 9 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations on June 11 

th

 , 2008 under number 1445. The articles of incorporation have been amended for the last time

pursuant to a deed of the same notary, on March 12 

th

 , 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations on April 16 

th

 , 2009 under number 822.

The partners hold all the twelve thousand five hundred (12,500) shares without a par value of one euro (EUR 1) each,

representing the entire share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), so that the following resolutions
can valably be taken.

The partners requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The partners decide to accept the resignations of Mr Mark FENCHELLE and Mr John KATZ and to grant them entire

discharge for the execution of their mandates as of September 10 

th

 , 2010.

112677

L

U X E M B O U R G

The partners decide to appoint as new manager as of September 10 

th

 , 2010 for an unlimited period:

Mr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, born in Bochum (Germany) on July 11 

th

 , 1975, professionally residing at

Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, as class A manager.

<i>Second resolution

The partners resolve to change the name of the Company from MLAnna Real Estate 6 S.à r.l. to “ANNA Real Estate

6 S.à r.l.” and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

“ Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "ANNA

Real Estate 6 S.à r.l." (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the
"Articles").”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

<i>Estimated cost

All costs and fees due as a result of the foregoing extraordinary general shareholders’ meeting are valued at one

thousand euro (EUR 1,000) and shall be charged to the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a German translation, and that in case of any divergence between the English
and the German text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with us the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung

Im Jahre zweitausendzehn, am sechzehnten September.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen im

luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 131.744, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Ange-
stellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 15. September
2010 ;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen

im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 96.380, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, An-
gestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 15. September
2010 ;

3) Colonia Real Estate AG, mit Sitz in Zeppelinstrasse 4-8, D50667 Köln und eingetragen im deutschen Handelsregister

unter der Nummer HRB 54006, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Angestellter, mit beruflicher Anschrift
in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 14. September 2010.

Die vorgenannten, von dem Vertreter der Erschienenen „ne varietur“ und dem unterzeichneten Notar unterschrie-

bene Vollmachten, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienen, vertreten wie oben beschrieben, erklären, dass sie die Gesellschafter der MLAnna Real Estate 6 S.à

r.l. (die „Gesellschaft“) sind. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen
im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 138.650 und gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch
Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 9. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations am 11. Juni 2008 unter der Nummer 1445. Die Statuten der Gesellschaft wurden zum letzten
Mal abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 12. März 2009, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations am 16. April 2009 unter der Nummer 822.

Die Gesellschafter halten alle zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (1.-

EUR),  was  das  gesamte  Kapital  von  zwölftausendfünfhundert  Euro  (12.500.-EUR)  darstellt,  so  dass  die  folgenden
Beschlüsse gefasst werden können.

Die Gesellschafter haben den Notar gebeten folgende Beschlüsse zu fassen:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter nehmen die Rücktritte von Herrn Mark FENCHELLE und Herrn John KATZ an, und erteilen ihnen

volle Entlast für die Ausführungen ihrer Mandate bis zum 10. September 2010.

Die Gesellschafter ernennen folgende Person für unbestimmte Dauer und ab dem 10. September 2010 zum neuen

Geschäftsführer:

112678

L

U X E M B O U R G

Herr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, geboren in Bochum (Deutschland), am 11. Juli 1975, mit beruflicher

Anschrift in Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, als Geschäftsführer der Klasse A.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Namen der Gesellschaft von MLAnna Real Estate 6 S.à r.l. in „ANNA Real Estate

6 S.à r.l.“ abzuändern und dementsprechend Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass er von nun an
wie folgt lauten wird:

« Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée') unter der Bezeichnung

„ANNA Real Estate 6 S.à r.l.“ (die „Gesellschaft") gegründet, die der Luxemburger Gesetzgebung unterliegt, insbesondere
dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Gesetz"), sowie gegenwärtiger
Satzung (die „Satzung").

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Abstimmung vorgesehen sind, wird die Versammlung geschlossen.

<i>Abschätzung der Kosten

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf

ungefähr eintausend Euro (1.000.-EUR).

Der Unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und auch schreibt, fügt hiermit an, dass die erschienen

Personen eine deutsche Fassung der Satzungen der Englischen haben folgen lassen möchten.

Bei etwaigen Nichtübereinstimmungen der in die deutsche Sprache übersetzten Satzungen hat die englische Fassung

Vorrang.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Strietzel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 septembre 2010. Relation: LAC/2010/41056. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129060/121.
(100146605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

ANNA Real Estate 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MLAnna Real Estate 5 S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.649.

In the year two thousand and ten, on the sixteenth of September.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.744, here represented by Mr
Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and
established on September 15, 2010;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-

bourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.380, here represented by
Mr Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal
and established on September 15, 2010;

3) Colonia Real Estate AG, having its registered office at Zeppelinstrasse 4-8, D-50667 Köln and registered with the

German Trade and Companies Register under number HRB 54006, here represented by Mr Robert STRIETZEL, em-
ployee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and established on September
14, 2010.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

112679

L

U X E M B O U R G

Such appearing parties, represented as aforementioned, declared being the partners of MLAnna Real Estate 5 S.à r.l.

(the “Company”) having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg  Trade  and  Companies  Register  under  number  B  138.649  and  incorporated  by  deed  of  Maître  Henri
HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on May 9 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations on June 11 

th

 , 2008 under number 1441. The articles of incorporation have been amended for the last time

pursuant to a deed of the same notary, on March 12th, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on April 16 

th

 , 2009 under number 822.

The partners hold all the twelve thousand five hundred (12,500) shares without a par value of one euro (EUR 1) each,

representing the entire share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), so that the following resolutions
can valably be taken.

The partners requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The partners decide to accept the resignations of Mr Mark FENCHELLE and Mr John KATZ and to grant them entire

discharge for the execution of their mandates as of September 10 

th

 , 2010.

The partners decide to appoint as new manager as of September 10 

th

 , 2010 for an unlimited period:

Mr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, born in Bochum (Germany) on July 11 

th

 , 1975, professionally residing at

Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, as class A manager.

<i>Second resolution

The partners resolve to change the name of the Company from MLAnna Real Estate 5 S.à r.l. to “ANNA Real Estate

5 S.à r.l.” and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

“ Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "ANNA

Real Estate 5 S.à r.l." (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the
"Articles").”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

<i>Estimated cost

All costs and fees due as a result of the foregoing extraordinary general shareholders’ meeting are valued at one

thousand euro (EUR 1,000) and shall be charged to the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a German translation, and that in case of any divergence between the English
and the German text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with us the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung

Im Jahre zweitausendzehn, am sechzehnten September.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen im

luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 131.744, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Ange-
stellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 15. September
2010 ;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen

im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 96.380, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, An-
gestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 15. September
2010 ;

3) Colonia Real Estate AG, mit Sitz in Zeppelinstrasse 4-8, D50667 Köln und eingetragen im deutschen Handelsregister

unter der Nummer HRB 54006, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Angestellter, mit beruflicher Anschrift
in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 14. September 2010.

Die vorgenannten, von dem Vertreter der Erschienenen „ne varietur“ und dem unterzeichneten Notar unterschrie-

bene Vollmachten, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienen, vertreten wie oben beschrieben, erklären, dass sie die Gesellschafter der MLAnna Real Estate 5 S.à

r.l. (die „Gesellschaft“) sind. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen

112680

L

U X E M B O U R G

im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 138.649 und gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch
Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 9. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations am 11. Juni 2008 unter der Nummer 1441. Die Statuten der Gesellschaft wurden zum letzten
Mal abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 12. März 2009, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations am 16. April 2009 unter der Nummer 822.

Die Gesellschafter halten alle zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (1.-

EUR),  was  das  gesamte  Kapital  von  zwölftausendfünfhundert  Euro  (12.500.-EUR)  darstellt,  so  dass  die  folgenden
Beschlüsse gefasst werden können.

Die Gesellschafter haben den Notar gebeten folgende Beschlüsse zu fassen:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter nehmen die Rücktritte von Herrn Mark FENCHELLE und Herrn John KATZ an, und erteilen ihnen

volle Entlast für die Ausführungen ihrer Mandate bis zum 10. September 2010.

Die Gesellschafter ernennen folgende Person für unbestimmte Dauer und ab dem 10. September 2010 zum neuen

Geschäftsführer:

Herr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, geboren in Bochum (Deutschland), am 11. Juli 1975, mit beruflicher

Anschrift in Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, als Geschäftsführer der Klasse A.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Namen der Gesellschaft von MLAnna Real Estate 5 S.à r.l. in „ANNA Real Estate

5 S.à r.l.“ abzuändern und dementsprechend Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass er von nun an
wie folgt lauten wird:

« Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée') unter der Bezeichnung

„ANNA Real Estate 5 S.à r.l.“ (die „Gesellschaft") gegründet, die der Luxemburger Gesetzgebung unterliegt, insbesondere
dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Gesetz"), sowie gegenwärtiger
Satzung (die „Satzung").

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Abstimmung vorgesehen sind, wird die Versammlung geschlossen.

<i>Abschätzung der Kosten

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf

ungefähr eintausend Euro (1.000.-EUR).

Der Unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und auch schreibt, fügt hiermit an, dass die erschienen

Personen eine deutsche Fassung der Satzungen der Englischen haben folgen lassen möchten.

Bei etwaigen Nichtübereinstimmungen der in die deutsche Sprache übersetzten Satzungen hat die englische Fassung

Vorrang.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Strietzel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 septembre 2010 Relation: LAC/2010/41055. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129059/121.
(100146604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

AutoArc Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 95.623.

Les comptes annuels au 30 avril 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010128845/9.
(100147049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

112681

L

U X E M B O U R G

ANNA Real Estate 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MLAnna Real Estate 4 S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.648.

In the year two thousand and ten, on the sixteenth of September.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.744, here represented by Mr
Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and
established on September 15, 2010;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-

bourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.380, here represented by
Mr Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal
and established on September 15, 2010;

3) Colonia Real Estate AG, having its registered office at Zeppelinstrasse 4-8, D-50667 Köln and registered with the

German Trade and Companies Register under number HRB 54006, here represented by Mr Robert STRIETZEL, em-
ployee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and established on September
14, 2010.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as aforementioned, declared being the partners of MLAnna Real Estate 4 S.à r.l.

(the “Company”) having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Lux-
embourg  Trade  and  Companies  Register  under  number  B  138.648  and  incorporated  by  deed  of  Maître  Henri  HEL-
LINCKX, notary residing in Luxembourg, on May 9 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations on June 11 

th

 , 2008 under number 1443. The articles of incorporation have been amended for the last time

pursuant to a deed of the same notary, on March 12 

th

 , 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations on April 17 

th

 , 2009 under number 824.

The partners hold all the twelve thousand five hundred (12,500) shares without a par value of one euro (EUR 1) each,

representing the entire share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), so that the following resolutions
can valably be taken.

The partners requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The partners decide to accept the resignations of Mr Mark FENCHELLE and Mr John KATZ and to grant them entire

discharge for the execution of their mandates as of September 10 

th

 , 2010.

The partners decide to appoint as new manager as of September 10 

th

 , 2010 for an unlimited period:

Mr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, born in Bochum (Germany) on July 11 

th

 , 1975, professionally residing at

Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, as class A manager.

<i>Second resolution

The partners resolve to change the name of the Company from MLAnna Real Estate 4 S.à r.l. to “ANNA Real Estate

4 S.à r.l.” and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

“ Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "ANNA

Real Estate 4 S.à r.l." (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the
"Articles").”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

<i>Estimated cost

All costs and fees due as a result of the foregoing extraordinary general shareholders’ meeting are valued at one

thousand euro (EUR 1,000) and shall be charged to the Company.

112682

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a German translation, and that in case of any divergence between the English
and the German text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with us the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung

Im Jahre zweitausendzehn, am sechzehnten September.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen im

luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 131.744, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Ange-
stellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 15. September
2010 ;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen

im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 96.380, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, An-
gestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 15. September
2010 ;

3) Colonia Real Estate AG, mit Sitz in Zeppelinstrasse 4-8, D50667 Köln und eingetragen im deutschen Handelsregister

unter der Nummer HRB 54006, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Angestellter, mit beruflicher Anschrift
in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 14. September 2010.

Die vorgenannten, von dem Vertreter der Erschienenen „ne varietur“ und dem unterzeichneten Notar unterschrie-

bene Vollmachten, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienen, vertreten wie oben beschrieben, erklären, dass sie die Gesellschafter der MLAnna Real Estate 4 S.à

r.l. (die „Gesellschaft“) sind. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen
im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 138.648 und gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch
Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 9. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations am 11. Juni 2008 unter der Nummer 1443. Die Statuten der Gesellschaft wurden zum letzten
Mal abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 12. März 2009, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations am 17. April 2009 unter der Nummer 824.

Die Gesellschafter halten alle zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (1.-

EUR),  was  das  gesamte  Kapital  von  zwölftausendfünfhundert  Euro  (12.500.-EUR)  darstellt,  so  dass  die  folgenden
Beschlüsse gefasst werden können.

Die Gesellschafter haben den Notar gebeten folgende Beschlüsse zu fassen:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter nehmen die Rücktritte von Herrn Mark FENCHELLE und Herrn John KATZ an, und erteilen ihnen

volle Entlast für die Ausführungen ihrer Mandate bis zum 10. September 2010.

Die Gesellschafter ernennen folgende Person für unbestimmte Dauer und ab dem 10. September 2010 zum neuen

Geschäftsführer:

Herr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, geboren in Bochum (Deutschland), am 11. Juli 1975, mit beruflicher

Anschrift in Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, als Geschäftsführer der Klasse A.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Namen der Gesellschaft von MLAnna Real Estate 4 S.à r.l. in „ANNA Real Estate

4 S.à r.l.“ abzuändern und dementsprechend Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass er von nun an
wie folgt lauten wird:

« Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée') unter der Bezeichnung

„ANNA Real Estate 4 S.à r.l.“ (die „Gesellschaft") gegründet, die der Luxemburger Gesetzgebung unterliegt, insbesondere
dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Gesetz"), sowie gegenwärtiger
Satzung (die „Satzung").

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Abstimmung vorgesehen sind, wird die Versammlung geschlossen.

<i>Abschätzung der Kosten

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf

ungefähr eintausend Euro (1.000.-EUR).

112683

L

U X E M B O U R G

Der Unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und auch schreibt, fügt hiermit an, dass die erschienen

Personen eine deutsche Fassung der Satzungen der Englischen haben folgen lassen möchten.

Bei etwaigen Nichtübereinstimmungen der in die deutsche Sprache übersetzten Satzungen hat die englische Fassung

Vorrang.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Strietzel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 septembre 2010. Relation: LAC/2010/41054. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129058/121.
(100146603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

ANNA Real Estate 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MLAnna Real Estate 3 S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.647.

In the year two thousand and ten, on the sixteenth of September.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.744, here represented by Mr
Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and
established on September 15, 2010;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-

bourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.380, here represented by
Mr Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal
and established on September 15, 2010;

3) Colonia Real Estate AG, having its registered office at Zeppelinstrasse 4-8, D-50667 Köln and registered with the

German Trade and Companies Register under number HRB 54006, here represented by Mr Robert STRIETZEL, em-
ployee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and established on September
14, 2010.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as aforementioned, declared being the partners of MLAnna Real Estate 3 S.à r.l.

(the “Company”) having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg  Trade  and  Companies  Register  under  number  B  138.647  and  incorporated  by  deed  of  Maître  Henri
HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on May 9th, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on June 12 

th

 , 2008 under number 1452. The articles of incorporation have been amended for the last time

pursuant to a deed of the same notary, on March 12th, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on April 20 

th

 , 2009 under number 841.

The partners hold all the twelve thousand five hundred (12,500) shares without a par value of one euro (EUR 1) each,

representing the entire share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), so that the following resolutions
can valably be taken.

The partners requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The partners decide to accept the resignations of Mr Mark FENCHELLE and Mr John KATZ and to grant them entire

discharge for the execution of their mandates as of September 10 

th

 , 2010.

112684

L

U X E M B O U R G

The partners decide to appoint as new manager as of September 10 

th

 , 2010 for an unlimited period:

Mr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, born in Bochum (Germany) on July 11 

th

 , 1975, professionally residing at

Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, as class A manager.

<i>Second resolution

The partners resolve to change the name of the Company from MLAnna Real Estate 3 S.à r.l. to “ANNA Real Estate

3 S.à r.l.” and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

“ Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "ANNA

Real Estate 3 S.à r.l." (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the
"Articles").”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

<i>Estimated cost

All costs and fees due as a result of the foregoing extraordinary general shareholders’ meeting are valued at one

thousand euro (EUR 1,000) and shall be charged to the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a German translation, and that in case of any divergence between the English
and the German text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with us the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung

Im Jahre zweitausendzehn, am sechzehnten September.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen im

luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 131.744, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Ange-
stellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 15. September
2010 ;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen

im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 96.380, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, An-
gestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 15. September
2010 ;

3) Colonia Real Estate AG, mit Sitz in Zeppelinstrasse 4-8, D50667 Köln und eingetragen im deutschen Handelsregister

unter der Nummer HRB 54006, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Angestellter, mit beruflicher Anschrift
in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 14. September 2010.

Die vorgenannten, von dem Vertreter der Erschienenen „ne varietur“ und dem unterzeichneten Notar unterschrie-

bene Vollmachten, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienen, vertreten wie oben beschrieben, erklären, dass sie die Gesellschafter der MLAnna Real Estate 3 S.à

r.l. (die „Gesellschaft“) sind. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen
im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 138.647 und gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch
Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 9. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations am 12. Juni 2008 unter der Nummer 1452. Die Statuten der Gesellschaft wurden zum letzten
Mal abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 12. März 2009, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations am 20. April 2009 unter der Nummer 841.

Die Gesellschafter halten alle zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (1.-

EUR),  was  das  gesamte  Kapital  von  zwölftausendfünfhundert  Euro  (12.500.-EUR)  darstellt,  so  dass  die  folgenden
Beschlüsse gefasst werden können.

Die Gesellschafter haben den Notar gebeten folgende Beschlüsse zu fassen:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter nehmen die Rücktritte von Herrn Mark FENCHELLE und Herrn John KATZ an, und erteilen ihnen

volle Entlast für die Ausführungen ihrer Mandate bis zum 10. September 2010.

Die Gesellschafter ernennen folgende Person für unbestimmte Dauer und ab dem 10. September 2010 zum neuen

Geschäftsführer:

112685

L

U X E M B O U R G

Herr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, geboren in Bochum (Deutschland), am 11. Juli 1975, mit beruflicher

Anschrift in Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, als Geschäftsführer der Klasse A.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Namen der Gesellschaft von MLAnna Real Estate 3 S.à r.l. in „ANNA Real Estate

3 S.à r.l.“ abzuändern und dementsprechend Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass er von nun an
wie folgt lauten wird:

« Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée') unter der Bezeichnung

„ANNA Real Estate 3 S.à r.l.“ (die „Gesellschaft") gegründet, die der Luxemburger Gesetzgebung unterliegt, insbesondere
dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Gesetz"), sowie gegenwärtiger
Satzung (die „Satzung").

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Abstimmung vorgesehen sind, wird die Versammlung geschlossen.

<i>Abschätzung der Kosten

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf

ungefähr eintausend Euro (1.000.-EUR).

Der Unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und auch schreibt, fügt hiermit an, dass die erschienen

Personen eine deutsche Fassung der Satzungen der Englischen haben folgen lassen möchten.

Bei etwaigen Nichtübereinstimmungen der in die deutsche Sprache übersetzten Satzungen hat die englische Fassung

Vorrang.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Strietzel et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 septembre 2010. Relation: LAC/2010/41053. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129057/121.
(100146602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

GSLP I Offshore C (Brenntag) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 140.435.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 16 septembre 2010, a décidé d'accepter:
- la démission de Christophe Cahuzac en qualité de gérant de classe A de la Société avec effet au 2 août 2010.
- La nomination avec effet au 2 août 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de classe A de la

Société de Nicole Götz, née à Brackenheim (Allemagne) le 4 Juin 1967, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du
Fossé, L-1536 Luxembourg.

- La nomination avec effet au 2 août 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de classe B de la

Société, de Véronique Menard, née à Le Loroux-Bottereau (France) le 2 octobre 1973, et résidant professionnellement
au 133 Peterborough Court, Fleet Street, GB - EC4A 2BB London, Royaume-Uni.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 2 août 2010, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant A
- Maxime NINO, gérant A
- Michael FURTH, gérant B
- Eric GOLDSTEIN, gérant B
- Véronique MENARD, gérant B

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

112686

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la Société
Maxime Nino
<i>Gérant

Référence de publication: 2010129877/26.
(100147080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

ANNA Real Estate GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MLAnna Real Estate GP S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.644.

In the year two thousand and ten, on the sixteenth of September.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.744, here represented by Mr
Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and
established on September 15, 2010;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-

bourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.380, here represented by
Mr Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal
and established on September 15, 2010;

3) Colonia Real Estate AG, having its registered office at Zeppelinstrasse 4-8, D-50667 Köln and registered with the

German Trade and Companies Register under number HRB 54006, here represented by Mr Robert STRIETZEL, em-
ployee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and established on September
14, 2010.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as aforementioned, declared being the partners of MLAnna Real Estate GP S.à r.l.

(the “Company”) having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Lux-
embourg  Trade  and  Companies  Register  under  number  B  138.644  and  incorporated  by  deed  of  Maître  Henri  HEL-
LINCKX, notary residing in Luxembourg, on May 9 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations on June 12 

th

 , 2008 under number 1453. The articles of incorporation have been amended for the last time

pursuant to a deed of the same notary, on March 12 

th

 , 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations on April 16 

th

 , 2009 under number 822.

The partners hold all the twelve thousand five hundred (12,500) shares without a par value of one euro (EUR 1) each,

representing the entire share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), so that the following resolutions
can valably be taken.

The partners requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The partners decide to accept the resignations of Mr Mark FENCHELLE and Mr John KATZ and to grant them entire

discharge for the execution of their mandates as of September 10 

th

 , 2010.

The partners decide to appoint as new manager as of September 10 

th

 , 2010 for an unlimited period:

Mr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, born in Bochum (Germany) on July 11 

th

 , 1975, professionally residing at

Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, as class A manager.

<i>Second resolution

The partners resolve to change the name of the Company from MLAnna Real Estate GP S.à r.l. to “ANNA Real Estate

GP S.à r.l.” and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

“ Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "ANNA

Real Estate GP S.à r.l." (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the
"Articles").”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

112687

L

U X E M B O U R G

<i>Estimated cost

All costs and fees due as a result of the foregoing extraordinary general shareholders’ meeting are valued at one

thousand euro (EUR 1,000) and shall be charged to the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a German translation, and that in case of any divergence between the English
and the German text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with us the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung

Im Jahre zweitausendzehn, am sechzehnten September.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen im

luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 131.744, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Ange-
stellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 15. September
2010 ;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen

im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 96.380, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, An-
gestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 15. September
2010 ;

3) Colonia Real Estate AG, mit Sitz in Zeppelinstrasse 4-8, D50667 Köln und eingetragen im deutschen Handelsregister

unter der Nummer HRB 54006, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Angestellter, mit beruflicher Anschrift
in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gebeben am 14. September 2010.

Die vorgenannten, von dem Vertreter der Erschienenen „ne varietur“ und dem unterzeichneten Notar unterschrie-

bene Vollmachten, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienen, vertreten wie oben beschrieben, erklären, dass sie die Gesellschafter der MLAnna Real Estate GP S.à

r.l. (die „Gesellschaft“) sind. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen
im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 138.644 und gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch
Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 9. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations am 12. Juni 2008 unter der Nummer 1453. Die Statuten der Gesellschaft wurden zum letzten
Mal abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 12. März 2009, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations am 16. April 2009 unter der Nummer 822.

Die Gesellschafter halten alle zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (1.-

EUR),  was  das  gesamte  Kapital  von  zwölftausendfünfhundert  Euro  (12.500.-EUR)  darstellt,  so  dass  die  folgenden
Beschlüsse gefasst werden können.

Die Gesellschafter haben den Notar gebeten folgende Beschlüsse zu fassen:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter nehmen die Rücktritte von Herrn Mark FENCHELLE und Herrn John KATZ an, und erteilen ihnen

volle Entlast für die Ausführungen ihrer Mandate bis zum 10. September 2010.

Die Gesellschafter ernennen folgende Person für unbestimmte Dauer und ab dem 10. September 2010 zum neuen

Geschäftsführer:

Herr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, geboren in Bochum (Deutschland), am 11. Juli 1975, mit beruflicher

Anschrift in Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, als Geschäftsführer der Klasse A.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Namen der Gesellschaft von MLAnna Real Estate GP S.à r.l. in „ANNA Real Estate

GP S.à r.l.“ abzuändern und dementsprechend Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass er von nun an
wie folgt lauten wird:

« Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée') unter der Bezeichnung

„ANNA Real Estate GP S.à r.l.“ (die „Gesellschaft") gegründet, die der Luxemburger Gesetzgebung unterliegt, insbeson-
dere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Gesetz"), sowie gegenwär-
tiger Satzung (die „Satzung").

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Abstimmung vorgesehen sind, wird die Versammlung geschlossen.

112688

L

U X E M B O U R G

<i>Abschätzung der Kosten

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf

ungefähr eintausend Euro (1.000.-EUR).

Der Unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und auch schreibt, fügt hiermit an, dass die erschienen

Personen eine deutsche Fassung der Satzungen der Englischen haben folgen lassen möchten.

Bei etwaigen Nichtübereinstimmungen der in die deutsche Sprache übersetzten Satzungen hat die englische Fassung

Vorrang.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Strietzel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 septembre 2010. Relation: LAC/2010/41058. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129056/121.
(100146607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

AXA Mezzanine II S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital

à Risque.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 138.458.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 28 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128864/11.
(100147050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Boris XC 90 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 71.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 100.761.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 20 septembre 2010 a approuvé les résolutions

suivantes:

- La démission de Frank Walenta et Jorrit Crompvoets, en tant qu'administrateurs de la société, est acceptée avec

effet immédiat.

- Robin Naudin ten Cate et Ivo Hemelraad, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxem-

bourg, sont élus nouveaux administrateurs de la société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle
de l'an 2015.

- Le siège social de la société est transféré du 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg au 15 rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg avec effet immédiat.

Il convient de noter que l'adresse professionnelle de Marjoleine Van Oort, administrateur, est désormais 15 rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010128889/22.
(100147052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

112689

L

U X E M B O U R G

Fairacre Properties (Lux) 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 117.111.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Fairacre Properties (LUX) 5 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2010128945/12.
(100147113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Exalog S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 117.245.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 1 

<i>er

<i> septembre 2010

<i>Première résolution

L’assemblée a pris acte de la démission en date du 16 août 2010 des administrateurs suivants:
- Madame Nadine COPP, demeurant professionnellement 371 route de Belval L-4024 ESCH/ALZETTE
- Madame Sandra FLORANGE, demeurant professionnellement 371 route de Belval L-4024 ESCH/ALZETTE
Puis l’assemblée élit en leurs remplacements:
- Monsieur Alain SAMSON, Chef d’entreprise, demeurant 6bis rue de la Poterie F-14980 ST CONTEST jusqu'à l’as-

semblée qui se tiendra en l’année 2012

- Monsieur Noël SAMSON, Chef d’entreprise, demeurant 35 rue du haut jardin F-14920 MATHIEU jusqu'à l’assemblée

qui se tiendra en l’année 2012

<i>Deuxième résolution

L’assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Marc LOFFREDO en date du 16 août 2010 de son poste d’Ad-

ministrateur Délégué.

L’assemblée décide de nommer Monsieur Marc LOFFREDO, Directeur, en tant que fondé de pouvoir, à compter du

er

 septembre 2010. La société est engagée en toute circonstance par la signature individuelle du fondé de pouvoir.

Référence de publication: 2010128939/22.
(100147010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Funcom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 94.866.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128951/10.
(100147040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Hyta Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 50.905.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

112690

L

U X E M B O U R G

<i>Pour HYTA INVEST S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010128988/11.
(100146964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Final S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 53.431.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 15 février 2010

L'assemblée générale renouvelle les mandats d'administrateurs de:
- Monsieur Jean-Claude LAVOREL, dirigeant d'entreprise, demeurant Chemin du Bois, F-69200 Caluire-et-Cuire;
- Monsieur Patrick ROCHAS, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- Monsieur Maurice HOUSSA, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
L'assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire aux comptes de la société Mazars, avec siège social au 10A,

rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'as-

semblée générale à tenir en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010129870/20.
(100146667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Hyta Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 50.905.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HYTA INVEST S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010128989/11.
(100146969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

MD Mezzanine S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital

à Risque.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 109.277.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129050/11.
(100146965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Orion Finance II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 101.513.

EXTRAIT

Par contrat de cession de parts sociales du 23 septembre 2010, Orion Master II Luxembourg S.à r.l., une société ayant

son siège social à 6, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

112691

L

U X E M B O U R G

Luxembourg sous le numéro B-101499, est devenue propriétaire de toutes les cinq cent vingt (520) parts sociales de la
société Orion Finance II Luxembourg S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orion Finance II Luxembourg S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010129098/16.
(100147038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Orion Finance III Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 140.852.

EXTRAIT

Par contrat de cession de parts sociales du 23 septembre 2010, Orion Master III Luxembourg S.à r.l., une société ayant

son siège social à 6, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg , et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B-140853, est devenue propriétaire de toutes les cinq cents (500) parts sociales de la société
Orion Finance III Luxembourg S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orion Finance III Luxembourg S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010129099/16.
(100147039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Pentagon Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Shield Topco S.à r.l.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 153.017.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129103/11.
(100147041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Sunrise Global S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 145.345.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010129138/10.
(100146971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

InterAtoz, Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg C 70.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Aux termes de l'assemblée générale des membres tenue le 19 août 2010, les membres du Groupement ont décidé:
- que la clôture de la liquidation du Groupement a été prononcée et que la liquidation du Groupement est à considérer

comme définitivement accomplie et clôturée,

112692

L

U X E M B O U R G

- que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq (5) ans au 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511

Luxembourg,

- que les fonds restants dans le Groupement seront utilisés pour régler les factures en suspens et que le solde bancaire

ultérieur sera versé aux membres,

- que le compte bancaire sera clôturé en finalité de tous les paiements.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 28 septembre 2010.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature

Référence de publication: 2010128994/25.
(100147047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Wallbridge Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 118.587.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «WALL-

BRIDGE REAL ESTATE S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de
Luxembourg), en date du 15 septembre 2010, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 septembre 2010. Relation : EAC/
2010/11148.

- que la société «WALLBRIDGE REAL ESTATE S.A..» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social

au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 118 587,

constituée suivant acte notarié du 20 juin 2006 et publié au Mémorial C numéro 1917 du 12 octobre 2006, au capital

social de trente et un mille Euros (31.000.- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de
cent Euros (100 EUR) par action

se trouve à partir de la date du 15 septembre 2010 définitivement liquidée,
l’assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 15 mars 2010 aux termes de laquelle la

Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège

social de la Société dissoute, en l’occurrence au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 28 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129194/28.
(100146997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Same Day Consulting, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 81.552.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STRATEGO INTERNATIONAL SàRL
Fiduciaire

Référence de publication: 2010129139/11.
(100147042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

112693

L

U X E M B O U R G

Admiral Institutional S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.125,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 122.644.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 2 août 2010, a décidé d'accepter:
- La nomination en qualité de gérant avec effet immédiat au 2 août 2010 de Nicole Götz, née à Brackenheim (Allemagne)

le 04 juin 1967, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

- La démission en qualité de gérant avec effet immédiat au 2 août 2010 de Christophe Cahuzac, né à Saint Mard

(Belgique) le 26 octobre 1972, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 2 août 2010, composé comme suit:
- Gerard MEIJSSEN
- Véronique MENARD
- Nicole GOTZ
- Maxime NINO
- Michael FURTH

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Maxime Nino
<i>Manager

Référence de publication: 2010129825/23.
(100147066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

WSI Education S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.609.300,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 105.793.

EXTRAIT

Il ressort d'une convention de transfert de parts sociales exécutée en date du 28 juillet 2010 entre WSI Holdings

Limited et Longman Group (Overseas Holdings) Limited que les soixante quatre mille trois cent soixante douze (64.372)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq euros (Euros 25,00) chacune, ont été transférées de WSI Holdings
Limited à Longman Group (Overseas Holdings) Limited, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à
Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2JE, Royaume-Uni, et enregistrée auprès du registre des sociétés d'Angleterre et
du Pays de Galles, sous le numéro 690236.

L'associé unique de la Société est depuis le 28 juillet 2010:
- Longman Group (Overseas Holdings) Limited, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Edinburgh

Gate, Harlow, Essex CM20 2JE, Royaume-Uni, et enregistrée auprès du registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de
Galles, sous le numéro 690236.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 28 septembre 2010.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature

Référence de publication: 2010129196/27.
(100147046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

112694

L

U X E M B O U R G

Same Day Consulting, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 81.552.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STRATEGO INTERNATIONAL SàRL
Fiduciaire

Référence de publication: 2010129140/11.
(100147043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Vasudevam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 140.331.

Le bilan au 31 DECEMBRE 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clémency, le 28 septembre 2010.

SV SERVICES S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010129186/12.
(100147116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Barton's Reitplatzbau Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3514 Dudelange, 43, route de Kayl.

R.C.S. Luxembourg B 86.968.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010129309/10.
(100146967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Credit Agricole Private Equity Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 132.220.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010129316/10.
(100147112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Huang Holding Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.096.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

„ Par jugement du 15 Juillet 2010, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6 

ème

 chambre, siègeant en matière

commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

HUANG HOLDING COMPANY S.A. (No. RCS. B 77 096) L-2449 Luxembourg 11, Boulevard Royal, siège dénoncé

le 17 février 2005.

Les livres et documents sociaux desdites sociétés sont déposés à l'adresse L-1540 Luxembourg, 36, rue Benjamin

Franklin, et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

112695

L

U X E M B O U R G

Ces mêmes jugements ont mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Me Dogan DEMIRCAN
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2010129333/19.
(100146974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

IIF Int'l Equity Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 138.697.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010129336/10.
(100147117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Aero Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 170.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 124.660.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 2 août 2010, a décidé d'accepter:
- La nomination en qualité de gérant avec effet immédiat au 2 août 2010 de Nicole Götz, née à Brackenheim (Allemagne)

le 04 juin 1967, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

- La démission en qualité de gérant avec effet immédiat au 2 août 2010 de Christophe Cahuzac, né à Saint Mard

(Belgique) le 26 octobre 1972, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 2 août 2010, composé comme suit:
- Gerard MEIJSSEN
- Véronique MENARD
- Nicole GÖTZ
- Maxime NINO
- Michael FURTH

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Maxime Nino
<i>Manager

Référence de publication: 2010129826/23.
(100147071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

NSH Capital Funding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 148.900.

Lors du conseil d'administration tenu en date du 19 août 2010, les décisions suivantes ont été prises:
- Démission de Monsieur Luke Jagger, avec adresse au 29, Providence Square, SE1 2EA Londres, Royaume-Uni, de son

mandat d'administrateur, avec effet rétroactif au 19 mai 2010.

- Cooptation de Monsieur Elliott Morley, avec adresse au 16, Park Crescent, Elstree, WD6 3PU Herts, Royaume-Uni,

en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Luke Jagger, administrateur démissionnaire. La ratification de sa
cooptation se fera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels se terminant au 31 mars
2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

112696

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 17 septembre 2010.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2010129922/20.
(100146994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

IIF Int'l Debt Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 136.354.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010129337/10.
(100147114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

IIF LuxCo1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 130.914.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010129338/10.
(100147118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

IIF LuxCo2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 130.912.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010129339/10.
(100147115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Falcon Mines S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R.C.S. Luxembourg B 39.774.

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 septembre 2010:
1. Acceptation de la démission de
- Mr Navaid Burney;
au poste d'administrateur de la Société en date du 13 novembre 2009.
2. Acceptation de la démission de
- Mr Craig Ian Campbell;
au poste d'administrateur de la Société en date du 21 juillet 2010.
3. Nominations de
- Mr. Ian Robert Saunders, administrateur de sociétés, né le 14 février 1967 à Gweru (Zimbabwe), demeurant à 38,

Essex Rd, Hillside, Bulawayo, Zimbabwe,

- Mr. Robert Neal Weingarten, administrateur de sociétés, né le 13 avril 1952 à California, United States of America,

demeurant à 5439 Lockhurst Drive, Woodland Hills, California 91367, United States of America,

112697

L

U X E M B O U R G

aux postes d'administrateurs de la Société avec effet au 17 juin 2010, jusqu'au 18 juin 2013;

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2010129869/24.
(100146972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 147.279.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/09/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010129374/10.
(100146769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka I Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 120.510.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/09/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010129375/10.
(100146901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 120.506.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/09/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010129376/10.
(100146893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka II Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 120.511.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/09/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010129377/10.
(100146902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 120.507.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/09/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010129378/10.
(100146895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

112698

L

U X E M B O U R G

D.P. Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4710 Pétange, 156, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg B 62.455.

L'an deux mil dix, le seize septembre.
Pardevant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Abdallah BENJEAA, né à Salé (Maroc), le 5 octobre 1959, demeurant à B- 6791 Athus, Quartier Schlauss

numéro 5, (propriétaire de 49 actions), agissant en nom personnel et au nom et pour compte de:

Monsieur Jean-Paul MARANGONI, né à Charleroi (B), le 4 décembre 1958, demeurant à B- 4040 Herstal, rue Nicolas

Defraîcheux, numéro 146, (propriétaire de 1 action),

en vertu d'une procuration annexée au présent acte.
agissant en leurs qualité d'uniques actionnaires de la société D.P. CONSULT S.A.. avec siège à L- 4710 Pétange, 156,

rue d'Athus (RCS B No 62.455), constituée suivant acte notarié du 18 décembre 1997, publié au Mémorial C No 235 du
10 avril 1998,

Lesquels comparants ont requis le notaire de documenter les modifications suivantes:
1. Augmentation de capital de € 13,31- € pour le porter de son montant actuel de € 30.986,69.- € à € 31.000.- € par

un versement en espèces

Suite à cette modification l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00) représenté par cinquante (50) actions

d'une valeur nominale de six cent vingt euros (EUR 620,00) chacune.

2. Modification de l'objet social
Les comparants entendent donner la teneur suivante à l'article 4 des statuts:

Art. 4. La société a pour objet:
- l'exploitation d'une agence générale d'assurances, l'accomplissement de toute opération d'assurances et d'intermé-

diaire  d'assurances,  la  gestion  de  portefeuilles  d'assurances  par  personnes  physiques  dûment  agréées,  ainsi  que  la
prestation de services y relatifs

- la prestation de travaux administratifs, l'organisation de services comptables et marketing, le conseil en ces matières,

la tenue de la comptabilité et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales, à
l'exception toutefois de travaux d'expertise comptable;

- ainsi que l'acquisition, l'échange, la vente, la location d'immeubles, bâtis ou non bâtis, la prise à bail, tant pour son

propre compte que pour compte de tiers.

La société peut également s'intéresser par voie d'apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entreprises

similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.

La société peut d'une façon générale faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou

immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension
ou le développement.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements

à d'autres personnes physiques ou morales.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de neuf cent dix euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: BENJEAA, D'HUART

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 21 septembre 2010.3 Relation: EAC/2010/11211. Reçu: soixante-quinze euros EUR

75.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME

Pétange, le 23 septembre 2010.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2010129856/52.
(100146675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

112699

L

U X E M B O U R G

Agence Heros S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SPC S.à r.l.).

Siège social: L-3441 Dudelange, 15, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 131.332.

L'an deux mil dix, le premier septembre.
Pardevant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Robert HÉROS, informaticien, né à Luxembourg, le 8 novembre 1962, demeurant à L-3441 Dudelange,

15, avenue Grande-Duchesse Charlotte;

2.- Mademoiselle Sandra SCHLINCKER, salariée, née à Dudelange le 20 juillet 1968, demeurant à L-3441 Dudelange,

15, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée "SPC S.à r.l.", avec siège social à L-3588

Dudelange,  5,  rue  de  Manom,  constituée  suivant  acte  reçu  par  le  notaire  instrumentant,  le  24  août  2007,  publié  au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2262 du 10 octobre 2007, ci-après la "Société",

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 131.332.
II.- Le capital social fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) est représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune, intégralement libérées et appartenant aux associés comme suit:

1) à Monsieur Robert HÉROS, prénommé, quatre-vingt-dix parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

2) à Mademoiselle Sandra SCHLINCKER, prénommée, dix parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

III.- Ensuite, Mademoiselle Sandra SCHLINCKER, prénommée, déclare par les présentes céder et transporter, sous

les garanties ordinaires de fait et de droit, les dix (10) parts sociales qu'elle détient de la Société à Monsieur Robert
HÉROS, prénommé, qui accepte, moyennant le prix global de un euro (EUR 1.-), somme que la cédante reconnaît avoir
reçue du cessionnaire dès avant la signature des présentes et en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont
bonne et valable quittance.

IV.- Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.
Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.
Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la Société et renonce à toute

garantie de la part de la cédante.

V.- Ensuite, Monsieur Robert HÉROS, prénommé, représentant comme seul et unique associé l'intégralité du capital

social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite à la susdite cession de parts sociales, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, pour

lui donner la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.

Les cent (100) parts ont été souscrites par Monsieur Robert HÉROS, informaticien, né à Luxembourg, le 8 novembre

1962, demeurant L-3441 Dudelange, 15, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.".

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination de la Société en "AGENCE HEROS S.à r.l." et de modifier par

conséquent l'article 1er des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

"La société prend la dénomination de "AGENCE HEROS S.à r.l.".".

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société et de modifier par conséquent l'article 3 des statuts de

la société qui aura dorénavant la teneur suivante:

"La société a pour objet l'exploitation d'une agence d'assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment

agréées.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.".

112700

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-3588 Dudelange, 5, rue de Manom, à L-3441

Dudelange, 15, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

VI.- Monsieur Robert HÉROS, prénommé, agissant en sa qualité de gérant unique de la Société, déclare se tenir, au

nom de la Société, la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.

VII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de huit cents

euros (EUR 800.-) sont à charge de la Société qui s'y oblige, l'associé unique en étant solidairement tenu envers le notaire.

VIII.- Les comparants élisent domicile au siège de la Société.
IX.- L'associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le

bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/ droits ayant servi à la libération
du capital social n'ont pas provenu d'activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(blanchiment) ou d'actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme),
respectivement que la société ne se livre pas à des activités ci-dessus émargées.

DONT ACTE,fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l'Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le Notaire.

Signé: Robert HÉROS, Sandra SCHLINCKER, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 02 septembre 2010. Relation: LAC/2010/38383. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions C.

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 septembre 2010.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2010129943/79.
(100146729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Aida Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 142.053.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 2 août 2010, a décidé d'accepter:
- La nomination avec effet immédiat au 2 août 2010 de Nicole Götz en qualité de gérant de la Société, née à Brackenheim

(Allemagne) le 04 juin 1967, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

- La démission avec effet immédiat au 2 août 2010 de Christophe Cahuzac en qualité de gérant de la Société, né à Saint

Mard (Belgique) le 26 octobre 1972, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 2 août 2010, composé comme suit:
- Gerard MEIJSSEN
- Véronique MENARD
- Nicole GÖTZ
- Maxime NINO
- Michael FURTH

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Maxime Nino
<i>Manager

Référence de publication: 2010129828/23.
(100147072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

112701

L

U X E M B O U R G

Transfroid Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 144.346.

L'an deux mille dix, le trente août.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TRANSFROID EUROPE

S.A." (numéro d'identité 2008 22 38 450), avec siège social à L-3598 Dudelange, 13, route de Zoufftgen, inscrite au R.C.S.L.
sous le numéro B 144.346, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 décembre 2008, publié
au Mémorial C, numéro 350 du 17 février 2009.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-

gique).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Miranda JANIN, employée privée, demeurant à Belvaux.
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de L-3598 Dudelange, 13, route de Zoufftgen à L-3895 Foetz, 8, rue du Commerce et

modification subséquente du 1 

er

 alinéa de l'article 2 et du 1 

er

 alinéa de l'article 15 des statuts.

2) Administrateurs.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-3598 Dudelange, 13, route de Zoufftgen à L-3895 Foetz, 8, rue

du Commerce.

<i>Deuxième résolution

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 et le

premier alinéa de l'article 15 des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:

«  Art. 2. al. 1 

er

 .  Le siège de la société est établi à Foetz.»

«  Art. 15. al. 1 

er

 .  L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Foetz, tel qu'indiqué

dans la convocation, le troisième mardi du mois de juin à 14.00 heures.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de révoquer Messieurs Patrick GEORGEL et Pierre-Laurent RIVARA comme administrateurs et

Monsieur Didier GEORGEL comme administrateur, respectivement administrateur-délégué de la société et de leur don-
ner décharge pour l'exercice de leurs mandats.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs:
a) Monsieur Romuald LAMBOLEY, salarié, né à Remiremont (France) le 21 septembre 1975, demeurant à F-70300

Luxeuil, 5, rue Marquiset;

b) Madame Sonia GEORGEL, salariée, née à Nancy (France) le 10 octobre 1977, demeurant à F-54850 Mereville, 7,

rue du Pressoir;

c) Monsieur Patrick SZKUTA, retraité, né à Jarville-la-Malgrange (France) le 28 juillet 1949, demeurant à F-54170

Colombey-les-Belles, 10, Clos d'Aleine.

Par dérogation à l'article 11 des statuts, l'assemblée décide de nommer Monsieur Romuald LAMBOLEY, préqualifié,

en qualité d'administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle.

Les mandats des administrateurs, respectivement administrateur-délégué ainsi nommés expireront immédiatement

après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

112702

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des

présentes, s'élèvent approximativement à neuf cents euros (€ 900.-).

DONT ACTE., fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J.M. WEBER, JANIN, RENTMEISTER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 2 septembre 2010. Relation: CAP/2010/3064. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur

 (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Bascharage, le 24 septembre 2010.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2010129947/66.
(100146711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

GSLP I Onshore (Brenntag) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 141.167.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 16 septembre 2010, a décidé d'accepter:
- la démission de Christophe Cahuzac en qualité de gérant de classe A de la Société avec effet au 2 août 2010.
- La nomination avec effet au 2 août 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de classe A de la

Société de Nicole Götz, née à Brackenheim (Allemagne) le 4 Juin 1967, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du
Fossé, L-1536 Luxembourg.

- La nomination avec effet au 2 août 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de classe B de la

Société, de Véronique Menard, née à Le Loroux-Bottereau (France) le 2 octobre 1973, et résidant professionnellement
au 133 Peterborough Court, Fleet Street, GB - EC4A 2BB London, Royaume-Uni.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 2 août 2010, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant A
- Maxime NINO, gérant A
- Michael FURTH, gérant B
- Eric GOLDSTEIN, gérant B
- Véronique MENARD, gérant B

<i>Pour la Société
Maxime Nino
<i>Gérant

Référence de publication: 2010129878/25.
(100147086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Fintime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 76.257.

Le Bilan au 30.06.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010128964/10.
(100147101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

112703

L

U X E M B O U R G

Malcolm &amp; Peter International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 108.563.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 13 septembre 2010, les mandats des ad-

ministrateurs de catégorie A, Monsieur Flavio BORGNA, VALON S.A., LANNAGE S.A. et KOFFOUR S.A., ainsi que
celui du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. ont été renouvelés pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de l'an 2016.

Luxembourg, le 23 SEP. 2010.

<i>Pour: MALCOLM &amp; PETER INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2010129914/17.
(100146982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Kamea International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 97.440.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du Conseil d'Administration prise par voie circulaire en conformité avec les articles 2 § 2 et

10 § 8 des Statuts de la Société en date du 7 septembre 2010 que:

Le siège social de la société est transféré du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 412F, route d'Esch,

L-2086 Luxembourg à compter du 7 septembre 2010.

Et que l'adresse d'un Administrateur est modifiée de la façon suivante:
- Madame Mireille GEHLEN, est domiciliée professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010129906/17.
(100147108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

J. Safra I.P. Holding Co., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 98.071.

<i>Dépôt rectificatif de l'extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 février 2008 déposé en date du 1 

<i>er

<i>avril 2008 sous la référence L080047976.05

Veuillez être informé qu'une erreur c'est produite lors de la nomination de M. Jorge KININSBERG en tant qu'Admi-

nistrateur de catégorie A et que l'adresse professionnelle exacte est:

10A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 6 septembre 2010.

Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliataire
Représenté par M. Matthijs BOGERS
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2010129902/17.
(100146810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

112704


Document Outline

Admiral Institutional S.à r.l.

Aero Investment S.à r.l.

Agence Heros S.à r.l.

Aida Holdings S.à r.l.

ANNA Real Estate 3 S.à r.l.

ANNA Real Estate 4 S.à r.l.

ANNA Real Estate 5 S.à r.l.

ANNA Real Estate 6 S.à r.l.

ANNA Real Estate 7 S.à r.l.

ANNA Real Estate GP S.à r.l.

AutoArc Holding S. à r. l.

AXA Mezzanine II S.A., SICAR

Barton's Reitplatzbau Sàrl

Boris XC 90 S.A.

Credit Agricole Private Equity Luxembourg

D.P. Consult S.A.

Exalog S.A.

Fairacre Properties (Lux) 5 S.à r.l.

Falcon Mines S.A.

Final S.A.

Fintime S.A.

Funcom S.à r.l.

GSLP I Offshore C (Brenntag) S.à r.l.

GSLP I Onshore (Brenntag) S.à r.l.

Huang Holding Company S.A.

Hyta Invest S.A.

Hyta Invest S.A.

IIF Int'l Debt Investments S.à r.l.

IIF Int'l Equity Investments S.à r.l.

IIF LuxCo1 S.à r.l.

IIF LuxCo2 S.à r.l.

InterAtoz

J. Safra I.P. Holding Co.

Kamea International S.A.

Malcolm &amp; Peter International Holding S.A.

MD Mezzanine S.A., SICAR

MLAnna Real Estate 3 S.à r.l.

MLAnna Real Estate 4 S.à r.l.

MLAnna Real Estate 5 S.à r.l.

MLAnna Real Estate 6 S.à r.l.

MLAnna Real Estate 7 S.à r.l.

MLAnna Real Estate GP S.à r.l.

NSH Capital Funding (Luxembourg) S.A.

OCM Luxembourg Nordenia POF S.à r.l.

OCM / Nordenia POF Luxembourg S.C.A.

Orion Finance III Luxembourg S.à r.l.

Orion Finance II Luxembourg S.à r.l.

Pentagon Holdings S.à r.l.

Same Day Consulting

Same Day Consulting

Shield Topco S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care X S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka I Alpha S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka II Beta S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka II S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka I S.à r.l.

SPC S.à r.l.

SPE 2 Berlin

Sunrise Global S.A.

Thema Production S.A.

Transfroid Europe S.A.

Vasudevam S.A.

Wallbridge Real Estate S.A.

WSI Education S.à r.l.