This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1661
16 août 2010
SOMMAIRE
AM HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79686
Aura International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
79684
BPT Hansa Lux SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . .
79694
Café Schlassstuff S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
79709
Capgro Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79685
Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79685
Diam International II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
79713
Energy and Infrastructure Management
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79686
Fashion Investment Holdings S.A. . . . . . . .
79689
Fides et Spes Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79691
Fides Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
79694
Fragrance Resources Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79691
Franzen und Brandt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79708
Freighter Leasing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79691
Green-Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79711
Green Way Arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79709
Hollywood Investments S.A. . . . . . . . . . . . .
79711
Immo-Nord Guy Kartheiser S.A. . . . . . . . .
79711
Infotime Analyse Concept S.A. . . . . . . . . . .
79713
Inkosi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79713
Inversiones Sociosanitarias S.à r.l. . . . . . . .
79721
Investissements Minéraux et Financiers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79721
IW Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79721
Jamalux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79682
Jardipal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79723
JM Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79723
JPMorgan Asset Management Holdings
(Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79723
J.P. Morgan Capital Holdings Limited . . . .
79722
J.P. Morgan Luxembourg International S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79722
Karal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79724
Key Plastics Automotive Europe S.àr.l. . .
79724
Kmind International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
79712
KP Automotive S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79724
Kyra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79725
Liparus Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79723
Lony Finance & Investment S.A. . . . . . . . . .
79725
Luxmarine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79725
Mac Aniaut SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79726
Mamiom Technologies S.A. . . . . . . . . . . . . .
79726
Marco Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79722
Metzeler Automotive Profile Systems S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79725
MGM Carbon Portfolio S.à.r.l. . . . . . . . . . . .
79726
Milestone International S.à r.l. . . . . . . . . . .
79726
Milestone International S.à r.l. . . . . . . . . . .
79727
Mistral E.E. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79727
Moltech Invent S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79727
Morgan Stanley Semaine S.à r.l. . . . . . . . . .
79725
Nehr & Sohne S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79721
Neuheim Lux Group Holding V . . . . . . . . .
79728
Newcontainer Management Services S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79728
Newcontainer Management Services S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79728
Nexis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79682
Northland Resources S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
79726
Opera Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
79727
Peronica S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79683
Projekt A2 SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79683
Property Projects S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
79728
Timolux Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
79724
Topco I, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79689
TPG Sonic V A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79689
Weisen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79685
Xaltys S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79691
79681
L
U X E M B O U R G
Jamalux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 123.598.
<i>Auszug aus dem Protokoll Ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 1. Juni 2010i>
Die Hauptversammlung beschließt einstimmig:
1. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt den Gesellschaftssitz der Gesellschaft von L-1528 Luxemburg,
16A, Boulevard de la Foire nach L-1330 Luxemburg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, zu verlegen.
2. Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt den Rücktritt von Herrn Pierre Berna als Verwaltungsratsmitglied der
Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2010 an.
3. Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt den Rücktritt von Herrn Gregory Mathis als Verwaltungsratsmitglied
der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2010 an,
4. Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt den Rücktritt von Frau Anabela Fonseca als Verwaltungsratsmitglied
der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2010 an.
5. Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt den Rücktritt von Herrn Jean Thyssen als Rechnungsprüfer der Ge-
sellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2010 an.
6. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Ernennung mit sofortiger Wirkung von Herrn Jérôme Wunsch,
geboren zu Luxemburg am 14. Juli 1959, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in L-1330 Luxemburg, 34A, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, zum Verwaltungsratsmitglied bis zur Jahreshauptversammlung im Jahr 2016.
7. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Ernennung mit sofortiger Wirkung von Herrn Dr. Peter Ha-
macher, geboren zu Aachen (Deutschland) am 22. Juni 1966, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in L-1330 Luxemburg,
34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, zum Verwaltungsratsmitglied bis zur Jahreshauptversammlung im Jahr 2016.
8. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Ernennung mit sofortiger Wirkung von Herrn Alexander
Mayer-Groth, Rechtsanwalt, geboren am 1. August 1974 in Löffingen (Deutschland), mit Berufsanschrift in D-22769
Hamburg, 26, Haferweg zum Verwaltungsratsmitglied bis zur Jahreshauptversammlung im Jahr 2016.
9. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Ernennung mit sofortiger Wirkung von Herrn François Geor-
ges, geboren zu Luxemburg am 21. März 1967, expert-comptable, mit Berufsanschrift in L-1330 Luxemburg, 34A,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, zum Rechnungsprüfer (Commissaire aux comptes) bis zur Jahreshauptversamm-
lung im Jahr 2016.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, 1. Juni 2010.
JAMALUX S.A.
Alexander-Mayer-Groth / Jérôme Wunsch
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratimitgliedi>
Référence de publication: 2010079514/37.
(100090962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2010.
Nexis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1218 Luxembourg, 22, rue Baudouin.
R.C.S. Luxembourg B 78.837.
EXTRAIT
Les actionnaires de la société NEXIS S.A. se sont réunis en assemblée générale ordinaire en date du 24 juin 2010 et
ont pris la décision suivante:
Maître Felix Laplume, avocat à la cour, né le 2 février 1961 à Dudelange, avec adresse professionnelle à L-2324 Lu-
xembourg, 6, Avenue J-P Pescatore est désigné représentant permanent de la société Hawkins Financial Corporation au
Conseil d'administration de notre société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
79682
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 24 juin 2010.
Felix Laplume
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2010080664/17.
(100090912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2010.
Projekt A2 SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 139.121.
<i>Auszug aus dem Protokoll Ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 1. Juni 2010i>
Die Hauptversammlung beschließt einstimmig:
1. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt den Gesellschaftssitz der Gesellschaft von L-1528 Luxemburg,
16A, Boulevard de la Foire nach L-1330 Luxemburg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, zu verlegen.
2. Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt den Rücktritt von Herrn Pierre Berna als Verwaltungsratsmitglied der
Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2010 an.
3. Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt den Rücktritt von Herrn Gregory Mathis als Verwaltungsratsmitglied
der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2010 an.
4. Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt den Rücktritt von Frau Anabela Fonseca als Verwaltungsratsmitglied
der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2010 an .
5. Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt den Rücktritt von Herrn Jean Thyssen als Rechnungsprüfer der Ge-
sellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2010 an .
6. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Ernennung mit sofortiger Wirkung von Herrn Jérôme Wunsch,
geboren zu Luxemburg am 14. Juli 1959, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in L-1330 Luxemburg, 34A, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, zum Verwaltungsratsmitglied bis zur Jahreshauptversammlung im Jahr 2016.
7. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Ernennung mit sofortiger Wirkung von Herrn Dr. Peter Ha-
macher, geboren zu Aachen (Deutschland) am 22. Juni 1966, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in L-1330 Luxemburg,
34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, zum Verwaltungsratsmitglied bis zur Jahreshauptversammlung im Jahr 2016.
8. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Ernennung mit sofortiger Wirkung von Herrn Alexander
Mayer-Groth, Rechtsanwalt, geboren am 1. August 1974 in Löffingen (Deutschland), mit Berufsanschrift in D-22769
Hamburg, 26, Haferweg zum Verwaltungsratsmitglied bis zur Jahreshauptversammlung im Jahr 2016.
9. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Ernennung mit sofortiger Wirkung von Herrn François Geor-
ges, geboren zu Luxemburg am 21. März 1967, expert-comptable, mit Berufsanschrift in L-1330 Luxemburg, 34A,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, zum Rechnungsprüfer (Commissaire aux comptes) bis zur Jahreshauptversamm-
lung im Jahr 2016.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, 1. Juni 2010.
PROJEKT A2 S.A.
Alexander-Mayer-Groth / Jérôme Wunsch
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitgliedi>
Référence de publication: 2010079570/37.
(100090920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2010.
Peronica S. à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 35.981.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés 31 mai 2010.i>
L'Assemblée des associés a décidé à l'unanimité, de nommer Monsieur Carlo Fischbach, comme liquidateur de la
société. Suite à cette nomination, le pouvoir de signature est arrêté comme suit: les liquidateurs, Monsieur Flemming
Pedersen, demeurant à Luxembourg, 32, avenue du Bois et Monsieur Carlo Fischbach, demeurant à Luxembourg, 20, rue
des Tilleuls, agissent avec signature conjointe. Les autres pouvoirs de signature, décidé le dix-huit décembre 1998, reste
inchangés.
79683
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 25 juin 2010.
<i>Pour Peronica S.à r.l.
i>Fiduciaire des Classes Moyennes
Signature
Référence de publication: 2010080669/17.
(100090770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2010.
Aura International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 121.043.
L'an deux mille dix, le quatorze juin.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph
ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. actuellement empêché, lequel aura la
garde de la présente minute.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AURA INTERNATIONAL S.A.",
ayant son siège social à Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 121.043, constituée suivant acte reçu le 18 juillet 2006, publié au
Mémorial C numéro 2324 du 13 décembre 2006.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par la présidente, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l’ordre du jour adressées par recommandé
aux actionnaires le 4 juin 2010.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence, que sur les 17.275 actions, actuellement émises, 16.350 actions sont pré-
sentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régulière-
ment constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Mise en liquidation;
2. Nomination du liquidateur et pouvoirs attribués;
3. Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolution:i>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
la société Amadeus Solutions, ayant son siège social à Edificio P.H. Plaza 2000, Calle 50, Panama City.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale
dans les cas où elle est requise.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant
meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
79684
L
U X E M B O U R G
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. UHL, H. JANSSEN, M. SCHAEFFER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 juin 2010. Relation: LAC/2010/26523. Reçu douze euros (12.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur sa demande
Luxembourg, le 21 juin 2010.
Référence de publication: 2010080165/60.
(100091075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 150.967.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 28 juin 2010.
Référence de publication: 2010080209/10.
(100091497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Capgro Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 62.035.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2010.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2010080223/12.
(100091507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Weisen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8001 Strassen, 2, rue du Cimetière.
R.C.S. Luxembourg B 14.583.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à 8001 Strassen, rue du Cimetière, BP 2,i>
<i>le 1 i>
<i>eri>
<i> juin 2010i>
Nominations statutaires.
Le mandat de commissaire-réviseur de ERNST & YOUNG vient à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
de ce 1
er
juin 2010.
L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire-réviseur de ERNST & YOUNG représenté par Monsieur
Werner WEYNAND, pour un terme d'un an, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2011.
Le Conseil d'administration est constitué comme suit:
- Monsieur Adrien SEGANTINI, Administrateur-délégué dont le mandat d'administrateur viendra à échéance à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire de 2012 et le mandat d'administrateur-délégué à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
de 2012.
- Monsieur Vincent DESCOURS, Administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2012.
- Monsieur Louis MARTIN , Administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2012.
79685
L
U X E M B O U R G
Le 1.06.2010.
Pour extrait conforme
Adrien SEGANTINI
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2010081660/26.
(100091518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Energy and Infrastructure Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 113.029.
<i>Extrait des délibérations de l’Associé unique du 28 juin 2010i>
L’associé unique a décidé de nommer avec effet immédiat Madame Barbara WEBER (résidant à CH-8044 ZURICH,
108, Susenbergstrasse) et Monsieur Benno FLURY (résidant à CH-4003 BÂLE, 41, Steinergraben) en qualité de Gérant
Delegué jusqu’à l’assemblée générale 2011.
L’associé unique, AIL STRUCTURED FINANCE LTD (ayant son siège social à CH-8050 ZÜRICH, 418, Schaffhausers-
trasse) confirme par ailleurs qu'il a racheté les 625 actions de Caperis AG et qu'il est désormais le seul actionnaire de la
société détenant les 1.250 actions actuellement en circulation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2010.
Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
<i>Fondé de Pouvoiri>
Référence de publication: 2010080253/18.
(100091465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
AM HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 152.762.
In the year two thousand ten, on the twenty-seventh of May.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),
there appeared:
1. the company «ArcelorMittal Spain Holding SL», having its registered office at Calle Albacete No.3, 28027 Madrid,
Spain, registered with the Register of Commerce and Companies of Madrid under number T20517; F-117;H-363161;
Insc-5.
represented by Mrs Linda QEQEH, Legal Counsel, with professional address at 19 avenue de la Liberté, L-2930 Lu-
xembourg, by virtue of a proxy given in Madrid on May 24, 2010; and
2. the company «ArcelorMittal France», having its registered office at 1A 5 rue Luigi Cherubini, F-93200 St Denis,
registered with the Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny under number 562 094 425,
represented by Mrs Bérangère POIRIER, LegalCounsel, with professional address at 19 avenue de la Liberté, L-2930
Luxembourg, by virtue of a proxy given in St-Denis on May 21, 2010.
The above mentioned proxies, signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, will remain an-
nexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, as represented here above, are the sole partners of “AM HoldCo S.à r.l.”, (hereinafter the
“Company”) a société à responsabilité limitée, having its registered office at 19, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
registered with the Trade and Company Register in Luxembourg under Section B, number 152 762, incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary on 9 April 2010, not yet published in the Memorial C. The articles of incorporation
have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary on 21 May 2010, not yet published on the Memorial
C.
The same appearing parties representing the whole corporate capital require the undersigned notary to act the fol-
lowing resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting resolved to increase the share capital of the Company by an amount of sixty-nine
thousand five hundred and three euro (69.503.- EUR) in order to raise it from its current amount of forty-two thousand
eight hundred and ninety-six euro (42.896.- EUR) to an amount of one hundred and twelve thousand three hundred and
ninety-nine euro (112.399.- EUR).
79686
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting resolved to issue sixty-nine thousand five hundred and three (69.503) new addi-
tional shares with a par value of one euro (1.- EUR) per share, having the same rights and privileges attached as the existing
shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the
proposed capital increase.
<i>Subscription - Payment - Allotmenti>
There now appears Mrs Linda QEQEH, previously named, acting in his capacity as duly authorised attorney in fact of
“ArcelorMittal Spain Holding SL”, previously named, declares to subscribe in the name and on behalf of “ArcelorMittal
Spain Holding SL” for the sixty-nine thousand five hundred and three (69.503) new shares with a par value of one euro
(1.- EUR) each and to make payment in full of the par value of each of such new share, by a contribution in kind which
consists in fifty-five million nine hundred and one thousand four hundred and forty-nine (55.901.449) shares in “Arce-
lorMittal Inox Brazil S.A.”, a company governed under the laws of Brazil, having its registered office at Avenida Carandai,
1115, 23° andar, Bairro Funcionarios, 30130-915 Belo Horizonte- Minas Gerais, Brazil and registered with the Brazilian
Trade and Companies registry under number 33.390.170/0001-89 (the “AMIB Shares”).
The subscriber acting trough his duly appointed attorney in fact declared that there subsist no impediments to the
free transferability of the Contribution to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions
have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of
the Contribution to the Company as it is further evidenced in the contribution agreement dated May 19, 2010, which
contribution agreement will remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The value of the Contribution has been certified by a valuation report on May 19, 2010, which valuation report will
remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The total contribution of eight hundred and ninety-seven million six hundred and sixty-four thousand seven hundred
and fifty-six euro and eighteen cents (897,664,756.18 EUR) by “ArcelorMittal Spain Holding SL ” consists in sixty-nine
thousand five hundred and three euro (69.503,- EUR) for the capital and eight hundred and ninety-seven million five
hundred and ninety-five thousand two hundred and fifty-three euro and eighteen cents (897,595,253.18 EUR) for the
issue premium.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of such increase, article 5 of the Articles of Incorporation of the Company is amended and shall
now read as follows:
Art. 5. “The Company's subscribed share capital is fixed at one hundred and twelve thousand three hundred and ninety-
nine euro (112.399.- EUR), represented one hundred and twelve thousand three hundred and ninety-nine (112.399) shares
with a par value of one euro (1.- EUR) per share.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at six thousand five hundred euro.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the
above appearing persons, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date indicated at the beginning thereof.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by his surname, first name, civil status
and residence, said persons signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille dix, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg),
ont comparu:
- la société «ArcelorMittal Spain Holding SL», ayant son siège social à Calle Albacete No.3, 28027 Madrid, Espagne,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro T-20517; F117;H-363161; Insc-5,
ici représentée par Madame Linda QEQEH, Legal Counsel, avec adresse professionnelle au 19, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Madrid, le 24 mai 2010.
- la société anonyme «ArcelorMittal France», ayant son siège social au 1A 5 rue Luigi Cherubini, F-93200 St Denis,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 562 094 425,
ici représentée par Madame Bérangère POIRIER, Legal Counsel, avec adresse professionnelle au 19, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à St-Denis, le 21 mai 2010.
79687
L
U X E M B O U R G
Les procurations prémentionnées signées «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant resteront an-
nexées aux présentes pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes, représentées, comme il est précisé ci-avant, sont les seuls associés de «AM HoldCo
S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 19, avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 152
762, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 avril 2010, non encore publié au Mémorial C. Les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 mai 2010, non encore publié au Mémorial
C.
Les mêmes parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social de ladite Société ont requis le notaire
instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un
montant de soixante-neuf mille cinq cent trois euros (69.503.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de quarante-
deux mille huit cent quatre-vingtseize euros (42.896.- EUR) à un montant de cent douze mille trois cent quatre-vingt-dix
neuf euros (112.399.- EUR).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire a décidé d'émettre soixante-neuf mille cinq cent trois (69.503) parts sociales
supplémentaires d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts
sociales existantes et conférant droit aux dividendes à partir de la date de l'assemblée générale extraordinaire décidant
de la présente augmentation de capital.
<i>Souscription - Libération - Attributioni>
Ensuite Madame Linda QEQEH, prénommée, s'est présentée, agissant en sa qualité de mandataire de «ArcelorMittal
Spain Holding SL», prénommée, déclare souscrire au nom et pour le compte de «ArcelorMittal Spain Holding SL» les
soixante-neuf mille cinq cent trois (69.503) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune
et libérer intégralement la valeur nominale de chacune de ces parts sociales nouvelles par un apport en nature consistant
en cinquante-cinq millions neuf cent un mille quatre cent quarante-neuf (55.901.449) parts sociales de la société «Arce-
lorMittal Inox Brazil S.A.”, une société constituée et existant sous les lois du Brésil, établie et ayant son siège social Avenida
Carandai, 1115, 23° andar, Bairro Funcionarios, 30130-915 Belo Horizonte- Minas Gerais, Brésil et inscrite au Registre
de Commerce du Brésil sous le numéro 33.390.170/0001-89 (les “AMIB actions”).
Le souscripteur, agissant par son mandataire dûment nommé, déclare qu'il ne subsiste aucun obstacle à la libre cessi-
bilité de l'Apport à la Société qui s'effectue sans restrictions ou limitations et que des instructions valables ont été données
afin d'effectuer toute notification, tout enregistrement ou toute autre formalité nécessaires en vue d'effectuer un transfert
valable de l'Apport à la Société, comme en témoigne également un contrat d'apport daté du 19 mai 2010 qui restera
annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La valeur de l'Apport a été certifié par un rapport spécial daté du 19 mai 2010 lequel rapport spécial restera annexé
aux présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'apport total de huit cent quatre-vingt-dix-sept millions six cent soixante-quatre mille sept cent cinquante-six euros
dix-huit cents (897.664.756,18 EUR) de «ArcelorMittal Spain Holding SL» consiste en soixante-neuf mille cinq cent trois
euros (69.503.- EUR) pour le capital et en huit cent quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille deux
cent cinquante-trois euros dix-huit cents (897.595.253,18 EUR) à titre de prime d'émission.
<i>Troisième résolutioni>
A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 5 des statuts de la Société est modifié en conséquence et
aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. «Le capital social est fixé à cent douze mille trois cent quatre-vingt-dix neuf euros (112.399.- EUR); il est
représenté par cent douze mille trois cent quatre-vingt-dix neuf (112.399) parts sociales d'un euro (EUR 1.-) chacune.».
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à six mille cinq cents euros.
Le notaire soussigné qui a parfaite connaissance de la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande
des mêmes comparants faire foi en cas de divergences avec la version française.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom,
état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
79688
L
U X E M B O U R G
Signé: L. QEQEH, B. POIRIER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 02 juin 2010. Relation: EAC/2010/6454. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2010083508/144.
(100093868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2010.
Fashion Investment Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 107.732.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010080267/9.
(100091494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Topco I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TPG Sonic V A S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 137.112.
In the year two thousand and ten, on the eighteenth day of the month of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,
There appeared
TPG Opportunity Fund I, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware,
United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware
19801, United States of America, registered with the Secretary of State of Delaware under number 4682002, acting
through its general partner TPG Opportunities Advisors, Inc.
represented by Me Cintia Martins Costa, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 14 May
2010, being the sole shareholder and holding all the one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares in
issue in "TPG Sonic V A S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5D, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
number B 137.112, incorporated on 29
th
February 2008 by deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxem-
bourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 915 on 14
th
April 2008.
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 15
th
October 2008 by deed of
Me Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg published in the Mémorial number 2970 on 16
th
December 2008.
The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
(A) The sole shareholder holds all the shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on the
items of the agenda.
(B) The items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. Change of name of the Company into "Topco I, S.à r.l." and consequential amendment of article 1 of the articles of
association of the Company as set forth below:
" Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Topco I, S.à r.l." (the
"Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The
Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation"
2. Acknowledgement of the resignation of Ramzi Gedeon and Gary Douglas Puckett as class A managers of the Com-
pany with immediate effect and granting of full and total discharge to the resigning managers for the proper performance
of their duties.
Thereafter the following resolutions were passed:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolved to change the name of the Company into "Topco I, S.à r.l." and to
amend article 1 of the articles of association of the Company as set forth in the agenda.
79689
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company acknowledged the resignation of Ramzi Gedeon and Gary Douglas Puckett as
class A managers of the Company with immediate effect.
The sole shareholder of the Company resolved to grant full and total discharge to the resigning managers for the
proper performance of their duties.
There being no further item on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille dix, le dix-huit mai.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu
TPG Opportunity Fund I, L.P., un limited partnership constitué et existant sous les lois de l'Etat du Delaware, Etats-
Unis d'Amérique, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801,
Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4682002, agissant par son
general partner TPG Opportunities Advisors, Inc.,
représenté par Me Cintia Martins Costa, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée
du 14 mai 2010, étant l'associé unique et détenant toutes les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales
émises dans «TPG Sonic V A S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5D, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 137.112,
constituée le 29 février 2008 suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 915 du 14 avril 2008. Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois le 15 octobre 2008 suivant acte reçu par Maître Henry Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg, publié au Mémorial numéro 2970 du 16 décembre 2008.
La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
(A) L'associé unique détient toutes les parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent vala-
blement être prises sur les points portés à l'ordre du jour.
(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:
1. Changement de dénomination de la Société en «Topco I, S.à r.l.» et modification subséquente de l'article 1 des
statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la comparante et toutes les personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Topco I, S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie par les
présents statuts et les dispositions légales afférentes.»
2. Prise de connaissance de la démission de Ramzi Gedeon et Gary Douglas Puckett en tant que gérants de classe A
de la Société avec effet immédiat et décharge complète et totale donnée aux gérants démissionnaires pour la correcte
exécution de leurs obligations.
Ensuite, les résolutions suivantes ont été passées:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique de la Société a décidé de changer la dénomination de la Société en «Topco I, S.à r.l.» et de modifier
l'article 1 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur indiquée dans l'ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique de la Société a pris connaissance de la démission de Ramzi Gedeon et Gary Douglas Puckett en tant
que gérants de classe A de la Société avec effet immédiat.
L'associé unique de la Société a décidé de donner décharge complète et totale aux gérants démissionnaires pour la
correcte exécution de leurs obligations.
Plus rien ne figurant dans l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,
le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante,
en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
79690
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite, la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: C. MARTINS COSTA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 mai 2010. Relation: LAC/2010/23313. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 24 juin 2010.
Référence de publication: 2010083882/99.
(100093892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2010.
Fragrance Resources Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 81.420.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2010.
Référence de publication: 2010080273/11.
(100091049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Freighter Leasing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 121.986.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Freighter Leasing S.A.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2010080274/11.
(100091005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Fides et Spes Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 31.923.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010080276/9.
(100091531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Xaltys S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 154.202.
STATUTS
L'an deux mille dix, le sept juillet.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Axel PIÉRARD, sans état, né à Charleroi (Belgique), le 25 octobre 1966, demeurant à L-1631 Luxembourg,
55, rue Glesener.
79691
L
U X E M B O U R G
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’il déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de “XALTYS S.à
r.l.” (la "Société").
Art. 2. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée
générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à
l’étranger.
Art. 3. La Société a pour objet, tant au Grand Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, de fournir à toutes personnes
physiques ou morales, luxembourgeoises ou étrangères, la prestation de conseils et de services. Ces conseils et services
concernent des interventions en gestion d’entreprises et toutes prestations de services annexes ou complémentaires,
notamment sur la réorganisation et la restructuration d’entreprises, l’analyse financière, l’évaluation d’entreprises, la
gestion administrative ainsi que la formation.
La Société a également pour objet pour son propre compte ou pour compte de tiers, tant au Grand Duché de Lu-
xembourg qu’à l’étranger, la réalisation de toutes prestations de services intellectuels et matériels dans le domaine de
l'informatique, notamment les conseils en systèmes informatiques, la réalisation de logiciel, le traitement de données, les
activités de bases de données et tous autres services rattachés à l’informatique.
Elle pourra réaliser, acheter, vendre, louer à court terme tout logiciel (software) ainsi que tout matériel (hardware)
sous quel que forme que ce soit.
La Société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, ainsi que l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La Société pourra également, consentir des garanties, accorder des prêts ou assister autrement les sociétés dans
lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société
et exercer tout mandat d’administrateur de sociétés et toutes missions d’administration et de gestion.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la Société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille euros (30.000,- EUR), représenté par trois cents (300) parts sociales
d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans la distribution des
bénéfices.
Art. 7.
a) La cession entre vifs:
Au cas où la Société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la Société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition
de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.
En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont
applicables.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
79692
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la Société et aux décisions des assemblées générales.
Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par décision de l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations, ainsi que la durée de leur mandat.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la Société, dans
la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la Société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement
de son objet social.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut se
faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 14. Lorsque la Société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée
des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa premier sont inscrites sur un procès-verbal ou
établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est applicable qu’aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.
L’Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la Société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.
L’associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la Société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements
de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, jusqu'à ce
que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de
la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés et révocables par l'assemblée générale des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée.
Art. 18. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la ou les parties s'en réfèrent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.
<i>Souscription et libération du capital sociali>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les trois cents (300) parts sociales ont été souscrites par l'associé
unique Monsieur Axel PIÉRARD, préqualifié, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement
en numéraire, de sorte que la somme de trente mille euros (30.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition
de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de mille Euros (1.000.- EUR).
79693
L
U X E M B O U R G
<i>Résolutions prises par l'associée uniquei>
Et aussitôt, le comparant pré-mentionné, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions
suivantes en tant qu'associé unique:
1. Le siège social est établi à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.
2. Monsieur Axel PIÉRARD, sans état, né à Charleroi (Belgique), le 25 octobre 1966, demeurant à L-1631 Luxembourg,
55, rue Glesener, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif la partie comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la partie comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à représentant de la partie comparante, ès-qualité qu'il agit, connu du
notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. PIERARD, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juillet 2010 LAC/2010/30493 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 14 juillet 2010.
Référence de publication: 2010093496/142.
(100104344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.
Fides Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 113.481.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010080277/9.
(100091490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
BPT Hansa Lux SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 122.072.
In the year two thousand and ten, on the twenty-fourth day of June.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an extraordinary general meeting of shareholders of BPT Hansa Lux SICAV-SIF (the "Company"), a société
anonyme qualifying as an investment company with variable share capital investment fund ("société d'investissement à
capital variable – fonds d'investissement spécialisé") with its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535
Luxembourg, incorporated under Luxembourg law by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg
on 23 October 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 58 of
26 January 2007. The articles of incorporation of the Company (the "Articles") have been amended for the last time
pursuant to a deed of the undersigned notary on 28 September 2009, published in the Mémorial number 2160 of 5
November 2009.
The extraordinary general meeting (the "Meeting") was opened by Mr Thomas Boening, private employee, professio-
nally residing in Luxembourg, in the chair.
The chairman appointed as secretary Ms Tania Araujo, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Ms Madeline Boucher, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to record that:
I. The extraordinary general meeting convened for 5 May 2010 could not validly deliberate and vote on the proposed
agenda due to a lack of quorum.
79694
L
U X E M B O U R G
II. The Meeting was convened by notices containing the agenda published on 18 May 2010 and 4 June 2010 in the
Mémorial, "La Voix" and the "Lëtzebuerger Journal" and by notices containing the agenda sent to every registered sha-
reholder by registered mail on 18 May 2010.
III. The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares held by each of them are shown
on an attendance list. The said list and proxies initialled "ne varietur" by the members of the bureau, the shareholders
present, the proxies of the represented shareholders and the notary will be annexed to this document, to be registered
with this deed.
IV. The agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the articles of incorporation by addition of a definition section as preliminary chapter of the articles
of incorporation.
2. Amendment of article 3 of the articles of incorporation so as to change the duration of the Company from currently
unlimited duration to a fixed term expiring on 3 May 2023.
3. Amendment of article 4 and 19 of the articles of incorporation so as to limit the location of the Company's investment
to Germany.
4. Amendment of article 6 of the articles of incorporation to allow the Board and the shareholders to access the
register of shareholders.
5. Amendment of article 7 of the articles of incorporation by deleting the reference to German Residents.
6. Amendment of article 8 of the articles of incorporation to inter alia limit the drawdown period for commitments
to 12 months.
7. Amendment of article 9 of the articles of incorporation to inter alia (i) include a provision for the listing of the
Company's shares, (ii) to change the redemption frequency and the determination of the redemption price and (iii) delete
the possibility to charge a redemption fee.
8. Amendment of article 13 of the articles of incorporation to provide for a minimum of 3 and maximum of 5 directors
of the Company.
9. Amendment of article 14 of the articles of incorporation to allow the convening of board meetings by 48 hours
prior notice.
10. Amendment of article 28 of the articles of incorporation to provide for a 90% majority for the amendment of
certain articles of the articles of incorporation.
11. Amendment of article 11, 22 and 24 of the articles of incorporation to correct typing errors.
V. It appears from the attendance list that 11,86% of the Company's issued share capital at the date of the Meeting are
present or represented at the Meeting.
VI. Pursuant to article 22 of the Articles, decisions at the Meeting will be taken by a majority vote of 75% of the votes
cast at the Meeting, no quorum being required, as the extraordinary general meeting held on 5 May 2010 could not validly
deliberate due to a lack of quorum.
VII. As result of the foregoing, the Meeting is regularly constituted and may validly deliberate and vote on the items of
the agenda.
After deliberation, the Meeting takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves by 27,926 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions to add a definitions section as
preliminary chapter of the Articles to read as follows:
"Preleminary chapter - Definitions
Articles or Articles of
Association
Means the articles of association of the Company.
Base Currency
Means the Euro (EU R).
Board / Board of Directors
Means the board of directors of the Company, as appointed from time to time.
BPT AM DK
Baltic Property Trust Asset Management A/S, Denmark.
BPT AM
BPT Asset Management A/S or BPT Asset Management Germany GmbH, the wholly-
owned subsidiary of BPT AM DK.
Business Day
A day on which banks are open for business in Luxembourg.
Closing
The date (or dates) determined by the Board of Directors to which subscription
agreements have to be received and accepted by the Board of Directors.
Company
BPT Hansa Lux SICAV-SIF, a company incorporated under the form of a public com-
pany limited by shares ("société anonyme") under the laws of Luxembourg and
79695
L
U X E M B O U R G
qualifying as a société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spé-
cialisé under the SIF Law.
Commitment(s)
The total investment sum each Investor has irrevocably undertaken to make in the
Fund. Commitments shall be drawn down from time to time based on investment
opportunities or other operational needs, upon request from the Board of Directors
and according to BPT AM Fund Raising Guidelines.
Drawdown
When Commitments from Investors are called in one or more tranches during the
Investment Period.
Fund
BPT Hansa Lux SICAV-SIF, a company incorporated under the form of a public com-
pany limited by shares ("société anonyme") under the laws of Luxembourg and
qualifying as a société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spé-
cialisé under the SIF Law.
Fund Size
The total investment capacity of the Company.
IFRS
International Financial Reporting Standards.
Initial Closing
Means the date on which Investors are first admitted to the Fund as Shareholders
being 2 January 2008.
Investment Period
The anticipated period of maximum 48 months from Fund Launch until the Fund is
fully invested.
NAV
Net Asset Value (per Share or for the Fund in total). Calculated as set out in article
11 of this Articles and the PPM in section "Fund Terms and Characteristics" under
"Reporting and Computation of NAV".
PPM
The Private Placement Memorandum of the Fund as amended from time to time.
Qualified Majority
Shall mean a decision taken by majority vote of 75% of the votes cast at a sharehol-
der's meeting where a quorum of two-thirds of all the shares in issue, at the date of
the meeting, has been reached.
If the quorum is not reached at the first meeting, the meeting shall be reconvened.
Any reconvened meeting having the same agenda will not be subject to the above
quorum requirement and decisions are validly taken by majority vote of 75% of the
votes cast at such reconvened meeting.
Subject to the requirements of Luxembourg law, any other reference to a sharehol-
ders vote shall mean a decision taken by majority vote of the votes cast at a
shareholder's meeting in which there shall be no quorum requirements.
Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the share-
holder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or
invalid vote.
SICAV
Société d'investissement à capital variable (investment company with variable capital).
Subscription Agreement
Means the agreement between the Fund and each Investor setting forth (i) the
amount of money (expressed in Euro) required to be contributed to the Fund by
such Investor, (ii) the number of Shares purchased by the Investor, and (iii) the rights
and obligations of the Investor in relation to the subscription of Shares.
US Person
Means a citizen or resident of the United States of America (including the States and
the District of Columbia) and any of its territories, possessions and other areas sub-
ject to its jurisdiction, or any corporation, partnership or other entity created in or
under the laws of the United States or any person falling within the definition of the
term "U.S. Person" under Regulation S promulgated under United States Securities
Act of 1933.
Valuation Day
The last bank business day in Luxembourg of each quarter, being a day by reference
to which the net asset value of the Fund is determined. For avoidance of doubt, only
the net asset value calculated as of the 31 December of each year will be based on
an independent property valuation of the real estate assets to be carried out by the
independent appraisers.
Well-Informed Investors
Investors who (i) adhere in writing to the status of well-informed investors and (ii)
either invest a minimum of EUR 125,000 in the Company or benefit from a certificate
delivered by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/CE, another
investment company within the meaning of Directive 2004/39/CE or a management
company within the meaning of Directive 2001/107/EC stating that they are expe-
rienced enough to appreciate in an adequate manner an investment in a specialised
investment fund."
79696
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves by 27,926 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions to amend article 3 of the Articles
so as to read as follows:
"The Company is established for a limited period so as to end on 3 May 2023. The Company may be dissolved prior
to its term at any moment by a resolution of the shareholders adopted by Qualified Majority, as prescribed in Article 22
hereof. The Board must submit, at the date of the annual general meeting to be held in 2022 a proposal to the shareholders
to restructure the Company. To be adopted, any such proposal for restructuring the Company will require a Qualified
Majority. If such proposal is rejected and the life of the Company is not extended beyond the Company's term, the
Company will fall automatically into liquidation."
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves by 27,926 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions to amend the first paragraph of
article 4 and the first paragraph of article 19 of the Articles so as to read as follows:
Art. 4. "The exclusive purpose of the Company is to invest, either directly or indirectly through its subsidiaries, the
funds available to it in real estate, real estate related assets of all types and other permitted assets, in accordance with
the investment strategy referred to in Article 19, with the purpose of spreading investment risks and affording its sha-
reholders the results of the management of its assets. The properties of the Company must be located in Germany and
investments cannot take place in any other countries."
Art. 19. "The Board has the power to determine the investment policies and strategies of the Company, based upon
the principle of risk spreading, and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, within
the restrictions as shall be set forth by the Board in compliance with applicable laws and regulations. The Company can
only invest in real estate located in Germany. The Investment Policies as more fully described in the PPM must be followed
in any event."
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves by 27,926 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions to insert a new paragraph at the
end of article 6 of the Articles so as to read as follows:
"The Board and each shareholder will have the right to access and inspect the shareholders register."
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves by 27,926 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions to amend the third paragraph of
article 7 of the Articles by deleting in article 7 the definition of "German residents" and hence any reference to "German
Residents" wherever it occurs in the Articles so as to read as follows:
"The Board shall not unreasonably withhold its consent to a transfer of shares; provided however that the Board shall
be entitled to refuse the transfer of shares in the following circumstances:
(a) if the Board reasonably considers that the transfer would result in a situation or event that would cause the
Company to be dissolved;
(b) if the transfer would result in shares being held by any person not qualifying as an Well Informed Investor (as
defined in Article 10);
(c) if the transfer is to a US Person (as defined hereafter);
(d) if the Board considers that the transfer would violate any applicable law and in particular the Law of 2007, regulation
or any term of these Articles, and in particular Article 10 hereinafter;
(e) if the Board considers the transferee to be of inappropriate creditworthiness;
(f) if the transfer would result in the transferor or transferee holding shares representing a Commitment of less than
the minimum Commitment; for the avoidance of doubt this shall not apply to a transfer relating to all shares of the
transferor;
(g) if the Board considers that the transfer may adversely affect the Company's reputation or its situation towards
potential competitors;
(h) if a shareholder would hold more than 25% of all the shares in issue."
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves by 27,926 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions to amend article 8 of the Articles
so as to read as follows:
"The Board is authorised, during a period of 48 months starting at the date of the Initial Closing, to issue without
limitation an unlimited number of fully paid up shares at any time until the Fund Size has reached an amount of up to EUR
300 million. The Board shall decide if a pre-emptive subscription right is to be granted to the existing shareholders
provided that under all circumstances existing shareholders shall be offered the same terms and conditions as new sha-
reholders.
79697
L
U X E M B O U R G
The Board may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued. The Board may, in particular,
decide that shares shall only be issued during one or more offering periods or at such other periodicity as provided for
in the Private Placement Memorandum (the "PPM") for the shares.
Furthermore, the Board may temporarily discontinue or finally suspend the issuance of shares without any prior notice
to shareholders, if the Board determines that this is in the best interest of the Company and the existing shareholders.
Investors wishing to subscribe for shares or existing shareholders wishing to subscribe for further shares following
the Initial Closing (a "Subsequent Closing") will be required to execute a subscription agreement and indicate therein
their total committed capital (the "Commitment" or "Commitments"); provided however that no shareholder of the
Company may hold at any time more than 25% of the total number of shares in issue. The minimum Commitment shall
be €125,000, unless the Board in its discretion accepts a lower amount. The Board may in its discretion accept or refuse
an offer to subscribe for shares made by an Investor. No subscription will be accepted more than 48 months after the
Initial Closing.
If a subscription is accepted by the Board, Commitments received from Investors must be drawn down by the Board,
in whole or in part, during a period of maximum 12 months after the Commitment was accepted by the Company (the
"Commitment Period").
Commitments will under all circumstance cease to be available for Drawdown after the expiry of 48 months period
from the Initial Closing; provided however that Commitments may be drawn down thereafter to the extent necessary
(i) to pay fees, expenses and liabilities of the Company, (ii) to complete any investments that have been committed to
during the Commitment Period such as the acquisition of a new property upon its completion or a refurbishment project
or (iii) to make any follow on investments in existing transactions, in this latter case up to a maximum of 10% of Com-
mitments. After the expiry of 12 months following the end of the Commitment Period, Commitments will cease to be
available for Drawdowns other than to satisfy any legal or contractual obligations of the Company, including without
limitation in relation to its position as a landlord of its existing real estate investments.
In no event will an Investor be required to make a capital contribution at any time in any amount in excess of its total
Commitment.
The price per share at which shares are issued at the Initial Closing shall be the initial subscription price of €1,000 and
thereafter the price per share at which the shares of each Class are issued shall be the Net Asset Value per share of the
relevant Class, as at the most recent Valuation Day determined in compliance with Article 11 as further adjusted on the
following basis:
(a) an adjustment shall be made for the difference between any deferred tax liability required to be provided for under
International Financial Reporting Standards as amended from time to time ("IFRS") and the estimated future tax liabilities
as estimated by the Board.
(b) the Board shall be entitled to require an additional assessment of the Net Asset Value including a property valuation,
prior to determining the Net Asset Value for the purpose of any issue of any shares, where the Board considers that
there has been an intervening event since the last Valuation Day which would render the current valuation materially
misleading.
(c) the Board shall make such further adjustment to the calculation of the price per share as they may consider
appropriate to ensure fairness between all shareholders. However, any price adjustment must be confirmed by indepen-
dent third party advice.
The Board may rely on advice from its advisors in quantifying the likely amount of any estimated tax liabilities and take
such other advice as they consider appropriate before making a determination as to the appropriate adjustment to the
NAV calculation.
Each new shareholder shall also be required (to the extent not already included in the Net Asset Value pursuant to
Article 11) to pay on subscription its pro rata share (as determined by the Board) of the costs of establishment, organi-
sation and administration of the Company, property advisor fees, acquisition fees, disposal fees, financing fees and other
fixed fees recalculated from the Initial Closing date as if all shareholders had been admitted to the Company and had
subscribed for their Commitments at the time of the Initial Closing.
Where a new shareholder commits to subscribe for shares on a Subsequent Closing and Commitments are drawn
down by the Board, the Board shall draw down the entirety of the Commitments from the shareholders having made
their Commitments prior to the Subsequent Closing, until the proportion of their total Commitments have been fully
drawn down, before the Commitments of the new shareholders are drawn down.
The issue price, as determined by the Board and disclosed in the PPM of the shares subscribed shall be payable within
the time limit as determined from time to time by the Board which shall not be later than fifteen Business Days from the
relevant issue date or Valuation Day. The Board may delegate to any director, manager, officer or other duly authorised
agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver
them.
The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities or other assets which
could be acquired by the Company pursuant to its investment policy and restrictions, in compliance with the conditions
set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company."
79698
L
U X E M B O U R G
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolves by 27,926 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions to amend article 9 of the articles so
as to read as follows:
" Art. 9. Listing and Redemption of Shares. The Board will actively be seeking a listing on a stock exchange in either
Luxembourg or another EU country and such listing being planned to be completed no later than by the end of 2016.
Shares in the Company may be tendered for redemption by the Company after a holding period of 10 years from the
date of issue. The Company shall redeem its own shares on 31
st
December of each year subject to a six months prior
notice (a "Redemption Day"). If a redemption request is accepted by the Company, the payment of the redemption
proceeds shall be made no later than 10 Business Days after the Annual Report has been approved by the Annual General
Meeting.
A shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company, under the terms and procedures
set forth by the Board in the PPM and within the limits provided by law and these Articles. For the avoidance of doubt,
the aforesaid holding period will only apply to redemption of shares by the Company and not to a transfer of shares.
In order to be accepted by the Company, any request for redemption of shares must be filed by the applying shareholder
in written form so as to arrive no later than six months before 31st December of each year at the registered office of
the Company in Luxembourg, together with the certificate or certificates for such shares in proper form.
There may be no redemption that would result in the redeeming shareholder holding shares representing a Commit-
ment of less than €125,000 unless the Board in its discretion agrees otherwise. For the avoidance of doubt, a redemption
of all of the shares of a redeeming shareholder does not require such Board approval.
The redemption price shall be based on the audited Net Asset Value of shares determined in accordance with the
provisions of Article 11 hereof on 31st December of each year and disclosed in the annual audited report.
Any costs relating to the redemption only (i.e. costs that the Company would not otherwise incur) shall be born by
the redeeming shareholder and would have to be fully documented. The redemption price may be reduced by disposal
costs and the breakage costs of financing, real or potential tax liabilities, and an accrual of performance fees payable to
any property advisor, as the Board may from time to time decide. The Board will only accept the relevant redemption
requests if sufficient liquid assets are available or have been made available. The Board must however do its best to make
such liquid assets available during the 6 months notice period. In its work getting liquid assets enough for the upcoming
redemption the Board must take into account both the interest of the shareholder who has requested the redemption
and the shareholders who will not be redeeming their shares. The Board may decide to temporarily suspend the right to
redeem shares if extraordinary circumstances occur which deem to make necessary such suspension in the interest of
the shareholders. In particular, the Board reserves the right to suspend the redemptions of shares due to the lack of
liquid assets if this seems necessary to protect the shareholders. If bank deposits and proceeds from the sale of liquid
assets are not sufficient for the payment of redemption prices and proper conduction of business of the Company, or if
bank deposits and liquid assets are not available immediately at the time of a requested redemption, then the Company
is entitled to suspend the right to redemption for a period of three months as of the applicable Redemption Day. If bank
deposits and the proceeds from the sale of liquid assets are not sufficient after the end of the aforementioned three-
months-period, then the Board shall realise sufficient investments of the Company, under due consideration of the
interests of all the shareholders. The realisation of such investments will be made over a period not exceeding one year
from the Redemption Day on which the right to redemption was initially suspended. The Company may suspend the right
to redemptions until it is able to sell or encumber sufficient real property on appropriate terms. The aforementioned
oneyear period may be extended by the Company for maximum 6 months by giving written notice to the shareholders.
After the lifting of the suspension of the right to redeem shares, redemption requests will be dealt with on the basis of
the audited Net Asset Value determined for the shares on the next Redemption Day after the end of such suspension.
In addition to the foregoing, the Board may decide to temporarily suspend the redemption of shares if exceptional
circumstances as set forth in Article 12 "Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share" so warrant.
Any request for redemption shall be irrevocable except in the event of suspension of redemption pursuant to Article
12 hereof. In the event of any such suspension under Article 12 hereof, redemption will occur, as of the first Business
Day after the end of the suspension.
If at any time a shareholder who has committed to subscribe for shares fails to honour its commitment through the
full payment of the subscription price within the timeframe decided by the Board (a "Defaulting Shareholder") and referred
to in the PPM, the Board has the authority, in addition to legal remedies, to charge interest on the resulting unpaid amount
at 4% per annum above European Central Bank's base rate from time to time. If the unpaid amount, plus interest thereon,
is not paid within 30 days, the Board shall have the right to:
a) impose damages corresponding to a maximum 10% of the amount committed by the investor; and
b) set off any distributions to the Defaulting Shareholder until any amounts owing to the Company have been paid in
full; and
c) redeem the shares of the Defaulting Shareholder as described in Article 10 below upon payment to such Defaulting
Shareholder of an amount equal to 85% of the NAV of its shareholding in the Company; provided that the payment will
only be operated once sufficient liquid assets are available payable at the time of liquidation of the Company;
79699
L
U X E M B O U R G
d) reduce or terminate the Defaulting Shareholder's Commitment;
e) exercise any other remedy available under applicable law;
f) offer the non-defaulting investor the right to purchase the defaulting investors interest in the Company at a price
equal to 85% of the Net Asset Value of the interest in the Company; or
g) admit new investors in order to replace the Defaulting Shareholder.
All redeemed shares shall be cancelled."
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting resolves by 27,926 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions to amend the first paragraph of
article 13 of the Articles so as to read as follows:
"The Company shall be managed by a board of directors (the "Board") composed of a minimum of three and a maximum
of five members, who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term of a maximum of six
years and shall hold office until their successor is appointed. The shareholders of the Class BPT Shares, as described in
Article 5 hereof, are entitled to propose to the general meeting of shareholders a list containing the names of candidates
for the position of director of the Company."
<i>Ninth resolutioni>
Meeting resolves by 27,926 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions to amend the fourth paragraph of article
14 of the Articles so as to read as follows:
"Written notice of any meeting of the Board shall be given to all directors at least 48 hours prior to the date set for
such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in
the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by email, telegram, telex, telefax or any other
similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
resolution adopted by the Board."
<i>Tenth resolutioni>
The Meeting resolves by 27,926 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions to amend the second paragraph of
article 28 of the Articles so as to read as follows:
"Any change in the Articles of Association that affects the purpose of the Company, the exit rules, the investment
strategy or the rights of shareholders of a Class must be approved by 90% of the shareholders of the Company or in case
of Class rights, by 90% of the shareholders of the Class concerned."
<i>Eleventh resolutioni>
The Meeting resolves by 27,926 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions to make the following amendments
to articles 11, 22 and 24 of the Articles so as to read as follows:
(a) Art. 11. Second paragraph, third sentence and seventh paragraph, first sentence.
Art. 11. Second paragraph, third sentence. "The Net Asset Value per share of each class shall be determined on the
last Business Day of each quarter or more frequently as the Board may decide (each a "Valuation Day"), by dividing the
net assets of the Company, being the value of the portion of assets attributable to such Class less the portion of liabilities
attributable to such Class, calculated at such time as the Board shall have set for such purpose, by the total number of
shares in the Company then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth below."
Art. 11. Seventh paragraph, first sentence. "The appraisal of the value of (i) property investments and property rights
registered in the name of the Company or any of its directly or indirectly owned subsidiaries and (ii) direct or indirect
shareholdings of the Company in real estate companies referred to under (b) above in which the Company shall hold
more than 50% of the outstanding voting stock, shall be undertaken by the independent appraiser. Such valuation may be
established at the accounting year end and used throughout the following year unless there is a change in the general
economic situation or in the condition of the relevant properties or property rights held by the Company or by any of
the companies in which the Company has a shareholding which requires new valuations to be carried out under the same
conditions as the annual valuations."
(b) Art. 22. Second and sixth paragraphs.
Art. 22. Second paragraph. "The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board. It may also be
called upon the request of shareholders representing at least 5 % of the share capital."
Art. 22. Sixth paragraph. "If such day is not a Business Day in Luxembourg, the annual meeting shall be held on the
following Business Day."
(c) Art. 24. First and second paragraphs. "To the extent permitted by law and having retained such amounts as are
required for the proper running of the Company and any identifiable liabilities or expenses of the Company as determined
by the Board, the profits of the Company may be distributed annually to the shareholders. If so decided, the Board shall
79700
L
U X E M B O U R G
declare and pay to each shareholder a distribution within a time period of 20 Business Days after the due issuing of the
annual report. The Board may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law.
If not reinvested pursuant to this article, net disposal proceeds and the proceeds of any refinancing after any deductions
required in relation to anticipated expenses or liabilities, as determined by the Board, shall be distributed to shareholders
within 60 Business Days."
<i>Twelfth resolutioni>
As requested by the chairman, the Meeting resolves to correct a clerical error in the second sentence of the fourth
paragraph of article 10 of the Articles by substituting "may" with "must".
There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a German translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English text shall prevail.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the Meeting, the members of the bureau of the meeting, all of whom are known
to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present
original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausend und zehn, am vierundzwanzigsten Juni.
Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),
wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre von BPT Hansa Lux SICAV-SIF (die "Gesellschaft"),
einer Aktiengesellschaft ("société anonyme") welche sich als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("société d'in-
vestissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé") qualifiziert, mit eingetragenem Sitz in 20, boulevard
Emmanuel Servais, L-2535 Luxemburg, gegründet nach luxemburgischen Recht am 23. Oktober 2006 mit Urkunde von
Me Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, die am 26. Januar 2007 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (das "Mémorial") Nummer 58 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") wurde zum
letzten Mal mit Urkunde des unterzeichnenden Notars am 28. September 2009 geändert, welche im Mémorial mit Num-
mer 2160 am 5. November 2009 veröffentlicht wurde.
Die außerordentliche Generalversammlung (die "Versammlung") wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Thomas
Boening, Angestellter, geschäftsansässig in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestimmte Frau Tania Araujo, Angestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, zur Sekretärin.
Die außerordentliche Generalversammlung bestimmte Frau Madeline Boucher, Angestellte, geschäftsansässig in Lu-
xemburg, zur Stimmenzählerin.
Nachdem das Büro der Versammlung auf diese Weise gebildet wurde, beauftragte der Vorsitzende den Notar, fol-
gendes festzuhalten:
I. Die für den 5. Mai 2010 einberufene außerordentliche Generalversammlung konnte mangels Quorum nicht recht-
mäßig über die vorgeschlagene Tagesordnung beraten und abstimmen.
II. Die Versammlung wurde durch Mitteilungen, die die Tagesordnung der Versammlung enthielten und am 18. Mai
2010 und am 4. Juni 2010 im Mémorial, "La Voix" und dem "Lëtzebuerger Journal" veröffentlicht und mittels eingeschrie-
benen Briefes, der am 18. Mai 2010 an alle Aktionäre der Gesellschaft (die "Aktionäre") geschickt wurde, einberufen.
III. Die bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen
Aktien sind auf der Anwesenheitsliste aufgeführt. Diese Liste sowie die Vollmachten wurden "ne varietur" von den Mit-
gliedern des Büros, den anwesenden Aktionären, den Vollmachtnehmern der vertretenen Aktionäre sowie dem unter-
zeichneten Notar paraphiert und werden als Anhang dieser Urkunde mit dieser bei der Eintragungsbehörde eingereicht.
IV. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung der Satzung durch Einfügen eines Definitionsteils am Anfang der Satzung.
2. Änderung von Artikel 3 der Satzung, um die momentan unbestimmte Dauer der Gesellschaft in eine festgelegte
Laufzeit mit Ende 3. Mai 2023 umzuändern.
3. Änderung der Artikel 4 und 19 der Satzung, um die Investition der Gesellschaft auf Deutschland zu beschränken.
4. Änderung von Artikel 6 der Satzung, um dem Verwaltungsrat und den Aktionären Zugang zum Aktionärsregister
zu gewähren.
5. Änderung von Artikel 7 der Satzung durch Löschen des Verweises auf in Deutschland Ansässige Personen.
6. Änderung von Artikel 8 der Satzung, um unter anderem die Frist während der Einzahlungsverpflichtungen abgerufen
werden können, auf 12 Monate zu beschränken.
79701
L
U X E M B O U R G
7. Änderung von Artikel 9 der Satzung um, unter anderem, (i) eine Bestimmung für die Börsennotierung der Aktien
der Gesellschaft einzufügen, (ii) die Rücknahmehäufigkeit sowie die Bestimmung des Rückkaufspreises zu ändern und (iii)
den Verweis auf eine mögliche Rückkaufsgebühr zu löschen.
8. Änderung von Artikel 13 der Satzung, um eine Anzahl von mindestens 3 und höchstens 5 Verwaltungsratsmitgliedern
der Gesellschaft vorzusehen.
9. Änderung von Artikel 14 der Satzung, um zu erlauben, dass Verwaltungsratssitzungen mit achtundvierzigstündiger
Vorankündigung einberufen werden.
10. Änderung von Artikel 28 der Satzung damit bestimmte Artikel der Satzung nur mit einer Mehrheit von 90% geändert
werden können.
11. Änderung der Artikel 11, 22 and 24 der Satzung, um Rechtschreibfehler zu beheben.
V. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass bei der Versammlung 11,86% der sich am Tag dieser Versammlung im
Umlauf befindenden Aktien der Gesellschaft vertreten oder anwesend sind.
VI. Wie in Artikel 22 der Satzung beschrieben werden bei der Versammlung Beschlüsse mit Zustimmung einer Mehrheit
von 75% der bei der Versammlung abgegebenen Stimmen gefasst. Ein Quorum ist nicht notwendig, da die außerordentliche
Generalversammlung, die am 5. Mai 2010 abgehalten wurde, mangels Quorum nicht rechtmäßig beraten konnte.
VII. Demzufolge ist die Versammlung ordnungsgemäß einberufen und kann rechtmäßig über die Tagesordnungspunkte
beraten.
Nach Beratung fasst die Versammlung folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt mit 27.926 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen, dem Anfang der
Satzung einen Definitionsteil hinzuzufügen, welcher wie folgt lautet:
"Einleitung - Definitionen
Basiswährung
Der Euro (EUR).
Bewertungsstichtag
Der letzte Bankarbeitstag jedes Quartals in Luxemburg, an dem der Nettovermö-
genswert des Fonds ermittelt wird. Um Zweifel zu vermeiden, nur der am 31.
Dezember eines jeden Jahres berechnete Nettovermögenswert basiert auf einer un-
abhängigen Immobilienbewertung der Liegenschaftsinvestitionen durch unabhängige
Bewertungsgutachter.
BPT AM
BPT Asset Management A/S oder BPT Asset Management Germany GmbH, eine
100%ige Tochtergesellschaft von BPT AM DK.
BPT AM DK
Baltic Property Trust Asset Management A/S, Dänemark.
Closing
Der vom Verwaltungsrat bestimmte Tag (oder die vom Verwaltungsrat bestimmten
Tage) an dem Zeichnungsvereinbarungen erhalten und vom Verwaltungsrat akzep-
tiert werden müssen.
Einzahlungsverpflichtung(en)
Die Summe des gesamten Einlagekapitals, welches sich jeder Investor unwiderruflich
verpflichtet hat, in die Gesellschaft zu investieren. Auf Anfrage des Verwaltungsrats
und in Übereinstimmung mit den "BPT AM Fund Raising Richtlinien" werden Einzah-
lungsverpflichtungen von Zeit zu Zeit auf Grundlage von Anlagegelegenheiten oder
anderen operationellen Bedürfnissen abgerufen.
Erstes Closing
Der Zeitpunkt, an dem Investoren zum ersten Mal als Aktionäre des Fonds zugelassen
werden; in diesem Fall der 2. Januar 2008.
Fonds
BPT Hansa Lux SICAV-SIF, eine als Aktiengesellschaft (société anonyme) nach lu-
xemburgischem Recht gegründete Gesellschaft, die als société d'investissement à
capital variable - fonds d'investissement spécialisé unter dem Gesetz von 2007 ein-
zustufen ist.
Fondsgröße
Die gesamte Investmentkapazität der Gesellschaft.
Gesellschaft
BPT Hansa Lux SICAV-SIF, eine als Aktiengesellschaft (société anonyme) nach lu-
xemburgischem Recht gegründete Gesellschaft, die als société d'investissement à
capital variable - fonds d'investissement spécialisé unter dem Gesetz von 2007 ein-
zustufen ist.
IFRS
International Financial Reporting Standards.
Investmentperiode
Die vorgesehene Periode von maximal 48 Monaten von der Lancierung des Fonds
bis zu dem Zeitpunkt an dem der Fonds komplett investiert ist.
Kapitalabruf
Wenn Einzahlungsverpflichtungen von Investoren in einer oder mehreren Tranchen
während der Investmentperiode abgerufen werden.
79702
L
U X E M B O U R G
Nettovermögenswert
Der Nettovermögenswert (pro Aktie oder für den gesamten Fonds). Nach den Be-
stimmungen von Artikel 11 dieser Satzung und dem Abschnitt "Fund Terms and
Characteristics" unter "Reporting and Computation of NAV" des PPM berechnet.
PPM
Das Private Placement Memorandum des Fonds, wie von Zeit zu Zeit geändert.
Qualifizierte Mehrheit
Bedeutet eine Entscheidung, welche von einer Versammlung der Aktionäre, bei der
ein Quorum von zwei Dritteln aller zum Tag der Versammlung ausgegebenen Aktien
anwesend ist, mit einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen gefasst wurde.
Wird das Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht, wird die Versammlung
erneut einberufen. Jede Versammlung in zweiter Einberufung mit derselben Tages-
ordnung unterliegt nicht den obigen Anforderungen an das Quorum und Beschlüsse
können gültig mit Zustimmung einer Mehrheit von 75% der bei einer solchen Ver-
sammlung in zweiter Einberufung abgegebenen Stimmen gefasst werden.
Vorbehaltlich der Voraussetzungen Luxemburger Rechts bezeichnet jede sonstige
Bezugnahme auf eine Abstimmung der Aktionäre einen Beschluss, der mit Zustim-
mung einer Mehrheit der bei einer beschlussfähigen Versammlung abgegebenen
Stimmen gefasst wurde, bei der kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist.
Abgegebene Stimmen beinhalten nicht Stimmen in Bezug auf Aktien für die der Ak-
tionär nicht an der Abstimmung teilgenommen, sich enthalten oder einen leeren oder
ungültigen Stimmzettel abgegeben hat.
Sachkundige Anleger
Anleger, welche (i) sich schriftlich mit der Einordnung als sachkundige Anleger ein-
verstanden erklären und (ii) entweder mindestens 125.000 Euro in die Gesellschaft
investieren oder über eine Einstufung seitens eines Kreditinstituts im Sinne der
Richtlinie 2006/48/EG, einer Wertpapierfirma im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG
oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG verfügen,
die ihnen bescheinigt, die notwendige Erfahrung zu besitzen, um auf angemessene
Weise eine Anlage in einen spezialisierten Investmentfonds einschätzen zu können.
Satzung
Die Satzung der Gesellschaft.
SICAV
Société d'investissement à capital variable (Investmentgesellschaft mit variablem Ka-
pital).
US Person
Ein Bürger oder eine Person mit Hauptwohnsitz in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich der Bundesstaaten und des District of Columbia) sowie jed-
wede ihrer Territorien, Besitzungen und sonstigen ihrer Gerichtsbarkeit unterwor-
fenen Gebiete oder auch jedwede in den Vereinigten Staaten oder nach der
Rechtsordnung der Vereinigten Staaten errichtete Gesellschaft, Personengesellschaft
oder sonstige Körperschaft oder jede Person, die unter die Definition einer "US
Person" gemäß Regulation S des United States Securities Act von 1933 fällt.
Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft, wie von Zeit zu Zeit ernannt.
Werktag
Ein Tag an dem Banken in Luxemburg geöffnet haben.
Zeichnungsvereinbarung
Die Vereinbarung zwischen dem Fonds und jedem Investor, welche (i) die Höhe des
Einlagekapitals (in EUR), das ein Investor verpflichtet ist in den Fonds einzubringen,
(ii) die Anzahl der vom Investoren gezeichneten Aktien und (iii) die Rechte und Ver-
pflichtungen des Investors in Bezug auf die gezeichneten Aktien darlegt."
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt mit 27.926 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen, Artikel 3 der Satzung
zu ändern, damit dieser wie folgt lautet:
"Die Gesellschaft ist für eine bestimmte Laufzeit mit Ende 3. Mai 2023 errichtet. Die Gesellschaft kann jederzeit vor
Ablauf seiner Laufzeit durch einen Beschluss der Aktionäre aufgelöst werden, der mit Qualifizierter Mehrheit, wie in
Artikel 22 beschrieben, angenommen wurde. Der Verwaltungsrat muss am Tag der im Jahr 2022 zu haltenden General-
versammlung den Vorschlag unterbreiten, die Gesellschaft zu restrukturieren. Um angenommen zu werden, bedarf jeder
solche Vorschlag, die Gesellschaft zu restrukturieren einer Qualifizierten Mehrheit. Wird ein solcher Vorschlag abgelehnt
und die Existenz der Gesellschaft nicht über das Ende der Laufzeit der Gesellschaft hinaus verlängert, wird die Gesellschaft
automatisch aufgelöst."
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt mit 27.926 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen, den ersten Absatz
von Artikel 4 und den ersten Absatz von Artikel 19 der Satzung zu ändern, damit diese wie folgt lauten:
Art. 4. "Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die - direkt oder indirekt über Tochtergesellschaften erfolgende
- Investition der ihr zur Verfügung stehenden Finanzmittel in Immobilien, mit Immobilien zusammenhängende Vermö-
gensgüter aller Art und sonstige zulässigen Vermögenswerte, und zwar im Einklang mit der in Artikel 19 beschriebenen
79703
L
U X E M B O U R G
Anlagestrategie, in der Absicht, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Aktionären die Ergebnisse ihrer Vermögensver-
waltung zuzuführen. Die Immobilien der Gesellschaft müssen sich in Deutschland befinden und Investitionen dürfen nicht
in anderen Ländern getätigt werden."
Art. 19. "Der Verwaltungsrat hat die Befugnis zur Festsetzung der Anlagestrategie und -politik der Gesellschaft auf der
Grundlage der Risikostreuung, sowie der großen Linien der Geschäftsführung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
innerhalb der Beschränkungen, die vom Verwaltungsrat unter Beachtung der anwendbaren Gesetze und Verordnungen
festgesetzt werden. Die Gesellschaft kann nur in sich in Deutschland befindende Immobilien investieren. Die Anlagepolitik,
die im PPM näher beschrieben ist, muss unter allen Umständen befolgt werden."
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt mit 97.926 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen, einen neuen Absatz
am Ende von Artikel 6 der Satzung einzufügen, welcher wie folgt lautet:
"Der Verwaltungsrat und jeder Aktionär haben Recht auf Zugang und Überprüfung des Registers der Aktionäre."
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt mit 27.926 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen, den dritten Absatz
von Artikel 7 der Satzung, durch Löschen des Verweises in Artikel 7 auf in "Deutschland Ansässige Personen" zu ändern
und folglich jeden Verweis auf in "Deutschland Ansässige Personen" wo immer er in der Satzung vorkommt, zu löschen,
damit dieser wie folgt lautet:
"Der Verwaltungsrat darf seine Zustimmung zu einer Aktienübertragung nicht ohne triftigen Grund verweigern; dies
gilt jedoch mit der Einschränkung, dass der Verwaltungsrat berechtigt ist, seine Zustimmung zu beantragten Übertragun-
gen in folgenden Fällen zu verweigern:
a) wenn der Verwaltungsrat in nachvollziehbarer Weise zu der Ansicht gelangt, dass sich aus der Übertragung eine
Situation oder ein Ereignis ergeben würde, die bzw. das zur Auflösung der Gesellschaft führen würde;
b) wenn sich aus der Übertragung ergeben würde, dass Aktien von einer Person gehalten werden, die nicht als Sach-
kundiger Anleger (wie in Artikel 10 definiert) qualifiziert;
c) wenn die Übertragung an eine US-Person (wie hiernach definiert) erfolgen soll;
d) wenn der Verwaltungsrat zu der Ansicht gelangt, dass die Übertragung gegen irgendeine anwendbare Gesetzes-
vorschrift und insbesondere gegen das Gesetz von 2007, gegen eine Verordnung oder eine Bestimmung dieser Satzung
und insbesondere gegen den folgenden Artikel 10 verstoßen würde;
e) wenn der Verwaltungsrat zu der Ansicht gelangt, dass der geplante Übertragungsempfänger keine angemessene
Kreditwürdigkeit besitzt;
f) wenn die Übertragung dazu führen würde, dass Zedent oder Zessionar Aktien hielten, mit denen eine Einzahlungs-
verpflichtung, welche geringer als die Mindesteinzahlungsverpflichtung ist, verbunden wäre; um Zweifel auszuschließen
wird festgehalten, dass dies nicht für eine Übertragung gilt, die sämtliche Aktien des Zedenten betrifft;
g) wenn der Verwaltungsrat zu der Ansicht gelangt, dass die Übertragung das Ansehen der Gesellschaft oder ihre
Stellung gegenüber potenziellen Mitbewerbern nachteilig beeinflussen könnte;
h) wenn ein Aktionär mehr als 25% aller ausgegebenen Aktien halten würde."
<i>Sechster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt mit 27.926 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen, Artikel 8 der Satzung
zu ändern, damit dieser wie folgt lautet:
"Der Verwaltungsrat ist berechtigt, während eines Zeitraums von 48 Monaten nach dem Ersten Closing, ohne Ein-
schränkung zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine unbegrenzte Zahl von voll einbezahlten Aktien auszugeben, bis die
Fondsgröße einen Betrag von bis zu 300 Millionen Euro erreicht hat. Der Verwaltungsrat entscheidet, ob bestehenden
Aktionären ein Vorzugsaktienbezugsrecht eingeräumt wird, vorausgesetzt, dass unter allen Umständen bestehenden Ak-
tionären die gleichen Bedingungen und Konditionen angeboten werden, wie neuen Aktionären.
Der Verwaltungsrat kann Beschränkungen hinsichtlich der Häufigkeit der Ausgabe von Aktien verfügen. Insbesondere
kann der Verwaltungsrat bestimmen, dass Aktien nur während einer oder mehreren Angebotsperioden oder zu solchen
anderen periodischen Terminen ausgegeben werden dürfen, die im Privat Placement Memorandum (das "PPM") für die
Aktien angeführt sind.
Außerdem kann der Verwaltungsrat ohne jegliche Vorankündigung gegenüber den Aktionären die Ausgabe von Aktien
vorübergehend aussetzen oder endgültig einstellen, wenn der Verwaltungsrat beschließt, dass dies im besten Interesse
der Gesellschaft und der bestehenden Aktionäre liegt.
Anleger, die in der auf das Erste Closing folgenden Zeit (ein "Folge-Closing") Aktien zeichnen möchten, oder schon
beteiligte Aktionäre, die bei derselben Runde weitere Aktien erwerben möchten, sind verpflichtet, eine Zeichnungsver-
einbarung mit darin enthaltener Angabe des gesamten Einlagekapitals, zu dem sie sich verpflichten (die "Einzahlungsver-
pflichtung" bzw. die "Einzahlungsverpflichtungen"), abzuschließen; wobei allerdings vorausgesetzt wird, dass zu keiner Zeit
ein Aktionär der Gesellschaft mehr als 25% der Gesamtzahl der ausgegeben Aktien halten darf. Die Mindest-Einzahlungs-
79704
L
U X E M B O U R G
verpflichtung beträgt 125,000 Euro, es sei denn, der Verwaltungsrat würde nach seiner freien Entscheidung einen
niedrigeren Betrag akzeptieren. Der Verwaltungsrat kann nach seinem freien Ermessen einen Antrag auf Zeichnung von
Aktien durch einen Anleger annehmen oder ablehnen. Später als 48 Monate nach dem Ersten Closing wird keine Zeich-
nung akzeptiert.
Wird eine Zeichnung vom Verwaltungsrat akzeptiert, dann müssen von den Anlegern zugesagte Einzahlungsverpflich-
tungen vom Verwaltungsrat ganz oder teilweise während einer Periode von höchstens 12 Monaten nach dem die
Einzahlungsverpflichtung von der Gesellschaft akzeptiert wurde (der "Einzahlungsverpflichtungsperiode") abgerufen wer-
den.
Nach Ablauf einer Frist von 48 Monaten ab dem Ersten Closing sind Einzahlungsverpflichtungen unter allen Umständen
nicht mehr für Kapitalabrufe (Drawdowns) verfügbar, mit der Einschränkung, dass Einzahlungsverpflichtungen auch danach
in dem (i) zur Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, (ii) zum Vollzug einer Anlage, die
während der Einzahlungsverpflichtungsperiode eingegangen wurde wie den Erwerb einer neuen Immobilie nach deren
Fertigstellung oder eines Renovierungsprojekts oder auch (iii) zur Tätigung von Folgeinvestitionen im Rahmen besteh-
ender Transaktionen (in diesem letzteren Fall bis zu einem Höchstbetrag von 10% der Einzahlungsverpflichtungen)
erforderlichen Ausmaß abgerufen werden können. Nach Ablauf von 12 Monaten nach Ende der Einzahlungsverpflich-
tungsperiode stehen Einzahlungsverpflichtungen nicht mehr für einen Kapitalabruf zur Verfügung, dies mit Ausnahme der
Zwecke der Erfüllung bestehender gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen der Gesellschaft, einschließlich - ohne
jede Einschränkung - solcher hinsichtlich der Stellung als Vermieter bestehender Immobilienanlagen.
Keinesfalls ist ein Anleger verpflichtet, zu irgendeinem Zeitpunkt eine Kapitaleinlage in einer Höhe zu leisten, die den
Betrag seiner gesamten Einzahlungsverpflichtung übersteigt.
Der Preis pro Aktie, zu dem Aktien beim Ersten Closing ausgegeben werden, ist der Anfangszeichnungspreis von 1.000
EUR, und danach entspricht der Preis pro Aktie, zu dem die Aktien jeder Aktienklasse ausgegeben werden, dem Netto-
vermögenswert pro Aktie der entsprechenden Klasse zum jüngsten Bewertungsstichtag, der im Einklang mit Artikel 11
in der Fassung späterer Abänderungen auf folgender Grundlage zu bestimmen ist:
(a) eine Anpassung ist für die Differenz zwischen einer latenten Steuerverbindlichkeit, für die nach den internationalen
Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards), in der jeweils aktuellen Fassung ("IFRS"), Rück-
stellungen zu bilden sind, und den geschätzten zukünftigen Steuerverbindlichkeiten laut der Schätzung durch den
Verwaltungsrat vorzunehmen.
(b) Der Verwaltungsrat ist berechtigt, eine zusätzliche Bewertung des Nettovermögenswerts unter Einschluss einer
Liegenschaftsbewertung vor Ermittlung des Nettovermögenswerts zum Zweck irgendeiner Ausgabe irgendwelcher Ak-
tien zu verlangen, wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass seit dem letzten Bewertungsstichtag ein Ereignis
vorgefallen ist, durch das die aktuelle Schätzung in wesentlicher Weise irreführend geworden wäre.
(c) Der Verwaltungsrat hat jene weiteren Anpassungen in der Berechnung des Preises pro Aktie vorzunehmen, die er
als angemessen erachtet, um eine faire Behandlung sämtlicher Aktionäre sicherzustellen. Jede Anpassung des Preises pro
Aktie muss jedoch von einem unabhängigen Drittberater bestätigt werden.
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, sich auf den Rat seiner Berater bei der Quantifizierung des wahrscheinlichen Be-
trages jedweder geschätzten Steuerverbindlichkeiten zu stützen und jeden anderen Rat einholen, den er für angemessen
erachtet, ehe er eine Bestimmung hinsichtlich der angemessenen Berichtigung der Nettovermögenswertberechnung
vornimmt.
Jeder neue Aktionär hat zudem (in dem Ausmaß, in dem das nicht bereits im Nettovermögenswert laut Artikel 11
enthalten ist) bei der Zeichnung den auf ihn (nach Festsetzung durch den Verwaltungsrat) entfallenden Anteil an den
Gründungs-, Organisations und Verwaltungskosten der Gesellschaft, den Gebühren des Property Advisers, Erwerbungs-,
Veräußerungs- und Finanzierungsvergütungsbeträgen und sonstigen festgesetzten Gebühren zu bezahlen, die ab dem Tag
des Ersten Closings noch einmal so zu berechnen sind, als ob alle Anleger beim Ersten Closing zugelassen worden wären
und ihre Einzahlungsverpflichtungen zu diesem Zeitpunkt gezeichnet hätten.
Verpflichtet sich ein neuer Aktionär an einem Folge-Closing Aktien zu zeichnen und werden Einzahlungsverpflichtungen
vom Verwaltungsrat abgerufen, wird der Verwaltungsrat die Gesamtheit der Einzahlungsverpflichtungen der Aktionäre,
die ihre Einzahlungsverpflichten vor dem Folge–Closing eingegangen sind, bis zur Höhe ihrer gesamten Einzahlungsver-
pflichtungen abrufen, bevor die Einzahlungsverpflichtungen der neuen Aktionäre abgerufen werden.
Der Ausgabepreis für die gezeichneten Aktien, so wie er vom Verwaltungsrat festgelegt und im PPM ausgewiesen wird,
ist binnen einer jeweils vom Verwaltungsrat festzusetzenden Frist zahlbar, die nicht mehr als fünfzehn Werktage ab dem
entsprechenden Ausgabetag beziehungsweise Bewertungsstichtag liegen darf. Der Verwaltungsrat kann die Vollmacht zur
Annahme von Zeichnungserklärungen, zur Entgegennahme der Zahlung des Preises der neuen auszugebenden Aktien
sowie zur Ausgabe derselben an jeden Direktor, Geschäftsführer, Funktionsträger oder sonstigen ordnungsgemäß be-
vollmächtigten Agenten delegieren.
Die Gesellschaft kann sich zur Ausgabe von Aktien als unbares Entgelt für Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte
verpflichten, die gegebenenfalls von der Gesellschaft gemäß ihrer Anlagestrategie und den Anlagebeschränkungen unter
Erfüllung der vom luxemburgischen Recht hierfür vorgesehenen Bedingungen, einschließlich der Verpflichtung zur Vorlage
eines Bewertungsberichts des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft, erworben werden könnten."
79705
L
U X E M B O U R G
<i>Siebter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt mit 27.926 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen, Artikel 9 der Satzung
zu ändern, damit dieser wie folgt lautet:
" Art. 9. Börsennotierung und Rückkauf von Aktien. Der Verwaltungsrat wird aktiv eine Börsennotierung entweder
in Luxemburg oder einem anderen EU Land anstreben und es ist geplant, diese Börsennotierung bis spätestens Ende 2016
vollzogen zu haben.
Aktien der Gesellschaft können nach einer Halteperiode von 10 Jahren ab Tag der Ausgabe zur Rücknahme durch die
Gesellschaft angeboten werden. Die Gesellschaft kauft ihre eigenen Aktien, vorausgesetzt dass dies sechs Monate im
Vorhinein angezeigt wurde, am 31. Dezember eines jeden Jahres zurück (der "Rückkaufstag"). Wird ein Antrag auf Rück-
kauf von der Gesellschaft akzeptiert, erfolgt die Auszahlung des Rückkauferlöses nicht später als 10 Werktage nach
Annahme des Jahresberichts durch die Jahreshauptversammlung.
Ein Aktionär ist berechtigt, den Rückkauf seiner Aktien zu beantragen, und zwar unter den Bedingungen und Verfah-
rensvorschriften, die vom Verwaltungsrat im PPM für Aktien ausgeführt sind, und innerhalb der von der Rechtsordnung
und dieser Satzung vorgesehenen Begrenzungen. Um Zweifel zu vermeiden wird festgehalten, dass die vorgenannte Hal-
teperiode nur bei der Aktienrücknahme durch die Gesellschaft anwendbar ist und nicht bei der Aktienübertragung.
Um von der Gesellschaft akzeptiert zu werden, muss jeder Antrag auf Rückkauf von Aktien von dem antragstellenden
Aktionär schriftlich so eingereicht werden, dass er bei dem eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg nicht später
als sechs Monate vor dem 31. Dezember eines jeden Jahres ankommt, zusammen mit dem bzw. den Zertifikaten für solche
Aktien in ordnungsgemäßer Form.
Ein Rückkauf, der dazu führen würde, dass der den Rückkauf betreibende Aktionär nunmehr Aktien hielte, die einer
Einzahlungsverpflichtung von weniger als 125.000 EUR entsprächen, findet nicht statt, es sei denn, der Verwaltungsrat
würde nach seinem freien Ermessen anders entscheiden. Um jeden Zweifel auszuschließen, erfordert ein Rückkauf sämt-
licher Aktien eines den Rückkauf betreibenden Aktionärs keine solche Zustimmung des Verwaltungsrats.
Der Rückkaufspreis beruht auf dem geprüften Nettovermögenswert der Aktien, welcher gemäß den Bestimmungen
von Artikel 11 dieser Satzung am 31. Dezember jedes Jahres ermittelt und im geprüften Jahresbericht bekanntgegeben
worden ist. Jegliche Kosten, die sich nur auf den Rückkauf beziehen (z.B. Kosten, welche die Gesellschaft sonst nicht zu
tragen hätte) sind vom den Rückkauf betreibenden Aktionär zu tragen und müssen vollständig dokumentiert werden.
Vom Rückkaufspreis können der Veräußerungsaufwand sowie die "Breakage Costs" (Zinsauflösungskosten aufgrund einer
Refinanzierung, A.d.Ü.) der Finanzierung, tatsächliche oder potenzielle Steuerverbindlichkeiten, sowie der Anfall der an
den Property Adviser zu zahlenden Performance Fee abgezogen werden, je nach der jeweiligen Entscheidung des Ver-
waltungsrats.
Der Verwaltungsrat wird die jeweiligen Rückkaufsforderungen, nur akzeptieren, sofern ausreichende liquide Vermö-
gensmittel verfügbar sind bzw. verfügbar gemacht wurden. Der Verwaltungsrat muss jedoch sein Bestes tun, solche
liquiden Vermögensmittel innerhalb der Sechsmonatsfrist verfügbar zu machen. Während seiner Bestrebungen ausrei-
chend liquide Vermögensmittel für den anstehenden Rückkauf zu beschaffen, muss der Verwaltungsrat sowohl die
Interessen des den Rückkauf betreibenden Aktionärs als auch die Interessen der verbleibenden Aktionäre berücksichtigen.
Der Verwaltungsrat kann eine vorübergehende Aussetzung des Rechts auf Rückkauf von Aktien verfügen, wenn außer-
ordentliche Umstände eintreten, die eine solche Aussetzung im Interesse der Aktionäre notwendig erscheinen lassen.
Insbesondere behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, den Rückkauf von Aktien mangels liquiden Vermögens aus-
zusetzen, wenn dies erforderlich ist, um die Aktionäre zu schützen. Reichen die Bankguthaben und die Erlöse aus dem
Verkauf liquiden Vermögens nicht zur Bezahlung des Rückkaufspreises und zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung der
Gesellschaft aus, oder sind Bankguthaben und liquide Vermögensgüter nicht unverzüglich im Augenblick eines beantragten
Rückkaufs verfügbar, dann ist die Gesellschaft berechtigt, das Rückkaufsrecht für die Dauer von drei Monaten ab dem
betreffenden Rückkaufstag auszusetzen. Wenn nach Ablauf der vorgenannten Dreimonatsfrist die Bankguthaben und die
Erlöse aus dem Verkauf liquiden Vermögens nicht ausreichen, dann hat der Verwaltungsrat Anlagen der Gesellschaft in
ausreichendem Ausmaß unter ordnungsgemäßer Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre zu veräußern. Die Ver-
äußerung solcher Anlagen hat während eines Zeitraums von höchstens einem Jahr ab dem Rückkaufstag, zu dem das
Rückkaufsrecht vorübergehend ausgesetzt wurde, zu erfolgen. Die Gesellschaft ist berechtigt, das Rückkaufsrecht solange
auszusetzen, bis sie imstande ist, genügend Immobilien zu angemessenen Bedingungen zu verkaufen oder zu verpfänden.
Die zuvor erwähnte Frist von einem Jahr kann durch die Gesellschaft unter schriftlicher Benachrichtigung der Aktionäre
um maximal 6 Monate verlängert werden. Nach Aufhebung der Aussetzung des Rückkaufsrechts für Aktien werden
Rückkaufsanträge zu dem geprüften Nettovermögenswert abgewickelt, der für Aktien zum nächsten Rückkaufstag nach
Ende einer solchen Aussetzungsfrist ermittelt wird.
Zusätzlich zu dem Vorstehenden kann der Verwaltungsrat eine vorübergehende Aussetzung des Aktienrückkaufs ver-
fügen, wenn außerordentliche Umstände, wie sie in Artikel 12 "Vorübergehende Aussetzung der Berechnung des
Nettovermögenswerts pro Aktie" ausgeführt sind, dies erfordern.
Jeder Antrag auf Rückkauf ist unwiderruflich, es sei denn im Fall einer Aussetzung des Rückkaufs nach Artikel 12 dieser
Satzung. Im Fall jeder solchen Aussetzung auf Grund des Artikels 12 dieser Satzung erfolgt der Rückkauf zum ersten
Werktag nach dem Ende der Aussetzung.
79706
L
U X E M B O U R G
Kommt zu irgendeinem Zeitpunkt ein Aktionär, der sich zur Zeichnung von Aktien verpflichtet hat, seiner Einzah-
lungsverpflichtung nicht durch volle Einzahlung des Zeichnungspreises innerhalb der vom Verwaltungsrat festgesetzten
und im PPM angegebenen Frist nach (ein "Säumiger Aktionär"), dann ist der Verwaltungsrat berechtigt, zusätzlich zur
Ergreifung rechtlicher Mittel auf den sich ergebenden rückständigen Betrag Zinsen in Höhe von 4% per annum über dem
jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu erheben. Wird der rückständige Betrag zuzüglich darauf ent-
fallender Zinsen nicht binnen 30 Tagen entrichtet, dann stehen dem Verwaltungsrat folgende Rechte zu:
a) Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von maximal 10% der Einzahlungsverpflichtung; sowie
b) Aufrechnung mit jedweden Ausschüttungen an den Säumigen Aktionär, bis sämtliche der Gesellschaft geschuldeten
Beträge vollständig bezahlt sind; und
c) Rückkauf der Aktien des Säumigen Aktionärs wie in Artikel 10 beschrieben, gegen Auszahlung eines Betrages in
Höhe von 85% des Nettovermögenswerts seiner an der Gesellschaft gehaltenen Aktien, auszahlbar zum Zeitpunkt der
Abwicklung der Gesellschaft, vorausgesetzt, dass die Auszahlung nur ausgeführt wird, sobald ausreichend liquides Ver-
mögen vorhanden ist;
d) Herabsetzung oder Kündigung der Einzahlungsverpflichtung des Säumigen Aktionärs;
e) Geltendmachung jedes sonstigen unter der anwendbaren Rechtsordnung zustehenden Rechtsmittels;
f) die Möglichkeit, den nicht säumigen Aktionären das Recht zum Kauf der Aktie des Säumigen Aktionärs an der
Gesellschaft zu einem Kaufpreis in Höhe von 85% des Nettovermögenswerts des Gesellschaftsanteils anzubieten; oder
g) Zulassung neuer Anleger als Ersatz für den Säumigen Aktionär.
Alle zurückgekauften Aktien werden für ungültig erklärt."
<i>Achter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt mit 27.926 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen, den ersten Absatz
von Artikel 13 der Satzung zu ändern, damit dieser wie folgt lautet:
"Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen Verwaltungsrat (der "Verwaltungsrat"), bestehend aus
mindestens drei und maximal fünf Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Sie werden für eine
Amtszeit von höchstens sechs Jahren gewählt und bleiben bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt. Die Aktionäre
der in Artikel 5 beschriebenen Klasse BPT-Aktien sind berechtigt, der Generalversammlung eine Liste mit Namen rats-
mitglieds von der Kandidaten für die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft vorzuschlagen."
<i>Neunter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt mit 27.926 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen, den vierten Absatz
von Artikel 14 der Satzung zu ändern, damit dieser wie folgt lautet:
"Eine schriftliche Einberufung zu jeder Verwaltungsratssitzung hat sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern wenigstens
achtundvierzig Stunden vor dem für eine solche Sitzung geplanten Termin zuzugehen, ausgenommen in Notfällen, in denen
die Art der diese begründenden Umstände in der Einberufung zur Sitzung anzugeben ist. Die Pflicht zur vorherigen
Einberufungsmitteilung kann durch schriftlich, per E-Mail, Telegramm, Fernschreiben, Telefax oder andere ähnliche Kom-
munikationsmittel bekundetes Einverständnis abbedungen werden. Eine gesonderte Einberufung für Sitzungen, die an
Orten und zu Terminen stattfinden, die in einem Verwaltungsratsbeschluss festgelegt wurden, ist nicht erforderlich."
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt mit 27.926 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen, den zweiten Absatz
von Artikel 28 der Satzung zu ändern, damit dieser wie folgt lautet:
"Jede Änderung der Satzung, welche den Zweck der Gesellschaft, die Ausstiegsregeln, die Anlagestrategie oder die
Rechte der Aktionäre einer Klasse betreffen, bedarf der Zustimmung von 90% der Aktionäre der Gesellschaft oder falls
die Interessen einer Aktienklasse betroffen sind, 90% der Aktionäre der betroffenen Klasse."
<i>Elfter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt mit 27.926 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen, die Artikel 11, 22 und
24 der Satzung zu ändern, um Rechtschreibfehler zu beheben, damit diese wie folgt lauten:
(a) Art. 11. Zweiter Absatz, dritter Satz und siebter Absatz, erster Satz.
Art. 11. Zweiter Absatz, dritter Satz. "Der Nettovermögenswert pro Aktie wird für jede Klasse zum letzten Werktag
jedes Quartals oder auch noch häufiger, je nach Entscheidung des Verwaltungsrats (jeweils ein "Bewertungsstichtag"),
ermittelt, und zwar durch Division des Nettovermögens der Gesellschaft (entspricht dem Wert der einer solchen Klasse
zuzurechnenden Aktiva abzüglich des Werts der einer solchen Klasse zuzurechnenden Passiva, berechnet zu dem Zeit-
punkt, den der Verwaltungsrat für diesen Zweck bestimmt hat) durch die Gesamtzahl der zu diesem Zeitpunkt
ausgegebenen Aktien im Einklang mit den nachstehend ausgeführten Bewertungsregeln."
Art. 11. Siebter Absatz, erster Satz. "Die Ermittlung des Werts von (i) Liegenschaftsinvestitionen und Liegenschafts-
rechten, die auf den Namen der Gesellschaft oder einer ihrer direkten oder indirekten Tochterunternehmen eingetragen
sind und (ii) direkte oder indirekte Beteiligungen der Gesellschaft an Immobiliengesellschaften, auf die sich obige lit. (b)
79707
L
U X E M B O U R G
bezieht, an welchen die Gesellschaft mehr als 50% des ausgegebenen stimmberechtigten Kapitals hält, hat durch unab-
hängige Schätzgutachter zu erfolgen. Eine solche Bewertung kann zum Ende des Geschäftsjahres durchgeführt und
während des Folgejahres verwendet werden, es sei denn, es hätte eine Veränderung in der allgemeinen wirtschaftlichen
Situation oder in dem Zustand der entsprechenden im Eigentum oder Eigentumsrecht der Gesellschaft oder einer der
Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft stehenden Liegenschaften beziehungsweise Liegenschaftsrechte gegeben, die
die Vornahme neuer Bewertungen unter denselben Bedingungen wie die jährlichen Bewertungen erforderlich machen
würde."
(b) Art. 22. Zweiter und sechster Absatz.
Art. 22. Zweiter Absatz. "Die Generalversammlung tritt auf Grund einer Einberufung durch den Verwaltungsrat zu-
sammen. Sie kann auch auf Wunsch von Aktionären einberufen werden, die wenigstens 5% des Stammkapitals repräsen-
tieren."
Art. 22. Sechster Absatz. "Sollte dieser Tag kein Werktag in Luxemburg sein, dann ist die jährliche Generalversammlung
am folgenden Werktag abzuhalten."
(c) Art. 24. Erster und zweiter Absatz. "In dem gesetzlich zulässigen Ausmaß und nach Einbehaltung jener Beträge, die
für die ordnungsgemäße Geschäftsführung der Gesellschaft und alle erkennbaren Verpflichtungen beziehungsweise Aus-
lagen der Gesellschaft in vom Verwaltungsrat bestimmter Höhe erforderlich sind, können die Gewinne der Gesellschaft
jährlich an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat hat binnen einer Frist von 20 Werktagen ab der
ordnungsgemäßen Herausgabe des Jahresberichts jeden Aktionär von einer Ausschüttung zu verständigen und sie an
denselben auszuzahlen. Der Verwaltungsrat kann beschließen, im Einklang mit den gesetzlich festgesetzten Bedingungen
Zwischendividenden auszuschütten.
Findet keine Wiederveranlagung statt, dann sind die Nettoveräußerungserträge und die Erträge aus jedweder Refi-
nanzierung nach jedweden für antizipierte Auslagen oder Verbindlichkeiten nach Festsetzung des Verwaltungsrats
vorgenommenen Abzügen binnen 60 Werktagen an die Aktionäre auszuschütten."
<i>Zwölfter Beschlussi>
Wie vom Vorsitzenden beantragt, beschließt die Versammlung einen Schreibfehler im zweiten Satz des vierten Absatzes
von Artikel 10 der Satzung zu berichtigen, indem "kann" durch "muss" ersetzt wird.
Da keine weiteren Angelegenheiten auf der Tagesordnung der Versammlung stehen, wurde diese daraufhin geschlos-
sen.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass diese Urkunde auf
Wunsch der erschienenen Personen in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde. Auf
Antrag der erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,
soll die englische Version maßgeblich sein.
Dem Vorgenannten entsprechend wurde diese Urkunde in Luxemburg am zu Beginn dieses Dokumentes genannten
Datum erstellt.
Nachdem die Urkunde der Generalversammlung, den Mitgliedern des Büros der Versammlung, die dem Notar alle
dem Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnsitz nach bekannt sind, verlesen wurde, wurde sie gemeinsam mit dem
unterzeichneten Notar unterschrieben.
Gezeichnet: T. BOENING - T. ARAUJO - M. BOUCHER - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 juillet 2010. Relation: LAC/2010/29619. Reçu soixante-quinze euros (75,00
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehren erteilt.
Luxemburg, den neunten Juli zweitausendzehn.
Référence de publication: 2010092490/801.
(100103484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2010.
Franzen und Brandt, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6470 Echternach, 24, rue de la Montagne.
R.C.S. Luxembourg B 128.391.
Le Bilan de clôture au 31 décembre 2009.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
79708
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 Juin 2010.
Référence de publication: 2010080278/11.
(100091538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Green Way Arbitrage, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 48.008.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2010.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2010080283/12.
(100091067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Café Schlassstuff S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5772 Weiler-la-Tour, 4, rue de Hassel.
R.C.S. Luxembourg B 154.188.
STATUTS
L'an deux mille dix, le vingt-neuf juin,
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
A comparu:
Monsieur Michel FEDERSPIEL, commerçant en retraite, né à Luxembourg le 7 juin 1947, demeurant à L-7330 Heisdorf,
28, rue de Luxembourg,
Lequel à requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée
unipersonnelle qu’il déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un café avec débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées avec
établissement de petite restauration, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet
ou le favorisant.
La société a également pour objet la vente en gros et en détail de boissons alcoolisées et non-alcoolisées.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de "CAFE SCHLASSSTUFF S.à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi à Weiler-la-Tour.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.
Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées par Monsieur Michel FEDERSPIEL, préqualifié.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199
de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
et des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort
à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés restants ont
un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.
79709
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par
lettre recommandée à ses coassociés.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés.
Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation relativement aux engagements régu-
lièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur
mandat.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le premier
exercice commence ce jour pour finir le trente-et-un décembre deux mille dix.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pourcent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci
ait atteint dix pourcent du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400,00).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et à l’instant l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, s’est constituée en assemblée général ex-
traordinaire et a pris les résolutions suivantes.
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Michel FEDERSPIEL, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-5772 Weiler-la-Tour, 4, rue de Hassel.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Federspiel, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 01 juillet 2010. Relation: LAC / 2010 / 29092. Reçu soixante-quinze euros
75,00€
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Pour copie conforme.
Luxembourg, le 14 juillet 2010.
Référence de publication: 2010093241/85.
(100103916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.
79710
L
U X E M B O U R G
Green-Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8365 Hagen, 38, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 54.385.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2010.
Référence de publication: 2010080288/10.
(100091496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Hollywood Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 131.425.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2010.
<i>POUR CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Gabriele Schneider / Pierre Schmit
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010080291/13.
(100091311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Immo-Nord Guy Kartheiser S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9160 Ingeldorf, 8, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 108.698.
L'an deux mille dix, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
a comparu
Monsieur Guy KARTHEISER, administrateur de sociétés, né le 5 novembre 1964 à Ettelbruck (matr. 1964 11 05 174),
demeurant L-9291 Diekirch, 10, rue Walebroch.
Le comparant, agissant en sa qualité d’actionnaire unique représentant l'intégralité du capital social, de la société
anonyme «IMMO-NORD GUY KARTHEISER S.A.», (matr. 2005 22 12 597), avec siège social à L-9051 Ettelbruck, 102,
Grand-rue,
constituée, alors sous la dénomination de IMMO NORD CONSEILS ET FINANCES SA., suivant acte reçu par Maître
Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 8 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 1168 du 8 novembre 2005,
laquelle société a pris la dénomination actuelle suivant acte reçu par le même notaire BETTINGEN en date 21 sep-
tembre 2005, publié au Mémorial C, numéro 90 du 13 janvier 2006, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois par le notaire instrumentant, en date du 30 novembre 2007, publié au Mémorial C, numéro 50 du 9 janvier 2008,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 108.698.
L’actionnaire unique a ensuite requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’actionnaire unique décide de transférer le siège social de la société vers L-9160 Ingeldorf, 8, route d’Ettelbruck et
de modifier par conséquent le 1
er
alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. (1
er
alinéa). Le siège de la société est établi dans la commune d’Erpeldange.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’actionnaire unique décide de modifier l’article 6 des statuts qui aura le teneur suivant:
«Art. 6. En cas d’existence d’un actionnaire unique la société peut être gérée par un administrateur unique.
En cas de pluralité d’actionnaires la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non.
79711
L
U X E M B O U R G
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.»
<i>Troisième résolutioni>
L’actionnaire unique décide de modifier l’article 10 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Art. 10. La société se trouve valablement engagée par la signature individuelle de l’administrateur délégué ou par la
signature conjointe de l’administrateur délégué et d’un autre administrateur de la société.
En cas d'administrateur unique, la société se trouve valablement engagée par la signature de ce dernier.
La signature d'un seul administrateur sera toujours suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports
avec les administrations publiques. »
<i>Quatrième résolutioni>
L’actionnaire unique accepte la démission de Monsieur Patrick WAMPACH et de Monsieur Marco JACOBY et leur
confère décharge de l'exécution de leurs mandats.
<i>Cinquième résolutioni>
L’actionnaire unique accepte la démission de Monsieur Guy KARTHEISER du poste d’administrateur-délégué et lui
confère décharge de l'exécution de son mandat.
<i>Sixième résolutioni>
L’actionnaire unique confirme, pour une durée de six ans, au poste d’administrateur unique, Monsieur Guy KAR-
THEISER, prénommé.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ 800,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G.KARTHEISER, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 31 mai 2010. DIE/2010/4930. Reçu soixante-quinze euros. EUR 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl
POUR COPIE CONFORME AUX FINS DE PUBLICATION AU MEMORIAL C
Ettelbruck, le 25 juin 2010.
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2010080300/66.
(100091056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Kmind International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 131.058.
Il résulte d'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 31 décembre 2009
- Que Monsieur FAYS Eric, né le 25 septembre 1968 à B-Messancy, demeurant à L-2210 Luxembourg, 66, Boulevard
Napoléon 1
er
, a présenté sa démission de ses fonctions d'Administrateur en date du 31 décembre 2009.
- Que Monsieur WIES Aurélien, né le 27 août 1982 à F-Villerupt, demeurant à F-54190 Villerupt, 40, Rue Jules Michelet,
a présenté sa démission de ses fonctions d'Administrateur en date du 31 décembre 2009.
- Que la société à responsabilité limitée "Fiduciaire Intercommunautaire S. à R.L.", établie et ayant son siège social à
L-2210 Luxembourg, 66, Boulevard Napoléon 1
er
, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B67480 a présenté sa démission de ses fonctions de Commissaires aux Comptes au 31 décembre 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
79712
L
U X E M B O U R G
Pour extrait sincère et conforme
KMIND INTERNATIONAL S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2010080656/19.
(100090801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2010.
Infotime Analyse Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 106, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 54.643.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010080302/9.
(100091101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Inkosi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 47.325.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010080304/9.
(100091495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Diam International II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 154.125.
STATUTES
In the year two thousand and ten, on the eleventh of June.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
“Diam International S.à r.l.”, a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1A,
rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
The founder is here represented by Mr Raymond THILL, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of
a proxy given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which it
declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company, governed by the present
articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10
th
, 1915 on commercial
companies, including its article 209, of September 18
th
, 1933 and of December 28
th
, 1992 on "sociétés à responsabilité
limitée", as amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following
shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.
Art. 2. The Company's name is "Diam International II S.à r.l.".
Art. 3. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
79713
L
U X E M B O U R G
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures. In a
general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies
or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the
Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the municipality of Strassen, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 12,500
(twelve thousand five hundred ) shares of EUR 1.- (one euro) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. In this case, the managers will be appointed as class A manager or class B manager. The
manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of shareholders holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of one class A manager and one class B manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
79714
L
U X E M B O U R G
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member
of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another
manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Shareholders decisions
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of
shareholders representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10
th
, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on January 1
st
and closes on December 31
st
.
Art. 17. Each year, as of the 31
st
of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
79715
L
U X E M B O U R G
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Interim dividend
Art. 20. Notwithstanding the provisions of the article nineteen, the general meeting of partners of the Company, by
the majority vote determined by the Law for payment of dividend, upon proposal of the board of managers or the sole
manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the
basis of a recent interim statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager itself (as the case
may be), and showing that sufficient reserves are available for distribution, it being understood that the amount to be
distributed may not exceed realised profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts
have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses
carried forward and any sums to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 21. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 22. The laws here above mentioned in article 1
st
shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2010.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by Diam
International S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of Euros 12,500 (twelve thousand five
hundred Euros) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand euro (EUR 2,000.-).
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as A manager for an undetermined duration:
Mr Russell Faulkner, born on November 12, 1977 in Dubai, with professional address at 25, St George Street, London,
W1S 1FS, United Kingdom.
2) Are appointed as B managers for an undetermined duration:
Mr Philippe Leclercq, born on May 18, 1968, in Liège, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg;
Ms Laurence Goblet born on February 27, 1981, in Malmedy, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg.
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager,
and, in case of plurality of managers, by the joint signature of one class A manager and one class B manager.
3) The Company shall have its registered office at 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
4) To increase the subscribed capital by an amount of EUR 1,623,550 (one million six hundred twenty-three thousand
five hundred and fifty euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros)
to EUR 1,636,050 (one million six hundred thirty-six thousand and fifty euros) by the issue of 1,623,550 (one million six
hundred twenty-three thousand five hundred and fifty) new shares having a par value of EUR 1 (one euro) each, the whole
to be paid up through a contribution in kind consisting of 250,000 (two hundred and fifty thousand) shares held in the
79716
L
U X E M B O U R G
company DIAM International SAS, a company incorporated under the laws of France, having its registered office at 40
rue Pierre Curie, F-78130 Les Mureaux and registered to the Versailles Trade Register under number B 431 259 159,
for a total amount of EUR 1,623,550 (one million six hundred twenty-three thousand five hundred and fifty euros).
Pursuant to the above increase of capital, article 8 of the Company's article of association is amended and shall hen-
ceforth read as follows:
“ Art. 8. The Company's capital is set at EUR 1,636,050 (one million six hundred thirty-six thousand fifty euros),
represented by 1,636,050 (one million six hundred thirty-six thousand fifty euros) shares of EUR 1 (one euro) each.”
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil dix, le onze juin.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
Comparaît:
«Diam International S. à r.l.», une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1A, rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen.
Fondateur ici représenté par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l'article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera "Diam International II S. à r.l.".
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés entités
commerciales, l'acquisition par achat, par souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange
ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de créances, de titres et d'autres valeurs de toutes espèces, et la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société pourra également détenir des
participations dans d'autres sociétés et exercer son activité à travers ses filiales au Luxembourg ou à l'étranger.
La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d'obligations
et autres titres de créances.
D'une manière générale, la Société pourra octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou
par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société à des participations ou; qui font
partie intégrante du groupe de sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement). Prendre
toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au déve-
loppement de son objet.
Finalement, la Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière ou toute autre opération,
en relation directe ou indirecte avec le champ d'application de son objet, afin de faciliter l'accomplissement de celui-ci.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.
79717
L
U X E M B O U R G
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature
à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à Euros 12,500.- (douze mille cinq cents Euros), représenté par 12.500 (douze mille
cinq cents) parts sociales de Euro 1,- (un Euro) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Dans ce cas, les gérants seront nommés gérants de classe A ou gérants de classe B. Le(s) gérant(s) ne sont
pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une
résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants
sont présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de
technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous
frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement
transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas
79718
L
U X E M B O U R G
où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs
envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits
auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément
formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de
la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dividendes intérimaires
Art. 20. Nonobstant les dispositions de l'article 19, l'assemblée générale des associés de la Société, par le vote majo-
ritaire déterminé par la loi sur le paiement des dividendes, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (le
cas échéant) peut décider de payer des dividendes intérimaires avant la fin de l'exercice social en cours, sur base d'un
récent état intérimaire des comptes préparé par e conseil de gérance ou le gérant unique lui-même (le cas échéant), et
laissant apparaître que les fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer
ne saurait excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social pour lesquels les comptes annuels ont été
79719
L
U X E M B O U R G
approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles et diminué
des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire".
Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le
capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à
sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 22. Les lois mentionnées à l'article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application
partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites
par Diam International S.à r.l. prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte
que la somme d' Euros 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant A pour une durée indéterminée:
Monsieur Russell Faulkner, né le 12 novembre 1977 à Dubai, avec adresse professionnelle au 25, St George Street,
London, W1S1FS, Royaume-Uni.
2) Sont nommés gérants B pour une durée indéterminée:
Monsieur Philippe Leclercq, né le 18 mai 1968 à Liège, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg;
Mademoiselle Laurence Goblet, née le 27 février 1981 à Malmedy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg.
Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique,
et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.
3) Le siège social de la Société est établi au 1A, rue Thomas Edison, L1445 Strassen.
4) Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 1,623,550 (un million six cent vingt-trois mille
cinq cent cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12,500.-(douze mille cinq cents euros) à EUR
1,635,050.-(un million six cent trente-cinq mille cinquante euros) par l'émission de 1,623,550 (un million six cent vingt-
trois mille cinq cent cinquante) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.-(un euro) chacune, la totalité
devant être entièrement libérée par apport en nature consistant en 250,000 (deux cent cinquante mille) parts sociales
détenues dans la société DIAM International SAS, une société de droit français, ayant son siège social au 40 rue Pierre
Curie, F – 78130 Les Mureaux et enregistrée auprès du Registre de Commerce de Versailles sous le numéro B 431 259
159, pour un montant total de EUR 1,623,550.-(un million six cent vingt-trois mille cinq cent cinquante euros).
Suite à l'augmentation du capital ci-dessus, l'article 8 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la
teneur suivante:
« Art. 8. Le capital social est fixé à Euros 1.636.050,- (un million six cent trente six mille cinquante Euros), représenté
par 1.636.050 (un million six cent trente six mille cinquante Euros) parts sociales de Euros 1,- (un Euro) chacune.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante
les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
79720
L
U X E M B O U R G
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 juin 2010. Relation: LAC/2010/26685. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2010.
Référence de publication: 2010090942/414.
(100101112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.
Inversiones Sociosanitarias S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 144.627.
Les comptes annuels pour la période du 28 janvier 2009 (date de constitution) au 31 décembre 2009 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2010.
Référence de publication: 2010080306/12.
(100091050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Investissements Minéraux et Financiers, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 22.181.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2010.
Référence de publication: 2010080307/10.
(100091528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
IW Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 87.332.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévue par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2009 de sa société
mère, Sogrape Investimentos SGPS ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2010.
Référence de publication: 2010080308/12.
(100091147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Nehr & Sohne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 113.960.
Suite à une réunion du Conseil d'Administration, il a été convenu ce qui suit:
La démission de la société INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., administrateur de la société NEHR & SOHNE S.A. est
acceptée, avec effet immédiat.
La démission de M. Marc LIESCH, administrateur de la société NEHR & SOHNE S.A. est acceptée, avec effet immédiat.
La démission de Mme Andrea THIELENHAUS, administrateur de la société NEHR & SOHNE S.A. est acceptée, avec
effet immédiat.
La démission de la société AUTONOME DE REVISION, E 955, commissaire aux comptes de la société NEHR &
SOHNE S.A., avec effet immédiat.
79721
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2010.
FIDUCIAIRE DE TREVES S.C.
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2010080818/20.
(100091483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
J.P. Morgan Capital Holdings Limited, Société Anonyme.
Siège de direction effectif: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 73.205.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2010.
Certifié conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Marie SCHNEIDER
<i>Acting Secretaryi>
Référence de publication: 2010080310/14.
(100091036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
J.P. Morgan Luxembourg International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 35.418.200,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 81.068.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2010.
Certifié conforme
<i>Pour le conseil de gérance
i>Marie SCHNEIDER
<i>Acting Secretaryi>
Référence de publication: 2010080311/15.
(100091037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Marco Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 118.178.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique en date du 3 novembre 2009 que l'associé unique
prononce la clôture de la liquidation volontaire et déclare que la société anonyme Marco Properties S.A., ayant son siège
social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a définitivement cessé d'exister.
Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la société.
Luxembourg, le 8 juin 2010.
Référence de publication: 2010080340/14.
(100091155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
79722
L
U X E M B O U R G
Jardipal S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 87.856.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010080313/9.
(100091532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
JM Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 123.621.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour JM Holdings S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2010080314/11.
(100091394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
JPMorgan Asset Management Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.452.375,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 36.308.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2010.
Certifié conforme
<i>Pour le conseil de gérance
i>Marie SCHNEIDER
<i>Acting Secretaryi>
Référence de publication: 2010080317/15.
(100091374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Liparus Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 115.929.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 12 avril 2010i>
La démission des sociétés DMC S.àr.l., LOUV S.à r.l. et FINDI S.à r.l. de leurs mandats d'Administrateurs est acceptée.
Madame Ariane VIGNERON, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-
xembourg, Madame Chantal MATHU, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086
Luxembourg et Madame Laurence MOSTADE, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch,
L-2086 Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2011.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.
Certifié sincère et conforme
LIPARUS INVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010080659/19.
(100090645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2010.
79723
L
U X E M B O U R G
Key Plastics Automotive Europe S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 102.406.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2010.
Référence de publication: 2010080319/11.
(100091052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Karal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 106.897.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010080322/9.
(100091505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
KP Automotive S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 102.530.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2010.
Référence de publication: 2010080324/11.
(100091051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Timolux Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 147.316.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 17 juin 2010i>
1. Messieurs Pietro LONGO et Philippe TOUSSAINT ont démissionné de leur mandat de gérant de catégorie A.
2. Messieurs Eric MAGRINI et Benoît NASR ont démissionné de leur mandat de gérant de catégorie B.
3. Messieurs Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de société, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, de-
meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et Cédric CARNOYE,
administrateur de sociétés, né à Charleroi (Belgique), le 14 septembre 1982, demeurant professionnellement à L-1331
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ont été nommés comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.
4. Messieurs David Yung-Ming GAN, administrateur de sociétés,né à Minnesota (Etats-Unis d'Amérique), le 15 févirer
1972, demeurant professionnellement à 6614 Abbottswood, Palos Verdes 90275 CA (Etats-Unis d'Amérique) et Wesley
Toshio SHIMODA administrateur de société, né en Californie (Etats-Unis d'Amérique), le 23 avril 1963, demeurant
professionnellement à 11137 Wagner St. Culver City CA 90230 (Etats-Unis d'Amérique), ont été nommés comme gérant
de catégorie A pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 25 juin 2010.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TIMOLUX INVESTMENTS S.àr.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A
Référence de publication: 2010080424/23.
(100091102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
79724
L
U X E M B O U R G
Kyra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 130.556.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Kyra S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2010080325/12.
(100091220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Lony Finance & Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 143.643.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LONY FINANCE & INVESTMENT S.A.
Référence de publication: 2010080329/10.
(100091096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Luxmarine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 37.795.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010080330/9.
(100091533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Metzeler Automotive Profile Systems S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 75.243.
EXTRAIT
Il résulte des minutes de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 21 mai 2010 que le siège social de la
Société est transféré au 17 rue Glesener, L-1631 Luxembourg avec effet au 21 mai 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2010.
Référence de publication: 2010080335/12.
(100091011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Morgan Stanley Semaine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 117.788.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Morgan Stanley Semaine S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2010080337/11.
(100091157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
79725
L
U X E M B O U R G
Mac Aniaut SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 91.929.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010080338/10.
(100091083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Mamiom Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 103.472.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010080339/10.
(100091110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
MGM Carbon Portfolio S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 120.502.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2010080342/11.
(100091221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Milestone International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 123.241.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Milestone International S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2010080345/12.
(100091502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Northland Resources S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 151.150.
Les comptes annuels pour la période du 18 janvier 2010 (date à laquelle la société a adopté la nationalité Luxembour-
geoise) au 31 janvier 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 21 juin 2010.
Référence de publication: 2010080360/11.
(100091039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
79726
L
U X E M B O U R G
Milestone International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 123.241.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Milestone International S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2010080346/12.
(100091511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Mistral E.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 137.178.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2010080347/12.
(100091098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Moltech Invent S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 29.008.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010080350/9.
(100091206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Opera Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 76.713.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 25/06/2010.i>
<i>Résolution:i>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée générale nomme
jusqu'en 2011:
<i>Administrateurs:i>
- M Michele Russo, industrial manager, résidant en Italie,
- M Pierre Thielen, avocat, résidant à Luxembourg,
- M Gustave Stoffel, conseil économique, demeurant à Luxembourg,
<i>Commissaire:i>
- Picigiemme Sàrl, 38, Haerebierg, L – 6868 Wecker
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25/06/2010.
Pour extrait conforme
<i>Un Administrateuri>
Référence de publication: 2010081128/21.
(100091747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.
79727
L
U X E M B O U R G
Neuheim Lux Group Holding V, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 120.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 137.498.
En date du 11 mai 2010, l'associé Sun ZeusHoldings, LLC, avec siège social au 1209, Orange Street, 19801 Delaware,
Etats-Unis a changé de dénomination pour être désormais Hewden Holdings, LLC.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2010.
Référence de publication: 2010080352/12.
(100091026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Newcontainer Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 18.750,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 122.765.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Newcontainer Management Services S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2010080353/12.
(100091498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Newcontainer Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 18.750,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 122.765.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 18 juin 2010i>
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique accepte la démission de Mr. Hans-Peter HOFFMANN de son poste de gérant de la Société avec
effet immédiat
Dorénavant, le Conseil de Gérance sera composé comme suit:
- Monsieur Peter Kong-Kan IP,
- Monsieur Kenneth Gilbert CAMBIE,
- Monsieur Alain PEIGNEUX,
Pour extrait
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2010080354/18.
(100091564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Property Projects S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 123.936.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010080380/9.
(100091132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
79728
AM HoldCo S.à r.l.
Aura International S.A.
BPT Hansa Lux SICAV-SIF
Café Schlassstuff S.à r.l.
Capgro Holding S.A.
Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l.
Diam International II S.à r.l.
Energy and Infrastructure Management S.à r.l.
Fashion Investment Holdings S.A.
Fides et Spes Spf S.A.
Fides Management S.A.
Fragrance Resources Investments S.à r.l.
Franzen und Brandt
Freighter Leasing S.A.
Green-Concept S.à r.l.
Green Way Arbitrage
Hollywood Investments S.A.
Immo-Nord Guy Kartheiser S.A.
Infotime Analyse Concept S.A.
Inkosi Holding S.A.
Inversiones Sociosanitarias S.à r.l.
Investissements Minéraux et Financiers
IW Investments S.A.
Jamalux SA
Jardipal S.A.
JM Holdings S.à r.l.
JPMorgan Asset Management Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
J.P. Morgan Capital Holdings Limited
J.P. Morgan Luxembourg International S.à r.l.
Karal S.A.
Key Plastics Automotive Europe S.àr.l.
Kmind International S.A.
KP Automotive S.àr.l.
Kyra S.à r.l.
Liparus Invest S.A.
Lony Finance & Investment S.A.
Luxmarine S.A.
Mac Aniaut SPF S.A.
Mamiom Technologies S.A.
Marco Properties S.A.
Metzeler Automotive Profile Systems S.A.
MGM Carbon Portfolio S.à.r.l.
Milestone International S.à r.l.
Milestone International S.à r.l.
Mistral E.E. S.A.
Moltech Invent S.A.
Morgan Stanley Semaine S.à r.l.
Nehr & Sohne S.A.
Neuheim Lux Group Holding V
Newcontainer Management Services S.à r.l.
Newcontainer Management Services S.à r.l.
Nexis S.A.
Northland Resources S.A.
Opera Management S.A.
Peronica S. à r.l.
Projekt A2 SA
Property Projects S.à r.l.
Timolux Investments S.à r.l.
Topco I, S.à r.l.
TPG Sonic V A S.à r.l.
Weisen S.A.
Xaltys S.à r.l.