logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 600

20 mars 2010

SOMMAIRE

Abakus Group Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

28762

Acutas s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28756

Agri-Top Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28756

Albra-Lux Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

28759

Analisis de Procesos Financieros Procesan-

do Luxemburgo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

28766

Arcipelagos Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28798

Astraios S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28758

AV Works Europe Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

28756

Bikenbach Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

28757

Brightside S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28757

Caro S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28757

Carsura Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28757

Classic Marine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28761

Continental-Leasing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

28758

Diversita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28765

Dynamic Global Advisors S.à r.l. . . . . . . . . .

28766

Eccu Business Angels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28761

Ecotank S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28799

Elster Group S.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28767

Entreprise de Construction et de Génie Ci-

vil Ben Scholtes SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28758

Ernster S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28760

Esplanade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28757

Eurazeo Real Estate Lux  . . . . . . . . . . . . . . . .

28800

Financière V.P.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28762

Flora Park S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28760

FPM Realty S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28760

HOS111 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28765

Hôtel-Restaurant SIMMER S.à r.l.  . . . . . . .

28798

Kershipping S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28800

LDV Management II Aerium IV Holding

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28800

Locomotive Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

28756

Merlin Entertainments Group Luxem-

bourg 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28763

MH Germany Property IV S.à r.l.  . . . . . . . .

28760

MH Germany Property XII S.à r.l.  . . . . . . .

28761

Montsoleil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28762

Moventum Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

28755

OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l.  . . . .

28788

Pan Atlantik Trading S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

28762

Romy Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28758

Skyventure S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28765

Starlux International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

28754

Stewball-Ranch S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28798

Tridex A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28756

Ulysses Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

28755

Wisson S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28762

28753

Starlux International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 103.165.

DISSOLUTION

L'an deux mil neuf, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Arthur LE CONTE, employé privé, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard

Emmanuel Servais,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de HANSEN INVEST LIMITED, Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre,

Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, Republique des Seychelles,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 15 décembre 2009.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société STARLUX INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, Boulevard Em-

manuel Servais, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 103.165, a été constituée
suivant acte du notaire soussigné en date du 24 septembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
n°1226 du 30 novembre 2004;

- que le capital social de la société STARLUX INTERNATIONAL S.A. s'élève actuellement à TRENTE-ET-UN MILLE

EUROS (31.000.- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, entièrement
libérées;

- que HANSEN INVEST LIMITED précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les actions;
- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution

anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 15 décembre

2009, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment
provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'actionnaire unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du

passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 15 décembre 2009 étant
seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société STARLUX INTERNATIONAL S.A. est à considérer comme

accomplie et clôturée;

- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;
il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2535 Luxembourg,

16, Boulevard Emmanuel Servais.

<i>Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement mille euros (EUR 1.000.-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: A. LE CONTE, G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55487. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2010.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010027531/55.
(100024445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

28754

Ulysses Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 152.021.346,66.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 125.646.

<i>Transferts de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 18 décembre 2009, que Ulysses Participation S.à

r.l. a transféré à SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST

63.311.928 parts sociales ordinaires
15.827.982 parts sociales préférentielles de catégorie A
15.827.982 parts sociales préférentielles de catégorie B
15.827.982 parts sociales préférentielles de catégorie C
15.827.982 parts sociales préférentielles de catégorie D
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 10 février 2010, que SOCIETE GENERALE BANK

&amp; TRUST a transféré à Ulysses Participation S.à r.l.

21.795.152 parts sociales ordinaires
5.448.788 parts sociales préférentielles de catégorie A
5.448.788 parts sociales préférentielles de catégorie B
5.448.788 parts sociales préférentielles de catégorie C
5.448.788 parts sociales préférentielles de catégorie D

Dès lors, les parts de ces deux associés sont réparties comme suit:
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST:
505.594.687 parts sociales ordinaires
126.398.672 parts sociales préférentielles de catégorie A
126.398.672 parts sociales préférentielles de catégorie B
126.398.672 parts sociales préférentielles de catégorie C
126.398.672 parts sociales préférentielles de catégorie D
Ulysses Participation S.à r.l.:
5.775.674.943 parts sociales ordinaires
1.443.918.762 parts sociales préférentielles de catégorie A
1.443.918.762 parts sociales préférentielles de catégorie B
1.443.918.762 parts sociales préférentielles de catégorie C
1.443.918.762 parts sociales préférentielles de catégorie D
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2010.

Ulysses Luxembourg S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010027401/40.
(100023139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Moventum Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 124.292.

Les comptes annuels au 31/03/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027106/10.
(100023767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

28755

Locomotive Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.077.

<i>Rectificatif du dépôt du 25/01/2010 (No L100011793)

Les comptes annuels au 30.06.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque S.A.
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010027168/14.
(100023247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Agri-Top Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 63.113.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027166/10.
(100023244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

AV Works Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R.C.S. Luxembourg B 135.314.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027165/10.
(100023245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Tridex A.G., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 36.871.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027164/10.
(100023246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Acutas s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4334 Esch-sur-Alzette, 29, rue des Tramways.

R.C.S. Luxembourg B 106.614.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027160/10.
(100023122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

28756

Brightside S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 125.256.

Le bilan au 31.12.2008 a été enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15.02.2010.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Société Anonyme
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2010027258/14.
(100023536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Bikenbach Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.225.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 16 février 2010.

Référence de publication: 2010027155/10.
(100023588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Caro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9166 Mertzig, 11, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 139.132.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027154/10.
(100023740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Carsura Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 122.503.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027104/10.
(100023772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Esplanade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 40.773.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027108/10.
(100023786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

28757

Entreprise de Construction et de Génie Civil Ben Scholtes SA, Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 67, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 27.540.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue au siège de la société

<i>en date du 9 février 2010 à 11.30 heures

L'assemblée générale accepte la démission à ce jour de Monsieur Ben SCHOLTES de son poste d'administrateur et

administrateur délégué, ainsi que la démission de Madame Lony SCHRAM de son poste d'administrateur.

Sont nommés au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2015:
Madame Monique OTTO, née à Luxembourg le 12.10.1961, demeurant à L-9350 Bastendorf, 16A, rue Principale.
Monsieur Pol BALTHASAR, né à Luxembourg le 23.07.1986, demeurant à L-9350 Bastendorf, 16A, rue Principale
Le mandat de Monsieur Tom BALTHASAR, né à Luxembourg le 24.08.1957, demeurant à L-9350 Bastendorf, 16A,

rue Principale est reconduit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2015.

Il est également décidé de reconduire le mandat du commissaire aux comptes la société EWA REVISION S.A., inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 38.937, avec siège à L-9053 ETTELBRUCK, 45, avenue J.F.
Kennedy, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2015.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2010027381/22.
(100023774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Romy Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 143.564.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
ROMY FINANCE S.A.
Signature

Référence de publication: 2010027627/12.
(100024177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

Continental-Leasing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 16.733.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027152/10.
(100023734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Astraios S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 142.930.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027089/10.
(100023695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

28758

Albra-Lux Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 95.070.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendneun, den dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Herr Siegfried PÜTZ, geboren in Dernbach (Deutschland), am 9. März 1942, wohnhaft in L-6683 Mertert, 43, rue de

la Moselle.

Der Komparent erklärt:
1)  Dass  die  Gesellschaft  ALBRA-LUX  HOLDING  S.A.,  mit  Sitz  in  L-2132  Luxemburg,  18,  avenue  Marie-Thérèse,

eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg unter Sektion B, Nummer 95.070, gegründet wurde
gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Alphonse LENTZ, vormals mit Amtswohnsitz in Remich, am 1. August
2003, veröffentlicht im Memorial C Nummer 919 am 8. September 2003.

2) Dass das Gesellschaftskapital der oben genannten Gesellschaft einen jetzigen Stand von einunddreissigtausend Euro

(EUR 31.000,-) hat, eingeteilt in hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-).

3) Dass Herr Siegfried PÜTZ, vorbenannt, alleiniger Eigentümer aller Gesellschaftsaktien ist.
4) Dass Herr Siegfried PÜTZ als einziger Aktionär ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen

Tage auflösen zu wollen.

5) Dass der Komparent sofort die zweite und dritte ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft einberuft,

gemäss Artikel 151 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und beide sofort hintereinander
abhalten wird.

Dass Herr Siegfried PÜTZ, in seiner Eigenschaft als Liquidator, genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der

Gesellschaft ALBRA-LUX HOLDING S.A. besitzt, und die Passiva übernommen hat.

Dass der Liquidationsbericht gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Der Komparent ernennt zum Prüfungskommissar Account Data Europe S.A. mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 77,

route de Trèves, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg unter Sektion B, Nummer 70.580, mit
Auftrag den Liquidationsbericht zu überprüfen.

Nach Kenntnisnahme durch den Komparenten des Berichtes des Prüfungskommissars, stimmt er den Schlussfolge-

rungen des Berichtes zu, und erteilt der Gesellschaft Account Data Europe S.A. Entlast für die Ausübung ihres Mandates.

Der Bericht des Prüfungskommissars, verbleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen.
6) Dass er den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihres Amtes erteilt.
7)  Dass  er  in  einer  dritten  ausserordentlichen  Generalversammlung  die  Auflösung  dieser  Gesellschaft  beschliesst,

welche damit definitiv abgeschlossen ist, unter Vorbehalt der Übernahme aller eventuellen Verpflichtungen der Gesell-
schaft durch den Unterzeichneten.

Somit ist deren Liquidation mit Wirkung auf den heutigen Tage beendet.
Dass die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren in L-6793 Gre-

venmacher, 77, route de Treves, aufbewahrt bleiben werden.

Für alle erforderlichen Schritte, wird dem Eigner einer Ausfertigung gegenwärtiger Urkunde Vollmacht erteilt.
Auf Grund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft ALBRA-LUX HOLDING S.A., vorgenannt,

mit Wirkung zum heutigen Tage festgestellt.

WORUEBER URKUNDE, aufgenommen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Siegfried PÜTZ, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 5 janvier 2010. LAC/2010/561. Reçu 75.-€

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 2. Februar 2010.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2010027567/53.
(100024457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

28759

MH Germany Property IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.847.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 26 janvier 2010

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Jan Willem OVERHEUL en tant que Gérant A de la Société avec effet au 26 janvier 2010;
* Madame Laurence QUÉVY en tant que Gérante A de la Société avec effet au 26 janvier 2010;
* Monsieur Paul CLARKE en tant que Gérant B de la Société avec effet au 26 janvier 2010;
- De nommer:
* Luxembourg Corporation Company S.A., enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B

37974, et ayant son siège au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Luxembourg, en tant que nouveau Gérant A de la
Société avec effet au 26 janvier 2010 pour une durée indéterminée.

* TCG Gestion S.A., enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 67822, et ayant son siège

au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Luxembourg, en tant que nouveau Gérant B de la Société avec effet au 26
janvier 2010 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 5 février 2010.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010027781/24.
(100024077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

FPM Realty S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 117.790.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2010.

Référence de publication: 2010027957/10.
(100024264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

Flora Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 113.978.

Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2010.

Référence de publication: 2010027958/10.
(100024233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

Ernster S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 29.547.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027960/10.
(100024154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

28760

MH Germany Property XII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.889.900,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.080.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 26 janvier 2010

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Jan Willem OVERHEUL en tant que Gérant A de la Société avec effet au 26 janvier 2010;
* Madame Laurence QUÉVY en tant que Gérante A de la Société avec effet au 26 janvier 2010;
* Monsieur Paul CLARKE en tant que Gérant B de la Société avec effet au 26 janvier 2010;
- De nommer:
* Luxembourg Corporation Company S.A., enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B

37974, et ayant son siège au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Luxembourg, en tant que nouveau Gérant A de la
Société avec effet au 26 janvier 2010 pour une durée indéterminée.

* TCG Gestion S.A., enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 67822, et ayant son siège

au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Luxembourg, en tant que nouveau Gérant B de la Société avec effet au 26
janvier 2010 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010027784/24.
(100024085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

Classic Marine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 86.143.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le vendredi 22 janvier 2010

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, accepte la démission du commissaire aux comptes Fiduciaire d'Expertise

Comptable et de Révision Everard-Klein Sàrl et de nommer à compter de ce jour en qualité de nouveau commissaire la
société READ SARL, de siège au 3A Boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg
sous le numéro B 45083. Son mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jonathan BEGGIATO
<i>Président

Référence de publication: 2010027771/15.
(100024536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

Eccu Business Angels, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 143.049.

Suite à la fusion des sociétés PKF Abax Audit (B 142.867) et PKF ABAX AUDIT (B27.761):
En date du 24 décembre 2008 le commissaire PKF Abax Audit, R.C.S. n° B142.867 ayant son siège social au 6, Place

de Nancy L-2212 Luxembourg remplace la société PKF ABAX AUDIT, R.C.S. B27.761 ayant son siège social au 6, place
de Nancy L-2212 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4/2/2010.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2010027780/15.
(100024086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

28761

Financière V.P.I., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 32, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 44.377.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027183/10.
(100023290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Abakus Group Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha.

R.C.S. Luxembourg B 92.735.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027185/10.
(100023407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Pan Atlantik Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha.

R.C.S. Luxembourg B 97.699.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027186/10.
(100023405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Wisson S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha.

R.C.S. Luxembourg B 61.965.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010027187/10.
(100023401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Montsoleil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 61.368.

Le bilan au 31.12.2007 a été enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15.02.2010.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Société Anonyme
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2010027060/14.
(100023548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

28762

Merlin Entertainments Group Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 346.300,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 109.647.

In the year two thousand and ten, on the twenty-second day of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Merlin Entertainments Group Luxembourg 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under

the laws of Luxembourg, with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg trade and companies' register under number B 108.847, here represented by Pierre-Yves Genot, lawyer, residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 22 January 2010.

Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party acting as the sole shareholder of Merlin Entertainments Group Luxembourg 3 S.à r.l., a société

à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 109.647
(the "Company") and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 5 July 2005 published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 1300 of 30 November 2005. The articles of association have been amended
for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 28 December 2005.

The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital from its current amount of three hundred thirty-one

thousand three hundred seventy-five euro (EUR 331,375) up to an amount of three hundred forty-six thousand three
hundred euro (EUR 346,300), through the issuance of five hundred ninety-seven (597) shares, with a par value of twenty-
five euro (EUR 25) each.

<i>Subscription and Payment

All of the five hundred ninety-seven (597) shares have been subscribed by the sole shareholder at a total subscription

price of nine million one hundred sixty-seven thousand twenty-six euro sixty-one cents (EUR 9,167,026.61) out of which
fourteen thousand nine hundred twenty-five euro (EUR 14,925) shall be allocated to the share capital of the Company
and nine million one hundred fifty-two thousand one hundred and one euro sixty-one cents (EUR 9,152,101.61) shall be
allocated to the share premium of the Company.

The subscribed shares have been fully paid up through a contribution in cash so that the total amount of nine million

one hundred sixty-seven thousand twenty-six euro sixty-one cents (EUR 9,167,026.61), equivalent to twelve million seven
hundred ninety thousand one hundred seventy-one US dollars sixteen cents (USD 12,790,171.16) at exchange rate of 21
January 2010 according to which one euro (EUR I) is the equivalent of one US dollar thirty-nine cents (USD 1.39), is at
the disposal of the Company as it has been proven to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder resolved to amend article six paragraph 1 of the articles

of association of the Company, which shall now read as follows:

Art. 6. The Company's share capital is set at three hundred forty-six thousand three hundred euro (EUR 346,300),

represented by thirteen thousand eight hundred fifty-two (13,852) shares having a par value of twenty-five euro (EUR
25) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at four thousand five hundred Euros (4.500.- EUR).

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at

the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

28763

The document having been read to the appearing person, said person signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Merlin Entertainments Group Luxembourg 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante selon

les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, enregistrée au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.847, ici représentée par Pierre-Yves Genot, avocat,
demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 22 janvier 2010.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante agissant en tant qu'associée unique de Merlin Entertainments Group Luxembourg 3 S.à r.l., une société

à responsabilité limitée, constituée et existante selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.647 (la
"Société"), constituée par acte reçu du notaire soussigné en date du 5 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1300, du 30 novembre 2005. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte reçu du notaire soussigné en date du 28 décembre 2005.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de son montant actuel de trois cent trente-et-un mille trois cent

soixante-quinze euro (EUR 331.375) à un montant de trois cent quarante-six mille trois cent euro (EUR 346.300) par
l'émission de cinq cent quatre-vingt-dix-sept (597) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune.

<i>Souscription et Libération

L'intégralité des cinq cent quatre-vingt-dix-sept (597) parts sociales ont été souscrites par l'associé unique pour un

montant total de neuf million cent soixante-sept mille vingt-six euro soixante-et-un cents (EUR 9.167.026,61), dont qua-
torze mille neuf cent vingt-cinq euro (EUR 14.925) seront alloués au capital social et dont neuf million cent cinquante-
deux mille cent et un euro soixante-et-un cents (EUR 9.152.101,61) seront alloués à la prime d'émission des parts sociales.

Les nouvelles parts ainsi souscrites ont été payées en espèces par le souscripteur de sorte que le montant de neuf

million cent soixante-sept mille vingt-six euro soixante-et-un cents (EUR 9.167.026,61), étant égal à douze million sept
cent quatre-vingt-dix mille cent soixante-et-onze dollars US seize cents (USD 12.790.171,16) au taux de conversion de
21 janvier 2010 selon lequel un euro (EUR 1) correspond à un dollar US trente-neuf cents (USD 1,39), est à la disposition
de la Société, comme il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article six paragraphe premier des statuts

de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de trois cent quarante-six mille trois cent euro (EUR 346.300),

représenté par treize mille huit cent cinquante-deux (13.852) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune."

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de quatre mille cinq cents Euros (4.500.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont Acte,
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom, prénoms usuels, état civil et demeure,

le mandataire du comparant a signé avec le notaire, le présent acte,

Signé: P-Y. GENOT, J. ELVINGER.

28764

Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 janvier 2010. Relation: LAC/2010/4026. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 04 FEV. 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010026882/113.
(100023670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

HOS111 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 132.908.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été enregistrés et déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2010.

<i>Pour HOS111 S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille WAGNER / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2010027124/16.
(100023825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Skyventure S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 131.563.

Les comptes annuels au 30.06.2009 ont été enregistrés et déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2010.

<i>Pour SKYVENTURE S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille WAGNER / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2010027127/16.
(100023823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Diversita, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123-125, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 115.375.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010026502/12.
(100022693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

28765

Dynamic Global Advisors S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Analisis de Procesos Financieros Procesando Luxemburgo S.à r.l.).

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 139.328.

L'an deux mille dix, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1) La société "Analisis de Procesos Financieros Procesando SL", ayant son siège social à 48901 Barakaldo (Vizcaya),

Espagne, Herriko Plaza, 9, inscrite au registre de commerce sous le numéro B95513131,

détentrice de cent vingt-cinq (125) parts sociales.
2) Monsieur Daniel Aldasoro Olabegoya, conseiller financier, né à Getxo (Espagne) le 30 janvier 1975, demeurant à

48901 Barakaldo (Vizcaya), Espagne, Herriko Plaza, 9,

détenteur de trois cent soixante-quinze (375) parts sociales.
3) Monsieur Angel Larrauri Zubieta, conseiller financier, né à Bilbao (Espagne) le 10 avril 1953, demeurant à 48901

Barakaldo (Vizcaya), Espagne, Herriko Plaza, 9,

détenteur de deux cent cinquante (250) parts sociales.
4) Monsieur Juan Carlos de Rio Alvarez, programmeur, né à Madrid (Espagne) le 19 septembre 1961, demeurant à

48901 Barakaldo (Vizcaya), Espagne, Herriko Plaza, 9,

détenteur de cinq cents (500) parts sociales.
Les quatre comparants étant ici représentés par Monsieur Jean-Yves STASSER, gérant de sociétés, demeurant pro-

fessionnellement à L-4963 Clemency, 9, rue Basse, en vertu de quatre procurations données le 19 janvier 2010.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-dessus, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à res-

ponsabilité limitée "ANALISIS DE PROCESOS FINANCIEROS PROCESANDO LUXEMBURGO S.à r.l." (numéro d'iden-
tité 2008 24 23 037), avec siège social à L-4963 Clemency, 9, rue Basse, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 139.328,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 mai 2008, publié au Mémorial C, numéro 1640
du 3 juillet 2008,

requièrent le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la société en "DYNAMIC GLOBAL ADVISORS S.à r.l.".
Suite à ce changement de dénomination, l'article 4 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

A) Version anglaise:

Art. 4. The Company will have the name "DYNAMIC GLOBAL ADVISORS S.à r.l.".

B) Version française:

Art. 4. La Société prend la dénomination de "DYNAMIC GLOBAL ADVISORS S.à r.l.".

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l'article 2 des statuts de la société, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur

suivante:

A) Version anglaise:

Art. 2. The object of the Company is investment advisory to Undertaking for Collective Investments (in Transferable

Securities and others), as well as to Specialized Investment Funds. The activities of investment advisory to natural persons
and other entities are excluded."

B) Version anglaise:

Art. 2. La Société a pour objet le conseil en investissement à un ou même à plusieurs Organismes de Placement

Collectif  en  Valeurs  Mobilières,  autres  Organismes  de  Placement  Collectif  ou  Fonds  d'Investissement  Spécialisés.  La
Société ne pourra pas fournir des conseils en investissement à d'autres entités ou personnes physiques."

28766

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à environ huit cent cinquante euros (€ 850.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: STASSER, A.WEBER.
Enregistré à Capellen, le 27 janvier 2010. Relation: CAP/2010/325. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 05 février 2010.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2010026864/63.
(100023873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Elster Group S.E., Société Européenne.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 103.553.

In the year two thousand and ten, on the thirteenth of January.
Before the undersigned, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- "Rembrandt Holdings S.A.", a société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg

with its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg register of commerce and companies under number B 108.466,

here represented by Mrs. Hélène Arvis, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

under private seal on 11 January 2010.

- "Nachtwache Metering Management Vermogensverwaltungs GmbH &amp; Co. KG", with its seat in D-65381 Wiesbaden,

5, Klopstockstrasse, registered with the commercial register of the local court of Wiesbaden under HRA 8299,

here represented by Julia Holm-Hadulla, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

under private seal on 8 January 2010.

The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholders of the parties appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of "ELSTER GROUP S.E." (formerly named "Elster Group S.A.", "Elster

Group S.à r.l.", "Nightwatch Investments S.à r.l." and "Gold Silver S.à r.l."), a Luxembourg European public limited liability
company ("société européenne"), having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 103.553
and incorporated under the Luxembourg law pursuant to a deed dated 4 October 2004 drawn up by Maître Jacques
Delvaux, notary, residing in Luxembourg, whose articles of association (the "Articles") have been published in the Lu-
xembourg official gazette, "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (the "Mémorial") under number 1291 dated
16 December 2004, page 61960; the Articles have been amended for the last time pursuant to two notarial deeds dated
26 October 2009 drawn up by Maître Martine Schaeffer, notary, residing professionally in Luxembourg, published in the
Memorial, under number 2208, dated 12 November 2009, page 105968 and 105972 (the "Company").

The appearing parties representing the whole corporate capital unanimously require the notary to act the following

resolutions:

<i>First resolution

The shareholders decide to transfer, in accordance with the provisions of article 101-1 to article 101-17 of the Lu-

xembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Luxembourg Law"), the registered office
of the Company from 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to Frankenstraße
362, 45133 Essen, Germany (the "Transfer"). The shareholders acknowledge that pursuant to article 101-11 of the Lu-
xembourg Law and Art. 8 paragraph 10 of Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for
a European company (SE) (the "SE Regulation") the Transfer shall take effect on the date on which the Company is
registered in the commercial register of Essen. The shareholders acknowledge further that pursuant to article 101-14 of
the Luxembourg Law and Art. 8 paragraph 13 of the SE Regulation, the Transfer will be effective towards third parties
as from the date of the publication of the new registration of the Company in the commercial register of Essen; however,
as long as the deletion of the Company's registration from the Luxembourg register of commerce and companies has not

28767

been published in the Memorial, third parties may continue to rely on the registered office in Luxembourg, unless the
Company proves that such third parties were aware of the new registered office in Germany.

<i>Second resolution

The shareholders approve the transfer proposal ("projet de transfert") which has been drawn up by the board of

directors  of  the  Company  (the  "Board  of  Directors")  on  26  October  2009  in  accordance  with  article  101-2  of  the
Luxembourg Law, and which has been published in the Memorial on 28 October 2009 under number 2115, page 101492
pursuant to article 101-3 of the Luxembourg Law.

<i>Third resolution

The shareholders decide that the Company will have the name Elster Group SE with effect on the date on which the

Company is registered in the commercial register of Essen.

<i>Fourth resolution

The shareholders decide to amend the Articles of the Company so as to reflect the above resolutions and decide to

fully restate the Articles of the Company in order to adapt them to the requirements of German law in the form as set
out below, with effect on the date on which the Company is registered in the commercial register of Essen pursuant to
article 101-11 of the Luxembourg Law and Art. 8 paragraph 10 of the SE Regulation:

ELSTER GROUP SE

Articles of Association

Chapter I. General Terms

1. Name, Corporate seat, Business year.
1.1 The company is a European public limited-liability company (Societas Europaea) and is named Elster Group SE

("Company").

1.2 The seat of the Company is Essen.
1.3 The business year of the Company is the calendar year.
1.4 The duration of the Company is unlimited.

2. Business purpose.
2. 1 The purpose of the Company is the management of companies and the administration of interests in companies,

in particular companies active in the following business fields: development, construction and manufacturing as well as
the distribution of assets, equipment and services in the fields of gasometry, electrical measurement and hydrometry.

2.2 The purpose of the enterprise shall include in particular the acquisition, holding and administration and the sale of

participations in such companies, their aggregation under common management and the provision of support and advice
to them, including the provision of services to such companies.

2.3 The Company may also be active itself in the business areas specified. This shall not apply to banking transactions

and financial services requiring approval.

2.4 The Company may engage in all kinds of business and take all measures that are related to the business purpose

or that appear to be directly or indirectly useful for achieving that purpose. In doing so, the Company may also establish
branches domestically and abroad, establish and purchase other companies and participate in them, as well as controlling
companies or limiting itself to the administration of its participation. Within the scope of the business purpose of the
Company, the Company is authorized to take out credits and to issue bonds or debt and to give the relevant guaranties
and security.

3. Publications. Any publications of the Company shall be made through the Electronic Federal Gazette, unless other-

wise required by applicable law. Voluntary publications can also be made solely on the Company's website.

Chapter II. Share Capital and Shares

4. Share capital.
4.1 The Company's share capital is EUR 325,252,670. It is divided into 16.320.750 Common Shares with a par value

of 1.00 Euro (par value shares) (the "Common Shares") and 308.931.920 Preferred Shares with a par value of 1.00 Euro
(par value shares) (the "Preferred Shares").

4.2 Each share entitles its holder to one vote, is fully paid up, and has been accorded all of the rights and obligations

of these Articles of Association.

5. Shares.
5.1 The Common Shares will be registered shares.
5.2 The Preferred Shares will be registered shares. The Preferred Shares shall not, subject to § 27 and § 29 of these

Articles of Association, entitle their holders to the assets (Vermögen) or the proceeds of any eventual liquidation of the

28768

Company. The Preferred Shares are granted the privileges established in § 27 of these Articles of Association as regards
the distribution of profits.

5.3 The format and the contents of the share certificates and of the dividend coupons and renewal talons shall be

determined by the Administrative Organ (Verwaltungsrat). Global certificates may be issued. The claim of a shareholder
to confirm their interest in writing (Verbriefen) is barred, as long as a confirmation in writing is not required by the rules
of the stock exchange where the shares are permitted to be traded.

5.4 In case the share capital is increased, the dividend for new shares may be determined in derogation from the

provision under § 60 Aktiengesetz.

6. Transfer of shares / Transfer restrictions.
6.1 Company shares may only be transferred with the approval of the Company. Shareholders of the Company are

allowed to transfer or sell their shares or parts of the shareholdings only in accordance with § 6 of these Articles of
Association. In order for the transfer or sale of shares of the Company to a non-shareholder of the Company, additionally,
the prior approval at a general shareholders' meeting ("General Meeting") of at least three-quarters of all voting shares
is required.

6.2 The shareholders are only permitted to transfer, assign, encumber or create any interest in or right or claim to

their shares in the Company:

6.2.1 as permitted under § 7 of these Articles of Association; or
6.2.2 when required, or in acceptance of an offer made by an Acquirer, under § 8 of these Articles of Association; or
6.2.3 upon a Sale or a Listing of the Company; or
6.2.4 with the prior written consent of the committee of Nachtwache Reserve GmbH, with its corporate seat in

Wiesbaden, entered in the Companies Register of the local court of Wiesbaden under HRB 21891 ("Nachtwache Reserve
GmbH"),

provided that no transfer, assignment, encumbrance or creation of any interest in or right or claim to, or for the benefit

of,  a  competitor  of  the  Acquired  Group  shall  be  permitted  without  the  prior  written  consent  of  the  committee  of
Nachtwache Reserve GmbH.

6.3 Other than in the event of § 6.5 below, upon an increase of the issued share capital of the Company, each person

then holding shares in the Company ("Existing Shareholder") shall have a right to subscribe on the same terms to an
amount of new shares as practicably equal to the proportion of the nominal value of the shares held by the Existing
Shareholder to the nominal value of all the shares then in issue. Such subscription right shall be exercisable for a period
of at least 30 (thirty) days following the resolution to increase the capital or issues new shares. The subscription right
may only be barred - either wholly or in part - in the resolution relating to the capital increase. If new shares are issued
with a premium or in connection with other related obligations (including the obligation to provide additional debt funding)
the same terms and conditions relating to the subscription of the~new shares shall apply to all Existing Shareholders.

6.4 Rembrandt Holdings S.A. (previously known as ELSTER HOLDINGS S.A.) is a company established under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg with its corporate seat in 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand
Duchy Luxembourg, and entered into the Luxembourg Commerce and Companies Register under B 108.466 ("Rembrandt
Holdings S.A."). Rembrandt Holdings S.A., or any of its Affiliates which is an Existing Shareholder, may transfer to any one
or more of its Affiliates the right to subscribe for all or any of the new shares in the Company for which Rembrandt
Holdings S.A. is entitled to subscribe to upon a capital increase.

6.5 An exclusion of subscription rights is permitted, in particular, for capital increases in return for stock for the

purchase of an Affiliate, company, transfer of assets, an exchange of shares or corporate merger. If the new shareholder
is an Affiliate of CVC Funds, the Administrative Organ must obtain a fairness opinion from a reputable independent
investment bank or corporate finance adviser as to the valuation of the shares or assets to be acquired by the Company
and the shares proposed to be issued by the Company. Such opinion shall be addressed to Rembrandt Holdings S.A., the
Nachtwache Metering Management Vermogensverwaltungs GmbH &amp; Co. KG with its corporate seat in 65381 Wiesbaden,
Klopstockstralie 5, entered in the Companies Register of the local court of Wiesbaden under HRA 8299 ("Management
KG") and the Company.

7. Rembrandt holdings S.A.'s permitted transfers / Limitation on transfer restrictions.
7.1 Rembrandt Holdings S.A. shall in its sole discretion have the right to transfer shares, and other securities of the

Company which have been issued to it, to:

7.2 (i) Affiliates (including on a distribution in kind or specie, to the underlying investors in such Affiliates), or (ii) to

another  institutional  investor  which  is  advised  or  managed  by  the  adviser  or  manager  of  such  CVC  Funds,  but  not,
however, companies in which such an investor has invested ("Portfolio Companies"), in each such case without any
restrictions;

7.2.1 with respect to a co-investment or similar scheme ("Co-Investment Scheme") to any person which holds or is

to hold assets for a Co-Investment Scheme or to the Directors, officers, employees and partners entitled to such assets
under the Co-Investment Scheme.

28769

8. Purchase offer and Bring along.
8.1 If shareholders holding more than fifty percent of the issued Common Shares then in issue (the "Selling Investors")

wish to sell all their Common Shares then in issue and find a bona fide arm's length purchaser which is not an Affiliate of
any such shareholders and agree arm's length terms for the sale to such purchaser of all the Common Shares or wish to
tender their Common Shares in a Listing and the Administrative Organ so resolves, then, on receipt of written notification
of such fact, all the other shareholders shall be bound and undertake to accept any offer from such a purchaser or to
tender such Common Shares in such Listing on the same terms as agreed and at the same time as the Selling Investors
sell or tender their Common Shares.

8.2 No sale of Rembrandt Holdings S.A. shares or shares then in issue, shall be made if it would result in any person

(the "Acquirer") alone or acting in concert with a group of persons, holding more than fifty percent of the shares owned
by Rembrandt Holdings S.A. or shares then in issue unless the Acquirer shall have made an offer to all holders of shares
issued by the Company at a price equal to the price or, in cases of other differing share categories, a price which reflects
the economic reality, at which such transfer is to be made.

Chapter III. Executive system and Corporate bodies

9. Executive system and Corporate bodies.
9.1 The Company shall have a one-tier executive system.
9.2 The corporate bodies shall be the General Meeting, the Administrative Organ and the managing directors.

Chapter IV. The Administrative Organ

10. Composition of the Administrative Organ.
10.1 The Administrative Organ consists of at least three and a maximum of ten members ("Directors"). Subject to §

11 the Directors shall be elected by simple majority of the shareholders at a General Meeting.

10.2 lf the Administrative Organ has seven or more Directors, up to three shall be managing directors pursuant to §

20 (the "Managing Members of the Administrative Organ") and the remaining Directors shall be non-managing directors
(the "Non-Managing Members of the Administrative Organ"). If the Administrative Organ has five or six Directors, up to
two of them may be Managing Members of the Administrative Organ. If the Administrative Organ consists of three or
four Directors, then up to one of them may be a Managing Member of the Administrative Organ.

10.3 Directors are appointed for a term of office "of six years. Directors may be reappointed.
10.4 Directors can at any time and without the existence of a compelling reason be removed from office through a

simple majority of the votes at the General Meeting.

10.5 The General Meeting will at all times be free to vote on any removal of office of any Director, it being understood

that

10.5.1 the right of one or more shareholders to appoint a Director according to § 11 includes the right to remove a

Director, who was appointed in accordance with paragraph §11, and

10.5.2 the provisions according to § 10 and § 11 for the appointment and removal of a Director shall apply equally to

the replacement of a Director.

10.6 It is possible to appoint a substitute Director for each regular Director, who will replace the regular Director if

the regular Director ceases to serve during his term in office. The substitute Director shall be appointed in the same way
as the Director for whom he is substituting was selected.

10.7 Each Director and each substitute Director may give up his office without the existence of a compelling reason

after executing a written declaration and providing one month's notice to the chairman. The chairman shall declare his
own resignation vis-a-vis his deputy.

11. Third party rights associated with directors' appointments. As long as CVC European Equity Partners IV (A) LP

or its approved transfer recipient are both Company shareholders, CVC European Equity Partners IV (A) LP is entitled
to appoint at least one Director, or, as the case may be and as permitted by applicable law, two Directors.

12. Chairman, Deputy.
12.1 Subsequent to the General Meeting in which the Directors are appointed, the Administrative Organ shall elect,

in a meeting that does not require special convocation, a chairman and a deputy from among its members. Whomever
received the majority of votes is elected. If no candidate is able to achieve a majority of the votes, a second election shall
take place. If no candidate receives a majority after the second election has taken place, a third election takes place, under
which the candidate with the most votes wins. In the case of a tie, a new vote will be taken.

12.2 In case the chairman or the deputy withdraws before the end of their term, the Administrative Organ shall without

undue delay proceed with a new election for the remaining term of the person who has withdrawn.

12.3 Declarations of intention of the Administrative Organ and of its committees shall be made by the chairman of the

Administrative Organ or, in case of his indisposition, by his deputy.

28770

12.4 In the case of a tie, the vote of the chairman of the Administrative Organ shall be decisive. If the chairman of the

Administrative Organ is a member of an Administrative Organ committee, his vote will also break any voting tie of such
committee.

12.5 The deputy only has the rights and obligations of the chairman whilst the chairman is indisposed.

13. Responsibilities of the Administrative Organ and its relationship to the Managing Directors.
13.1 The Administrative Organ has the power to lead the Company based upon law, these Articles of Association as

well as the Administrative Organ rules of procedure, if such exist. Directors have the same rights and obligations and are
not bound by instructions and orders.

13.2 The Administrative Organ will supervise the activities of the managing directors. The managing directors must

therefore inform the Administrative Organ of their activities on a regular basis. The Administrative Organ may establish
rules of procedure which more closely regulate the activities of the managing directors.

13.3 When exercising the duties of its position, the Administrative Organ shall work together with the managing

directors with confidence and faith. The Administrative Organ is authorized to supervise the managing directors.

13.4 The Administrative Organ shall be authorised to modify and supplement these Articles of Association in view of

their mere wording and composition.

13.5 The Administrative Organ can establish its own rules of procedure.

14. Meeting and Voting.
14.1 The chairman or his deputy shall convene meetings of the Administrative Organ as often as the business of the

Company so requires, but at least once each quarter.

14.2 The meetings of the Administrative Organ shall be called in writing or by email, the place, date, time and preliminary

agenda being indicated with at least seven days notice unless all of the Directors waive these formalities. In urgent cases
the chairman can reduce the notice period as necessary and may call the meeting orally or by telephone. The notice
period shall begin to run on the day following the day on which the invitation is mailed or, if the invitation is transmitted
by email, on the day of transmission. The day of the meeting shall not count as part of the notice period. Meetings of the
Administrative Organ shall be held at the registered office of the Company unless the Administrative Organ unanimously
decides to hold the meeting either abroad or at some place other than Essen.

14.3 Any Director can, by giving the purpose and the reasons, demand that the chairman of the Administrative Organ

without undue delay convene a meeting of the Administrative Organ. The meeting shall take place within two weeks
following such call. In case the demand is not answered, the Director in question may convene the Administrative Organ
themselves by stating the facts and an agenda, and observing the form and the notice periods according to § 14.2.

14.4 As a rule, the Administrative Organ shall make its decisions during meetings. Directors who participate by video

or telephone conference, or similar means of communication, shall be deemed present, provided that no other Director
objects. Directors who are absent may participate in the voting by allowing written votes to be handed over on their
behalf, as long as no other Director objects. Resolutions may also be passed outside of meetings in the form of a written
resolution if this resolution is signed by all Directors and no Director objects to this procedure. Such a resolution may
be concluded via one or more documents, if the content of all documents is the same.

14.5 The Administrative Organ shall be quorate if, upon notice being given to all Directors, at least half of the Directors

are present or represented. Administrative Organ resolutions are passed with the majority of the votes of the present
or represented Directors. In case of a tie, the vote of the chairman shall be decisive. In case the chairman is unable to
attend the meeting, this shall also apply to a vote cast in writing by the chairman. If the chairman is unable to attend and
if nobody submits a written vote on his behalf, the vote cast by the deputy chairman shall be decisive.

14.6 If a quorum cannot be reached, a new meeting of the Administrative Organ with the same agenda will be called,

observing the same form and the notice periods according to § 14.2. In the new meeting, the meeting shall be deemed
to be quorate as long as at least two Directors, at least 50% of which have to be Non-Managing Members of the Admi-
nistrative Organ, are present or represented, provided that the Directors have been notified of these circumstances in
the invitation to the meeting.

14.7 Minutes of the meetings and the resolutions of the Administrative Organ shall be drawn up, signed by the person

chairing the meeting in question and kept with the files of the Company. Such minutes shall state the place and the date
of the meeting, the persons attending, the subjects of the agenda, the main contents of the deliberations, and the reso-
lutions of the Administrative Organ. A copy of the minutes shall be sent to each Director.

14.8 For discussion of individual subjects on the agenda, experts and advisers can be consulted. Observers may as an

exception and with the approval of the chairman of the meeting of the Administrative Organ take part, as long as these
persons do not participate in the consulting and voting procedures and legal participation requirements are not violated.

15. Administrative Organ committees.
15.1 The Administrative Organ may, with a simple majority, appoint one or more committees composed of Directors,

in order to, namely, prepare its proceedings and resolutions and to supervise the implementation of its resolutions. It
can transfer, as far as it is legally permissible, its decision making capabilities to the committees.

15.2 The audit committee and the compensation committee will be appointed as standing committees.

28771

15.3 The members of the committees will be selected by a simple majority of the submitted votes for the relevant

period of office for the given vote. If a committee member retires prematurely, the Administrative Organ will call a by-
election without delay, and no later than its next meeting.

15.4 The committees shall report back to the Administrative Organ about their work on a regular basis.

16. Transactions requiring consent.
16.1 The following transactions shall not be carried out by the managing directors without both the prior express

approval of the Administrative Organ and the approval of the majority of the Non-Managing Members of the Adminis-
trative Organ:

16.1.1 the acceptance of the overall business plan and annual budget for the Company together with its direct and

indirect subsidiary companies (each a "Subsidiary");

16.1.2 the alteration of the accounting reference date of the Company or of any Subsidiary;
16.1.3 the approval of the IFRS accounting "manual (or its successor) used by the Company and its Subsidiaries and

any material changes thereto;

16.1.4 the incurring of borrowings by the Company or any of its Subsidiaries, other than as pursuant to the facilities

agreements that may be entered into from time to time by the Company or as permitted there under;

16.1.5 the alteration of the facilities agreements and/or the intercreditor agreements that may be entered into from

time to time by the Company;

16.1.6 any encumbrance over any asset of the Company or any Subsidiary or the giving of any guarantee by the Company

or any Subsidiary, other than pursuant to or permitted under the facilities agreements that may be entered into from
time to time by the company or in the ordinary course of trading;

16.1.7 any action or omission that would constitute a breach of the facilities agreements or the intercreditor agree-

ments that may be entered into from time to time by the Company;

16.1.8 agreeing, varying or revoking (in whole or in part) a list of transactions which require the prior approval of the

managing directors, as determined by the Administrative Organ;

16.1.9 the entry into, termination or variation of any contract (including employment contracts) or arrangement bet-

ween (a) the Company or any Subsidiary and (b) a Director or a person who is closely connected to a Director, including
the variation of the remuneration or other benefits under such a contract or arrangement, and the waiver of any breach
of such a contract or arrangement;

16.1.10 the acquisition or disposal of a business or real estate with a value in excess of EUR 2,500,00 in the individual

case by the Company or any Subsidiary, unless contained in an annual budget approved pursuant to § 16.1.1 above;

16.1.11 the entering into capital expenditure commitments ("Excess Commitments") in excess of amounts contained

in an annual budget approved pursuant to § 16.1.1 above, if an Excess Commitment exceeds EUR 1,500,000 in an individual
case or the Excess Commitments exceed EUR 3,000,000 in total;

16.1.12 the initiating, setting or compromising litigation (other than debt collection in the ordinary course of trading),

arbitration, or regulatory proceedings or investigations relating to a claim or a risk of EUR 5,000,000 or more in each
case or related series of cases;

16.  1.13 the  appointment of consultants  and  advisors  (other than tax and  legal  advisors and  auditors)  where the

committed or anticipated fees either for a project or within a calendar year are estimated to exceed EUR 600,000 (or
the revocation of any such appointment);

16.1.14 the appointment (or the revocation of the appointment) of the auditors for the group consisting of the Com-

pany (to the extent permitted by law) and its Subsidiaries; and

16.1.15 the acquisition, sale, divestiture of other disposal of any interest, share, any interest in any share or equity

related investment or debt or equity security in other companies or businesses or capital increase in other companies
(including, but not limited to, amalgamation, merger, demerger, consolidation, contribution or asset swap).

17. Audit Committee.
17.1 If the Administrative Organ appoints an audit committee, it shall appoint at least two Non-Managing Members of

the Administrative Organ to the audit committee and instruct the audit committee to carry out the duties set out in this
§17.

17.2 The audit committee shall handle the supervision of the payments systems, the effectiveness of the internal control

systems, the risk management systems and the internal revision systems, in particular the accounting systems in order to
establish the independence of the accounting systems from any additional functions.

17.3 The audit committee shall meet as needed, at least however once per quarter.
17.4 The following resolutions shall not be carried out by the Administrative Organ or the managing directors without

receiving the prior written recommendation of the audit committee, which may only be made on the basis of a duly-
passed resolution of the committee:

17.4.1 the approval of a change of auditors for the Acquired Group;

28772

17.4.2 the review and internal approval of the form and substance of the consolidated accounts of the Acquired Group

if requested by the audit committee.

17.5 The recommendation of the audit committee shall not be binding on the managing directors or the Administrative

Organ. However, for each decision where the managing directors or the Administrative Organ resolve not to follow the
recommendation of the audit committee, it shall convene an extraordinary meeting of the shareholders for the purpose
of the approval of such decision. The notice convening such meeting will include the reasons for the decision proposed
by the managing directors or the Administrative Organ. The resolution of the extraordinary meeting of the shareholders
of the Company on the matter referred to it requires a simple majority of the votes cast.

17.6 The audit committee shall report back to the Administrative Organ on a regular basis.

18. Compensation Committee.
18.1 If the Administrative Organ appoints a compensation committee, it shall appoint at least two Non-Managing

Members of the Administrative Organ to the compensation committee and instruct compensation committee to carry
out the duties set out in this §18.

18.2 The responsibilities of the committee include the development of general compensation principles for the Ad-

ministrative  Organ,  compensation  regulations  for  the  managing  directors  and  the  Non-Managing  Members  of  the
Administrative Organ, the detailed classification of the compensation in its varied constituent parts (fixed compensation,
variable compensation), analysis of the associated performance targets, analysis of the Directors' respective retirement
claims, the preparation of the resolutions concerning the Directors' compensation, including retirement claims and a
regular review of the adequacy of the compensation, taking into consideration the current legal requirements and criteria
of the German Corporate Governance Kodex.

18.3 The compensation committee shall meet when necessary, at least however once per year.
18.4 The following resolutions shall not be carried out by the Administrative Organ or the managing directors without

receiving the prior written recommendation of the compensation committee, based upon a duly passed resolution of the
compensation committee:

18.4.1 general policies for remuneration and benefits for Directors, officers and employees of the Acquired Group,
18.4.2 the introduction, amendment or termination of any pension or benefit schemes (to the extent not contained

in an annual budget approved in accordance with § 16.1 of the Articles of Association),

18.4.3 to the extent permitted by law, the appointment or removal of any Director (or similar officer) and any change

to, termination or entering into employment or service agreements with managing directors (managing directors (ge-
schäftsführende Direktoren), managing directors (Geschäftsführer), board of management (Vorstand) or other corporate
bodies) or administrateurs-délégués as the case may be, of the Company or any subsidiary in each case providing for an
annual remuneration (including target bonus) exceeding an amount of EUR 350,000, and

18.4.4 the determination of an annual bonus structure concerning agreements with managing directors (managing

directors (geschäftsführende Direktoren), managing directors (Geschäftsführer), board of management (Vorstand) or
other corporate bodies) or administrateur-délégués as the case may be, of the Company or any subsidiary, where such
managing directors' service agreements with the respective company in each case provide for an annual remuneration
exceeding an amount of EUR 350,000 (including target bonus), and any similar employee benefit or incentive scheme
relating to the foregoing entities.

18.5 The recommendation of the compensation committee shall not be binding on the managing directors or the

Administrative Organ. However, for each decision where the managing directors or the Administrative Organ resolve
not to follow the recommendation of the compensation committee, it shall convene an extraordinary meeting of the
shareholders for the purpose of the approval of such decision. The notice convening such meeting will include the reasons
for the decision proposed by the managing directors or the Administrative Organ. The resolution of the extraordinary
meeting of the shareholders of the Company on the matter referred to it requires a simple majority of the votes cast.

18.6 The compensation committee shall report back to the Administrative Organ on a regular basis.

19. Directors' remuneration.
19.1 Each Director is entitled to an annual fee of EUR 20,000 (twenty thousand Euro), payable within one week after

the end of the business year. If a Director is also at the same time a managing director, this Director receives no additional
compensation for this position beyond what is in his service contract. Directors who were on the Administrative Organ
for only a part of the year are entitled to a twelfth of the annual compensation for each month in which they were a
Director.

19.2 All Non-Managing Members of the Administrative Organ who fulfil their duties for more than one day per week

have a claim for additional compensation, to be ascertained by the Administrative Organ.

19.3 The Administrative Organ shall ensure that it compensates the individual managing directors (with whom the

Company shall enter into a service agreement) in relation to their responsibilities, performance and the state of the
Company itself. The compensation shall not be increased without a specific reason. This applies by analogy to pensions,
back claims, and related types of benefits.

19.4 The Directors shall be adequately reimbursed for their expenses incurred during their duties as Directors.

28773

19.5 Each Director will be eventually entitled to reimbursement for out-of-pocket expenses regarding the taxes which

result from his participation on the Administrative Organ (such as the value added tax), as far as each Director is able to
separately invoice such sales tax and exercises this right.

19.6 The Company shall provide the Directors with adequate insurance. In particular, the Company will cover the

cost of liability insurance for the Directors (so-called Director's and Officer's insurance), which covers to a reasonable
amount legal liability from their Administrative Organ services and provides for an excess of at least 10 percent of the
damages and up to one and a half times the yearly compensation of the Director.

Chapter V. The Managing Directors

20. Managing Directors.
20.1 The Administrative Organ shall appoint, from its own members or from an external source, one or more managing

directors. Directors can be appointed as managing directors only if a majority of the Administrative Organ making such
appointment is composed of Non-Managing Members of the Administrative Organ.

20.2 The managing directors shall conduct the business of the Company. If multiple managing directors have been

appointed, they are only authorized to lead the Company collectively, unless these Articles of Association or any rules
of procedure enacted by the Administrative Organ dictate otherwise.

20.3 Managing directors may be removed from office at any time though a resolution of the Administrative Organ.

21. Proxy.
21.1 The Company will be represented through two managing directors or through a managing director in conjunction

with a proxy (Prokurist). The Administrative Organ can grant sole power of representation to managing directors. If only
one managing director is appointed, then he may represent the Company alone.

21.2 Each managing director and/or proxy legally authorised to represent the Company together with a managing

director can be - unless otherwise legally prohibited - exempted from the limitations of § 181 BGB.

21.3 When conducting business with the managing directors, the Company shall be represented by the Administrative

Organ.

Chapter VI. The General Meeting

22. Ordinary and Extraordinary General Shareholders' meeting.
22.1 The General Meeting that decides on, inter alia, the discharge of the Directors, the distribution of profits, the

choice of the auditor, the appointment of Directors, provisions of capital raising or reduction and amendments to these
Articles of Association (ordinary general meeting), shall be convened by the Administrative Organ and shall take place
promptly, at the latest within the first six months of each business year, after the receipt of the report of the Administrative
Organ on the results of its verification according to § 26.1 of these Articles of Association.

22.2 Extraordinary general meetings are to be convened whenever required by law or for the benefit of the Company.

23. Location and Convocation.
23.1 The General Meeting of the Company shall take place at its seat or in a city in which a German stock exchange

is situated.

23.2 The Administrative Organ shall decide on the convening of a General Meeting with a simple majority of votes.

For the preparation and format of the General Meeting's resolutions, § 83 AktG applies; the Administrative Organ may
transfer related single tasks to the managing directors.

23.3 Notice of the General Meeting shall be made known on the electronic Federal Gazette at least 30 days prior to

the day on which the shareholders have to register for the General Meeting and shall state the agenda of the meeting.

24. Procedure of the General Meeting.
24.1 The General Meeting shall be chaired by the chairman of the Administrative Organ ("Meeting Chairman"), as long

as he is not simultaneously a managing director. If he is in fact simultaneously a managing director, the General Meeting
will be chaired by the deputy chairman of the Administrative Organ, as long as he is not also a managing director. If he is
also a managing director, then a third person shall be chosen by the Administrative Organ to be Meeting Chairman. A
managing director or the certifying notary may not be chosen as the chairman of the General Meeting.

24.2 If so announced in the invitation to the General Meeting, the Meeting Chairman may allow an audiovisual trans-

mission of the General Meeting through specified methods.

24.3 The Meeting Chairman shall conduct the meeting. He shall determine the order of the speakers. In addition he

can the limit the question and comment period of the shareholders; he can, especially at the beginning or during the
course of the General Meeting, appropriately determine the amount of time for the General Meeting, discussions on
points of the agenda as well as individual question and comments. By the determination of the individual question and
comment time allotments, the Meeting Chairman can take into account first and repeat contributions and additional
criteria. The Meeting Chairman selects the voting procedure. He can choose a different order for proceeding through
the agenda than that stated in the invitation.

28774

25. Voting Rights.
25.1 Each share in the Company entitles its holder to one vote.
25.2 The resolutions of the General Meeting shall be determined with the simple majority of votes, unless mandatory

law provides otherwise. Unless mandatory law provides otherwise, amendments of these Articles of Association shall
require a majority of two thirds of the votes cast or, if at least half of the Company's share capital is represented, the
simple majority of the votes cast. If law requires a majority of capital besides a majority of votes cast in order to pass a
General Meeting resolution, as far as is permitted by law a simple majority of the capital present at the General Meeting
will suffice.

25.3 A General Meeting must be convened following a written request from a Company shareholder representing at

least five per cent of the Common Shares which describes the purpose and justification for such meeting. Shareholders
representing at least five per cent of the Common Shares may request the addition of one or several items to the agenda
of any General Meeting. Such request must be addressed to the Company's registered office by registered mail at least
five days before the date of the meeting.

25.4 The voting right can be exercised via proxy. The Company can determine that the proxy may also be transmitted

via electronic media or telefax and determine the manner of issuance in detail. The details for the transmission of a proxy
will be made known at the time notice of the General Meeting is given.

25.5 If all shareholders are present or represented, they may waive all requirements for convening a General Meeting

and formalities of publication.

25.6 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or

to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company
and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals to be decided
at the meeting, as well as three boxes per proposal, which provide the shareholder with the ability to vote in favour,
against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

25.7 Voting forms which show neither a vote in favour nor against the resolution, nor an abstention, shall be void. The

Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the General Meeting to which they
relate.

25.8 Shareholders are entitled to participate in the meeting by videoconference or by other means of telecommuni-

cation which allows for their identity to be confirmed, and such participation enables them to be deemed present for the
quorum requirements and the voting majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective
participation in the meeting whereby the deliberations of the meeting are transmitted in a continuous manner.

Chapter VII. Annual financial accounts, Distribution of profits

26. Annual financial statements.
26.1 The Administrative Organ shall retain an auditor to carry out an audit of the annual accounts and the consolidated

accounts. The managing directors must provide the annual accounts, annual report, consolidated accounts and the con-
solidated annual report to the Administrative Organ immediately after their preparation. At the same time, the managing
directors should recommend to the Administrative Organ what level of profit distribution should be proposed to the
General Meeting. The Administrative Organ shall verify the annual accounts, the annual report, the consolidated accounts,
the consolidated annual report and the recommendation of how the profits should be distributed.

26.2 The annual accounts, the annual report, the consolidated accounts and the consolidated annual report, as well as

the report of the Administrative Organ and the recommendation for use of profits are to be made available in the offices
of the Company from the time of notice of a General Meeting.

26.3 At the determination of the annual accounts, the Administrative Organ is empowered to allocate the profits that

remain after deduction of the amounts that have to be allocated to the statutory reserve fund and losses carried forward,
either in part or in whole, to other reserve accounts.

27. Distribution rights.
27.1 The General Meeting will determine how to use profits subject to the following §§ 27.2 through 27.4.
27.2 The holders of the Preferred Shares shall obtain from the annual profit, derived from the annual accounts after

amortisations, depreciations, accruals, payments to the reserves set up by the Administrative Organ, and the payment of
any accounts for preferred dividends, a preferred dividend payment in the amount of 5.96 per cent of the par value per
annum for each Preferred Share. In case the distributable profits in any one business year do not cover the preferred
dividends or the preferred dividends are not agreed to in a General Meeting, the respective arrears shall be paid prefe-
rentially without interest out of the profits of the following business years, by settling older arrears before newer arrears,
and the profits of a business year for a payment of preferred amounts shall be paid only after all arrears have been paid
off.

27.3 Following the payment of the preferred dividend pursuant to § 27.2, any remaining profit can be distributed to

the holders of the Common Shares.

27.4 At the completion of the business year, the Administrative Organ, in the scope of § 59 AktG, may decide to pay

an interim dividend in accordance with expected profits.

28775

Chapter VIII. Dissolution, Liquidation

28. Dissolution and Liquidation. In the event of any liquidation or winding up of the Company, the Company shall be

liquidated by one or more liquidators, who need not be shareholders, and who are appointed by the General Meeting
which will determine their powers and fees.

29. Liquidation proceeds.
29.1 The proceeds of liquidation shall be applied to instruments issued by the Company as follows:
29.1.1 firstly, the loan obligations or comparable liabilities shall be fully repaid and pari passu between the holders of

a particular instrument, including in each case all accrued but unpaid interest;

29.1.2 secondly, the paid-up par value of the Preferred Shares, plus the amount of any unpaid dividend, shall be returned

to the preferred shareholder;

29.1.3 finally, the remaining liquidation proceeds shall be distributed among the common shareholders pro rata to the

nominal value of their holdings of Common Shares,

provided that to the extent the proceeds do not suffice for all payments due under any of articles 29.1.1 to 29.1.3 they

shall be paid to the relevant persons entitled thereto pro rata to their entitlements under that article.

Chapter IX. Definitons

30. Definitions.
Acquired Group means Rembrandt Holdings S.A., the Company and each of their subsidiaries from time to time;
Affiliate or Affiliated when used (i) with reference to a specified person (excluding, however, any individual), shall mean

any person that directly or indirectly through one or more intermediaries owns or controls, is owned or controlled by
or is under common control or ownership with the specified person. For such purposes, the term "control" (including
the terms "controlling", "controlled by" and "under common control with") shall mean the possession, direct or indirect,
of the power to direct or cause the direction of the management and business policies of a person, whether through the
ownership of a majority of voting securities, by contract or otherwise; and in addition when used (ii) with reference to
the CVC Funds shall mean where such CVC Fund(s) is a body corporate, any Affiliated Party within the meaning of (i) or
controlled by or under common control with another nominee, trustee, general partner, custodian, adviser or manager
of such CVC Fund(s);

CVC Funds means CVC European Partners IV (A) LP, CVC European Partners IV (B) LP, CVC European Partners IV

(C) LP, CVC European Partners IV (D) LP and CVC European Partners IV (E) LP;

Listing means the making of an application for admission to listing on any internationally recognised securities market

of the shares (or the equivalent securities following a reconstruction or amalgamation) of any of Rembrandt Holdings
S.A. or the Company (being understood that prior to a listing the Company may be converted into" another form) (or
its legal successor as the case may be) or a newly-formed company of which the Company or Rembrandt Holdings S.A.
or its legal successor are subsidiaries or which is wholly-owned by the Company;

Permitted Transfers means a disposal made in accordance with § 7 of the Articles of Association (the transferees of

the Shares transferred as a consequence of the Permitted Transfers being the "Permitted Transferees");

Sale means a sale of more than fifty percent (50%) of the Shares or of the business of the AcquiredGroup in one

transaction or a series of related transactions.

<i>Fifth resolution

The shareholders acknowledge the resignation of the following persons from the Board of Directors:
- Mrs. Emanuela Brero, born on 25 May 1970 in Bra, Italy, residing professionally at 20, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose resignation was effective on 7 January 2010;

- Mrs. Delphine Tempé, born on 15 February 1971 in Strasbourg, France, residing professionally at 291, route d'Arlon,

L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose resignation was effective on 7 January 2010;

- Mr. Hugh Alexander Briggs, born on 8 September 1968 in Harpenden, United Kigdom, residing professionally at 111

Strand, London, WC2R 0AG, United Kingdom, whose resignation was effective on 7 January 2010;

and grant them discharge in respect of the performance of their duties as directors of the Company up to their

respective resignation, such discharge shall be confirmed during the next shareholders' meeting of the Company approving
the annual accounts.

<i>Sixth resolution

The shareholders acknowledge that the following persons, currently being all the members of the Board of Directors,

shall remain in their function as members of the administration board of the Company {Verwaltungsrat) after the date
on which the Company is registered in the commercial register of Essen:

- Mr. Steven Koltes, born on 9 March 1956 in Pennsylvania, United States, residing professionally at 20, avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

28776

- Mr. Howard Dyer, born on 17 January 1950 in Oxford, United Kingdom, residing professionally at Frankenstr. 362,

45133 Essen, Germany;

- Mr. Gregor Hilverkus, born on 12 January 1972 in Wermelskirchen, Germany, residing professionally at Bahnhofs-

trasse 94, 8001 Zürich, Switzerland;

- Mr. Marc Strobel, born on 25 November 1966 in Nürnberg, Germany, residing professionally at Bockenheimer

Landstrasse 24, 60323 Frankfurt, Germany; and

- Mr. Simon Beresford-Wylie, born on 18 May 1958 in Harrogate, United Kingdom, residing professionally at Fran-

kenstr. 362, 45133 Essen, Germany.

<i>Seventh resolution

The shareholders decide to remove KPMG Audit S.à r.l., réviseurs d'entreprises, 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

as independent auditor (réviseur d'entreprises) of the Company and auditor for the Company's consolidated accounts
with effect on the date on which the Company is registered in the commercial register of Essen.

<i>Notarial Verification and Certification

The notary declares in accordance with article 101-10 (2) of the Luxembourg Law, that she has verified and that she

certifies the existence and legality of the required acts and formalities to be fulfilled by the Company for the Transfer and
of the transfer proposal (projet de transfert).

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to one thousand euro (EUR 1,000.-).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by the German version; on request of the appearing parties the German version will prevail.

The document having been read to the proxyholders of the appearing parties known to the notary by their name, first

name, civil status and residence, the proxyholders of the appearing parties signed together with the notary the present
deed.

Es folgt die deutsche Fassung:

Im Jahr zweitausendundzehn, am dreizehnten Januar.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg.

Ist erschienen:

- "Rembrandt Holdings S.A.", eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete société anonyme mit

Sitz in 20, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 108.466,

vertreten durch Frau Hélène Arvis, Rechtsanwältin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, per privatschriftlicher

Vollmacht vom 11. Januar 2010.

- "Nachtwache Metering Management Vermögensverwaltungs GmbH &amp; Co. KG", mit Sitz in D-65381 Wiesbaden, 5,

Klopstockstraße, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter der Nummer HRA 8299,

vertreten durch Frau Julia Holm-Hadulla, Rechtsanwältin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, per privatschriftlicher

Vollmacht vom 8. Januar 2010.

Die besagten Vollmachten, "ne varietur" durch die Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und die unterzeich-

nende Notarin unterzeichnet, bleiben dieser Urkunde beigefügt um mit ihr bei den Registrierungsbehörden eingereicht
zu werden.

Die erschienenen Parteien sind die Aktionäre der "ELSTER GROUP S.E." (früher: "Elster Group S.A.", "Elster Group

S.à r.l.", "Nightwatch Investments S.à r.l." und "Gold Silver S.à r.l."), eine Europäische Aktiengesellschaft Luxemburger
Rechts ("société européenne"), mit Satzungssitz in 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg (Großherzogtum
Luxemburg), eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 103.553, welche nach
Luxemburger Recht gemäß Urkunde des Notars Maître Jacques Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, vom 4. Oktober
2004 gegründet wurde, deren Satzung (die "Satzung") im Luxemburger Amtsblatt, dem "Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations" (das "Mémorial") unter der Nummer 1291, am 16. Dezember 2004 auf Seite 61960 veröffentlicht wurde;
die Satzung wurde zum letzten Mal durch zwei notarielle Urkunden vom 26. Oktober 2009 der Notarin Maître Martine
Schaeffer abgeändert, welche unter der Nummer 2208 am 12. November 2009 auf den Seiten 105968 und 105972 im
Mémorial veröffentliche wurden (die "Gesellschaft").

Die erschienenen Parteien, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, bitten einstimmig die Notarin Folgendes

zu beurkunden:

28777

<i>Erster Beschluss

Die Aktionäre beschließen gemäß den Bestimmungen der Artikel 101-1 bis 101-17 des Luxemburger Gesetzes vom

10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung (das "Luxemburger Gesetz") den Satzungssitz
der Gesellschaft von 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, nach Frankenstraße
362, 45133 Essen, Deutschland, zu verlegen (die "Verlegung"). Die Aktionäre nehmen zur Kenntnis, dass gemäß Artikel
101-11 des Luxemburger Gesetzes und Artikel 8 Absatz 10 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001
über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (die "SE-Verordnung") die Verlegung zu dem Zeitpunkt wirksam wird,
zu dem die Gesellschaft im Handelsregister in Essen eingetragen wird. Die Aktionäre nehmen darüber hinaus zur Kenntnis,
dass die Verlegung gemäß Artikel 101-14 des Luxemburger Gesetzes und Artikel 8 Absatz 13 der SE-Verordnung mit der
Offenlegung der neuen Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister in Essen gegenüber Dritten wirksam ist; jedoch
können sich Dritte, solange die Löschung der Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister nicht im
Memorial veröffentlicht worden ist, weiterhin auf den Satzungssitz der Gesellschaft in Luxemburg berufen, es sei denn
die Gesellschaft beweist, dass den Dritten der neue Sitz der Gesellschaft in Deutschland bekannt war.

<i>Zweiter Beschluss

Die Aktionäre genehmigen den Verlegungsplan ("projet de transfert"), welcher vom Verwaltungsrat der Gesellschaft

(der "Verwaltungsrat") am 26. Oktober 2009 gemäß Artikel 101-2 des Luxemburger Gesetzes erstellt und welcher am
28. Oktober 2009 unter der Nummer 2115 auf Seite 101492 des Memorials gemäß Artikel 101-3 des Luxemburger
Gesetzes veröffentlicht wurde.

<i>Dritter Beschluss

Die Aktionäre beschließen, dass die Gesellschaft die Firma Elster Group SE führen wird mit Wirkung zu dem Zeitpunkt,

zu dem die Gesellschaft im Handelsregister in Essen eingetragen wird.

<i>Vierter Beschluss

Die Aktionäre beschließen die Satzung der Gesellschaft im Sinne der obigen Beschlüsse abzuändern, und beschließen

die Satzung der Gesellschaft in der unten beigefügten Form und gemäß Artikel 101-11 des Luxemburger Gesetzes und
Artikel 8 Absatz 10 der SE-Verordnung mit Wirkung zu dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft im Handelsregister in
Essen eingetragen wird, vollständig neuzufassen, um sie an die Erfordernisse deutschen Rechts anzupassen:

ELSTER GROUP SE

Satzung

I. Kapitel. Allgemeine Bestimmungen

§ 1. Firma, Sitz und Geschäftsjahr der Gesellschaft.
1.1 Die Gesellschaft ist eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) und führt die Firma Elster Group SE.
1.2 Der Sitz der Gesellschaft ist Essen.
1.3 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
1.4 Die Dauer der Gesellschaft ist nicht beschränkt.

§ 2. Gegenstand des Unternehmens.
2.1 Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an Un-

ternehmen, die insbesondere in den Geschäftsfeldern der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und des Vertriebs von
Anlagen, Geräten und Dienstleistungen für die Gas-, Strom- und Wassermessung tätig sind.

2.2 Die Tätigkeit des Unternehmens umfasst insbesondere den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräu-

ßerung von Beteiligungen an solchen Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie deren
Unterstützung und Beratung einschließlich der Übernahme von Dienstleistungen für diese Unternehmen.

2.3 Die Gesellschaft kann in den genannten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. Dies gilt nicht für genehmi-

gungsbedürftige Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen.

2.4 Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Zweck

des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen. Sie kann im Inland und
im Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen sowie
Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Im Rahmen ihres Unternehmensgegen-
standes ist die Gesellschaft berechtigt, Kredite aufzunehmen und Schuldverschreibungen auszustellen und die entsprech-
enden Garantien und Sicherheiten zu geben.

§ 3. Bekanntmachungen. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger, sofern nicht

zwingende gesetzliche Bestimmungen anderes vorsehen. Freiwillige Bekanntmachungen können auch nur auf der Web-
seite der Gesellschaft erfolgen.

28778

II. Kapitel. Grundkapital und Aktien

§ 4. Grundkapital.
4.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 325.252.670,00 (in Worten: dreihundertfünfundzwanzig Million

zweihundertzweiundfünfzigtausend  sechshundertsiebzig  Euro).  Es  ist  eingeteilt  in  16.320.750  Stammaktien  mit  einem
Nennwert je Aktie von 1,00 Euro (Nennbetragsaktien) (die "Stammaktien") und 308.931.920 Vorzugsaktien mit einem
Nennwert je Aktie von 1,00 Euro (Nennbetragsaktien) (die "Vorzugsaktien").

4.2 Jede Aktie hat eine Stimme und ist voll eingezahlt und mit allen in der vorliegenden Satzung enthaltenen Rechten

und Pflichten ausgestattet.

§ 5. Aktien.
5.1 Die Stammaktien lauten auf den Namen.
5.2 Die Vorzugsaktien lauten auf den Namen. Die Vorzugsaktien der Gesellschaft sind am Vermögen und an einem

eventuellen Liquidationserlös der Gesellschaft vorbehaltlich der § 27 und § 29 dieser Satzung nicht beteiligt. Die Aus-
stattung der Vorzugsaktien im Zusammenhang mit der Beteiligung an dem jährlichen Bilanzgewinn ergibt sich aus § 27
dieser Satzung.

5.3 Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Verwaltungsrat. Es

können Sammelurkunden ausgegeben werden. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausge-
schlossen, soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktien
zum Handel zuzulassen sind.

5.4 Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend von § 60 Aktiengesetz geregelt

werden.

§ 6. Übertragung von Aktien / Vinkulierung.
6.1 Die Aktien der Gesellschaft können nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden. Aktionäre dürfen

Aktien oder Beteiligungen an Aktien nur in Übereinstimmung mit § 6 dieser Satzung übertragen oder veräußern. Für die
Übertragung oder Veräußerung von Aktien der Gesellschaft an einen Nichtaktionär dieser Gesellschaft ist zudem eine
vorherige Zustimmung der Hauptversammlung von mindestens drei Viertel aller Stimmrechte der Gesellschaft erforder-
lich.

6.2 Aktionären der Gesellschaft ist eine Übertragung, Abtretung, Belastung oder Schaffung einer Beteiligung, eines

Rechts oder Anspruchs an ihren Aktien der Gesellschaft nur in folgenden Fällen gestattet:

6.2.1 gemäß § 7 dieser Satzung; oder
6.2.2 in den von § 8 dieser Satzung geregelten Fällen; oder
6.2.3 bei einem Verkauf der Gesellschaft oder einer Börsenzulassung der Aktien der Gesellschaft; oder
6.2.4 mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Beirats der Nachtwache Reserve GmbH mit Sitz in Wiesbaden,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRB 21891,

jeweils unter der Bedingung, dass eine Übertragung, Abtretung, Belastung oder Schaffung einer Beteiligung, eines Rechts

oder Anspruchs an oder zugunsten eines Wettbewerbers der übernommenen Gruppe nicht ohne vorherige schriftliche
Zustimmung des Beirats der Nachtwache Reserve GmbH mit Sitz in Wiesbaden, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Wiesbaden unter HRB 21891, zulässig ist.

6.3 Außer im Falle des § 6.5 dieser Satzung muss bei einer Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft jedem Aktionär

("derzeitiger Aktionär") auf sein Verlangen ein seinem Anteil an dem bisherigen Grundkapital entsprechender Teil der
neuen Aktien zugeteilt werden. Für die Ausübung des Bezugsrechts ist vom Verwaltungsrat eine Frist von mindestens
dreißig Tagen nach dem Beschluss zur Kapitalerhöhung oder Ausgabe neuer Aktien zu bestimmen. Das Bezugsrecht kann
ganz oder zum Teil nur im Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals ausgeschlossen werden. Falls neue Aktien mit
einem Aufschlag oder zusammen mit anderen damit verbundenen Verpflichtungen (einschließlich der Verpflichtung zur
Bereitstellung zusätzlichen Fremdkapitals) ausgegeben werden, gelten für alle derzeitigen Aktionäre die gleichen Bedin-
gungen und Konditionen für die Zeichnung neuer Aktien.

6.4 Rembrandt Holdings S.A. (vormals ELSTER HOLDINGS S.A.), eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxem-

burg gegründete Aktiengesellschaft mit Geschäftssitz in 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter B 108.466 (im Folgenden "Rem-
brandt Holdings S.A.") oder eines ihrer verbundenen Unternehmen, das zu diesem Zeitpunkt ein derzeitiger Aktionär ist,
kann das Bezugsrecht im Falle einer Kapitalerhöhung an eines oder mehrere seiner verbundenen Unternehmen für die
Zeichnung der neuen Aktien der Gesellschaft übertragen.

6.5 Ein Bezugsrechtsausschluss ist insbesondere zulässig für Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Erwerb von

Beteiligungen, Unternehmen oder Vermögensgegenständen - auch durch Aktientausch -sowie bei Unternehmenszusam-
menschlüssen, vorausgesetzt, dass der Verwaltungsrat für den Fall, dass der neue Aktionär ein verbundenes Unterneh-
mens  des  CVC-Fonds  ist,  von  einer  anerkannten  unabhängigen  Investmentbank  oder  Corporate-Finanzberater  eine
Stellungnahme zur Vorteilhaftigkeit des Unternehmens(ver)kaufs (fairness opinion) über die Kapitalanteile oder Vermö-
genswerte, die von der Gesellschaft erworben werden sollen, und die Aktien, die von der Gesellschaft ausgegeben werden
sollen, einholen muss und dieses Gutachten an Rembrandt Holdings S.A., die Nachtwache Metering Management Ver-

28779

mögensverwaltungs GmbH &amp; Co. KG, mit Sitz in 65381 Wiesbaden, Klopstockstraße 5, eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRA 8299 (im Folgenden "Management KG") und die Gesellschaft adressieren ist.

§ 7. Zulässige Übertragungen von Rembrandt Holdings S.A. / Beschränkung der Vinkulierung.
7.1 Rembrandt Holdings S.A. hat das Recht, Aktien und sonstige von der Gesellschaft ausgegebene Wertpapiere nach

ihrem alleinigen Ermessen an folgende Empfänger zu übertragen:

7.1.1 jeweils uneingeschränkt an (i) verbundene Unternehmen (darunter auch in einer Natural- oder Sachausschüttung

an die Basisinvestoren dieser verbundenen Unternehmen) oder (ii) an einen anderen institutionellen Anleger, der vom
Berater oder Manager dieses CVC-Fonds beraten oder verwaltet wird, nicht jedoch ein Unternehmen, in das ein solcher
Investor investiert hat ("Portfoliounternehmen");

7.1.2 in Bezug auf eine Ko-Investition oder ein ähnliches Programm („Ko-Investitionsprogramm") an eine Person, die

Vermögenswerte für ein Ko-Investitionsprogramm hält oder halten soll, oder an die Direktoren, leitenden Angestellten,
Beschäftigten und Partner, die gemäß dem Ko-Investitionsprogramm Anspruch auf diese Vermögenswerte haben.

§ 8. Kaufangebot und Gesamtangebot.
8.1 Wenn Aktionäre, die mehr als fünfzig Prozent der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Stammaktien der Gesellschaft

besitzen (die "verkaufsbereiten Anleger"), sämtliche zu diesem Zeitpunkt von ihnen gehaltenen Stammaktien verkaufen
wollen und einen zum Kauf dieser Stammaktien bereiten unabhängigen Dritten finden, der kein verbundenes Unternehmen
eines dieser Aktionäre ist, und Konditionen wie zwischen fremden Dritten für den Verkauf aller ihrer Stammaktien an
diesen Käufer vereinbaren oder ihre Stammaktien bei einer Börsenzulassung andienen wollen und der Verwaltungsrat
einen entsprechenden Beschluss fasst, sind alle anderen Aktionäre nach Erhalt einer schriftlichen Mitteilung über diesen
Sachverhalt verpflichtet und sagen zu, ein Angebot dieses Käufers anzunehmen oder diese Stammaktien bei dieser Bör-
senzulassung zu den vereinbarten Konditionen und zum gleichen Zeitpunkt anzudienen, zu denen die verkaufsbereiten
Anleger ihre Stammaktien verkaufen oder andienen.

8.2 Ein Verkauf von zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Stammaktien der Gesellschaft, die Eigentum der Rembrandt

Holdings S.A. sind, erfolgt nicht, wenn dies dazu führen würde, dass eine Person (der "Übernehmer") allein oder in
Abstimmung mit einer Personengruppe mehr als 50% der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Aktien, die Eigentum der
Rembrandt Holdings S.A. sind, oder zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Aktien besitzt, es sei denn, der Übernehmer hat
allen Inhabern von Aktien der Gesellschaft ein Angebot zu einem Preis unterbreitet, der ebenso hoch ist wie der Preis
bzw. im Falle von Aktien einer anderen Gattung den Preis wirtschaftlich wiederspiegelt, zu dem die genannte Übertragung
vorgenommen werden soll.

III. Kapitel. Leitungssystem und Organe der Gesellschaft

§ 9. Leitungssystem und Organe der Gesellschaft.
9.1 Die Gesellschaft besitzt ein monistisches Leitungssystem.
9.2 Organe der Gesellschaft sind die Hauptversammlung, der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren.

IV. Kapitel. Der Verwaltungsrat

§ 10. Zusammensetzung des Verwaltungsrats.
10.1 Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei und maximal zehn Mitgliedern, die vorbehaltlich § 11 jeweils mit

einfacher Stimmenmehrheit von der Hauptversammlung bestellt werden.

10.2 Hat der Verwaltungsrat sieben oder mehr Mitglieder sind bis zu drei geschäftsführende Direktoren ("geschäfts-

führende  Verwaltungsratsmitglieder"),  die  anderen  sind  nicht-geschäftsführende  Verwaltungsratsmitglieder  ("nicht-ge-
schäftsführende Verwaltungsratsmitglieder"). Hat der Verwaltungsrat fünf oder sechs Mitglieder sind bis zu zwei von ihnen
geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Hat der Verwaltungsrat drei oder vier Mitglieder ist bis zu eines von ihnen
geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

10.3 Die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt für eine Amtszeit von sechs Jahren. Wiederbestellungen sind

zulässig.

10.4 Mitglieder des Verwaltungsrates können jederzeit und ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes durch Beschluss

der Hauptversammlung der Gesellschaft mit einfacher Mehrheit der Stimmen abberufen werden.

10.5 Die Hauptversammlung der Gesellschaft kann jederzeit frei über eine Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds

abstimmen, wobei als vereinbart gilt, dass

10.5.1 das Recht einer oder mehrerer Aktionäre, Mitglieder in den Verwaltungsrat gemäß § 11 zu entsenden, auch das

Recht einschließt, die entsprechend entsendeten Mitglieder des Verwaltungsrats abzuberufen, und

10.5.2 die Bestimmungen gemäß § 10 und § 11 für die Entsendung und Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds

gleichermaßen für den Wechsel eines Verwaltungsratsmitglieds gelten.

10.6 Für jedes Verwaltungsratsmitglied kann mit dessen Bestellung ein Ersatzmitglied bestellt werden, das Mitglied des

Verwaltungsrats wird, wenn das Mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit wegfällt. Das Ersatzmitglied wird nach den Vor-
schriften bestellt, wie das zu ersetzende Verwaltungsratsmitglied.

28780

10.7 Jedes Verwaltungsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des durch eine an den Vorsitzenden zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
niederlegen. Der Vorsitzende erklärt die Niederlegung seines Amts gegenüber seinem Stellvertreter.

§ 11. Entsendung von Verwaltungsratsmitgliedern. Solange CVC European Equity Partners IV (A) LP oder ihre zuläs-

sigen Übertragungsempfänger zusammen Aktionär der Gesellschaft ist bzw. sind, ist der CVC European Equity Partners
IV (A) LP berechtigt ein Mitglied bzw. zwei Mitglieder, wenn gesetzlich zulässig, in den Verwaltungsrat zu entsenden.

§ 12. Vorsitzender des Verwaltungsrates und Stellvertreter.
12.1 Der Verwaltungsrat wählt in einer ohne besondere Einladung stattfindenden Sitzung im Anschluss an die Haupt-

versammlung, in der die Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt worden sind, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt. Gelingt dies keinem Kandidaten, so
ist ein zweiter Wahlgang durchzuführen. Dabei ist gewählt, wer die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt. Gelingt dies
keinem Kandidaten, so ist ein dritter Wahlgang durchzuführen, bei dem der Kandidat gewählt ist, der die meisten Stimmen
erlangt. Bei Stimmgleichheit wird erneut abgestimmt.

12.2 Scheidet der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende während der Amtszeit aus, so hat der Verwal-

tungsrat unverzüglich eine Ergänzungswahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

12.3 Willenserklärungen des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse gibt der Vorsitzende und im Falle seiner Verhin-

derung sein Stellvertreter ab.

12.4 Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates den Ausschlag. Ist der Vorsitzende

des Verwaltungsrates Mitglied eines Ausschusses des Verwaltungsrates, so gibt bei Stimmgleichheit bei Beschlüssen dieses
Ausschusses ebenfalls seine Stimme den Ausschlag.

12.5 Der Stellvertreter hat nur dann die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist.

§ 13. Aufgaben des Verwaltungsrats und Verhältnis gegenüber geschäftsführenden Direktoren.
13.1 Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft nach den gesetzlichen Vorschriften und dieser Satzung der Gesellschaft

sowie der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats, sofern eine solche beschlossen wurde. Mitglieder des Verwaltungsrats
haben gleiche Rechte und Pflichten und sind nicht an Weisungen gebunden.

13.2 Der Verwaltungsrat überwacht die Tätigkeit der geschäftsführenden Direktoren. Er wird dazu von den geschäfts-

führenden  Direktoren  regelmäßig  informiert.  Der  Verwaltungsrat  kann  für  die  geschäftsführenden  Direktoren  eine
Geschäftsordnung erlassen, die das Nähere regelt.

13.3 Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben arbeitet der Verwaltungsrat vertrauensvoll mit den geschäftsführenden

Direktoren zusammen. Der Verwaltungsrat ist gegenüber den geschäftsführenden Direktoren weisungsbefugt.

13.4 Der Verwaltungsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur die Fassung betreffen.
13.5 Der Verwaltungsrat kann sich im übrigen eine Geschäftsordnung geben.

§ 14. Sitzungen und Beschlussfassungen.
14.1 Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter beruft mindestens einmal im Kalendervierteljahr eine Sitzung des Ver-

waltungsrats ein. Im Übrigen finden Sitzungen des Verwaltungsrats so oft statt, wie das Geschäft der Gesellschaft es
erfordert.

14.2 Zu den Verwaltungsratssitzungen wird schriftlich oder per E-Mail mit Angabe von Ort, Datum, Uhrzeit und Angabe

der vorläufigen Tagesordnung mit einer Frist von mindestens sieben Tagen eingeladen, außer wenn alle Verwaltungsrats-
mitglieder auf diese Formalitäten verzichten. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Einberufungsfrist angemessen
verkürzen und auch mündlich oder fernmündlich einberufen. Die Frist beginnt am Tag nach dem Postabsendetag der
Einladung oder, falls die Einladung per E-Mail übermittelt wird, am Übermittlungstag. Für die Berechnung der Frist ist der
Tag der Sitzung nicht mitzurechnen. Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden am Sitz der Gesellschaft abgehalten, außer
wenn der Verwaltungsrat einstimmig beschließt, die Sitzung an einem anderen Ort als Essen oder im Ausland abzuhalten.

14.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass der Vorsitzende

unverzüglich eine Sitzung des Verwaltungsrats einberuft. Die Sitzung muss binnen zwei Wochen nach der Einberufung
erfolgen. Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann der Antragsteller unter Mitteilung des Sachverhalts, der Angabe
einer Tagesordnung und unter Beachtung der Form- und Fristerfordernisse von § 14.2 dieser Satzung selbst den Ver-
waltungsrat einberufen.

14.4 Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Verwaltungsratsmitglieder können auch

über eine Telefonoder Videokonferenz oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel, mit dem mehrere Sitzungsteil-
nehmer gleichzeitig miteinander kommunizieren können, an einer Sitzung teilnehmen und gelten als anwesend, sofern
kein  Mitglied  diesem  Verfahren  widerspricht.  Abwesende  Verwaltungsratsmitglieder  können  an  der  Beschlussfassung
teilnehmen, in dem sie durch anwesende Verwaltungsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen und
kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Beschlüsse können auch außerhalb von Sitzungen durch einen von allen
Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnenden schriftlichen Beschluss gefasst werden, wenn kein Mitglied diesem Ver-
fahren widerspricht. Ein solcher Beschluss kann in einer einzigen Urkunde oder in mehreren gesonderten Urkunden mit
dem gleichen von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichneten Inhalt dokumentiert werden.

28781

14.5 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn nach Einladung sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder mindestens die

Hälfte der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind. Der Verwaltungsrat beschließt mit der Mehrheit der
anwesenden oder vertretenen Mitglieder. Ergibt eine Abstimmung eine Stimmengleichheit, so gibt die Stimme des Vor-
sitzenden den Ausschlag. Dies gilt im Falle einer Verhinderung des Vorsitzenden auch für eine schriftliche Stimmabgabe.
Ist der Vorsitzende verhindert und überreicht niemand für ihn eine schriftliche Stimmabgabe, gibt die Stimme des stell-
vertretenden Vorsitzenden den Ausschlag.

14.6 Ist eine Sitzung nicht beschlussfähig, wird eine neue Verwaltungsratssitzung mit der gleichen Tagesordnung ein-

berufen, wobei die gleiche Einladungsfrist und die gleiche Mitteilungspflicht einzuhalten sind wie in § 14.2 dieser Satzung
angegeben. In dieser neuen Sitzung gilt die Beschlussfähigkeit als hergestellt, solange zwei Verwaltungsratsmitglieder, von
denen mindestens 50% nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder sein müssen, anwesend oder vertreten sind,
jedoch  unter  der  Bedingung,  dass  die  Verwaltungsratsmitglieder  in  der  Einladung  auf  diesen  Sachverhalt  hingewiesen
wurden.

14.7 Über die Sitzungen des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vor-

sitzenden zu unterzeichnen und zu den Akten der Gesellschaft zu nehmen ist. In der Niederschrift sind der Ort und der
Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die
Beschlüsse des Verwaltungsrats anzugeben. Eine Kopie der Niederschrift ist jedem Verwaltungsratsmitglied zuzusenden.

14.8 Sachverständige und Auskunftspersonen können zur Beratung einzelner Tagesordnungspunkte bei Sitzungen des

Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse hinzugezogen werden. Beobachter können in Ausnahmefällen und mit Zustim-
mung des Vorsitzenden an Sitzungen des Verwaltungsrats teilnehmen, sofern diese Personen nicht an Beratungen und
Abstimmungen teilnehmen und gesetzliche Vorschriften einer Teilnahme nicht entgegenstehen.

§ 15. Ausschüsse des Verwaltungsrats.
15.1 Der Verwaltungsrat kann mit einfacher Mehrheit aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bestellen,

namentlich, um seine Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten und die Durchführung seiner Beschlüsse zu überwa-
chen. Er kann den Ausschüssen, soweit gesetzlich zulässig, Entscheidungsbefugnisse übertragen.

15.2 Als ständige Ausschüsse werden Prüfungsausschuss und der Vergütungsausschuss bestellt.
15.3 Die Mitglieder der Ausschüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die bei ihrer Wahl

bestimmte Amtsdauer gewählt. Scheidet ein Ausschussmitglied vorzeitig aus, führt der Verwaltungsrat unverzüglich, spä-
testens jedoch in seiner nächsten Sitzung, eine Nachwahl durch.

15.4 Dem Verwaltungsrat ist regelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse zu berichten.

§ 16. Zustimmungspflichtige Geschäfte.
16.1 Die geschäftsführenden Direktoren bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrats und der Mehrheit der nicht

geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder vor Vornahme folgender Geschäfte durch die Gesellschaft:

16.1.1 Annahme des Gesamtgeschäftsplans und des Jahresbudgets für die Gesellschaft sowie für ihre direkten und

indirekten Tochtergesellschaften (jeweils eine "Tochtergesellschaft");

16.1.2 Änderung des Bilanzstichtags der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft;
16.1.3 Genehmigung des von der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften verwendeten IFRS-Rechnungslegungs-

handbuchs (oder dessen Nachfolgedokuments) und wesentlicher Änderungen desselben;

16.1.4 Aufnahme von Krediten durch die Gesellschaft oder ihre Tochtergesellschaften, außer gemäß den Kreditrah-

menverträgen, die jeweils von der Gesellschaft geschlossen werden können, oder gemäß darin enthaltenen Erlaubnissen;

16.1.5 Änderung der Kreditrahmenverträge und/oder sog. Intercreditorverträge zwischen Gläubigern, die jeweils von

der Gesellschaft abgeschlossen werden können;

16.1.6 Belastung von Vermögensgegenständen der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft oder Stellung einer

Bürgschaft durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft, außer gemäß den Bestimmungen oder Erlaubnissen in
den Kreditrahmenverträgen, die jeweils von der Gesellschaft geschlossen werden können, oder im Rahmen der normalen
Geschäftstätigkeit;

16.1.7 Handlungen oder Unterlassungen, die eine Verletzung der Kreditrahmenverträge oder der Intercreditorvertäge,

die jeweils von der Gesellschaft geschlossen werden können, darstellen würden;

16.1.8 Vereinbarung, Änderung oder Widerruf (ganz oder teilweise) einer Liste von Rechtsgeschäften, die gemäß der

Entscheidung des Verwaltungsrats der vorherigen Genehmigung der geschäftsführenden Direktoren bedürfen;

16.1.9 Abschluss, Kündigung oder Änderung von Verträgen (einschließlich Anstellungsverträgen) oder Vereinbarungen

zwischen (a) der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft und (b) einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einer
Person, die in Bezug auf ein Mitglied des Verwaltungsrates eine nahestehende Person ist, einschließlich Änderung der
Vergütung oder sonstiger Leistungen gemäß einem solchen Vertrag oder einer solchen Vereinbarung, sowie Rechtsver-
zicht bei Verletzung eines solchen Vertrages oder einer solchen Vereinbarung;

16.1.10 Erwerb oder Veräußerung eines Geschäfts oder Grundbesitzes mit einem Einzelwert über EUR 2.500,00 durch

die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft, außer soweit dies in einem gemäß § 16.1.1 genehmigten Jahresbudget
enthalten ist;

28782

16.1.11 Abgabe von Investitionszusagen ("überhöhte Zusagen") über die in einem gemäß § 16.1.1 genehmigten Jahres-

budget enthaltenen Beträge hinaus, wenn eine überhöhte Zusage einzeln EUR 1.500.000 übersteigt oder die überhöhten
Zusagen insgesamt EUR 3.000.000 übersteigen;

16.1.12 Einleitung, Beilegung oder vergleichsweise Beilegung von Rechtsstreitigkeiten (außer Inkasso im Rahmen der

normalen Geschäftstätigkeit), Schiedsverfahren oder Aufsichtsverfahren oder Ermittlungen im Zusammenhang mit einem
Anspruch oder Risiko von EUR 5.000.000 oder mehr in einem Einzelfall oder in einer Reihe zusammenhängender Fälle;

16.1.13 Beauftragung von Gutachtern oder Beratern, mit Ausnahme von Steuerberatern, Rechtsberatern und Wirt-

schaftsprüfern,  wenn  die  zugesagte  oder  zu  erwartende  Vergütung  entweder  für  ein  Projekt  oder  innerhalb  eines
Kalenderjahres voraussichtlich EUR 600.000 übersteigen wird (beziehungsweise der Widerruf einer solchen Beauftra-
gung);

16.1.14 Beauftragung oder Widerruf einer solchen Beauftragung der Wirtschaftsprüfer für die aus der Gesellschaft

(soweit rechtlich zulässig) und ihren Tochtergesellschaften bestehenden Gruppe; und

16.1.15 Erwerb, Verkauf, Veräußerung oder sonstige Verfügung über einer Beteiligung, Anteil oder Aktie, eines Rechts

darauf oder einer eigenen kapitalbezogenen Anlage oder Verbindlichkeit oder ein Wertpapier (fremd-oder eigenkapital-
ähnlich) anderer Unternehmen oder Geschäfte oder eine Kapitalerhöhung oder andere Kapitalmaßnahmen oder Maß-
nahmen nach dem Umwandlungsgesetz (oder vergleichbare Maßnahmen ausländischer Gesellschaften).

§ 17. Prüfungsausschuss (Audit Committee).
17.1 Sofern der Verwaltungsrat einen Prüfungsausschuss bestellt, soll dieser aus mindestens zwei nicht geschäftsführ-

enden Verwaltungsratsmitgliedern bestehen und die in diesem § 17 bezeichneten Aufgaben haben.

17.2 Der Prüfungsausschuss befasst sich mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des

internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der Abschlussprüfung,
hier insbesondere der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistun-
gen.

17.3 Der Prüfungsausschuss tagt nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Kalendervierteljahr.
17.4 Nachfolgende Beschlüsse dürfen vom Verwaltungsrat oder den geschäftsführenden Direktoren nicht ohne vor-

herige schriftliche Empfehlung des Prüfungsausschusses getroffen werden, die auf der Grundlage eines ordnungsgemäß
verabschiedeten Beschlusses des Prüfungsausschusses erfolgt ist:

17.4.1 Genehmigung eines Wechsels der Wirtschaftsprüfer für die übernommene Gruppe;
17.4.2 Prüfung und interne Billigung von Form und Inhalt des Konzernabschlusses der übernommenen Gruppe, sofern

vom Prüfungsausschuss verlangt.

17.5 Die Empfehlung des Prüfungsausschusses ist für die geschäftsführenden Direktoren oder den Verwaltungsrat nicht

bindend.  Für  jede  Entscheidung,  bei  der  die  geschäftsführenden  Direktoren  oder  der  Verwaltungsrat  beschließt,  der
Empfehlung des Prüfungsausschusses nicht zu folgen, ist jedoch eine außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmi-
gung dieser Entscheidung einzuberufen. In der Einladung zu dieser Hauptversammlung sind die Gründe für die von den
geschäftsführenden Direktoren oder vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Entscheidung darzulegen. Für den Beschluss
der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft über die ihr dargelegte Angelegenheit ist die einfache Mehrheit
der abgegebenen Stimmen erforderlich.

17.6 Dem Verwaltungsrat ist regelmäßig über die Arbeit des Prüfungsausschusses zu berichten.

§ 18. Vergütungsausschuss.
18.1 Sofern der Verwaltungsrat einen Vergütungsausschuss bestellt, soll dieser aus mindestens zwei nicht-geschäfts-

führenden Verwaltungsratsmitgliedern bestehenden und die nachfolgend bezeichneten Aufgaben haben.

18.2  Zu  den  Aufgaben  des  Ausschusses  gehören  die  Entwicklung  von  allgemeinen  Vergütungsgrundsätzen  für  den

Verwaltungsrat, Vergütungsregelungen für die geschäftsführenden Direktoren und die nicht-geschäftsführenden Verwal-
tungsratsmitglieder,  die  detaillierte  Aufgliederung  der  Vergütung  in  ihre  verschiedenen  Bestandteile  (Fixvergütung,
variable Vergütung), die Darlegung der damit verbundenen Kopplungsgrößen bzw. Performanceziele, die Darlegung des
Umfangs der jeweiligen Pensionsansprüche der Verwaltungsratsmitglieder, die Vorbereitung der Beschlussfassung über
die Vergütung der jeweiligen Verwaltungsratsmitglieder inklusive ihrer Pensionsansprüche sowie die regelmäßige Über-
prüfung der Angemessenheit der Vergütung unter Zugrundelegung der gesetzlichen Bestimmungen und der Kriterien des
Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner jeweils aktuellen Fassung.

18.3 Der Vergütungsausschuss tagt nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr.
18.4 Folgende Beschlüsse des Verwaltungsrats oder den geschäftsführenden Direktoren bedürfen einer vorherigen

schriftlichen Empfehlung des Vergütungsausschusses, die auf der Grundlage eines ordnungsgemäß verabschiedeten Be-
schlusses des Vergütungsausschusses erfolgt ist:

18.4.1 allgemeine Grundsätze für Vergütung und Nebenleistungen für Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte

und Beschäftigte der übernommenen Gruppe,

18.4.2 Einführung, Änderung oder Kündigung von Pensions- oder Leistungsprogrammen (soweit nicht in einem in

Übereinstimmung mit § 16.1 dieser Satzung genehmigten Jahresbudget enthalten),

28783

18.4.3 soweit gesetzlich zulässig, die Berufung oder Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds (oder eines vergleich-

baren leitenden Angestellten) und Änderung, Kündigung oder Neuabschluss eines Anstellungs- oder Dienstvertrages mit
Geschäftsführern (geschäftsführende Direktoren, Geschäftsführer, Vorstände oder andere Organe) bzw. administrateurs-
délégués der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft, in denen jeweils eine Jahresvergütung (einschließlich Leistungs-
prämie) von mehr als EUR 350.000 vorgesehen ist, und

18.4.4 die Festlegung einer Jahresprämienstruktur für Verträge mit Geschäftsführern (geschäftsführende Direktoren,

Geschäftsführer, Vorstände oder andere Organe) bzw. administrateurs-délégués der Gesellschaft oder einer Tochter-
gesellschaft,  wenn  in  diesem  Dienstvertrag  eines  Geschäftsführers  mit  der  betreffenden  Gesellschaft  jeweils  eine
Jahresvergütung (einschließlich Leistungsprämie) von mehr als EUR 350.000 vorgesehen ist, und vergleichbare Neben-
leistungs- oder leistungsbezogene Vergütungsprogramme für die vorgenannten Organe.

18.5 Die Empfehlung des Vergütungsausschüsses ist für die geschäftsführenden Direktoren oder den Verwaltungsrat

nicht bindend. Für jede Entscheidung, bei der die geschäftsführenden Direktoren oder der Verwaltungsrat beschließt, der
Empfehlung des Vergütungsausschusses nicht zu folgen, ist jedoch eine außerordentliche Hauptversammlung zur Geneh-
migung dieser Entscheidung einzuberufen. In der Einladung zu dieser Sitzung sind die Gründe für die von den geschäfts-
führenden  Direktoren  oder  vom  Verwaltungsrat  vorgeschlagene  Entscheidung  anzugeben.  Für  den  Beschluss  der
außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft über die ihr übertragene Angelegenheit ist die einfache Mehrheit
der abgegebenen Stimmen erforderlich.

18.6 Dem Verwaltungsrat ist regelmäßig über die Arbeit des Vergütungsausschusses zu berichten.

§ 19. Vergütung vom Mitgliedern des Verwaltungsrates.
19.1 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats erhält für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat

eine feste Vergütung in Höhe von EUR 20.000 (zwanzigtausend Euro), zahlbar innerhalb einer Woche nach Ablauf des
Geschäftsjahres. Sofern ein Mitglied des Verwaltungsrats zugleich geschäftsführender Direktor ist, erhält dieses Mitglied
keine  Vergütung  über  seinen  Dienstvertrag  hinaus.  Verwaltungsratsmitglieder,  die  nur  während  eines  Teils  des  Ge-
schäftsjahrs dem Verwaltungsrat angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein Zwölftel der
Vergütung.

19.2 Alle nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder, die an mehr als einem Tag der Woche die Aufgaben

eines Verwaltungsratsmitglieder erfüllen, haben Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung, die vom Verwaltungsrat fest-
zulegen ist.

19.3 Der Verwaltungsrat hat bei der Festsetzung der Gesamtbezüge der einzelnen geschäftsführenden Direktoren (mit

denen von der Gesellschaft ein Dienstvertrag zu schließen ist) dafür zu sorgen, dass diese in einem angemessenen Ver-
hältnis zu den Aufgaben und Leistungen des geschäftsführenden Direktors sowie zur Lage der Gesellschaft stehen und
die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigen. Dies gilt sinngemäß für Ruhegehalt, Hinterbliebenen-
bezüge und Leistungen verwandter Art.

19.4 Den Verwaltungsratsmitgliedern werden die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglieder angefallenen

angemessenen Auslagen erstattet.

19.5 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats erhält evtl. auf den Auslagenersatz bzw. die Verwaltungsratsvergütung entfal-

lende Steuern (wie etwa Mehrwertsteuer) erstattet, soweit das Verwaltungsratsmitglied berechtigt ist, der Gesellschaft
die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausübt.

19.6  Die  Gesellschaft  gewährt  den  Verwaltungsratsmitgliedern  angemessenen  Versicherungsschutz;  insbesondere

schließt die Gesellschaft zugunsten der Verwaltungsratsmitglieder eine Haftpflichtversicherung (sogenannte Director's
and Officers-Versicherung) ab, die die gesetzliche Haftpflicht aus ihrer Verwaltungsratstätigkeit in angemessenem Umfang
abdeckt und ein Selbstbehalt von mindestens 10 Prozent des Schadens bis zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen
jährlichen Vergütung des Verwaltungsratsmitglieds vorsieht.

V. Kapitel. Die geschäftsführenden Direktoren

§ 20. Geschäftsführende Direktoren.
20.1 Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte oder aus einem externen Kreise einen oder mehrere geschäftsfüh-

rende Direktoren. Mitglieder des Verwaltungsrats können zu geschäftsführenden Direktoren bestellt werden, sofern die
Mehrheit des Verwaltungsrats aus Verwaltungsratsmitgliedern besteht, die nicht geschäftsführende Direktoren sind.

20.2 Die geschäftsführenden Direktoren führen die Geschäfte der Gesellschaft. Sind mehrere geschäftsführende Di-

rektoren  bestellt,  so  sind  sie  nur  gemeinschaftlich  zur  Geschäftsführung  befugt,  sofern  diese  Satzung  oder  eine  vom
Verwaltungsrat erlassene Geschäftsordnung nichts Abweichendes bestimmt.

20.3 Geschäftsführende Direktoren können jederzeit durch Beschluss des Verwaltungsrats abberufen werden.

§ 21. Vertretung.
21.1 Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor

gemeinsam mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Der Verwaltungsrat kann geschäftsführenden Direktoren Einzel-
vertretungsbefügnis erteilen. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.

28784

21.2 Die geschäftsführenden Direktoren und zur gesetzlichen Vertretung gemeinsam mit einem geschäftsführenden

Direktor  berechtigte  Prokuristen  können  -  soweit  gesetzlich  nichts  anderes  zwingend  vorgesehen  ist  -  von  den  Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit werden.

21.3 Gegenüber den geschäftsführenden Direktoren wird die Gesellschaft durch den Verwaltungsrat vertreten.

VI. Kapitel. Die Hauptversammlung

§ 22. Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlungen.
22.1 Unverzüglich - spätestens jedoch innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres - nach der Eingang

des Berichts des Verwaltungsrats über das Ergebnis seiner Prüfung gemäß § 26.1 dieser Satzung hat der Verwaltungsrat
die Hauptversammlung einzuberufen, die unter anderem über die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder, die Verwen-
dung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats, die Bestellung des Abschlussprüfers, Maß-
nahmen  der  Kapitalbeschaffung  und  der  Kapitalherabsetzung  und  Satzungsänderungen  beschließt  (ordentliche
Hauptversammlung).

22.2 Wenn das Gesetz oder das Wohl der Gesellschaft es erfordert, ist eine außerordentliche Hauptversammlung

einzuberufen.

§ 23. Ort und Einberufung.
23.1 Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet an deren Sitz oder an einem deutschen Börsenplatz statt.
23.2 Der Verwaltungsrat entscheidet über die Einberufung mit einfacher Mehrheit. Für die Vorbereitung und Ausfüh-

rung von Hauptversammlungsbeschlüssen gilt § 83 AktG entsprechend; der Verwaltungsrat kann einzelne damit verbun-
dene Aufgaben auf die geschäftsführenden Direktoren übertragen.

23.3 Die Einberufung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre zur Hauptver-

sammlung anzumelden haben, unter Angabe der Tagesordnung im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu machen.

§ 24. Durchführung der Hauptversammlung.
24.1 Die Hauptversammlung leitet der Vorsitzende des Verwaltungsrates ("Versammlungsleiter"), sofern dieser nicht

zugleich geschäftsführender Direktor ist. Ist dieser zugleich geschäftsführender Direktor, leitet die Hauptversammlung
der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats, soweit dieser nicht selbst zugleich geschäftsführender Direktor
ist. Bei dessen Verhinderung bestimmt der Verwaltungsrat einen Dritten zum Versammlungsleiter. Ein geschäftsführender
Direktor oder der beurkundende Notar dürfen nicht zum Versammlungsleiter bestimmt werden.

24.2 Wenn dies in der Einladung zur Hauptversammlung angekündigt ist, kann der Versammlungsleiter die audiovisuelle

Übertragung der Hauptversammlung über elektronische Medien in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zulassen.

24.3 Der Versammlungsleiter regelt den Ablauf der Hauptversammlung. Er bestimmt die Reihenfolge der Redner.

Ferner kann er das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere zu Beginn
der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache
zu den Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Frage- und Redebeitrags angemessen festsetzen. Bei der Festlegung
der für den einzelnen Frage- und Redebeitrag zur Verfügung stehenden Zeit kann der Versammlungsleiter zwischen erster
und  wiederholter  Wortmeldung  und  nach  weiteren  sachgerechten Kriterien  unterscheiden. Der Versammlungsleiter
bestimmt das Abstimmungsverfahren. Er kann eine von der Einladung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegen-
stände bestimmen.

§ 25. Stimmrechte.
25.1 Jede Aktie der Gesellschaft gewährt eine Stimme.
25.2 Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen,

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften ent-
gegenstehen, bedarf es für Satzungsänderungen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bzw., sofern
mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Sofern das
Gesetz für Beschlüsse der Hauptversammlung außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt,
soweit gesetzlich zulässig, die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.

25.3 Auf schriftliches Verlangen unter Angabe des Zwecks und der Gründe von Aktionären, die mindestens fünf Prozent

der Stammaktien der Gesellschaft repräsentieren, muss eine Hauptversammlung einberufen werden. Aktionäre, die min-
destens fünf Prozent der Stammaktien der Gesellschaft repräsentieren, können die Aufnahme eines oder mehrerer Punkte
in die Tagesordnung einer Hauptversammlung beantragen. Ein solcher Antrag ist per Einschreiben mindestens fünf Tage
vor dem Datum der Hauptversammlung an den Sitz der Gesellschaft zu senden.

25.4 Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Gesellschaft kann bestimmen, dass

Vollmachten auch mittels elektronischer Medien oder per Telefax erteilt werden können und die Art der Erteilung im
einzelnen  regeln.  Die  Einzelheiten  für  die  Erteilung  dieser  Vollmachten  werden  zusammen  mit  der  Einberufung  der
Hauptversammlung bekannt gemacht.

25.5 Wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind können sie auf alle Einladungsvorschriften und Veröffent-

lichungsformalitäten verzichten.

28785

25.6 Jeder Aktionär kann durch Abstimmungsformulare abstimmen, die per Post oder Telefax an den Sitz der Gesell-

schaft oder an die in der Einladung genannte Adresse gesandt werden. Die Aktionäre dürfen nur Abstimmungsformulare
verwenden, die von der Gesellschaft bereitgestellt wurden und mindestens Ort, Datum und Uhrzeit der Versammlung,
die Tagesordnung der Versammlung, den der Versammlung zur Entscheidung vorgelegten Antrag und für jeden Antrag
drei Kästchen enthält, so dass der Aktionär für oder gegen jeden Beschlussantrag stimmen bzw. sich der Stimme enthalten
kann, indem er das entsprechende Kästchen ankreuzt.

25.7 Abstimmungsformulare, die keine Stimmabgabe für oder gegen den Beschluss oder keine Enthaltung vorsehen,

sind ungültig. Die Gesellschaft wird nur Abstimmungsformulare berücksichtigen, die drei (3) Tage vor der Hauptver-
sammlung, für die sie bestimmt sind, bei ihr eingegangen sind.

25.8 Die Aktionäre sind berechtigt, durch eine Videokonferenz oder Telekommunikationsanlage, die ihre Identifizie-

rung  gestattet,  an  der  Versammlung  teilzunehmen  und  gelten  dann  zur  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit  und  der
Stimmenmehrheit als anwesend. Diese Anlage muss technische Merkmale aufweisen, die eine wirksame Teilnahme an der
Versammlung sicherstellen, bei der die Beratungen in der Versammlung fortlaufend übertragen werden.

VII. Kapitel. Jahresabschluss und Gewinnverwendung

§ 26. Jahresabschluss.
26.1 Der Verwaltungsrat erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag für den Jahres- und Konzernabschluss. Die

geschäftsführenden Direktoren haben den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Konzernabschluss und den Konzernla-
gebericht unverzüglich nach ihrer Aufstellung dem Verwaltungsrat vorzulegen. Zugleich haben die geschäftsführenden
Direktoren dem Verwaltungsrat den Vorschlag vorzulegen, den der Verwaltungsrat der Hauptversammlung für die Ver-
wendung des Bilanzgewinns machen soll. Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht, der Konzernab-
schluss und der Konzernlagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen.

26.2 Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht sowie der Bericht des

Verwaltungsrats und der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung der Hauptversammlung
an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft auszulegen.

26.3 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresabschlusses den Jahresüberschuss, der nach

Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder ganz in
andere Rücklagen einzustellen.

§ 27. Gewinnverwendung.
27.1 Über die Verwendung des. Bilanzgewinns beschließt die Hauptversammlung vorbehaltlich der folgenden §§ 27.2

bis 27.4.

27.2 Vorzugsaktionäre erhalten vorrangig aus dem jährlichen Bilanzgewinn, der sich aus dem Jahresabschluss nach

Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen und dem vom Verwaltungsrat gebildeten Rücklagen sowie nach
Zahlung etwaiger Rückstände auf Vorzugsdividenden ergibt, eine Vorzugsdividende je Vorzugsaktie in Höhe von 5,96
Prozent des Nennbetrages per annum. Reicht der verteilbare Bilanzgewinn in einem Geschäftsjahr nicht zur Zahlung der
Vorzugsdividende aus oder wird eine Vorzugsdividende in einem Jahr nicht beschlossen, so ist der sich daraus ergebende
Rückstand ohne Zinsen aus dem Bilanzgewinn der folgenden Geschäftsjahre vorrangig nachzuzahlen, und zwar so, dass
die älteren Rückstände vor den jüngeren zu tilgen und die aus dem Gewinn eines Geschäftsjahres für dieses zu zahlenden
Vorzugsbeträge erst nach Tilgung sämtlicher Rückstände zu leisten sind.

27.3 Nach Ausschüttung der Vorzugsdividende im Sinne von § 27.2 kann der verbleibende Bilanzgewinn an die Stamm-

aktionäre ausgeschüttet.

27.4 Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Verwaltungsrat im Rahmen des § 59 Aktiengesetz einen Abschlag auf

den voraussichtlichen Bilanzgewinn an die Aktionäre zahlen.

VIII. Kapitel. Auflösung, Liquidation

§ 28. Auflösung und Abwicklung.
28.1 Bei einer Abwicklung der Gesellschaft wird die Gesellschaft durch einen oder mehrere Abwickler abgewickelt,

die  keine  Aktionäre  sein  müssen  und  die  von  der  Hauptversammlung  bestellt  werden,  die  auch  ihre  Befugnisse  und
Vergütungen festlegt.

§ 29. Abwicklungserlös.
29.1 Der Abwicklungserlös wird für die von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien wie folgt verwendet:
29.1.1 Erstens sind die Darlehensverpflichtungen oder vergleichbare Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären voll-

ständig zurückzuzahlen und zu gleichen Teilen zwischen den Inhabern eines bestimmten Wertpapiers aufzuteilen, jeweils
einschließlich aller aufgelaufenen, jedoch noch nicht gezahlten Zinsen;

29.1.2 zweitens ist der geleistete Nennbetrag der Vorzugsaktien zuzüglich des Betrages eventuell noch nicht ausge-

schütteter Dividenden den Inhabern der Vorzugsaktien zurückzuzahlen;

29.1.3 schließlich wird der verbleibende Liquidationserlös auf die Aktionäre der Stammaktien anteilig zum Nennwert

ihres Bestands an Stammaktien aufgeteilt,

28786

jeweils unter der Bedingung, dass dann, wenn der Erlös nicht für alle nach einem der §§ 29.1.1 bis 29.1.3 fälligen

Zahlungen ausreicht, er den betreffenden Personen, die Anspruch darauf haben, jeweils anteilig zu ihren Ansprüchen aus
dem betreffenden Paragrafen gezahlt wird.

IX. Kapitel. Begriffsbestimmungen

§ 30. Begriffsbestimmungen.
Übernommene Gruppe bezeichnet Rembrandt Holdings S.A., die Gesellschaft und jede ihrer jeweiligen Tochterge-

sellschaften;

Verbundenes Unternehmen oder verbunden bezeichnet bei Verwendung (i) in Bezug auf eine bestimmte Person (je-

doch mit Ausnahme natürlicher Personen) jede Person, die direkt oder indirekt über eine oder mehrere Mittelspersonen
Eigentümer der bestimmten Person ist oder sie beherrscht, ihr Eigentum ist oder von ihr beherrscht wird oder mit ihr
unter  gemeinsamer  Beherrschung  oder  in  gemeinsamem  Eigentum  steht.  In  diesem  Sinne  bezeichnet  der  Begriff
"Beherrschung" (einschließlich der Begriffe "beherrschend", "beherrscht von" und "unter gemeinsamer Beherrschung")
den direkten oder indirekten Besitz der Macht, die Geschäftsführung und Geschäftspolitik einer Person zu bestimmen
oder bestimmen zu lassen, sei es durch Eigentum einer Mehrheit stimmberechtigter Wertpapiere, durch Vertrag oder
auf anderem Wege, und ferner bei Verwendung (ii) im Zusammenhang mit dem CVC-Fonds, wenn diese(r) CVC-Fonds
eine juristische Person ist (sind), jede verbundene Partei im Sinne von (i) bzw. jede verbundene Partei, die von einem
anderen Beauftragten, Treuhänder, Komplementär, Depotbank, Berater oder Manager dieses (dieser) CVC-Fonds be-
herrscht wird oder zusammen mit ihm unter gemeinsamer Beherrschung steht;

CVC-Fonds bezeichnet CVC European Equity Partners IV (A) LP, CVC European Equity Partners IV (B) LP, CVC

European Equity Partners IV (C) LP, CVC European Equity Partners IV (D) LP und CVC European Equity Partners IV (E)
LP;

Überhöhte Zusagen hat die dem Begriff in § 16.1.11 dieser Satzung beigemessene Bedeutung;
Börsenzulassung bezeichnet die Stellung eines Antrags auf Börsenzulassung an einem international anerkannten Wert-

papiermarkt für die Aktien (oder der entsprechenden gleichwertigen Wertpapiere nach einer Reorganisation oder einem
Zusammenschluss) von Rembrandt Holdings S.A. oder der Gesellschaft (wobei als vereinbart gilt, dass die Gesellschaft
vor einer Börsenzulassung in eine andere Rechtsform umgewandelt werden kann) (bzw. deren Rechtsnachfolgers) oder
einer neu gegründeten Gesellschaft, deren Tochtergesellschaft die Gesellschaft oder Rembrandt Holdings S.A. oder deren
Rechtsnachfolger sind oder die eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gesellschaft ist;

Zulässige Übertragungen bezeichnet eine Veräußerung in Übereinstimmung mit § 7 dieser Satzung (und die Übertra-

gungsempfänger der auf Grund der zulässigen Übertragung übertragenen Aktien sind die "zulässigen Übertragungsemp-
fänger");

Verkauf bezeichnet einen Verkauf von über fünfzig Prozent (50%) der Aktien oder des Geschäfts der übernommenen

Gruppe in einer einzigen Transaktion oder einer Reihe miteinander verbundener Transaktionen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Aktionäre nehmen den Rücktritt folgender Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft jeweils

mit Wirkung zum 7. Januar 2010 zur Kenntnis:

- Frau Emanuela Brero, geboren am 25. Mai 1970 in Bra, Italien, mit beruflicher Anschrift in 20, avenue Monterey,

L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Frau Delphine Tempé, geboren am 15. Februar 1971 in Straßburg, Frankreich, mit beruflicher Anschrift in 291, route

d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

- Herr Hugh Alexander Briggs, geboren am 8. September 1968 in Harpenden, Vereinigtes Königreich, mit beruflicher

Anschrift in 111 Stand, London, WC2R 0AG, Vereinigtes Königreich.

Die Aktionäre erteilen diesen vorgenannten Personen Entlastung für ihre Tätigkeit als Mitglieder des Verwaltungsrates

der Gesellschaft bis zum Zeitpunkt ihres jeweiligen Rücktritts, wobei die Entlastung in der nächsten Generalversammlung
der Gesellschaft, welche über den Jahresabschluss der Gesellschaft entscheidet, bestätigt werden soll.

<i>Sechster Beschluss

Die Aktionäre bestätigen, dass die folgenden Personen, aus denen derzeit der gesamte Verwaltungsrat der Gesellschaft

besteht, ihre Funktion als Mitglieder des Verwaltungsrates nach dem Zeitpunkt, zu welchem die Gesellschaft im Han-
delsregister in Essen eingetragen wird, beibehalten werden:

- Herr Steven Koltes, geboren am 9. März 1956 in Pennsylvania, USA, mit beruflicher Anschrift in 20, avenue Monterey,

L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Howard Dyer, geboren am 17. Januar 1950 in Oxford, Vereinigtes Königreich, mit beruflicher Anschrift in

Frankenstraße 362, 45133 Essen, Deutschland;

- Herr Gregor Hilverkus, geboren am 12. Januar 1972 in Wermelskirchen, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in

Bahnhofstraße 94, 8001 Zürich, Schweiz;

28787

- Herr Marc Strobel, geboren am 25. November 1966 in Nürnberg, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in Bock-

enheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt, Deutschland; und

- Herr Simon Beresford-Wylie, geboren am 18. Mai 1958 in Harrogate, Vereinigtes Königreich, mit beruflicher Anschrift

in Frankenstraße 362, 45133 Essen, Deutschland.

<i>Siebter Beschluss

Die Aktionäre beschließen die Absetzung von KPMG Audit S.à r.l., réviseurs d'entreprises, 9, allée Scheffer, L-2520

Luxemburg als unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) der Gesellschaft und als Wirtschaftsprüfer für
den konsolidierten Jahresabschluss der Gesellschaft mit Wirkung zu dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft im Han-
delsregister in Essen eingetragen wird.

<i>Notarielle Überprüfung und Beglaubigung

Die Notarin erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 101-10 (2) des Luxemburger Gesetzes, dass sie das Vorliegen und

die Rechtmäßigkeit der erforderlichen Rechtshandlungen und Formalitäten, insbesondere des Verlegungsplans (projet de
transfert) überprüft hat und diese bezeugt.

<i>Kosten und Aufwendungen

Die Kosten, Aufwendungen, Entgelte oder Gebühren, in welcher Form auch immer, die im Zusammenhang mit der

vorliegen Urkunde der Gesellschaft auferlegt und ihr in Rechnung gestellt werden, werden auf eintausend Euro geschätzt.

Hierüber wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg an dem eingangs erwähnten Datum erstellt.
Die unterzeichnende Notarin, welche Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in

Englisch erstellt wird, gefolgt von der deutschen Fassung; auf Verlangen der erschienenen Parteien genießt die deutsche
Fassung Vorrang.

Nachdem dieses Dokument den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche der Notarin nach ihren Namen,

Vornamen, Familienstand und Wohnsitz bekannt sind, vorgelesen wurde, haben die Bevollmächtigten der erschienenen
Parteien zusammen mit der Notarin die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Signé: H. Arvis, J. Holm-Hadulla et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 janvier 2010. LAC/2010/2713. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2010.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010026367/1188.
(100022990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 151.276.

STATUTES

In the year two thousand ten, on the eleventh day of Janyary:
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Oaktree Opportunities Fund VIII, L.P., a exempted limited partnership organised under the laws of the Cayman

Islands, having its registered office at Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman,
KYI-9002, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership of the Cayman Islands under
number WK-33548;

and
2. Oaktree Opportunities Fund VIII (Parallel), L.P., a exempted limited partnership organised under the laws of the

Cayman Islands, having its registered office at Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand
Cayman, KYI-9002, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership of the Cayman Islands
under number WK-33552;

both represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of

proxies given under private seal,

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

28788

Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Form - Corporate name. The name of the company is OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l. (the Company). The

Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these
articles of incorporation (the Articles).

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company

within the City of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board
of Managers.

3. Object.
3.1 The objects of the Company are to invest in a portfolio of domestic or foreign securities or similar instruments,

including but not limited to shares, warrants and equity securities, bonds, notes, loans and other debt instruments or
securities, trade receivables or other forms of claims, obligations (including but not limited to synthetic securities obli-
gations), to acquire rights or participations in loans and in financial derivatives agreements or instruments, to enter into
any other agreements relating to such portfolio and to grant and receive pledges, guarantees or other security interests
of any kind under any law. The Company may invest in real estate whatever the acquisition modalities including but not
limited the acquisition by way of sale or enforcement of security.

3.2 The Company may also:
(a) raise funds through, including, but not limited to, the issue of notes (including asset linked notes), bonds, promissory

notes and other debt instruments or debt securities, the use of financial derivatives or otherwise and obtain loans or any
other form of credit facility;

(b) advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or other companies in which it has a direct or

indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any
company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies" and each
as a "Connected Company").

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another
company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the
company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether
through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

(c) enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company or any of the
Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of any applicable law;

(d) enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the

Company may provide credit protection to the swap counterparty;

(e) enter into agreements, including, but not limited to:
1. underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration

agreements, selling agreements and other contracts for services;

2. interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in connection with the

objects mentioned under 3.2 (a), (b), (c), (d), and (e) 1 above; and

3. bank and cash administration agreements, liquidity facility agreements, credit insurance agreements and agreements

creating security in connection with the objects mentioned under 3.2 (a), (b), (c), (d), (e) 1 and 2 above.

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

28789

3.3 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or

operation and in general, enter into all transactions agreements and arrangements which are necessary to fulfil its object
as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object in all areas described
above, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II. - Capital, Shares

5. Share capital.
5.1 The corporate capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by

twelve million five hundred thousand (12,500,000) ordinary shares (the Ordinary Shares), without nominal value.

The Company may also create and issue (i) class A "tracker" shares (in case of plurality, the Class A Shares and

individually, a Class A Share), (ii) class B "tracker" shares (in case of plurality, the Class B Shares and individually, a Class
B Share), (iii) class C "tracker" shares (in case of plurality, the Class C Shares and individually, a Class C Share), (iv) class
D "tracker" shares (in case of plurality, the Class D Shares and individually, a Class D Share), (v) class E "tracker" shares
(in case of plurality, the Class E Shares and individually, a Class E Share), (vi) class F "tracker" shares (in case of plurality,
the Class F Shares and individually, a Class F Share), (vii) class G "tracker" shares (in case of plurality, the Class G Shares
and individually, a Class G Share) and (viii) class H "tracker" shares (in case of plurality, the Class H Shares and individually,
a Class H Share), without nominal value (collectively, the Tracker Shares, and individually, a Tracker Share) that will track
the performance and returns of the underlying assets that they will track. The Ordinary Shares and the Tracker Shares
shall collectively and irrespectively of their class be designated as the Shares and individually and irrespectively of their
class be designated as a Share. The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders. Each Share entitles
its holder to one vote.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced one or more times by a resolution of the general

meeting of the Shareholders, adopted in the manner required for amendment of these Articles.

5.3 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. Any share premium paid in respect of the subscription of any Tracker Share of a specific class upon
their issuance shall be allocated to a share premium reserve account corresponding to that specific class of Tracker Shares,
to be denominated by the corresponding letter.

5.4 All shares will have equal rights, except as otherwise provided for in these articles.

6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted

per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

7.3 In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share without

the prior written consent of the Board of Managers.

Chapter III. - Management

8. Management.
8.1 The Company is managed by a board of managers (the "Board of Managers" or the "Managers"). The members of

the Board of Managers need not be shareholders.

8.2 They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of

votes.

8.3 Any decision in connection with the management of the Company shall be taken collectively by the Board of

Managers in compliance with article 12 of the Articles.

8.4 Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to any two Managers as

provided by article 8 of the Articles, and pursuant to article 191 bis paragraph 5 of the Law, any deed, agreement or
generally any document executed in compliance with articles 8 and 10 of the present Articles are valid and binding vis-à-
vis third parties. The exercise of the general power of representation by any two Managers does not require prior approval
by the Board of Managers acting collectively.

9. Powers of the board of managers. In dealing with third parties and without prejudice to articles 8 and 10 of the

present Articles, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and
to carry out and approve all administration and disposition acts and operations consistent with the Company's objects.

10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of any

two Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any two Managers.

28790

11. Delegation and Agent of the board of managers.
11.1 Any two Managers, acting jointly, may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
11.2 Any two Managers, acting jointly, will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the

duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

12. Meeting of the board of managers.
12.1 The meetings of the Board of Managers are convened by any two Managers. In case that all the Managers are

present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

12.2 Any member of the Board of Managers may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing

or by telegram or telefax or email or letter another member as his proxy. A member of the Board of Managers may also
appoint another member to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.3 The resolutions by the Board of Managers are validly adopted if approved by more than half of the members of

the Board of Managers, present or represented.

12.4 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

member of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not
using this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall
be authorised to vote by video or by telephone.

12.5 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by more than

half of the members of the Board of Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent
by fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers'
meetings, physically held.

12.6 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is

confirmed in writing.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the

meeting. Extracts shall be certified by any two members of the Board of Managers or by any person nominated by any
two members or during a meeting of the Board of Managers.

Chapter IV. - General meeting of shareholders

13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.
13.1 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Board of Managers.

13.2 In particular, the general meeting of the Shareholders is authorized to amend the Articles of the Company, to

change the nationality of the Company and to increase the commitments of its Shareholders.

13.3 Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he owns.

Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

13.4 In case of one Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general Shareholders'

meeting and its decisions recorded are in minutes or drawn-up in writing.

14. Holding of general meetings.
14.1 Shareholders meetings may always be convened by any two Managers, failing which by Shareholders representing

more than half of the capital of the Company.

14.2 The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Shareholders does not exceed

twenty-five. In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

14.3 Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held

each year on the first Friday of June.

14.4 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the

Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Board of Managers.

15. Majorities.
15.1 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the Share capital

adopt them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be
convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast,
regardless of the portion of capital represented.

15.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three-

quarters of the Company's Share capital, in accordance with any provisions of the Law.

15.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be

increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

28791

Chapter V. - Business year

16. Business year.
16.1 The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.
16.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Managers and the Board

of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

16.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

17. Distribution right of shares.
17.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

17.2 From the net profit thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's
nominal capital.

17.3 After the allocation of any profits to the above statutory reserve account, all further profits shall be distributed

and paid as follows:

(a) the holders of the Shares of each class shall, pro rata the capital invested by each of them in respect of their Shares

(nominal value and, as the case may be, share premium), be entitled to a dividend equal to (i) any proceeds and income
derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any
other proceeds and income) from its direct investment in the assets acquired with the proceeds of the subscription for
the Shares of such class, minus (ii) any costs directly related to such investment, items (i) and (ii) to be determined by
the Board of Managers;

(b) the general meeting of the Shareholders has discretionary power to dispose of the surplus, if any. It may in particular

allocate such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward.

Chapter VI. - Liquidation

18. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

19. Liquidation.
19.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing

three-quarters of the Company's share capital.

19.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders  who  shall  determine  their  powers  and  remuneration.  Unless  otherwise  provided  in  the  resolution  of  the
Shareholders or by law, the liquidator(s) shall be invested with the broadest powers available under applicable law for
the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company, it being specified that the liquidation surplus of the
Company is to be disposed of in the manner provided for in article 17.3 of these Articles.

Chapter VII. - Applicable law

20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is

made in these Articles.

21. Transitory provision. The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31,

2010.

<i>Subscription - Payment

Thereupon,
(1) Oaktree Opportunities Fund VIII, L.P., prenamed and represented as stated above declares to subscribe for nine

million two hundred and forty-three thousand two hundred and twenty-five (9,243,225) ordinary shares in registered
form, without nominal value and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to nine thousand two
hundred and forty-three euro and twenty-two point five cents (EUR 9,243.225); and

(2) Oaktree Opportunities Fund VIII (Parallel), L.P., prenamed and represented as stated above declares to subscribe

for three million two hundred and fifty-six thousand seven hundred and seventy-five (3,256,775) ordinary shares in re-
gistered form, without nominal value and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to three thousand
two hundred and fifty-six euro and seventy-seven point five cents (EUR 3,256.775).

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved

to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

28792

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entirety of

the subscribed share capital, have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Szymon DEC, born on July 3, 1978 in Lodz, Poland, residing professionally at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;
- Hugo NEUMAN, born on October 21, 1960 in Amsterdam, The Netherlands, residing at 16, rue J.B. Fresez, L-1724

Luxembourg;

- Jean-Pierre BACCUS, born on September 14, 1976 in Malmedy, Belgium, residing professionally at 53, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg;

- Christopher BOEHRINGER, born on January 1, 1971 in Forbes, Australia, residing professionally at 27 Knightsbridge,

London SW1X 7LY, United Kingdom; and

- Pedro URQUIDI, born on May 29, 1970 in EI Paso, United States of America, residing professionally at 27 Knights-

bridge, London SW1X 7LY, United Kingdom.

2. The registered office of the Company is set at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the latter signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le onze janvier.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. Oaktree Opportunities Fund VIII, L.P., un exempted limited partnership organisé selon les lois des Iles Cayman,

ayant son siège social à Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KYI-9002,
Iles Cayman, immatriculé au Registrar of Exempted Limited Partnership sous le numéro WK-33548;

Et
2. Oaktree Opportunities Fund VIII (Parallel), L.P., un exempted limited partnership organisé selon les lois des Iles

Cayman, ayant son siège social à Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman,
KYI-9002, Iles Cayman, immatriculé au Registrar of Exempted Limited Partnership sous le numéro WK-33552;

Tous deux représentés par Madame Ariette Siebenaler, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxem-

bourg, en vertu de procurations données sous seing privé,

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

1. Forme - Dénomination. Le nom de la société est "OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l." (la Société). La Société est

une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la Ville de

Luxembourg.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être  transféré  provisoirement  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Conseil de Gérance.

28793

3. Objet.
3.1 Les objets de la Société sont d'investir dans un portefeuille comprenant des titres ou autres instruments, luxem-

bourgeois ou étrangers tels que, mais sans que cela soit limitatif, des actions, warrants et autres titres représentatifs de
capital, des obligations, des prêts et autres instruments similaires, des créances commerciales ou autres formes de créan-
ces, des dettes, des obligations (notamment, sans que ceci soit limitatif, des obligations de couvertures synthétiques),
d'acquérir des droits ou des participations dans des prêts ou contrats sur des produits dérivés ou autres instruments, de
conclure des contrats relatifs à ce portefeuille et de fournir des gages, garanties et autres sûretés de toutes sortes soumis
à une quelconque loi. La Société peut également investir dans l'immobilier quelles que soient les modalités d'acquisition
notamment, sans que ceci soit limitatif, l'acquisition par voie d'achat ou suite à l'exercice de sûretés. La Société peut
également:

(a) réunir des fonds, et notamment émettre des obligations (notamment, sans que ceci soit limitatif, des obligations

traçantes), des billets à ordre, des titres de créance et autres dettes, utiliser des instruments financiers dérivés ou autres
et conclure des emprunts ou tout autre forme de moyen de crédit;

(b) avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les "Sociétés Apparentées" et chacune
une "Société Apparentée");

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même "groupe" que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société,
que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme con-
trôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du
capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

(c) accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement

personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces
méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute
assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par toute loi applicable;

(d) entrer dans toute forme de contrats de crédit dérivés tels que, mais sans que cela soit limitatif, des contrats de

swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contrepartie;

(e) conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative:
1. des contrats de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats

d'administration et autres contrats de services, des contrats de vente, en relation avec les capitaux que la Société s'est
procurée;

2. des contrats d'échange sur devises ou taux d'intérêts et tous autres contrats sur des produits dérivés en relation

avec les objets mentionnés dans l'article 3.2 les points (a), (b) (c) (d) et (e)1 ci-dessus;

3. des contrats bancaires, contrats de facilités de crédit, des contrats d'assurance-crédit et des contrats portant sur

des garanties en relation avec les objets mentionnés dans l'article 3.2 points (a), (b), (c) (d) et (e)1 et 2 ci-dessus, il est
entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités pouvant
être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

3.3 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières

et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir béné-
ficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital, Parts

5. Capital social.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze millions

cinq cent mille (12.500.000) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires) sans valeur nominale. La Société peut
également créer et émettre (i) des parts sociales de classe A "tracker" (en cas de pluralité les Parts Sociales de Classe A
et individuellement une Part Sociale de Classe A), (ii) des parts sociales de classe B "tracker" (en cas de pluralité les Parts
Sociales de Classe B et individuellement une Part Sociale de Classe B), (iii) des parts sociales de classe C "tracker" (en
cas de pluralité les Parts Sociales de Classe C et individuellement une Part Sociale de Classe C), (iv) des parts sociales de
classe D "tracker" (en cas de pluralité les Parts Sociales de Classe D et individuellement une Part Sociale de Classe D),
(v) des parts sociales de classe E "tracker" (en cas de pluralité les Parts Sociales de Classe E et individuellement une Part
Sociale de Classe E), (vi) des parts sociales de classe F "tracker" (en cas de pluralité les Parts Sociales de Classe F et
individuellement une Part Sociale de Classe F), (vii) des parts sociales de classe G "tracker" (en cas de pluralité les Parts
Sociales de Classe G et individuellement une Part Sociale de Classe G) et (viii) des parts sociales de classe H "tracker" (en
cas de pluralité les Parts Sociales de Classe H et individuellement une Part Sociale de Classe H), sans valeur nominale

28794

(collectivement les Parts Sociales Tracker et individuellement une Part Sociale Tracker) qui traceront la performance et
le rendement des actifs sous-jacents qu'elles suivront.

Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Tracker seront collectivement et sans tenir compte de leur classe

désignées les Parts Sociales, et individuellement et sans tenir compte de leur classe une Part Sociale.

Les détenteurs des Parts Sociales seront désignés ensemble les Associés. Chaque Part Sociale donne à son détenteur

droit à un vote.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par une décision de l'assemblée

générale des Associés adoptée selon la manière requise pour modifier ces Statuts.

5.3 En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission

payée pour toute Part Sociale sera versée. Toute prime d'émission payée pour la souscription de n'importe quelle Part
Sociale Tracker d'une classe spécifique lors de son émission sera affectée à un compte de réserve prime d'émission
correspondant à cette classe spécifique de Parts Sociales Tracker, et en portera la lettre correspondante.

5.4 Toutes les Parts Sociales auront des droits égaux sauf stipulation contraire des Statuts.

6. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part

Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

7. Transfert des parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

7.3 Chaque Associé s'engage à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales qu'il détient

sans le consentement préalable et écrit du Conseil de Gérance.

Titre III. - Gérance

8. Gérance.
8.1 La Société est gérée par un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance" ou les "Gérants"). Les membres du Conseil

de Gérance ne sont pas obligatoirement associés.

8.2 Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des Associés titulaires de

la majorité des votes.

8.3 Toute décision à prendre concernant la gestion de la Société sera prise collectivement par le Conseil de Gérance

conformément à l'article 12 des Statuts.

8.4 Envers les tiers, le pouvoir général de représentation de la Société est conféré à deux Gérants tel que stipulé à

l'article 8 des Statuts, et en vertu de l'article 191 bis paragraphe 5 de la Loi, tout acte, contrat ou généralement tout
document exécuté en conformité aux articles 8 et 10 sont valables et créeront des obligations à la charge de la Société
vis-à-vis des tiers. L'exercice du pouvoir général de représentation par deux Gérants ne requiert pas l'approbation pré-
alable du Conseil de Gérance agissant collectivement.

9. Pouvoirs du conseil de gérance. Dans les rapports avec les tiers et sans préjudice des articles 8 et 10 des présents

Statuts, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes
d'administration et de disposition et toutes opérations conformes à l'objet social.

10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de

deux Gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par deux Gérants.

11. Délégation et Agent du conseil de gérance.
11.1 Deux Gérants agissant conjointement peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour

des tâches déterminées.

11.2 Deux Gérants agissant conjointement déterminent les responsabilités et la rémunération (le cas échéant) de tout

mandataire, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation de deux Gérants. Lorsque tous les Gérants sont présents ou

représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

12.2 Tout membre du Conseil de Gérance est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance

par un autre membre, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax,
d'un email ou d'une lettre. Un membre du Conseil de Gérance pourra également nommer par téléphone un autre membre
pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.3 Toute décision du Conseil de Gérance est valablement adoptée lorsqu'elle est approuvée par plus de la moitié

des membres du Conseil de Gérance, présent ou représenté.

12.4 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de

28795

technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou
la vidéo.

12.5 Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées

et approuvées par écrit par plus de la moitié des membres du Conseil de Gérance. Cette approbation peut résulter d'un
seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même
effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil de Gérance physiquement tenue.

12.6 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tel que télécopie, e-

mail, télégramme, facsimilé ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés

aux séances. Des extraits seront certifiés par deux des Gérants ou par toute personne désignée par les deux Gérants ou
lors d'une réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - Votes.
13.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Conseil de Gérance.

13.2 L'assemblée générale des Associés est notamment compétente pour modifier les Statuts de la Société, changer

la nationalité de la Société et augmenter les engagements de ses Associés.

13.3 Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales dé-

tenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts Sociales détenues par lui

13.4  Lorsqu'un  Associé  détient  toutes  les  Parts  Sociales,  il  exerce  tous  pouvoirs  qui  sont  conférés  à  l'assemblée

générale des Associés et ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

14. Tenue d'assemblées générales.
14.1 Des assemblées générales pourront toujours être convoquées par deux membres du Conseil de Gérance, à défaut

par les Associés représentant plus de la moitié du capital de la Société.

14.2 La tenue d'assemblée générale n'est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à vingt-

cinq. Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

14.3 Lorsqu'il y aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale le premier

vendredi du mois de juin.

14.4 Quel que soi le nombre d'Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des

Associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge à donner au Conseil de Gérance.

15. Majorités.
15.1 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié

du capital social les adoptent. Si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première réunion ou consultation par écrit, les
Associées sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la
majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

15.2 Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'Associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

15.3 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne peuvent

être décidés qu'avec l'accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

Titre V. - Exercice social

16. Exercice social.
16.1 L'année sociale commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre de chaque année.
16.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance et

celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

16.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

17. Droit de distribution des parts.
17.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-

sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

17.2 Du bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

17.3 Après affectation des bénéfices à la réserve légale ci-dessus, tous les bénéfices restants seront distribués et payés

comme suit:

(a) les détenteurs des Parts Sociales de chaque classe auront, au pro rata du capital investi par chacun d'eux pour leurs

Parts Sociales (valeur nominale et, le cas échéant, prime d'émission), droit à un dividende égal à (i) tous les produits et

28796

tout revenu réalisés par la Société (en ce compris, sans limitation, les dividendes, les gains sur capital, les boni de liquidation,
les produits d'une vente ou tout autre produit ou revenu) sur leur investissement direct dans les avoirs acquis grâce au
produit de la souscription aux Parts Sociales de cette classe, moins (ii) tous les coûts directement liés à cet investissement,
les points (i) et (ii) étant déterminés par le Conseil de Gérance;

(b) l'assemblée générale des Associés peut disposer du surplus, s'il y en a, à sa discrétion. Elle peut, en particulier,

affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, le transférer à une réserve ou le reporter.

Titre VI. - Liquidation

18. Causes de dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,

d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

19. Liquidation.
19.1 La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés représentant les

trois quarts du capital social de la Société.

19.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations. Sauf stipulation contraire suivant décision des Associés ou en vertu de la
Loi, le(s) liquidateur(s) sera (seront) investi(s) des pouvoirs les plus larges prévus par la loi applicable pour réaliser les
actifs et assurer le paiement du passif de la Société, étant précisé qu'il sera disposé du boni de la liquidation de la Société
de la manière prévue à l'Article 17.3 des présents Statuts.

Titre VII. - Loi applicable

20. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la

loi.

21. Disposition transitoire. La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 dé-

cembre 2010.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés,
(1) Oaktree Opportunities Fund VIII, L.P., prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à

neuf millions deux cent quarante-trois mille deux cent vingt-cinq (9.243.225) parts sociales ordinaires sous forme nomi-
native sans valeur nominale et les libérer entièrement par versement en espèces de neuf mille deux cent quarante-trois
euros et vingt-deux virgule cinq cents (EUR 9.243,225); et

(2) Oaktree Opportunities Fund VIII (Parallel), L.P., prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare sou-

scrire à trois millions deux cent cinquante-six mille sept cent soixante-quinze (3.256.775) parts sociales ordinaires sous
forme nominative sans valeur nominale et les libérer entièrement par versement en espèces de trois mille deux cent
cinquante-six euros et soixante-dix-sept virgule cinq cents (EUR 3.256,775); et

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.200.-.

<i>Décisions des associés

Et aussitôt après la constitution de la Société, les associés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris

les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Szymon DEC, né le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, ayant son adresse professionnelle au 53, avenue Pasteur, L-2311

Luxembourg;

- M. Hugo NEUMAN, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant au 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Lu-

xembourg;

- Jean-Pierre BACCUS, né le 14 septembre 1976 à Malmedy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 53, avenue

Pasteur, L-2311 Luxembourg;

-  Christopher  BOEHRINGER,  né  le  1erjanvier  1971  à  Forbes,  Australie,  ayant  son  adresse  professionnelle  au  27

Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni; et

-  Pedro  URQUIDI,  né  le  29  mai  1970  à  El  Paso,  Etats-Unis  d'Amérique,  ayant  son  adresse  professionnelle  au  27

Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni.

2. Le siège social de la Société est établi au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

28797

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 janvier 2010. Relation: LAC/2010/1890. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 février 2010.

Référence de publication: 2010027597/527.
(100024328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

Hôtel-Restaurant SIMMER S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5416 Ehnen, 117, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 57.778.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature

Référence de publication: 2010026451/13.
(100022503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Arcipelagos Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8023 Strassen, 14B, rue des Violettes.

R.C.S. Luxembourg B 98.520.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par voie circulaire lors de la réunion du Conseil d'Administration en date du 4 février

2010 que:

- Monsieur Cesare Sagramoso, administrateur, demeurant à CH-6900 Lugano, 19, Via Cantonale, a été nommé Pré-

sident du Conseil d'Administration;

Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle de la Société appelée à statuer sur

l'exercice clôturé au 30 septembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8 février 2010.

Pour extrait conforme
LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010028029/19.
(100024665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

Stewball-Ranch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4499 Limpach, 11, rue Centrale.

R.C.S. Luxembourg B 89.911.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le onze février.
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

28798

Ont comparu:

1.- Madame Gabrielle Aline Emilie dite Gaby SERVAIS, institutrice, née à Luxembourg le 28 mai 1949, demeurant à

L-4499 Limpach, 11, rue Centrale.

2- Monsieur Emmanuel François Ernest Joseph dit Emmanuel SERVAIS, fonctionnaire, né à Esch-sur-Alzette le 26 mai

1949, demeurant à L-8156 Bridel, 24, rue Lucien Wercollier.

3.-  Madame  Diane  Marie-Jeanne  Paulette  dite  Diane  DIEDERICH,  institutrice,  née  à  Luxembourg  le  6  août  1971,

demeurant à L-3313 Bergem, 88c, Grand-Rue.

Lesquels comparants déclarent être le seuls associés de la société ci-après désignée et ont requis le notaire instru-

mentaire de documenter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée "STEWBALL-RANCH S.à r.l." établie et ayant son siège social à L-4499 Limpach,

11, rue Centrale, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 novembre 2002, publié
au Mémorial C numéro 1780 du 14 décembre 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 89911.

- Que le capital social de ladite société est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-), divisé en

CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune entièrement
libérées.

- Que les comparants sont détenteur de l'intégralité des parts sociales et ont décidé de dissoudre et de liquider ladite

société, celle-ci ayant cessé toute activité le 31 décembre 2009.

Un bilan de clôture a été dressé au 31 décembre 2009.
- Que partant, ils prononcent la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Qu'ils déclarent avoir réglé tout le passif de la société et transféré tous les actifs à leur profit.
- Qu'ils se trouvent donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle, et règleront également les frais
des présentes.

- Qu'en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clôturée

et liquidée.

- Que décharge pleine et entière est accordée à la gérante de la société, Mademoiselle Natasha Paulette Manuela dite

Natasha SERVAIS, monitrice d'équitation, née à Salvador (Brésil) le 15 août 1983, demeurant à L-4499 Limpach, 11, rue
Centrale, pour l'exercice de son mandat.

- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-4499 Limpach, 11,

rue Centrale.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G.Servais, E.Servais, D.Diederich, Moutrier Blanche
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 février 2010. Relation: EAC/2010/1744. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 11 février 2010.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2010027561/50.
(100024489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

Ecotank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 119.021.

<i>Extrait des décisions de l'assemblée générale du 10 février 2010

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs pour une année, soit jusqu'à l'issue de

l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2010.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de délégué à la gestion journalière de Fabrice MAIRE, pour une

année, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2010.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le cabinet Compagnie Européenne de Révision sis 15, rue des Carrefours

L-8124 Bridel - RCSL no B-37039, en qualité de commissaire aux comptes pour une année, soit jusqu'à l'issue de l'as-
semblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2010.

28799

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010028033/17.
(100024628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

Eurazeo Real Estate Lux, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.397,29.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 94.709.

La Société a été constituée suivant l'acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-

Duché de Luxembourg), en date du 15 juillet 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations - n°
901 du 3 septembre 2003. Modifié en date du 8 avril 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
- n° 751 du 22 juillet 2004. Modifié en date du 8 avril 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
- n°  751 du  22  juillet  2004. Modifié  en  date  du  29  février 2008,  publié  au  Mémorial C  Recueil  des Sociétés  et
Associations - n° 926 du 15 avril 2008. Modifié en date du 9 mai 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés
et Associations -n° 1457 du 12 juin 2008. Modifié en date du 26 novembre 2009, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations - n° 64 du 11 janvier 2010.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christophe Aubut / Vincent Cormeau
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2010027099/21.
(100023783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Kershipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 104.071.

<i>Extrait des décisions de l'assemblée générale du 11 février 2010

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs pour une année, soit jusqu'à l'issue de

l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2010.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de délégué à la gestion journalière de Fabrice MAIRE, pour une

année, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2010.

L'Assemblée Générale décide de renouveler, le cabinet Compagnie Européenne de Révision sis 15, rue des Carrefours

L-8124 Bridel - RCSL n 

o

 B-37039, en qualité de commissaire aux comptes pour une année, soit jusqu'à l'issue de l'as-

semblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010028034/17.
(100024631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2010.

LDV Management II Aerium IV Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 105.050.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010026975/9.
(100023189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

28800


Document Outline

Abakus Group Holding S.A.

Acutas s.à r.l.

Agri-Top Holding S.A.

Albra-Lux Holding S.A.

Analisis de Procesos Financieros Procesando Luxemburgo S.à r.l.

Arcipelagos Sicav

Astraios S.à r.l.

AV Works Europe Sàrl

Bikenbach Finance S.A.

Brightside S.A.

Caro S.à r.l.

Carsura Invest S.A.

Classic Marine S.A.

Continental-Leasing S.A.

Diversita

Dynamic Global Advisors S.à r.l.

Eccu Business Angels

Ecotank S.A.

Elster Group S.E.

Entreprise de Construction et de Génie Civil Ben Scholtes SA

Ernster S.àr.l.

Esplanade S.A.

Eurazeo Real Estate Lux

Financière V.P.I.

Flora Park S.à r.l.

FPM Realty S.A.

HOS111 S.A.

Hôtel-Restaurant SIMMER S.à r.l.

Kershipping S.A.

LDV Management II Aerium IV Holding S.C.A.

Locomotive Holding S.A.

Merlin Entertainments Group Luxembourg 3 S.à r.l.

MH Germany Property IV S.à r.l.

MH Germany Property XII S.à r.l.

Montsoleil S.A.

Moventum Holdings S.A.

OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l.

Pan Atlantik Trading S.A.

Romy Finance S.A.

Skyventure S.A.

Starlux International S.A.

Stewball-Ranch S.à r.l.

Tridex A.G.

Ulysses Luxembourg S.à r.l.

Wisson S.A.