logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 39

7 janvier 2010

SOMMAIRE

Alternative Investments Sicav . . . . . . . . . . .

1854

Alternative Investments Sicav . . . . . . . . . . .

1854

Altrum SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1872

Annurca S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1839

Ares S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1846

Armet S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1854

Bio Technology CONSULTING Sàrl  . . . . .

1847

CACEIS Bank Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

1864

Compagnie Agricole de l'Est S.A. . . . . . . . .

1872

Darmazel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1841

EKIAM S. à r. l. & Cie. F.W. Zweite S.e.c.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1828

EKIAM S. à r. l. & Cie. L.W. Dritte S.e.c.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1831

EKIAM S. à r. l. & Cie. L.W. Erste S.e.c.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1834

EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Siebte S.e.c.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1845

EKIAM S. à r. l. & Cie. R.N. Dritte S.e.c.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1838

EKIAM S. à r. l. & Cie. R.N. Vierte S.e.c.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1841

Exeel Developments S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .

1840

Gamma III S.C.A., Sicar  . . . . . . . . . . . . . . . .

1853

Gibrela S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1847

Goforth Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

1853

GWM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1841

Halley S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1840

Howick Place JV S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

1840

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent neuvième

(109.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1832

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent neuvième

(109.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1834

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent neuvième

(109.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1835

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent neuvième

(109.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1834

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent treizième

(113.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1829

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent treizième

(113.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1831

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent treizième

(113.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1831

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-

vingt-onzième (591.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . .

1826

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-

vingt-onzième (591.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . .

1828

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-

vingt-onzième (591.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . .

1828

INNCONA S.à r.l. & Cie. Quatre cent cin-

quante et unième (451.) S.e.c.s.  . . . . . . . .

1835

INNCONA S.à r.l. & Cie. Quatre cent cin-

quante et unième (451.) S.e.c.s.  . . . . . . . .

1838

INNCONA S.à r.l. & Cie. Quatre cent cin-

quante et unième (451.) S.e.c.s.  . . . . . . . .

1839

INNCONA S.à r.l. & Cie. Quatre cent cin-

quante et unième (451.) S.e.c.s.  . . . . . . . .

1838

INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante et on-

zième (71.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1843

INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante et on-

zième (71.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1845

INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante et on-

zième (71.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1845

International Trading and Investments

Holdings S.A. Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

1864

Koch Financing Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

1865

L'Echo d'Iran S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1842

LGAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1855

Orion IPDL 5 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1842

Pervinage S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1855

QCI International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1853

Scilux Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

1842

S Group Participation S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

1846

Solutions Engineering Management S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1852

1825

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-onzième (591.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.854.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-onzième (591.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: Wollenhaupt, Dr. Frank
Straße: Königsmoorweg 7
Postleitzahl/Wohnort: 26802 Moormerland
Geburtsdatum/Geburtsort: 05.07.64 / Kassel
Beruf: Arzt
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt  seinen  Kommanditanteil  durch  Zahlung  in  das  Gesellschaftsvermögen.  Daneben  zahlt  der  Kommanditist  ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;

1826

h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter
Wenn  in  eiligen  Fällen  die  INNCONA  Management  S.à  r.l.  die  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  nicht

einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.ä r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und

den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen
hat (Rumpfgeschäftsjahr).

1827

Schengen, den 29. Juni 2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift

Référence de publication: 2009158544/114.
(090191685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

EKIAM S. à r. l. & Cie. F.W. Zweite S.e.c.s., Société en Commandite simple,

(anc. INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-onzième (591.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.854.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S. ä r. I. & Cie. F.W. Zweite S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. ä r. I. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158545/20.
(090191685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cinq cent quatre-vingt-onzième (591.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.854.

<i>Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft

in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r.l., Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher
nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S.à r.l. allein zuständig für die Aufnahme neuer

Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,
- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt -
und der
EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,
EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Dr. Frank Wollenhaupt, Königsmoorstr. 7, D-26802

Moormerland, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt-
unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete

Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S.à r.l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere

persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S.à r.l. &amp; Cie. Cinq cent
quatre-vingt-onzième (591.) S.e.c.s. aufgenommen. EKIAM übernimmt ab diesem Datum als geschäftsführende Gesell-
schafterin die persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INN-

CONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S.à r.l. &amp; Cie.

Cinq cent quatre-vingt-onzième (591.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern
wirksam entstanden sind, frei.

1828

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den

Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S.à r.l. / EKIAM Management S.à r.l.
Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158546/38.
(090191685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent treizième (113.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.843.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent treizième (113.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer ----------. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: Walther, Dr. Lutz
Straße: Carl-Ulrich-Str. 11
Postleitzahl/Wohnort: 64297 Darmstadt
Geburtsdatum/Geburtsort: 13.12.62 / Mainz
Beruf: Kieferorthopäde
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder "associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt  seinen  Kommanditanteil  durch  Zahlung  in  das  Gesellschaftsvermögen.  Daneben  zahlt  der  Kommanditist  ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;

1829

b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter
Wenn  in  eiligen  Fällen  die  INNCONA  Management  S.à  r.l.  die  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  nicht

einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

1830

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und

den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäfteführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen
hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 19.06.2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift

Référence de publication: 2009158547/114.
(090191667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. L.W. Dritte S.e.c.s., Société en Commandite simple,

(anc. INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent treizième (113.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.843.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S. à r. I. &amp; Cie. L.W. Dritte S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. ä r. I. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158548/20.
(090191667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent treizième (113.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.843.

<i>Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft

in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r. l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher
nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S.à r.l. allein zuständig für die Aufnahme neuer

Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,
- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt -
und der
EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,
EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Dr. Lutz Walther, Carl-Ulrich-Str. 11, D-64297

Darmstadt, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt -
unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete

Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S.à r.l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere

persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S.à r.l. &amp; Cie. Cent trei-
zième  (113.)  S.e.c.s.  aufgenommen.  EKIAM  übernimmt  ab  diesem  Datum  als  geschäftsführende  Gesellschafterin  die
persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

1831

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der. Gesellschaft berechtigt; die INN-

CONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S.à r.l. &amp; Cie.

Cent treizième (113.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern wirksam entstanden
sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den

Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S.à r.l. / EKIAM Management S.à r.l.
Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158549/38.
(090191667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent neuvième (109.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.840.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent neuvième (109.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer --------. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: Walther, Dr. Lutz
Straße: Carl-Ulrich-Str. 11
Postleitzahl/Wohnort: 64297 Darmstadt
Geburtsdatum/Geburtsort: 13.12.62 / Mainz
Beruf: Kieferorthopäde
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt  seinen  Kommanditanteil  durch  Zahlung  in  das  Gesellschaftsvermögen.  Daneben  zahlt  der  Kommanditist  ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von

1832

Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter
Wenn  in  eiligen  Fällen  die  INNCONA  Management  S.à  r.l.  die  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  nicht

einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfänigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, daraufist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.

1833

(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und

den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen
hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 19.06.2007.

INNCONA Management S.à r.l, vertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift

Référence de publication: 2009158550/114.
(090191661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. L.W. Erste S.e.c.s., Société en Commandite simple,

(anc. INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent neuvième (109.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.840.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S.à r.l. &amp; Cie. L.W. Erste S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. à r. I. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158551/20.
(090191661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent neuvième (109.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.840.

<i>Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r.

<i>l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher

nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S.à r.l. allein zuständig für die Aufnahme neuer

Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,
- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt-
und der
EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,
EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Dr. Lutz Walther, Carl-Ulrich-Str. 11, D-64297

Darmstadt, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt-

1834

unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete

Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S.à r.l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere

persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S.à r.l. &amp; Cie. Cent neu-
vième  (109.)  S.e.c.s.  aufgenommen.  EKIAM  übernimmt  ab  diesem  Datum  als  geschäftsführende  Gesellschafterin  die
persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INN-

CONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S.à r.l. &amp; Cie.

Cent neuvième (109.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern wirksam entstanden
sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den

Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S.à r.l. / EKIAM Management S.à r.l.
Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158552/38.
(090191661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent neuvième (109.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.840.

<i>Niederschrift zum Gesellschafterbeschluss vom 15.10.2009, der Gesellschaft

in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r.l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher
Wurde unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften wurde die Gesellschafterversammlung für die oben

bezeichnete Gesellschaft abgehalten und Folgendes beschlossen:

1. Die EKIAM Management S.à r.l. wurde mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere

persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S.à r.l. &amp; Cie. Cent neu-
vième  (109.)  S.e.cs.  aufgenommen.  EKIAM  übernimmt  ab  diesem  Datum  als  geschäftsführende  Gesellschafterin  die
persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INNCONA

verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäftsführung und
Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S.à r.l. &amp; Cie.

Cent neuvième (109.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern wirksam entstanden
sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmten dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu,

den Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es wurden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

EKIAM Management S.à r.l.
Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158553/27.
(090191661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent cinquante et unième (451.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.860.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent cinquante et unième (451.) S.e.c.s.

1835

(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 150.000,00 Euro ist:
Nachname,Vorname: Kolle, Carsten
Straße: Hindenburgring 1
Postleitzahl/Wohnort: 37115 Duderstadt
Geburtsdatum/Geburtsort: 12.06.78 / Duderstadt
Beruf: Dipl. Kaufm.
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter
Wenn  in  eiligen  Fällen  die  INNCONA  Management  S.à  r.l.  die  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  nicht

einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

1836

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über

a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;

b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;

c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;

d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);

e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;

f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.

(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.

(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und

den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen
hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 29. Juni 2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift

Référence de publication: 2009158554/113.

(090191691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

1837

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. R.N. Dritte S.e.c.s., Société en Commandite simple,

(anc. INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent cinquante et unième (451.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.860.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S. à r. I. &amp; Cie. R.N. Dritte S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S.à r.l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158555/20.
(090191691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent cinquante et unième (451.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.860.

<i>Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r.

<i>l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher

nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S.à r.l. allein zuständig für die Aufnahme neuer

Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,
- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt -
und der
EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,
EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Rolf Nacke, Parkallee 1-3, D-15758 Zernsdorf,

aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt -
unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete

Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S.à r.l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere

persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent
cinquante et unième (451.) S.e.c.s. aufgenommen. EKIAM übernimmt ab diesem Datum als geschäftsführende Gesell-
schafterin die persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INN-

CONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S. à r. &amp; Cie.

Quatre cent cinquante et unième (451.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu de jeweiligen Gläubigern
wirksam entstanden sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffene Beschluss zu, den

Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

1838

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S.à r.l. / EKIAM Management S.à r.l.
Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158556/38.
(090191691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent cinquante et unième (451.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.860.

<i>Gesellschafterbeschluss (Umlauf) über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft

Unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung im schriftlichen Umlaufver-

fahren abgehalten und Folgendes beschlossen:

Art. 3 des Gesellschaftsvertrages wird wie folgt geändert:
Der alleinige Kommanditist Herr Carsten Kolle scheidet zum 28. Juni 2007 aus der Gesellschaft aus.
Mit Wirkung zum 29. Juni 2007 tritt
Herr Rolf Nacke
Geb. 08.12.1962 in Seifhennersdorf
Beruf: Rechtsanwalt
Parkallee 1- 3, D-15758-Zernstorf
in die Gesellschaft ein.
Der Kommanditanteil in Höhe von 150.000,00 € wird auf Herrn Rolf Nacke übertragen. Das Protokoll wird genehmigt

und wie folgt eigenhändig unterzeichnet:

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

- / - / EKIAM Management S.à r. I.
Carsten Kolle / Rolf Nacke / Wolfgang Albus
<i>Kommanditist (ausscheidend) / Kommanditist (eintretend) / Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158557/24.
(090191691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Annurca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 137.341.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée

<i>Générale Extraordinaire tenue au siège social le 30 novembre 2009

1. L'assemblée générale décide de transférer le siège social du 69, Rue de la Semois L-2533 Luxembourg au 8, Boulevard

Royal L-2449 Luxembourg.

- L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur unique Monsieur Bruno ABBATE, demeurant profes-

sionnellement au 69, Rue de la Semois, L-2533 Luxembourg, du commissaire aux comptes la société IC Dom-Com Sàrl
(anciennement ALTER DOM-COM S.à.r.l..) ayant son siège social au 69, Rue de la Semois, L-2533 Luxembourg.

2. L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateurs:
- Madame Luisella MORESCHI, demeurant professionnellement au 8, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Madame Frédérique VIGNERON, demeurant professionnellement au 8, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Madame Patricia JUPILLE, demeurant professionnellement au 8, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Et comme commissaire aux comptes:
- La société Gordale Marketing Limited, avec siège au Strovolou 77, Strovolos Center Office 204, 2018 Strovolos,

Nicosia, CYPRUS.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale de 2014.

Luxembourg, le 30 novembre 2009.

<i>Pour ANNURCA S.A.
Signature

Référence de publication: 2009155205/25.
(090188048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

1839

Halley S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 30.686.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait de jugement du tribunal

<i>de commerce de Luxembourg du 26 novembre 2009

Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6 

ème

 Chambre, siégeant en matière com-

merciale que les opérations de liquidation de la société HALLEY S.A. (jugement n°1386/09), dont le siège social à L-2240
Luxembourg, 45, rue Notre-Dame, a été dénoncé en date du 15 décembre 1994, ont été déclarées closes pour absence
d'actif.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2009.

Pour extrait conforme
Me Nathalie WEBER-FRISCH
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009155216/17.
(090187525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Exeel Developments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 63.185.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 novembre 2009,

enregistré à Mersch, le 25 novembre 2009, Relation: MER/2009/2201, que l'associé unique a:

- prononcé la clôture de la liquidation de la société,
- décidé que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1930

Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 2 décembre 2009.

Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009155230/18.
(090187670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Howick Place JV S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 100.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 119.820.

En date du 8 décembre 2009, l'associé Terrace Hill (Howick Place) Investments Limited, avec siège social au 1, Portland

Place, W1B 1PN Londres, Royaume-Uni a cédé 20 parts sociales à l'associé DH Howick Place S.à r.l., avec siège social au
28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg qui les acquiert.

En conséquence, les associés de la Société sont les suivants:
- Terrace Hill (Howick Place) Investments Limited, détient 539 parts sociales
- DH Howick Place S.à r.l. détient 3.460 parts sociales
- DHCRE II HoldCo II S.à r.l., avec siège social au 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, détient 1 part sociale

Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2009.

Laurent Bélik
<i>Gérant

Référence de publication: 2009158096/18.
(090191355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.

1840

Darmazel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 134.707.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration

<i>de la société DARMAZEL S.A. qui s'est tenue en date du 21 octobre 2009

Il a été décidé ce qui suit:
- Le Conseil d'Administration approuve la démission de Monsieur Didier Schönberger en sa qualité d'administrateur

la Société et décide de coopter en remplacement Mademoiselle Andreea Antonescu, Avocat, demeurant professionnel-
lement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

- Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2013.
- Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
Mademoiselle Ingrid Lafond, Madame Cristina Floroiu et Mademoiselle Andreea Antonescu.

Extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009155184/19.
(090187550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

GWM, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.837.

<i>Extrait des résolutions prises lors de

<i>l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2009

En date du 12 mai 2009, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Sigieri Diaz Della Vittoria Pallavicini, de Monsieur Arturo Nattino, de Mon-

sieur Andrea Nattino, de Monsieur Giacomo Scribani Rossi et de Monsieur Moataz El-Sherif en qualité d'Administrateurs
pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2010.

Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2009155187/17.
(090187657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. R.N. Vierte S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.859.

<i>Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1. Firma, Sitz
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. R.N. Vierte S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L-6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKIAM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158154/18.
(090191690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

1841

Orion IPDL 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 129.965.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 7 décembre 2009

L'associé unique de la Société:
- approuve le rapport de l'auditeur à la liquidation;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 7 décembre

2009;

- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse

suivante: SGG S.A., 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2009.

Orion IPDL 5 S.à r.l. (en liquidation volontaire)
Signature

Référence de publication: 2009158114/19.
(090191628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

L'Echo d'Iran S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2153 Luxembourg, 10, rue Antoine Meyer.

R.C.S. Luxembourg B 11.292.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société L'ECHO D'IRAN S.à.r.l., avec siège social au 10, rue Antoine Meyer, L-2153 Luxembourg, de fait inconnue

à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge, et liquidateur Maître Cédric SCHIR-

RER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 1 

er

 janvier 2010 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Pour extrait conforme
Me Cédric Schirrer
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2009158147/21.
(090191848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Scilux Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.800,00.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 127.082.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2009.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2009158271/13.
(090191659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

1842

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Soixante et onzième (71.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.841.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Soixante et onzième (71.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer... Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00 Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: v. Lueder, Martin
Straße: Theodor-Storm-Str. 17
Postleitzahl/Wohnort: 74564 Crailsheim
Geburtsdatum/Geburtsort: 18.05.57 / Altdorf
Beruf: Geschäftsführer
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt  seinen  Kommanditanteil  durch  Zahlung  in  das  Gesellschaftsvermögen.  Daneben  zahlt  der  Kommanditist  ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;

1843

h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter
Wenn  in  eiligen  Fällen  die  INNCONA  Management  S.à  r.l.  die  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  nicht

einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.á r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsfuhrungsmaßnahmen der INNCONA Management S.á r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und

den

einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-

den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres.

Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

1844

Schengen, den 13.06.2007.

INNCONA Management S.à r.l.,
<i>v ertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift

Référence de publication: 2009158528/115.
(090191663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. M.v.L. Siebte S.e.c.s., Société en Commandite simple,

(anc. INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Soixante et onzième (71.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.841.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. M.v.L. Siebte S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L-6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158529/20.
(090191663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Soixante et onzième (71.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.841.

<i>Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft

in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r. l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher
nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S. à r. l. allein zuständig für die Aufnahme neuer

Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,
- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt -
und der
EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,
EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Martin von Lueder, Theodor-Storm-Str. 17, D-74564

Crailsheim, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt -
unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete

Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S. à r. l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere

persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S. à r. 1. &amp; Cie. Soixante-
onzième  (71.)  S.e.c.s.  aufgenommen.  EKIAM  übernimmt  ab  diesem  Datum  als  geschäftsführende  Gesellschafterin  die
persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INN-

CONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft.

1845

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S. à r. l. &amp; Cie.

Soixante-onzième (71.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern wirksam ents-
tanden sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den

Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S. à r. l. / EKIAM Management S. à r. l.
Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158530/38.
(090191663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

S Group Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 68.884.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2009

L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer deux nouveaux administrateurs de catégorie A:
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-

bourg,

- Monsieur Luc HANSEN, demeurant professionnellement au au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
en remplacement de Madame Lorenza SEMERARO et de Monsieur Luigi Angelo ZAVAGLIO, démissionnaires, et

confirme le nouveau conseil d'administration:

<i>Administrateurs de Catégorie A:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI,
- Monsieur Luc HANSEN

<i>Administrateurs de Catégorie B:

- Monsieur John SEIL, Président du Conseil d'Administration,
- Monsieur Pierre LENTZ,
- Monsieur Thierry FLEMING
Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les

comptes au 31 décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2009.

Référence de publication: 2009158491/25.
(090191456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Ares S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 122.661.

EXTRAIT

En date du 27 novembre 2009, les associés ont pris les résolutions suivantes:
- La démission de Bart Zech, en tant qu'administrateur, est acceptée.
- Johanna Dirkje Van Oort, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élue nouvel

administrateur de la société pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Pour extrait conforme
Frank Walenta

Référence de publication: 2009158492/16.
(090191578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

1846

Bio Technology CONSULTING Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 17.

R.C.S. Luxembourg B 138.159.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique

<i>de Bio Technology CONSULTING S.à.r.l. tenue le 7 décembre 2009 à 14.30 heures à Drinklange

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-9911 Troisvierges, 31, Route de Wilwerdange

à L-9952 Drinklange, Maison 17.

Drinklange, le 7 décembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un gérant

Référence de publication: 2009158121/14.
(090192149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Gibrela S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 149.858.

STATUTES

In the year two thousand and nine.

On the second of December.

Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The public limited company (société anonyme) LANNAGE S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg,

283, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg number B63130,

here represented by Mr Gianni De Bortoli, private employee, residing professionally in L-1145 Luxembourg, 180, rue

des Aubépines, on behalf of a proxy given under private seal given on 1 

st

 December 2009

The prenamed proxy initialled "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary will remain annexed to

the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has decided to form a company in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a Luxembourg corporation (société anonyme) under the name of GIBRELA S.A..
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen thousand five

hundred (15,500) shares of two Euro (EUR 2.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law on

Commercial Companies of 10 August 1915, as amended prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or

more shares.

1847

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed

by the old shares.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any

denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions, which may be related to such, bond issue. A ledger of the registered
bondholders will be held at the registered office of the company.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in
a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of
director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more
than one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting of the

board of directors duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an
identical document stating the terms of the resolution accurately, and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management

of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one
or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revo-
cation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board
of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on
the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic
proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom

such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation's financial year shall begin on 1 

st

 January and shall end on 31 

st

 December the same year.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the first Monday of June, at 11 am.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

bearer shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by
proxy, who need not be a shareholder.

1848

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional dispositions

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on December 31, 2010.
2. The first annual general meeting will be extraordinarily held on the first Monday of February in 2011, at 11.00 a.m..

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named party has subscribed the shares as follows:
LANNAGE S.A., prenamed, fifteen thousand five hundred (15,500) shares.
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euro (EUR

31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Declaration

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one thousand and fifty Euro.

<i>Decisions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following

resolutions as sole shareholder:

1. The number of directors is set at 3 and that of the auditors at 1.
2. The following are appointed directors:
- LANNAGE S.A., a public limited company (société anonyme), established and having its registered office in 283, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B63130, Mr Jean BODONI, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg, will act as permanent representative.

- VALON S.A., a public limited company (société anonyme), established and having its registered office in 283, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B63143, Mr Guy KETTMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg, will act as permanent representative.

- KOFFOUR S.A., a public limited company (société anonyme), established and having its registered office in 283, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B86086, Mr Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg, will act as permanent representative.

The company LANNAGE S.A. has appointed as President of the Board of Directors.
3. Has been appointed auditor:
AUDIT TRUST S.A., a public limited company (société anonyme), having its registered office in L-1150 Luxembourg,

283, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg B63115.

4. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2015.
5. The registered office will be fixed at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, he signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la version française de l'acte qui précède:

L'an deux mille neuf.
Le deux décembre.

1849

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon, R.C.S. Luxem-

bourg numéro B63130,

ici représentée par Monsieur Gianni De Bortoli, employé privé, demeurant professionnellement à L-1145 Luxembourg,

180, rue des Aubépines, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 1 

er

 décembre 2009.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de GIBRELA S.A..

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés lu-

xembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) divisé en quinze mille cinq cents (15.500)

actions de deux euros (EUR 2.-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

De  même,  le  Conseil  d'administration  est  autorisé  à  émettre  des  emprunts  obligataires  convertibles  sous  forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

1850

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de l'année suivante.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le 1 

er

 lundi de juin à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra extraordinairement le 1 

er

 lundi de février en 2011 à

11.00 heures.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
LANNAGE S.A., prénommée, quinze mille cinq cents (15.500) actions.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.

1851

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinquante Euro.

<i>Décisions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- LANNAGE S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg numéro B63130 avec pour représentant permanent Monsieur Jean BODONI, 180, rue des Aubépines,
L-1145 Luxembourg;

- VALON S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg numéro B63143 avec pour représentant permanent Monsieur Guy KETTMANN, 180, rue des Au-
bépines, L-1145 Luxembourg;

- KOFFOUR S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S.

Luxembourg numéro B86086 avec pour représentant permanent Monsieur Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépines,
L-1145 Luxembourg.

La société LANNAGE S.A. est nommée Président du Conseil d'Administration.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
AUDIT TRUST S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon, R.C.S.

Luxembourg B63115.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.
5. Le siège social est fixé à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française, à la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: De Bortoli - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 décembre 2009. Relation GRE/2009/4567. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €

<i>Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 14 décembre 2009.

Référence de publication: 2009158601/291.
(090191265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Solutions Engineering Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 17.

R.C.S. Luxembourg B 123.686.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés

<i>de Solutions Engineering Management S.à.r.l. tenue le 7 décembre 2009 à 14.30 heures à Drinklange

Les associés décident à l'unanimité de transférer le siège social de la société de L - 9911 Troisvierges, 31, Route de

Wilwerdange à L - 9952 Drinklange, Maison 17.

Drinklange, le 7 décembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un gérant

Référence de publication: 2009158124/14.
(090192153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

1852

QCI International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 100.337.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la

présente de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents de ses administrateurs:

Mme  Christelle  Ferry,  résidant  professionnellement  au  2-8  avenue  Charles  de  Gaulle,  L-1653  Luxembourg,  a  été

nommée en date du 2 novembre 2009 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A.
avec effet immédiat.

M. Doeke van der Molen termine ses fonctions en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation

Company S.A., avec effet au 2 novembre 2009.

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
Christelle Ferry
<i>Représentant permanent

Référence de publication: 2009158445/18.
(090191764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Gamma III S.C.A., Sicar, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investisse-

ment en Capital à Risque.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 126.988.

<i>Extrait de la décision prise par l'associé commandité en date du 27 novembre 2009

La société anonyme ERNST &amp; YOUNG, R.C.S. Luxembourg B 47 771, ayant son siège social à L-5365 Münsbach, 7,

Parc d'Activité Syrdall, a été nommée comme réviseur d'entreprises et chargée de l'audit des comptes annuels au 31
décembre 2009.

Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Gamma III S.C.A., Sicar
Gamma III S.àr.l.
<i>Associé commandité
Signatures

Référence de publication: 2009158456/18.
(090191819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Goforth Investment S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 103.776.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait de jugement du tribunal

<i>de commerce de Luxembourg du 26 novembre 2009

Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6 

ème

 Chambre, siégeant en matière com-

merciale que les opérations de liquidation de la société GOFORTH INVESTMENT S.A. (jugement n°1383/09), dont le
siège social à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, a été dénoncé en date du 22 juin 2006, ont été déclarées closes
pour absence d'actif.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2009.

Pour extrait conforme
Me Nathalie WEBER-FRISCH
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009155220/17.
(090187528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

1853

Alternative Investments Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 95.778.

<i>Extrait des résolutions prises par voie

<i>de résolution circulaire en date du 10 septembre 2009

En date du 10 septembre 2009, le Conseil d'Administration a décidé:
- d'accepter la démission, avec effet au 9 septembre 2009, de Monsieur José-Benjamin Longrée en qualité d'Adminis-

trateur

- de coopter, avec effet au 9 septembre 2009, Monsieur Olivier Storme, CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, en qualité d'Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, en remplacement
de Monsieur José-Benjamin Longrée, démissionnaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2009155185/19.
(090187599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Armet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 21.950.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009158182/12.
(090192011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Alternative Investments Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 95.778.

<i>Extrait des résolutions prises lors de

<i>l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 octobre 2009

En date du 6 octobre 2009, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d'accepter la démission, avec effet au 9 septembre 2009, de Monsieur José-Benjamin Longrée en qualité d'Adminis-

trateur

- de coopter, avec effet au 9 septembre 2009, Monsieur Olivier Storme, CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, en qualité d'Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, en remplacement
de Monsieur José-Benjamin Longrée, démissionnaire

- de renouveler les mandats de Monsieur Olivier Storme, de Monsieur Alexander Svoboda, de Monsieur Christian

Mayer et de Madame Heike Findeisen en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2010.

Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2009155186/22.
(090187627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

1854

Pervinage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 115.755.

EXTRAIT

En date du 27 novembre 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Bart Zech, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- Marjoleine Van Oort, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élue nouvelle

gérante de la société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 14 décembre 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009158593/16.
(090192273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

LGAV, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 149.869.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société Debrex Management Services S.A., avec siège social à Road Town, PO Box 3175, Tortola, Iles Vierges

Britanniques

dûment représentée par Maître Juliette Mayer, avocat à la Cour, domiciliée à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 3 septembre 2009.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et par le notaire, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d'acter les statuts d'une société anonyme

régie les lois du Grand-duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Nom - Siège - Durée - Objet

Art. 1. Nom.
Il est créé, par les souscripteurs et toute personne qui deviendra par la suite propriétaire des actions, une société

anonyme, prenant la dénomination de LGAV (la Société).

Art. 2. Siège social.
2.1 La Société a son siège social à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré à tout autre endroit du Grand-duché de

Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale), délibérant
de la manière prévue pour la modification des Statuts. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune de Luxembourg
par une décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration).

2.2 Dans l'hypothèse où des événements exceptionnels d'ordre politique, économique ou social qui sont de nature à

compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et des pays étrangers,
arrivent ou sont imminents, le siège social pourra être provisoirement transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances anormales. Un tel transfert n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société qui reste une société
luxembourgeoise. La décision de transfert provisoire du siège social à l'étranger sera prise et notifiée aux tiers par un
dirigeant de la Société, le mieux placé pour le faire dans de telles circonstances.

Art. 3. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social.
4.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par

1855

souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé ou

public, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut
prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes
autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer
et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre
société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la
Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

4.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

4.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille

cent (3.100) actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune. ( ci-après désignées les "Actions").

5.2. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale

délibérant conformément à la procédure prévue pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1 Les Actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats re-

présentatifs de plusieurs actions.

6.2 Les Actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
6.3 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites de la Loi.

Gestion - Surveillance

Art. 7. Désignation et Révocation des administrateurs.
7.1 La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, nommés pour

un terme qui ne peut excéder six (6) ans, par l'Assemblée Générale. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout
moment, à la seule discrétion de l'Assemblée Générale.

7.2 Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'Assemblée

Générale.

7.3 Les membres du Conseil d'Administration dont le mandat prend fin sont rééligibles.

Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration.
8.1 Le Conseil d'Administration élira un président (le Président) parmi les administrateurs. Le Président n'a ni voix

prépondérante ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non, dont
la tâche sera de rédiger et de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.

8.2 Le Président présidera toutes les Assemblées Générales et toutes les réunions du Conseil d'Administration. En

son absence, l'Assemblée Générale ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration désignera une autre personne en qualité
de président pro tempore, par vote de la majorité des membres présents ou représentés à la réunion.

8.3 Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président ou par deux autres membres du Conseil

d'Administration.

8.4 Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d'Administration. Hormis les cas

d'urgence qui devront être spécifiés dans la convocation ou les cas où il y a accord préalable de tous ceux qui sont
autorisés à être présents, une convocation écrite de la réunion du conseil devra être donnée au moins un (1) jour à
l'avance.

La réunion se tiendra valablement sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou dûment

représentés.

8.5 Les réunions se tiennent au lieu, date et heure spécifiés dans la convocation, pour autant que toutes les réunions

se tiennent à Luxembourg.

8.6 L'avis de convocation peut être omis si l'administrateur exprime son consentement par écrit ou par télécopie ou

télégramme ou e-mail adressé à tous les membres du Conseil d'Administration. Aucun avis séparé n'est requis pour les

1856

réunions qui se tiennent aux moments et lieux spécifiés dans un plan préalablement arrêté par une résolution du Conseil
d'Administration.

8.7 Chaque administrateur peut intervenir à chaque réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou par

télécopie ou télégramme ou e-mail un autre administrateur comme mandataire.

8.8 Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d'Administration par vidéo conférence ou autre

moyen de communication similaire permettant l'identification de cet administrateur et permettant à toutes les personnes
participant à la réunion de s'entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à une
participation en personne à une telle réunion. Une réunion tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée
avoir été tenue au siège social à Luxembourg.

8.9 Le Conseil d'Administration peut valablement délibérer et prendre des décisions uniquement si la majorité de ses

membres est présente ou représentée.

8.10 Lors des réunions du Conseil d'Administration, toutes les décisions sont prises à la majorité des administrateurs

présents ou représentés.

8.11 Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs (les Résolutions Circulaires des Administrateurs)

sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

Art. 9. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d'Administration.
Les décisions du Conseil d'Administration seront actées dans des procès-verbaux signés par le Président, ou le pré-

sident pro tempore, ou par deux autres administrateurs, ou encore par les membres du bureau du conseil. Tous les
pouvoirs de représentation y resteront annexés. Des copies ou des extraits de ces procès-verbaux, pouvant être produits
dans des procédures judiciaires ou ailleurs, seront signés par le Président ou par deux autres administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et

de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les présents
Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs.
11.1 Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie des ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. De

plus, il peut nommer des représentants pour des transactions spécifiques et révoquer ces nominations à tout moment.

11.2 Le Conseil d'Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires et la représentation de la

Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non.

Art. 12. Représentation.
12.1 La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux adminis-

trateurs de la Société.

12.2 La Société est aussi valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou individuelle de toutes

personnes à qui un tel pouvoir de signature a été valablement délégué par le Conseil d'Administration, mais toujours dans
les limites définies par la délégation.

Art. 13. Audit.
13.1 Le contrôle des comptes annuels de la Société est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes désigné(s)

par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leur rémunération et la fin de leur fonction; une telle fonction ne peut
excéder six (6) ans.

13.2 Les commissaires aux comptes peuvent être réélus et remplacés à tout moment.

Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires.
L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui lui sont

attribués par la Loi et les présents Statuts.

Art. 15. Assemblée générale annuelle des Actionnaires - Autres assemblées générales.
15.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale Annuelle) se tient au siège

social de la Société, ou à tout autre endroit dans la localité du siège social tel que spécifié dans la convocation, le troisième
mardi du mois de mai de chaque année à 9.00 heures.

15.2 Si ce jour est un jour férié, l'Assemblée Générale Annuelle se tient le jour ouvrable suivant.
15.3 Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieu et date spécifiés dans leur convocation respective.

Art. 16. Délibérations - Vote.
16.1 L'Assemblée Générale se réunit sur convocation du Président, du Conseil d'Administration ou, si des circons-

tances exceptionnelles le requièrent à la demande conjointe de deux administrateurs.

1857

16.2 Les actionnaires sont convoqués par lettre recommandée au minimum huit (8) jours à l'avance. Toutes les lettres

de convocation doivent contenir l'ordre du jour de telles assemblées.

16.3 Si l'ensemble des actionnaires est présent ou représenté à l'Assemblée Générale et s'il est établi qu'ils ont été

dûment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale peut être tenue sans convocation
préalable.

16.4 Chaque actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, ou e-mail comme mandataire une autre personne qui peut ne pas être actionnaire.

16.5 Le Conseil d'Administration peut fixer d'autres conditions qui doivent être remplies pour participer à une As-

semblée Générale.

16.6 Chaque Action donne à son actionnaire droit à une (1) voix.
16.7 A moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la Loi, les résolutions lors d'une Assemblée Générale dûment

convoquée seront prises à la majorité des actionnaires présents ou représentés et votant, sans exigence de quorum
aucune.

16.8 Avant le début des délibérations, le président de l'Assemblée Générale désigne un secrétaire et les actionnaires

désignent un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée.

16.9 Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau et tout actionnaire qui le

souhaite.

16.10 Toutefois, si des décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, s'il doit en être fait des copies ou

des extraits pour être produits devant les tribunaux et cours de justice ou pour un autre usage, ceux-ci doivent être
signés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux autres administrateurs.

Année comptable - Comptes annuels - Distributions des profits

Art. 17. Année sociale.
L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. Comptes annuels.
18.1 Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration arrêtera les comptes annuels de la Société

selon la forme prévue par la Loi.

18.2 Le Conseil d'Administration soumettra les comptes annuels de la Société avec son rapport, si nécessaire, et les

autres documents tels qu'exigés par la Loi au commissaire aux comptes qui rédigera son rapport.

18.3 Les comptes annuels de la Société, le rapport du Conseil d'Administration (si prescrit par la Loi), le rapport du

commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents requis par la Loi seront déposés au siège social de la Société
où ils seront disponibles pour l'inspection par les actionnaires pendant les heures régulières de bureau.

Art. 19. Distributions des profits.
19.1 Le solde créditeur du compte des pertes et profits, après déduction des dépenses générales, charges sociales,

amortissements, et provisions pour les événements passés et futurs tels que déterminés par le Conseil d'Administration
représente le bénéfice net.

19.2 Chaque année, cinq (5) pour cent des bénéfices nets sont alloués à la constitution de la réserve légale. Cette

déduction cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint un dixième du capital social émis.

19.3 Le solde du bénéfice net sera à la disposition de l'Assemblée Générale.
19.4 Les dividendes, lorsqu'ils sont payables, seront distribués au moment et au lieu fixé par le Conseil d'Administration

endéans les limites imposées par la décision de l'Assemblée Générale. Des dividendes intérimaires pourront être distri-
bués à l'initiative du Conseil d'Administration conformément aux dispositions de la Loi.

19.5 L'Assemblée Générale peut décider d'allouer les profits et les réserves distribuables au remboursement du capital

sans diminuer le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

Art. 21. Liquidation.
Dans le cas d'une dissolution de la Société, l'Assemblée Générale déterminera la méthode de liquidation et nommera

un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Dispositions générales

Art. 22.
22.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Administrateurs sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication
électronique.

1858

22.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

22.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Administrateurs sont
apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique docu-
ment.

22.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les actionnaires.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2010.

<i>Souscription et Libération

Toutes les trois mille cent (3.100) Actions ont été souscrites par la société Debrex Management Services S.A. pré-

qualifiée.

Toutes les trois mille cent (3.100) actions ont été intégralement libérées par le souscripteur prénommé de sorte que

la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique, représenté comme indiqué ci-dessus, repré-

sentant l'intégralité du capital, a pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est fixé au 11b, bld Joseph II, L-1840 Luxembourg;
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3);
3) Les personnes suivantes sont nommées en qualité d'administrateur pour une période prenant fin lors de l'assemblée

générale des actionnaires approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2014:

- Maître Véronique Wauthier, avocat à la Cour, née le 11 mars 1965 à Arlon (Belgique), résidant professionnellement

au 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg;

- Madame Sabine Colin, employée privée, née le 24 mai 1972 à Thionville (France), résidant professionnellement au

10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg;

- Madame Delphine Goergen, employée privée, née le 1 

er

 octobre 1977 à Messancy (Belgique), résidant profession-

nellement au 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

4) La société suivante est nommée commissaire au compte pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale

des actionnaires approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2014:

- FIDALPHA S.A., ayant son siège social au 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.321.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, telle que modifiée, et déclare expressément qu'elles ont été remplies. Le notaire soussigné,
qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en français,
suivi d'une traduction anglaise et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française
fait foi.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la société suite à cet acte sont estimées

approximativement à EUR 2.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ledit mandataire a

signé avec le notaire le présent acte.

Follows the English translation of the foregoing text:

In the year two thousand and nine, on the day of September.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The company Debrex Management Services S.A., with registered office at Road Town, PO Box 3175, Tortola, British

Virgin Islands,

duly represented by Maître Juliette Mayer, avocat à la Cour, residing in Luxembourg,

1859

by virtue of a proxy given under private seal on the 3rd of September 2009. The said proxy, after having been signed

ne varietur by the appearing person and by the notary will remain attached to the present deed and will be filed together
with it with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the articles of incorpo-

ration of a public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of
incorporation (the Articles):

Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name.
There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of the shares hereafter

created, a public limited liability company (société anonyme) under the name of LGAV (the Company).

Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place

within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company (the
General Meeting), deliberating in the manner provided for the amendments to these Articles. It may be transferred within
the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company (the Board of Directors).

2.2 If extraordinary events of political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries, shall occur or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such
a transfer will have no effect on the nationality of the Company, which shall remain a Luxembourg company. The decla-
ration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of third parties
by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

Art. 3. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. Corporate object.
4.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue, by way of private or public placement, notes, bonds and any

kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any bor-
rowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and
pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own
obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person.
For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having
obtained the required authorisation.

4.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 5. Share Capital.
5.1 The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by three

thousand one hundred (3,100) shares having a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, (the Shares).

5.2 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting delib-

erating in the manner provided for the amendments to the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 The Shares may be created at the owner's option in certificates representing single Shares or in certificates rep-

resenting two or more Shares.

6.2 The Shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
6.3 The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law.

1860

Management - Supervision

Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors.
7.1 The Company is managed by a Board of Directors composed of at least three members, who are appointed for a

period not exceeding six years by the General Meeting. The directors may be dismissed at any time at the sole discretion
of the General Meeting.

7.2 The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the General Meeting.
7.3 Retiring members of the Board of Directors are eligible for re-election.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors.
8.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the Chairman) from among the directors. The Chairman will not

have a second or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of drafting
and keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.

8.2 The Chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board of Directors. In his absence, the

General Meeting or, as the case maybe, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro tempore by
vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3 Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any other two members of the Board of

Directors.

8.4 The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one (1)
day' prior written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
8.5 The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice, provided that all meetings

shall be held in Luxembourg.

8.6 The notice may be waived by the consent in writing or by telefax, telegram or by e-mail addressed to all members

of the Board of Directors by each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified
in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

8.7 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram

or by e-mail another director as his proxy.

8.8 Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other similar

means of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in the meeting
to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the registered office in
Luxembourg.

8.9 The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

8.10 All decisions at a meeting of the Board of Directors shall be taken by the majority of those directors present or

represented.

8.11 Circular resolutions in writing, signed and approved by all the directors (the Directors Circular Resolutions), are

valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors.
The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes and signed by the Chairman, the chairman pro

tempore, by any two other directors or by the members of the meeting's board (le bureau). Any proxies will remain
attached thereto. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will
be signed by the Chairman or by any two other directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors.
The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the General Meeting fall
within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers.
11.1 The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint

proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

11.2 The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and representation of the Company's

business to one or more persons, whether directors or not.

Art. 12. Representation.
12.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of two directors of the

Company.

1861

12.2 The Company shall also be validly bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to

whom such signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 13. Audit.
13.1 The audit of the Company's annual accounts shall be entrusted to one or several statutory auditors (commissaire

aux comptes), appointed by the General Meeting which shall fix their number, remuneration, and their term of office;
such office not to exceed six (6) years.

13.2 The statutory auditor(s) may be re-elected and removed at any time.

General Meetings of Shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders.
The General Meeting properly constituted represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred

upon it by the Law and these Articles.

Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings.
15.1 The annual general meeting of the Shareholders of the Company (the Annual General Meeting) shall be held at

the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified
in the notice of meeting, on the third Tuesday in May of each year at 9 a.m.

15.2 If such day is a legal holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following business day.
15.3 Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 16. Proceedings - Vote.
16.1 General Meetings shall meet upon call of the Chairman, the Board of Directors or, if exceptional circumstances

require by any two directors acting jointly.

16.2 Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than eight (8) days' prior notice. All notices

calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.

16.3 If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly

informed of the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

16.4 Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex

as his proxy another person who need not be shareholder.

16.5 The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General

Meeting.

16.6 Each Share entitles its shareholder to one (1) vote.
16.7 Unless otherwise provided by Law, resolutions at a General Meeting duly convened will be passed by a simple

majority of the shareholders present or represented and voting, without any quorum requirements.

16.8 Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the

shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the Meeting's board.

16.9 The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the meeting's board and by any shareholder

who wishes to do so.

16.10 However, if decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere

must be signed by the Chairman of the Board of Directors or any two directors.

Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 17. Financial Year.
The Company's financial year shall begin on 1 January and shall terminate on 31 December of each year.

Art. 18. Annual Accounts.
18.1 Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company

in the form required by the Companies Act.

18.2 The Board of Directors will submit the Company's annual accounts together with its report, if necessary and such

other documents as may be required by the Law Act to the statutory auditor who will thereupon draw up his report.

18.3 The annual accounts, the board's report (if required by Law), the statutory auditor's report and such other

documents as may be required by the Law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be
available for inspection by the shareholders during regular business hours.

Art. 19. Distribution of Profits.
19.1 The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, social charges, write-

offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net profit.

19.2 Every year five (5) per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction

ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

1862

19.3 The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.
19.4 Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits

of the decision of the General Meeting. Interim dividends may be distributed by the Board of Directors in accordance
with the provisions of the Law.

19.5 The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital

without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution.
The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting.

Art. 21. Liquidation.
In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, will determine the method of liquidation and

nominate one or several liquidators and determine their powers.

General provisions

Art. 22.
22.1. Notices and communications are made or waived and the Directors Circular Resolutions are evidenced in writing,

by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

22.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

22.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Directors Circular Resolutions are affixed on one original or on
several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

22.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2010.

<i>Subscription and Paying-up

All the three thousand one hundred (3,100) shares have been subscribed by Debrex Management Services S.A., pre-

named.

All the three thousand one hundred (3,100) shares have been fully paid in by the subscriber prenamed so that the

amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) is at the free disposal of the Company, as certified to the undersigned
notary.

<i>Resolution of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, represented as here above stated, repre-

senting the entire corporate capital takes the following resolutions:

1) The registered office of the Company is fixed at lib, bld Joseph II, L-1840 Luxembourg.
2) The number of the directors is fixed at three (3).
3) The following persons are appointed as directors for a period ending at the general meeting of shareholders to be

held to approve the annual accounts as at December 31, 2014:

- Maître Véronique Wauthier, avocat à la Cour, born on March 11, 1965, in Arlon (Belgium), residing professionally

at 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg;

- Mrs Sabine Colin, private employee, born on May 24, 1972, in Thionville (France), residing professionally at 10, rue

Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg;

- Mrs Delphine Goergen, private employee, born on October 1st, 1977, in Messancy (Belgium), residing professionally

at 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

4) The following company is appointed as statutory auditor for a period ending at the general meeting of shareholders

to be held to approve the annual accounts as at December 31, 2014:

- FIDALPHA S.A., with registered office at 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, registered with the Luxembourg

Register of Commerce and Companies under number B 114.321.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions of the law on commercial

companies, as amended dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled. The undersigned notary
who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is

1863

worded in French followed by an English version. On request of the same appearing person and in case of divergences
between the French and the English text, the French version will be prevailing.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its in corporation are estimated at EUR 2,000.-.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the proxy holder, known to the notary by

her surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with the notary the present original deed.

Signé: J. MAYER, Paul DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 novembre 2009. Relation: LAC/2009/49994. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009158623/483.
(090191759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 29.742.

EXTRAIT

Les fonctions d'administrateur de classe A, de président du conseil d'administration et d'administrateur-délégué de M.

Jan Wejchert ont pris fin au 31 octobre 2009.

M. Mariusz Walter, administrateur de classe A, a été nommé en tant que président du conseil d'administration avec

effet au 1 

er

 novembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2009.

<i>Pour International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009155189/16.
(090187747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

CACEIS Bank Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 91.985.

<i>Extrait du procès-verbal

<i>du Conseil d'Administration du 5 novembre 2009

Le Conseil d'Administration qui s'est réuni à la date du 5 novembre 2009 a adopté les résolutions suivantes:
- Il prend acte de la démission de Madame Sylvie Bratel en qualité d'Administrateur de la société, avec effet au 30 juin

2009.

- Il co-opte, avec effet immédiat, Monsieur Philippe Marronnier, dont l'adresse privée est: 39, rue Balard à 75015 Paris

(France), à la fonction d'Administrateur, en remplacement de Madame Sylvie Bratel, démissionnaire. La prochaine As-
semblée Générale nommera définitivement Monsieur Philippe Marronnier en tant qu'Administrateur, pour une durée de
deux ans, jusqu'à l'Assemblée Générale de 2012.

Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Pour extrait conforme
Monique J. E. Lodewijckx
<i>Secrétariat Général

Référence de publication: 2009155190/20.
(090187778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

1864

Koch Financing Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 149.852.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twentieth of November.
Before Us Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

FHR CAL, L.P., an exempt limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered office at

Crawford House, 50, Cedar Avenue, Hamilton, HM 11, Bermuda, registered with the Companies Register of Bermuda
under number 41011,

here represented by Ms Lucie Audigane, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg

by virtue of a proxy given on November 19, 2009.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended

(hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

The Company may provide financial support to any of its affiliates, in particular by granting loans, facilities, security

interests or guarantees in any form and for any term whatsoever and grant them any advice and assistance in any form
whatsoever.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or
any other financial instruments, which may be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name "Koch Financing Luxembourg S.à r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at forty thousand United States Dollars (USD 40,000.-) represented by forty thousand

(40,000) shares of one United States Dollar (USD 1.-) each.

Any share premium paid on the subscription of shares of the Company shall remain linked to such shares on which it

has been paid. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Articles and by the Law.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by a resolution of the single shareholder or by a resolution of

the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company as further defined in

articles 17 and 18 of the Articles.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

1865

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers composed of category A managers and category B managers. The manager(s) need not
to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the com-

petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one category A manager and one category B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to

one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies and with at least the presence or the representation of one category A manager and one category B manager.
Any decisions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented including
at least the favorable vote of one category A manager and one category B manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings. Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video
conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear
one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends on the basis
of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers (as the case may be) showing that sufficient
funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits
since  the  end  of the  preceding accounting year,  increased by profits carried forward and  distributable  reserves, but
decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by Law or by the Articles.

Art. 13. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company has(ve) a personal interest in,
or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any manager or officer of the Company
who serves as a director, associate, or employee of any company or firm with which the Company shall contract or
otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from
considering and voting or acting upon matters with respect to such contract or other business.

In the event that any manager or officer of the Company may have any personal conflicting interest in any transaction

of the Company, he shall make known to the shareholders such personal interest and shall not consider or approve any
such transaction.

Every person who was or is a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending, or completed

action, suit, or proceeding, whether civil, criminal, administrative, or investigative (other than an action by or in the right
of the Company) by reason of the fact that the person is or was an officer, manager, or employee of the Company or is
or was serving at the request of the Company as a director (including committees of the Board), manager, officer, or
employee of another corporation or entity (a "Covered Person"), may be indemnified by the Company, at its sole and
absolute discretion and in all cases where the Company is obliged to indemnify the Covered Person by virtue of applicable
laws, judgments or orders, against any and all reasonable costs and expenses, judgments, fines, and amounts paid in
settlement actually and reasonably incurred by the Covered Person in connection with such action, suit, or proceeding
if the Covered Person acted in good faith and in a manner the person reasonably believed to be in or not opposed to
the best interests of the Company, and, with respect to any criminal action or proceeding, had no reasonable cause to
believe the person's conduct was unlawful. The resolution of any action, suit, or proceeding by judgment, order, settle-
ment, conviction, or upon a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not, of itself, create a presumption that the
Covered Person did not act in good faith and in a manner which the Covered Person reasonably believed to be in or not
opposed to the best interests of the Company, and, with respect to any criminal action or proceeding, had reasonable
cause to believe that the person's conduct was unlawful.

Expenses (including attorneys' fees) incurred by a Covered Person with respect to any action, suit, or proceeding of

the nature described in the preceding paragraph may, in the Company's sole and absolute discretion and in all cases where
the Company is obliged to do so by virtue of applicable laws, judgments or orders, be paid by the Company in advance
of the final disposition of such action, suit, or proceeding upon receipt of an undertaking by or on behalf of the Covered
Person to repay such amount if it shall ultimately be determined that the Covered Person is not entitled to be indemnified
by the Company as authorized in this section. In addition, the Company may elect at any time to discontinue advancing

1866

expenses to a Covered Person if such advancement is determined by the Company, in its sole and absolute discretion,
not to be in the best interest of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights in proportion to his share holding.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the

share capital. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning
at least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five percent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the Company's share capital. The
balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their share holding in the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. After payment
of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds
shall be distributed to the shareholders in proportion to their share holding in the Company.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2010.

<i>Subscription - Payment

FHR CAL, L.P., prenamed, declared to subscribe to all forty thousand (40,000) shares and fully paid them up at their

nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, for an aggregate amount of forty thousand United States Dollars
(USD 40,000.-) to be fully paid up by contribution in kind consisting in the contribution of a receivable in the amount of
forty thousand United States Dollars (USD 40,000.-) held by FHR CAL, L.P., prenamed, towards Koch KIG Financing II
L.P., an exempted limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered address at Crawford
House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM11, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number
43029, which receivable is incontestable, payable and due (the "Receivable").

<i>Evidence of the contribution's existence and Value

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:
- a balance sheet dated November 20, 2009 of FHR CAL, L.P., certified true and correct by the management of FHR

CAL, L.P.;

- a contribution declaration of FHR CAL, L.P., attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable.

<i>Effective implementation of the contribution

FHR CAL, L.P., through its proxy holder, declares that:
-  it  is  the  sole  unrestricted  owner  of  the  Receivable  and  possesses  the  power  to  dispose  of  it,  being  legally  and

conventionally freely transferable;

- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Receivable, in order to duly carry out

and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (€ 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:

1867

<i>Category A managers:

- Mr Ross A. Goering, treasury director, born on September 11, 1967 in Newport News, Virginia, United States of

America, and with professional address at 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, Kansas, United States of America;

- Mr Richard K. Dinkel, corporate controller, born on November 23, 1967, in Kansas, United States of America, and

with professional address at 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, Kansas, United States of America;

- Mr David J. May, treasurer, born on May 29, 1967 in Miami, Florida, United States of America, and with professional

address at 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, Kansas, United States of America.

<i>Category B manager:

- Mrs Susan K. Kuethe, vice-president, born on November 13, 1952 in Alton, Illinois, United States of America, and

with professional address at 111 5 

th

 Avenue S.W., Suite 1500, Calgary, Alberta, Canada.

The duration of their mandate is unlimited. The Company will be bound by the joint signature of one category A

manager and one category B manager.

2) The address of the registered office of the Company is established at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt du mois de novembre.
Par-devant. Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

FHR CAL, L.P., un exempt limited partnership organisé selon les lois des Bermudes, ayant son siège social à Crawford

House, 50, Cedar Avenue, Hamilton, HM 11, Bermudes, inscrit auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le
numéro 41011,

ici représenté par Mademoiselle Lucie Audigane, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736

Senningerberg,

en vertu d'une procuration donnée le 19 novembre 2009.
Laquelle procuration restera, après avoir été parahée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elle.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra fournir une assistance financière à n'importe quelle société liée, en particulier accorder des prêts,

des ouvertures de crédit, des intérêts sur titres ou des garanties sous quelque forme que ce soit et quels qu'en soient
les termes et leur fournir du conseil ou une assistance sous quelque forme que ce soit.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles
à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou tous autres

instruments financiers qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination "Koch Financing Luxembourg S.à r.l.".

1868

Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand

Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en
matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à quarante mille Dollars Américains (USD 40.000,-) représenté par quarante mille

(40.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollars Américain (USD 1,-) chacune.

Toute prime d'émission émise lors de la souscription à des parts sociales de la Société restera rattachée aux parts

sociales sur lesquelles elle a été libérée.

La Société pourra racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par les Statuts et la Loi.

Art. 7. Le capital social peut être modifié à tout moment par une résolution de l'associé unique ou par une résolution

de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, suivant les dispositions des

articles 17 et 18 des Statuts.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.  Dans  l'hypothèse  où  il  y  a  plusieurs  associés,  les  parts  sociales  détenues  par  chacun  d'entre  eux  ne  sont
transmissibles que moyennant l'application des prescriptions de l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations et qu'au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B sont
présents ou représentés. Toute décision du Conseil de Gérance doit être adoptée à la majorité des gérants présents ou
représentés avec au moins le vote affirmatif de un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d'un état comptable préparé par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance duquel il
ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent
pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la clôture du dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés
et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une
obligation légale ou statutaire.

Art. 13. Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé

par le fait qu'un ou plusieurs des gérants ou fondés de pouvoir de la Société y aura un intérêt personnel, ou en est
administrateur, associé, fondé de pouvoir ou salarié. Tout gérant ou fondé de pouvoir de la société qui remplira les
fonctions d'administrateur, d'associé, de fondé de pouvoir ou d'employé d'un société ou firme avec laquelle la Société
contractera ou entrera autrement en relation d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société

1869

ou firme, empêché de donner son avis ou de voter ou d'agir sur toutes opérations relatives à un tel contrat ou à une
telle opération. Un gérant ou un fondé de pouvoir de la Société ayant un intérêt personnel opposé dans une opération
de la Société sera obligé d'en informer les actionnaires et s'abstiendra de donner un avis ou de voter sur telle opération.

Toute personne qui était ou est partie ou est menacée d'être partie à une action, demande ou un procès qui est en

cours, annoncé ou a abouti, de nature civile, criminelle, administrative ou d'enquête (autre qu'une action par ou pour la
Société) en raison du fait que la personne est un agent, gérant ou employé de la Société ou agissait ou agit à la demande
de la Société comme administrateur (ceci incluant les comités du conseils d'administration), gérant, agent, ou employé
d'une autre société ou entité (une "Personne Couverte"), peut être indemnisée par la Société, à sa seule et absolue
discrétion et dans tous les cas où la Société est obligée d'indemniser la Personne Couverte en vertu des lois applicables,
de jugements ou ordonnances, de tous coûts et dépenses raisonnables, jugements, amendes ou montants à payer par
transaction,  effectivement  et  raisonnablement  encourus  par  la  Personne  Couverte  en  relation  avec  une  telle  action,
demande ou procès dans la mesure où la Personne Couverte a agi de bonne foi et d'une manière que la personne avait
des raisons de croire dans l'intérêt ou non contraire aux meilleurs intérêts de la Société, et, en ce qui concerne une
éventuelle action ou procès criminel, la personne n'avait pas de raisons de croire que sa conduite était contraire à la loi.
La fin d'une quelconque action, demande ou procès par jugement, ordonnances, transaction, condamnation ou sur une
défense de nolo contendere ou son équivalent, ne devra pas créer en soi une présomption que la Personne Couverte n'a
pas agi de bonne foi ou d'une manière que la personne avait des raisons de croire dans l'intérêt ou non contraire aux
meilleurs intérêts de la Société, et, s'agissant d'une éventuelle action ou procès criminel, la personne n'avait pas de raisons
de croire que sa conduite était contraire à la loi.

Les frais (incluant les honoraires d'avocats) encourus par la Personne Couverte dans le cadre d'une éventuelle action,

demande ou procès de la nature décrite dans l'alinéa précédant peut, à la seule et absolue discrétion de la Société et dans
tout les cas où la Société y est obligée en vertu des lois applicables, jugements ou ordonnances, peuvent être payés par
la Société en avance sur la décision finale de l'action, demande ou procès à condition d'avoir reçu un engagement par ou
pour le compte de la Personne Couverte de repayer un tel montant s'il devait finalement être déterminé que la Personne
Couverte n'a pas droit à être indemnisée par la Société comme autorisé dans cette section. De plus, la Société peut
choisir à tout moment de cesser d'avancer des frais à la Personne Couverte si de telles avances sont déterminées par la
Société, à sa seule et absolue discrétion, comme n'étant dans le meilleur intérêt de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au

moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être
distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. Après paiement de toutes les dettes
et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation sera réparti équitablement entre tous les
associés en proportion de leur participation dans la Société.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2010.

<i>Souscription - Libération

FHR CAL, L.P., prénommé, souscrit toutes les quarante mille (40.000) parts sociales et les libère intégralement à leur

valeur nominale unitaire d'un Dollar Américain (USD 1,-) chacune, pour un montant total de quarante mille Dollars

1870

Américains (USD 40.000,-), par apport en nature consistant en une créance d'un montant de quarante mille Dollars
Américains (USD 40.000.-) détenue par FHR CAL, L.P., susnommé, à l'encontre de Koch KIG Financing II L.P., un exempt
limited partnership de droit des Bermudes, ayant son siège social à Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM11,
Bermudes, enregistré auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 43029 laquelle créance est créance
certaine, liquide et exigible (la "Créance"),

<i>Preuve de l'existence et Valeur de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:
- un bilan au 20 novembre 2009 de FHR CAL, L.P., prénommée, certifié "sincère et véritable" par la gérance de FHR

CAL, L.P.;

- une déclaration d'apport de FHR CAL, L.P., prénommée, certifiant qu'elle est propriétaire sans restrictions de la

Créance apportée.

<i>Réalisation effective de l'apport

FHR CAL, LP., par son mandataire, déclare que:
- elle est seule propriétaire sans restrictions de la Créance et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant léga-

lement et conventionnellement librement transmissibles;

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance, aux fins d'effectuer

leur transfert et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ un mille cinq cents Euro (€ 1.500.-).

<i>Décisions de l'associé unique

1) La Société sera administrée par les gérants suivants:

<i>Gérants de catégorie A:

- M. Ross A. Goering, treasury director, né le 11 septembre 1967 à Newport News, Virginie, Etats-Unis d'Amérique,

et ayant son adresse professionnelle au 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, Kansas, Etats-Unis d'Amérique;

- M. Richard K. Dinkel, treasurer, né le 23 novembre 1967 au Kansas, Etats-Unis d'Amérique, et ayant son adresse

professionnelle au 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, Kansas, Etats-Unis d'Amérique;

- M. David J. May, treasurer, né le 29 mai 1967 à Miami, Floride, Etats-Unis d'Amérique, et ayant son adresse profes-

sionnelle au 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, Kansas, Etats-Unis d'Amérique;

<i>Gérant de catégorie B:

- Mme Susan K. Kuethe, vice-présidente, née le 13 novembre 1952 à Alton, Illinois, Etats-Unis d'Amérique, et ayant

son adresse professionnelle au 111 5 

th

 Avenue S.W., Suite 1500, Calgary, Alberta, Canada.

La durée de leur mandat est illimitée. La Société est valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de

catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

2) L'adresse du siège social est fixée au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de

documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: Audigane, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 novembre 2009. Relation: EAC/2009/14227. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009158594/377.
(090191082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

1871

Altrum SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 81.918.

AUFLÖSUNG

Die  Außerordentliche  Generalversammlung  der  Altrum  SICAV  vom  20.  November  2009  hat  folgende  Beschlüsse

gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Bericht des Liquidators für den Zeitraum vom 30. Dezember 2008 bis 16. No-

vember 2009 zur Kenntnis und Genehmigung.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Bericht des Wirtschaftsprüfers für den Zeitraum vom 30. Dezember 2008 bis

16. November 2009 zur Kenntnis und Genehmigung.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt die geprüften Konten für den Zeitraum vom 30. Dezember 2008 bis 16. Novem-

ber 2009.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat der Sicav, dem Liquidator und dem Wirtschaftsprüfer Entlastung

für die Ausübung ihrer Mandate bis zum 20. November 2009.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Liquidation der Gesellschaft somit abgeschlossen ist und dass die Gesell-

schaft aufgehört hat zu bestehen.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Bücher der Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren ab heute

am Gesellschaftssitz der aufgelösten Gesellschaft in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, hinterlegt bleiben.

Luxemburg, den 23. November 2009.

<i>Für Altrum SICAV in Liquidation
DZ BANK International S.A.
Vera Augsdörfer / Ulrich Juchem

Référence de publication: 2009155233/32.
(090188110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

CADELEST, Compagnie Agricole de l'Est S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 83.406.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 septembre 2008

que:

1. Est élu, en tant que commissaire de la société et son mandat prenant fin lors de l'Assemblée générale statuant sur

les comptes 2008, la société:

- BF CONSULTING Sàrl, Société à Responsabilité Limitée, sise 1, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, enregistrée

au Registre de Commerce de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro B 125.757.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009155191/18.
(090187849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

1872


Document Outline

Alternative Investments Sicav

Alternative Investments Sicav

Altrum SICAV

Annurca S.A.

Ares S.à r.l.

Armet S.A.

Bio Technology CONSULTING Sàrl

CACEIS Bank Luxembourg

Compagnie Agricole de l'Est S.A.

Darmazel S.A.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. F.W. Zweite S.e.c.s.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. L.W. Dritte S.e.c.s.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. L.W. Erste S.e.c.s.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. M.v.L. Siebte S.e.c.s.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. R.N. Dritte S.e.c.s.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. R.N. Vierte S.e.c.s.

Exeel Developments S.àr.l.

Gamma III S.C.A., Sicar

Gibrela S.A.

Goforth Investment S.A.

GWM

Halley S.A.

Howick Place JV S.à.r.l.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent neuvième (109.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent neuvième (109.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent neuvième (109.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent neuvième (109.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent treizième (113.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent treizième (113.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent treizième (113.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cinq cent quatre-vingt-onzième (591.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cinq cent quatre-vingt-onzième (591.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cinq cent quatre-vingt-onzième (591.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent cinquante et unième (451.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent cinquante et unième (451.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent cinquante et unième (451.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent cinquante et unième (451.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Soixante et onzième (71.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Soixante et onzième (71.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Soixante et onzième (71.) S.e.c.s.

International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg

Koch Financing Luxembourg S.à r.l.

L'Echo d'Iran S.à r.l.

LGAV

Orion IPDL 5 S.à r.l.

Pervinage S.à r.l.

QCI International S.A.

Scilux Consulting S.à r.l.

S Group Participation S.A.

Solutions Engineering Management S.à r.l.