This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 966
8 mai 2009
SOMMAIRE
ABF Lux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46335
Agro-Sud Finances Holding S.A. . . . . . . . . .
46340
Allianz ROSNO Investment Strategies . . .
46345
Allianz ROSNO Investment Strategies . . .
46345
Arcobaleno Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46327
Banca Lombarda Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . .
46350
Batz S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46340
BL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46322
Capital Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46341
CARMIGNAC GESTION Luxembourg . . .
46368
CIC CH Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46341
Clovis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46367
Cnig S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46336
E24 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46353
EDM International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46338
Endicott S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46323
Fidimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46323
Financière d'Evry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46336
Financière d'Investissement Technologi-
que S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46354
Fuchs Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46342
Giolu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46351
Goldwell Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46335
G&P Invest Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46337
Hydrosol S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46332
Ignis et Glacies S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46361
Immo BPM SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46335
Infor-ID S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46322
Ingenium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46342
Karisso S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46343
KIZ 5 Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
46352
Linston S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46344
Lis Bleu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46344
Lysara Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46343
Maltesia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46336
Mariva Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46339
Memento S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46367
Metro International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
46332
Millicom International Cellular S.A. . . . . . .
46324
Misam S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46354
NG Luxembourg 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
46363
Orthodontic Management Service S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46368
Parax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46337
Poseidon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46344
Prosper S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46322
QS Italy SICAR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46334
Randeor Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46343
REA Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46359
Reliance Finance Limited . . . . . . . . . . . . . . .
46340
Re World S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46342
Servizi Finanziari Internazionali S.A. . . . . .
46323
Sinagua S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46339
Sun Microsystems Luxembourg S.à.r.l. . . .
46345
Taïga Computer Europe S.A. . . . . . . . . . . .
46354
The Modern Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46338
The Triangle Investment Group Holdings
SAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46368
Transcom WorldWide S.A. . . . . . . . . . . . . .
46327
Westland Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46339
46321
Prosper S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 50.488.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>25 mai 2009i> à 10:30 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009051880/696/15.
Infor-ID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 54.077.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>25 mai 2009i> à 14:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009051881/696/16.
BL, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 45.243.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav BL à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le Jeudi <i>28 mai 2009i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises
6. Nominations statutaires
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.
46322
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054473/7/23.
Endicott S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 46.942.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>25 mai 2009i> à 14:30 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009051882/696/17.
Servizi Finanziari Internazionali S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 112.064.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des Actionnaires qui aura lieu au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, le <i>27 mai 2009i> à 8 heures 30, pour délibérer
sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et son approbation.
2. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
3. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2006, au 31
décembre 2007 et au 31 décembre 2008.
4. Décision à prendre quant à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
SERVIZI FINANZIARI INTERNAZIONALI S.A.
Référence de publication: 2009053002/545/20.
Fidimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 47.189.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>25 mai 2009i> à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2008.
4. Décision de la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
46323
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054486/1023/17.
Millicom International Cellular S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 40.630.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
("2009 AGM") of the shareholders of MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. ("Millicom") is convened to be
held at the Château de Septfontaines, 330, rue de Rollingergrund, Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg, on
Tuesday, <i>26 May 2009i> at 4.00 p.m. Central European Time ("CET"), to consider and vote on the following resolutions:
<i>Agenda:i>
1. To acknowledge the delegation by the Chairman of the Board of Directors of the duty to preside the 2009 AGM.
2. To elect the Secretary and the Scrutineer of the 2009 AGM.
3. To receive the Directors' Report (Rapport de Gestion) and the Report of the external auditor on the consolidated
and parent company (Millicom) accounts at 31 December 2008.
4. To approve the consolidated accounts and the parent company (Millicom) accounts for the year ended 31 De-
cember 2008.
5. To allocate the results of the year ended 31 December 2008. On a parent company basis, Millicom generated a
profit of USD 1,383,410,071 for the year ended 31 December 2008. Of this amount, USD 880,366 is proposed to
be allocated to the legal reserve in accordance with the requirements of the Luxembourg Law on commercial
companies dated 10 August 1915, as amended (the "1915 Law") and the remaining part of the profit of USD
1,382,529,705 is proposed to be carried forward.
6. To discharge all the current directors of Millicom for the performance of their mandate during the year ended 31
December 2008.
7. To set the number of Directors at 7 Directors.
8. To re-elect Mr. Kent Atkinson as Director for a term ending on the day of the annual general meeting to take place
in 2010 (the "2010 AGM").
9. To re-elect Ms. Maria Brunell Livfors as Director for a term ending on the day of the 2010 AGM.
10. To re-elect Ms. Donna Cordner as Director for a term ending on the day of the 2010 AGM.
11. To re-elect Mr. Daniel Johannesson as Director for a term ending on the day of the 2010 AGM.
12. To re-elect Mr. Michel Massart as Director for a term ending on the day of the 2010 AGM.
13. To re-elect Mr. Allen Sangines-Krause as Director for a term ending on the day of the 2010 AGM.
14. To elect Mr. Paul Donovan as a new Director for a term ending on the day of the 2010 AGM.
15. To re-elect PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg as the external auditor of Millicom for a term ending on
the day of the 2010 AGM.
16. To approve the Directors' fee-based compensation for the period from the 2009 AGM to the 2010 AGM and
share-based compensation from the period from the 2009 AGM to the 2010 AGM, such shares to be issued within
Millicom's authorised share capital exclusively in exchange for the allocation from the premium reserve i.e. for nil
consideration from the relevant Directors.
17. (a) To authorise the Board of Directors, at any time between 26 May 2009 and the day of the 2010 AGM, provided
the required levels of distributable reserves are met by Millicom at that time, to engage in a share repurchase plan
of Millicom's shares (the "Share Repurchase Plan"), either directly or through a subsidiary or a third party, using its
available cash reserves in an amount not exceeding the lower of (i) ten percent (10%) of Millicom's issued and
outstanding share capital as of the date of the 2009 AGM (i.e., approximating a maximum of 10,800,000 shares
corresponding to USD 16,200,000 in nominal value) or (ii) the then available amount of Millicom's distributable
reserves on a parent company basis, in the open market on NASDAQ and OMX Nordic Exchange Stockholm AB,
at an acquisition price which may not be less than USD 5 per share nor exceed the higher of (x) the published bid
that is the highest current independent published bid on a given date or (y) the last independent transaction price
quoted or reported in the consolidated system on the same date, regardless of the market or exchange involved.
(b) To approve the Board of Directors' decision to give joint authority to Millicom's Chief Executive Officer and
the Chairman of the Board of Directors to (i) decide, within the limits of the authorisation set out in (a) above, the
timing and conditions of any Millicom's Share Repurchase Plan according to market conditions and (ii) give mandate
on behalf of Millicom to one or more designated broker-dealers to implement a Share Repurchase Plan.
(c) To authorise Millicom, at the discretion of the Board of Directors, in the event the Share Repurchase Plan is
done through a subsidiary or a third party, to (a) purchase the bought back Millicom shares from such subsidiary
or third party, (b) pay the bought back Millicom shares using either distributable reserves or funds from its share
premium account, (c) transfer all or part of the purchased Millicom shares to employees of the Millicom Group in
connection with any existing or future Millicom long-term incentive plan, and/or (d) use the purchased shares as
46324
consideration for merger and acquisition purposes, including joint ventures and the buy-out of minority interests
in Millicom's subsidiaries, as the case may be, in accordance with the limits set out in articles 49-2, 49-3, 49-4, 49-5
and 49-6 of the 1915 Law.
(d) To further grant all powers to the Board of Directors with the option of sub-delegation to implement the above
authorisation, conclude all agreements, carry out all formalities and make all declarations with regard to all autho-
rities and, generally, do all that is necessary for the execution of any decisions made in connection with this
authorization.
NOTES REGARDING THE NOTICE
CHAIRMAN OF THE MEETING (2009 AGM - item 1)
Pursuant to paragraph 8 of Millicom's Articles, the Chairman of the Board of Directors delegates the duty of presiding
the 2009 AGM to Mr. Jean-Michel Schmit, attorney at law (avocat à la Cour), having his offices in Luxembourg-City.
ELECTION OF THE SECRETARY AND SCRUTINEER (2009 AGM - item 2)
It is proposed that Ms. Candida Gillespie, employee of Millicom, is elected Scrutineer and Mr. Lars Swenningsson, also
employee of Millicom, is elected Secretary of the 2009 AGM.
ELECTION OF THE DIRECTORS (2009 AGM - item 8-14)
The Nominations Committee proposes that, until the 2010 AGM, Mr. Kent Atkinson, Ms. Maria Brunell Livfors, Ms.
Donna Cordner, Mr. Daniel Johannesson, Mr. Michel Massart and Mr. Allen Sangines-Krausen be re-elected as Directors
of Millicom and that Mr. Paul Donovan be elected as new Director of Millicom.
Mr. Paul Donovan, born 1958, has significant telecom management and senior leadership experience from several
markets in the world, including Asia Pacific and Africa.
Mr. Donovan's most recent executive position was Chief Executive, EMAPA Region for the Vodafone Group which
he held until 2008.
Mr. Donovan's background includes a decade in fast moving consumer goods before he moved into the technology
sector, principally with BT and Vodafone.
His career with Vodafone started 10 years ago and for the last five years, he has overseen Vodafone's operations in
subsidiaries in Eastern Europe, Middle East and Asia Pacific. Africa, the US, India and China were added to his remit in
2006. As part of his role, he sat on the boards of numerous subsidiaries and joint ventures during this period.
He holds a BA (with Honors) from University College, London and an MBA from the Bradford University Management
Centre with a specialization in Finance and Business Policy.
He presently does not have any other board assignments.
Mr. Donovan would qualify as an "independent" director of Millicom as defined in the NASDAQ Stock Market, Inc.
Marketplace Rules.
A more detailed description of Mr. Donovan's background can be found on Millicom's web page (www.millicom.com)
under "AGM 2009".
ELECTION OF THE AUDITOR (2009 AGM - item 15)
The Board of Directors, supported by the Audit Committee, proposes that PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxem-
bourg, be re-elected as external auditor for a term ending at the 2010 AGM.
DIRECTORS' FEES (2009 AGM - item 16)
The Nominations Committee proposes a total of EUR 343,500 as fee-based compensation for the seven Directors
expected to serve from the 2009 AGM to the 2010 AGM with such total amount to be split between the Directors in
accordance with a key proposed by the Nominations Committee.
The Nominations Committee also proposes share-based compensation for the period from the 2009 AGM to the
2010 AGM in the form of fully paid-up shares of Millicom common stock. The number of shares issued to the Chairman
of the Board of Directors to be USD 82,500 divided by the Millicom share closing price on NASDAQ on the 2009 AGM
date provided that shares shall not be issued below the par value. The number of shares issued to each of the six other
Directors to be USD 50,000 divided by the Millicom share closing price on NASDAQ on the 2009 AGM date provided
that shares shall not be issued below the par value.
In respect of Directors who did not serve an entire term, the share-based compensation will be pro-rated pro rata
temporis.
SHARE REPURCHASE PLAN (2009 AGM - item 17)
The Board of Directors of Millicom proposes that the meeting approve a Share Repurchase Plan and authorises the
Board of Directors of Millicom, with the option to delegate, to acquire and dispose of the Millicom's shares under the
abovementioned Share Repurchase Plan as further detailed below.
a) Objectives:
46325
The Share Repurchase Plan will be carried out for all purposes allowed or which would become authorised by the
laws and regulations in force, and in particular the 1915 Law and in accordance with the objectives, conditions, and
restrictions as provided by the European Commission Regulation No. 2273/2003 of 22 December 2003.
The purpose of the Share Repurchase Plan will be in particular to reduce the Millicom's share capital (in value or in
number of the shares) or to meet obligations arising from any of the following:
(a) debt financial instruments exchangeable into equity instruments;
(b) employee share option programmes or other allocations of shares to employees of the issuer or of an associate
company;
(c) consideration for merger and acquisition purposes.
The transactions over the shares under the Share Repurchase Plan may be carried out by any means, on or off the
market or by the use of derivative financial instruments, listed on a regulated stock exchange or transacted by mutual
agreement subject to all applicable laws and stock exchange regulations.
b) Maximum proportion of the share capital that may be repurchased
- The maximum aggregate number of shares authorised to be purchased is an amount not exceeding the lower of (i)
ten percent (10%) of Millicom's issued and outstanding share capital as of the date of the 2009 AGM (i.e., approximating
a maximum of 10,800,000 shares corresponding to USD 16,200,000 in nominal value) or (ii) the then available amount
of Millicom's distributable reserves on a parent company basis in the open market on NASDAQ and OMX Nordic
Exchange Stockholm AB. The nominal value or, in the absence thereof, the accountable par of the acquired shares,
including shares previously acquired by Millicom and held by it (including the stakes held by other group companies
referred to in Article 49bis of the 1915 Law), and shares acquired by a person acting in his own name but on Millicom's
behalf, may not exceed ten percent (10%) of the issued share capital it being specified that (i) such limit applies to a number
of shares that shall be, as necessary, adjusted in order to take into account transactions affecting the share capital following
the 2009 AGM as further detailed under c) below (ii) that the acquisitions carried out by Millicom may in no event cause
it to hold, directly or indirectly, more than ten percent (10%) of the share capital, (iii) the aggregate amount that Millicom
may assign to the buyback of its own shares shall be set in accordance with the provisions of the 1915 Law.
- The acquisitions may not have the effect of reducing Millicom's net assets below the amount of the subscribed share
capital plus those reserves, which may not be distributed under law or Millicom's Articles.
- Only fully paid-up shares may be included in the transactions.
c) Price and volume considerations
The minimum and maximum purchase prices at which the Company may repurchase respectively its shares to be set
at:
- Minimum repurchase price: USD 5
- Maximum repurchase price not to exceed the higher of: (x) the published bid that is the highest current independent
published bid on a given date or (y) the last independent transaction price quoted or reported in the consolidated system
on the same date, regardless of the market or exchange involved.
The 2009 AGM grants all powers to the Board of Directors to proceed with unit price adjustments and the maximum
number of securities to be acquired in proportion to the variation in the number of shares or their nominal value resulting
from possible financial operations by Millicom such as but not limited to capital increase by incorporation of reserves and
free allocation of shares or in case of splitting or regrouping of shares et sq.
Any transaction undertaken by Millicom under the Share Repurchase Plan as to price and volume will be undertaken
in accordance with all legal requirements, including those of the European Commission Regulation No. 2273/2003 of 22
December 2003 or any accepted market practices as defined under the Directive 2003/6/EC dated 28 January 2003 on
insider dealing and market manipulation and recognized by the Swedish competent authority for the purposes of the
abovementioned Directive.
d) Duration
Such a Share Repurchase Plan will start no earlier than 26 May 2009, and end no later than at the earliest of (i) the
next AGM to take place in 2010, (ii) the moment on which the aggregate value of shares repurchased by Millicom since
the start of this Share Repurchase Plan reaches the limits indicated under (b) above; (iii) the moment on which Millicom'
shareholding (including the stakes held by other group companies referred to in Article 49bis of the 1915 Law and shares
acquired by a person acting in his own name but on Millicom's behalf) reaches 10 per cent of the subscribed share capital
in accordance with article 49-2 (1) of the 1915 Law or (iv) within eighteen months as of the date of the 2009 AGM.
QUORUM AND MAJORITY
There is no quorum of presence requirement for the 2009 AGM. The 2009 AGM agenda items are adopted by a simple
majority of the shares present or represented.
OTHER INFORMATION
Millicom has issued 108,046,548 outstanding shares with a nominal value of USD 1.50 and with one vote attached to
each such share.
46326
Millicom's consolidated accounts and the parent company (Millicom) accounts as at and for the year ended 31 De-
cember 2008, as well as the Directors' Report and the Report of the external auditor, will be available from 11 May 2009
at Millicom's registered office and copies available upon request by e-mail to: information@millicom.com.
Participation in the 2009 AGM is reserved to shareholders who (i) are registered in the shareholders' register kept
by Millicom and/or Euroclear Sweden AB (Formerly VPC AB) and/or AST as of Tuesday, 19 May 2009, and (ii) give notice
of their intention to attend the 2009 AGM by mail or return a duly completed power of attorney form so that it is received
at Millicom's registered office no later than Friday, 22 May 2009, 5:00 p.m. CET. Forms are available on Millicom's website
(www.millicom.com) or upon request at Millicom's registered office, at the following address and contact numbers:
Millicom International Cellular S.A., 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg, attention: Cândida Gillespie,
telephone: + 352 27 759 702, fax: + 352 27 759 353. The shares of any holder who wishes to attend the 2009 AGM will
not be transferable between May 19, 2009 and the date of the AGM.
Shareholders holding their shares through a third party such as a broker or bank and wishing to attend the AGM or
to be represented at the AGM by power of attorney may have to contact such third party in order to exercise their
shareholder's rights at the AGM.
Holders of Swedish Depository Receipts wishing to attend the 2009 AGM or to be represented at the AGM by power
of attorney have to give notice to, and request a power of attorney form from, HQ Bank AB, with mailing address: 103
71 Stockholm, Sweden, and visiting address: Hovslagargatan 3, Stockholm, Sweden, telephone: + 46 8 463 85 00, or
download it from Millicom's website (www.millicom.com) and send it duly completed to HQ Bank AB at the address
indicated above, so that it is received no later than 5:00 p.m. CET on Friday, 22 May 2009. Holders of Swedish Depository
Receipts having registered their Swedish Depository Receipts in the name of a nominee must temporarily register the
Swedish Depository Receipts in their own name in the records maintained by Euroclear Sweden AB (Formerly VPC AB)
in order to exercise their shareholders' rights at the 2009 AGM. Such registration must be completed no later than
Tuesday, 19 May 2009.
May 2009.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2009053383/10005/195.
Arcobaleno Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 94.352.
The shareholders are hereby invited to attend the
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office on <i>June 9, 2009i> at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the board of directors and the independent auditor
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2008 and the allocation of the results
3. Discharge to be granted to the directors
4. Discharge to be granted to the conducting officers of the management company
5. Statutory appointments
6. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the
registered office of the SICAV.
In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares one working day before the date
of the assembly with KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2009054463/755/21.
Transcom WorldWide S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Luxembourg, 45, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 59.528.
I/ Annual General Meeting of the Shareholders
Convening notice is hereby given to the shareholders of Transcom to attend the
46327
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Transcom's shareholders (the "AGM") that will be held on <i>26 May 2009,i> at 3.00 p.m. CET at Château de
Septfontaines, 330, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg, which will have the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Election of Chairman of the AGM.
2. Presentation of the reports of the board of directors of Transcom and of the external auditor of Transcom on (i)
the annual accounts of Transcom for the financial year ended 31 December 2008 and (ii) the consolidated annual
accounts for the financial year ended 31 December 2008.
3. Approval of the annual accounts and the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2008.
4. Allocation of the results as of 31 December 2008.
5. Discharge of the liability of the members of the board of directors of Transcom for, and in connection with, the
financial year ended 31 December 2008.
6. Appointment of the members of the board of directors of Transcom.
7. Appointment of the external auditor of Transcom.
8. Determination of the directors' fees.
9. Approval of the procedure of the Nomination Committee of Transcom.
10. Approval of the share repurchase plan of Transcom (the "Share Repurchase Plan").
11. Miscellaneous.
INFORMATION
ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING (AGM item 1)
The Nomination Committee proposes that the attorney at law (avocat à la Cour), Christian Kremer, be elected
Chairman of the AGM.
ALLOCATION OF THE RESULTS AS OF 31 DECEMBER 2008 (AGM item 4)
The Board acknowledges that the profit and loss account for the period starting January 1, 2008 and ending December
31, 2008 shows a loss of EUR 1,975,502 and decides to propose to the AGM the allocation of such results to the profits
carried forward account.
APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TRANSCOM (AGM item 6)
The Nomination Committee proposes that, until the end of the annual general meeting to be held in 2010 (the "2010
AGM"), the number of directors of Transcom will be set at 7 directors. The Nomination Committee proposes (i) to re-
elect Mr James Beers, Ms Mia Brunell Livfors, Ms Sandra Frimann-Clausen, Ms Torun Litzén, Mr Roel Louwhoff and Mr
William Walker as directors of Transcom, and (ii) to elect Mr Henning Boysen as new director of Transcom.
Henning Boysen, born in 1946, is an experienced international executive with significant operational experience of the
travel industry. Henning is currently Chairman of Kuoni, one of Europe's leading leisure travel companies. He has been
Chairman since 2006 having joined the Board in 2003. He is also Chairman of Global Refund Group, a market leading
supplier of financial services for the merchant market in their interactions with foreign customers, and Apodan Nordic,
a Danish-based supplier and distributor of products primarily to the Scandinavian public healthcare sector. Previously,
Henning was President and CEO of Gate Gourmet between 1996 and 2004. During this period he transformed Gate
Gourmet from a mid-sized European company into a truly global organisation before selling the business to Texas Pacific
Group. Before becoming President and CEO he held leadership roles in a number of the company's subsidiaries. Before
joining Gate Gourmet, Henning was COO and Deputy President of Saudia Catering in Saudi Arabia between 1988 and
1992 and before that he held a succession of increasingly senior management positions with SAS Service Partner A/S
between 1974 and 1988. He began his career with Booz Allen Hamilton as a management consultant. Henning holds a
Masters in Economics from Aarhus University, Denmark. Henning is a Danish national.
The Nomination Committee further proposes that the board of directors of Transcom appoints Mr William Walker
to be Chairman of the board of directors of Transcom, and that a Remuneration Committee and an Audit Committee
are appointed at a board meeting following the AGM.
APPOINTMENT OF THE EXTERNAL AUDITOR OF TRANSCOM (AGM item 7)
As recommended by the Audit Committee, the Nomination Committee proposes that Ernst & Young S.A., Luxem-
bourg be re-appointed as external auditor for a term ending at the 2010 AGM. The remuneration of the auditor shall be
paid in accordance with an approved bill which specifies time, persons who worked and tasks performed.
DIRECTORS' FEES (AGM item 8)
The Nomination Committee proposes that the meeting resolves that the fees for the members of the board of di-
rectors of Transcom (including remuneration for the work in the committees of the board of directors of Transcom) for
the period until the end of the 2010 AGM be a total of EUR 359,500 and with such amount to be split as follows: Mr.
William Walker, Chairman of the board of directors of Transcom, fees in an amount of EUR 90,000 (whereof EUR 45,000
in cash and 45,000 in shares of Transcom) and the six directors of Transcom, fees in the amount of EUR 40,000 (whereof
EUR 20,000 in cash and 20,000 in shares of Transcom) for each; and remuneration for the work in the committees of
46328
the board of directors of Transcom shall be a total of EUR 29,500. For the work of the Audit Committee, fees of EUR
20,000 will be split as follows: EUR 10,000 for the Chairman of the Audit Committee and EUR 5,000 for each of the two
Audit Committee members. For the work of the Remuneration Committee, fees of EUR 9,500 will be split as follows:
EUR 4,500 to the Chairman of the Remuneration Committee and EUR 2,500 for each of the two Remuneration Com-
mittee members.
The share-based compensation in relation to the period from AGM and the 2010 AGM will take the form of fully paid-
up shares of the Transcom common stock to be issued within the Transcom's authorised share capital to the directors
of Transcom who will serve until the 2010 AGM. The number of shares issued to the Chairman will be EUR 45,000
divided by the Transcom share closing price on the NASDAQ OMX Stockholm on the day of the AGM provided that
shares shall not be issued below the par value. The shares shall be issued in equal number of Class A and Class B shares
based on the Class A and Class B share closing price on the NASDAQ OMX Stockholm on the day of the AGM. Such
shares shall be issued subject to a one-year lock-up period as of their respective date of issue.
APPROVAL OF THE PROCEDURE FOR THE NOMINATION COMMITTEE (AGM item 9)
The Nomination Committee proposes that the AGM approves the following procedure for preparation of the election
of the board of directors and auditor of Transcom. The work of preparing a proposal on the directors of the board and
auditor, and their remuneration, as well as the proposal on the Chairman of the 2010 AGM shall be performed by a
Nomination Committee. The Nomination Committee will be formed during October 2009 in consultation with the largest
shareholders of Transcom as at September 30, 2009. The Nomination Committee will consist of at least three members
representing the larger shareholders of Transcom. The Nomination Committee is appointed for a term of office com-
mencing at the time of the announcement of the third quarter report in 2009 and ending when a new Nomination
Committee is formed. The majority of the members of the Committee may not be directors of the board of directors
or employed by Transcom. If a member of the Committee resigns during the Nomination Committee term before the
work is concluded, a replacement member can be appointed in the corresponding manner. A representative of the largest
shareholder at the time of the announcement will be a member of the Committee and will also act as its convenor. The
members of the Committee will appoint the Committee Chairman at their first meeting. The Nomination Committee
shall have the right to upon request receive personnel resources such as secretarial services from Transcom, and to
charge Transcom with costs for recruitment consultants if deemed necessary.
The above proposals of the Nomination Committee are supported by shareholders representing more than 50% of
the votes in Transcom including among others Investment AB Kinnevik, Emesco AB, Swedbank Robur fonder, Catella
fonder and Fjärde AP-fonden.
APPROVAL OF THE SHARE REPURCHASE PLAN (AGM item 10)
The board of directors of Transcom proposes to the meeting to approve the Share Repurchase Plan and to authorise
the board of directors of Transcom, with the option to delegate, to acquire and dispose of the Transcom's Class A voting
shares and Class B non-voting shares under the abovementioned Share Repurchase Plan as further detailed below.
a) Objectives:
The Share Repurchase Plan will be carried out for all purposes allowed or which would become authorised by the
laws and regulations in force, and in particular the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
"1915 Law") and in accordance with the objectives, conditions, and restrictions as provided by the European Commission
Regulation No. 2273/2003 of 22 December 2003.
The purpose of the Share Repurchase Plan will be in particular to reduce the Transcom's share capital (in value or in
number of Class A shares and/or Class B shares) or to meet obligations arising from any of the following:
(a) debt financial instruments exchangeable into equity instruments;
(b) employee share option programmes or other allocations of shares to employees of the issuer or of an associate
company.
The transactions over the Class A and/or Class B shares under the Share Repurchase Plan may be carried out by any
means, on or off the market or by the use of derivative financial instruments, listed on a regulated stock exchange or
transacted by mutual agreement subject to all applicable laws and stock exchange regulations.
b) Maximum proportion of the share capital that may be repurchased
- The maximum aggregate number of shares authorised to be purchased is up to 3,662,631 Class A shares and 3,662,341
Class B shares respectively but such numbers being capped at 10% of the issued and outstanding share capital as of the
date of the AGM it being specified that (i) such limit applies to a number of shares that shall be, as necessary, adjusted in
order to take into account transactions affecting the share capital following this AGM as further detailed under c) below
(ii) that the acquisitions carried out by Transcom may in no event cause it to hold, directly or indirectly, more than 10%
of the share capital, (iii) the aggregate amount that Transcom may assign to the buyback of its own shares shall be set in
accordance with the provisions of the 1915 Law.
- The acquisitions may not have the effect of reducing the Transcom's net assets below the amount of the subscribed
capital plus those reserves, which may not be distributed under law or the Articles.
- Only fully paid-up Class A Shares and Class B Shares may be included in the transactions.
46329
c) Price and volume considerations
The minimum and maximum purchase prices at which Transcom may repurchase respectively its Class A shares and
its Class B shares at mid market price within the share price quoted on the NASDAQ OMX Stockholm, where share
price interval means the difference between the highest buying price and lowest selling price as of the date preceding the
buy back and subject to the terms of this Share Repurchase Plan.
d) Duration
The Share Repurchase Plan will start no earlier than 27 May 2009 and end no later than at the earliest of (i) the 2010
AGM, (ii) the moment on which the aggregate par value of Class A shares and Class B shares repurchased by Transcom
since the start of this Share Repurchase Plan reaches EUR 3,145,760 (iii) the moment on which Transcom' shareholding
(including the stakes held by other group companies referred to in article 49bis of the 1915 Law and shares acquired by
a person acting in his own name but on the Transcom's behalf) reaches 10 per cent of the subscribed share capital in
accordance with article 49-2 (1) of the 1915 Law or (iv) within eighteen months as of the date of the AGM.
The meeting further grants all powers to the board of directors of Transcom with the option of sub-delegation to
implement the present authorisation, conclude all agreements, carry out all formalities and make all declarations with
regard to all authorities and, generally, do all that is necessary for the execution of any decisions made in connection with
this authorisation. The board of directors of Transcom shall inform the shareholders of Transcom of any transactions
performed in accordance with applicable regulations.
QUORUM AND MAJORITY
The share capital of Transcom is composed of thirty-six millions six hundred twenty-six thousand three hundred
fourteen (36,626,314) Class A voting shares and thirty six millions six hundred twenty-three thousand four hundred
thirteen (36,623,413) Class B non-voting shares. No specific quorum is required for the indication of the valid deliberation
or acknowledgement of the AGM. The resolutions will be validly adopted at a simple majority of the votes cast by the
Class A shareholders.
II/ Extraordinary General Meeting of the Shareholders
Convening notice is hereby given to the shareholders of Transcom to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Transcom's shareholders (the "EGM") that will be held on <i>26 May 2009i> , immediately after the AGM, in front
of a Luxembourg public notary, in order to amend the articles of association of Transcom (the "Articles"), which will have
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Decision to fix the nominal value of the shares in Transcom to EUR 0.43 (forty-three cents) per each Class A and
Class B share and for that purpose, reduce the value of the share capital of Transcom by an amount of two hundred
fifty-one thousand eight hundred ninety-six Euro and two cents (EUR 251,896.02), without cancellation of any share
and without any reimbursement to the shareholders of Transcom, so that the share capital of Transcom will amount
to thirty one million four hundred ninety-seven thousand three hundred eighty-two Euro sixty-one cents (EUR
31,497,382.61), divided into thirty six millions six hundred twenty-six thousand three hundred fourteen
(36,626,314) Class A voting shares, each with a nominal value of EUR 0.43 (forty-three cents) and thirty six millions
six hundred twenty-three thousand four hundred thirteen (36,623,413) Class B non-voting shares, each with no-
minal value of EUR 0.43 (forty-three cents).
2. Decision to allocate the amount of two hundred fifty-one thousand eight hundred ninety-six Euro and two cents
(EUR 251,896.02), resulting from the above share capital value decrease, to the foreign exchange reserve of Trans-
com.
As a consequence of the above-mentioned decisions, the first and the second paragraphs of article 5 of the Articles
shall read as follows:
"The Company has an issued capital of thirty one million four hundred ninety-seven thousand three hundred eighty-
two Euro sixty-one cents (EUR 31,497,382.61), divided into thirty six millions six hundred twenty-six thousand
three hundred fourteen (36,626,314) Class A voting shares, each with a nominal value of EUR 0.43 (forty-three
cents) and thirty six millions six hundred twenty-three thousand four hundred thirteen (36,623,413) Class B non-
voting shares, each with nominal value of EUR 0.43 (forty-three cents) all shares being fully paid-in.
The authorised share capital is set at six hundred fifty-two million seven hundred ninety-three thousand four hun-
dred Euro (EUR 652,793,400) divided into eight hundred million (800,000,000) Class A voting shares and seven
hundred and fifty million (750,000,000) Class B non-voting shares, each with a nominal value of EUR 0.43 (forty-
three cents)."
3. Decision to amend and restate the first paragraph of article 17 of the Articles.
As a consequence of the above mentioned decision, the first paragraph of article 17 of the Articles shall read as
follows:
46330
"The annual general meeting will be held in the Grand-Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the last Wednesday of May
of each year, at 10 a.m.."
4. Decision to add a new paragraph at the end of the Articles.
As a consequence of the above mentioned decision, the latest paragraph of the Articles shall read as follows:
«In case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.»
5. Decision to amend and restate the third paragraph of article 21 of the French version of the Articles in order to
comply it with article 21 of the English version of the Articles.
As a consequence of the above mentioned decision, the third paragraph of article 21 of the French version of the
Articles shall read as follows:
«Les actionnaires de Classe B auront droit à la plus grande des valeurs entre (i) un dividende préférentiel cumulatif
correspondant à 0.5% de la valeur nominale comptable des actions de Classe B dans la Société et (ii) 2% du montant
global des dividendes versés endéans une année.»
6. Decision to renew the authorised share capital in the Articles for a period ending on 26 May 2014 with authorisation
to the board of directors to cancel or limit the preferential subscription rights of the shareholders.
As a consequence, the second and the subsequent paragraphs of article 5 of the Articles shall read as follows:
«The authorised share capital is set at six hundred sixty-six million five hundred thousand Euro (EUR 666,500,000)
divided into eight hundred million (800,000,000) Class A voting shares and seven hundred and fifty million
(750,000,000) Class B non-voting shares, each with a nominal value of EUR 0.43 (forty-three cents).
The board of directors is authorised and empowered to:
- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive
tranches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other
manner;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of
the subscription of and paying up of the new shares; and
- remove or limit the preferential subscription rights of the shareholders in case of issue of shares against payment
in cash.
This authorisation is valid for a period expiring 5 (five) years after 26 May 2009 and it may be renewed by a general
meeting of shareholders for those shares of the authorised corporate capital which up to then will have not been issued
by the board of directors.
Following each increase of the corporate capital realised and duly stated in the form provided for by law, the first
paragraph of Article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic
form by the board of directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose."
Presentation of the special report of the board of directors of Transcom issued in accordance with Article 32-3 (5)
of the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the "Law") to waive and, to the extent appro-
priate, cancel or limit the preferential subscription rights of the shareholders in relation to the above-mentioned
authorised share capital of Transcom.
7. Miscellaneous.
QUORUM AND MAJORITY
The share capital of Transcom is composed of thirty-six millions six hundred twenty-six thousand three hundred
fourteen (36,626,314) Class A voting shares and thirty six millions six hundred twenty-three thousand four hundred
thirteen (36,623,413) Class B non-voting shares. Considering the decisions to be taken, the EGM shall not validly deliberate
unless at least one half of the Class A shareholders and at least one half of the Class B shareholders are present or
represented. The resolutions at the EGM will only be validly adopted by the favorable vote of a majority of the two thirds
(2/3) of the votes cast by the Class A shareholders and by the favorable vote of a majority of the two thirds (2/3) of the
votes cast by the Class B shareholders.
OTHER INFORMATION
Participation at the AGM/EGM of shareholders is reserved for shareholders who file their intention to attend the
AGM/EGM by mail and/or return a duly completed power of attorney form to the following address: Transcom World-
Wide S.A., 45, rue des Scillas, L-2529 Howald, Grand Duchy of Luxembourg, Tel: + 352 - 27 755 012, Fax: + 352 - 27
755 007, so that it shall be received not later than Monday, 25 May 2009, 12:00 p.m. CET. Power of attorney forms for
the AGM/EGM are available at the same address and on the Transcom's website, www.transcom.com.
Holders of Swedish Depository Receipts (SDRs) wishing to attend the AGM/EGM or be represented at the AGM/
EGM via power of attorney must give notice to and request a power of attorney form from HQ Bank AB, with mailing
address: Box 16027, SE-103 21 Stockholm, Sweden, and visiting address: Hovslagargatan 5 Stockholm, Sweden, Tel: +46
- 8 463 85 00. Holders of SDRs wanting to be represented at the AGM/EGM have to send the power of attorney duly
completed to HQ Bank AB at the same address, so that it shall be received not later than Thursday, 21 May 2009, 12.00
p.m CET. Those holders of SDRs having registered their SDRs in the name of a nominee must temporarily register the
SDRs in their own name in the records maintained by Euroclear Sweden AB (formerly VPC AB) in order to exercise
46331
their shareholders' rights at the AGM/EGM. Such registration must be completed not later than Tuesday, 19 May 2009,
5.00 p.m CET. Power of attorney forms for the AGM/EGM can also be found on the HQ Bank AB's website, www.hq.se.
Visit our website: www.transcom.com.
Luxembourg, on 8 May 2009,
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2009054177/1092/243.
Hydrosol S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 31.400.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra jeudi, le <i>28 mai 2009i> à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Non ratification de la cooptation de Monsieur Sébastien ANDRE comme administrateur décidée par le conseil
d'administration le 13 février 2009 et décharge.
6. Décharge à l'administrateur démissionnaire, Monsieur Sinan SAR, pour l'exercice de son mandat.
7. Nomination de Monsieur Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974,
demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme admi-
nistrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
8. Ratification de la cooptation de Monsieur Jacques CLAEYS comme administrateur, décidée par le conseil d'admi-
nistration, en date du 9 février 2009 et nomination de Monsieur Jacques CLAEYS comme administrateur jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
9. Décharge à l'administrateur et au président du conseil d'administration démissionnaire, Monsieur Cornelius Martin
BECHTEL, pour l'exercice de ses mandats.
10. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054461/29/27.
Metro International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 73.790.
Convening notice is hereby given to the shareholders of Metro to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Metro's shareholders (the "AGM") that will be held on <i>26 May 2009i> at 5:00 p.m. CET at Château de Septfontaines,
330, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Election of Chairman of the AGM.
2. Presentation of the reports of the board of directors of Metro and of the external auditor of Metro on (i) the
annual accounts of Metro for the financial year ended 31 December 2008 and (ii) the consolidated annual accounts
for the financial year ended 31 December 2008.
3. Approval of the annual accounts and the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2008.
4. Allocation of the results as of 31 December 2008.
5. Discharge of the liability of the members of the board of directors of Metro for, and in connection with, the financial
year ended 31 December 2008.
6. Appointment of the members of the board of directors of Metro.
7. Appointment of the external auditor of Metro.
8. Determination of the directors' fees.
9. Approval of the procedure for the Nomination Committee of Metro.
10. Miscellaneous.
46332
INFORMATION
ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING (AGM item 1)
The Nomination Committee proposes that the attorney at law (avocat à la Cour), Christian Kremer, be elected
Chairman of the AGM.
ALLOCATION OF THE RESULTS AS OF 31 DECEMBER 2008 (AGM item 4)
The board of directors of Metro acknowledges that the profit and loss account for the period starting January 1, 2008
and ending December 31, 2008 shows a loss and decides to propose to the AGM the allocation of the loss to the losses
carried forward account.
APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF METRO (AGM item 6)
The Nomination Committee proposes that, until the close of the annual general meeting of the shareholders of the
Company to take place in 2010 (the "2010 AGM"), Ms Mia Brunell Livfors, Mr Nigel Cooper, Mr Henry Guy, Mr Mario
Queiroz and Ms Cristina Stenbeck, be re-appointed directors of Metro and that Mr Didier Breton and Mr Erik Mitteregger
be elected directors of Metro.
Mr Didier Breton, born in 1953, is a member of the senior team of Pamoja Capital, a private equity business founded
in 2006 that creates value through long-term, socially-responsible, global investments across a number of industry sectors,
and he is responsible for the operations relating to the investee companies of Pamoja Capital. Previously, Didier was the
Chief Operating Officer of Trader Classified Media, one of the largest classified advertising companies in the world, a
position he held from 2000 until the company was sold in 2006 for €1.3bn. Prior to joining Trader, Didier was President
of the Infrastructure & Systems Division at Groupe Bull. His previous roles include managing international operations at
Hewlett Packard and Valeo. He holds an MBA from the Institut Supérieur des Affaires and an Engineering degree from
ICAM. Didier is a French national.
Mr Erik Mitteregger, born in 1960, is a member of the board of Investment AB Kinnevik since 2004. Erik also serves
as Chairman of the board of Wise Group AB, and is a member of the board of Firefly AB. Erik has been Head of Equity
Research and member of the Management Board at Alfred Berg Fondkommission 1989-1995. He has also been founding
partner and fund manager at Brummer & Partners Kapitalförvaltning AB 1995-2002. Erik holds a degree in Business
Administration from Stockholm School of Economics. Erik is a Swedish national.
The Nomination Committee further proposes that Ms Mia Brunell Livfors be appointed as the Chairman of the board
of directors of Metro, and that a Remuneration Committee and an Audit Committee are appointed at a board meeting
following the AGM.
APPOINTMENT OF THE EXTERNAL AUDITOR OF METRO (AGM item 7)
As recommended by the Audit Committee, the Nomination Committee proposes that KPMG Audit Sàrl, Luxembourg
be re-appointed as external auditor for a term ending at the 2010 AGM. The remuneration of the auditor shall be paid
in accordance with an approved bill, which specifies time, persons who worked and tasks performed.
DETERMINATION OF DIRECTORS' FEES (AGM item 8)
The Nomination Committee proposes that the AGM resolves that the fees for the members of the board of directors
of Metro (including remuneration for the work in the committees of the board of directors Metro) for the period until
the end of the 2010 AGM be a total of EUR 294,500 and with such amount to be split as follows: the Chairman of the
board of directors of Metro, fees in an amount of EUR 65,000 (whereof EUR 32,500 in cash and 32,500 in shares of
Metro); each of the six ordinary directors of the board of directors of Metro, fees in an amount of EUR 32,500 (whereof
EUR 16,250 in cash and 16,250 in shares of Metro); and in total EUR 34,500 as remuneration for the work within the
Audit Committee and the Remuneration Committee. The Nomination Committee also proposes, for work within the
Audit Committee, fees of EUR 16,000 that shall be allocated to its Chairman and of EUR 4,500 to each of the other
members, and for work within the Remuneration Committee fees of EUR 4,500 that shall be allocated to its Chairman
and of EUR 2,500 to each of the other members.
The Nomination Committee also proposes that the AGM approves an additional remuneration in arrears for the
period from the 2008 AGM to the AGM of EUR 7,000 to the Chairman of the Audit Committee due to the amount of
work and engagement that this committee assignment has required during the period.
The share-based compensation in relation to the period from the AGM to 2010 AGM will take the form of fully paid-
up shares of Metro common stock to be issued within Metro's authorised share capital to the members of the board of
directors of Metro who will serve until the 2010 AGM. The shares shall be issued in equal number of Class A and Class
B shares (or equivalent shares in case of conversion, merger or transaction having the same effect) based on the Class A
and Class B share closing price on the OMX Nordic Exchange Stockholm on the day of the AGM. Such shares shall be
issued subject to a one-year lock-up period as of their respective date of issue.
APPROVAL OF THE PROCEDURE FOR THE NOMINATION COMMITTEE (AGM item 9)
The Nomination Committee proposes that the AGM approves the following procedure for preparation of the election
of the Board of Directors and the auditor of Metro. The work of preparing a proposal on the members of the board of
directors of Metro and the auditor of Metro, and their remuneration, as well as the proposal on the Chairman of the
46333
2010 AGM shall be performed by a Nomination Committee. The Nomination Committee will be formed during October
2009 in consultation with the largest shareholders of Metro as at September 30, 2009. The Nomination Committee will
consist of at least three members representing the larger shareholders of Metro. The Nomination Committee is appointed
for a term of office commencing at the time of the announcement of the third quarter report in 2009 and ending when
a new Nomination Committee is formed. The majority of the members of the Committee may not be directors of the
Board of Directors or employed by Metro. If a member of the Committee resigns during the Nomination Committee
term before the work is concluded, a replacement member can be appointed in the corresponding manner. A represen-
tative of the largest shareholder at the time of the announcement will be a member of the Committee and will also act
as its convenor. The members of the Committee will appoint the Committee Chairman at their first meeting. The No-
mination Committee shall have the right to upon request receive personnel resources such as secretarial services from
Metro, and to charge Metro with costs for recruitment consultants if deemed necessary.
The above proposals of the Nomination Committee are supported by shareholders representing more than 50% of
the votes in Metro including among others Investment AB Kinnevik, Emesco AB, Fjärde AP-fonden and Orkla ASA.
QUORUM AND MAJORITY
The share capital of Metro is composed of 264,385,212 Class A voting shares and 263,427,379 Class B non-voting
shares. No specific quorum is required for the indication of the valid deliberation or acknowledgement of the AGM. The
resolutions will be validly adopted at a simple majority of the votes cast by the Class A shareholders.
OTHER INFORMATION
Participation in the AGM is reserved for shareholders who file their intention to attend the AGM by mail and/or return
of a duly completed power of attorney form to the following address: Metro International S.A., 2-4, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg, Tel: +352 - 27 751 350, Fax: + 352 - 27 751 312, so that it shall be received not later than Friday,
22 May 2009, 5.00 p.m. CET. Power of attorney forms for the AGM are available at the same address and on the Metro's
website, www.metro.lu.
Holders of Swedish Depository Receipts (SDRs) wishing to attend the AGM or to be represented at the AGM via
power of attorney must give notice to and request a power of attorney form from HQ Bank AB, with mailing address:
Box 16027, SE-103 21 Stockholm, Sweden, and visiting address: Hovslagargatan 3 Stockholm, Sweden, Tel: +46 - 8 463
85 00. Holders of SDRs wanting to be represented at the AGM have to send the power of attorney duly completed to
HQ Bank AB at the same address, so that it shall be received not later than Friday, 22 May 2009, 5.00 p.m. CET.
Those holders of SDRs having registered their SDRs in the name of a nominee must temporarily register the SDRs in
their own name in the records maintained by Euroclear Sweden AB (formerly VPC AB), in order to exercise their
shareholders' rights at the AGM. Such registration must be completed no later than Tuesday, 19 May 2009, 5.00 p.m.
CET.
Power of attorney forms for the AGM can also be found on Metro's website, www.metro.lu and on HQ Bank AB's
website, www.hq.se.
Luxembourg, on 7 May 2009.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2009054199/1092/117.
QS Italy SICAR S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 106.582.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of QS ITALY SICAR S.A. for the financial year ended on <i>31 December 2008i> (the "Meeting") will be held at the registered
office of the Company in Luxembourg, 84, Grand-Rue, on 27 May 2009 at 11:00 a.m. (Luxembourg time) for the purpose
of considering the following agenda :
<i>Agenda:i>
1. To approve the report of the board of directors (collectively referred to as the "Board", each member being
individually referred to as a "Director") and the report of the independent auditor (the "Auditor") for the financial
year ended on 31 December 2008.
2. To approve the annual accounts for the financial year ended on 31 December 2008.
3. To grant discharge to the Directors with respect to the performance of their respective duties for the financial
year ended on 31 December 2008.
4. To re-appoint the Auditor and the Directors for the period ending on 31 December 2009.
5. To address any other business, which may be properly brought before the Meeting.
46334
The shareholders are advised that no quorum is required to resolve on the items set out in the agenda of the Meeting
and that resolutions will be taken on simple majority of the shares present or represented and favourably voting for such
resolutions at the Meeting.
Shareholders may vote in person or by proxy. A proxy form is available at the Company's registered office at 84,
Grand-Rue, L-1660 Luxembourg (fax: +352 22 60 56).
Proxy forms should be returned to the registered office of the Company to the attention of Jean-Benoît Lachaise
before 05.00 p.m. (Luxembourg time) on May 25, 2009 as further detailed on the proxy form.
<i>For and on behalf of QS ITALY SICAR S.A.
The Boardi>
Référence de publication: 2009054203/260/29.
Goldwell Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 61.609.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>29 mai 2009i> à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054481/534/16.
ABF Lux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 93.600.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, en date du <i>29 mai 2009i> à 13.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2008.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054458/1004/18.
Immo BPM SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9573 Wiltz, 7, rue Michel Thilges.
R.C.S. Luxembourg B 92.481.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
46335
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social en date du <i>30 mai 2009i> à 17.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2008.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes.
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054459/1004/19.
Maltesia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 116.030.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>25 mai 2009i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2008.
4. Décision de la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054492/1023/17.
Financière d'Evry, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 34.498.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>28 mai 2009i> à 16.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2008;
- Affectation du résultat au 31.12.2008;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Ratification de la nomination d'un administrateur par le conseil d'administration du 27.03.2009;
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054460/531/19.
Cnig S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 102.307.
46336
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>3 juin 2009i> à 10.15 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054464/755/19.
Parax S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 2, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 48.142.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>29 mai 2009i> à 14.30 heures au 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054483/534/16.
G&P Invest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 111.408.
Die Aktionäre der G&P Invest SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>27. Mai 2009i> um 14.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen
mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2008 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2008 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Ertragsverwendung
6. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
46337
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der G&P Invest SICAV (DZ BANK
International S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44 903 - 4009
angefordert werden.
Luxemburg, im Mai 2009.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2009054465/755/30.
The Modern Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 67.545.
The fifty per cent quorum of shares not being reached at the Extraordinary General Meeting of May 7, 2009, the
Shareholders are hereby invited to a second extraordinary general meeting in order to deliberate and vote on proposed
amendments to the articles of incorporation of The Modern Funds (the "Company").
This
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
(the "Meeting") of the Company will be held at the registered office of the Company in Luxembourg on <i>June 8, 2009i>
at 11.00 a.m. (Luxembourg time) to deliberate and vote on the following agenda:
<i>Extraordinary Resolutioni>
Amendment of the articles of incorporation of the Company by changing certain provisions.
1. Change of the name of the Company. Amendment of article 1 of the articles of incorporation of the Company so
as to read as follows:
"There exists among the shareholders and all those who may become holders of shares, a Company in the form
of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable à compartiments multiples" under
the name of "Capinordic Funds, SICAV".
English will be the official language of the Company and will be binding for these Articles of Incorporation and any
other documents, agreement etc., related to the Company. In case of divergence or conflict between English and
any other languages, English will prevail."
2. Deletion of BANK INVIK S.A. and replacement by CAPINORDIC BANK A/S as entity referred to into the definition
of "personal interest". Amendment of the second paragraph of article 16 of the articles of incorporation of the
Company so as to read as follows:
"In the event that any Director, Manager or Officer of the Company may have any personal interest in any trans-
actions of the Company, such Director, Manager or Officer shall make known to the Board of Directors such
personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such Director's,
Manager's or Officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of Shareholders. The term
"personal interest" used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter,
position or transaction involving CAPINORDIC BANK A/S, any subsidiary thereof or holding company thereof or
any subsidiary of any holding company thereof, or such other company or entity as may be determined by the Board
of Directors in their absolute discretion."
<i>Quorum requirementsi>
There is no quorum required for this Meeting and the resolution will be passed by a majority of two thirds of the
shares represented at the Meeting.
If you can not attend the Meeting and are willing to receive a proxy form, please liaise with Mrs Céline Parmentier,
CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, by telefax n. (+352) 47 67 75 08 or mail.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2009054466/755/40.
EDM International, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 50.523.
Notice is hereby given to the shareholders, that the
46338
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of EDM INTERNATIONAL will be held at the offices of RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette on <i>May 26, 2009i> at 9.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at December
31, 2008;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no
restrictions.
In order to attend the Meeting of EDM INTERNATIONAL the owners of bearer shares will have to deposit their
shares five clear days before the Meeting with Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470
Luxembourg.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2009054468/584/25.
Sinagua S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 46.841.
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>25 mai 2009i> à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du liquidateur
2. Nomination d'un commissaire dont la fonction sera de contrôler les comptes du liquidateur
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054503/506/13.
Mariva Holding, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 19.260.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme MARIVA HOLDING S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi, <i>26 mai 2009i> à 14.30 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bld Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054469/750/15.
Westland Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 22.185.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme WESTLAND HOLDING S.A. sont priés d'assister à
46339
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi, <i>25 mai 2009i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bld Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054470/750/15.
Batz S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 127.153.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>26 mai 2009i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054471/833/18.
Agro-Sud Finances Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 53.315.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 mai 2009i> à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
novembre 2008.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054484/1023/16.
Reliance Finance Limited, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 18.853.
Les actionnaires sont priés d'assister à
46340
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>28 mai 2009i> à 17.30 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054472/833/18.
Capital Gestion, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.332.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav CAPITAL GESTION à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>28 mai 2009i> à 9.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises
6. Nominations statutaires
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.
Les Actionnaires au porteur qui souhaitent participer à la présente Assemblée doivent déposer leurs actions, au moins
cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Ano-
nyme à Luxembourg.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054475/7/23.
CIC CH Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 75.914.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav CIC CH FUND à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>28 mai 2009i> à 10.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises
6. Nominations statutaires
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires exprimées présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.
46341
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054476/7/20.
Fuchs Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 93.660.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav FUCHS INVEST à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 mai 2009i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises
6. Nominations statutaires
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054478/7/20.
Re World S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 133.730.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>25 mai 2009i> à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2008.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054497/1023/17.
Ingenium, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 98.032.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav INGENIUM à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>28 mai 2009i> à 11.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises
6. Nominations statutaires
46342
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054479/7/20.
Karisso S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 134.501.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>25 mai 2009i> à 16.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2008.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054487/1023/16.
Lysara Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 73.081.
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement au siège social de la société en date du <i>29 mai 2009i> à 10.00 heures avec l'ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.
4. Décision conformément à l'article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la
dissolution éventuelle de la société.
5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs.
7. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes.
8. Décharge spéciale votée et accordée au Commissaire aux Comptes démissionnaire.
9. Election d'un nouveau Commissaire aux Comptes.
10. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054499/802/23.
Randeor Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 29.684.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 mai 2009i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
46343
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2008.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054495/1023/16.
Linston S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 59.773.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>25 mai 2009i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2008.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054489/1023/16.
Lis Bleu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 138.063.
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the headoffice on <i>May 26, 2009i> at 9.00 p.m.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2008 an allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending December 31, 2008.
4. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2009054491/1023/16.
Poseidon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 13.338.
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>25 mai 2009i> à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009054501/506/16.
46344
Allianz ROSNO Investment Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 114.617.
<i>Auszug aus der Niederschrifti>
In der Jahreshauptversammlung vom 14. April 2009 haben die Anteilinhaber einstimmig u.a. folgende Beschlüsse gefasst:
- Die Versammlung beschliesst, die Herren Hannes Chopra, Dr. Klaus Junker und Arnd Thorn als Verwaltungsrats-
mitglieder bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2010 wiederzuwählen.
- Die Versammlung beschliesst, KPMG Audit S.à r.l., Luxemburg, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr
2010 als Abschlussprüfer wiederzuwählen.
Senningerberg, 22. April 2009.
Für die Richtigkeit des Auszuges
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Markus Biehl / Oliver Eis
Référence de publication: 2009053235/755/19.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08409. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090062231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.
Allianz ROSNO Investment Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 114.617.
Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22.04.2009.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009053176/755/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08413. - Reçu 44,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090062227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.
Sun Microsystems Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 211.063.550,00.
Siège social: L-8308 Capellen, 77-79, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 76.953.
In the year two thousand and nine, on the twenty-sixth day of March.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, under-
signed.
Sun Microsystems International B.V., a company incorporated and existing under the laws of The Netherlands, regis-
tered with the Commercial Register of Amersfoort under number 31036373, having its registered office at 2, Disketteweg,
NL-3821 AR Amersfoort, The Netherlands (the "Sole Shareholder") here represented by Ms. Isabel Dias, private em-
ployee, residing professionnally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given on 10 March
2009,
the said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party appearing in its capacity as Sole Shareholder of Sun Microsystems Luxembourg S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 76953, having its
registered office at 77-79, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, and incorporated by a deed
drawn up by Maître Frank Baden, notary, residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), dated 30 June 2000,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") on 11 December 2000 under
number 883, page 42356 (the "Company"), and whose articles of association (the "Articles") were last amended pursuant
46345
to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 27 January
2006, published in the Mémorial C on 21 July 2006 under number 1407, page 67534,
hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg
law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended from time to time (the "Law").
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledges that the provisions of articles 278 seq. of the Luxembourg law on commercial
companies dated 10 August 1915 as amended (the "1915 Law") regarding the simplified merger procedure have been
fulfilled:
(a) Publication on 30 January 2009 of the Merger Plan, as defined below, in the Mémorial C number 206, page 9849,
(b) Deposit of the relevant documents required by article 267 of the 1915 Law at the registered office of the Company
during one month after the publication of the Merger Plan in the Mémorial C.
The Sole Shareholder declares that it has knowledge of the Merger Plan relating to the merger of Sun Microsystems
Financial Sector S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 108786, having
its registered office at 77-79, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg and incorporated by a deed
drawn up by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 10 June 2005,
published in the Mémorial C number 670, page 32118 on 8 July 2005 ("Sun Microsystems"), with the Company by ab-
sorption of Sun Microsystems under the simplified merger procedure (the "Merger") provided for in articles 278 and seq.
of the 1915 Law (the "Merger Plan") by the Company.
The Sole Shareholder notes that the Merger is effective, from an accounting and fiscal point of view, as from 1
st
July
2008 without prejudice to the provisions of Article 273 of the 1915 Law regarding the effects of the merger towards
third parties.
The Sole Shareholder notes that the Merger Plan has been recorded in the notarial form by the undersigned notary
public, residing in Luxembourg, on 15 January 2009 and has been published on 30 January 2009 in the Mémorial C number
206, page 9849.
The Sole Shareholder further acknowledges the Merger and notes and approves that, according to the Merger Plan,
the Merger will be effective as at 1
st
April 2009 amongst the parties as at least one month has passed since the publication
of the Merger Plan in the Mémorial C pursuant to article 9 of the Law.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the object of the Company, in order to reflect the above merger, and
therefore resolves to amend article 2 of the Articles, which shall now read as follows:
" Art. 2. The company may generally act as an operator of information systems and networks and more specifically to
act as an operator of information systems and network that form part of the information and communication equipment
of credit institutions, professionals of the financial sector (PSF), undertakings for collective investment (OPC) or pension
funds organized under Luxembourg or foreign law, which either are owned by the latter or are placed at the disposal of
the latter by the operator, as well as the treatment of data, the transfer of data stored in the information system, and the
installation and maintenance of information systems and communication networks in general and of the financial sector
in particular, in the framework of article 29.3 of the law of April 5, 1993 on the financial sector, as amended from time
to time.
The company may produce, sell, buy, rent, lease, grant license, maintain, use and proceed to any kind of operation in
the area of IT products, tangible or intangible, and/or act as intermediary in the activities/operations in relation to these
services.
The company may also provide consultancy, training, support or other services in relation to the above mentioned IT
products.
The company may participate, by means of share subscription, contribution in kind, merger, takeover, cooperation,
financial operation/agreement, in any other Luxembourg or foreign company, institution, firm of which social object is
identical, similar or equivalent to its own and in which the participation or with which the cooperation may help in the
realization of its own social object.
The company may give warranties to those companies or warrant those companies, act as their agent or representative.
This listing is not limitation. The company may consequently undertake any action which may help, in any way, to the
realization of its social object."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to replace articles 10 and 12 by the following articles 10 to 17 in order to reflect, inter
alia the 4-eyes-principle management, which shall read as follows:
" Art. 10. The company is managed by a board of at least two members, who need not be shareholders, appointed by
resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
46346
Managers may be dismissed ad nutum by the general meeting of shareholders.
Art. 11. All powers not expressly reserved by the law or the present articles to the general meeting of shareholders,
such as the approval of the annual accounts, the allocation of the results, the appointment and dismissal of managers and
the amending of the articles, fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry
out and approve all acts and operations consistent with the company's object.
Special and limited powers may be delegated for well-determined matters to one or more agents, whether shareholders
or not, by any two manager(s) of the company acting jointly.
The board of managers may establish one or several committees, whose members need not to be managers, and
determine their composition and powers.
Art. 12. The board of managers shall meet as often as the company's interests so require or upon call of any manager,
at the place indicated in the convening notice.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice.
No convening notice is required if all members of the board of managers of the company are present or represented
at the meeting and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.
The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by facsimile or e-mail, of each member of the
board of managers of the company.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting. In the event of
a tied vote, the chairman's vote shall be decisive.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to participation in person at such meeting.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 13. The board of managers will choose from among its members a chairman.
In the absence of the chairman, the managers present at a meeting will appoint another manager as chairman pro
tempore.
Art. 14. The managers are not remunerated for the exercise of their mandate.
Art. 15. The supervision of the operations of the company shall be entrusted to one or more certified public auditors,
chosen from among the members of the "Institut des Réviseurs d' entreprises", appointed by the board of the managers,
who fixes their remuneration.
Art. 16. The company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers
of the company. However, the company shall be bound by the joint or single signature of any persons to whom such
signatory powers have been validly delegated in accordance with article 11 of the Articles.
Art. 17. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the company, provided such commitment is in compliance with these articles as well as the
applicable provisions of the Law."
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to renumber article 11 as well as articles 13 to 18 of the Articles, in order to reflect
the above amendments. Therefore the Sole Shareholder resolves that article 11 will become 18, article 13 will become
article 19, article 14 will become article 20, article 15 will become article 21, article 16 will become article 22, article 17
will become article 23 and article 18 will become article 24.
<i>Statementsi>
The undersigned notary stated, the existence and the legality of the deeds and formalities of the Merger executed by
the Company and Sun Microsystems.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1.200.-).
46347
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, said proxyholder appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille neuf, le vingt-six mars.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sous-
signé.
Sun Microsystems International B.V., une société créée et existant conformément aux lois des Pays-Bas, immatriculée
au Registre du Commerce d'Amersfoort sous le numéro 31036373, ayant son siège social au 2, Disketteweg, NL-3821
AR Amersfoort, Pays-Bas, (l'"Associé Unique"), ici représentée par Isabel Dias, employée privée, demeurant profession-
nellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 10 mars
2009,
la procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'Associé Unique de Sun Microsystems Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, créée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 76953, ayant son siège social au 77-79, Parc d'Activités, L-8308
Capellen, Grand-Duché de Luxembourg et constituée selon un acte instrumenté par Maître Frank Baden, notaire de
résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 30 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le "Mémorial C") en date du 11 décembre 2000, numéro 883, page 42356 (la "Société"), et dont
les statuts (les "Statuts") ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire Maître Joseph Elvinger, en date du 27
janvier 2006, publié au Mémorial C en date du 21 juillet 2006, numéro 1407, page 67534,
adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, telle que modifiée (la "Loi").
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique reconnaît que les dispositions des articles 278 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés
commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la "Loi de 1915"), relatives à la procédure de fusion simplifiée, ont été
accomplies:
(a) Publication le 30 janvier 2009 du Plan de Fusion (tel que défini ci-dessous) dans le Mémorial C numéro 206, page
9849,
(b) Dépôt des documents pertinents, requis par l'article 267 de la Loi de 1915, au siège social de la Société pendant
un mois après la publication du Plan de Fusion au Mémorial C.
L'Associé Unique déclare qu'il a connaissance du Plan de Fusion relatif à la fusion de Sun Microsystems Financial Sector
S.à r.l., société à responsabilité limitée, constitutée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108786, ayant son siège social au 77-79,
Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant un acte par Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 10 juin 2005, publié au Mémorial C numéro 670,
page 32118, du 8 juillet 2005 ("Sun Microsystems"), avec la Société par absorption de Sun Microsystems suivant la pro-
cédure de fusion simplifiée (la "Fusion") prévue aux articles 278 et suivants de la Loi de 1915 ("Plan de Fusion") par la
Société.
L'Associé Unique constate que la Fusion prendra effet, d'un point de vue comptable et fiscal, à partir du 1
er
juillet
2008 sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la Loi de 1915 relatives aux effets de la fusion vis-à-vis des tiers.
L'Associé Unique note que le Plan de Fusion a été enregistré dans sa forme authentique par le notaire instrumentant,
résidant à Luxembourg, le 15 janvier 2009, et, a été publié le 30 janvier 2009 au Mémorial C numéro 206, page 9849.
L'Associé Unique prend, en outre, acte de la Fusion, et note et approuve que, conformément au Plan de Fusion, la
Fusion sera effective au 1
er
avril 2009 entre les parties dans la mesure où un délai au moins d'un mois s'est écoulé depuis
la publication du Plan de Fusion au Mémorial C comme prévu par l'article 9 de la Loi de 1915.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'objet de la Société afin de refléter la fusion décrite ci-dessus, et décide ainsi de
modifier l'article 2 des Statuts, comme suit:
" Art. 2. La société a pour objet d'agir généralement en tant qu'opérateur de systèmes informatiques et de réseaux,
et plus spécifiquement, en tant qu'opérateur de systèmes informatiques et de réseaux faisant partie du dispositif infor-
46348
matique et de communication propre aux établissements de crédit, aux professionnels du secteur financier (PSF), aux
organismes de placement collectif (OPC) ou aux fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger, qui,
soit appartiennent à ces-derniers, soit sont mis à leur disposition par l'opérateur, ainsi que, le traitement de données, le
transfert de données stockées dans le dispositif informatique, et, la mise en place et la maintenance des systèmes infor-
matiques et réseaux de communication en général et du secteur financier en particulier, dans le cadre de l'article 29.3 de
la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée.
La société peut produire, vendre, acheter, louer, accorder des licences, entretenir, utiliser et effectuer toute opération
quelconque dans le domaine de produits des technologies de l'information, corporels ou incorporels et/ou agir en tant
qu'intermédiaire dans les opérations/ activités relatives avec ces services.
La société peut également fournir des services de consultance, de formation, l'assistance ou d'autres services en relation
avec les produits des technologies de l'information mentionnés précédemment.
La société peut participer, par voie de souscription d'actions, apport en nature, fusion, absorption, coopération, in-
terventions ou accords financiers, dans toute autre société, institution, entreprise, de droit luxembourgeois ou étranger,
dont l'objet social est identique, similaire ou équivalent au sien, et, dans lesquelles la participation ou avec lesquelles la
coopération peut aider à la réalisation de son propre objet social.
La société peut donner des garanties à ces sociétés ou garantir les obligations de ces sociétés, agir comme leur agent
ou leur représentant.
Cette énumération n'est pas limitative. La société peut en conséquence entreprendre toutes actions qui pourraient
favoriser, de quelque manière que ce soit, la réalisation de son objet social."
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de remplacer les articles 10 et 12 par les articles 10 à 17 suivants afin de refléter inter alia le
principe des "quatre yeux", comme suit:
" Art. 10. La société est gérée par un conseil composé d'au moins deux membres, lesquels ne sont pas nécessairement
des associés, et sont nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera
la durée de leur mandat.
Les gérants sont révocables ad nutum par l'assemblée générale des associés.
Art. 11. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les présents
statuts, tels que l'approbation des comptes annuels, l'affectation des résultats, la nomination et la révocation des gérants
ainsi que la modification des statuts, seront de la compétence du conseil de gérance qui aura tous pouvoirs pour effectuer
et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par deux gérants de la société agissant conjointement.
Le conseil de gérance peut constituer un ou plusieurs comités dont les membres ne doivent pas être gérants et
déterminer leur composition et pouvoirs.
Art. 12. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige ou sur convocation d'un des
gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence seront mentionnés dans
l'avis de convocation.
Une convocation n'est pas requise si tous les gérants de la société sont présents ou représentés à la réunion et déclarent
avoir été dûment informés et avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convo-
cation avec l'accord de chaque gérant de la société donné, soit par écrit, soit en original, soit par téléfax ou courrier
électronique.
Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix exprimées. Les décisions
du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à
la réunion. En cas de partage des voix, la voix du président sera prépondérante.
Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre
et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme
si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et pourront être prouvées par lettre ou
téléfax.
46349
Art. 13. Le conseil de gérance élira parmi ses membres un président.
En l'absence du président, les gérants présents à une réunion désigneront un autre gérant en tant que président pro
tempore.
Art. 14. Les gérants exercent leur mandat à titre gratuit.
Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs réviseurs d'entreprise, choisis parmi
les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, nommés par le conseil de gérance qui fixera leur rémunération.
Art. 16. La société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de deux des gérants
de la société. Néanmoins, la société sera engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels
pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 11 des Statuts.
Art. 17. Les gérants ne contractent en raison de leur mandat aucune obligation personnelle relative aux engagements
valablement pris par eux au nom de la société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les statuts
et les dispositions de la loi."
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de renuméroter l'article 11 ainsi que les articles 13 à 18 des Statuts, afin de refléter les
modifications ci-dessus. Ainsi l'Associé Unique décide que l'article 11 devient l'article 18, l'article 13 devient l'article 19,
l'article 14 devient l'article 20, l'article 15 devient l'article 21, l'article 16 devient l'article 22, l'article 17 devient l'article
23 et l'article 18 devient l'article 24.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate, l'existence et la légalité des actes et des formalités de la Fusion signés par la Société et
Sun Microsystems.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison des présentes, est évalué à environ mille deux cents Euro (EUR 1.200,-).
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom,
prénom, état civil et résidence, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 mars 2009. LAC/2009/12496. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009053237/5770/281.
(090063003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2009.
Banca Lombarda Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 62.318.
DISSOLUTION
L'an deux mil neuf, le sept avril.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
La société «UBI MANAGEMENT COMPANY» ayant son siège social au 47, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n°81.255,
ci-après nommée "l'actionnaire unique",
ici représentée par Mr Gianluca Rossi, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg, 47, Bld du
Prince Henri,
en vertu d'une procuration donnée le 6 Avril 2009, laquelle procuration, après avoir été signée NE VARIETUR par le
mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
46350
Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit :
- Que la Société dénommée "BANCA LOMBARDA SICAV", société à capital variable de droit luxembourgeois, inscrite
au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 62.318, établie et a son siège social à L-2535 Luxembourg, 20
Emmanuel Servais,
ci-après nommée la " Société ",
a été constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Réginald NEUMAN notaire à Luxembourg en date du 30
décembre 1997, et les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par
Maître Jacques DELVAUX notaire à Luxembourg le 7 novembre 2005, publié au Mémorial C n
o
1234 du 18 novembre
2005.
- Que les actifs nets de la société BANCA LOMBARDA SICAV, s'élèvent actuellement à 246.804,14 EUR représentés
par 3.000 parts de valeur nette d'inventaire de 82,2680 EUR chacune.
- Que l'actionnaire unique, s'est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;
- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme ac-
tionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;
- Que l'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire ins-
trumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la
liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement
inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en
conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;
- Que l'actif restant est réparti à l'actionnaire unique.
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la
loi, par «KPMG Luxembourg» désignée "commissaire à la liquidation" par l'actionnaire unique de la Société.
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de la «Banque Privée Edmond de
Rotschild Europe» à Luxembourg.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg.
Date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par
nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. ROSSI, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 14 avril 2009, LAC/2009/14382 : Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2009.
Jacques DELVAUX.
Référence de publication: 2009054205/208/58.
(090064298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.
Giolu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 124.213.
DISSOLUTION
L'an deux mille neuf.
Le neuf avril.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A COMPARU:
La société de droit des Antilles Néerlandaises IRW Equity Holdings II N.V., ayant son siège social à Willemstad, Fransche
Bloemweg 4, Curaçao (Antilles Néerlandaises),
46351
ici représentée par Monsieur Romain ZIMMER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2714 Luxem-
bourg, 6-12, rue du Fort Wallis,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit
ses déclarations et constatations:
I.- Que la société anonyme GIOLU S.A., ayant son siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, R.C.S.
Luxembourg numéro B124213, a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à
Niederanven, en date du 30 janvier 2007, publié au Mémorial C numéro 613 du 14 avril 2007.
II.- Que le capital social de la société anonyme GIOLU S.A., prédésignée, s'élève actuellement à trente et un mille euros
(31.000.- EUR), représenté par trente et une (31) actions avec une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
III.- Que la comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la susdite société GIOLU
S.A..
IV.- Que l'activité de la société GIOLU S.A. ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution anticipée de la
prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
V.- Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.
VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la
société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.
VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le
passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.
VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme GIOLU S.A. est à considérer comme faite et clôturée.
IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société
pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des actions.
XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège
social de la société dissoute.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cent cinquante euros, sont à charge de la société
dissoute.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il
a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: ZIMMER; SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 15 avril 2009. Relation GRE/2009/1495. Reçu soixante quinze euros 75 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Junglinster, le 21 avril 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009052407/231/51.
(090060379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2009.
KIZ 5 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 129.629.
EXTRAIT
Monsieur Van James STULTS, gérant de la Société, a changé d'adresse et demeure maintenant Onslow Gardens Flat
271, London SW7 3QD, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
46352
<i>Pour KIZ 5 Luxembourg S.à r.l.
i>Signature
<i>Avocati>
Référence de publication: 2009052535/267/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2009, réf. LSO-DD06448. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090060541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2009.
E24 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6479 Echternach, 25, rue Grégoire Schouppe.
R.C.S. Luxembourg B 129.937.
Im Jahre zweitausendneun, den achten September.
Vor uns Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).
SIND ERSCHIENEN:
1. Die Gesellschaft niederländischen Rechts Aphex Holding B.V., KvK Nummer 27307601, mit Sitz in NL-2729 MC
Zoetermeer, Waarderstraat 153, Niederlande,
hier rechtmäßig vertreten durch ihren einzigen Direktor Herrn Boris Alexander Samuel VAN ABS, wohnhaft in
NL-2729 MC Zoetermeer, Waarderstraat 153, Niederlande;
2. Die Gesellschaft niederländischen Rechts ii-Yo Holding B.V., KvK Nummer 27326097, mit Sitz in NL-2727 HE
Zoetermeer, Ooiweide 25, Niederlande,
hier rechtsmässig vertreten durch ihren einzigen Direktor Herrn Patrick LAPRÉ, wohnhaft in NL-2727 HE Zoetermeer,
Ooiweide 25, Niederlande.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung E24 S.à r.l. (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-6479 Echternach, 25, rue
Grégoire Schouppe, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
129937, gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 28. Juni 2007, veröffent-
licht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1881 vom 4. September 2007,
und dass deren Satzungen mehrmals abgeändert wurden und zum letzten Mal gemäß Urkunde aufgenommen durch
den amtierenden Notar vom 29. September 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 2675 vom 3. November 2008;
- Dass die Komparenten erklären die einzigen Gesellschafter der vorgenannten Gesellschaft zu sein und dass sie den
amtierenden Notar ersuchen die von ihnen gefassten Beschlüsse wie folgt zu dokumentieren:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Herrn Thomas ANDRATSCHKE, Geschäftsführer, wohnhaft in D-63694 Limes-
hain, 5, Bachstraße, als Geschäftsführer der Gesellschaft abzuberufen und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines
Mandates bis zum heutigen Tage zu erteilen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung ernennt Herrn Boris Alexander Samuel VAN ABS, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in
NL-2729 MC Zoetermeer, Waarderstraat 153, (Niederlande), auf unbegrenzte Dauer zum neuen Geschäftsführer.
Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft rechtmäßig und ohne Einschränkungen
durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschaft ii-Yo Holding B.V., vorgenannt, tritt durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an die
vorgenannte Gesellschaft Aphex Holding B.V. ihre zweihundertfünfzig (250) Anteile, zum Preis von fünfundzwanzigtausend
Euro (25.000,- EUR), welchen Betrag der Zedent bekennt, vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde und außerhalb der
Anwesenheit des Notars, vom Zessionar in bar erhalten zu haben, weshalb der Zedent dem Zessionar hiermit Quittung
und Titel bewilligt.
Die Gesellschaft Aphex Holding B.V. wird Eigentümerin der ihr am heutigen Tag abgetretenen Anteile und erhält das
Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tage.
<i>Vierter Beschlussi>
Gemäß Artikel 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, respektive
gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, wird sodann die obige Anteilsabtretung im Namen der Gesellschaft ausdrüc-
46353
klich angenommen und in ihrem vollen Umfange nach genehmigt durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herrn Boris
Alexander Samuel VAN ABS, vorgenannt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Nach dieser Gesellschaftsanteilsabtretung werden sämtliche fünfhundert (500) Anteile von der vorgenannten Gesell-
schaft Rechts Aphex Holding B.V. gehalten.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
achthundert Euro abgeschätzt.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit Uns dem Notar ge-
genwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: VAN ABS; LAPRE; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 10 avril 2009. Relation GRE/2009/1460. Reçu soixante quinze euros 75 €
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
Junglinster, den 24. April 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009052405/231/65.
(090060325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2009.
Financière d'Investissement Technologique S.A., Société Anonyme,
(anc. Taïga Computer Europe S.A.).
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 90.714.
<i>Décisions de l'associé unique du 20 mars 2009i>
Le 20 mars 2009, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- L'associé unique décide de révoquer avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société
Monsieur Jérôme GUEZ, dirigeant de sociétés, né le 28 mars 1951 à Casablanca (Maroc), et demeurant professionnel-
lement à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
- L'associé unique décide de nommer au poste de commissaire aux comptes de la société Monsieur Jean-Jacques
SCHERER, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl, jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire à tenir en l’an 2014.
Pierre PRADIER
<i>L'associé uniquei>
Référence de publication: 2009052318/508/20.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2009, réf. LSO-DD07043. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090060578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2009.
Misam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 69.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 133.966.
In the year two thousand and nine, on the twenty-second of April.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "Misam S. à r.l.", a société à responsabilité limitée,
having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxembourg number B 133.966, incor-
porated by deed enacted by the undersigned notary on the 21
st
of November 2007, published in Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 3,004, page 144.173, on 27
th
December 2007. The Articles have not yet been
amended since.
46354
The meeting is presided by Mrs Corinne PETIT, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo.
The chairman appoints as secretary Mrs Isabel DIAS, private employee, with same professional address.
The meeting elects as scrutineer Mrs Sylvie DUPONT, private employee, with same professional address.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance
list. That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 1,150 (one thousand one hundred fifty) shares, representing the whole
capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholder has been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 12,000 (twelve thousand euro) so as to raise it from its
present amount of EUR 57,500 (fifty-seven thousand five hundred euro) to EUR 69,500 (sixty-nine thousand five hundred
euro) by the issue of 240 (two hundred and forty) new shares having a par value of EUR 50 (fifty euro) each;
2.- Subscription, intervention of the subscriber, full payment of all the new shares by contribution in kind consisting
of a waiver of an unquestioned claim, existing against the company in favour of Mr Ulf Rosberg, and acceptation by the
managers of Misam S.à r.l.;
3.- New composition of the shareholding of the Company;
4.- Amendment of article 8 of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decides what follows:
<i>First resolutioni>
It has been decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 12,000 (twelve thousand euro) so as to
raise it from its present amount of EUR 57,500 (fifty-seven thousand five hundred euro) to EUR 69,500 (sixty-nine
thousand five hundred euro) by the issue of 6 (six) new ordinary shares (the "Ordinary Shares"), 26 (twenty-six) new
class A preferred shares (the "Class A Preferred Shares"), 26 (twenty-six) new class B preferred shares (the "Class B
Preferred Shares"), 26 (twenty-six) new class C preferred shares (the "Class C Preferred Shares"), 26 (twenty-six) new
class D preferred shares (the "Class D Preferred Shares"), 26 (twenty-six) new class E preferred shares (the "Class E
Preferred Shares"), 26 (twenty six) new class F preferred shares (the "Class F Preferred Shares"), 26 (twenty-six) new
class G preferred shares (the "Class G Preferred Shares"), 26 (twenty-six) new class H preferred shares (the "Class H
Preferred Shares"), 26 (twenty-six) new class I preferred shares (the "Class I Preferred Shares"), and together with the
Class A Preferred Shares, the Class B Preferred Shares, the Class C Preferred Shares, the Class D Preferred Shares, the
Class E Preferred Shares, the Class F Preferred Shares, the Class G Preferred Shares, the Class H Preferred Shares, the
Class I Preferred Shares and the Ordinary Shares, being a total of 240 (two hundred forty) new shares having a par value
of EUR 50 (fifty euro) each, to be subscribed and fully paid up by waiver of an unquestioned claim, existing in favour of
Mr Ulf Rosberg, amounting to EUR 12,000 (twelve thousand euro).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder accepts the subscription of the new shares by himself, that is to say:
- Mr Ulf Rosberg, prenamed, for all the 240 (two hundred and forty) new shares to be issued.
<i>Contributor's Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes Mr Ulf Rosberg, born in Allhelgona on September 10, 1965, residing at Burevägen 9, SE-182 63
Djursholm,, Sweden, prenamed, here represented as stated here-above;
who declares to subscribe to the 6 (six) new ordinary shares, the 26 (twenty-six) new class A preferred shares, the
26 (twenty-six) new class B preferred shares, the 26 (twenty-six) new class C preferred shares, the 26 (twenty-six) new
class D preferred shares, the 26 (twenty-six) new class E preferred shares, the 26 (twenty-six) new class F preferred
shares, the 26 (twenty-six) new class G preferred shares, the 26 (twenty-six) new class H preferred shares, the 26 (twenty-
six) new class I preferred shares and to fully pay them up by irrevocable waiver of its claim existing against the Company
Misam S.à r.l.
The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned
notary by a statement account of the company where the said claim appears, by a certificate of acknowledgement of debt
signed by the managers of the Luxembourg company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the
subscriber.
46355
<i>Managers' interventioni>
Thereupon intervene the current managers of Misam S.à r.l., all of them here represented by virtue of a proxy which
will remain here annexed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of
the Company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of
the contribution in kind, with its valuation, with the effective irrevocable waiver of claims, and confirm the validity of the
subscription and payment.
<i>Third resolutioni>
By virtue of the foregoing resolutions, the share capital is now subscribed as follows:
Mr Ulf Rosberg, prenamed,
256 (two hundred fifty six) ordinary shares, 126 (one hundred twenty-six) class A preferred shares, 126 (one hundred
twenty-six) class B preferred shares, 126 (one hundred twenty-six) class C preferred shares, 126 (one hundred twenty-
six) class D preferred shares, 126 (one hundred twenty-six) class E preferred shares, 126 (one hundred twenty-six) class
F preferred shares, 126 (one hundred twenty-six) class G preferred shares, 126 (one hundred twenty-six) class H pre-
ferred shares, 126 (one hundred twenty-six) class I preferred shares.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is decided
to amend article 8 of the Articles of Association to read as follows:
" Art. 8. The Company's capital is set at sixty-nine thousand five hundred euro (EUR 69,500), represented by two
hundred fifty-six (256) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), one hundred twenty-six (126) class A preferred shares
(the "Class A Preferred Shares"), one hundred twenty-six (126) class B preferred shares (the "Class B Preferred Shares"),
one hundred twenty-six (126) class C preferred shares (the "Class C Preferred Shares"), one hundred twenty-six (126)
class D preferred shares (the "Class D Preferred Shares"), one hundred twenty-six (126) class E preferred shares (the
"Class E Preferred Shares"), one hundred twenty-six (126) class F preferred shares (the "Class F Preferred Shares"), one
hundred twenty-six (126) class G preferred shares (the "Class G Preferred Shares"), one hundred twenty-six (126) class
H preferred shares (the "Class H Preferred Shares"), one hundred twenty-six (126) class I preferred shares (the "Class I
Preferred Shares"), and together with the Class A Preferred Shares, the Class B Preferred Shares, the Class C Preferred
Shares, the Class D Preferred Shares, the Class E Preferred Shares, the Class F Preferred Shares, the Class G Preferred
Shares, the Class H Preferred Shares, the Class I Preferred Shares (the "Preferred Shares") and together with the Ordinary
Shares (the "shares"), being a total of one thousand three hundred ninety (1,390) shares of a nominal value EUR 50 (fifty
euro) each. The share capital of the Company may be increased or reduced by decision of the extraordinary general
meeting of shareholders resolving at the majorities required for the amendment of the present articles."
<i>Evaluationi>
For the purposes of registration, the total contribution is valued at EUR 12,000 (twelve thousand euro).
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,500 (one thousand five hundred euro).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille neuf, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "Misam S.à
r.l.", ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B numéro 133.966 constituée suivant acte reçu le 21 novembre 2007, publiée au Mémorial C,
numéro 3,004, page 144,173 du 27 décembre 2007 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
L'assemblée est présidée par Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Lu-
xembourg, 74, avenue Victor Hugo.
46356
Le président désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, avec même adresse professionnelle.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie DUPONT, employée privée, avec même adresse professionnelle.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence.
Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.150 (mille cent cinquante) parts sociales, représentant l'intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé a été préalablement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 12.000 (douze mille euros) pour le porter de
son montant actuel de EUR 57.500 (cinquante-sept mille cinq cents euros) à EUR 69.500 (soixante-neuf mille cinq cents
euros) par l'émission de 240 (deux cent quarante) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 50 (cinquante
euros) chacune;
2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les nouvelles parts par un apport en nature
consistant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société
au profit de Mr Ulf Rosberg, et acceptation par les gérants de Misam S.à r.l.;
3.- Nouvelles composition de l'actionnariat de la société;
4.- Modification afférente de l'article 8 des statuts de la société afin de tenir compte de cette action.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé décide ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 12.000 (douze mille euros) pour le porter de son
montant actuel de EUR 57.500 (cinquante-sept mille cinq cents euros) à EUR 69.500 (soixante-neuf mille cinq cents euros)
par l'émission de 6 (six) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires"), 26 (vingt-six) parts sociales préféren-
tielles de classe A (les "Parts Sociales Préférentielles de Classe A"), 26 (vingt-six) parts sociales préférentielles de classe
B (les "Parts Sociales Préférentielles de Classe B"), 26 (vingt-six) parts sociales préférentielles de classe C (les "Parts
Sociales Préférentielles de Classe C"), 26 (vingt-six) parts sociales préférentielles de classe D (les "Parts Sociales Préfé-
rentielles de Classe D"), 26 (vingt-six) parts sociales préférentielles de classe E (les "Parts Sociales Préférentielles de Classe
E"), 26 (vingt-six) parts sociales préférentielles de classe F (les "Parts Sociales Préférentielles de Classe F"), 26 (vingt-six)
parts sociales préférentielles de classe G (les "Parts Sociales Préférentielles de Classe G"), 26 (vingt-six) parts sociales
préférentielles de classe H (les "Parts Sociales Préférentielles de Classe H"), 26 (vingt-six) parts sociales préférentielles
de classe I (les "Parts Sociales Préférentielles de Classe I"),et ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles de Classes
A, les Parts Sociales Préférentielles de Classe B, les Parts Sociales Préférentielles de Classe C, les Parts Sociales Préfé-
rentielles de Classe D, les Parts Sociales Préférentielles de Classe E, les Parts Sociales Préférentielles de Classe F, les Parts
Sociales Préférentielles de Classe G, les Parts Sociales Préférentielles de Classe H, les Parts Préférentielles de Classe I et
les Parts Sociales Ordinaires, étant un total de 240 (deux cent quarante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 50
(cinquante euros) chacune, souscrites intégralement et libérées par un apport en nature consistant en la renonciation à
due concurrence à une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société au profit de Mr Ulf Rosberg,
s'élevant à EUR 12.000 (douze mille euros).
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique accepte la souscription des parts sociales nouvelles par lui-même, à savoir:
- Mr Ulf Rosberg, prédésigné, pour l'ensemble des 240 (deux cent quarante) nouvelles parts sociales à émettre.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite Mr Ulf Rosberg, directeur de la société, né à Allhelgona le 10 septembre 1965, résidant à Burevägen
9, SE-182 63 Djursholm,, Suède, prénommé, ici représenté comme dit ci-avant;
a déclaré souscrire aux 6 (six) parts sociales ordinaires, 26 (vingt-six) parts sociales préférentielles de Classes A, 26
(vingt-six) parts sociales préférentielles de Classe B, 26 (vingt-six) parts sociales préférentielles de Classe C, 26 (vingt-
six) parts sociales préférentielles de Classe D, 26 (vingt-six) parts sociales préférentielles de Classe E, 26 (vingt-six) parts
sociales préférentielles de Classe F, 26 (vingt-six) parts sociales préférentielles de Classe G, 26 (vingt-six) parts sociales
préférentielles de Classe H, 26 (vingt-six) parts sociales préférentielles de Classe I, et les libérer intégralement par re-
nonciation définitive et irrévocable de sa créance certaine, existant à charge de la société Misam S.à r.l..
La justification de l'existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-
mentant, par une situation comptable et un certificat de reconnaissance de dette signés par les gérants de la société
luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation signée par le souscripteur.
46357
<i>Intervention des gérantsi>
Sont alors intervenus les gérants de la société Misam S.à r.l., ici représentés en vertu d'une procuration qui restera ci-
annexée.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants
de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de
l'apport en nature, sur son évaluation, sur la renonciation à une créance effectuée et confirment la validité des souscri-
ptions et libération.
<i>Troisième résolutioni>
En vertu des résolutions qui précèdent, le capital social est maintenant souscrit comme suit:
Mr Ulf Rosberg, prénommé,
256 (deux cent cinquante-six) parts sociales ordinaires, 126 (cent vingt-six) parts sociales préférentielles de Classe A,
126 (cent vingt-six) parts sociales préférentielles de Classe B, 126 (cent vingt-six) parts sociales préférentielles de Classe
C, 126 (cent vingt-six) parts sociales préférentielles de Classe D, 126 (cent vingt-six) parts sociales préférentielles de
Classe E, 126 (cent vingt-six) parts sociales préférentielles de Classe F, 126 (cent vingt-six) parts sociales préférentielles
de Classe G, 126 (cent vingt-six) parts sociales préférentielles de Classe H, 126 (cent vingt-six) parts sociales préféren-
tielles de Classe I.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, il est
décidé de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 8. Le capital de la Société est de soixante-neuf mille cinq cents euros (EUR 69.500), représenté par deux cent
cinquante-six (256) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires"), cent vingt-six (126) parts sociales préfé-
rentielles de classe A (les "Parts Sociales Préférentielles de Classe A"), cent vingt-six (126) parts sociales préférentielles
de classe B (les "Parts Sociales Préférentielles de Classe B"), cent vingt-six (126) parts sociales préférentielles de classe
C (les "Parts Sociales Préférentielles de Classe C"), cent vingt-six (126) parts sociales préférentielles de classe D (les
"Parts Sociales Préférentielles de Classe D"), cent vingt-six (126) parts sociales préférentielles de classe E (les "Parts
Sociales Préférentielles de Classe E"), cent vingt-six (126) parts sociales préférentielles de classe F (les "Parts Sociales
Préférentielles de Classe F"), cent vingt-six (126) parts sociales préférentielles de classe G (les "Parts Sociales Préféren-
tielles de Classe G"), cent vingt-six (126) parts sociales préférentielles de classe H (les "Parts Sociales Préférentielles de
Classe H"), cent vingt-six (126) parts sociales préférentielles de classe I (les "Parts Sociales Préférentielles de Classe I"),
et ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles de Classe A, les Parts Sociales Préférentielles de Classe B, les Parts
Sociales Préférentielles de Classe C, les Parts Sociales Préférentielles de Classe D, les Parts Sociales Préférentielles de
Classe E, les Parts Sociales Préférentielles de Classe F, les Parts Sociales Préférentielles de Classe G, les Parts Sociales
Préférentielles de Classe H, les Parts Sociales Préférentielles de Classe I et les Parts Sociales Ordinaires, étant un total
de mille trois cent quatre-vingt-dix (1.390) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 50 (cinquante euros) chacune.
Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des
associés décidant à la majorité requise pour la modification de ces statuts."
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l'enregistrement, l'apport en sa totalité est estimé à EUR 12.000 (douze mille euros).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.500 (mille cinq cents euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Petit, I. Dias, S. Dupont et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 avril 2009, LAC/2009/15723. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
46358
Luxembourg, le 24 avril 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009052795/5770/229.
(090060975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2009.
REA Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 128.430.
DISSOLUTION
In the year two thousand and nine, on the third day of April,
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "REA Lux 2 S.à r.l.", a Luxembourg "société à
responsabilité limité", having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered at the
Luxembourg Trade and Companies Register with the number B 128 430, incorporated pursuant to a deed of Maître
Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg on the 14
th
of May, 2007, published in the "Mémorial C, recueil des
Sociétés et Associations'" number 1477 on 17
th
of July 2007 (the "Company").
There appeared:
The sole partner of the Company, "REA Europe S.à r.l.", a private limited liability company incorporated under Lu-
xembourg laws, having its registered office at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 124
445 ("Sole Partner"), represented by Mr. Régis Galiotto, residing in Luxembourg, duly authorised to act on behalf of REA
Europe S.à r.l. by virtue of a proxy given under private seal.
The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Sole Partner declared and requested the notary to act that:
I. - As it appears from the attendance list annexed to this deed to be registered with it, the 125 (one hundred twenty
five) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred euros) each, representing the whole share capital of the
Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
II. - The Sole Partner waives its right to the prior notice of the current meeting; it acknowledges being sufficiently
informed beforehand on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote
upon all the items of the agenda. The Sole Partner resolves further that all the documentation produced to the meeting
has been put at its disposal within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
III. - The Company, REA Lux 2 S.à r.l., with registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and companies register under the number B 128 430 has been incorporated pursuant to a
deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg on the 14
th
of May 2007, published in the "Mémorial
C, recueil des Sociétés et Associations" number 1477 of the 17
th
of July 2007.
IV. - The corporate capital of the Company is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) divided into
125 (one hundred twenty five) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred euros) each, which is entirely
subscribed and fully paid up.
V. - The Sole Partner is the sole owner of all the shares of the Company.
VI. - The Sole Partner, acting as the sole shareholder, approves the interim balance sheet of the Company as at 3 april,
2009 attached hereto and declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect.
VII. - The Sole Partner appoints itself as liquidator of the Company and will have full powers to sign, execute and deliver
any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring into effect the
purposes of this act.
The Sole Partner, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:
(i) the Company does no longer carry out any activity;
(ii) all rights, title, interest and obligations in an with respect to the existing assets of the Company, are hereby assigned,
transferred and conveyed to the Sole Partner, which has acknowledged and consented to this assignment;
(iii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing liabilities of the Company, are hereby
assumed, transferred and conveyed to the Sole Partner which has acknowledged and consented to this transfer; any
outstanding liabilities in relation to the closure of the liquidation are duly supplied with and the Sole Partner irrevocably
undertakes to assume and to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company.
VIII. - The Sole Partner declares that the liquidation of the Company is closed.
IX. - Discharge is given to the managers of the Company:
46359
- Pascal Roumiguié, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg
- Bruno Bagnouls, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg
- Paul Wilson, with professional address at 33, Canvendish Square, W1G 0PW London, United Kingdom
- Laura Mc Grath, with professional address at 730, Third Avenue, 10017 New York, United States of America
- Mark J. Wood, with professional address at 730, Third Avenue, 10017 New York, United States of America
- Trevor Michael, with professional address at 730, Third Avenue, 10017 New York, United States of America
X. - The books and documents of the Company will be kept for a period of 5 (five) years in Luxembourg at the former
registered office of the Company, 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
It has then been proceeded to the cancellation of the share register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would
be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about 1,100.- Euros..
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte
anglais fait foi.
L'an deux mille neuf, le trois avril,
Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "Rea Lux 2 S.à
r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 14 mai 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 128 430, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et des Associations du 17 juillet
2007, numéro 1477.
A comparu:
L'associé unique de la Société, "REA Europe S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 7A rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 124 445 ("Associé Unique"),
représenté par Mr. Régis Galiotto, demeurant à Luxembourg, dûment autorisé à représenter REA Europe S.à r.l. en vertu
d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
L'associé unique a déclaré et a requis le au notaire d'acter que:
I.- Qu'il apparaît de la liste de présence annexée au présent acte pour être formalisée avec lui que les 125 (cent vingt
cinq) parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social
(d'un montant de EUR 12.500), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
II.- Que l'Associé Unique renonce à ses droits de convocation, reconnaît avoir été suffisamment informé au préalable
sur les points portés à l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et accepte dès lors de délibérer et
de voter les points portés à l'ordre du jour. L'Associé Unique décide ensuite que toute la documentation présentée lors
de l'assemblée a été mise à sa disposition endéans une période suffisante pour lui permettre d'examiner attentivement
chaque document.
III.- Que la société à responsabilité limitée "REA Lux 2 S.à r.l." ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 128 430, a été
constituée pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
suivant acte reçu le 14 mai 2007, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et des Associations du 17 juillet 2007,
numéro 1477.
IV.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté
par 125 (cent vingt cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, intégralement libérées.
V.- L'Associé Unique est propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.
46360
VI.- L'Associé Unique, en tant qu'associé unique de la Société, approuve la situation financière de la Société au 3 avril
2009, annexée au présent acte et déclare expressément procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat.
VII.- L'Associé Unique se nomme liquidateur de la Société et aura les pleins pouvoirs pour signer, exécuter et délivrer
tout acte et tout document, pour faire toute déclaration et pour exécuter toutes opérations pouvant être nécessaires à
l'accomplissement des objectifs du présent acte.
L'Associé Unique, en sa capacité de liquidateur de la Société, déclare que:
(i) la Société n'a plus d'activité;
(ii) que tous les droits, titres, intérêts et obligations liés aux actifs existant de la Société, sont, par le présent acte,
assignés, transférés et transmis à l'Associé Unique, qui a pris connaissance et consent à cet affectation.
(iii)que tous les droits, titres, intérêts et obligations liés aux actifs existant de la Société, sont par le présent acte, pris
en charge, transférés et transmis à l'Associé Unique, qui a pris connaissance et consent à cette affectation; toutes dettes
impayées en relation avec la clôture de la liquidation seront dûment adressées à l'Associé Unique, qui s'engage à les
prendre en charge ainsi que toute dette impayée et inconnue à ce jour de la Société dissoute.
VIII.- L'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est close.
IX.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société:
- Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg
- Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg
- Paul Wilson, 33, avec adresse professionnelle au Canvendish Square, W1G 0PW London, United Kingdom
- Laura Mc Grath, avec adresse professionnelle au 730, Third Avenue, 10017 New York, United States of America
- Mark J. Wood, avec adresse professionnelle au 730, Third Avenue, 10017 New York, United States of America
- Trevor Michael, avec adresse professionnelle au 730, Third Avenue, 10017 New York, United States of America
X.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant 5 (cinq) ans à Luxembourg à l'ancien
siège social de la Société, 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, ont été estimés à environ 1.100.- Euros.
Le soussigné notaire qui comprend et parle anglais déclare que sur demande de la personne ayant comparu, le présent
acte a été établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne ayant comparu et en cas
de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 08 avril 2009. Relation: LAC/2009/13818. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009052389/211/149.
(090060338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2009.
Ignis et Glacies S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1645 Luxembourg, 28, Montée du Grund.
R.C.S. Luxembourg B 115.078.
L'an deux mille neuf, le neuf avril,
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1. Monsieur Philippe HOFFMANN, employé privé, né à Luxembourg, le 3 octobre 1986, demeurant à L-2128 Luxem-
bourg, 76, rue Marie-Adélaïde.
2. Monsieur Marcel ERNST, retraité, né à Luxembourg, le 2 septembre 1942, demeurant à L-1328 Luxembourg, 38,
rue Charlemagne.
46361
3. Madame Anne ZENS, retraitée, née à Ettelbruck, le 18 septembre 1951, épouse de Monsieur Marcel ERNST, de-
meurant à L-1328 Luxembourg, 38, rue Charlemagne.
4. Monsieur Olivier ERNST, fonctionnaire de l'Etat, né à Luxembourg, le 3 janvier 1973, demeurant à L-7220 Helmsange,
130, route de Diekirch.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter que les comparants sont les associés actuels de la
société à responsabilité limitée "IGNIS ET GLACIES S.àr.l.", établie et ayant son siège social à L-1645 Luxembourg, 28,
Montée de Grund, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 115078,
(ci-après la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en
date du 2 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1152 du 14 juin 2006, dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 juillet 2008, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2177 du 8 septembre 2008,
et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les
résolutions suivantes:
<i>Exposé préliminairei>
A présent sont inscrits auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, en tant que détenteurs des cinq cent cinquante
(550) parts sociales représentatives du capital social, les personnes suivantes:
1) Monsieur Frédéric ERNST: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 parts sociales (faisant 95,45% du capital social), et
2) Monsieur Philippe HOFFMANN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 parts sociales (faisant 4,55% du capital social)
Monsieur Frédéric ERNST, en son vivant gérant de société, né à Luxembourg, le 20 avril 1980, ayant demeuré en
dernier lieu à L-1328 Luxembourg, 38, rue Charlemagne, est décédé intestat à St. Ingbert, (Allemagne), le 15 décembre
2008.
Sa succession, dont font partie également les parts sociales dont question ci-avant, est échue à raison de chaque fois
un quart indivis (23,86% du capital social) à ses parents, savoir les époux Monsieur Marcel ERNST et Madame Anne ZENS,
préqualifiés, et pour l'autre moitié indivise (47,73% du capital social) à son seul frère, savoir le prénommé Monsieur Olivier
ERNST.
<i>Première résolutioni>
- Monsieur Philippe HOFFMANN, préqualifié, cède et transporte par les présentes sous la garantie de fait et de droit
ses 4,55 % qu'il détient dans la Société pour le prix total de deux cent cinquante euros (250,- EUR) aux époux Marcel
ERNST-ZENS, préqualifiés, ici présents et ce acceptant.
Le cédant Monsieur Philippe HOFFMANN déclare avoir reçu la somme de deux cent cinquante euros (250,- EUR) des
cessionnaires avant la signature des présentes et en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable
quittance.
- Les époux Marcel ERNST-ZENS, préqualifiés, cèdent et transportent par les présentes sous la garantie de fait et de
droit 2,27% qu'ils détiennent dans la Société pour le prix total de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) à Monsieur Olivier
ERNST, préqualifié, ici présent et ce acceptant.
La partie cédante, savoir les époux Marcel ERNST-ZENS déclarent avoir reçu la somme de cent vingt-cinq euros (125,-
EUR) du cessionnaire avant la signature des présentes et en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne
et valable quittance.
Ces cessions de parts sociales sont approuvées conformément à l'article 8 des statuts et les associés les considèrent
comme dûment signifiées à la Société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Les cessionnaires sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir d'aujourd'hui et ils ont droit à partir de ce
jour aux revenus et bénéfices dont ces parts seront productives à compter de ce jour et ils seront subrogés dans tous
les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.
Ils reconnaissent en outre avoir une parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée constate que les cinq cent cinquante (550) parts sociales représentatives du capital social sont dorénavant
détenues comme suit:
1) Les époux Marcel ERNST-ZENS, préqualifiés, deux cent soixante-quinze parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . 275
2) Monsieur Olivier ERNST, préqualifié, deux cent soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Total: cinq cent cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
<i>Troisième résolutioni>
Afin de refléter ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante-cinq mille euros (55.000,- EUR), représenté par cinq cent cinquante (550)
parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées.
46362
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales."
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée constate avec regret le décès du gérant Frédéric ERNST.
L'assemblée décide de restructurer la gérance de la Société et de nommer aux fonctions de gérants pour une durée
indéterminée:
- Monsieur Jorge Manuel DA COSTA FERNANDES, gérant de société, né à Luxembourg, le 28 juin 1979, demeurant
à L-1311 Luxembourg, 31, boulevard Marcel Cahen, gérant technique,
- Monsieur Marcel ERNST, retraité, né à Luxembourg, le 2 septembre 1942, demeurant à L-1328 Luxembourg, 38,
rue Charlemagne, gérant administratif,
- Madame Anne ZENS, retraitée, née à Ettelbruck, le 18 septembre 1951, épouse de Monsieur Marcel ERNST, de-
meurant à L-1328 Luxembourg, 38, rue Charlemagne, gérante administrative,
- Monsieur Olivier ERNST, fonctionnaire de l'Etat, né à Luxembourg, le 3 janvier 1973, demeurant à L-7220 Helmsange,
130, route de Diekirch, gérant administratif.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer le pouvoir de signature des gérants comme suit:
"La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et d'un
gérant administratif."
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à charge de la Société,
et les associés s'y engagent personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: HOFFMANN - ERNST - ZENS - ERNST - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 avril 2009. Relation GRE/2009/1500. Reçu soixante-quinze euros 75,- €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Junglinster, le 21 avril 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009052906/231/100.
(090061389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2009.
NG Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 5.084.606.720,00.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 120.899.
In the year two thousand and nine, on the thirty-first day of March.
Before M
e
Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
National Grid plc, a company governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 1-3 Strand,
WC2N 5 EH London, United Kingdom, listed on the London Stock Exchange,
hereby represented by Me Tom Loesch, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 30 March 2009, (the "Sole Shareholder").
The said proxy signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall be annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Sole Shareholder is the sole sha-
reholder of NG Luxembourg 3 S.à r.l., a private limited liability company (Société à responsabilité limitée) governed by
the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365, Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under Section B, number 120.899,
incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)
46363
dated 12 October 2006, published on 28 November 2006 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2221 (the "Company"). The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed dated 24
March 2009 of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder represented as above mentioned has recognised to be fully informed of the resolutions to be
taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To increase the corporate capital by an amount of five billion eighty-four million four hundred forty-eight thousand
seven hundred and twenty United States Dollars (USD 5,084,448,720.-) so as to raise it from its present amount of one
hundred fifty-eight thousand United States Dollars (USD 158,000.-) to an amount of five billion eighty-four million six
hundred six thousand seven hundred and twenty United States Dollars (USD 5,084,606,720.-) by the creation of one
hundred twenty-seven million one hundred eleven thousand two hundred and eighteen (127,111,218) shares with a
nominal value of forty United States Dollars (USD 40.-) each.
2 To issue one hundred twenty-seven million one hundred eleven thousand two hundred and eighteen (127,111,218)
shares with a nominal value of forty United States Dollars (USD 40.-) each, having the same rights and privileges as the
existing shares.
3 To accept subscription for the new one hundred twenty-seven million one hundred eleven thousand two hundred
and eighteen (127,111,218) shares with a nominal value of forty United States Dollars (USD 40.-) each, by National Grid
plc, a company governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 1-3 Strand, WC2N 5 EH
London, United Kingdom, listed on the London Stock Exchange (the "Sole Shareholder"), to accept payment in full of the
subscription price for such new shares amounting totally to five billion eighty-four million four hundred forty-eight thou-
sand seven hundred and forty-eight United States Dollars (USD 5,084,448,748.-) composed of the aggregate nominal
value of such new shares amounting totally to five billion eighty-four million four hundred forty-eight thousand seven
hundred and twenty United States Dollars (USD 5,084,448,720.-) and a share premium in an aggregate amount of twenty-
eight United States Dollars (USD 28.-), by a contribution in kind in the form of a transfer of receivables in an amount of
five billion eighty-four million four hundred forty-eight thousand seven hundred and forty-eight United States Dollars
(USD 5,084,448,748.-), to allocate such new shares to the Sole Shareholder and to acknowledge the effectiveness of the
capital increase.
4 To amend the first paragraph of Article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the above
resolutions.
5 Miscellaneous.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the corporate capital by an amount of five billion eighty-four million four
hundred forty-eight thousand seven hundred and twenty United States Dollars (USD 5,084,448,720.-) so as to raise it
from its present amount of one hundred fifty-eight thousand United States Dollars (USD 158,000.-) to an amount of five
billion eighty-four million six hundred six thousand seven hundred and twenty United States Dollars (USD 5,084,606,720.-)
by the creation of one hundred twenty-seven million one hundred eleven thousand two hundred and eighteen
(127,111,218) shares with a nominal value of forty United States Dollars (USD 40.-) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to issue one hundred twenty-seven million one hundred eleven thousand two hundred
and eighteen (127,111,218) shares with a nominal value of forty United States Dollars (USD 40.-) each, having the same
rights and privileges as the existing shares.
<i>Subscription and Paymenti>
There now appeared Me Tom Loesch prenamed,
acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of the Sole Shareholder by virtue of a proxy given on 30 March
2009, which proxy signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder prenamed, for the one
hundred twenty-seven million one hundred eleven thousand two hundred and eighteen (127,111,218) shares with a
nominal value of forty United States Dollars (USD 40.-) each, and to make payment in full of the subscription price for
such new shares amounting totally to five billion eighty-four million four hundred forty-eight thousand seven hundred and
forty-eight United States Dollars (USD 5,084,448,748.-) composed of the aggregate nominal value of such new shares
amounting totally to five billion eighty-four million four hundred forty-eight thousand seven hundred and twenty United
States Dollars (USD 5,084,448,720.-) and a share premium in an aggregate amount of twenty-eight United States Dollars
(USD 28.-), by a contribution in kind in the form of a transfer of receivables in an amount of five billion eighty-four million
46364
four hundred forty-eight thousand seven hundred and forty-eight United States Dollars (USD 5,084,448,748.-) (the
"Contribution").
Proof of the ownership by the Sole Shareholder of the Contribution has been given to the undersigned notary.
The Sole Shareholder acting through its duly appointed attorney in fact declared that the Contribution is free of any
charges and pledges, and that there exist no further impediments to the free transferability of the Contribution to the
Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications,
registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.
The Sole Shareholder acting through its duly appointed attorney in fact further stated that a report has been drawn
up by the Board of Managers of the Company on 31 March 2009, wherein the Contribution is valued at five billion eighty-
four million four hundred forty-eight thousand seven hundred and forty-eight United States Dollars (USD 5,084,448,748.-).
The Contribution thus represents a net contribution in an aggregate amount of five billion eighty-four million four
hundred forty-eight thousand seven hundred and forty-eight United States Dollars (USD 5,084,448,748.-).
<i>Third resolutioni>
Thereupon the Sole Shareholder, resolved to accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot
the new one hundred twenty-seven million one hundred eleven thousand two hundred and eighteen (127,111,218) shares
to the Sole Shareholder.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend the first paragraph of Article 5 of the articles of incorporation of the Company
which shall forthwith read as follows:
"The subscribed capital of the Company is set at five billion eighty-four million six hundred six thousand seven hundred
and twenty United States Dollars (USD 5,084,606,720.-) represented by one hundred twenty-seven million one hundred
fifteen thousand one hundred and sixty-eight (127,115,168) shares having a nominal value of forty United-States Dollars
(USD 40,-) each."
<i>Costsi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any form whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of the present deed amount to seven thousand Euro (7,000.- EUR).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le trente et un mars,
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel restera
dépositaire du présent acte.
A comparu:
National Grid plc, une société de droit anglais, ayant son siège social au 1-3 Strand, London WC2N 5EH, Royaume-
Uni et cotée à la bourse de Londres,
représentée aux fins des présentes par Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration donnée le 30 mars 2009 ("l'Associé Unique")
La prédite procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné restera annexée
aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
L' Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé Unique est le seul associé de NG Luxembourg
3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, Parc d'Activité
Syrdall, L-5365, Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous la section B numéro 120.899, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de rési-
dence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 12 octobre 2006, publié le 28 novembre 2006 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2221 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois le 24 mars 2009 suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a reconnu être parfaitement au courant des décisions à inter-
venir sur base de l'ordre du jour suivant:
46365
<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social d'un montant de cinq milliards quatre-vingt-quatre millions quatre cent quarante-huit
mille sept cent vingt Dollars des États-Unis (USD 5.084.448.720,-) afin de le porter de son montant actuel de cent
cinquante-huit mille Dollars des États-Unis (USD 158.000,-) à un montant de cinq milliards quatre-vingt-quatre millions
six cent six mille sept cent vingt Dollars des États-Unis (USD 5.084.606.720,-) par la création de cent vingt-sept millions
cent onze mille deux cent dix-huit (127.111.218) parts sociales d'une valeur nominale de quarante Dollars des États-Unis
(USD 40,-) chacune.
2 Émission de cent vingt-sept millions cent onze mille deux cent dix-huit (127.111.218) parts sociales d'une valeur
nominale de quarante Dollars des États-Unis (USD 40,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales
existantes.
3 Acceptation de la souscription des cent vingt-sept millions cent onze mille deux cent dix-huit (127.111.218) nouvelles
parts sociales d'une valeur nominale de quarante Dollars des États-Unis (USD 40,-) chacune, par National Grid plc, une
société de droit anglais, ayant son siège social au 1-3 Strand, London WC2N 5EH, Royaume-Uni et cotée à la bourse de
Londres ("l'Associé Unique"), acceptation du payement intégral du prix de souscription de ces nouvelles parts sociales
d'un montant total de cinq milliards quatre-vingt-quatre millions quatre cent quarante-huit mille sept cent quarante-huit
Dollars des États-Unis (USD 5.084.448.748,-) composé de la valeur nominale totale de ces nouvelles parts d'un montant
de cinq milliards quatre-vingt-quatre millions quatre cent quarante-huit mille sept cent vingt Dollars des États-Unis (USD
5.084.448.720,-) et d' une prime d'émission d'un montant total de vingt-huit Dollars des Etats-Unis (USD 28,-), par un
apport en nature en la forme d'une cession de créances d'un montant de cinq milliards quatre-vingt-quatre millions quatre
cent quarante-huit mille sept cent quarante-huit Dollars des États-Unis (USD 5.084.448.748,-), attribution de ces nouvelles
parts sociales à l'Associé Unique et constatation de la réalisation de l'augmentation de capital.
4 Modification du premier paragraphe de l'Article 5 des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions
mentionnées ci-dessus.
5 Divers.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de cinq milliards quatre-vingt-quatre millions
quatre cent quarante-huit mille sept cent vingt Dollars des États-Unis (USD 5.084.448.720,-) afin de le porter de son
montant actuel de cent cinquante-huit mille Dollars des États-Unis (USD 158.000,-) à un montant de cinq milliards quatre-
vingt-quatre millions six cent six mille sept cent vingt Dollars des États-Unis (USD 5.084.606.720,-) par la création de cent
vingt-sept millions cent onze mille deux cent dix-huit (127.111.218) parts sociales d'une valeur nominale de quarante
Dollars des États-Unis (USD 40,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'émettre cent vingt-sept millions cent onze mille deux cent dix-huit (127.111.218) parts
sociales d'une valeur nominale de quarante Dollars des États-Unis (USD 40,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges
que les parts sociales existantes.
<i>Souscription et Paiementi>
Ensuite Maître Tom Loesch précité, s'est présenté, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de l'Associé
Unique, précité, en vertu d'une procuration donnée le 30 mars 2009, laquelle après avoir été paraphée "ne varietur" par
le mandataire et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de l'Associé Unique aux cent vingt-sept millions cent onze
mille deux cent dix-huit (127.111.218) parts sociales d'une valeur nominale de quarante Dollars des États-Unis (USD 40,-),
et libérer intégralement, le prix de souscription de ces nouvelles parts sociales d'un montant de cinq milliards quatre-
vingt-quatre millions quatre cent quarante-huit mille sept cent quarante-huit Dollars des États-Unis (USD 5.084.448.748,-)
composé de la valeur nominale totale de ces nouvelles parts d'un montant de cinq milliards quatre-vingt-quatre millions
quatre cent quarante-huit mille sept cent vingt Dollars des États-Unis (USD 5.084.448.720,-) et d' une prime d'émission
d'un montant total de vingt-huit Dollars des Etats-Unis (USD 28,-), par un apport en nature en la forme d'une cession de
créances d'un montant de cinq milliards quatre-vingt-quatre millions quatre cent quarante-huit mille sept cent quarante-
huit Dollars des États-Unis (USD 5.084.448.748,-) (l'"Apport").
La preuve de la propriété de l'Apport de l'Associé Unique a été apportée au notaire soussigné.
L'Associé Unique agissant par le biais de son mandataire a déclaré que l'Apport est libre de tout privilège ou gage et
qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été
données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert
valable de l'Apport à la Société.
L'Associé Unique agissant par le biais de son mandataire a déclaré qu'un rapport a été établi par le Conseil de Gérance
de la Société le 31 mars 2009, dans lequel l'Apport est évalué à cinq milliards quatre-vingt-quatre millions quatre cent
quarante-huit mille sept cent quarante-huit Dollars des États-Unis (USD 5.084.448.748,-).
46366
L'Apport représente ainsi un apport total net d'un montant de cinq milliards quatre-vingt-quatre millions quatre cent
quarante-huit mille sept cent quarante-huit Dollars des États-Unis (USD 5.084.448.748,-).
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique à ensuite décidé d'accepter ladite souscription et le paiement par le souscripteur et d'attribuer les
cent vingt-sept millions cent onze mille deux cent dix-huit (127.111.218) nouvelles parts sociales à l'Associé Unique.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, lequel suivant
cette modification aura la teneur suivante:
"Le capital social de la société est fixé à cinq milliards quatre-vingt-quatre millions six cent six mille sept cent vingt
Dollars des États-Unis (USD 5.084.606.720,-) divisé en cent vingt-sept millions cent quinze mille cent soixante-huit
(127.115.168) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de quarante Dollars des États-Unis (USD 40,-)".
<i>Coûtsi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte
sont estimés à environ sept mille Euros (7.000,- EUR).
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: T. Loesch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 avril 2009. Relation: LAC/2009/12909. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-)
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2009.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2009052823/220/214.
(090061308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2009.
Clovis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 95.065.
RECTIFICATIF
du bilan au 31/12/2005 enregistré à Luxembourg, le 20/01/2009 Référence L090010760.04 déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg le 21/01/2009.
Le bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009052220/5863/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2009, réf. LSO-DD04512. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090060760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2009.
Memento S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 119.257.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
46367
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009053364/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2009, réf. LSO-DD06160. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090059481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2009.
Orthodontic Management Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9080 Ettelbruck, 46, avenue Lucien Salentiny.
R.C.S. Luxembourg B 97.305.
RECTIFICATIF
du bilan au 31/12/2007 enregistré à Luxembourg, le 06/11/2008 Référence L080166368.05 déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg le 12/11/2008.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009052221/5863/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2009, réf. LSO-DD04515. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090060762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2009.
CARMIGNAC GESTION Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 67.549.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Bruneau
<i>Délégué à la gestion journalièrei>
Référence de publication: 2009052222/5398/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2009, réf. LSO-DD08157. - Reçu 113,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090060775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2009.
The Triangle Investment Group Holdings SAH, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 33.118.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 AVR. 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009052251/763/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2009, réf. LSO-DD06503. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090060645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
46368
ABF Lux SA
Agro-Sud Finances Holding S.A.
Allianz ROSNO Investment Strategies
Allianz ROSNO Investment Strategies
Arcobaleno Fund
Banca Lombarda Sicav
Batz S.A.
BL
Capital Gestion
CARMIGNAC GESTION Luxembourg
CIC CH Fund
Clovis S.A.
Cnig S.A.
E24 S.à r.l.
EDM International
Endicott S.A.
Fidimmo S.A.
Financière d'Evry
Financière d'Investissement Technologique S.A.
Fuchs Invest
Giolu S.A.
Goldwell Holding S.A.
G&P Invest Sicav
Hydrosol S.A.
Ignis et Glacies S.àr.l.
Immo BPM SA
Infor-ID S.A.
Ingenium
Karisso S.A.
KIZ 5 Luxembourg S.à r.l.
Linston S.P.F.
Lis Bleu S.A.
Lysara Holding S.A.
Maltesia S.A.
Mariva Holding
Memento S.à r.l.
Metro International S.A.
Millicom International Cellular S.A.
Misam S.à r.l.
NG Luxembourg 3 S.à r.l.
Orthodontic Management Service S.à r.l.
Parax S.A.
Poseidon S.A.
Prosper S.A.
QS Italy SICAR S.A.
Randeor Holding S.A.
REA Lux 2 S.à r.l.
Reliance Finance Limited
Re World S.A.
Servizi Finanziari Internazionali S.A.
Sinagua S.A.
Sun Microsystems Luxembourg S.à.r.l.
Taïga Computer Europe S.A.
The Modern Funds
The Triangle Investment Group Holdings SAH
Transcom WorldWide S.A.
Westland Holding S.A.