This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 321
13 février 2009
SOMMAIRE
Artod S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15371
BE.L.Part S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15375
Benictim Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15371
Berin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15372
Betafin Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15370
Bonzaï S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15373
Business Technology Services . . . . . . . . . . .
15369
CB Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15408
Chaussea S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15406
Cienega Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
15365
Claremont Consulting Services S.A. . . . . .
15369
eBay Treasury S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15364
Edgecliff Finance S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15365
ETV Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15372
Europa Régions Magazine S.A. . . . . . . . . . .
15369
European Captive Insurance and Reinsu-
rance Owners' Association . . . . . . . . . . . . .
15402
Euro-Shopping, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15371
Euro-Shopping, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15370
Farenzena Jules Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15364
Fidelity International Real Estate Fund
Company 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15367
Fidelity International Real Estate Fund
Company 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15366
Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15363
Financière des Ardennes S.A. . . . . . . . . . . .
15366
Financière Tiara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15408
Fintinvest A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15362
Founty Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15407
GDI Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15376
GENPASA Environmental Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15368
Green House S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15362
Heidt-Hang Assurances s.à r.l. . . . . . . . . . . .
15366
Hua Yuan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15373
Idia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15370
Industrial Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15367
Komzept 7c S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15365
Koukab S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15371
Linea Grazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15375
Logicrane Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15378
Martin & Martin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15362
Med-Tel International Holdings S.A. . . . . .
15374
Melusine Aviation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
15362
Menaa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15377
MOOR PARK MB 7 Hannover-Bornum S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15368
Murex Participations Luxembourg S.A. . .
15370
Naxos Capital Managers S.àr.l. . . . . . . . . . .
15376
Ortatlantic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15364
Paepeweg Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15375
Pfizer Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
15363
ProLogis UK LVIII S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
15363
Rolo Operation Project S.A. . . . . . . . . . . . .
15373
Rosevo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15367
SFM Training & Consultancy, s.à r.l. . . . . .
15369
Silver Vending System . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15374
Smart Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15379
Syntech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15380
VATit Israel Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
15377
VDC Alpha Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15400
VF Finance s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15373
Woodsmore-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15376
15361
Green House S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 66.970.
Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009014582/1023/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06519. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090013428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Fintinvest A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 61.446.
Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
N. SCHMITZ
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2009014580/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06522. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Melusine Aviation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 130.071.
Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
S.G.A. SERVICES S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2009014581/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06521. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Martin & Martin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 114.288.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/2008.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009014597/717/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01822. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
15362
ProLogis UK LVIII S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 81.226.
Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2008.
ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
i>Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Géranti>
Référence de publication: 2009014567/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00152. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090013932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Pfizer Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 84.125.
Le Bilan au 30 novembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Ivan STEENKISTE.
Référence de publication: 2009014565/4287/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05683. - Reçu 44,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 67.904.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 novembre 2008 que:
Les mandats de tous les administrateurs étant venus à échéance, l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des
administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2009:
- Maurice Lam avec adresse professionnelle au 560 rue de Neudorf à L - 2220 Luxembourg
- Franz Prost avec adresse professionnelle au 560 rue de Neudorf à L - 2220 Luxembourg
- Marie-José Steinborn avec adresse professionnelle au 560 rue de Neudorf à L - 2220 Luxembourg
- Georges Kioes avec adresse professionnelle au 560 rue de Neudorf à L - 2220 Luxembourg
- Philippe Bruneton avec adresse professionnelle au 560 rue de Neudorf à L - 2220 Luxembourg
Le mandat de commissaire étant venu à échéance, l'assemblée décide de renommer jusqu'à l'assemblée générale or-
dinaire devant approuver les comptes de l'exercice 2009 la société:
- PKF ABAX AUDIT, RC B 142867, avec siège social au 6, Place de Nancy à L-2212 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2009.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2009014600/799/25.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07546. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
15363
Farenzena Jules Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3531 Dudelange, 81, rue du Nord.
R.C.S. Luxembourg B 73.366.
Constituée le 29 décembre 1999 par-devant Me Norbert MULLER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, acte publié
au Mémorial C no 166 du 23 février 2000, modifié par-devant Me Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-
Bonnevoie en date du 22 août 2002, acte publié au Mémorial C no 1519 du 22 octobre 2002.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19/12/2008.
<i>Pour FARENZENA JULES S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Référence de publication: 2009014599/1261/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05850. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090013509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Ortatlantic S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 130.956.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
N. SCHMITZ
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2009014596/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06534. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
eBay Treasury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.000,00.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 135.500.
<i>Extraits des résolutions des associési>
Il résulte des résolutions des associés de la Société prises en date du 4 décembre 2008 que les associés ont approuvé
la démission de Monsieur Robert Caplehorn de son poste de gérant de la Société avec effet au 4 décembre 2008.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est depuis le 4 décembre 2008 constitué par les personnes
suivantes:
- Jennifer Ceran;
- Nicholas Staheyeff; et
- Craig Ferreira.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2009.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009014579/1092/23.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06586. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090014094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
15364
Cienega Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 118.137.
Il résulte des résolutions de l'Associé Unique, en date du 12 décembre 2008 de la société Cienega Investments S.à r.l.
que l'actionnaire a pris les décisions suivantes:
1. Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à compter du 28 novembre 2008:
Manacor (Luxembourg) S.A., enregistré sous le numéro B9098 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg, et dont le siège social se situe 46A Avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg.
2. Démission du Gérant suivant à compter du 28 novembre 2008:
Cienega Holding B.V / S.à r.l., enregistré sous le numéro B118.125 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
du Luxembourg, et dont le siège social se situe 46A Avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Cienega Investments S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2009014590/683/23.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA07914. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Komzept 7c S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 110.030.
Election du nouveau Commissaire aux Comptes pour une durée indéterminée à compter du 10 décembre 2008:
- EURAUDIT S.à r.l. enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
B42899, et dont le siège social se situe 16 Allée Marconi L-2120 Luxembourg.
Démission du Commissaire aux Comptes suivant à compter du 31 janvier 2008:
- Crown Corporate Services, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le
numéro B77027, et dont le siège social se situe 25 A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Komzept 7c S.A.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2009014589/683/20.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA07906. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Edgecliff Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 132.150.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009014538/236/11.
(090013535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
15365
Heidt-Hang Assurances s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9633 Baschleiden, 27, rue du Barrage.
R.C.S. Luxembourg B 143.542.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009014539/236/11.
(090013497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Fidelity International Real Estate Fund Company 2, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 129.344.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 28 novembre 2008i>
L'associé unique décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers S. à r. l.
400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 janvier 2008.
<i>Pour FIDELITY INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND COMPANY 2
i>Société à responsabilité limitée
RBC Dexia investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Signatures
Référence de publication: 2009014607/1126/21.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05306. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Financière des Ardennes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 115.414.
<i>Extrait de la réunion de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2008i>
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> résolution.i>
L'Assemblée accepte la démission de l'Administrateur unique du Conseil d'Administration Monsieur Roland MERTZ,
né le 3 mai 1956, demeurant à 321, rue des Marquisat-Thiaumont, B-6717 Attert.
<i>2 i>
<i>èmei>
<i> résolution.i>
L'Assemblée constate que les actions sont détenues par un seul actionnaire. En vertu de la loi sur les sociétés com-
merciale du 25 août 2006, l'Assemblée décide que Monsieur Gilles SAUTHON demeurant à 86, boulevard de la Pétruse,
L-2320 Luxembourg est nommé Administrateur unique de la société.
Le mandat de l'Administrateur ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en
l'année 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
15366
FINANCIERE DES ARDENNES S.A.
Signature
Référence de publication: 2009014601/1682/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07643. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Fidelity International Real Estate Fund Company 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 129.345.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 28 novembre 2008i>
L'associé unique décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers S. à r. l.
400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 janvier 2008.
<i>Pour FIDELITY INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND COMPANY 1
i>Société à responsabilité limitée
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Signatures
Référence de publication: 2009014613/1126/21.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05307. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Rosevo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.
R.C.S. Luxembourg B 118.755.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009014540/236/11.
(090013754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Industrial Partnership, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 73.500.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 décembre 2008i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2008:
- Dr. iur. Urs SCHEUCH, Rechtsanwalt, demeurant au 31, Dufourstrasse, CH - 8008 Zürich, Suisse, Président
- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2008:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
15367
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2009014740/534/22.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04086. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
MOOR PARK MB 7 Hannover-Bornum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 125.367.
AUSZUG
Es erhellt aus einer Geschäftsabtretungsurkunde vom 17. Dezember 2008, aufgenommen durch Notar Dr. Peter RIE-
DER, mit dem Amtssitz in Erlangen (Bundesrepublik Deutschland), dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung des
tschechischen Rechts "BAKERMAN s.r.o.", mit Sitz in 18, Lochotinská, Landkreis Pilsen-Stadt, 301 00, eingetragen im
Handelsregister von Pilsen, Sektion C, Seite 17942, unter der Nummer 264 02 246, ihre sämtlichen (d.h.: 1.186.250)
Anteile welche sie in der Gesellschaft luxemburgischen Rechtes "MOOR PARK MB 7 Hannover-Bornum S.à r.l.", eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1130 Luxemburg, 37, rue d'Anvers, eingetragen beim Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 125367, wie folgt abgetreten hat:
- 1.125.000 Anteile an die Gesellschaft mit beschränkter Haftung slowakischen Rechtes "SLOVIMEX - Obchody, s.r.o.",
mit Sitz in Bratislava, Záhradnicka 34, PLZ 821 08, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bratislava 1 unter
der Nummer III. 16261/2007, und
- 61.250 Anteile an die Gesellschaft mit beschränkter Haftung des tschechischen Rechts "GEBO IMMOBILIA-RONDEL
s.r.o.", mit Sitz in 18, Lochotinská, Landkreis Pilsen-Stadt, 301 00, eingetragen im Handelsregister von Pilsen, Sektion C,
Seite 8564, unter der Nummer 411 97 968.
Luxemburg, den 7. Januar 2009.
Für gleichlautenden Auszug
MOOR PARK MB 7 Hannover-Bornum S.à r.l.
Dr. Günther ZEMBSCH
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2009014775/231/28.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06718. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
GENPASA Environmental Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 86.510.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 26 novembre 2008i>
<i>à 9:00 heures.i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La démission de Eurolex Management S.A., avec adresse professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
en tant que Gérant de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,
2. La nomination de Monsieur Matthijs BOGERS, né à Amsterdam, Pays-Bas le 24 novembre 1966, avec adresse
professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de
la réunion,
3. La nomination de Monsieur Stéphane HEPINEUZE, né à Dieppe, France, le 18 juillet 1977, avec adresse profes-
sionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée à la date de la
réunion.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
15368
Luxembourg, le 26 novembre 2008.
Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
i>Représentée par Mr. Julien FRANCOIS
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2009014681/1084/26.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01696. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090014044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Business Technology Services, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 45.444.
Le bilan au 20.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009014714/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06205. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Claremont Consulting Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 72.766.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009014712/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06184. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
SFM Training & Consultancy, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 99.726.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009014713/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06201. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Europa Régions Magazine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 74.633.
<i>Assemblée Gén. Extraord des Actionnaires tenue à Luxembourg le 15 décembre 2008 à 11 heures.i>
<i>Extraits des résolutionsi>
1) Par votes spéciaux, l'assemblée révoque Mr Strummeyer Patrick comme administrateur avec effet immédiat.
2) Par votes spéciaux, l'assemblée révoque Mr Strummeyer Michael comme administrateur et administrateur-délégué
avec effet immédiat.
15369
3) Par votes spéciaux, l'assemblée modifie le droit de signature: La société est engagée soit par la signature individuelle
de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2009014749/725/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08809. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Betafin Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 38.550.
En date du 5 janvier 2009, Monsieur Jean Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue
Michel Welter, la société @CONSEILS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel
Welter et Monsieur Angel Caschera, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter ont
démissionné de leur mandat d'administrateur de la société BETAFIN HOLDING SA, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.550 et établie à L-2730 Luxembourg, 67 rue Michel
Welter, et ce, avec effet immédiat.
La société READ S.à R.L. avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter a démissionné de son mandat
de commissaire aux comptes de la société BETAFIN HOLDING SA, avec effet immédiat.
Signature.
Référence de publication: 2009014753/1137/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06142. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090013820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Idia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 81.739.
Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/01/2009.
Signature.
Référence de publication: 2009014721/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05599. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Murex Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 108.040.
Les comptes annuels au 30 septembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009014722/280/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05247. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Euro-Shopping, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 99.733.
Le bilan au 30.06.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
15370
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009014718/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06194. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Euro-Shopping, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 99.733.
Le bilan au 30.06.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009014717/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06191. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090013649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Koukab S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 86.706.
Le bilan au 15.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009014715/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01162. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Benictim Properties, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 217, rue Albert Unden.
R.C.S. Luxembourg B 40.841.
Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009014711/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06176. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Artod S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 89.662.
En date du 9 janvier 2009, Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant à L-1724 Luxembourg,
3A, Boulevard du Prince Henri, la société @CONSEILS (@centure) S.à r.L, établie et ayant son siège social à L-1724
Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri et Monsieur Angel Caschera, demeurant professionnellement à L-2730
Luxembourg, 67, rue Michel Welter ont démissionné de leur mandat d'administrateurs de la société ARTOD SA, enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.662 et établie à L-2730
Luxembourg, 67 rue Michel Welter, et ce, avec effet immédiat.
15371
La société READ S.à R.L. avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri a démissionné de son
mandat de commissaire aux comptes de la société ARTOD SA, avec effet immédiat.
Signature.
Référence de publication: 2009014754/1137/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06145. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Berin Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 58.617.
EXTRAIT
Rectificatif de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 10/02/2000, déposé auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 17/04/2000.
Il y a lieu de lire:
«la société "Coral Management Company Trading Limited" avec son siège social aux Iles Vierges Britaniques a été élue
aux fonctions de commissaire aux comptes pour un terme expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2007, en
remplacement de l'ancien» et non la société "Coral Management Company Ltd.".
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15/04/2008 que l'assemblée a décidé à l'unanimité de:
- reconduire le mandat des administrateurs suivants:
* Victor Elvinger, demeurant professionnellement à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich;
* Catherine Dessoy, demeurant professionnellement à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich;
* Serge Marx, demeurant professionnellement à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
- reconduire le mandat de commissaire aux comptes de la société «Coral Management Company Trading Limited»
ayant son siège à Upper Main Street, Wickhams Cay 1, Tortola, British Virgin Islands.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l'assemblée générale qui se
tiendra en 2013.
Luxembourg, le 23 décembre 2008.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009014747/304/29.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02467. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
ETV Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 96.982.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 9 janvier 2009i>
L'actionnaire unique de la société ETV CAPITAL S.A. a pris les résolutions suivantes:
1) La révocation de Monsieur Charles Etonde, en sa qualité d'administrateur, avec effet au 7 novembre 2008, est
décidée.
2) La révocation de Mr William Holwell, en sa qualité d'administrateur, avec effet à la date de la présente résolution,
est décidée.
3) Il est décidé de nommer Madame Marie-Sybille Wolf, employée privée, née le 13 novembre 1967 à Liège (Belgique),
résidant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet
à la date de la présente résolution, et ce jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle de 2014.
4) Il est décidé de nommer Monsieur Robert Quinn, employé privé, né le 8 mai 1977 à Stockton On Tees (Royaume
Uni), résidant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec
effet à la date de la présente résolution, et ce jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle de 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
15372
<i>Pour ETV CAPITAL S. A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009014784/1649/25.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06485. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090014006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Bonzaï S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 85.647.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22/01/2009.
Signature.
Référence de publication: 2009014723/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA06965. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090014060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
VF Finance s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 100.676.
Le Bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2005 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2009.
VF Finance s.à r.l.
F.W.J.J. Welman
<i>Géranti>
Référence de publication: 2009014728/683/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA07904. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090014083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Rolo Operation Project S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 118.539.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/01/09.
Signature.
Référence de publication: 2009014720/5878/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05597. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Hua Yuan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3511 Dudelange, 99, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 118.484.
Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
15373
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009014729/510/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07175. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090014086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Med-Tel International Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 70.430.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 novembre 2008i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur John C. RUTHERFORD, demeurant au 265 Franklin Street, Boston MA 02110, USA
- Monsieur H. Bradley SLOAN, demeurant au Parthenon Capital, 4 Embarcadero Center, Suite 3610, San Francisco,
CA 94111 USA
- Monsieur Thompson Smith DENT, homme d'affaires, demeurant au 810 Crescent Centre Drive, Suite 560, Franklin,
Tennessee 37067, USA
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2008:
- AUDIEX S.A., 57 avenue de la Faïencerie, Luxembourg
Luxembourg, le 23 décembre 2008.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2009014743/534/23.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02855. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Silver Vending System, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 108.726.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des associés (clôture de liquidation) de la société «Silver
Vending System», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
en date du 30 décembre 2008, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 janvier 2009. Relation: EAC/2009/180.
- que la société «Silver Vending System» (la «Société»), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
au 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section
B sous le numéro 108.726,
constituée suivant acte du notaire soussigné du 10 juin 2005 et publié au Mémorial C numéro 1166 du 8 novembre
2005; les statuts de la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du
28 juin 2005 et publié au Mémorial C numéro 69 du 11 janvier 2006, au capital social de sept cent vingt-sept mille sept
cent cinquante Euros (727.750.- EUR) représenté par vingt-neuf mille cent dix (29.110) parts sociales d'une valeur no-
minale de vingt-cinq Euros (25.- EUR) chacune,
se trouve à partir de la date du 30 décembre 2008 définitivement liquidée,
l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 21 mars 2008 aux termes de laquelle la
Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les
articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au 76 Grand-
Rue, L-1660 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
15374
Belvaux, le 21 janvier 2009.
Jean-Joseph WAGNER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009014734/239/31.
(090013616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Paepeweg Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 131.954.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 août 2008.i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, Luxembourg, Président.
- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, Luxembourg.
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, Luxembourg
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2009014744/534/23.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02609. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
BE.L.Part S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 38.349.
Les Comptes Annuels au 30 juin 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 6/1/2009.
Signature.
Référence de publication: 2009014553/553/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04658. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Linea Grazia, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 65, route d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 120.123.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2008i>
L'associé unique Madame Grazia MOSCHETTI de la société à responsabilité limitée «LINEA GRAZIA» ayant son siège
social à L-1461 Luxembourg, 65, rue d'Eich a pris la résolution suivante:
"L'adresse privée de la gérante Madame Grazia MOSCHETTI a été transféré de L-2552 Luxembourg 1, rue de la Station
à L-1461 Luxembourg, 65, route d'Eich."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
15375
Fait à Luxembourg, le 1
er
décembre 2008.
Pour extrait conforme
AREND & PARTNERS S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2009014667/568/19.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03106. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Woodsmore-Lux S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 27.166.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 06 juin 2008i>
Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Philippe DUJARDIN, Administrateur, Président Directeur Général, avec adresse professionnelle au 51, rue
de Ponthieu, F-75008 Paris, France, aux fonctions d'administrateur;
- Monsieur Mohammed Saleh BEHBEHANI, Administrateur, avec adresse professionnelle au PO Box 550, Safat, Koweit,
aux fonctions d'administrateur,
- Maître John Iglehart, Avocat au Barreau de Genève, avec adresse au 16, rue Bellot, 1211 Genève, Suisse
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2008.
L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- MONTBRUN REVISION Sàrl, 11, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2009014661/550/25.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01094. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
GDI Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 110.757.
Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26/01/2009.
Signature.
Référence de publication: 2009014651/1595/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02705. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Naxos Capital Managers S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 102.783.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2008:i>
L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG SA., société anonyme, 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.
15376
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2009014663/550/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01100. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
Menaa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 72.045.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009014537/236/11.
(090013483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
VATit Israel Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 136.746.
L'an deux mille huit, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) VATit Holdings S.à r.l., ayant son siège social à Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite sous le numéro B 136.564,
ici représentée par Monsieur Nicolas KADRI, gérant de société, demeurant professionnellement à Luxembourg, 2,
rue Astrid,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 décembre 2008.
2) Madame Michal KOHEN-HARFENIST, gérante de sociétés, demeurant à 24, Ben Gurion Street, Ramat Gan, 52573
Israël,
ici représentée par Monsieur Nicolas KADRI, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 décembre 2008.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparantes et le
notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elles sont les seules associées de la société VATit Israel Holdings S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée
suivant acte notarié en date du 15 février 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 792 du
2 avril 2008.
- Qu'elles ont pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Les associées décident de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 560A, rue de Neudorf à L-8080
Bertrange, 57, route de Longwy.
En conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Siège social (premier alinéa). Le siège social est établi à Bertrange.»
<i>Version anglaisei>
" Art. 5. Registered office (first paragraph). The registered office of the Company is established in Bertrange."
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ SIX CENTS EUROS (600,- EUR).
Plus rien n'étant fixé à l'ordre du jour, la séance est levée.
15377
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. KADRI, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2008, LAC/2008/51450. - Reçu douze euros (EUR 12,-)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): F. SCHNEIDER.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2009.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2009013532/220/43.
(090013007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.
Logicrane Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 102.916.
L'an deux mille huit, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires (l'"Assemblée") de "LOGICRANE HOLDING
S.A." (la "Société"), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 22 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxem-
bourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 102.916), constituée suivant acte notarié daté du 9 septembre 2004, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1170 du 18 novembre 2004.
La séance est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Michaël Gil, employé privé, avec adresse professionnelle
au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire de l'Assemblée Madame Virginie Gardinetti, employée privée, avec adresse
professionnelle au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe Jasica, employé privé, avec adresse professionnelle au
22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Le Bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
a) Décision de dissoudre la Société et de prononcer sa liquidation.
b) Nomination d'un liquidateur de la Société et détermination des pouvoirs du liquidateur.
c) D'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils
détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et par les membres du Bureau, restera annexée au présent
acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les quinze mille cinq cents (15.500) actions représentant l'intégralité
du capital social souscrit de la Société fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) sont présentes à l'Assemblée
qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.
Après délibération, l'Assemblée générale prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée DÉCIDE de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce
jour.
<i>Seconde résolutioni>
L'Assemblée DÉCIDE de nommer comme seul liquidateur de la Société:
- la société "IAM Trust S.à r.l." une société à responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, établie et ayant
son siège social au 22 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg et étant enregistrée auprès du Registre de Commerce
sous le numéro B 97.032.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée DÉCIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, telles que modifiées;
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée
Générale des Associés dans les cas où elle est requise;
15378
- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société;
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.
Des bénéfices nets de la liquidation, le liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois,
toute distribution en espèces qu'il juge appropriée, eu égard cependant aux dispositions de la loi luxembourgeoise con-
cernant les sociétés commerciales.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la
Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. GIL, V. GARDINETTI, C. JASICA, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 30 décembre 2008. Relation: EAC/ 2008/15971. Reçu douze euros 12,- €.
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Belvaux, le 19 janvier 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009013574/239/65.
(090012449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.
Smart Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 124.816.
L'an deux mille huit, le vingt-troisième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société "Smart Partners S.A." (ci-
après la "Société"), société anonyme, ayant son siège social au 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le "Mémorial") numéro 785 du 4 mai 2007.
L'Assemblée élit comme président Monsieur Joachim Cour, licencié en droit, demeurant au Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Kathrin Kraemer, maître en droit, demeurant au Luxembourg.
L'Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Sébastien Moies, licencié en droit, demeurant au Luxembourg.
Le bureau de l'Assemblée étant dûment constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
Modification de l'article 13, premier alinéa, des statuts afin de fixer la date de l'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires au quatrième vendredi du mois d'avril à 15.00 heures.
II.- Que tous les actionnaires sont représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent chacun est indiqué sur une liste
de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par leur mandataire, les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que l'ensemble des actions actuellement émises par la Société sont représentées
à la présente Assemblée. Tous les actionnaires représentés déclarent avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour
et ont décidé de renoncer aux formalités de convocation. L'Assemblée est dès lors valablement constituée et peut
valablement délibérer et décider sur le point porté à l'ordre du jour.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend, à l'unanimité, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide de fixer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires au quatrième vendredi du mois
d'avril à 15.00 heures. L'article 13, premier alinéa des statuts, ainsi modifié, aura la teneur suivante:
"L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations,
le quatrième vendredi du mois d'avril à 15.00 heures."
Aucun point ne figurant plus à l'ordre du jour, l'Assemblée est dès lors close.
15379
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à l'Assemblée, aux membres du bureau tous connus du notaire par
leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. COUR, K. KRAEMER, S. MOIES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52930 Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009013308/242/43.
(090012987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.
Syntech S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 14.898.
In the year two thousand and eight, on the twelfth day of December.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders and the holders of founder parts (parts de fondateur)
of SYNTECH S.A., a public limited liability company, société anonyme, incorporated under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 14.898 (the "Company"). The Company has been incorporated by deed of
Me Hyacinthe GLAESENER, notary residing in Luxembourg, on April 29, 1977, published in the 'Mémorial C' number 163
on July 29, 1977. The articles of association were subsequently amended several times and for the last time by deed of
Me Léon Thomas METZLER, notary residing in Luxembourg, dated December 2, 1992.
The meeting is presided by Marcus PETER, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Natalie O'SULLIVAN-GALLAGHER, attorney-at-law, professionally residing in Luxem-
bourg.
The meeting elects as scrutineer Nicolas RONZEL, avocat, residing in Luxembourg.
The presidency of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned
notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Approval of interim financial statements of the Company as of 30 November 2008;
2. Transfer of the registered office of the Company from 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg to 22
Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX and consequently, change of the place of incorporation of the Company, with
effect from the date (the "Effective Date") on which a certificate of continuance in respect to the Company is issued by
the Jersey Financial Services Commission in its capacity as the Jersey Companies Registrar in accordance with Article
127O of the Companies (Jersey) Law 1991, as amended, (the "Jersey Law") provided that the Company ceases to be a
Luxembourg company subject to the fulfilment of all applicable provision of the laws of Jersey also as of the Effective Date;
3. Determination of the corporate form of the Company under the Jersey Law and therefore subsequent adoption of
a new memorandum and articles of association of the Company compatible with the Jersey Law (the "New Articles") and
the name under which it is proposed to continue the Company as a body corporate under the Jersey Law with effect
from the Effective Date;
4. Acceptance of the resignation of Pierre LENTZ, John SEIL and Franz J. MENG as current directors of the Company
duly appointed under Luxembourg law. The resignation of the current directors shall take effect from the Effective Date;
5. Granting of a discharge to all three directors of the Company in respect of the performance of their duties until the
Effective Date;
6. Appointment of
a) Charles Stuart HORNBY, born in Liverpool, England, UK on 25
th
May 1953, residing professionally at 22 Grenville
Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Director of Client Services for Mourant Private Wealth;
b) Alan BINNINGTON, born in Jersey, CI on 20
th
January 1958, residing professionally at 22 Grenville Street, St
Helier, Jersey JE4 8PX, Director of Client Services for Mourant Private Wealth;
c) Anthony COOKE-YARBOROUGH, born in Oxford, England, UK on 6
th
August 1956, residing professionally at
22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, CEO of Mourant Private Wealth;
as new directors of the Company to take effect on the Effective Date; and
d) Blair KEMPSTER, born in Jersey, CI on 14
th
January 1967, residing professionally at 22 Grenville Street, St Helier,
Jersey JE4 8PX, Senior Manager at Mourant Private Wealth
15380
as alternate for each director mentioned in a) to c), to take effect on the Effective Date.
7. Acceptance of the resignation of AUDIEX S.A. as statutory auditor of the Company duly appointed under Luxem-
bourg law on the Effective Date and granting of a discharge to AUDIEX S.A. in respect of the performance of its duties
as of the Effective Date;
8. Confirmation by all shareholders of the Company and all holders of founders parts that (i) the New Articles are
consistent with requirements of Jersey, (ii) the Company will, with effect from the Effective Date, cease to be a Luxem-
bourg company and (iii) that the Company will, subject to the applicable provisions of the Jersey Law with effect from
the Effective Date, be subject only to the applicable laws of Jersey and (iv) that neither the transfer of the registered office
of the Company nor the change of its place of incorporation and of its corporate form entails the dissolution and/or
liquidation of the Company and the creation of a new legal entity;
9. Delegation of powers to take any action, including without limitation the execution and delivery of any deed, form,
certificate, agreement or other document and the compliance with all applicable filing and publication formalities under
Luxembourg law and the laws of Jersey in connection with the recording of the transfer of the registered office and the
change of the place of incorporation of the Company; and
10. Approval that the books and documents in relation to the Company shall be transferred to the new registered
office of the Company in Jersey as soon as possible following the Effective Date.
II) The attending shareholders of the Company and holders of founders parts of the Company, the proxies of the
represented shareholders and holders of founders parts, and the number of their shares and founders parts are shown
on an attendance list; this attendance list, signed by the attending shareholders and holders of founders parts and the
officers of this meeting and, the proxies of the represented shareholders and holders of founders parts signed by the
officers of the meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present deed and will be registered with
the deed.
The proxies of the represented shareholders and holders of founders parts after having been signed "ne varietur" by
the proxyholders, the officers of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to these minutes.
III) It appears from the attendance list that all the FOUR THOUSAND (4,000) shares with no par value issued by the
Company, representing the entire issued share capital of the Company of TWENTY-TWO MILLION SWISS FRANCS
(CHF 22,000,0000.-), and all ONE THOUSAND (1,000) founders parts issued by the Company are present or represented
at this meeting.
IV) The meeting is therefore regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the shareholders have
been advised duly in advance.
After deliberation, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders and the holders of founders parts unanimously resolve to approve the interim
financial statements of the Company as of 30 November 2008.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders and the holders of founders parts unanimously resolve to transfer the registered
office of the Company from 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg to 22 Grenville Street, St Helier, Jersey
JE4 8PX and consequently, to change the place of incorporation of the Company with effect from the Effective Date, and
in compliance with articles 2 third paragraph, 67-1 (1) and 159 second paragraph of the Luxembourg law dated August
10, 1915 on commercial companies, as amended, and to file any and all documents required under the Jersey Law to give
full effect to this resolution, including the filing of a certified copy of these resolutions with the Jersey Financial Services
Commission which states the Company's new registered office as being 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX
upon its continuance into Jersey.
In addition the general meeting of shareholders and the holders of founders parts unanimously resolve to change as
of the Effective Date the corporate form of the Company from a Luxembourg public limited liability company into a
private company incorporated in Jersey subject to the legal and regulatory provisions applicable to such corporate form
under the Jersey Law and subsequently to adopt the New Articles so as to make them being in line with the laws of Jersey;
the New Articles are set forth at the end of this deed.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders and the holders of founders parts unanimously resolve to accept the resignation
of the current directors of the Company duly appointed under Luxembourg law, being Pierre LENTZ, John SEIL, and
Franz J. MENG. The resignation of the current directors shall effect from the Effective Date.
In addition the general meeting of shareholders and the holders of founders parts unanimously resolve to discharge
from their liability toward the Company all three directors of the Company in respect of the performance of their duties
until and including the Effective Date.
The general meeting of shareholders and the holders of founders parts unanimously resolve to appoint:
15381
a) Charles Stuart HORNBY, born in Liverpool, England, UK on 25
th
May 1953, residing professionally at 22 Grenville
Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Director of Client Services for Mourant Private Wealth;
b) Alan BINNINGTON, born in Jersey, CI on 20
th
January 1958, residing professionally at 22 Grenville Street, St
Helier, Jersey JE4 8PX, Director of Client Services for Mourant Private Wealth;
c) Anthony COOKE-YARBOROUGH, born in Oxford, England, UK on 6th August 1956, residing professionally at 22
Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, CEO of Mourant Private Wealth;
as new directors of the Company to take effect on the Effective Date; and
d) Blair KEMPSTER, born in Jersey, CI on 14
th
January 1967, residing professionally at 22 Grenville Street, St Helier,
Jersey JE4 8PX, Senior Manager at Mourant Private Wealth
as alternate for each director mentioned in a) to c), to take effect on the Effective Date.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders and the holders of founders parts unanimously resolve to accept the resignation
of AUDIEX S.A. as statutory auditor of the Company duly appointed under Luxembourg law as of the Effective Date.
In addition the general meeting of shareholders and the holders of founders parts unanimously resolve to discharge
AUDIEX S.A. from its liability toward the Company in respect of the performance of its duties until and including the
Effective Date.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders and the holders of founders parts unanimously confirm that (i) the New Articles
are consistent with requirements of the laws of Jersey, (ii) the Company will, with effect from the Effective Date, cease
to be a Luxembourg company, and (iii) that the Company will, subject to the applicable provisions of the Jersey Law as
of the Effective Date, be subject to the applicable laws of Jersey, and (iv) that neither the transfer of the registered office
of the Company nor the change of its place of incorporation and of its corporate form entails the dissolution and/or
liquidation of the Company and the creation of a new legal entity.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting and the holders of beneficiary parts further unanimously resolve to appoint Alex SCHMITT,
Marcus PETER, Natalie O'SULLIVAN-GALLAGHER, Nicolas RONZEL, Franz J. MENG (lawyer residing in Switzerland),
Mathew SHAXSON (lawyer residing in Jersey), and Nicolas LEBLANC (lawyer residing in Jersey), each severally, with
the broadest powers (including the power of substitution) to take any action, including without limitation the execution
and delivery of any deed, form, certificate, agreement or other document and the compliance with all applicable filing and
publication formalities under Luxembourg law and the laws of Jersey and in connection with the recording of the transfer
of the registered office and the change of the place of incorporation of the Company at the Luxembourg Register of
Commerce and Companies and the filing of any and all documents required under the Jersey Law to give full effect to
this resolution, including the filing of a certified copy of these resolutions with the Jersey Financial Services Commission
which states the Company's new registered office as being 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX upon its conti-
nuance into Jersey, which might be necessary or useful for the registered office of the Company to be duly and validly
transferred to Jersey.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting of shareholders and the holders of founders parts unanimously resolve that the books and do-
cuments in relation to the Company shall be transferred to the new registered office of the Company in Jersey as soon
as possible following the Effective Date.
* * *
<i>New articles and Memorandum (for the purposes of the jersey law)i>
I - Memorandum of Association of Syntech Limited
1. The name of the Company is Syntech Limited.
2. The Company is a private company.
3. The Company is a no par value company.
4. The Company is authorised to issue an unlimited number of shares with no par value, designated as Ordinary Shares
and an unlimited number of shares with no par value, designated as Founder Shares.
5. The liability of a member of the Company is limited to the amount unpaid (if any) on such member's share or
shares.Articles of Association
15382
II - Articles of Association of Syntech Limited
1. Definitions and Interpretation.
1.1 In these Articles, unless inconsistent with the subject or context, the following expressions shall have the following
meanings:
"these Articles" means these Articles of Association in their present form or as from time to time altered and "Article"
shall refer to an Article of these Articles.
"auditors" means auditors (if any) of the Company appointed pursuant to these Articles.
"bankrupt" shall have the meaning defined in the Interpretation (Jersey) Law, 1954.
"business day" means a day (other than a Saturday or a Sunday) on which banks are open for normal business in Jersey
[and London].
"class rights" means the special rights of the holders of Ordinary Shares and Founder Shares, as set out in these Articles
and the terms of such shares.
"clear days" in relation to the period of a notice, shall mean that period excluding the day when the notice is served
or deemed to be served and the day for which it is given or on which it is to take effect.
"Directors" means the directors of the Company for the time being.
"Founder Share" means a share in the capital of the Company designated as a Founder Share as set out in the Memo-
randum of Association and having the class rights prescribed in these Articles.
"Jersey" means the Island of Jersey and its dependencies.
"the Law" means the Companies (Jersey) Law 1991, as amended.
"Member" means a person whose name is entered in the Register as the holder of shares in the Company.
"month" means a calendar month.
"notice" means a written notice unless otherwise specifically stated.
"Office" means the registered office of the Company.
"Ordinary Share" means a share in the capital of the Company designated as an Ordinary Share as set out in the
Memorandum of Association and having the class rights prescribed in these Articles.
"paid up" shall include credited as paid up.
"present in person" in relation to general meetings of the Company and to meetings of the holders of any class of
shares, shall include present by attorney or by proxy or, in the case of a corporate shareholder, by representative.
"Register" means the register of Members to be kept pursuant to Article 8.1.
"Secretary" means any person appointed by the Directors to perform any of the duties of secretary of the Company
(including a temporary or assistant secretary), and in the event of two or more persons being appointed as joint secretaries
any one or more of the persons so appointed.
"Sole Directorship Resolution" has the meaning given in Article 20.2.
"Special Resolution" means a resolution of the Company passed as a special resolution in accordance with the Law.
"Written Instruments" means any document or instrument in writing and includes contracts, agreements, deeds,
mortgages, hypothecs, charges, conveyances, transfers, assignments, releases, receipts, discharges, all paper writings, all
cheques, drafts or orders for the payment of money and all notes, acceptances and bills of exchange.
1.2 In these Articles, unless inconsistent with the subject or context:
(a) the word "may" shall be construed as permissive and the word "shall" shall be construed as imperative;
(b) the word "signed" shall be construed as including a signature or representation of a signature affixed by mechanical
or other means;
(c) the words "in writing" shall be construed as including written, printed, telexed, electronically transmitted or any
other mode of representing or reproducing words in a visible form;
(d) words importing "persons" shall be construed as including companies or associations or bodies of persons whether
incorporated or unincorporated; words importing the singular number shall be construed as including the plural number
and vice versa; words importing one gender only shall be construed as including any other gender;
(e) a reference to the Company being a private company or a public company is a reference to such status as determined
for the time being in accordance with the Law;
(f) the word "includes" shall mean "includes without limitation";
(g) where any expression is defined or the interpretation of it is set out herein, other parts of speech of such expression
shall have a corresponding meaning; and
(h) references to enactments are to such enactments as are from time to time modified, re-enacted or consolidated
and shall include any enactment made in substitution for an enactment that is repealed.
1.3 The headings herein are for convenience only and shall not affect the construction of these Articles.
15383
2. Preliminary.
2.1 The preliminary expenses incurred in forming the Company may be discharged out of the funds of the Company.
2.2 The business of the Company shall be commenced as soon after the incorporation of the Company as the Directors
think fit.
3. Share Capital.
3.1 The share capital of the Company is as specified in the Memorandum of Association and the shares of the Company
shall have the rights and be subject to the conditions contained in these Articles.
3.2 Subject to any variation of the rights attaching to any Founder Shares or Ordinary Shares in accordance with these
Articles from time to time at any time, the Ordinary Shares and the Founder Shares shall rank pari passu in all respects
save as set out in Articles 3.3 and 3.4.
3.3 Income Rights: Each issued share in the share capital of the Company shall confer on the holder a right to receive
a distribution in respect of each financial year of the Company out of assets available for distribution in accordance with
the Law in the following order of priority. "Net Profit" for the purposes of this Article 3.3 shall be the positive result in
the balance sheet for the relevant financial period after deduction of expenses and amortisations.
(a) 5% of the Net Profit shall be assigned to a share premium reserve or such other reserve as the directors may
determine PROVIDED THAT and such assignment shall cease to be mandatory upon the reserve reaching an amount
equal to 10% of the issued share capital; and thereafter
(b) the surplus, if any, after the assignment referred to in Article 3.3(a) shall be distributed as follows:
(i) an amount equal to 10% of the paid-up capital shall be distributed to the holders of the Ordinary Shares of the
Company, pro rata to the amount paid-up; and thereafter
(ii) the balance, to which each holder of Ordinary Shares and Founder Shares is entitled to equally, shall be available
for distribution in such manner as may be approved by the Company at general meeting.
(c) Without prejudice to the above, the Directors may resolve to assign all or any amount of the Net Profit, after the
assignment referred to in Article 3.3(a), to any carry-forward account, a provisional fund or an extraordinary reserve,
subject to the rights attached to the shares in the share capital of the Company contained in these Articles.
3.4 Rights to Capital on Winding Up: Upon the realisation of the assets and the settlement of liabilities, the share
capital shall be returned to the shareholders:
(a) first, in respect of each Founder Share in the amount paid-up thereon and, as the case may be, of their privileged,
but not yet paid-out portion of the profits;
(b) secondly, in repaying the amount paid-up on each Ordinary Share to the holders thereof; and
(c) thirdly, if after the refund there should remain any surplus, it shall be distributed pro rata among all of the Ordinary
Shares and all of the Founder Shares to the extent they are paid-up at the commencement of the winding-up of the
Company.
4. Shares.
4.1 Without prejudice to any special rights for the time being conferred on the holders of any class of shares (which
special rights shall not be varied or abrogated except with such consent or sanction as is required by Article 6.1 and
subject to the Law) any share in the Company (including any share created on an increase or other alteration of share
capital) may be issued with such preferred, deferred or other special rights, or such restrictions, whether in regard to
dividends, return of capital, voting or otherwise, as the Company may from time to time, by Special Resolution, determine.
4.2 The unissued shares for the time being in the capital of the Company shall be at the disposal of the Directors, and
they may (subject to the provisions of Article 4.1) allot, grant options over, or otherwise dispose of them to such persons
at such times and on such terms as they think proper.
4.3 The Directors may issue shares in the Company to any person and without any obligation to offer such shares to
the Members (whether in proportion to the existing shares held by them or otherwise).
4.4 The Company may issue fractions of shares in accordance with and subject to the provisions of the Law, provided
that:
(a) a fraction of a share shall be taken into account in determining the entitlement of a Member as regards dividends
or on a winding up; and
(b) a fraction of a share shall not entitle a Member to a vote in respect thereof.
4.5 Subject to the Law, the Company may, by Special Resolution, convert any existing non-redeemable limited shares
(whether issued or not) into, limited shares that are to be redeemed, or are liable to be redeemed in accordance with
their terms, which may include provision for redemption at the option of either or both of the Company or the holder
thereof.
4.6 The Company may pay commissions as permitted by the Law. Subject to the provisions of the Law, any such
commission may be satisfied either by the payment of cash or by the allotment of fully or partly paid shares or partly in
one way and partly in the other.
15384
4.7 Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any share upon any trust, and
the Company shall not be bound by or recognise any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or
(except only as by these Articles otherwise provided or as by law required) any interest in any fraction of a share, or any
other right in respect of any share, except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.
5. Alteration of Share Capital.
5.1 The Company may, by altering its Memorandum of Association by Special Resolution, alter its share capital in any
manner permitted by the Law.
5.2 Any capital raised by the issue of shares shall, unless otherwise provided by the conditions of issue of such shares,
be considered as part of the original capital, and such shares shall be subject to the provisions of these Articles with
reference to the payment of calls, transfer and transmission of shares, lien or otherwise, applicable to the existing shares
in the Company.
5.3 Subject to the provisions of the Law, the Company may, by Special Resolution, reduce its share capital in any way.
6. Variation of Rights.
6.1 Whenever different classes of shares in the capital of the Company are in issue, the special rights attached to any
class, unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class, may be varied or abrogated, either whilst
the Company is a going concern or during or in contemplation of a winding up, with the consent in writing of the holders
of the majority of the issued shares of that class, or with the sanction of a resolution passed at a separate meeting of the
holders of shares of that class, but not otherwise. To every such separate meeting all the provisions of these Articles and
of the Law relating to general meetings of the Company or to the proceedings thereat shall apply, mutatis mutandis,
except that the necessary quorum shall be two persons holding or representing at least one-third of the issued shares of
that class but so that if at any adjourned meeting of such holders a quorum as above defined is not present, those holders
who are present in person shall be a quorum.
6.2 The special rights conferred upon the holders of any class of shares issued with preferred or other special rights
shall be deemed to be varied by the reduction of the capital paid up on such shares and by the creation of further shares
ranking in priority thereto, but shall not (unless otherwise expressly provided by these Articles or by the conditions of
issue of such shares) be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking after or pari passu therewith.
6.3 Unless otherwise expressly provided by the conditions of issue of such shares (including pursuant to Article 6.2),
the class rights:
(a) shall be deemed to be varied by the reduction of the capital paid up on such shares; and
(b) shall not be deemed to be varied by:
(i) the creation or issue of further shares ranking after or pari passu therewith;
(ii) the creation, allotment or issue of any Ordinary Shares;
(iii) the issue of any further Founder Shares;
(iv) the redemption or repurchase of any Founder Shares in accordance with these Articles;
(v) the capitalisation of any undistributed profits of the Company pursuant to 34; or
(vi) the payment of a dividend on any Founder Shares or on Ordinary Shares in accordance with these Articles.
7. Share Certificates.
7.1 Every Member shall be entitled:
(a) without payment, to one certificate for all his shares of each class and, when part only of the shares comprised in
a certificate is sold or transferred, to a new certificate for the remainder of the shares so comprised; or
(b) upon payment of such sum for each certificate as the Directors shall from time to time determine, to several
certificates each for one or more of his shares of any class.
7.2 Every certificate shall be issued within two months after allotment or lodgement of transfer (or within such other
period as the conditions of issue shall provide), shall be issued either under seal or signed by two Directors or by one
Director and the Secretary, and shall specify the shares to which it relates and the amount paid up thereon and, if so
required by the Law, the distinguishing numbers of such shares.
7.3 In respect of a share held jointly by several persons, the Company shall not be bound to issue more than one
certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such
holders.
7.4 If a share certificate is defaced, damaged, lost or destroyed, it may be renewed on payment of such fee and on such
terms (if any) as to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses of the Company in relation thereto
as the Directors think fit.
8. Register of Members.
8.1 The Directors shall keep or cause to be kept at the Office or at such other place in Jersey where it is made up, as
the Directors may from time to time determine, a Register in the manner required by the Law. In each year the Directors
shall prepare or cause to be prepared and filed an annual return containing the particulars required by the Law.
15385
9. Joint Holders.
9.1 Where two or more persons are registered as the holders of any share they shall be deemed to hold the same as
joint tenants with the benefit of survivorship, subject to the following provisions:
(a) the Company shall not be bound to register more than four persons as the joint holders of any share;
(b) the joint holders of any share shall be liable, severally as well as jointly, in respect of all payments to be made in
respect of such share;
(c) any one of such joint holders may give a good receipt for any dividend, bonus or return of capital payable to such
joint holders;
(d) only the senior of the joint holders of a share shall be entitled to delivery of the certificate relating to such share
or to receive notices from the Company and any notice given to the senior joint holder shall be deemed notice to all the
joint holders; and
(e) for the purpose of the provisions of this Article, seniority shall be determined by the order in which the names of
the joint holders appear in the Register.
10. Lien.
10.1 The Company shall have a first and paramount lien on every share (not being a fully paid share) for all monies,
whether presently payable or not, called or payable at a fixed time in respect of such shares; and the Company shall also
have a first and paramount lien on all shares (other than fully paid shares) registered in the name of a single Member for
all the debts and liabilities of such Member or his estate to the Company, whether the same shall have been incurred
before or after notice to the Company of any interest of any person other than such Member and whether the period
for the payment or discharge of the same shall have actually commenced or not, and notwithstanding that the same are
joint debts or liabilities of such Member or his estate and any other person whether a Member or not. The Company's
lien (if any) on a share shall extend to all dividends or other monies payable thereon or in respect thereof. The Directors
may resolve that any share shall, for such period as they think fit, be exempt from the provisions of this Article.
10.2 The Company may sell any shares on which the Company has a lien in such manner as the Directors think fit, but
no sale shall be made unless some monies in respect of which the lien exists are presently payable, and fourteen days
have expired after a notice, stating and demanding payment of the monies presently payable and giving notice of intention
to sell in default, shall have been served on the holder for the time being of the shares or the person entitled by reason
of his death or bankruptcy to the shares.
10.3 The net proceeds of such sale, after payment of the costs of such sale, shall be applied in or towards payment or
satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists, so far as the same is presently payable, and any
residue shall (subject to a like lien for debts or liabilities not presently payable as existed upon the shares prior to the
sale) be paid to the person entitled to the shares at the time of the sale. For giving effect to any such sale the Directors
may authorise a person to execute an instrument of transfer of the shares sold to the purchaser thereof. The purchaser
shall be registered as the holder of the shares so transferred and he shall not be bound to see to the application of the
purchase money nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference
to the sale.
11. Calls on Shares.
11.1 The Directors may, subject to the provisions of these Articles and to any conditions of allotment, from time to
time make calls upon the Members in respect of any monies unpaid on their shares, provided that (except as otherwise
fixed by the conditions of application or allotment) no call on any share shall be payable within fourteen days of the date
appointed for payment of the last preceding call, and each Member shall (subject to being given at least fourteen clear
days' notice specifying the time or times and place of payment) pay to the Company at the time or times and place so
specified the amount called on his shares.
11.2 A call may be made payable by instalments. A call may be postponed or wholly or in part revoked as the Directors
may determine. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorising
the call was passed.
11.3 If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person
from whom the sum is due may be required to pay interest on the sum from the day appointed for payment thereof to
the time of actual payment at a rate determined by the Directors not exceeding the rate of ten per cent per annum.
11.4 Any sum which by or pursuant to the terms of issue of a share becomes payable upon allotment or at any fixed
date shall, for all the purposes of these Articles, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which, by
or pursuant to the terms of issue, the same becomes payable, and in case of non-payment, all the relevant provisions of
these Articles as to payment of interest, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue
of a call duly made and notified.
11.5 The Directors may make arrangements on the issue of shares for a difference between the holders in the amount
of calls to be paid and in the times of payment.
11.6 The Directors may, if they think fit, receive from any Member willing to advance the same, all or any part of the
money uncalled and unpaid upon the shares held by him beyond the sums actually called up thereon as a payment in
15386
advance of calls. Any such payment in advance of calls shall extinguish, so far as the same shall extend, the liability upon
the shares in respect of which it is advanced. The Company may pay interest upon the money so received, or upon so
much thereof as from time to time exceeds the amount of the calls then made upon the shares in respect of which it has
been received, at such rate as the Directors shall think fit provided that any amount paid up in advance of calls shall not
entitle the holder of the shares upon which such amount is paid to participate in respect thereof in any dividend until the
same would but for such advance become presently payable.
12. Forfeiture and Surrender of Shares.
12.1 If a Member fails to pay any call or instalment of a call on or before the day appointed for payment thereof, the
Directors may at any time thereafter, during such time as any part of such call or instalment remains unpaid, serve a
notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may
have accrued and any expenses which may have been incurred by the Company by reason of such non-payment or accept
their surrender instead of causing them to be so forfeited.
12.2 The notice shall name a further day (not earlier than fourteen days from the date of service thereof) on or before
which and the place where the payment required by the notice is to be made, and shall state that in the event of non-
payment at or before the time and at the place appointed, the shares on which the call was made will be liable to be
forfeited.
12.3 If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which such
notice has been given may at any time thereafter, before payment of all calls and interest due in respect thereof have
been made, be forfeited by a resolution of the Directors to that effect, and such forfeiture shall include all dividends which
shall have been declared on the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.
12.4 When any share has been forfeited in accordance with these Articles, notice of the forfeiture shall forthwith be
given to the holder of the share or the person entitled to the share by transmission, as the case may be, and an entry of
such notice having been given, and of the forfeiture with the date thereof, shall forthwith be made in the Register opposite
to the entry of the share; but no forfeiture shall be invalidated in any manner by any omission or neglect to give such
notice or to make such entry as aforesaid.
12.5 A forfeited or surrendered share may be sold, re-allotted or otherwise disposed of, either to the person who
was before forfeiture or surrender the holder thereof or entitled thereto, or to any other person, upon such terms and
in such manner as the Directors think fit, and at any time before a sale, re-allotment or disposition the forfeiture or
surrender may be cancelled on such terms as the Directors think fit. The Directors may, if necessary, authorise some
person to transfer a forfeited or surrendered share to any other person as aforesaid.
12.6 A Member whose shares have been forfeited or surrendered shall cease to be a Member in respect of the forfeited
or surrendered shares but shall, notwithstanding the forfeiture or surrender, remain liable to pay to the Company all
monies which at the date of forfeiture or surrender were presently payable by him to the Company in respect of the
shares, with interest thereon at a rate determined by the Directors not exceeding ten per cent per annum from the date
of forfeiture or surrender as the case may be until payment and the Directors may enforce payment without any allowance
for the value of the shares at the time of forfeiture or surrender.
12.7 An affidavit by a Director or the Secretary that a share has been duly forfeited or surrendered on the date stated
therein shall be conclusive evidence of the facts so stated as against all persons claiming to be entitled to the share and
such affidavit and the receipt of the Company for the consideration (if any) given for the share on the sale, re-allotment
or disposal thereof, together with the certificate for the share delivered to a purchaser or allottee thereof, shall (subject
to the execution of a transfer if the same be so required) constitute good title to the share and the person to whom the
share is sold, re-allotted or disposed of shall be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to
the application of the consideration (if any), nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in
the proceedings in respect of the forfeiture, surrender, sale, re-allotment or disposal of the share.
12.8 The provisions of these Articles as to forfeiture and surrender shall apply in the case of non-payment of any sum
which by the terms of issue of a share becomes payable at a fixed time as if the same had been payable by virtue of a call
duly made and notified.
13. Transfer and Transmission of Shares.
13.1 All transfers of shares shall be effected by notice (a "Transfer Notice") in the usual common form or in any other
form approved by the Directors. All Transfer Notices shall be signed by or on behalf of the transferor and, in the case
of a partly paid share, by the transferee. The transferor shall be deemed to remain the holder of the share until the name
of the transferee is entered on the Register in respect thereof.
13.2 The Directors may in their absolute discretion, and without assigning any reason therefor, refuse to register any
transfer of partly paid shares, including a transfer of such shares to a person of whom they do not approve and may refuse
to register any transfer of shares on which the Company has a lien, but shall not otherwise refuse to register a transfer
of shares made in accordance with these Articles.
13.3 The Directors may decline to recognise any Transfer Notice, unless:
15387
(a) the Transfer Notice is deposited at the Office or such other place as the Directors may appoint accompanied by
the certificate for the shares to which it relates and such other evidence as the Directors may reasonably require to show
the right of the transferor to make the transfer; and
(b) the Transfer Notice is in respect of only one class of shares.
13.4 If the Directors refuse to register any transfer of shares they shall, within two months after the date on which
the Transfer Notice was lodged with the Company, send to the proposed transferor and transferee notice of the refusal.
13.5 All Transfer Notices relating to transfers of shares which are registered shall be retained by the Company, but
any Transfer Notices relating to transfers of shares which the Directors decline to register shall (except in any case of
fraud) be returned to the person depositing the same.
13.6 The registration of transfers of shares or of any class of shares may not be suspended.
13.7 In respect of any allotment of any share the Directors shall have the same right to decline to approve the regis-
tration of any renouncee of any allottee as if the application to allot and the renunciation were a transfer of a share under
these Articles.
13.8 In the case of the death of a Member, the survivors or survivor, where the deceased was a joint holder, and the
executors or administrators of the deceased, where he was a sole or only surviving holder, shall be the only persons
recognised by the Company as having any title to his interest in the shares, but nothing in this Article shall release the
estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share jointly held by him.
13.9 Any guardian of an infant Member and any curator or guardian or other legal representative of a Member under
legal disability and any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency or bankruptcy of
a Member or otherwise by operation of law may, upon such evidence as to his entitlement being produced as may from
time to time be required by the Directors and subject as hereinafter provided, elect either to be registered himself as
the holder of the share or to have some person nominated by him registered as the holder thereof.
13.10 If the person so becoming entitled shall elect to be registered himself, he shall deliver or send to the Company
a notice signed by him stating that he so elects together with such evidence as to his entitlement as may from time to
time be required by the Directors. If he shall elect to have another person registered, he shall testify his election by signing
a Transfer Notice in favour of that person. All the limitations, restrictions and provisions of these Articles relating to the
right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or Transfer Notice as
aforesaid as would have existed had such transfer occurred before the death, insolvency or bankruptcy of the Member
concerned.
13.11 A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency or bankruptcy of a Member or
otherwise by operation of law shall, upon such evidence as to his entitlement being produced as may from time to time
be required by the Directors, be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if
he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a Member in respect of
the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the Company
provided always that the Directors may at any time give notice requiring any such person to elect either to be registered
himself or to transfer the share and if the notice is not complied with within one month such person shall be deemed to
have so elected to be registered himself and all the restrictions on the transfer and transmission of shares contained in
these Articles shall apply to such election.
13.12 Unless otherwise decided by the Directors in their sole discretion, no fee shall be charged in respect of the
registration of any probate, letters of administration, certificate of marriage or death, power of attorney or other docu-
ment relating to or affecting the title to any shares.
14. General Meetings and Class Meetings.
14.1 The provisions of Article 14.2 shall apply with regard to annual general meetings of the Company unless all of the
Members have agreed in writing to dispense with the holding of annual general meetings and any such agreement is and
remains valid in accordance with the Law.
14.2 An annual general meeting shall be held once in every calendar year; but so long as the Company holds its first
annual general meeting within eighteen months of its incorporation it need not hold it in the year of its incorporation or
in the following year. All other general meetings shall be called extraordinary general meetings. Each general meeting shall
be held at such time and such place (either in or outside Jersey) as may be determined by the Directors.
14.3 The Directors may whenever they think fit, and upon a requisition made in writing by Members in accordance
with the Law the Directors shall, convene an extraordinary general meeting of the Company.
14.4 At any extraordinary general meeting called pursuant to a requisition, unless such meeting is called by the Di-
rectors, no business other than that stated in the requisition as the objects of the meeting shall be transacted.
14.5 Save as is provided in this Article and otherwise in these Articles, all the provisions of these Articles and of the
Law relating to general meetings of the Company and to the proceedings thereat shall apply, mutatis mutandis, to every
class meeting. At any class meeting the holders of shares of the relevant class shall, on a poll, have one vote in respect of
each share of that class held by each of them.
15388
15. Notice of General Meetings.
15.1 Subject to any contrary class rights, at least fourteen clear days' notice shall be given of every annual general
meeting and of every general meeting called for the passing of a Special Resolution, and at least fourteen clear days' notice
shall be given of all other general meetings. Every notice shall specify the place, the day and the time of the meeting and
in the case of special business, the general nature of such business and, in the case of an annual general meeting, shall
specify the meeting as such. Notice of every meeting shall be given in the manner hereinafter mentioned to all the Members
and to the Directors and to the auditors.
15.2 A meeting of the Company shall, notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in Article
15.1, be deemed to have been duly called if it is so agreed:
(a) in the case of an annual general meeting, by all the Members entitled to attend and vote thereat; and
(b) in the case of any other meeting, by a majority in number of Members having a right to attend and vote at the
meeting, being a majority together holding not less than ninety-five per cent of the total voting rights of the Members
who have that right.
15.3 In every notice calling a meeting of the Company there shall appear with reasonable prominence a statement that
a Member entitled to attend and vote is entitled to appoint one or more proxies to attend and vote instead of him and
that a proxy need not also be a Member.
15.4 It shall be the duty of the Company, subject to the provisions of the Law, on the calling of a meeting on the
requisition in writing of such number of Members as is specified by the Law:
(a) to give to the Members entitled to receive notice of general meetings and to the Directors notice of any resolution
which may properly be moved and which it is intended to move at that meeting; and
(b) to circulate to Members entitled to have notice of any general meeting sent to them, any statement of not more
than one thousand words with respect to the matter referred to in any proposed resolution or the business to be dealt
with at that meeting.
15.5 The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person
entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.
16. Proceedings at General Meetings.
16.1 The business of an annual general meeting shall be to receive and consider the accounts of the Company and the
reports of the Directors and auditors, to elect Directors (if necessary), to elect auditors and fix their remuneration, to
sanction a dividend if thought fit so to do, and to transact any other business of which notice has been given.
16.2 No business shall be transacted at any general meeting except the adjournment of the meeting unless a quorum
of Members is present at the time when the meeting proceeds to business. Such quorum shall consist of not less than
two Members present in person, but so that not less than two individuals will constitute the quorum provided that, if at
any time all of the issued shares in the Company are held by one Member, such quorum shall consist of the Member
present in person.
16.3 If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, or if during the meeting
a quorum ceases to be present, the meeting, if convened by or upon the requisition of Members, shall be dissolved. If
otherwise convened the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or
such day, time and place as the Directors shall determine.
16.4 The chairman (if any) of the Directors shall preside as chairman at every general meeting of the Company. If there
is no such chairman, or if at any meeting he is not present, the Members present in person shall choose one of the
Directors present to be chairman, or if no Director shall be present and willing to take the chair the Members present
in person shall choose one of their number to be chairman.
16.5 The chairman may with the consent of any meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the
meeting) adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any
adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. When
a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of the original
meeting. Save as aforesaid, it shall not be necessary to give any notice of any adjourned meeting or of the business to be
transacted at an adjourned meeting.
16.6 Minutes of all resolutions and proceedings of general meetings shall be duly and regularly entered in books kept
for that purpose and shall be available for inspection by a Member during business hours without charge. A Member may
require a copy of any such minutes in such manner, and upon payment of such sum, as provided in the Law.
16.7 If a Member is by any means in communication with one or more other Members so that each Member participating
in the communication can hear what is said by any other of them, each Member so participating in the communication is
deemed to be present in person at a meeting with the other Members so participating, notwithstanding that all the
Members so participating are not present together in the same place. A meeting at which any or all of the Members
participate as aforesaid shall be deemed to be a general meeting of the Company for the purposes of these Articles
notwithstanding any other provisions of these Articles and all of the provisions of these Articles and of the Law relating
to general meetings of the Company and to the proceedings thereat shall apply, mutatis mutandis, to every such meeting.
15389
16.8 The Directors and the auditors shall be entitled to receive notice of and to attend and speak at any meeting of
Members.
17. Voting at General Meetings.
17.1 Save where otherwise provided in these Articles, no person shall be entitled to be present or take part in any
proceedings or vote either personally or by proxy at any general meeting unless he has been registered as owner of the
shares in respect of which he claims to vote.
17.2 Save where otherwise provided in the Law or in these Articles, all resolutions shall be adopted if approved by a
majority of the votes cast. In the event of an equality of votes at any general meeting, whether upon a show of hands or
on a poll, the chairman shall not be entitled to a second or casting vote.
17.3 At any general meeting every question shall be decided in the first instance by a show of hands and, unless a poll
is demanded by the chairman or by any Member, a declaration by the chairman that a resolution has on a show of hands
been carried or not carried, or carried or not carried by a particular majority or lost, and an entry to that effect in the
minutes of the meeting shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes
recorded in favour of or against such resolution.
17.4 On a show of hands every Member present in person shall have one vote.
17.5 If a poll is demanded in the manner mentioned above, it shall be taken at such time (within twenty-one days) and
in such manner as the chairman directs and the results of such poll shall be deemed to be the resolution of the Company
in general meeting. A poll may be demanded upon the election of the chairman and upon a question of adjournment and
such poll shall be taken forthwith without adjournment. Any business other than that upon which a poll has been demanded
may proceed pending the taking of the poll.
17.6 Subject to any special voting powers or restrictions for the time being attached to any shares, as may be specified
in the terms of issue thereof or these Articles, on a poll every Member present in person shall have one vote for each
share held by him.
17.7 On a poll a Member entitled to more than one vote need not use all his votes or cast all the votes he uses in the
same way.
17.8 Where there are joint registered holders of any share, such persons shall not have the right of voting individually
in respect of such share but shall elect one of their number to represent them and to vote whether in person or by proxy
in their name. In default of such election the person whose name appears first in order in the Register in respect of such
share shall be the only person entitled to vote in respect thereof.
17.9 A Member for whom a special or general attorney is appointed or who is suffering from some other legal incapacity
or interdiction in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction (whether in Jersey or
elsewhere) in matters concerning legal incapacity or interdiction may vote, whether on a show of hands or on a poll, by
his attorney, curator, or other person authorised in that behalf appointed by that court, and any such attorney, curator
or other person may vote by proxy. Evidence to the satisfaction of the Directors of the authority of such attorney, curator
or other person may be required by the Directors prior to any vote being exercised by such attorney, curator or other
person.
17.10 No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at
which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all
purposes. Any such objection made in due time shall be referred to the chairman of the meeting whose decision shall be
final and conclusive.
17.11 Where a person is authorised under Article 19.8 to represent a body corporate at a general meeting of the
Company the Directors or the chairman of the meeting may require him to produce a certified copy of the resolution
from which he derives his authority.
18. Members' Resolutions in Writing.
18.1 A resolution in writing (including a Special Resolution but excluding a resolution removing an auditor) signed by
all Members who would be entitled to receive notice of and to attend and vote at a general meeting at which such a
resolution would be proposed, or by their duly appointed attorneys, shall be as valid and effectual as if it had been passed
at a general meeting of the Company duly convened and held.
18.2 Any such resolution may consist of several documents in the like form each signed by one or more of the Members
or their attorneys and signature in the case of a corporate body which is a Member shall be sufficient if made by a director
or other duly authorised officer thereof or its duly appointed attorney.
19. Proxies for General Meetings and Corporate Members.
19.1 The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or of his attorney duly
authorised in writing or if the appointor is a corporation either under seal or under the hand of an officer or attorney
duly authorised. A proxy need not be a Member.
19.2 The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed,
or a copy of that power or authority certified as a true copy to the satisfaction of the Secretary, shall be deposited at the
Office within such time (not exceeding forty-eight hours) before the time for holding the meeting or adjourned meeting
15390
or for the taking of a poll at which the person named in the instrument proposes to vote as the Directors may from time
to time determine.
19.3 A Member may, by one or more instruments specifically identifying the number (and, if applicable, the class) of
shares to which it relates and otherwise complying with these Articles, appoint different proxies in respect of different
shares held by such Member and who shall each have the right to attend, speak and vote at the meeting for which he is
appointed. Each such proxy shall take effect in accordance with these Articles only in respect of such specified number
of shares held by such Member.
19.4 The instrument appointing a proxy may be in any common form or in any other form approved by the Directors
including the following form:
"(_Insert name of Company_)
I/We (___) of (___) being a Member/Members of the above named Company hereby appoint (___) of (___) or failing
him (___) of (___) as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the (annual or extraordinary as the case may
be) general meeting of the Company to be held on the (___) day of (___) and at any adjournment thereof.
Signed this (___) day of (___)"
19.5 Unless the contrary is stated thereon the instrument appointing a proxy shall be as valid as well for any adjourn-
ment of the meeting as for the meeting to which it relates.
19.6 A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous
death or insanity of the principal or revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed
provided that no intimation in writing of such death, insanity or revocation shall have been received by the Company at
the Office before the commencement of the meeting or adjourned meeting or the taking of the poll at which the proxy
is used.
19.7 The Directors may at the expense of the Company send by post or otherwise to the Members instruments of
proxy (with or without provision for their return prepaid) for use at any general meeting or at any separate meeting of
the holders of any class of shares of the Company either in blank or nominating in the alternative any one or more of
the Directors or any other persons. If for the purpose of any meeting invitations to appoint as proxy a person or one or
more of a number of persons specified in the invitations are issued at the Company's expense they shall be issued to all
(and not to some only) of the Members entitled to be sent a notice of the meeting and to vote thereat by proxy.
19.8 Any body corporate which is a Member may by resolution of its directors or other governing body authorise
such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of Members (or of any class of Members) and the
person so authorised shall be entitled to exercise on behalf of the body corporate which he represents the same powers
as that body corporate could exercise if it were an individual. The body corporate may, by one or more of such resolutions,
specifically identifying the number (and, if applicable, the class) of shares to which it relates, appoint different persons in
respect of different shares held by such body corporate. Each such resolution shall take effect in accordance with this
Article only in respect of such specified number of shares held by such body corporate.
20. Directors.
20.1 The Company may by ordinary resolution determine the maximum and minimum number of Directors and unless
and until otherwise so determined or (save where the Law otherwise provides) where only one Director is appointed
by the Subscribers to the Memorandum of Association or by the majority of them pursuant to Article 23.1, the minimum
number of Directors shall be two. The Company shall keep or cause to be kept at the Office a register of its Directors
in the manner required by the Law.
20.2 Save where the Law otherwise provides, the Company may determine by ordinary resolution that there shall be
only one Director. Such resolution (a "Sole Directorship Resolution") shall cease to have effect upon the Company ceasing
to be permitted by the Law to have only one Director and shall not revive if the Company again becomes permitted by
the Law to do so.
20.3 A Director need not be a Member but shall nevertheless be entitled to receive notice of and to attend and speak
at any general meeting or at any separate meeting of the holders of any class of shares in the Company.
20.4 The Directors shall be paid out of the funds of the Company their travelling and other expenses properly and
necessarily expended by them in attending meetings of the Directors or Members or otherwise on the affairs of the
Company. They shall also be paid by way of remuneration for their services as Directors such sum as shall be fixed by
resolution of the Company, which shall be divided between them as they shall agree or, failing agreement, equally and
shall be deemed to accrue from day to day. If any Director shall be appointed agent or to perform extra services or to
make any special exertions or to go or reside abroad for any of the purposes of the Company, the Directors may
remunerate such Director therefor either by a fixed sum or by commission or participation in profits or otherwise or
partly one way and partly in another as they think fit, and such remuneration may be either in addition to or in substitution
for his remuneration hereinbefore provided.
21. Alternate Directors.
21.1 Any Director may at his sole discretion and at any time and from time to time appoint any person (other than a
person disqualified by law from being a director of a company) as an alternate Director to attend and vote in his place at
15391
any meetings of Directors at which he is not personally present. Each Director shall be at liberty to appoint under this
Article more than one alternate Director provided that only one such alternate Director may at any one time act on
behalf of the Director by whom he has been appointed. Every such appointment shall be effective and the following
provisions shall apply in connection therewith:
(a) every alternate Director while he holds office as such shall be entitled to notice of meetings of Directors and to
attend and to exercise all the rights and privileges of his appointor at all such meetings at which his appointor is not
personally present;
(b) every alternate Director shall ipso facto vacate office if and when his appointment expires or the Director who
appointed him ceases to be a Director of the Company or removes the alternate Director from office by notice under
his hand served upon the Company;
(c) every alternate Director shall be entitled to be paid all travelling, hotel and other expenses reasonably incurred by
him in attending meetings. The remuneration (if any) of an alternate Director shall be payable out of the remuneration
payable to the Director appointing him as may be agreed between them;
(d) a Director may act as alternate Director for another Director and shall be entitled to vote for such other Director
as well as on his own account, but no Director shall at any meeting be entitled to act as alternate Director for more than
one other Director; and
(e) a Director who is also appointed an alternate Director shall be considered as two Directors for the purpose of
making a quorum of Directors when such quorum shall exceed two.
21.2 If a Director who has appointed an alternate Director is for the time being temporarily unable to act through ill
health or disability the signature of the alternate Director to any resolution in writing made by the Directors shall be as
effective as the signature of his appointer.
21.3 The instrument appointing an alternate Director may be in any form approved by the Directors including the
following form:
"(_Insert name of Company_)
I, (___) a Director of the above named Company, in pursuance of the power in that behalf contained in the Articles
of Association of the Company, do hereby nominate and appoint (___) of (___) to act as alternate Director in my place
at the meeting of the Directors to be held on the (___) day of (___) and at any adjournment thereof which I am unable
to attend and to exercise all my duties as a Director of the Company at such meeting.
Signed this (___) day of (___)"
21.4 Save as otherwise provided in Article 21.1(b), any appointment or removal of an alternate Director shall be by
notice signed by the Director making or revoking the appointment and shall take effect when lodged at the Office or
otherwise notified to the Company in such manner as is approved by the Directors.
22. Executive Directors.
22.1 The Directors may from time to time appoint one or more of their number to be the holder of any executive
office on such terms and for such periods as they may determine. The appointment of any Director to any executive
office shall be subject to termination if he ceases to be a Director, but without prejudice to any claim for damages for
breach of any contract of service between him and the Company.
22.2 The Directors may entrust to and confer upon a Director holding any executive office any of the powers exer-
cisable by the Directors, upon such terms and conditions and with such restrictions as they think fit, and either collaterally
with or to the exclusion of their own powers and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of
such powers.
23. Appointment of Directors.
23.1 The first Directors shall be appointed in writing by the Subscribers to the Memorandum of Association or by the
majority of them.
23.2 Subject to the provisions of Article 20.1, the Directors shall have power at any time and from time to time to
appoint any person to be a Director, either to fill a casual vacancy or as an addition to the existing Directors.
23.3 At any general meeting at which a Director retires or is removed from office the Company may elect a Director
to fill the vacancy, unless the Company determines to reduce the number of Directors in office.
23.4 If the Company in general meeting determines to increase the number of Directors in office the Company shall
elect additional Directors.
23.5 Seven clear days' notice shall be given to the Company of the intention of any Member to propose any person
for election to the office of Director provided always that, if the Members present in person at a general meeting una-
nimously consent, the chairman of such meeting may waive the said notice and submit to the meeting the name of any
person duly qualified and willing to act.
24. Resignation, Disqualification and Removal of Directors.
24.1 The office of a Director shall be vacated if:
(a) he resigns his office by notice to the Company; or
15392
(b) he ceases to be a Director by virtue of any provision of the Law or becomes prohibited or disqualified by law from
being a Director; or
(c) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
(d) he is removed from office by resolution of the Members.
24.2 Unless specified otherwise in the instrument or resolution of appointment, a Director shall hold office until he
resigns or is disqualified in accordance with Article 24.1.
25. Powers of Directors.
25.1 The business of the Company shall be managed by the Directors who may exercise all such powers of the Company
as are not by the Law or these Articles required to be exercised by the Company in general meeting, and the power and
authority to represent the Company in all transactions relating to real and personal property and all other legal or judicial
transactions, acts and matters and before all courts of law shall be vested in the Directors. At any time that a Sole
Directorship Resolution is in effect, the business of the Company shall be managed by the sole Director. The Directors'
powers shall be subject to these Articles, the Law and to such regulations, being not inconsistent with these Articles or
the Law, as may be prescribed by the Company in general meeting, but no regulations made by the Company in general
meeting shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if such regulations had not been made.
25.2 The Directors may, by power of attorney, mandate or otherwise, appoint any person to be the agent of the
Company for such purposes and on such conditions as they determine, including authority for the agent to delegate all
or any of his powers.
26. Transactions with Directors.
26.1 A Director, including an alternate Director, may hold any other office or place of profit under the Company
(other than the office of auditor) in conjunction with his office of Director and may act in a professional capacity to the
Company on such terms as to tenure of office, remuneration and otherwise as the Directors may determine.
26.2 Subject to the provisions of the Law, and provided that he has disclosed to the Directors the nature and extent
of any of his interests which conflict or may conflict to a material extent with the interests of the Company at the first
meeting of the Directors at which a transaction is considered or as soon as practical after that meeting by notice in writing
to the Secretary or has otherwise previously disclosed that he is to be regarded as interested in a transaction with a
specific person, a Director notwithstanding his office:
(a) may be a party to, or otherwise interested in, any transaction or arrangement with the Company or in which the
Company is otherwise interested;
(b) may be a director or other officer of, or employed by, or a party to any transaction or arrangement with, or
otherwise interested in, any body corporate promoted by the Company or in which the Company is otherwise interested;
and
(c) shall not, by reason of his office, be accountable to the Company for any benefit which he derives from any such
office or employment or from any such transaction or arrangement or from any interest in any such body corporate and
no such transaction or arrangement shall be liable to be avoided on the ground of any such interest or benefit.
26.3 For the purposes of Article 26.2:
(a) a general notice given to the Directors or Secretary in the manner there specified that a Director is to be regarded
as having an interest of the nature and extent specified in the notice in any transaction or arrangement in which a specified
person or class of persons is interested shall be deemed to be a disclosure that the Director has an interest in any such
transaction of the nature and extent so specified; and
(b) an interest of which a Director has no knowledge and of which it is unreasonable to expect him to have knowledge
shall not be treated as an interest of that Director.
26.4 Where disclosure of an interest is made to the Secretary in accordance with Article 26.2 the Secretary shall
inform the Directors that it has been made and table the notice of the disclosure at the next meeting of the Directors.
Any disclosure at a meeting of the Directors shall be recorded in the minutes of the meeting.
27. Proceedings of Directors.
27.1 The Directors may meet together for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings
as they think fit. Questions arising at any meeting shall be determined by a majority of votes. In case of an equality of
votes the chairman shall have a second or casting vote. A Director who is also an alternate Director shall be entitled, in
the absence of the Director whom he is representing, to a separate vote on behalf of such Director in addition to his
own vote. A Director may, and the Secretary on the requisition of a Director shall, at any time, summon a meeting of
the Directors by giving to each Director and alternate Director not less than twenty-four hours' notice of the meeting
provided that any meeting may be convened at shorter notice and in such manner as each Director or his alternate
Director shall approve provided further that unless otherwise resolved by the Directors notices of Directors' meetings
need not be in writing.
27.2 A meeting of the Directors at which a quorum is present shall be competent to exercise all powers and discretions
for the time being exercisable by the Directors. The quorum necessary for the transaction of the business of the Directors
may be fixed by the Directors, and unless so fixed at any other number shall be two. At any time that a Sole Directorship
15393
Resolution is in effect, such quorum shall be one. For the purposes of this Article and subject to the provisions of Article
21.1(d), an alternate Director shall be counted in a quorum, but so that not less than two individuals will constitute the
quorum.
27.3 A Director, notwithstanding his interest, may be counted in the quorum present at any meeting at which he is
appointed to hold any office or place of profit under the Company, or at which the terms of his appointment are arranged,
but he may not vote on his own appointment or the terms thereof.
27.4 A Director, notwithstanding his interest, may be counted in the quorum present at any meeting at which any
contract or arrangement in which he is interested is considered and, subject to the provisions of Article 26.2, he may
vote in respect of any such contract or arrangement.
27.5 The continuing Directors or a sole continuing Director may act notwithstanding any vacancies in their number,
but, if the number of Directors is less than the number fixed as the quorum, the continuing Directors or Director may
act only for the purpose of filling vacancies or of calling a general meeting of the Company. This Article shall not apply at
any time that a Sole Directorship Resolution is in effect.
27.6 If there are no Directors or no Director is able or willing to act, then any Member or the Secretary may summon
a general meeting for the purpose of appointing Directors.
27.7 The Directors may from time to time elect from their number, and remove, a chairman and/or deputy chairman
and/or vice-chairman and determine the period for which they are to hold office. The chairman, or in his absence the
deputy chairman, or in his absence, the vice-chairman, shall preside at all meetings of the Directors, but if no such chairman,
deputy chairman or vice-chairman be elected, or if at any meeting the chairman, the deputy chairman and vice-chairman
be not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present may choose one
of their number to be the chairman of the meeting.
27.8 The Directors may delegate any of their powers to committees consisting of such Directors or Director or such
other persons as they think fit. Any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to
any regulations that may be imposed on it by the Directors. The meetings and proceedings of any such committee
consisting of two or more persons shall be governed by the provisions of these Articles regulating the meetings and
proceedings of the Directors, so far as the same are applicable and are not superseded by any regulations made by the
Directors under this Article.
27.9 If a Director is by any means in communication with one or more other Directors so that each Director parti-
cipating in the communication can hear what is said by any other of them, each Director so participating in the
communication is deemed to be present at a meeting with the other Directors so participating, notwithstanding that all
the Directors so participating are not present together in the same place. The place of any such meeting shall be recorded
as the place at which the chairman is present, unless the Directors otherwise determine.
27.10 All acts done bona fide by any meeting of Directors or of a committee appointed by the Directors or by any
person acting as a Director shall, notwithstanding that it is afterwards discovered that there was some defect in the
appointment of any such Director or committee or person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified
or had vacated office or were not entitled to vote, be as valid as if every such person had been duly appointed and was
qualified and had continued to be a Director or a member of a committee appointed by the Directors and had been
entitled to vote.
28. Directors' Resolutions in Writing.
28.1 A resolution in writing of which notice has been given to all of the Directors or to all of the members of a
committee appointed pursuant to Article 27.8 (as the case may be), if signed by a majority of the Directors or of the
members of such committee (as the case may be), shall be valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the
Directors or of the relevant committee duly convened and held and may consist of two or more documents in like form
each signed by one or more of the Directors or members of the relevant committee.
29. Minute Book.
29.1 The Directors shall cause all resolutions in writing passed in accordance with Articles 18.1 and 28.1 and minutes
of proceedings at all general meetings of the Company or of the holders of any class of the Company's shares and of the
Directors and of committees appointed by the Directors to be entered in books kept for the purpose. Any minutes of
a meeting, if purporting to be signed by the chairman of the meeting or by the chairman of the next succeeding meeting,
shall be evidence of the proceedings.
30. Secretary.
30.1 The Secretary shall be appointed by the Directors and any secretary so appointed may be removed by the
Directors. Anything required or authorised to be done by or to the Secretary may, if the office is vacant or there is for
any other reason no secretary capable of acting, be done by or to any assistant or deputy secretary or if there is no
assistant or deputy secretary capable of acting, by or to any officer of the Company authorised generally or specially in
that behalf by the Directors provided that any provisions of these Articles requiring or authorising a thing to be done by
or to a Director and the Secretary shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as Director
15394
and as, or in place of, the Secretary. The Company shall keep or cause to be kept at the Office a register of particulars
with regard to its Secretary in the manner required by the Law.
31. Execution of Instruments, Seals and Authentication of Documents.
31.1 The Company may have a common seal and may, in accordance with the Law, have an official seal for use outside
of Jersey and an official seal for sealing securities issued by the Company or for sealing documents creating or evidencing
securities so issued. The Directors shall provide for the safe custody of all seals. No seal of the Company shall be used
except by the authority of a resolution of the Directors or of a committee of the Directors authorised in that behalf by
the Directors.
31.2 The Directors may, by resolution, authorise a person or persons to witness the affixing of the Company's common
seal to any Written Instrument to which the Company is a party. In the absence of an express authorisation, either
generally or with respect to a specific Written Instrument, any two Directors or a Director and the Secretary, are
authorised to witness the affixing of the Company's common seal to any Written Instrument to which the affixing of the
common seal has been approved by the Directors.
31.3 Written Instruments to which the Company's common seal is not to be affixed may be signed on behalf of the
Company by such person or persons as the Directors may from time to time by resolution authorise. In the absence of
an express authorisation, either generally or with respect to a specific Written Instrument, any one Director is authorised
to sign any Written Instrument on behalf of the Company.
31.4 Any Director or the Secretary or any person appointed by the Directors for the purpose shall have power to
authenticate any documents affecting the constitution of the Company (including the Memorandum of Association and
these Articles) and any resolutions passed by the Company or the Directors and any books, records, documents and
accounts relating to the business of the Company, and to certify copies thereof or extracts therefrom as true copies or
extracts; and where books, records, documents or accounts are elsewhere than at the Office, the local manager or other
officer of the company having the custody thereof shall be deemed to be a person appointed by the Directors as aforesaid.
32. Dividends.
32.1 Subject to the provisions of the Law and these Articles, the Company may by resolution declare dividends in
accordance with the respective rights of the Members, but no dividend shall exceed the amount recommended by the
Directors.
32.2 Subject to any particular rights or limitations as to dividend for the time being attached to any shares, as may be
specified in these Articles or upon which such shares may be issued, all dividends shall be declared, apportioned and paid
pro-rata according to the amounts paid up on the shares (otherwise than in advance of calls) during any portion or
portions of the period in respect of which the dividend is paid.
32.3 Subject to the provisions of the Law, the Directors may, if they think fit, from time to time pay to the Members
such interim dividends as appear to the Directors to be justified.
32.4 If at any time the share capital of the Company is divided into different classes, the Directors may pay interim
dividends in respect of those shares in the capital of the Company which confer on the holders thereof deferred or non-
preferred rights, as well as in respect of those shares which confer on the holders thereof preferential rights with regard
to dividend. The Directors may also pay half-yearly, or at other suitable intervals to be settled by them, any dividend
which may be payable at a fixed rate if they are of the opinion that the financial resources of the Company justify the
payment. Provided the Directors act bona fide they shall not incur any personal liability to the holders of shares conferring
a preference for any damage that they may suffer by reason of the payment of an interim dividend on any shares having
deferred or non-preferred rights.
32.5 The Directors may deduct from any dividend or other monies payable to any Member on or in respect of a share
all sums of money (if any) presently payable by him to the Company on account of calls or otherwise in relation to the
shares of the Company.
32.6 All unclaimed dividends may be invested or otherwise made use of by the Directors for the benefit of the Company
until claimed. No dividend shall bear interest as against the Company.
32.7 Any dividend which has remained unclaimed for a period of ten years from the date of declaration thereof shall,
if the Directors so resolve, be forfeited and cease to remain owing by the Company and shall thenceforth belong to the
Company absolutely.
32.8 Any dividend or other monies payable on or in respect of a share may be paid by cheque or warrant sent through
the post to the registered address of the Member or person entitled thereto, and in the case of joint holders to any one
of such joint holders, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. Every
such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent or to such other person as
the holder or joint holders may in writing direct, and payment of the cheque or warrant shall be a good discharge to the
Company. Every such cheque or warrant shall be sent at the risk of the person entitled to the money represented thereby.
32.9 A general meeting declaring a dividend may, upon the recommendation of the Directors, direct payment of such
dividend wholly or in part by the distribution of specific assets, and in particular of paid up shares or debentures of any
other company, and the Directors shall give effect to such resolution; and where any difficulty arises in regard to the
distribution they may settle the same as they think expedient, and in particular may issue certificates representing part
15395
of a shareholding or fractions of shares, and may fix the value for distribution of such specific assets or any part thereof,
and may determine that cash payment shall be made to any Members upon the footing of the value so fixed, in order to
adjust the rights of Members, and may vest any specific assets in trustees upon trust for the persons entitled to the
dividend as may seem expedient to the Directors, and generally may make such arrangements for the allotment, accep-
tance and sale of such specific assets or certificates representing part of a shareholding or fractions of shares, or any part
thereof, and otherwise as they think fit.
32.10 Any resolution declaring a dividend on the shares of any class, whether a resolution of the Company in general
meeting or a resolution of the Directors, or any resolution of the Directors for the payment of a fixed dividend on a date
prescribed for the payment thereof, may specify that the same shall be payable to the persons registered as the holders
of shares of the class concerned at the close of business on a particular date, notwithstanding that it may be a date prior
to that on which the resolution is passed (or, as the case may be, that prescribed for payment of a fixed dividend), and
thereupon the dividend shall be payable to them in accordance with their respective holdings so registered, but without
prejudice to the rights inter se in respect of such dividend of transferors and transferees of any shares of the relevant
class.
33. Reserve Fund.
33.1 Before the declaration of a dividend the Directors may set aside any part of the net profits of the Company to
create a reserve fund, and may apply the same either by employing it in the business of the Company or by investing it
in such a manner (not being the purchase of or by way of loan upon the shares of the Company) as they think fit. Such
reserve fund may be applied for the purpose of maintaining the property of the Company, replacing wasting assets, meeting
contingencies, forming an insurance fund, or equalising dividends or special dividends, or for any other purpose for which
the net profits of the Company may lawfully be used, and until the same shall be applied it shall remain undivided profits.
The Directors may also carry forward to the accounts of the succeeding year or years any balance of profit which they
do not think fit either to divide or to place to reserve.
34. Capitalisation.
34.1 Subject to Article 3, the Company may by Special Resolution, upon the recommendation of the Directors, resolve
that it is desirable to capitalise an amount to the Members, by means of a transfer to the stated capital account maintained
in accordance with the Law for any class of issued shares of the Company of the amount resolved to be capitalised from
a profit and loss account or from any capital or revenue reserve, and accordingly that the Directors be authorised and
directed to appropriate the amount resolved to be capitalised to the Members in the proportion in which such amount
would have been divisible amongst them had the same been applicable and had been applied in paying dividends, and to
apply such amount on their behalf, either in or towards paying up the amounts, if any, for the time being unpaid on any
shares held by such Members respectively, or in paying up in full any unissued shares or debentures of the Company, such
shares or debentures to be allotted and distributed, credited as fully paid up, to and amongst such Members in the
proportions aforesaid, or partly in one way and partly in the other provided that any unrealised profits may not be applied
in the paying up of any debentures of the Company.
34.2 Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Directors shall make all appropriations and
applications of the amount resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares or deben-
tures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effect thereto, with full power to the Directors to
make such provision by the issue of certificates representing part of a shareholding or fractions of shares or by payments
in cash or otherwise as they think fit in the case of shares or debentures becoming distributable in fractions, and also to
authorise any person to enter on behalf of all the Members entitled to the benefit of such appropriations and applications
into an agreement with the Company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid up, of any
further shares or debentures to which they may be entitled upon such capitalisation, and any agreement made under such
authority shall be effective and binding on all such Members.
35. Accounts and Audit.
35.1 The Company shall keep accounting records and the Directors shall prepare accounts of the Company, made up
to such date in each year as the Directors shall from time to time determine, in accordance with and subject to the
provisions of the Law.
35.2 No Member shall have any right to inspect any accounting records or other book or document of the Company
except as conferred by the Law or authorised by the Directors or by resolution of the Company.
35.3 Where required by the Law or determined to be necessary or appropriate for any other reason, auditors shall
be appointed for any period or periods either by the Directors or the Company by resolution in general meeting, to
examine the accounts of the Company and to report thereon in accordance with the Law.
36. Notices.
36.1 Any notice to be given to or by any person pursuant to these Articles shall be in writing, save as provided in
Article 27.1. In the case of joint holders of a share, all notices shall be given to that one of the joint holders whose name
stands first in the Register in respect of the joint holding and notice so given shall be sufficient notice to all the joint
holders.
15396
36.2 Any notice may be posted to or left at the registered address of any person, and any notice so posted shall be
deemed to be served one clear day after the day it was posted.
36.3 Any Member present in person at any meeting of the Company shall, for all purposes, be deemed to have received
due notice of such meeting and, where requisite, of the purposes for which such meeting was convened.
36.4 Any notice or document served on a Member shall, notwithstanding that such Member be then dead or bankrupt
and whether or not the Company has notice of his death or bankruptcy, be deemed to have been duly served on such
Member as sole or joint holder, unless his name shall at the time of the service of the notice or document have been
removed from the Register, and such service shall for all purposes be deemed a sufficient service of such notice or
document on all persons interested (whether jointly with or as claiming through or under him) in the shares of such
Member.
36.5 Notwithstanding any of the provisions of these Articles, any notice to be given by the Company to a Director or
to a Member may be given in any manner agreed in advance by any such Director or Member.
37. Winding Up.
37.1 Subject to any particular rights or limitations for the time being attached to any shares, as may be specified in
these Articles or upon which such shares may be issued, if the Company is wound up, the assets available for distribution
among the Members shall be applied first in repaying to the Members the amount paid up on their shares respectively,
and if such assets shall be more than sufficient to repay to the Members the whole amount paid up on their shares, the
balance shall be distributed among the Members in proportion to the amount which at the time of the commencement
of the winding up had been actually paid up on their said shares respectively.
37.2 If the Company is wound up, the Company may, with the sanction of a Special Resolution and any other sanction
required by the Law, divide the whole or any part of the assets of the Company among the Members in specie and the
liquidator or, where there is no liquidator, the Directors, may, for that purpose, value any assets and determine how the
division shall be carried out as between the Members or different classes of Members, and with the like sanction, vest
the whole or any part of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the Members as he with the like sanction
determines, but no Member shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.
38. Indemnity.
38.1 In so far as the Law allows, every present or former officer of the Company shall be indemnified out of the assets
of the Company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been such an officer.
39. Non-Application of Standard Table.
39.1 The regulations constituting the Standard Table in the Companies (Standard Table) (Jersey) Order 1992 shall not
apply to the Company.
* * *
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned by the Chairman.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at EUR 3,500.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,
surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille huit, le douzième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Henri HELLINCKX notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et des porteurs de parts de fondateurs de SYN-
TECH S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 14.898 (la
"Société"). La Société a été constituée suivant acte reçu par Me Hyacinthe GLAESENER, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 29 avril 1977 et publié au Mémorial C numéro 163 le 29 juillet 1977. Les statuts ont été modifiés à
plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Me Léon METZLER, notaire résidant à Luxembourg, en date du 2
décembre 2000.
L'assemblée est présidée par Marcus PETER, Rechtsanwalt, demeurant professionnellement à Luxembourg,
15397
qui désigne comme secrétaire, Natalie O'SULLIVAN-GALLAGHER, attorney-at-law, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur, Nicolas RONZEL, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis du notaire soussigné d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1. Approbation des comptes intérimaires de la Société au 30 novembre 2008.
2. Transfert du siège social de la Société de 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg à 22 Greenville Street,
St Helier, Jersey JE4 8PX, et en conséquence, modification du lieu d'enregistrement de la Société, avec effet à compter
de la date (la "Date d'Effet") à partir de laquelle un certificat de continuation concernant la Société est émis par la Jersey
Financial Services Commission en qualité de détenteur du registre des sociétés de Jersey conformément à l'article 127O
de la loi de Jersey sur les sociétés de 1991, telle que modifiée (la "Loi de Jersey") à la condition que la Société cesse d'être
une société luxembourgeoise, sous réserve de la réalisation de toutes les dispositions applicables de droit de Jersey à la
Date d'Effet,
3. Détermination de la forme sociale de la Société selon le droit de Jersey et approbation consécutive de nouveaux
statuts de la Société compatibles avec le droit de Jersey (les "Nouveaux Statuts"), ainsi que de la dénomination sous
laquelle il est proposé que la Société continue d'exister comme société sous la loi de Jersey à compter de la Date d'Effet,
4. Acceptation de la démission de Pierre LENTZ, John SEIL et Franz J. MENG en tant qu'administrateurs actuels de la
Société, dûment nommés en vertu de la loi luxembourgeoise. La démission des administrateurs actuels prendra effet à
compter de la Date d'Effet,
5. Décharge des administrateurs actuels en relation avec l'exécution de leurs fonctions jusqu'à la Date d'Effet,
6. Désignation de
a) Charles Stuart HORNBY, né à Liverpool, Angleterre, GB le 25 mai 1953, résidant professionnellement à 22 Grenville
Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, directeur du serveur client de Mourant Private Wealth,
b) Alan BINNINGTON, né à Jersey, CI le 20 janvier 1958, résidant professionnellement à 22 Grenville Street, St Helier,
Jersey JE4 8PX, directeur du serveur client de Mourant Private Wealth,
c) Anthony COOKE-YARBOROUGH, né à Oxford, Angleterre, GB le 6 août 1956, résidant professionnellement 22
Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, président de Mourant Private Wealth;
comme nouveaux administrateurs de la Société à partir de la Date d'Effet; et
d) Blair KEMPSTER, né à Jersey, CI le 14 janvier 1967, résidant professionnellement 22 Grenville Street, St Helier,
Jersey JE4 8PX, gérant senior à Mourant Private Wealth
comme suppléant des administrateurs indiqués sous a) à c) à partir de la Date d'Effet.
7. Acceptation de la démission de AUDIEX S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société dûment nommé
en vertu de la loi luxembourgeoise à partir de la Date d'Effet et décharge de AUDIEX S.A. de sa responsabilité pour
l'exécution de ses fonctions jusqu'à la Date d'Effet,
8. Confirmation par tous les actionnaires de la Société que (i) les Nouveaux Statuts sont conformes aux prescriptions
du droit de Jersey, (ii) à partir de la Date d'Effet, la Société cessera d'être une société de droit luxembourgeois et, (iii)
sous réserve des dispositions du droit de Jersey, à partir de la Date d'Effet, la Société sera exclusivement soumise aux
lois de Jersey applicables et (iv) ni le transfert du siège social de la Société, ni le changement de son lieu d'enregistrement,
ni le changement de sa forme sociale n'ont pour effet la dissolution et/ou le liquidation de la Société et la création d'une
nouvelle entité juridique.
9. Délégation de pouvoirs pour réaliser toute action, en ce compris notamment, la signature et la délivrance de tout
acte, formulaire, certificat, contrat ou autre document et l'observation de toutes formalités de dépôt et de publicité
requises d'après le droit luxembourgeois et le droit de Jersey pour l'enregistrement du transfert du siège social et le
transfert du lieu d'enregistrement de la Société, et
10. Approbation du transfert des livres et des documents liés à la Société au nouveau siège social de la Société aussitôt
que possible après la Date d'Effet.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires et les porteurs de parts de fondateurs de la Société
présents, les procurations des actionnaires et porteurs de parts de fondateur représentés, ainsi que le nombre d'actions
et de parts de fondateur qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires et porteurs
de parts de fondateur présents ou leurs mandataires, par les membres du bureau et par le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent acte et sera enregistrée avec lui.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires et porteurs de parts de fondateur
représentés après avoir été signées "ne varietur" par les mandataires, les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Il résulte de la liste de présence que l'intégralité des QUATRE MILLE (4.000) actions sans valeur nominale, repré-
sentant l'intégralité du capital social émis de la Société qui s'élève à VINGT-DEUX MILLIONS de FRANCS SUISSES (CHF
22.000.000,-), et l'intégralité des MILLE (1.000,-) parts de fondateurs émises par la Société sont présents ou représentées
à la présente assemblée.
15398
IV) Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer de l'ordre du jour, dont les
actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité par l'assemblée:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires et des porteurs de parts de fondateur résout à l'unanimité d'approuver les
comptes intérimaires de la Société au 30 novembre 2008.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires et des porteurs de parts de fondateur résout à l'unanimité de transférer le siège
social de la Société de 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg à 22 Greenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX,
et en conséquence, de modifier le lieu d'enregistrement de la Société, avec effet à compter de la Date d'Effet, et confor-
mément au troisième alinéa de l'article 2, l'article 67-1 (1) et le deuxième alinéa de l'article 159 de la loi luxembourgeoise
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et de déposer tous les documents requis d'après le
droit de Jersey afin de donner plein effet à ces résolutions, y compris le dépôt d'une copie certifiée de ces résolutions à
la Jersey Financial Services Commission qui confirme qu'à partir de sa continuation à Jersey, le nouveau siège social de la
Société est situé à 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE 8PX.
De plus, l'assemblée générale des actionnaires et des porteurs de parts de fondateur résout à l'unanimité de changer
à compter de la Date d'Effet la forme sociale de la Société de société anonyme de droit luxembourgeois, à private company
enregistrée à Jersey et soumise aux dispositions légales et réglementaires applicables à cette forme de société d'après la
Loi de Jersey, et en conséquence d'adopter les Nouveaux Statuts afin de les mettre en conformité avec le droit de Jersey,
les Nouveaux Statuts sont indiqués à la fin du présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires et des porteurs de parts de fondateur résout à l'unanimité d'accepter la démis-
sion de Pierre LENTZ, John SEIL et Franz J. MENG en tant qu'administrateurs actuels de la Société, dûment nommés en
vertu de la loi luxembourgeoise. La démission des administrateurs actuels prendra effet à compter de la Date d'Effet.
De plus l'assemblée générale des actionnaires et des porteurs de parts de fondateur résout à l'unanimité de décharger
les administrateurs actuels pour l'exécution de leurs fonctions jusqu'à et y compris la Date d'Effet.
L'assemblée générale des actionnaires et des porteurs de parts de fondateur résout à l'unanimité de désigner:
a) Charles Stuart HORNBY, né à Liverpool, Angleterre, GB le 25 mai 1953, résidant professionnellement à 22 Grenville
Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, directeur du serveur client de Mourant Private Wealth,
b) Alan BINNINGTON, né à Jersey, CI le 20 janvier 1958, résidant professionnellement à 22 Grenville Street, St Helier,
Jersey JE4 8PX, directeur du serveur client de Mourant Private Wealth,
c) Anthony COOKE-YARBOROUGH, né à Oxford, Angleterre, GB le 6 août 1956, résidant professionnellement 22
Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, président de Mourant Private Wealth;
comme nouveaux administrateurs de la Société à partir de la Date d'Effet; et
d) Blair KEMPSTER, né à Jersey, CI le 14 janvier 1967, résidant professionnellement 22 Grenville Street, St Helier,
Jersey JE4 8PX, gérant senior à Mourant Private Wealth
comme suppléant des administrateurs indiqués sous a) à c) à partir de la Date d'Effet.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires et des porteurs de parts de fondateur résout à l'unanimité d'accepter la démis-
sion de AUDIEX S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société dûment nommé en vertu de la loi luxembour-
geoise à partir de la Date d'Effet.
De plus l'assemblée générale des actionnaires et des porteurs de parts de fondateur résout à l'unanimité de décharger
AUDIEX S.A. de sa responsabilité pour l'exécution de ses fonctions jusqu'à et y compris la Date d'Effet.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires et des porteurs de parts de fondateur confirme à l'unanimité que (i) les Nouveaux
Statuts sont conformes aux prescriptions du droit de Jersey, (ii) à partir de la Date d'Effet, la Société cessera d'être une
société de droit luxembourgeois et, (iii) sous réserve des dispositions du droit de Jersey, à partir de la Date d'Effet, la
Société sera exclusivement soumise aux lois de Jersey applicables et (iv) ni le transfert du siège social de la Société, ni le
changement de son lieu d'enregistrement, ni le changement de sa forme sociale n'ont pour effet la dissolution et/ou le
liquidation de la Société et la création d'une nouvelle entité juridique.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires et des porteurs de parts de fondateur résout à l'unanimité de désigner Alex
SCHMITT, Marcus, PETER, Natalie O'SULLIVAN-GALLAGHER, Nicolas RONZEL, Franz J. MENG (avocat résidant en
Suisse), Mathew SHAXSON (avocat résidant à Jersey), et Nicolas LEBLANC (avocat résidant à Jersey) individuellement
15399
et avec les pouvoirs le plus étendu (y compris le pouvoir de substitution), de réaliser toute action, en ce compris no-
tamment, la signature et la délivrance de tout acte, formulaire, certificat, contrat ou autre document et l'observation de
toutes formalités de dépôt et de publicité requises d'après le droit luxembourgeois et le droit de Jersey pour l'enregis-
trement du transfert du siège social et le transfert du lieu d'enregistrement de la Société auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg et le dépôt de tout document requis d'après le droit de Jersey, et nécessaire ou utile au
transfert diligent et valide du siège social de la Société à Jersey, afin de donner plein effet à ces résolutions, y compris le
dépôt d'une copie certifiée de ces résolutions à la Jersey Financial Services Commission qui confirme qu'à partir de la
continuation de la Société à Jersey, le nouveau siège social de la Société sera situé 22 Grenville Street, St Helier Jersey
JE4 8PX.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires et des porteurs de parts de fondateur résout à l'unanimité que les livres et liés
à la Société au nouveau siège social de la Société seront transférés à son nouveau siège social aussitôt que possible après
la Date d'Effet.
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour de l'assemblée, le Président leva l'assemblée.
* * *
NOUVEAU STATUTS
<i>Référence est faite à la version anglaise du présent actei>
* * *
<i>Fraisi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la Société et facturés en
raison du présent acte sont évalués à EUR 3.500.-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, lesdits
comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. PETER, N. O'SULLIVAN-GALLAGHER, N. RONZEL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2008. Relation: LAC/2008/50885. Reçu douze euros (12.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Luxembourg, le 23 décembre 2008.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009014346/242/1152.
(090013464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
VDC Alpha Lux, Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 89.537.
DISSOLUTION
In the year two thousand eight, on the twenty-ninth of December.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
There appeared:
Mrs Stéphanie GRISIUS,M. Phil. Finance B. Sc. Economics, with professional address at 3-5, Place Winston Churchill,
L-1340 Luxembourg,
acting as a special proxy holder of:
"VDCapital L.P.", having its registered office No. 1 Seaton Place, St. Helier, Jersey JE4 8YJ, Channel Islands,
hereafter referred to as "the principal",
by virtue of a proxy given under private seal
which proxy, after having been signed " ne varietur " by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will
be registered with this deed.
The same proxy holder declared and requested the notary to act:
15400
I.- That the company "VDC ALPHA LUX", a "société anonyme", established and having its registered office at 3-5,
Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, registered in the "Registre de Commerce et des Sociétés" in Luxembourg,
section B number 89537, has been incorporated under Luxembourg Law, pursuant to a deed of the undersigned notary
on 25 October 2002, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 1693 of 27 November 2002.
The Articles of Association of said company have not been amended since.
II.- That the subscribed capital of the company is fixed at five hundred thousand euros (EUR 500.000.-) represented
by fifty thousand (50.000) shares of a par value of ten euro (EUR 10.-) each, fully paid up.
III.- That the principal is the sole owner of all the shares of said company.
IV.- That the principal, being sole shareholder of the company "VDC ALPHA LUX", has decided to proceed immediately
to the dissolution of the said company.
V.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the
company "VDC ALPHA LUX", prementioned.
VI.- That the principal, in its activity as liquidator of the company, declares that the business activity of the company
has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved company
committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved company as well as to be personally
charged with any presently unknown liability.
VII.- That the principal fully grants discharge to the managers of the dissolved company for the due performance of
their duties up to this date.
VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at its former registered
office.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and
in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.
The document after having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first name,
civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
Madame Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics avec adresse professionnelle au 3-5, Place Winston
Churchill, L-1340 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
"VDCapital L.P.", ayant son siège social au No. 1 Seaton Place, St. Helier, Jersey JE4 8YJ, Channel Islands,
ci-après dénommée: "le mandant",
en vertu d'une procuration lui donnée sous seing privé
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter:
I.- Que la société "VDC ALPHA LUX", une société anonyme, établie et ayant son siège social au 3-5, Place Winston
Churchill, L-1340 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro
89537, a été constituée sous le droit luxembourgeois, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 octobre
2002, publié au Mémorial C numéro 1693 du 27 novembre 2002.
Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis lors.
II.- Que le capital social souscrit de la société est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500'000.-), représenté par cinquante
mille (50'000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune, intégralement libérées.
III.- Que le mandant est le seul propriétaire de toutes les actions de ladite société.
IV.- Que le mandant, étant le seul associé de la société "VDC ALPHA LUX", a décidé de procéder à la dissolution de
ladite société.
V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société "VDC
ALPHA LUX", prédésignée.
VI.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la société, déclare que l'activité de la société a cessé, que lui, en tant
qu'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la société dissoute s'engageant à reprendre
tous actifs, dettes et autre engagements de la société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle
obligation inconnue à l'heure actuelle.
15401
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats
jusqu'à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre
le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: ST.GRISIUS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 06 janvier 2009. Relation: EAC/ 2009/129. Reçu douze euros 12.- €.
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Belvaux, le 19 janvier 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009013685/239/90.
(090013281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.
ECIROA, European Captive Insurance and Reinsurance Owners' Association, Association sans but lucra-
tif.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg F 7.729.
<i>Articles fori>
<i>European Captive Insurance and Reinsurance Owners' Association ECIROAi>
<i>as adopted by the General Meeting on the 19th of August 2008i>
<i>and as changed by the General Meeting on the 26th of November 2008i>
Chapter I - Name, headquarters, duration, objects
§1. Name. The name of the association is "European Captive Insurance and Reinsurance Owners' Association" (ECI-
ROA). It may use either its full name or its abbreviated name.
§2. Location. The registered office of the association is established in Luxembourg.
§3. Duration.
The duration of the association is unlimited.
§4. Objectives. The association has as its object the protection and development of the interest of its members in the
broadest sense as well as to represent its members in discussions with official, regulatory bodies. It shall do all in its power
to promote captives.
Chapter II - Members
§5. Admission, Resignation, Exclusion. The number of members is unlimited; it may not be less than three.
Membership is open for any company owning a captive in Europe, which declares itself prepared to observe these
statutes.
The admission of new members is decided by the Board of Directors. A request to become a member should be made
to the Chairman of the board and be approved by a board meeting. Following a board meeting the already existing
members will have one month for objections. Should an objection be filed the request will be handled by the next General
Meeting.
Any member of the Association has the right to renounce membership of the Association, subject to giving a period
of notice of three months.
When a member of the association is guilty of a serious violation of the ethical principles of the association, he may
be expelled by the General Meeting after having been heard.
If a member ceases to own a captive in Europe it is immediately excluded from membership.
The resigning or excluded member and its successors-in-title have no rights to the corporate funds of the association,
and they may not ask for any accounts, or ask for an inventory, or claim a refund of subscriptions paid.
15402
Chapter III - General Meeting
§6. General Meeting. The General Meeting comprises all members. It meets as often as the interests of the association
require. It is presided by the Chairman of the association or, if she/he is unable to attend, by the Vice-Chairman or, in
her/his absence, by a Chairman elected by the meeting.
The association should hold its Annual General Meeting during the first half of every year. Day, time and location is
to be decided by the board. Notice to attend the General Meeting together with the agenda should be delivered to the
members at least 14 days in advance. In the case of an emergency, an Extraordinary General Meeting may be called within
a shorter period.
An Extraordinary General Meeting shall meet on being convened by the Board of Directors. It is bound to call a meeting
when a fifth of the members so requests.
A member who would like to raise a proposal at the General Meeting should deliver the proposal to the board at least
1 month before the General Meeting.
§7. Powers. The General Meeting elects the Board of Directors, approves the annual budget, peruses the annual
accounts and approves them.
The General Meeting may amend the statutes in accordance with the law.
In all circumstances, the General Meeting may only legitimately meet if at least half of its members are present or
represented.
If a first meeting does not achieve this quorum, the Board of Directors may, within one month, convene a second
meeting, which may legitimately discuss the agenda, whatever the number of members present or represented.
The resolutions of the General Meeting are entered into an ad hoc register and all members are informed by electronic
letter.
§8. Right to vote. Every member has the right to one vote at the time of voting in the General Meeting. A member
could be represented by another member via a proxy.
Voting is made via hand raising. If the Chairman or a fifth of the members present at the meeting so demand, the vote
shall be by secret ballot. Save where otherwise stipulated in law all decisions are made with a simple majority of the votes.
§9. Elections to the board of directors. The General Meeting elects the Board of Directors, which is comprised of a
maximum of 7, and a minimum of 3 members, amongst whom there shall be a Chairman and a Vice-Chairman.
The election of the board is made by a simple majority. The members of the Board, including the Chairman and the
Vice-Chairman are elected for a period of 2 years renewable.
§10. Budget. The financial year shall follow the calendar year and should end on 31 December 2008 for the first time.
The General Meeting annually approves the accounts of the past year and the budget of the association including the
membership fee.
The annual membership fee is a flat fee of 100 EUR per member. The membership fee could be changed by a decision
made by the General Meeting.
No seat on the Board of Directors or any committee gives a right to remuneration.
§11. Representation of the association. As regards third parties, the association is committed by joint signatures of any
two members of the Board and in any other manner determined by the Board of Directors.
Chapter IV - Board of Directors
§12. The Board of Directors. The Board of Directors manages the affairs of the association and represents it in all
judicial and non-judicial matters. It may, under its responsibility, delegate all or part of its powers to one of its members
or to a third party.
The Board of Directors is presided over by the Chairman of the association or, in the case of non-availability, by the
Vice-Chairman. In the absence of the Chairman or Vice-Chairman, the chairmanship of the Board of Directors may not
be exercised by their substitute.
The board should have board meetings at least 2 times per year. Minutes should be distributed to the members and
filed.
The board could make decisions when at least 3 members are available at a board meeting. The Board of Directors
takes its decision by a simple majority. In the case of non-availability, each Director may be represented at the Board of
Directors by another director on presentation of a written proxy.
When the conditions required for a majority cannot be obtained with regard to a point on the agenda, it may be
submitted to an extraordinary General Meeting.
15403
Chapter V - Executive Management
§13. Executive Management. The Board of Directors is assisted by an Executive Manager appointed by the Board of
Directors.
The Executive Manager performs all the tasks entrusted to her/him by the Board of Directors. She/he is automatically
responsible for the internal administration of the association and for communication with the members and with third
parties.
For the performance of the tasks entrusted to her/him, the Executive Manager of the association is committed by the
signature of two members of the Board.
The Chairman may give a mandate to the Executive Manager or to outside experts to represent the association in all
national, international and supranational bodies.
§14. Treasurer. The daily financial administration of the association is assumed by a treasurer chosen by the Board of
Directors. The competence and tasks of the treasurer are defined by the Board of Directors
The functions as Executive Manager and Treasurer could be assumed by the same person or different persons.
Chapter VI - Miscellaneous
§15. Dissolution of the Association. Decision on the dissolution of the association should be made on a General Meeting
and should be approved by at least 3/4 of the votes in this meeting. If the association is dissolved the General Meeting
should also decide on the allocation of any remaining assets.
§16. Procedures and law. Internal rules of procedure may define the procedures and detailed arrangements, in particular
for organisation and operation. These rules shall be drawn up and amended by the Board of Directors and placed before
the General Meeting for its approval.
In all cases not provided for in these statutes, the law of 21 April 1928 on non-profit-making associations and public
utility establishments shall apply.
The German translation follows:
Kapitel I - Name, Sitz, Dauer, Vereinszweck
§1. Name. Der Name des Vereins ist "European Captive Insurance and Reinsurance Owners' Association" (ECIROA).
Er kann den vollen oder den abgekürzten Namen benutzen.
§2. Sitz. Der Verein hat seinen Sitz in Luxemburg.
§3. Dauer. Die Dauer des Vereins ist zeitlich unbefristet.
§4. Vereinszweck. Der Zweck des Vereins ist der Schutz und Entwicklung der Interessen seiner Mitglieder im weitesten
Sinne und außerdem seine Mitglieder in Gesprächen mit öffentlichen Gremien, Einrichtungen sowie Aufsichtsbehörden
zu vertreten. Er soll alles in seiner Macht stehende zur Förderung von „Captives" tun.
Kapitel II - Mitglieder
§5. Aufnahme, Rücktritt, Ausschluss. Die Anzahl der Mitglieder ist unbegrenzt, es dürfen aber nicht weniger als drei
sein.
Die Mitgliedschaft ist offen für jede Gesellschaft, die einen „Captive" in Europa hat und die sich bereit erklärt, diese
Satzung zu beachten.
Die Aufnahme neuer Mitglieder wird vom Vorstand beschlossen. Der Aufnahmeantrag wird beim Vorstandsvorsit-
zenden eingereicht und dem Vorstand in der nächsten Sitzung zur Genehmigung, vorgelegt. Im Anschluss an eine
Vorstandssitzung haben die (bereits existierenden) Mitglieder einen Monat Zeit für Einwände. Sollte ein Einwand vorliegen,
wird er in der nächsten Mitgliederversammlung behandelt.
Jedes Mitglied hat das Recht, auf seine Mitgliedschaft unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in einer schriftlichen
Erklärung gegenüber dem Vorstand zu verzichten.
Wenn ein Mitglied gegen die Interessen des Vereins in erheblichem Umfang oder nachhaltig verstoßen hat, kann es
von der Mitgliederversammlung nach Anhörung ausgeschlossen werden.
Falls ein Mitglied keine „Captive" mehr in Europa hat, endet die Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung.
Die zurückgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder und ihre Rechtsnachfolger haben keinen Rechtsanspruch auf
das Vereinsvermögen und sie können weder die Herausgabe von Vermögensgegenständen noch die Rückerstattung von
Beitragszahlungen verlangen.
Kapitel III - Mitgliederversammlung
§6. Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung besteht aus allen Mitgliedern. Sie findet so oft statt, wie es die
Interessen des Vereins erfordern. Sie wird vom Vorsitzenden des Vorstands oder in dessen Abwesenheit vom stellver-
15404
tretenden Vorsitzenden oder in dessen Abwesenheit durch einen Vorsitzenden, der in der Versammlung berufen wird,
geleitet.
Die jährliche Mitgliederversammlung des Vereins sollte jeweils in der ersten Jahreshälfte stattfinden. Tag, Zeit und Ort
wird durch den Vorstand festgelegt. Zusammen mit der Benachrichtigung über die bevorstehende Mitgliederversammlung
soll den Mitgliedern 14 Tage im voraus die Tagesordnung zugesandt werden. In dringenden Fällen kann eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung in einem kürzeren Zeitraum einberufen werden.
Die außerordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand einberufen. Er ist verpflichtet eine Versammlung
einzuberufen, wenn ein Fünftel der Mitglieder es verlangt.
Ein Mitglied, das einen Vorschlag in die Mitgliederversammlung einbringen möchte, sollte diesen Vorschlag dem Vor-
stand mindestens einen Monat vor der Mitgliederversammlung vorlegen.
§7. Befugnisse. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand, genehmigt den jährlichen Haushaltsplan, prüft die
Abschlusskonten und genehmigt sie.
Die Mitgliederversammlung kann die Satzung abändern in Übereinstimmung mit den Gesetzen.
Nach dem Gesetz kann die Mitgliederversammlung nur dann stattfinden, wenn mindestens die Hälfte der Vereinsmit-
glieder anwesend oder vertreten ist.
Wenn eine erste Versammlung dieses Quorum nicht erreicht, dann kann der Vorstand innerhalb eines Monats eine
zweite Versammlung einberufen. Diese kann über die Tagesordnungspunkte diskutieren und Beschlüsse fassen, ohne dass
es auf die Anzahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder ankommt.
Die Beschlussfassungen der Mitgliederversammlung werden in ein ad hoc Register eingetragen und jedes Mitglied durch
eine elektronische Mitteilung informiert.
§8. Stimmrecht. Jedes Mitglied hat eine Stimme bei der Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung. Ein Mitglied
kann von einem anderen Mitglied via Vollmachtserteilung vertreten werden.
Die Stimmabgabe erfolgt durch Handheben. Wenn der Vorsitzende oder ein Fünftel der anwesenden Mitglieder es
wünschen, kann die Abstimmung geheim erfolgen. Wenn im Gesetz nichts anderes vorgeschrieben ist, erfolgen alle Ent-
scheidungen mit einfacher Mehrheit der Stimmen.
§9. Wahl des Vorstands. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand, der aus höchstens 7 und mindestens 3
Mitgliedern bestehen soll und unter ihnen den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden.
Die Wahl des Vorstands erfolgt durch einfache Mehrheit. Die Vorstandsmitglieder einschließlich des Vorsitzenden und
des stellvertretenden Vorsitzenden werden für 2 Jahre gewählt; die Wiederwahl ist zulässig.
§10. Haushaltsplan. Das Geschäftsjahr folgt dem Kalenderjahr und endet das erste Mal am 31. Dezember 2008.
Die Mitgliederversammlung genehmigt jährlich den Haushaltsplan des Vereins einschließlich der Mitgliedschaftsbeiträge.
Die Mitgliederversammlung stimmt über die Schlussabrechnungen des vergangenen Jahres ab, sowie über den Haus-
haltsplan des Vereins einschließlich der Mitgliedschaftsbeiträge.
Der jährliche Mitgliedschaftsbeitrag ist ein Pauschalbetrag von 100 EUR pro Mitglied. Die Mitgliedschaftsbeiträge kön-
nen durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung geändert werden.
Weder ein Sitz im Vorstand noch in irgendeinem Ausschuss gibt das Recht für eine Vergütung.
§11. Verpflichtung des Verbandes. Gegenüber Dritten wird der Verein durch die gemeinsame Unterschrift von zwei
Vorstandsmitglieder verpflichtet und in irgendeiner anderen Weise durch Beschluss des Verwaltungsrats.
Kapitel IV - Vorstand
§12. Vorstand. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und vertritt ihn in allen juristischen und nicht juristischen
Angelegenheiten. Er kann, unter seiner Verantwortung, alle oder einen Teil seiner Befugnisse an eines seiner Mitglieder
oder einem Dritten übertragen.
Der Vorstand wird vom Vorsitzenden oder in dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. In
Abwesenheit vom Vorsitzenden und vom stellvertretenden Vorsitzenden kann das Amt des Vorsitzenden nicht von einem
anderen Vorstandsmitglied ausgeübt werden.
Der Vorstand sollte mindestens zweimal im Jahr eine Sitzung abhalten. Protokolle sollen an die Mitglieder verteilt und
archiviert werden.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 Mitglieder bei der Sitzung anwesend sind. Der Vorstand beschließt
durch einfache Mehrheit. Wenn ein Mitglied des Vorstands nicht zur Verfügung steht, kann jedes Vorstandsmitglied in
der Sitzung durch ein anderes Vorstandsmitglied durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht vertreten werden.
Wenn die Bedingungen für eine Mehrheit zu einem Tagesordnungspunkt nicht erreicht werden, so kann dieser in einer
Außerordentlichen Generalversammlung vorgelegt werden.
15405
Kapitel V - Leitende Geschäftsführung
§13. Leitende Geschäftsführung. Der Vorstand wird von einer leitenden Geschäftsführung unterstützt, welche vom
Vorstand ernannt wird.
Der Geschäftsführer erledigt alle Aufgaben die ihm/ihr vom Vorstand anvertraut werden. Sie/Er ist automatisch ver-
antwortlich für die interne Verwaltung des Vereins und für die Benachrichtigung zwischen den Mitgliedern und Dritten.
Für die Ausführung dieser Aufgaben, benötigt der Geschäftsführer die Unterschriften von zwei Vorstandsmitgliedern.
Der Vorsitzende des Vorstands kann dem Geschäftsführer oder einem externen Experten das Mandat geben den
Verein in allen nationalen, internationalen und supranationalen Gremien zu vertreten.
§14. Kassenwart. Die tägliche Finanzverwaltung des Vereins wird von einem Kassenwart geführt welcher vom Vorstand
bestimmt wird. Die Kompetenzen und Aufgaben des Kassenwarts werden vom Vorstand festgelegt.
Das Amt des Geschäftsführers und des Kassenwarts kann von derselben Personn oder von verschiedenen Personen
ausgeübt werden.
Kapitel VI - Verschiedenes
§15. Auflösung des Vereins. Der Beschluss, den Verein aufzulösen, soll in einer Generalversammlung erfolgen und
mindestens von 3/4 der Stimmen genehmigt werden. Wenn der Verband aufgelöst ist, soll die Generalversammlung über
die Verteilung der verbleibenden Vermögenswerte entscheiden.
§16. Verfahren und Gesetz. Interne Regeln legen die Verfahren und ausführliche Vereinbarungen fest, besonders für
Organisation und Betrieb. Diese Richtlinien werden vom Vorstand aufgestellt und geändert und der Mitgliederversamm-
lung zur Genehmigung vorgelegt.
Für alle Fälle, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 21. April 1928 für nicht Gewinn bringende
(„gemeinnützige") Vereine und öffentliche Einrichtungen.
Délivrée aux fins de la publicaion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Martine SCHAEFFER
<i>Notari>
Référence de publication: 2009013534/5770/216.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00888. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090012997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.
Chaussea S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3544 Dudelange, 40, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 68.832.
L'an deux mille huit, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
ONT COMPARU:
1) Monsieur Gaëtan GRIECO, gérant de société, né à Briey, (France), le 30 janvier 1963, demeurant à F-54910 Valleroy,
106, avenue Charles de Gaulle.
2) Monsieur Michel GRIECO, directeur des achats, né à Briey, (France), le 5 février 1961, demeurant à F-54910 Valleroy,
106, rue du Stade.
3) Monsieur Mario GRIECO, responsable logistique, né à Briey, (France), le 23 octobre 1966, demeurant à F-57100
Terville, 2, rue Emile Zola.
4) Monsieur François GRIECO, comptable, né à Briey, (France), le 21 janvier 1971, demeurant à F-54910 Valleroy,
110, avenue Charles de Gaulle.
5) La société par actions simplifiée de droit français "V.G.M. HOLDING", établie et ayant son siège social à F-54910
Valleroy, 105, avenue Charles de Gaulle, (France), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Briey sous le
numéro B 330 726 449.
Tous sont ici représentés par Madame Sandrine BELLATRECCIA, employée privée, demeurant professionnellement
à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu de cinq procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles
procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte afin d'être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'ils sont les seuls
associés actuels de la société à responsabilité limitée "CHAUSSEA S.à r.l.", (ci-après la "Société"), établie et ayant son
siège social à L-4010 Esch-sur-Alzette, 86-88, Coin rue de l'Alzette et du X Septembre, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 68.832, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas
15406
METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 2 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 388 du 28 mai 1999,
et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, par leur mandataire, sur ordre
du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première préliminairei>
L'assemblée constate que l'associé sub 5) actuellement inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous la dénomination de "VGM" a entretemps changé de forme juridique et modifié sa dénomination sociale en
"V.G.M. HOLDING".
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social d'Esch-sur-Alzette à L-3544 Dudelange, 40, avenue Grande-Duchesse
Charlotte, et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 4. (1
re
phrase). Le siège social est établi à Dudelange, (Grand-Duché de Luxembourg)."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cents euros et les
associés, s'y engagent personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire
par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: BELLATRECCIA; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 décembre 2008. Relation GRE/2008/5199. Reçu douze euros 12,- €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): BENTNER.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Junglinster, le 19 janvier 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009013548/231/54.
(090013280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.
Founty Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 103.844.
Im Jahre zweitausendundacht, den funfundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft "Financière des Dahlias Holding S.A.H.", mit Sitz in L-1411 Luxemburg, 2, rue des Dahlias,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Nummer B 81.795,
hier vertreten durch ihr Verwaltungsratsmitglied Herrn Alain Lorang, Anwalt, beruflich wohnend in L-2551 Luxemburg,
41, avenue du X Septembre,
welche Gesellschaft erklärte, gemäss Anteilsabtretung vom 19. Februar 2008, alleinige Gesellschafterin zu sein der
Gesellschaft "FOUNTY INVEST S.à r.l." , mit Sitz in L-1411 Luxemburg, 2, rue des Dahlias, gegründet laut Urkunde des
amtierenden Notars vom 22. Oktober 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 75 vom 27. Januar 2005, deren
Satzung abgeändert wurde gemäss Urkunde des amtierenden Notars vom 5. Dezember 2005, veröffentlicht im Mémorial
C Nummer 527 vom 13. März 2006 und zum letzten Mal gemäss Urkunde des amtierenden Notars vom 12. Juni 2008,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1851 vom 28. Juli 2008, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter
Nummer B 103.844.
Alsdann ist erschienen:
Heix Yusuf Meynioglu, Rechtsanwalt, beruflich wohnend in L-2551 Luxemburg, 41, avenue du X Septembre,
handelnd in seiner Eigenschaft als Vollmachtnehmer von:
Herr Markus Möller, Finanzberater, beruflich wohnend in L-1411 Luxemburg, 2, rue des Dahlias,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ihm erteilt in Luxemburg am 19. November 2008 und welche gegen-
wärtiger Urkunde beigebogen bleibt,
welcher handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der vorgenannten Gesellschaft "FOUNTY INVEST S.à r.l.",
15407
erklärte besagte Anteilsabtretung im Namen der Gesellschaft anzunehmen und als rechtmässig zugestellt zu betrachten.
In Folge dessen wird Artikel 6 der Statuten umgeändert, durch Zusatz eines zweiten Abschnitts, wie folgt:
"Les parts sociales sont intégralement attribuées à l'associé unique".
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen respektiv deren Vertreter, dem Notar nach Vornamen,
Namen, Stand und Wohnorten bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Lorang, Y. Meynioglu, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2008. LAC/2008/47934. Reçu € 12,- (douze euros).
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.
Luxemburg, den 19. Dezember 2008.
Emile SCHLESSER.
Référence de publication: 2009013377/227/39.
(090012631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.
CB Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 96.443.
Le bilan au 31 décembre 2007 et les annexes ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 13 Janvier 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009013738/9606/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07530. - Reçu 115,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090012467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.
Financière Tiara, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 35.205.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement et par le conseil d'administrationi>
<i>en date du 29 décembre 2008i>
1) Fin des mandats de:
- M. Cornelius Martin BECHTEL, administrateur de catégorie A et président du conseil d'administration.
- Mme Christine SCHWEITZER, administrateur de catégorie B.
2) Nomination au conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011:
- M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant professionnel-
lement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur de catégorie A.
- M. Michel JENTGES, administrateur de sociétés, né à Saint-Mard (Belgique), le 29 janvier 1971, demeurant profes-
sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur de catégorie B.
3) Nomination comme président du conseil d'administration:
- Mme Virginie DOHOGNE.
Luxembourg, le 6 janvier 2009.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FINANCIERE TIARA
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009014012/29/26.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04416. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090013204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
15408
Artod S.A.
BE.L.Part S.A.
Benictim Properties
Berin Holding S.A.
Betafin Holding SA
Bonzaï S.A.
Business Technology Services
CB Luxembourg S.A.
Chaussea S.à r.l.
Cienega Investments S.à r.l.
Claremont Consulting Services S.A.
eBay Treasury S.à r.l.
Edgecliff Finance S.à.r.l.
ETV Capital S.A.
Europa Régions Magazine S.A.
European Captive Insurance and Reinsurance Owners' Association
Euro-Shopping, s.à r.l.
Euro-Shopping, s.à r.l.
Farenzena Jules Sàrl
Fidelity International Real Estate Fund Company 1
Fidelity International Real Estate Fund Company 2
Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A.
Financière des Ardennes S.A.
Financière Tiara
Fintinvest A.G.
Founty Invest S.à r.l.
GDI Invest S.A.
GENPASA Environmental Holdings S.à r.l.
Green House S.A.
Heidt-Hang Assurances s.à r.l.
Hua Yuan S.à r.l.
Idia S.A.
Industrial Partnership
Komzept 7c S.A.
Koukab S.A.
Linea Grazia
Logicrane Holding S.A.
Martin & Martin S.A.
Med-Tel International Holdings S.A.
Melusine Aviation S.à r.l.
Menaa S.A.
MOOR PARK MB 7 Hannover-Bornum S.à r.l.
Murex Participations Luxembourg S.A.
Naxos Capital Managers S.àr.l.
Ortatlantic S.A.
Paepeweg Holding S.A.
Pfizer Luxembourg S.à r.l.
ProLogis UK LVIII S.àr.l.
Rolo Operation Project S.A.
Rosevo S.A.
SFM Training & Consultancy, s.à r.l.
Silver Vending System
Smart Partners S.A.
Syntech S.A.
VATit Israel Holdings S.à r.l.
VDC Alpha Lux
VF Finance s.à r.l.
Woodsmore-Lux S.A.