This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2835
26 novembre 2008
SOMMAIRE
Acergy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136036
Altrum Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136037
Bakerfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136044
BI-Invest Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136064
Bodena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136044
Cesare Fiorucci Luxco . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136047
Checkfree Solutions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
136061
CIS Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136062
Compagnie Luxembourgeoise de Partici-
pations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136058
Ellegi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136056
Eurfinance SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136080
Eurfinance SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136060
Euromutuel Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136034
Eurostampa International S.A. . . . . . . . . . .
136059
Exante S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136060
Finkerri S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136052
G.P.P. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
136080
Gruppo Fabbri International S.A. . . . . . . . .
136059
High-Tech Hotel Investments S.à r.l. . . . .
136080
Induserv Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136058
Investment Light II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
136077
Investment Light I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
136078
Jost Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
136057
Katoen Natie Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
136034
KBC Districlick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136034
KBC Renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136037
Kidsco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136041
Le Bourgeon SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136057
Life One . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136041
Longford Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
136048
LSF5 Giga Investments III S.à r.l. . . . . . . . .
136078
Merton Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136048
Nordea Alternative Investment . . . . . . . . .
136035
Oakville Invest Limited S.à r.l. . . . . . . . . . . .
136053
Orion Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
136059
Paro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136042
Photo Video Dichter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136042
Russia International Card Finance S.A. . . .
136038
Sadin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136043
Shalimar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136035
Sinvar Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136056
S.M.M. spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136077
Société Anonyme des Chaux de Contern
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136036
SOCIETE DE PARTICIPATIONS TAMI-
SE, société anonyme de gestion de patri-
moine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136061
Thaleya S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136053
Thaleya S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136044
Trident Locations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136058
Triple Crown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136047
UniGarantPlus: Klimawandel (2013) . . . . .
136047
UT97 Global Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136042
Vdo.nrg S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136042
Vdo.nrg S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136043
VR Premium Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136043
WP Roaming III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
136060
WP Roaming S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136057
136033
Katoen Natie Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 110.988.
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held extraordinarily at registered office, Luxembourg, on <i>December 12, 2008i> at 10.00 o'clock,
with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the independent auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2007.
3. Discharge to the directors.
4. Elections.
5. Miscellaneous.
<i>The board of directors.i>
Référence de publication: 2008145667/534/17.
KBC Districlick, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 61.496.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société, qui se tiendra le <i>12 décembre 2008i> à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2008 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2008
4. Décharge à donner aux dirigeants de la société de gestion
5. Nominations statutaires
6. Divers
Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l'Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.
Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 9 décembre
2008 au plus tard auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2008145679/755/22.
Euromutuel Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 34.148.
Par la présente, nous avons l'honneur de vous convoquer à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de la société d'EUROMUTUEL SICAV qui se tiendra le <i>12 décembre 2008i> à 11 heures au siège social
de la société, 17 Côte d'Eich, L - 1450 Luxembourg.
L'ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des rapports annuels du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises pour
l'exercice social clôturé au 30 septembre 2008 ;
2. Présentation et approbation des comptes annuels pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2008 ;
3. Affectation du résultat ;
136034
4. Vote sur la décharge des administrateurs concernant l'exécution de leur mission pour l'exercice clôturé au 30
septembre 2008 ;
5. Ratification de la cooptation de Monsieur Daniel Schaerer en qualité d'administrateur, remplaçant Monsieur Thierry
de Pascal ;
6. Divers.
Pour les points à l'ordre du jour, aucun quorum n'est requis. Les décisions seront prises à la majorité simple des voix
des actionnaires présents ou représentés et votants.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l'assemblée générale devra en aviser la SICAV au moins cinq
jours francs avant la tenue de l'assemblée.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2008144670/1035/26.
Shalimar S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 16.737.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>12 décembre 2008i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2008.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2008145669/1023/17.
Nordea Alternative Investment, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 106.173.
Notice is hereby given to the shareholders of Nordea Alternative Investment, SICAV that a first
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders shall be held at the registered office of the Company, 562, rue de Neudorf, Luxembourg, on <i>15i>
<i>December 2008i> at 14:00 local time, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Revision of the Statutes of the Company, and more particularly amendment to the Articles 4 (Registered office),
5 (Capital), 17 (Redemption and Conversion of shares), 19 (Issuance of shares), and 24 (Liquidation of the Company,
Liquidation, Merger or Contribution of a sub-fund).
2. The changes shall become effective as per 1st February 2009.
A copy of the Statutes as proposed to the extraordinary general meeting of shareholders is available at the registered
office of the Company where each shareholder may consult them and request a copy thereof.
The above-mentioned decisions on the agenda of this first extraordinary general meeting shall require a quorum of
50% of the outstanding shares. Decisions shall be validly made at a majority of two thirds of the shares present or
represented at the meeting and voting.
In case of lack of quorum at the first extraordinary general meeting, a second extraordinary general meeting will be
convened so as to be held on January 26, 2009 at the same address and with the same agenda, at which decisions may be
approved without quorum and at a majority of two thirds of the shares present or represented at the second extraor-
dinary general meeting.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at the Meeting by proxy.
In order to vote at the extraordinary general meeting(s), shareholders may be present in person or represented by a
duly appointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and
signed proxy form to the address of the Company to arrive not later than December 12, 2008. Proxy forms can be
obtained from the registered office of the Company. The meetings will be conducted in the English language.
136035
Luxembourg, 26 November 2008.
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2008145681/755/31.
Acergy S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 43.172.
The EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of Acergy S.A. (the "Company"), a Société Anonyme Holding, R.C.S. Luxembourg B 43.172, having its
Registered Office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, will be held at the offices of Services Généraux de Gestion
S.A., 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, on Thursday <i>December 18, 2008i> at 11.00 a.m. Local Time, for the following
purposes:
<i>Agenda:i>
1. To approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to increase the number of Common
Shares reserved for issuance under the Company's 2003 Stock Option Plan by two million four hundred thousand
(2,400,000) Common Shares of which five hundred and one thousand (501,000) are allocated to the French Stock
Option Plan, from the current six million three hundred and ten thousand (6,310,000) Common Shares to eight
million seven hundred and ten thousand (8,710,000) Common Shares.
2. To approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to adopt the proposed Acergy S.A.
2008 Long Term Incentive Plan.
A summary of the proposed Long Term Incentive Plan is included as part of this Notice, the full 2008 Long Term
Incentive Plan is available online at:
www.acergy-group.com/public/2008EGM
The Extraordinary General Meeting shall be conducted in conformity with the quorum and voting requirements of
Luxembourg Company Law and the Company's Articles of Association.
The Board of Directors of the Company has determined that Shareholders of record at the close of business on
November 19, 2008 will be entitled to vote at the aforesaid meeting and any adjournments thereof.
November 21, 2008.
Mark Woolveridge
<i>Chairmani>
To assure their representation at the Extraordinary General Meeting, shareholders are hereby requested to fill in,
sign, date and return the Proxy Card provided for such purpose and which is available at the registered office or will be
mailed upon request so as to arrive at the registered office by 12:00 hours Central European Time on December 11,
2008. The giving of such Proxy will not affect your right to revoke such Proxy or vote in person should you later decide
to attend the meeting.
Référence de publication: 2008145665/795/34.
Société Anonyme des Chaux de Contern, Société Anonyme.
Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.
R.C.S. Luxembourg B 7.119.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 décembre 2008i> à 15.00 heures, à Contern, rue des Chaux, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Distribution d'un dividende supplémentaire.
2. Divers.
Conformément à l'article 16 des statuts, les actionnaires propriétaires d'actions au porteur qui désirent assister ou se
faire représenter à l'assemblée générale doivent déposer leurs titres cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée
dans un des établissements suivants:
au siège social à Contern,
à la Banque Fortis Luxembourg,
à la Dexia Banque Internationale à Luxembourg.
136036
Les actionnaires en nom qui désirent assister ou se faire représenter à l'assemblée générale doivent en aviser la société
cinq jours au moins avant l'assemblée.
Les procurations devront être parvenues au siège social trois jours francs au moins avant l'assemblée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2008145488/2857/23.
Altrum Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 81.918.
Die Aktionäre der ALTRUM SICAV werden hiermit zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>15. Dezember 2008i> , 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen
mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Liquidation der Gesellschaft zum 31. Dezember 2008
2. Verschiedenes
Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von
50 Prozent der ausgegebenen Aktien sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen
Aktien. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht wird,
wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxem-
burgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser
Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der
Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.
Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen
Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung
sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Ver-
sammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen
möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 10. Dezember 2008 anzumelden.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der ALTRUM SICAV (DZ BANK
International S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 an-
gefordert werden.
Luxemburg, im November 2008.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2008145676/755/30.
KBC Renta, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 23.669.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société, qui aura lieu le <i>12 décembre 2008i> à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2008 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2008
4. Décharge à donner aux dirigeants de la société de gestion
5. Nominations statutaires
6. Divers
Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des voix exprimées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire repré-
senter à l'Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.
Chaque actionnaire qui souhaite être présent ou se faire représenter à cette Assemblée doit déposer ses actions au
plus tard le 9 décembre 2008 aux guichets des institutions suivantes:
136037
Au Luxembourg:
KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg
En Belgique:
KBC Bank NV, 2, avenue du Port, B-1080 Bruxelles
CBC Banque S.A., 5, Grand'Place, B-1000 Bruxelles
Centea NV, 180, Mechelsesteenweg, B-2018 Anvers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2008145680/755/28.
Russia International Card Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 103.464.
NOTICE OF NOTEHOLDERS' MEETING AND CONSENT SOLICITATION
Russia International Card Finance S.A., a company incorporated with limited liability under the laws of Luxembourg
and subject to the law of 22 March 2004 on securitization, (the "Issuer"), HEREBY GIVES NOTICE to the holders (the
"Holders") of its outstanding Class 2004 9.75% Structured Receivables Notes due 2010 (the "Notes") that, pursuant to
the Trust Deed dated 1 November 2004 made among the Issuer; the Bank of New York Mellon, acting through its London
Branch (the "Trustee"); the Bank of New York (Luxembourg) S.A. (the "Luxembourg Agent"); and the Bank of New York
(the "Registrar"), as amended and supplemented by the First Supplemental Trust Deed dated 4 February 2005 made
among the same parties, (the "Trust Deed"), and pursuant to condition 15 of the terms and conditions which govern the
Notes (which terms and conditions are part of the Trust Deed) (the "Terms and Conditions"), that pursuant to the
provisions of the Trust Deed, a
MEETING OF THE HOLDERS
(the "Meeting") will be held at the offices of Hogan & Hartson, Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard, London EC4M
8BU, England on <i>17 December 2008i> at 11 a.m. London time for the purpose of considering and, if thought fit, passing the
resolutions set out below, which will be proposed as extraordinary resolutions (each, an "Extraordinary Resolution" and
together the "Extraordinary Resolutions") in accordance with the provisions of Schedule 3 of the Trust Deed (all capi-
talized terms used but not defined below shall have the meanings ascribed to them in the UCS Parent Undertaking and
the UCS Parent Pledge, as those documents are defined below).
On 7 November 2008 a meeting (the "Initial Meeting") of the Holders was held in order to consider and, if thought
appropriate pass, the Extraordinary Resolutions. Pursuant to the terms of the Trust Deed, the required quorum to pass
the Extraordinary Resolutions at the Initial Meeting was 75% of the principal amount of the Notes at that time being
outstanding (the "Initial Required Quorum"). The Initial Required Quorum was not achieved at the Initial Meeting and
the Initial Meeting was adjourned through want of quorum. The purpose of the Meeting is to reconvene the Initial Meeting
which was previously adjourned though want of quorum and, pursuant to the terms of the Trust Deed, the required
quorum to pass the Extraordinary Resolutions at the Meeting is 25% of the principal amount of the Notes for the time
being outstanding.
The Issuer and its advisers will host a global investor conference call on 10 December 2008. The conference call will
include an on-screen presentation describing the background to and rationale for the Extraordinary Resolutions. Members
of the management of Rosbank will also be available to answer Holders' questions. To receive dial-in details, a copy of
the on-screen presentation and participate in the conference call, Holders should contact the Information Agent, Lucid
Issuer Services Limited, on +44 20 7704 0880 or at rosbank@lucid-is.com, and register their details. Conference call
details and materials will be distributed to participating Holders 24 hours before the call.
Voting instructions in respect of the Initial Meeting returned by any Holder via the Clearing System prior to 11 a.m.
on 5 November 2008 shall remain in effect unless expressly withdrawn by such Holder. The deadline for the issue of
voting instructions (or the appointment of a proxy) is 11 a.m. London time on 15 December 2008.
The Meeting will be asked to consider the following Extraordinary Resolutions:
EXTRAORDINARY RESOLUTION NO. 1
"That this Meeting of the Holders of the outstanding Notes of the Issuer hereby:
(1) assents to the modification of the UCS Parent Undertaking, entered into on 1 November 2004 by ZAO United
Investments ("United Investments") (formerly ZAO KM Invest) and the Trustee (the "UCS Parent Undertaking") for the
purpose of facilitating the sale (the "Sale") by United Investments of 100% of the shares (the "UCS Shares") of United
Card Services ("UCS") to Global Payment Acquisition Corporation 4 (the "Buyer"), in the form of the marked-up version
of the UCS Parent Undertaking available for inspection by Holders during normal office hours at the office of the Principal
Paying Agent and made available at this Meeting, such modifications having the effect of providing that:
136038
(a) with the consent of the Trustee (which consent shall be granted pursuant to this Extraordinary Resolution), United
Investments shall be allowed to transfer the UCS Shares to the Buyer, who shall assume from United Investments the
rights and obligations of United Investments under the UCS Parent Undertaking by way of (i) a valid assignment or novation
of United Investments' rights and obligations under the UCS Parent Undertaking to the Buyer, or (ii) the execution of a
new UCS parent undertaking between the Buyer and the Trustee in substantially the same form as the UCS Parent
Undertaking;
(b) references to "NewCo" shall be replaced with references relating to "an Affiliate". This change will, in particular,
have the effect that, subject to the conditions set out in the UCS Parent Undertaking, the party who has assumed the
rights and obligations of the parent under the UCS Parent Undertaking (the "Current Parent") will be able to transfer the
UCS Shares to one of its Affiliates (as defined in the UCS Parent Undertaking) without the consent of the Trustee;
(c) the prohibition in the UCS Parent Undertaking on the Current Parent's ability (without the consent of the Trustee)
to sell, assign, pledge, or otherwise transfer all or any part of its right, title and interest in and to the UCS Shares shall
be amended so that such prohibition shall not apply to the UCS Shares in the case of a merger, consolidation or amal-
gamation of UCS with another entity as permitted by the Servicing Agreement;
(d) the conditions to be satisfied in respect of a transfer of the UCS Shares to an Affiliate of the Current Parent be
modified so that (i) such Affiliate shall be required either (x) to enter into a new UCS parent undertaking agreement and
new UCS parent pledge in substantially the same form as the then existing UCS parent pledge and UCS parent undertaking,
or (y) for it to assume (by way of assignment or novation) the rights and obligations of the Current Parent under the
then existing UCS parent pledge and UCS parent undertaking, and (ii) the Current Parent is obliged to deliver the legal
opinions required pursuant to the UCS Parent Undertaking to the Trustee at least five business days prior to a transfer
of the UCS Shares instead of ten business days;
(e) the prohibition on assignment of the UCS Parent Undertaking by the Current Parent be modified to allow the
Current Parent to assign, or novate the UCS Parent Undertaking (i) pursuant to a permitted transfer of the UCS Shares
under either the UCS Parent Undertaking or the Servicing Agreement, or (ii) with the written consent of the Trustee
(which consent shall only be granted if the Trustee is so instructed by an Extraordinary Resolution of the Holders); and
(f) to delete clause 3.6 of the UCS Parent Undertaking which limits transfer to "Eligible Shareholders" (being particularly
those affiliated to the Borrower or United Investments) and replace this provision so that, the Current Parent can transfer
the UCS Shares to an Affiliate of the Current Parent. In addition, the UCS Parent Undertaking shall be modified so that
an Affiliate that acquires the UCS Shares shall ensure that UCS continues to meet the requirements as set out in the UCS
Parent Undertaking that (i) UCS uses the Borrower as its exclusive settlement bank, (ii) UCS does not dispose of any
part of its merchant voucher processing and servicing business, and (iii) UCS does not issue any further shares (thereby
ensuring that the ownership of UCS is confined solely to the UCS Shares). Furthermore, the UCS Parent Undertaking
shall provide that an Affiliate that acquires the UCS Shares shall be liable to the Trustee (on behalf of the Holders) if UCS
is in breach of any of the obligations set out in this paragraph (1)(f) of this Extraordinary Resolution;
(2) assents to the modification of the Servicing Agreement, entered into on 1 November 2004 by the Issuer, UCS and
the Trustee ("Servicing Agreement") in the form of the marked-up version of the Servicing Agreement available for
inspection by Holders during normal office hours at the office of the Principal Paying Agent and made available at the
Meeting, such modification to have the effect of:
(a) allowing the Trustee to consent (which consent shall only be granted if the Trustee is so directed by this Extraor-
dinary Resolution) to the "Servicer" (as defined in the Servicing Agreement) creating, assuming or otherwise incurring
indebtedness that would otherwise be prohibited by clause 2.6(c) of the Servicing Agreement; and
(b) modifying the provision of the Servicing Agreement that obliges any owner (the "Successor Company") of the UCS
Shares, on a merger of the "Servicer" (as defined in the Servicing Agreement) with another entity, to assume the rights
and obligations (the "Assumption of Rights and Obligations") of the Current Parent under the UCS Parent Undertaking
and the Pledgor under the UCS Parent Pledge by way of the Successor Company entering into agreements ("Replacement
Agreements") in substantially the same form as the UCS Parent Undertaking and UCS Parent Pledge, so that (after the
modification of the Servicing Agreement proposed herein) the Assumption of Rights and Obligations may be effected
either by way of either (i) an assignment or novation of such rights and obligations under the UCS Parent Undertaking
and the UCS Parent to the Successor Company, or (ii) the Successor Company entering into Replacement Agreements.
(3) authorises and directs the Trustee to concur in and give its consent to the modifications referred to in paragraphs
(1) and (2) of this Extraordinary Resolution and, in order to give effect thereto, to execute with immediate effect the
relevant amendments to the UCS Parent Undertaking and the Servicing Agreement;
(4) authorises and directs the Trustee, pursuant to the terms of the UCS Parent Undertaking (as amended by the
aforementioned provisions of this Extraordinary Resolution) and the Pledge of Shares dated 1 November 2004 between
ZAO United Investments and Bank of New York Mellon (as amended and supplemented, the "UCS Parent Pledge") to
consent to a transfer of the UCS Shares by United Investments to the Buyer, subject to:
(a) the Buyer assuming from United Investments the rights and obligations of United Investments under the UCS Parent
Undertaking by way of (i) a valid assignment or novation of United Investments' rights and obligations under the UCS
Parent Undertaking to the Buyer, or (ii) the execution of a new UCS parent undertaking between the Buyer and the
Trustee in substantially the same form as the UCS Parent Undertaking; and
136039
(b) the rights and obligations of the Pledgor under the UCS Parent Pledge being assumed by the Buyer by way of either
(i) the UCS Shares being transferred to the Buyer but remaining subject to the UCS Parent Pledge with the rights and
obligations of the Pledgor (as defined in the UCS Parent Pledge) being assigned or novated to the Buyer, or (ii) the UCS
Shares be transferred to the Buyer free of the UCS Parent Pledge on condition that, simultaneously with such transfer,
the Buyer and the Trustee enter into a new UCS parent pledge in substantially the same form as the UCS Parent Pledge;
(5) authorises and directs the Trustee, pursuant to the terms of the UCS Parent Pledge, to consent to any transfer (a
"Future UCS Parent Pledge Transfer") of the rights and obligations of the Pledgor (from time to time) under the UCS
Parent Pledge to any Affiliate of the Current Parent (the "Acquiring Affiliate") in connection with the acquisition by the
Acquiring Affiliate of the UCS Shares pursuant to a transfer of the UCS Shares as permitted by the UCS Parent Undertaking
or the Servicing Agreement. Such Future UCS Parent Pledge Transfer shall be effected either by (i) the UCS Shares being
transferred to the Acquiring Affiliate but remaining subject to the UCS Parent Pledge with the rights and obligations of
the Pledgor (as defined in the UCS Parent Pledge) being assigned or novated to the Acquiring Affiliate, or (ii) the UCS
Shares being transferred to the Acquiring Affiliate free of the UCS Parent Pledge on condition that, simultaneously with
such transfer, the Acquiring Affiliate and the Trustee enter into a new UCS parent pledge in substantially the same form
as the UCS Parent Pledge;
(6) authorises and directs the Trustee to give its written consent, pursuant to Clause 2.6(c) of the Servicing Agreement
(as amended by paragraph (2) of this Extraordinary Resolution), to the party bearing the rights and obligations of the
"Servicer" as defined under the Servicing Agreement to assume or otherwise incur indebtedness in the form of a pro-
missory note or promissory notes to the Buyer or an Affiliate (as defined in the Servicing Agreement) of the Buyer in the
aggregate amount of up to US$140,000,000, to take place after the acquisition by the Buyer of the UCS Shares, with the
condition in each case that such indebtedness shall be expressly subordinated to all obligations of the Servicer under the
UCS Share Pledge, the UCS Parent Undertaking and all other agreements relating to the Notes;
(7) authorises and directs the Trustee, if required, to take all actions and sign all documents as the Trustee may agree
to be necessary to enact the above Extraordinary Resolutions; and
(8) agrees to discharge and exonerate the Trustee from all liability for which it may have become or may become
responsible under the Trust Deed or the Notes or otherwise in respect of any act or omission in connection with the
implementation of this Extraordinary Resolution."
Subject to the terms set forth in the Consent Solicitation Statement, the Borrower offers to pay each Holder whose
votes were not withdrawn and who validly votes in favour of Extraordinary Resolution No. 1, a cash payment of US$10
(ten US Dollars) per US$1000 (one thousand US Dollars) of outstanding principal amount of Notes that were validly
presented as voting in favour of Extraordinary Resolution No. 1 (the "Consent Payment").
The proposed Extraordinary Resolution No. 1 constitutes a single proposal and a consenting Holder must consent to
Extraordinary Resolution No. 1 in its entirety and may not consent selectively with respect to certain elements of Ex-
traordinary Resolution No. 1.
On the terms and subject to the satisfaction of the conditions contained in the Consent Solicitation Statement (the
"Consent Solicitation Statement") dated 16 October 2008 that was circulated to the Holders with the notice of the Initial
Meeting, if Extraordinary Resolution No. 1 passes, the Borrower shall pay, pursuant to the terms contained in the Consent
Solicitation Statement and the Consent Payment Deed (as defined in the Consent Solicitation Statement), to each Holder
who had validly voted in favour of Extraordinary Resolution No. 1, the Consent Payment (as defined in the Consent
Payment Deed).
If Extraordinary Resolution No. 1 is passed, the proposed amendments therein will become effective and binding on
all Holders, including non-consenting Holders and such non-consenting Holders will not be entitled to receive the Consent
Payment.
EXTRAORDINARY RESOLUTION NO. 2
"That this Meeting of the Holders of the outstanding Notes of the Issuer hereby agrees that:
(1) whereas in section 18(a) of the Terms and Conditions it is stated that the "...Notes and the Trust Deed and all
matters arising from or connected with the Notes and the Trust Deed are governed by and shall be construed in accor-
dance with, English law", purely for clarification purposes, this section 18(a) of the Terms and Conditions shall be amended
by adding a second sentence as follows:
"Articles 86 through to 94-8 (inclusive) of the Luxembourg Law of 10 August 1915 Concerning Commercial Companies
shall be expressly excluded.";
(2) authorises and directs the Trustee, if required, to take all actions and sign all documents as the Trustee may agree
to be necessary to enact the above Extraordinary Resolution; and
(3) agrees to discharge and exonerate the Trustee from all liability for which it may have become or may become
responsible under the Trust Deed or the Notes or otherwise in respect of any act or omission in connection with the
implementation of this Extraordinary Resolution."
Any questions in relation to the Consent Solicitation Statement may be directed to the Information Agent, Lucid Issuer
Services Limited, on +44 20 7704 0880 or at rosbank@lucid-is.com, or to the Borrower, Rosbank (OJSC JSCB) (attention:
136040
(i) Anton Pak, Managing Director of Corporate Development and Investor Relations, Rosbank (OJSC JSCB), Shepkina
str. 42/2a, Moscow, 129110 phone: +7 495 604 9593, fax: + 7 495 604 9607, e-mail: APak@rosbank.ru and (ii) Andrey
Ukolov, Head of Financial Institutions, Rosbank (OJSC JSCB), Masha Poryvayeva str. 11, Moscow, 107078, phone: +7 495
956 6727, fax: +7 495 725 2404, e-mail: AUkolov@rosbank.ru.
For further information regarding voting please contact the Information Agent, Lucid Issuer Services Limited, on +44
20 7704 0880 or at rosbank@lucid-is.com, or the Trustee, The Bank of New York Mellon, acting through its London
Branch, One Canada Square, London E14 5AL, England, (attention: (i) Iqbal Nasim, EMEA Structured Products Group,
phone: +44 207 964 8812, e-mail: iqbal.nasim@bnymellon.com, fax +44 207 964 2533 and (ii) Frederick Wayman, EMEA
Structured Products Group, phone: +44 207 964 8809, e-mail: frederick.wayman@bnymellon.com, fax: +44 207 964
2533) or the Luxembourg Agent, The Bank of New York (Luxembourg) S.A, Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof, L-1736
Senningerberg, Luxembourg (attention: Peter Bun, phone: +(352) 34 20 90 56 30, fax: +(352) 34 20 90 60 35).
You may also contact your broker, dealer, commercial bank or trust company nominee for assistance concerning the
Consent Solicitation Statement.
Référence de publication: 2008145530/250/180.
Kidsco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 130.586.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 décembre 2008i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination sociale de la Société en CESTO S.A.
2. Modification subséquente de l'article 1
er
des Statuts.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2008139770/581/13.
Life One, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 102.356.
Die Anteilinhaber der SICAV LIFE ONE werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Anteilinhaber am <i>5. Dezember 2008i> am Gesellschaftssitz 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großher-
zogtum Luxemburg um 11.00 Uhr eingeladen.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 31. Juli 2008
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für das abgelaufene Geschäftsjahr
4. Wahl/Wiederwahl des Verwaltungsrates
5. Wahl/Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Verschiedenes
Jeder Anteilinhaber ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Die Anteilinhaber müssen
ihre Teilnahme an der Generalversammlung bis zum 1. Dezember 2008, spätestens um 16.00 Uhr am Gesellschaftssitz
der Life One Sicav oder unter der Faxnummer 00352-2511-4401 anmelden.
Ein Anteilinhaber kann sich auf Grund schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Das Formular für
die Vollmacht ist am Gesellschaftssitz der Life One Sicav oder unter der Nummer 00352-2511-1 zu beziehen. Die Voll-
machten müssen ebenfalls bis zum 1. Dezember 2008, spätestens um 16.00 Uhr bei der Adresse der Life One Sicav
eingehen.
Es besteht kein Quorum für die Generalversammlung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der
anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber gefasst.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2008141423/755/28.
136041
Paro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 45.366.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra extraordinairement le vendredi <i>5 décembre 2008i> à 10.00 hrs au siège social de la société
à L-9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy, avec
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice
clôturé au 31.12.2007;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2007;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2008142078/832/20.
UT97 Global Fund, Fonds Commun de Placement.
The Board of Directors of JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., acting as management company to
the Portfolio, is putting the Portfolio into liquidation as of October 23, 2008, due to the reception of a request, of the
sole unitholder, for the redemption of all the units of UT97 GLOBAL FUND - EUR BOND PORTFOLIO.
Luxembourg, November 4, 2008.
JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>The Board of Directorsi>
Référence de publication: 2008143244/1232/10.
Vdo.nrg S. à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Photo Video Dichter).
Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 67.790.
L'an deux mille huit, le onze novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Jérôme DICHTER, photographe, demeurant à L-8227 Marner, 53, rue des Eglantiers,
agissant en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée PHOTO VIDEO DICHTER, avec siège
social à Dudelange, constituée suivant acte notarié en date du 17 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial C,
numéro 171 du 16 mars 1999. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 5 février
2008, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 587 du 8 mars 2008.
Lequel comprant a requis le notaire instrumentant d'acter qu'il prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de changer le nom de la Société de PHOTO VIDEO DICHTER en "Vdo.nrg S.à r.l."
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 3 des statuts de la Société comme suit:
«Art. 3. La société prend la dénomination de «Vdo.nrg S.à r.l.».»
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
136042
Signé: J. DICHTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 novembre 2008. Relation: LAC/2008/45459. - Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2008.
H. HELLINCKX.
Référence de publication: 2008143259/242/30.
(080169749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.
Vdo.nrg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 67.790.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2008.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2008143260/242/11.
(080169751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.
Sadin Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 58.284.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 6 novembre 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, a prononcé la dissolution et la liquidation de la société suivante:
SADIN HOLDING S.A., dont le siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, a été dénoncé en date
du 28 février 2006.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge au tribunal d'arrondissement et liqui-
dateur Maître Yves WAGENER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 27 novembre 2008 au greffe de la sixième
chambre de ce Tribunal.
Pour extrait conforme
M
e
Yves WAGENER
<i>Avocat à la Couri>
Référence de publication: 2008144674/7992/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2008, réf. LSO-CW06704. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080171073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2008.
VR Premium Fonds, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement des Umbrella-Fonds VR Premium Fonds, in Kraft getreten am 20. Oktober 2008, wurde
beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, im November 2008.
IPConcept Fund Management S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2008140497/1239/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03461. - Reçu 70,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080166100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.
136043
Bakerfin S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 63.870.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 6 novembre 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, a prononcé la dissolution et la liquidation de la société suivante:
BAKERFIN S.A., dont le siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, a été dénoncé en date du 16
décembre 2005.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge au tribunal d'arrondissement et liqui-
dateur Maître Yves WAGENER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 27 novembre 2008 au greffe de la sixième
chambre de ce Tribunal.
Pour extrait conforme
Me Yves WAGENER
Avocat à la Cour
Référence de publication: 2008144677/7992/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2008, réf. LSO-CW06700. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080171068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2008.
Thaleya S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 83.535.
Bodena, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 39.362.
PROJET DE FUSION
L'an deux mille huit, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Jean-Michel Schmit, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet
agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme THALEYA S.A., ayant son siège
social à L-2520 Luxembourg, allée Scheffer 1, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 83.535, constituée par acte reçu par le notaire Emile Schlesser le 23 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 157 du 29 janvier 2002 (ci-après, "Thaleya"),
en vertu d'une procuration lui conférée par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 14 novembre
2008 dont une copie, après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera
annexée au présent acte aux fins de formalisation, et
agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme BODENA S.A., ayant son siège
social à L-2520 Luxembourg, allée Scheffer 1, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 39.362, constituée par acte reçu par le notaire Martine Weinandy le 10 décembre 1991, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 293 de 1992 (ci-après, "Bodena"),
en vertu d'une procuration lui conférée par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 14 novembre
2008 dont une copie, après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera
annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Lequel comparant, dans sa qualité décrite ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion qui
suit:
<i>Projet de fusioni>
1) Lors de leurs réunions du 14 novembre 2008, les conseils d'administration des sociétés prémentionnées ont pris
la décision de réaliser une fusion par absorption de Bodena par Thaleya, ayant pour effet de transférer l'ensemble des
éléments d'actif et de passif de Bodena à Thaleya, conformément aux Articles 259 et suivants de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi").
2) Thaleya a un capital social qui est fixé à cinquante mille deux cent vingt euros (EUR 50.220-) et divisé en mille six
cent vingt (1.620) actions ayant une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, entièrement souscrites
136044
et libérés, et détient l'intégralité du capital social de Bodena et s'élevant à trente et un mille euros (EUR 31.000-) repré-
senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions ayant une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingt
centimes (EUR 24,80) chacune.
3) Thaleya (la "Société Absorbante") entend fusionner conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la
Loi et les textes subséquents, avec Bodena (la "Société Absorbée" et, ensemble avec la Société Absorbante, les "Sociétés
Fusionnantes") par absorption de cette dernière.
4) La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour compte de la Société Absorbante est fixée au 31 décembre 2008.
5) Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a d'actionnaires titulaires de droits spéciaux ou détenteurs de titres autres que
les actions.
6) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des Sociétés Fusion-
nantes.
7) La fusion prendra effet entre parties et vis-à-vis des tiers au 31 décembre 2008, après publication du présent projet
de fusion au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi.
8) L'actionnaire de la Société Absorbante a le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du projet de fusion, de prendre connaissance au siège social, des documents indiqués
à l'article 267 (1) a) b) et c) de la Loi et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.
9) L'actionnaire de la Société Absorbante, qui disposera de plus de 5% des actions du capital souscrit, a le droit de
requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de
la fusion, laquelle assemblée doit alors être tenue dans le mois de la réquisition.
10) A défaut de réquisition d'une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive,
comme indiqué ci-avant au point 7) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la Loi, à l'exception du
paragraphe (1) (b) de cet article.
11) La fusion s'effectuera sur base de la valeur comptable.
12) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société Absorbée prennent fin à la date de
la fusion et décharge pleine et entière est accordée aux organes de la Société Absorbée.
13) La Société Absorbante procèdera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la
cession de tous les avoirs et obligations de la Société Absorbée vers la Société Absorbante.
14) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société
Absorbante.
<i>Remises de titresi>
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de
tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres
de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les
valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments de
droit apportés.
<i>Frais et droitsi>
Les dépenses, frais, honoraires, rémunérations et charges de toutes espèces dus au titre de la fusion seront supportés
par la Société Absorbante et sont estimés à environ 1.000,- EUR.
La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
Le notaire soussigné déclare attester, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, de l'existence et
de la légalité des actes et des formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes ainsi que du présent projet de fusion.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise déclare par la présente qu'à la demande du mandataire des compa-
rants, le présent acte est suivi d'une version anglaise, et qu'à la demande du même mandataire des comparants, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.
Thereafter follows the English version of the preceding text:
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
Mr Jean-Michel Schmit, attorney-at-law, professionally residing at L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet
acting as duly authorised representative of the board of directors of the public limited liability company, THALEYA
S.A., having its registered office at L-2520 Luxembourg, allée Scheffer 1, registered with the Luxembourg trade and
136045
companies register under number B 83.535, incorporated pursuant to a deed of notary Emile Schlesser on 23 August
2001, published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations, number 157 on 29 January 2002 (hereafter
"Thaleya"),
by virtue of a proxy given by the board of directors, in accordance with the resolution taken during the meeting dated
November 14th, 2008, a copy of which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration, and
acting as duly authorised representative of the board of directors of the public limited liability company, BODENA
S.A, having its registered office at L-2520 Luxembourg, allée Scheffer 1, registered with the Luxembourg trade and com-
panies register under number B 39.362, incorporated pursuant to a deed of notary Martine Weinandy on 10 December
1991, published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations, number 293 in 1992 (hereafter "Bodena"),
by virtue of a proxy given by the board of directors, in accordance with the resolution taken during the meeting dated
November 14th, 2008, a copy of which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the
undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, duly represented as stated above, has requested the undersigned notary to draw-up the following
merger proposal:
<i>Merger proposali>
1) During their meetings of November 14th, 2008, the boards of directors of the above mentioned companies have
decided to carry out a merger by absorption of Bodena by Thaleya, by which all the assets and liabilities of Bodena will
be transferred to Thaleya, in accordance with Articles 259 and subsequent to the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended (the "Law").
2) Thaleya has a share capital amounting to fifty thousand two hundred twenty euros (EUR 50,220.-) and divided into
one thousand six hundred twenty (1,620) shares having a nominal value of thirty-one euros (EUR 31) each, fully subscribed
and paid up and holds the entire share capital of Bodena which amounts to thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-)
represented by one thousand two hundred fifty (1,250) shares having a nominal value of twenty-four euros and eighty
cents (EUR 24.80) each.
3) Thaleya (the "Absorbing Company") intends to merge with Bodena (the "Absorbed Company" and the Absorbing
Company will be referred to as the "Merging Companies") by absorption of the latter, in accordance with the provisions
of articles 278 and 279 of the Law and the subsequent provisions.
4) The date from which the transactions of the Absorbed Company will be considered, from an accountancy point of
view, complete on behalf of the Absorbing Company is set as of 31 December 2008.
5) None of the Merging Companies have shareholders entitled to specific rights or holder of securities other than
shares.
6) No specific advantage has been granted to any of the directors, statutory auditors or independent auditors of the
Merging Companies.
7) In accordance with the provisions of article 9 of the Law, the merger will be effective between the parties and vis-
à-vis third parties as from 31 December 2008, after publication of the present merger proposal in the Mémorial, Receuil
des Sociétés et Associations.
8) Within one month of the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the merger proposal,
the shareholder of the Absorbing Company is entitled to view the documents indicated in article 267 (1) a) b) and c) of
the Law and at the registered office can obtain a full copy free of charge and upon simple request.
9) Within the same period of time, the shareholder of the Absorbing Company owning more than 5% of the shares
of the subscribed capital is entitled to request the convening of a general meeting, which will decide on the approval of
the merger. Such meeting must be held within one month of the request to hold such.
10) If no meeting is convened or for the case that such a meeting has rejected the merger proposal, the merger will
become definitive, as indicated under item 7) and will trigger the effects proved for in article 274 of the Law, to the
exception of paragraph (1) (b) of the same article.
11) The merger is operated on the basis of the book values.
12) The directors and statutory auditors' mandates end the day of the merger and discharge will be granted to the
bodies of the Absorbed Company.
13) The Absorbing Company will assume all the necessary formalities which will give effect to the merger and to the
transfer of all the rights and obligations from the Absorbed Company to the Absorbing Company.
14) The corporate documents of the Absorbed Company will be kept at the registered office of the Absorbing Com-
pany for the necessary period required by law.
<i>Handing over of the sharesi>
Upon completion of the merger, the Absorbed Company will hand over to the Absorbing Company the originals of
all its articles of incorporation and association, accounting books and other accounting documents, property deeds or
other documentary evidence of property of all assets, documentary evidence of transactions, stock and other agreements,
archives as well as any other documents related to the contributed assets.
136046
<i>Expenses and rightsi>
All expenses, fees and remuneration of all kind due in relation to the merger will be assumed by the Absorbing Company
and are estimated to approximately EUR 1,000.-.
The Absorbing Company will settle, if the case arises, the taxes due by the Absorbed Company on the capital and on
the profits regarding the financial years that have not been taxed yet.
In accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the undersigned notary certifies the existence and
legality of the deeds and formalities falling to the Merging Companies as well as of the present merger proposal.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
Whereas this deed has been read and signed by Us and the appearing party already known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, and has also been signed by the notary himself .
The undersigned notary who understands English, states herewith that on request of the party mentioned above, a
French version proceeds the present deed which is worded in English on request of the party mentioned above, and in
case of discrepancies between the English and the French text, the French text will prevail.
(Signé): J.-M. SCHMIT, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 novembre 2008. Relation: LAC/2008/46133. - Reçu € 12.- (douze euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2008144796/206/170.
(080171653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2008.
UniGarantPlus: Klimawandel (2013), Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement des UniGarantPlus: Klimawandel (2013), welches am 24. September 2008 in Kraft tritt,
wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24. September 2008.
Union Investment Luxembourg S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2008145689/685/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05329. - Reçu 38,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080173186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2008.
Triple Crown, Fonds Commun de Placement.
JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (the "Management Company"), acting as management company
to the Fund, has decided, on May 30, 2008 with the approval of Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A., acting as
custodian to the Fund, to put the Fund into liquidation as of 14 August 2008 (the "Effective Date), at the close of business
in Luxembourg, because it is now at a level where the Fund is becoming too small to operate efficiently and it is not in
the interests of the shareholders to remain invested in the Fund.
JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>The Board of Directorsi>
Référence de publication: 2008143820/1232/11.
Cesare Fiorucci Luxco, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.983.
<i>Rectificatif de l'extrait déposé au RCS sous la référence: LSO-CU02546 premier dépôt L080135922.05 du 11/09/08i>
Il résulte des Résolutions du Gérant Unique de la société prises en date du 1
er
septembre 2008 que le siège social de
la société est transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
136047
<i>Pour CESARE FIORUCCI LUXCO
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008145474/795/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2008, réf. LSO-CW06791. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080172009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2008.
Longford Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 107.802.
Merton Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 107.793.
TERMS OF THE MERGER
Merger to be carried out by way of the absorption of the private limited liability company (société à responsabilité
limitée) Merton Finance S.à r.l. by the private limited liability company (société à responsabilité limitée) Longford Invest-
ments S.à r.l.
The board of managers of Longford Investments S.à r.l. (the Absorbing Company) and the board of managers of Merton
Finance S.à r.l. (the Absorbed Company) have decided to draw up the following terms of the merger in accordance with
the provisions of article 261 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law) and to
present the terms of the merger to their respective sole shareholder.
<i>1. Description of the mergeri>
The managers of the above companies propose to carry out the merger which will imply the transfer of all assets and
liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company, in accordance with the provisions of article 274 of the
Law.
The managers mutually undertake to take all required steps in order to carry out the merger, in accordance with the
conditions detailed hereafter and set out, hereby, the terms of the merger.
In accordance with article 272 of the Law, the merger will take effect between the Absorbed Company and the
Absorbing Company when the concurring decisions of the said companies shall have been adopted, i.e. on the date of
the adoption of the last resolutions of the sole shareholders of the merging companies approving the proposed merger
(the Effective Date).
The merger shall only take effect towards third parties after the publication of the resolutions of the sole shareholder
of each of the merging companies, in accordance with article 9 of the Law.
<i>2. Information provided under article 261 (2) of the Lawi>
a) General information regarding the merging companies
- The Absorbed Company
The private limited liability company (société à responsabilité limitée) Merton Finance S.à r.l. has its registered office
at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 107.793.
The Absorbed Company has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a
deed of M
e
Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on April 18, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et des Associations, N° - :939 of September 24, 2005.
The articles of association, as incorporated in the deed of incorporation of the Absorbed Company have not been
amended.
- The Absorbing Company
The private limited liability company (société à responsabilité limitée) Longford Investments S.à r.l. has its registered
office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 107.802.
The Absorbing Company has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a
deed of M
e
Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on April 18, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et des Associations, N° - 940 of September 24, 2005.
The articles of association, as incorporated in the deed of incorporation of the Absorbing Company have not been
amended.
136048
b) Share exchange ratio
The share exchange ratio is calculated on the basis of the nominal value of the shares of the Absorbing Company and
the Absorbed Company.
- The Absorbing Company
The subscribed share capital of the Absorbing Company is set at EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred euro)
consisting of 100 (one hundred) shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each.
- The Absorbed Company
The subscribed share capital of the Absorbed Company is set at EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred euro)
consisting of 100 (one hundred) shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each.
- Exchange for the contribution
In remuneration for the contribution of the assets and liabilities of the Absorbed Company, the Absorbing Company
will increase its share capital by an amount of EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred euro) so as to raise it from
its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred euro) to EUR 25,000 (twenty-five thousand euro)
through the issuance of 100 (one hundred) new shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five
euro) each, of the same kind and carrying the same rights and obligations as the existing shares of the Absorbing Company.
The newly issued shares of the Absorbing Company will be allocated to the sole shareholder of the Absorbed Company,
on the basis of an exchange ratio of 1 (one) share of the Absorbed Company for 1 (one) share of the Absorbing Company,
the number of shares so allocated being rounded to the nearest full number of shares:
* 100 (one hundred) shares to Dotcom Sagl;
No cash payment will be granted to the shareholders of the Absorbed Company.
Art. 6 of the articles of association of the Absorbing Company will be amended accordingly.
c) Terms for the delivery of the shares in the Absorbing Company
The newly issued shares will be registered in the shareholders register of the Absorbing Company as of the Effective
Date of the merger.
As a result of the merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its shares in issue will be cancelled.
d) Date as of which the newly issued shares shall carry the right to participate in the profits and any special condition
regarding such right
The newly issued shares will entitle their holder(s) to participate in the profits of the Absorbing Company as of January
1, 2008 and shall further be taken into consideration for the granting of any future dividends. This right is subject to no
special condition.
e) Date as of which the operations of the Absorbed Company shall be treated, for accounting purposes, as being
carried out on behalf of the Absorbing Company
The operations of the Absorbed Company shall be treated, for accounting purposes, as being carried out on behalf of
the Absorbing Company as of January 1, 2008.
f) Rights conferred by the Absorbing Company to shareholders having special rights and to holders of securities other
than shares
All shares of the Absorbed Company are identical and confer the same rights and advantaged to their holder so that
the Absorbing Company is not obliged to issue shares with special rights.
g) Special advantages granted to the experts referred to in article 266 of the Law, to the members of the board of
managers of the merging companies
Neither the experts referred to in article 266 of the Law, nor the members of the boards of managers of the merging
companies shall be entitled to receive any special advantages.
<i>3. Consequences of the mergeri>
3.1 The merger will trigger ipso jure all the consequences detailed in article 274 of the Law.
Indeed, as a result of the merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.
3.2 The Absorbing Company will become the owner of the assets contributed by the Absorbed Company as they exist
on the Effective Date, with no right of recourse whatsoever against the Absorbed Company.
3.3 The Absorbed Company guarantees to the Absorbing Company that the claims transferred as a result of the merger
are certain and due but does not guarantee the solvency of their respective debtors.
3.4 The Absorbing Company shall pay, as of the Effective Date, all taxes, contributions, duties, levies and insurance
premium which will or may become due with respect to the ownership of the assets which have been contributed.
3.5 As of the Effective Date the Absorbing Company shall perform all agreements and obligations whatsoever of the
Absorbed Company.
3.6 The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing
Company with all the securities, either in rem or personal, attached thereto. The Absorbing Company shall thus be
136049
subrogated, without novation, in all rights, whether in rem or personal, of the Absorbed Company with respect to all
assets and against all debtors without any exception.
3.7 The Absorbing Company shall incur all debts and liabilities of any kind of the Absorbed Company. In particular, it
shall pay interest and principal on all debts and liabilities of any kind incurred by the Absorbed Company.
3.8. All corporate documents of the Absorbed Company shall be kept at the registered office of the Absorbing Com-
pany for as long as prescribed by the Law.
3.9 The mandates of the members of the board of managers of the Absorbed Company will be terminated on the date
of effect of the merger. Full discharge will be given to the members of the board of managers for the performance of
their mandate.
<i>4. Additional provisionsi>
4.1 The cost of the merger will be incurred by the Absorbing Company.
4.2 The undersigned mutually undertake to take all steps in their power in order to carry out the merger in accordance
with the legal and statutory requirements of both companies.
4.3 The Absorbing Company shall carry out all required and necessary formalities in order to carry out the merger
as well as the transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company.
4.4 The shareholders of the merging companies shall be entitled to inspect the following documents at the registered
office of the said companies, at least one month before the date of the adoption of the last resolutions of the sole
shareholder of each company regarding the terms of the merger: terms of the merger, report from the expert referred
to in article 266 of the Law, board of managers' reports, annual accounts and annual reports of the merging companies
for the last three financial years and, if necessary, a recent accounting statement. A copy of the above mentioned docu-
ments will be obtainable upon request.
5. The present document has been drawn up in Luxembourg on November 17 2008, in original, in order to be
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and to be published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et des Associations, at least one month prior to the date of the adoption of the last resolutions of the sole
shareholders regarding the terms of the merger, in accordance with article 262 of the Law.
Suit la version française du texte qui précède
PROJET DE FUSION
Fusion à accomplir par absorption de la société à responsabilité limitée Merton Finance S.à r.l. par la société anonyme
Longford Investments S.à r.l.
Le conseil de gérance de Longford Investments S.à r.l. (la Société Absorbante) et le conseil de gérance de Merton
Finance S.à r.l. (la Société Absorbée) ont décidé d'établir le présent projet de fusion, conformément aux dispositions de
l'article 261 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et de présenter ledit projet
de fusion à leur associé unique respectif.
<i>1. Description de la fusioni>
Les gérants des sociétés précitées proposent d'effectuer une fusion ayant pour effet la transmission universelle de
l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante et ce conformément aux dispo-
sitions de l'article 274 de la Loi.
Les gérants s'engagent réciproquement à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de réaliser ladite
fusion aux conditions définies ci-après et fixent par la présente, le projet de fusion.
Conformément à l'article 272 de la Loi, la fusion entrera en vigueur entre la Société Absorbée et la Société Absorbante
lorsque seront intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en question, c'est-à-dire, à la date
d'adoption des dernières résolutions des associés uniques des sociétés fusionnantes approuvant la fusion (la Date Effec-
tive).
La fusion n'aura d'effet à l'égard des tiers qu'après la publication des résolutions des associés uniques de chacune des
sociétés fusionnantes, conformément à l'article 9 de la Loi.
<i>2. Mentions prévues sous l'article 261 (2) de la Loii>
a) Renseignements généraux concernant les sociétés concernées par la fusion
- La Société Absorbée
La société à responsabilité limitée Merton Finance S.à r.l. a son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg
et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.793.
La Société Absorbée a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte de M
e
Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 18 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associa-
tions, N° - 939 du 24 septembre 2005.
Les statuts de la Société Absorbée n'ont pas été modifiés.
- La Société Absorbante
136050
La société à responsabilité limitée Longford Investments S.à r.l. a son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.802.
La Société Absorbante a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte de M
e
Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 18 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associa-
tions, N° - 940 du 24 septembre 2005.
Les statuts de la Société Absorbante n'ont pas été modifiés.
b) Rapport d'échange des parts sociales
Le rapport d'échange des parts sociales s'établira sur base de la valeur nominale des parts sociales de la Société
Absorbée et de la Société Absorbante.
- La Société Absorbante
Le capital souscrit de la Société Absorbante s'élève à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 100
(cent) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.
- La Société Absorbée
Le capital souscrit de la Société Absorbée s'élève à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 100
(cent) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.
- Rémunération de l'apport
En contrepartie de l'apport des actifs et passifs de la Société Absorbée, la Société Absorbante procédera à l'augmen-
tation de son capital social à concurrence de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) pour le porter de son montant
actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 25.000 (vingt-cinq mille euros) par l'émission de 100 (cent)
nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, de même nature et
conférant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes de la Société Absorbante.
Les parts sociales nouvellement émises de la Société Absorbante seront attribuées à l'associé unique de la Société
Absorbée, en appliquant le rapport d'échange de 1 (une) part sociale de la Société Absorbante pour 1 (une) part sociale
de la Société Absorbée, le nombre de parts sociales ainsi attribué étant arrondi au nombre entier le plus proche:
* 100 (cent) part sociale à Dotcom Sagl;
Aucune soulte ne sera payée aux associés de la Société Absorbée.
L'article 6 des statuts de la Société Absorbante sera modifié en conséquence.
c) Modalités de remise des parts sociales de la Société Absorbante
Les parts sociales nouvellement émises seront inscrites dans le registre des associés de la Société Absorbante à compter
de la Date Effective de la fusion.
Par l'effet de la fusion, la Société Absorbée sera dissoute et toutes les parts sociales alors émises par ladite société
seront annulées.
d) Date à partir de laquelle les parts sociales nouvellement émises donneront droit de participer aux bénéfices ainsi
que toute modalité particulière relative à ce droit
Les parts sociales nouvellement émises donneront droit à leurs détenteurs de participer aux bénéfices de la Société
Absorbante à compter du 1
er
janvier 2008 et seront en outre prises en compte pour l'attribution de tous dividendes
futurs. Aucune condition spéciale ne sera attachée à ce droit.
e) Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable
comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante
Les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le
compte de la Société Absorbante à compter du 1
er
janvier 2008.
f) Droits conférés par la Société Absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres
que des parts sociales
Toutes les parts sociales de la Société Absorbée sont identiques et confèrent les mêmes droits et avantages à leurs
détenteurs de sorte qu'il n'y a pas lieu de créer au sein de la Société Absorbante des parts sociales conférant des droits
spéciaux.
g) Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 266 de la Loi, aux membres des conseils de gérance
des sociétés qui fusionnent
Ni les experts au sens de l'article 266 de la Loi, ni les membres des conseils de gérance des sociétés qui fusionnent
n'auront le droit de recevoir aucun avantage particulier.
<i>3. Effets de la fusioni>
3.1 La fusion par absorption entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par l'article 274 de la Loi.
Ainsi, par l'effet de la fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes les parts sociales alors émises par ladite
société seront annulées.
136051
3.2 La Société Absorbante deviendra propriétaire des actifs qui lui ont été apportés par la Société Absorbée dans l'état
où ils se trouvent à la Date Effective, sans droit de recours contre la Société Absorbée pour quelque raison que ce soit.
3.3 La Société Absorbée garantit à la Société Absorbante que les créances cédées dans le cadre de la fusion sont
certaines et liquides mais ne garantit pas la solvabilité des débiteurs cédés.
3.4 La Société Absorbante acquittera, à compter de la Date Effective, tous impôts, contributions, taxes, redevances et
primes d'assurances, qui grèveront ou pourront grever la propriété des actifs apportés.
3.5 Dès la Date Effective, la Société Absorbante exécutera tous contrats et obligations de quelque nature que soit de
la Société Absorbée.
3.6 Les droits et créances compris dans le patrimoine de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante
avec toutes les garanties tant réelles que personnelles qui y sont attachées. La Société Absorbante sera ainsi subrogée,
sans novation, dans tous les droits réels et personnels de la Société Absorbée relativement à l'ensemble des actifs et
contre tous les débiteurs sans exception.
3.7 La Société Absorbante assumera toutes les obligations et dettes, de quelque nature que ce soit, de la Société
Absorbée. En particulier, elle paiera en principal et intérêt, toutes dettes et obligations, de quelque nature que ce soit,
incombant à la Société Absorbée.
3.8 Tous les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la
Société Absorbante.
3.9 Les mandats des membres du conseil de gérance de la Société Absorbée prendront fin à la date d'effet de la fusion.
Décharge entière sera donnée aux membres du conseil de gérance pour l'exercice de leurs mandats.
<i>4. Mentions complémentairesi>
4.1 Le coût de l'opération de fusion sera supporté par la Société Absorbante.
4.2 Les soussignés s'engagent mutuellement et réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser la
fusion en respectant les prescriptions légales et les dispositions statutaires des deux sociétés.
4.3 La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires et utiles pour donner effet à la fusion ainsi
que pour réaliser le transfert de tous les avoirs et obligations de la Société Absorbée à la Société Absorbante.
4.4 Les associés des sociétés qui fusionnent auront le droit, au moins un mois avant la date d'approbation des dernières
résolutions des associés uniques de chaque société relative au projet de fusion, de prendre connaissance des documents
suivants au siège social desdites sociétés: projet de fusion, rapports des réviseurs d'entreprises en application de l'article
266 de la Loi , rapports des conseils de gérance, comptes annuels et rapports de gestion des sociétés fusionnantes des
trois derniers exercices et, si nécessaire, un état comptable récent. Une copie des documents susmentionnés pourra être
obtenue sur demande.
5. Le présent texte est établi le 17 novembre 2008 à Luxembourg, en original, aux fins d'être déposé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg et d'être publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, au
moins un mois avant la date d'adoption des dernières résolutions des associés uniques relatives au projet de fusion,
conformément à l'article 262 de la Loi.
<i>Pour la Société Absorbante / Pour la Société Absorbée
i>Frank WALENTA / B. ZECH
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2008144707/2460/254.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2008, réf. LSO-CW06519. - Reçu 36,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080171609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2008.
Finkerri S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 66.352.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 6 novembre 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, a prononcé la dissolution et la liquidation de la société suivante:
FINKERRY S.A., dont le siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, a été dénoncé en date du 9
décembre 2005.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge au tribunal d'arrondissement et liqui-
dateur Maître Yves WAGENER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 27 novembre 2008 au greffe de la sixième
chambre de ce Tribunal.
136052
Pour extrait conforme
Me Yves WAGENER
<i>Avocat à la Couri>
Référence de publication: 2008144676/7992/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2008, réf. LSO-CW06701. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080171071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2008.
Thaleya S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 83.535.
Oakville Invest Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 109.386.
L'an deux mille huit, le le dix-sept novembre,
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
Monsieur Jean-Michel Schmit, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet,
agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme THALEYA S.A., ayant son siège
social à L-2520 Luxembourg, allée Scheffer 1, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 83.535, constituée par acte reçu par le notaire Emile Schlesser le 23 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 157 du 29 janvier 2002 (ci-après, "Thaleya"),
en vertu d'une procuration lui conférée par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 14 novembre
2008 dont une copie, après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera
annexée au présent acte aux fins de formalisation, et
agissant en tant que mandataire du conseil de gérance de la société à responsabilité limitée OAKVILLE INVEST LIMITED
S.À R.L., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, allée Scheffer 1, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 109.386, initialement constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques sous le
nom de "Oakville S.à r.l." le 10 août 1987, avec son siège statuaire et principal établissement à Tortola, Mill Mall, Toad
Town, Iles Vierges Britanniques, et existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques jusqu'au 3 juin 2005, quand son
siège social fût transféré au Luxembourg et ses statuts refondus par acte notarié établi par devant le notaire Jean-Joseph
Wagner le 3 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1180 du 10 novembre 2005
(ci-après, "Oakville"),
en vertu d'une procuration lui conférée par décision du conseil de gérance prise en sa réunion du 14 novembre 2008
dont une copie, après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera
annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Lequel comparant, dans sa qualité décrite ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion qui
suit:
<i>Projet de fusioni>
1) Lors de leurs réunions du 14 novembre 2008, les conseils d'administration et de gérance des sociétés prémention-
nées ont pris la décision de réaliser une fusion par absorption de Oakville par Thaleya, ayant pour effet de transférer
l'ensemble des éléments d'actif et de passif de Oakville à Thaleya, conformément aux Articles 259 et suivants de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi").
2) Thaleya a un capital social qui est fixé à cinquante mille deux cent vingt euros (EUR 50.220) et divisé en mille six
cent vingt (1.620) actions ayant une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune, entièrement souscrites et
libérés, et détient l'intégralité du capital social de Oakville et s'élevant à soixante-quatorze mille euros (EUR 74.000),
représenté par deux mille neuf cent soixante (2.960) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25) chacune.
3) Thaleya (la "Société Absorbante") entend fusionner conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la
Loi et les articles subséquents, avec Oakville (la "Société Absorbée" et, ensemble avec la Société Absorbante, les "Sociétés
Fusionnantes") par absorption de cette dernière.
4) La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour compte de la Société Absorbante est fixée au 31 décembre 2008.
5) Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a d'actionnaires titulaires de droits spéciaux ou détenteurs de titres autres que
les actions.
136053
6) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des Sociétés Fusion-
nantes.
7) La fusion prendra effet entre parties et vis-à-vis des tiers au 31 décembre 2008, après publication du présent projet
de fusion au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi.
8) L'actionnaire de la Société Absorbante a le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du projet de fusion, de prendre connaissance au siège social, des documents indiqués
à l'article 267 (1) a) b) et c) de la Loi et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.
9) L'actionnaire de la Société Absorbante, qui disposera de plus de 5% des actions du capital souscrit, a le droit de
requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de
la fusion, laquelle assemblée doit alors être tenue dans le mois de la réquisition.
10) A défaut de réquisition d'une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive,
comme indiqué ci-avant au point 7) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la Loi, à l'exception du
paragraphe (1) (b) de cet article.
11) La fusion s'effectuera sur base de la valeur comptable.
12) Les mandats des gérants de la Société Absorbée prennent fin à la date de la fusion et que décharge pleine et entière
est accordée aux gérants de la Société Absorbée.
13) La Société Absorbante procèdera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la
cession de tous les avoirs et obligations de la Société Absorbée vers la Société Absorbante.
14) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société
Absorbante.
<i>Condition suspensivei>
Les conseils de gérance et d'administration des Sociétés Fusionnantes consentent expressément que, préalablement
à ce projet de fusion, le projet de fusion entre Thaleya et Bodena S.A, une société anonyme régie par le droit luxem-
bourgeois dont le siège social se situe au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39.362, ait été acté.
<i>Remises de titresi>
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de
tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres
de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les
valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments de
droit apportés.
<i>Frais et droitsi>
Les dépenses, frais, honoraires, rémunérations et charges de toutes espèces dus au titre de la fusion seront supportés
par la Société Absorbante et sont estimés à environ 1.000,- EUR.
La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
Le notaire soussigné déclare attester, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, de l'existence et
de la légalité des actes et formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes ainsi que du présent projet de fusion.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise déclare par la présente qu'à la demande du mandataire des compa-
rants, le présent acte est suivi d'une version anglaise, et qu'à la demande du même mandataire des comparants, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.
Thereafter follows the English version of the preceding text:
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
Mr Jean-Michel Schmit, attorney-at-law, professionally residing at L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet,
acting as duly authorised representative of the board of directors of the public limited liability company, THALEYA
S.A., having its registered office at L-2520 Luxembourg, allée Scheffer 1, registered with the Luxembourg trade and
companies register under number B 83.535, incorporated pursuant to a deed of notary Emile Schlesser on 23 August
2001, published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations, number 157 on 29 January 2002 (hereafter
"Thaleya"),
by virtue of a proxy given by the board of directors, in accordance with the resolution taken during the meeting dated
November 14th, 2008, a copy of which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration, and
136054
acting as duly authorised representative of the board of managers of the private limited liability company, OAKVILLE
INVEST LIMITED S.à r.l., having its registered office at L-2520 Luxembourg, allée Scheffer 1, registered with the Luxem-
bourg trade and companies register under number B 109.386, originally incorporated under the laws of the British Vigin
Islands laws under the name of "Oakville S.à r.l." on 10 August 1987, having its statutory seat and principal establishment
at Tortola, Mill Mall, Toad Town, British Virgin Islands and existing under the laws of the British Virgin Islands until 3 June
2005, when its registered office was transferred to Luxembourg and its articles restated by a notorial deed before notary
Jean-Joseph Wagner on 3 June 2005 published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations, number 1180 on
10 November 2005 (hereafter "Oakville"),
by virtue of a proxy given by the board of directors, in accordance with the resolution taken during the meeting dated
November 14th, 2008, a copy of which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the
undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, duly represented as stated above has requested the undersigned notary to draw-up the following
merger proposal:
<i>Merger proposali>
1) During their meetings of November 14th, 2008, the boards of directors the board of managers of the above
mentioned companies have decided to carry out a merger by absorption of Bodena by Thaleya, by which all the assets
and liabilities of Bodena will be transferred to Thaleya, in accordance with Articles 259 and subsequent to the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law").
2) Thaleya has a share capital amounting to fifty thousand two hundred twenty euros (EUR 50,220.-) and divided into
one thousand six hundred twenty (1,620) shares having a nominal value of thirty-one euros (EUR 31) each, fully subscribed
and paid up and holds the entire share capital of Oakville which amounts to seventy-four thousand euros (EUR 74,000.-)
represented by two thousand nine hundred sixty (2,960) shares having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-)
each.
3) Thaleya (the "Absorbing Company") intends to merge with Bodena (the "Absorbed Company" and the Absorbing
Company will be referred to as the "Merging Companies") by absorption of the latter, in accordance with the provisions
of articles 278 and 279 of the Law and the subsequent provisions.
4) The date from which the transactions of the Absorbed Company will be considered, from an accountancy point of
view, complete on behalf of the Absorbing Company is set as from of 31 December 2008.
5) None of the Merging Companies have shareholders entitled to specific rights or holder of securities other than
shares.
6) No specific advantage has been granted to any of the directors, statutory auditors or independent auditors of the
Merging Companies.
7) In accordance with the provisions of article 9 of the Law, the merger will be effective between the parties and vis-
à-vis third parties as from 31 December 2008, after publication of the present merger proposal in the Mémorial, Receui
Spéciall des Sociétés et Associations.
8) Within one month of the publication in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations of the merger proposal,
the shareholder of the Absorbing Company is entitled to view the documents indicated in article 267 (1) a) b) and c) of
the Law at the registered office and can obtain a full copy free of charge and upon simple request.
9) Within the same period of time, the shareholder of the Absorbing Company owning more than 5% of the shares
of the subscribed capital is entitled to request the convening of a general meeting, which will decide on the approval of
the merger. Such meeting must be held within one month of the request to hold such.
10) If no meeting is convened or for the case that such a meeting has rejected the merger proposal, the merger will
become definitive, as indicated under item 7) and will trigger the effects proved for in article 274 of the Law, to the
exception of paragraph (1) (b) of the same article.
11) The merger is operated on the basis of the book values.
12) The directors and statutory auditors' mandates end the day of the merger and discharge will be granted to the
bodies of the Absorbed Company.
13) The Absorbing Company will assume all the necessary formalities which will give effect to the merger and to the
transfer of all the rights and obligations from the Absorbed Company to the Absorbing Company.
14) The corporate documents of the Absorbed Company will be kept during the applicable legal period of time at the
registered office of the Absorbing Company for the necessary period required by the law.
<i>Condition precedenti>
The board of directors and board of managers of the Merging Companies expressly agree that, prior to the present
merger proposal, the merger proposal between Thaleya and Bodena S.A, a public limited liability company incorporated
under the Luxembourg laws having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and registered with the
Luxembourg trade and companies register under number B 39.362 had been acted.
136055
<i>Handing over of the sharesi>
Upon completion of the merger, the Absorbed Company will hand over to the Absorbing Company the originals of
all its articles of incorporation and association, accounting books and other accounting documents, property deeds or
other evidence of property of all assets, documentary evidence of transactions, stock and other agreement, archives as
well as any other documents related to the contributed assets.
<i>Expenses and rightsi>
All expenses, fees and remuneration of all kind due in relation to the merger will be assumed by the Absorbing Company
and are estimated to approximately EUR 1,000.-.
The Absorbing Company will settle, if the case arises, the taxes due by the Absorbed Company on the capital and on
the profits regarding the financial years that have not been taxed yet.
In accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the undersigned notary certifies the existence and
legality of the deeds and formalities falling to the Merging Companies as well as of the present merger proposal.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
Whereas this deed has been read and signed by Us and the appearing party already known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, and has also been signed by the notary himself.
The undersigned notary who understands English, states herewith that on request of the party mentioned above, a
French version proceeds the present deed which is worded in English on request of the party mentioned above, and in
case of discrepancies between the English and the French text, the French text will prevail.
Signé: J.-M.SCHMIT, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 novembre 2008. Relation: LAC/2008/46135. - Reçu € 12.- (douze euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Pour expedition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2008144795/206/187.
(080171658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2008.
Sinvar Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 71.383.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 6 novembre 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, a prononcé la dissolution et la liquidation de la société suivante:
SINVAR HOLDING S.A., dont le siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, bd du Prince Henri, a été dénoncé en date
du 31 janvier 2006.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge au tribunal d'arrondissement et liqui-
dateur Maître Yves WAGENER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 27 novembre 2008 au greffe de la sixième
chambre de ce Tribunal.
Pour extrait conforme
Me Yves WAGENER
Avocat à la Cour
Référence de publication: 2008144679/7992/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2008, réf. LSO-CW06706. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080171076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2008.
Ellegi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 117.756.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 29 octobre 2008i>
1. Le siège social de la Société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412 F, route d'Esch,
L-2086 Luxembourg à compter de ce jour.
2. L'adresse professionnelle des Administrateurs suivants de la société est modifié comme suit:
136056
- Madame Nicole THIRION, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à Luxembourg
(L-2086)
- Monsieur Thierry SIMONIN, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à Luxembourg
(L-2086)
- Monsieur Harald CHARBON, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à Luxembourg
(L-2086)
3. Il est pris acte du changement de siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A.,
Commissaire aux Comptes de la Société, désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 octobre 2008.
Certifié conforme
<i>ELLEGI S.A.
i>H. CHARBON / T. SIMONIN
<i>Administrateur et Président du Conseil d'Administration / Administrateuri>
Référence de publication: 2008143815/795/26.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02616. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080169151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2008.
Jost Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: EUR 33.575.075,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 107.073.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008142031/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02869. - Reçu 36,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080166833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.
Le Bourgeon SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 49.296.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008143695/1137/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04609. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080168444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2008.
WP Roaming S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.903.850,00.
Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 110.016.
Il résulte de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 29 octobre 2008 que l'associé unique a pris acte
de la démission de Monsieur Vince Tallent de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 août 2008 et a nommé
la personne suivante en tant que gérant et chief financial officer de la Société à partir du 20 octobre 2008 et ce jusqu'à la
prochaine décision de l'associé unique approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2008 de la Société:
- Monsieur Jean Mandeville, gérant, né le 24 février 1960 à Brasschaat, Belgique, demeurant professionnellement au 2,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Luxembourg,
de sorte que le conseil de gérance est désormais composé comme suit
136057
- M. Jean Mandeville;
- M. Martin Lippert;
- Mr Morten Brogger.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2008.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008143816/260/24.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2008, réf. LSO-CW01787. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080168395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2008.
Trident Locations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 93.168.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 septembre 2008i>
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2009:
- Madame Dominique JONES-PICHERIT Administrateur-délégué, demeurant professionnellement au 2a, rue des Ca-
pucins L-1313 Luxembourg, Président;
Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2008144186/534/17.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04382. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080169645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.
Induserv Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-3961 Ehlange, 7A, Am Brill.
R.C.S. Luxembourg B 72.035.
L'Assemblée Générale du 14 août 2006 accepte la démission de Madame Mireille Kronz du Conseil d'Administration.
Un nouvel administrateur est nommé:
Monsieur Claude KREMER, comptable, professionnellement domicilié à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, «Am Brill»
<i>Pour Induserv Holding S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008144184/1113/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04289. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080169754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.
Compagnie Luxembourgeoise de Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 52.383.
- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey à LUXEMBOURG (L-2086) au 412F, route d'Esch
à LUXEMBOURG (L-2086) à compter de ce jour.
- L'adresse professionnelle des Administrateurs suivants de la société est modifiée comme suit:
* Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à LU-
XEMBOURG (L-2086)
* Madame Antonella GRAZIANO, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à LU-
XEMBOURG (L-2086)
136058
* Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à LUXEM-
BOURG (L-2086)
- Le siège social de la société FIN-CONTROLE S.A., Commissaire aux Comptes de la Société, est désormais situé au
12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, à LUXEMBOURG (L-1882)
Luxembourg, le 27 octobre 2008.
<i>COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS S.A.
i>A. GRAZIANO / P. MESTDAGH
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2008143819/795/24.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02604. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080169161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2008.
Gruppo Fabbri International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 45.723.
Au terme du Conseil d'Administration tenu au siège social le 1
er
juillet 2008 il a été décidé:
- de transférer le siège social de la société du 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, au 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, avec effet au 1
er
juillet 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A.
i>Régis DONATI / Vincent THILL
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008143744/24/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04345. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080168634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2008.
Orion Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 65.588.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2008.
<i>Pour ORION PARTICIPATIONS S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008142032/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2008, réf. LSO-CW01218. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080166828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.
Eurostampa International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 126.254.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2008i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2013:
<i>Administrateur de catégorie A:i>
Monsieur Gian Franco CILLARIO, administrateur de sociétés, demeurant à 12068 Narzole (CN), Via Maggior Chiari
77, Italie.
136059
<i>Administrateurs de catégorie B:i>
Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président,
Monsieur Pierre LENTZ, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2013:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2008.
Référence de publication: 2008144185/534/24.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04370. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080169685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.
Eurfinance SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 38.453.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008143696/1137/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04602. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080168437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2008.
Exante S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: EUR 762.245,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 64.455.
Avec effet au 20 juin 2008, le siège social de la Société a été transféré au:
33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
<i>Exante Sarl, en liquidation
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008143758/5499/16.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04454. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080168497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2008.
WP Roaming III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.859.250,00.
Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 109.535.
Il résulte de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 29 octobre 2008 que l'associé unique a pris acte
de la démission de Monsieur Vince Tallent de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 août 2008 et a nommé
la personne suivante en tant que gérant et chief financial officer de la Société à partir du 20 octobre 2008 et ce jusqu'à la
prochaine décision de l'associé unique approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2008 de la Société:
- Monsieur Jean Mandeville, gérant, né le 24 février 1960 à Brasschaat, Belgique, demeurant professionnellement au 2,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Luxembourg,
de sorte que le conseil de gérance est désonnais composé comme suit
- M. Jean Mandeville;
136060
- M. Martin Lippert;
- Mr Morten Brogger.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2008.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2008143818/260/24.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2008, réf. LSO-CW01788. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080168390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2008.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS TAMISE, société anonyme de gestion de patrimoine familial, Société
Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 45.498.
Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14.11.2008.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme, Luxembourg
<i>Cabinet d'Experts Comptables
i>Signature
Référence de publication: 2008143821/687/16.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03413. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080168581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2008.
Checkfree Solutions S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 81.879.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 5 novembre 2008i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 novembre 2008 tenue au 24, avenue
Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg que:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de révoquer avec effet immédiat Monsieur Chris ANDERSON en tant qu'administrateur de caté-
gorie B de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer en remplacement de Monsieur Chris ANDERSON, prénommé, Monsieur John FIBLY,
administrateur de catégorie B, né à London, Otario (Canada) le 14 septembre 1962, demeurant professionnellement à
255, Fiserv Drive, Brookfield, WI 53045 (Etats-Unis d'Amérique).
En application de l'article 52 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée,
Monsieur John FIBLY achèvera le mandat de son prédécesseur.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de révoquer rétroactivement à compter du 1
er
septembre 2008 Monsieur Mark, Stanley CAPPELL
en tant qu'administrateur de catégorie B de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
136061
Luxembourg, le 5 novembre 2008.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008144187/1729/30.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04523. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080169501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.
CIS Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 104.282.
In the year two thousand and eight, on the thirtieth day of October.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
Maître Tom Loesch, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as special attorney-in-fact of the board of directors of CIS Luxembourg S.A., a société anonyme
governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 12, rue Leon Thyes, L-2636 Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of Maître Léon Thomas, known as Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg, on 22 November
2004, published in Mémorial C number 106 on 4 February 2005, entered in the Luxembourg Register of Commerce and
Companies, Section B, under the number 104.282, the articles of incorporation of which have been amended for the last
time following a deed of the undersigned notary on 13 July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1786 of 23 September 2006 (the "Company"),
by virtue of the authority conferred on him by resolutions of the board of directors on 9 October 2008, a copy of
which resolutions, signed "ne varietur" by the attorney-in-fact and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed with which it shall be formalised.
The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following
declarations and statements:
I. The issued share capital of the Company is presently set at six hundred twenty thousand US Dollars (USD 620,000.-)
divided into six hundred twenty (620) redeemable shares, each of a nominal value of one thousand US Dollars (USD
1,000.-) and each with the rights and privileges as defined herein, redeemable shares.
II. Pursuant to article 6 of the Company's articles of association, the authorised capital of the Company has been set
at two million US Dollars (USD 2,000,000.-) to be divided into two thousand (2,000) shares, each with a nominal value
of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) and pursuant to the same article 6, the board of directors of the Company
has been authorised to increase the issued share capital of the Company, such article of the articles of association then
to be amended so as to reflect the increase of capital.
III. The directors of the Company, by resolutions adopted at the meeting of the board of directors held on 9 October
2008, and in accordance with the authority conferred on them pursuant to article 6 of the Company's articles of asso-
ciation, have decided to increase of the Company's issued share capital by an amount of five hundred ten thousand US
Dollars (USD 510,000.-) in order to raise the issued share capital to the amount of one million one hundred thirty thousand
US Dollars (USD 1,130,000.-) by the creation of five hundred ten (510) new redeemable shares with a par value of one
thousand US Dollars (USD 1,000.-) having the same rights and privileges as the already existing redeemable shares.
IV. The directors of the Company, by resolutions adopted at the meeting of the board of directors held on 9 October
2008, have decided subject to the confirmation by Mr Cathal Anthony Lyons, director of the Company, of the receipt of
the relevant subscription monies, which confirmation has occurred on 21 October 2008, to issue five hundred ten (510)
new redeemable shares with a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) having the same rights and privileges
as the already existing redeemable shares and to cancel the preferential subscription rights of the existing shareholders.
V. Mr Cathal Anthony Lyons, director of the Company, has confirmed in a written resolution dated 21 October 2008,
in accordance with the resolutions adopted at the meeting of the board of directors held on 9 October 2008, that these
new redeemable shares have been entirely subscribed and fully paid up by contribution in cash to the Company, so that
the total amount of five hundred ten thousand US Dollars (USD 510,000.-) representing the aggregate amount of the
above mentioned capital increase has been on 21 October 2008 at the free disposal of the Company, as was evidenced
to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments and that the issue and
allotment of the new redeemable shares have become effective on 21 October 2008.
VI. As a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital paragraph one of article 6 of the
Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:
136062
" Art. 6. Corporate Capital. The issued capital of the Company is set at one million one hundred thirty thousand US
Dollars (USD 1,130,000.-) divided into one thousand one hundred thirty (1,130) redeemable shares. Each issued share
has a nominal value of one thousand US Dollars (USD 1,000.- ) and is fully paid up."
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-
mately EUR 3,900.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trente octobre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire, de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de CIS Luxembourg S.A., une société anonyme
régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, constituée le 22
novembre 2004 suivant acte de Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire, de résidence à Luxembourg, publié au
Mémorial C numéro 106 le 6 février 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section
B, sous le numéro 104.282, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire instrumentant,
le 13 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
1786 du 23 septembre 2006 (la «So-
ciété»),
en vertu d'une procuration lui conférée par les résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société en
date du 9 octobre 2008, une copie desdites résolutions, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et
constatations suivantes:
I. La Société a actuellement un capital social de six cent vingt mille US Dollars (USD 620.000,-) représenté par six cent
vingt (620) actions rachetables, les actions ayant une valeur nominale de mille US Dollars (USD 1.000,-) chacune, ces
actions étant entièrement libérées.
II. En vertu de l'article 6 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à deux millions de US
Dollars (USD 2.000.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions, ayant chacune une valeur nominale de mille US
Dollars (USD 1.000,-) et qu'en vertu du même article 6, le conseil d'administration de la Société a été autorisé à procéder
à une augmentation de capital, lequel article des statuts étant alors à modifier de manière à refléter l'augmentation de
capital ainsi réalisée.
III. Les administrateurs de la Société, par résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration en date
du 9 octobre 2008, et en conformité avec les pouvoirs leur conférés en vertu de l'article 6 des statuts de la Société, ont
décidé d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de cinq cent dix mille US Dollars (USD 510.000,-) afin de
porter le capital social souscrit à un million cent trente mille US Dollars (USD 1.130.000,-) par la création de cinq cent
dix (510) nouvelles actions rachetables d'une valeur nominale de mille US Dollars (USD 1.000,-) chacune, et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions rachetables existantes.
IV. Les administrateurs de la Société, par résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration en date
du 9 octobre 2008, ont décidé sous réserve de la confirmation par Monsieur Cathal Anthony Lyons, administrateur de
la Société, de la réception des fonds de souscription, laquelle confirmation est intervenue le 21 octobre 2008, d'émettre
cinq cent dix (510) nouvelles actions rachetables d'une valeur nominale de mille US Dollars (USD 1.000,-) chacune et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions rachetables existantes et d'annuler les droits de souscription
préférentiels des actionnaires existants.
V. Monsieur Cathal Anthony Lyons, administrateur de la Société, a confirmé par une résolution écrite en date du 21
octobre 2008, conformément aux résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration en date du 9 octobre
2008, que toutes ces nouvelles actions rachetables ont été entièrement souscrites et libérées intégralement, par apport
en numéraire à la Société, de sorte que la somme de cinq cent dix mille US Dollars (USD 510.000,-) correspondant au
montant total de la susdite augmentation du capital social se trouvait le 21 octobre 2008 à la libre disposition de la Société,
tel que démontré au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de libération et que l'allocation et
l'émission de ces nouvelles actions ont pris effet le 21 octobre 2008.
136063
VI. Suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l'article 6 des statuts est
modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à un million cent trente mille US Dollars (USD
1.130.000,-) représenté par mille cent trente (1.130) actions rachetables. Chaque action émise a une valeur nominale de
mille US Dollars (USD 1.000,-) et est entièrement libérée.»
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société et mis à sa charge, en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme
de 3.900,- EUR.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. A la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms usuels, état et demeure, ledit comparant
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. LOESCH, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 novembre 2008. Relation: LAC/2008/44937. - Reçu € 1956,27 (mille neuf cent
cinquante-six Euros vingt-sept Cents).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2008.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2008144775/206/127.
(080170492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
BI-Invest Holdings, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 142.921.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the sixteenth day of October.
Before Us, Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of BI-Invest Holdings, a public limited
liability company (société anonyme) originally incorporated under the laws of Jersey as a limited liability company with
corporate seat in Jersey and having its address at PO Box 87, 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX (the Company).
The Meeting is presided by Matthieu Chambon, attorney at law, residing in Luxembourg (the Chairman).
The Meeting appoints as secretary Régis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Caroline Bader-Keller, attorney at law, residing in Luxembourg, who together with
the Chairman and the secretary constitute the bureau of the Meeting.
The Chairman declares and requests the notary to act:
I) The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares held by each of them, are shown
on an attendance list signed by the shareholders and/or their proxy-holders.
This attendance list, signed ne varietur by the bureau of the Meeting and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed to be filed with the registration authorities.
In the same way the proxies of the represented shareholders at the Meeting, initialled ne varietur by the appearing
persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
II) The shares representing the entire subscribed capital of the Company are present or represented at the Meeting,
so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.
III) By resolution validly adopted by the shareholders of the Company on 19 August 2008, acting pursuant to Articles
127Q(2)(a), 127Q(2)(b) and 143 of the Companies (Jersey) Law 1991, the Company resolved to transfer its statutory
seat and principal establishment from Jersey to the City of Luxembourg as from the date of signature of the present deed,
without the Company being dissolved but on the contrary with corporate continuance. All formalities required under
the laws of Jersey to give effect to that resolution have been duly performed.
IV) The agenda of the Meeting is as follows:
136064
1. Transfer of the registered office, the principal establishment and the place of effective management of the Company
from Jersey to the City of Luxembourg with immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary
with full corporate and legal continuance;
2. Adoption by the Company of the legal form of a public limited liability Company (société anonyme) with the name
BI-Invest Holdings and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, the
principal establishment and the place of effective management of the Company to the City of Luxembourg and, to the
extent needed, decision to change the legal form of the Company into a public limited liability company (société anonyme);
3. Approval of the opening balance sheet of the Company;
4. Acknowledgment of the report of the independent auditor as at 15 October 2008;
5. Determination of the share capital and the par value per share of the Company;
6. Restatement of the Company's articles of association into those of a société anonyme, so as to conform them to
the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in
item 2. above, with the Company having a share capital of one million one hundred fifty-six thousand thirty-three euro
(EUR 1,156,033.-) divided into one million one hundred fifty-six thousand thirty-three (1,156,033) shares with a par value
of one euro (EUR 1.-) each and reallocation of shares following consolidation of number of shares in issue;
7. Confirmation of the appointment of the current directors for a term of office not exceeding 6 years;
8. Appointment of a statutory auditor for a term of office not exceeding 6 years;
9. Establishment of the registered office, the principal establishment and the place of effective management of the
Company at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
10. Miscellaneous.
V) The following documents have been submitted to the meeting:
- Memorandum of Association and Articles of Association of the Company as a Jersey law governed company;
- Opening balance sheet dated 10 October 2008;
- Valuation report of the independent auditor dated 15 October 2008.
All above mentioned documents, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed, to be filed with the registration authorities.
After the foregoing was approved by the Meeting, the Meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to transfer the registered office, the principal establishment and the place of effective management
of the Company from Jersey to the City of Luxembourg with immediate effect, without the Company being dissolved but
on the contrary with full corporate and legal continuance. The Meeting further declares that all formalities required under
the laws of Jersey to give effect to such transfer have been duly performed.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves that the Company adopts the form of a public limited liability company (société anonyme) with
the name BI-Invest Holdings, accepts the Luxembourg nationality and shall as from the date of the present deed be subject
to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and to the extent needed, decides to change the legal form of the Company
into a public limited liability company (société anonyme).
<i>Third resolutioni>
The Meeting approves the opening balance sheet of the Company in Luxembourg as at 10 October 2008, showing
total assets at one hundred sixteen million nine hundred ten thousand eight hundred fifteen euro (EUR 116,910,815.-)
and a net asset value at eight million four hundred sixty-three thousand six hundred twenty-three euro (EUR 8,463,623.-).
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting acknowledges and, to the extent applicable, approves the report of PricewaterhouseCoopers, located at
400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg as at 15 October 2008. The conclusion is the following:
"Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the net book value of the
Company does not correspond at least to the share equity of the Company as of October 16, 2008, represented by the
called share capital, capital and share premium reserve and profit and loss reserve."
The said report, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting sets the share capital of the Company at one million one hundred fifty-six thousand thirty-three euro
(EUR 1,156,033.-) represented by one million one hundred fifty-six thousand thirty-three (1,156,033.-) shares in registered
form with a par value of one euro (EUR 1.-) all subscribed and fully paid-up.
136065
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to restate the articles of association of the Company into those of a société anonyme so as to
conform them to Luxembourg law.
The restated Articles of Association of the Company shall read as follows:
I.- Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
The name of the company is "BI-Invest Holdings" (the Company). The Company is a public company limited by shares
(société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10,
1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It
may be transferred within the municipality by a resolution of the board of directors (the Board). The registered office
may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of
shareholders (the General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the
Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The
Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated com-
panies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company,
and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.
3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II.- Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The share capital is set at one million one hundred fifty-six thousand thirty-three euro (EUR 1,156,033.-), repre-
sented by one million one hundred fifty-six thousand thirty-three (1,156,033) shares in registered form, having a par value
of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the General Meeting
acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
5.3. The Board is authorized, for a period of five (5) years from the date of the publication of the deed of incorporation,
to:
(a) increase the current share capital in one or several times up to one million eight hundred twelve thousand five
hundred euro (EUR 1,812,500.-), by the issue of six hundred fifty-six thousand four hundred sixty-seven (656,467) new
shares, having the same rights as the existing shares;
136066
(b) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new shares and determine the persons
authorised to subscribe to the new shares; and
(c) record by way of a notarial deed each share capital increase and amend the share register accordingly.
Art. 6. Shares
6.1. The shares are and will remain in registered form.
6.2. A register of shares is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.3. A share transfer is carried out by entering in the register of shares, a declaration of transfer, duly dated and signed
by the transferor and the transferee or by their authorised representatives and following a notification to, or acceptance
by, the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept as evidence of a share
transfer other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.
6.4. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III.- Management - Representation
Art. 7. Board of directors
7.1. Composition of the board of directors
(i) The Company is managed by a Board composed of at least three (3) members, who need not be shareholders.
(ii) The General Meeting appoints the director(s) and determines their number, remuneration and the term of their
office. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible.
(iii) Directors may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting.
(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative who represents such entity
in its duties as a director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if
it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of
the legal entity which it represents.
(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint
another permanent representative.
(vi) If the office of a director becomes vacant, the majority of the remaining directors may fill the vacancy on a provi-
sional basis until the final appointment is made by the next General Meeting.
7.2. Powers of the board of directors
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management and the power to represent the Company in this
respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either indi-
vidually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or several directors, the Board must report to the
annual General Meeting any salary, fees and/or any other advantages granted to such director(s) during the relevant
financial year.
7.3. Procedure
(i) The Board must appoint a chairman among its members and may choose a secretary, who need not be a director,
and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.
(ii) The Board meets upon the request of the chairman or any two (2) directors, at the place indicated in the notice
which, in principle, is in Luxembourg.
(iii) Written notice of any meeting of the Board is given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a director, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(v) A director may grant a power of attorney to any other director in order to be represented at any meeting of the
Board.
(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions
of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors present or represented. The chairman has a
casting vote in the event of tie. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman or all the
directors present or represented at the meeting or by the secretary (if any).
(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
136067
(viii) Circular resolutions signed by all the directors are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened
and held and bear the date of the last signature.
(ix) Any director having an interest conflicting with that of the Company in a transaction carried out otherwise than
under normal conditions in the ordinary course of business, must advise the Board thereof and cause a record of his
statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in these deliberations.
A special report on the relevant transaction(s) is submitted to the shareholders before any vote, at the next General
Meeting.
7.4. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the signature of any director.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special
signatory powers have been delegated.
Art. 8. Sole director
8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a sole director until
the ordinary General Meeting following the introduction of an additional shareholder. In such case, any reference in the
Articles to the Board or the directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate.
8.2. The transactions entered into by the Company may be recorded in minutes and, unless carried out under normal
conditions in the ordinary course of business, must be so recorded when entered with its sole director having a conflicting
interest.
8.3 The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature
of any persons to whom special signatory powers have been delegated.
Art. 9. Liability of the directors
9.1. The directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made
by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
IV.- Shareholder(s)
Art. 10. General meetings of shareholders
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at General Meetings. The General Meeting has the broadest powers
to adopt and ratify all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) General Meetings are held at such place and time as specified in the notices.
(ii) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(iii) A shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in order
to be represented at any General Meeting.
(iv) Each shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other similar
means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
(v) Each shareholder may vote by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place
and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three boxes allowing to
vote in favour, against or abstain from voting. Voting forms must be sent back by the shareholders to the registered office.
Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account for the calculation of the quorum. Voting
forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions) nor an abstention, are void.
(vi) Resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority of the votes cast, regardless of the proportion
of the share capital represented.
(vii) The extraordinary General Meeting may amend the Articles only if at least one-half of the share capital is repre-
sented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles as well as the text of any proposed amendments
to the object or form of the Company. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened by
means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the meeting in the
Mémorial and in two Luxembourg newspapers. Such notices reproduce the agenda of the General Meeting and indicate
the date and results of the previous General Meeting. The second General Meeting deliberates validly regardless of the
proportion of the capital represented. At both General Meeting, resolutions must be adopted by at least two-thirds of
the votes cast.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).
136068
Art. 11. Sole shareholder
11.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
11.2. Any reference in the Articles to the General Meeting is to be read as a reference to such sole shareholder, as
appropriate.
11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.
V.- Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 12. Financial year and approval of annual accounts
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the officers, directors and statutory auditors towards the Company.
12.3. One month before the annual General Meeting, the Board provides documentary evidence and a report on the
operations of the Company to the statutory auditors, who then prepare a report setting forth their proposals.
12.4. The annual General Meeting is held at the address of the registered office or at such other place in the municipality
of the registered office, as may be specified in the notice, on the third Friday of June of each year at 10.00 a.m.. If such
day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting is held on the following business day.
12.5. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional
circumstances so require.
Art. 13. Statutory auditors / Réviseurs d'entreprises
13.1. The operations of the Company are supervised by one or several statutory auditors (commissaires).
13.2. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by
law.
13.3. The General Meeting appoints the statutory auditors/réviseurs d'entreprises and determines their number, re-
muneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. Statutory auditors/réviseurs d'entreprises
may be re-appointed.
Art. 14. Allocation of profits
14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
14.2. The General Meeting determines how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such
balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends is taken by the Board within two (2) months from the date of the
interim accounts; and
(iv) in their report to the Board, as applicable, the statutory auditors or the réviseurs d'entreprises must verify whether
the above conditions have been satisfied.
VI.- Dissolution - Liquidation
15.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with
the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting appoints one or several liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determines their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay
the liabilities of the Company.
15.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII.- General provision
16.1. Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by telegram,
telefax, e-mail or any other means of electronic communication.
136069
16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions are affixed on one original or on several coun-
terparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.
16.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject
to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year after the continuation of the Company in Luxembourg, which begins on the date of the
present deed, ends in Luxembourg on 31 December 2008.
<i>Allocation of sharesi>
Each shareholder shall receive the same number of shares originally held
As a result of the migration, the share capital has been allocated as follows:
- BI-Invest International Holdings Ltd, 867,025 shares in registered form, with a par value of one (EUR 1.-) euro each;
and
- Alpha Beta Beheer NV, 289,008 shares in registered form, with a par value of one (EUR 1.-) euro each.
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolves to appoint as directors of the Company, effective as of the date of the present deed, the following
persons:
- Stuart Hornby, director, born in Liverpool, UK on 25 May 1953, with professional address at P.O. Box 87, 22 Grenville
Street, ST Hellier, Jersey JE4 9PX, UK.
- Henry Christopher Tilley, director, born in Oxford on 25 July 1938, with professional address at Chemin de la Praly
15, CH-1222 Vesanaz, Genève, Suisse.
- Neil Smith, director, born in Darwin, UK on 17 June 1956, with professional address at 1 Duchess Street, W1W
5AN, UK
Their term of office shall expire at the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2014.
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting resolves to appoint as statutory auditor of the Company for a period expiring at the annual general
meeting of the shareholders of the Company to be held in 2014:
- KPMG Luxembourg with registered address at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
<i>Nineth resolutioni>
The Meeting resolves to establish the registered office, the principal establishment and place of effective management
of the Company at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be
borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason this deed, are estimated at approximately
48,000.- EUR.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between the
English and the French text, the English version shall prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le seizième jour du mois d'octobre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réuni l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de BI-Invest Holdings, une société
anonyme incorporée à l'origine sous droit de Jersey en tant que société à responsabilité limitée ayant son siège à PO Box
87, 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX (la Société)
L'Assemblée est présidée par Matthieu Chambon, avocat, demeurant à Luxembourg (le Président).
L'Assemblée désigne comme secrétaire Régis Galiotto, juriste, demeurant à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Caroline Bader-Keller, attorney at law, demeurant à Luxembourg.
136070
Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I) Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent
ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents ou par leur mandataire.
Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Pareillement, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente Assemblée, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être
enregistrées avec lui.
II) Les actions représentant l'intégralité du capital social souscrit sont présentes ou représentées à l'Assemblée, de
sorte que l'Assemblée peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.
III) Par résolution valablement adoptée par les actionnaires de la Société le 19 août 2008, agissant conformément aux
Articles 127Q(2)(a), 127Q(2)(b) and 143 de la Loi sur les Sociétés (Jersey) de 1991, la Société a décidé de transférer son
siège social statutaire et son principal établissement de Jersey vers la Ville de Luxembourg avec effet à la date de signature
du présent acte, sans dissolution de la Société mais avec continuation de sa personnalité juridique. Toutes les formalités
requises par le droit de Jersey afin de réaliser cette décision ont d'ores et déjà été accomplies.
IV) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège statutaire et du principal établissement de la Société de Jersey à la Ville de Luxembourg avec effet
immédiat, sans dissolution de la Société mais avec continuation de sa personnalité juridique ;
2. Adoption de la Société de la forme légale d'une société anonyme sous le nom BI-Invest Holdings et acceptation de
la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du siège social statutaire et du principal établissement de la Société
à Luxembourg et, pour autant que de besoin, décision de convertir la Société en société anonyme;
3. Approbation du bilan d'ouverture de la Société;
4. Lecture du rapport du réviseur d'entreprises agréée en date du 15 octobre 2008;
5. Détermination du capital social de la Société et de la valeur nominale des parts sociales;
6. Modification des statuts de la Société pour les adapter aux lois luxembourgeoises, et en conséquence de l'acceptation
par la Société de la nationalité luxembourgeoise comme spécifié dans l'article 2 ci-dessus. La Société ayant un capital social
de un million cent cinquante six mille trente-trois euro (1.156.033,- EUR) divisé en un million cent cinquante six mille
trente-trois (1.156.033) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune et allocation des actions suite à la
consolidation du nombre d'actions émises;
7. Confirmation de la nomination des administrateurs actuels de la Société pour un terme ne dépassant pas 6 ans;
9. Nomination d'un commissaire pour un terme ne dépassant pas 6 ans;
10. Etablissement du siège social statutaire, de l'établissement principal et le lieu de gestion effective de la Société au
51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
11. Divers
V) Les documents suivants sont soumis à l'Assemblée:
- Memorandum of Association et Articles of Association de la Société en tant que société soumis au droit de Jersey;
- Bilan d'ouverture daté au 10 octobre 2008;
- Rapport du réviseur d'entreprises agréée daté au 15 octobre 2008.
Tous les documents précités seront signés ne varietur par le notaire instrumentant et les comparants pour être annexés
à l'acte et enregistrés avec lui.
Ensuite, l'Assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social, le principal établissement et le lieu de gestion effective de la Société
de Jersey à la Ville de Luxembourg avec effet immédiat, sans que soit dissoute la Société mais, au contraire, avec une
complète continuité légale et statutaire. L'Assemblée déclare en outre que toutes les formalités requises selon les lois de
Jersey afin de donner effet à un tel transfert, ont été dûment remplies.
<i>Seconde résolutioni>
L'Assemblée décide que la Société adopte la forme d'une société anonyme avec le nom BI-Invest Holdings, accepte la
nationalité luxembourgeoise et sera, à la date du présent acte, soumise aux lois du Grand-Duché du Luxembourg, et,
pour autant que de besoin, décide de convertir la Société en société anonyme.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée approuve le bilan d'ouverture de la Société daté au 10 octobre 2008, indiquant les actifs totaux de la
Société à hauteur de cent seize million neuf cent dix mille huit cent quinze euro (116.910.815,- EUR) et la valeur de l'actif
net se portant à huit million quatre cent soixante trois mille six cent vingt-trois euro (8.463.623,- EUR).
136071
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée prend acte et, dans la mesure applicable, approuve le rapport établi par PricewaterhouseCoopers, 400
route d'Esch, L-1471 Luxembourg en date du 15 octobre 2008, dont la conclusion est la suivante:
"Sur base des vérifications effectuées, nous n'avons pas d'observation à formuler ou d'indication qui nous laisserait
penser que la valeur de l'actif net de la Société ne correspond pas à la valeur de l'apport de la Société en date du 16
Octobre 2008, représenté par le nombre et la valeur comptable des actions, le capital et le compte de la prime d'émission"
Ce rapport, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au
présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée fixe le capital social de la Société à un million cent cinquante six mille trente-trois euro (1.156.033,- EUR),
représenté par un million cent cinquante six mille trente-trois (1.156.033) actions nominatives avec une valeur nominale
de un euro (1,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier et d'adapter les statuts de la Société pour se conformer aux lois luxembourgeoises.
Les statuts auront dorénavant la teneur suivante:
I.- Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
Le nom de la société est "BI-Invest Holdings" (La Société). La Société est une société anonyme régie par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être
transféré dans la commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en
tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'As-
semblée Générale), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.1.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre,
d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment,
les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa
faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité
réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4 Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
136072
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.
II.- Capital - Actions
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à un million cent cinquante six mille trente-trois euro (1.156.033,- EUR), représenté par
un million cent cinquante six mille trente-trois (1.156.033) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un
euro (1,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée
Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
5.3. Le Conseil est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de l'acte constitutif,
à:
(a) augmenter le capital social existant en une ou plusieurs fois, à hauteur de un million huit cent douze mille cinq cent
euros (1.812.500,- EUR), par l'émission de six cent cinquante six mille quatre cent soixante sept (656.467) nouvelles
actions, ayant les mêmes droits que les actions existantes;
(b) limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires aux nouvelles actions et déterminer
les personnes autorisées à souscrire aux nouvelles actions; et
(c) faire constater chaque augmentation de capital social par acte notarié et modifier le registre des actions en con-
séquence.
Art. 6. Actions
6.1. Les actions sont et resteront sous forme nominative.
6.2. Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.
6.3. Une cession d'action(s) s'opère par la mention sur le registre des actions, d'une déclaration de transfert, valable-
ment datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires et suivant une notification à, ou une
acceptation par, la Société, conformément à l'article 1690 du Code Civil. La Société peut également accepter comme
preuve du transfert d'actions, d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.
6.4. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.
6.5. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.
III.- Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil d'administration
7.1. Composition du conseil d'administration
(i) La Société est gérée par un conseil d'administration (le Conseil) composé d'au moins trois (3) membres, qui ne
doivent pas être actionnaires.
(ii) L'Assemblée Générale nomme le(s) administrateur(s) et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de
leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles.
(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'Assemblée Générale.
(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux
mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre
compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer
immédiatement un autre représentant permanent.
(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoi-
rement jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.
7.2. Pouvoirs du conseil d'administration
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux actionnaires sont de la compétence
du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette
gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou
conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à
l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) adminis-
trateur(s) pendant l'exercice social en cause.
7.3. Procédure
136073
(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur,
et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.
(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d'au moins deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l'avis
de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.
(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre
(24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à la
convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas
exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le
Conseil.
(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion
du Conseil.
(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président ou par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le
secrétaire (s'il en existe un).
(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout
autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'en-
tendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion
valablement convoquée et tenue.
(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si
elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature.
(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des
opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un
rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine
Assemblée Générale.
7.4. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature d'un administrateur.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui
des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.
Art. 8. Administrateur unique
8.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1), la Société peut être gérée par un administrateur
unique jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction d'un actionnaire supplémentaire. Dans ce cas, toute
référence dans les Statuts au Conseil ou aux administrateurs doit être considérée, le cas échéant, comme une référence
à cet administrateur unique.
8.2. Les transactions conclues par la Société peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux et, sauf si elles con-
cernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales, doivent être ainsi mentionnées si elles sont
intervenues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé.
8.3. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de l'administrateur unique ou par la signature conjointe
ou unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.
Art. 9. Responsabilité des administrateurs
9.1. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux
Statuts et à la Loi.
IV.- Actionnaire(s)
Art. 10. Assemblée générale des actionnaires
10.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (l'Assemblée Géné-
rale). L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes
à l'objet social.
(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.
10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
136074
(i) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.
(ii) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués
et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(iii) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire)
afin de le représenter à toute Assemblée Générale.
(iv) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre
moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de
s'entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion.
(v) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires de vote
indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, le texte des résolutions proposées ainsi que, pour chaque
résolution, trois cases permettant de voter en faveur, de voter contre ou de s'abstenir. Les formulaires de vote doivent
être renvoyés par les actionnaires au siège social. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires de
vote reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont men-
tionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.
(vi) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la
proportion du capital social représenté.
(vii) L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est
représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient
l'objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être
convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assem-
blée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la
réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valable-
ment quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent
être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans
la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu).
Art. 11. Actionnaire unique
11.1. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1), l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés
par la Loi à l'Assemblée Générale.
11.2. Toute référence dans les Statuts à l'Assemblée Générale doit être doit être considérée, le cas échéant, comme
une référence à cet actionnaire unique.
11.3. Les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.
V.- Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 12. Exercice social et approbation des comptes annuels
12.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un décembre (31) de chaque année.
12.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.
12.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de
la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.
12.4. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du
siège social, comme indiqué dans la convocation, le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 10 heures. Si
ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.
12.5. L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon l'avis absolu et définitif du Conseil, des cir-
constances exceptionnelles le requièrent.
Art. 13. Commissaires / Réviseurs d'entreprises
13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.
13.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, quand cela est requis
par la loi.
13.3. L'Assemblée Générale nomme les commissaires/réviseurs d'entreprises et détermine leur nombre, leur rému-
nération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les commissaires/réviseurs d'entreprises peuvent
être réélus.
Art. 14. Affectation des bénéfices
14.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.
136075
14.2. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice
au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.
14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes :
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale ou statutaire;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la
date des comptes intérimaires; et
(iv) dans leur rapport au Conseil, selon le cas, les commissaires ou les réviseurs d'entreprises doivent vérifier si les
conditions prévues ci-dessous ont été remplies.
VI.- Dissolution - Liquidation
15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont
pas besoin d'être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.
15.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes est distribué aux actionnaires
proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.
VII.- Dispositions générales
16.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions
circulaires sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.
16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques
remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires peuvent être apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document,
qui ensemble, constituent un seul et unique document.
18.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légale d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les actionnaires.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social, après continuation de la Société à Luxembourg débutera à la date du présent acte et se
terminera le 31 décembre 2008.
<i>Allocation des actionsi>
Chaque actionnaire recevra le même nombre d'actions détenues à l'origine.
En conséquence, le capital social a été alloué comme suit:
- BI-Invest International Holdings, 867,025 actions sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un euro (1,-
EUR) chacune; et
- Alpha Beta Beheer NV, 289,008 actions sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes, avec effet immédiat comme administrateurs de la Société:
- Stuart Hornby, director, né à Liverpool, RU le 25 mai 1953, ayant pour adresse professionnelle P.O. Box 87, 22
Grenville Street, ST Hellier, Jersey JE4 9PX, UK.
- Henry Christopher Tilley, director, né à Oxford, Angleterre le 25 juillet 1938, ayant pour adresse professionnelle
Chemin de la Praly 15, CH-1222 Vesanaz, Genève, Suisse.
- Neil Smith, director, né à Darwin, RU le 17 juin 1956, ayant pour adresse professionnelle 1 Duchess Street, W1W
5AN, UK
Leur mandat expirera à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant se tenir en 2014.
<i>Huitième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer comme commissaire de la Société avec mandat expirant à l'assemblée générale an-
nuelle des actionnaires devant se tenir en 2014.
- KPMG Luxembourg with registered address at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
136076
<i>Neuvième résolutioni>
L'Assemblée décide d'établir le siège social, le principal établissement et lieu de gestion effective de la Société au 51,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont approximativement estimés à la somme de 48.000,- EUR.
Dont acte, le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, certifie par les présentes qu'à la demande de la
partie comparante, le présent acte a été créé en anglais suivi d'une traduction française, et en cas de divergences entre
les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Le document ayant été lu aux membres du bureau, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. CHAMBON, R. GALIOTTO, C. BADER-KELLER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 octobre 2008. Relation: LAC/2008/42178 - Reçu à 0,50%: quarante-deux mille
trois cent dix-huit euros douze cents (42.318,12 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008145129/211/704.
(080171059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2008.
S.M.M. spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 38.531.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 15/10/2008i>
Le Conseil décide de transférer le siège social de la société au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le Conseil prend également acte de la nouvelle adresse professionnelle de Messieurs Etienne Gillet et Jacques Tordoor,
administrateurs, et de la société AUDITEX Sàrl, commissaire aux comptes, au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg.
Pour copie conforme
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2008144731/3842/17.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04738. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080170445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Investment Light II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 111.197.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008142030/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02868. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080166836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.
136077
Investment Light I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.825,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 111.196.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008142029/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02867. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080166838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.
LSF5 Giga Investments III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.750,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 142.585.
In the year two thousand and eight, on the thirtieth of October.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.
THERE APPEARED:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by
Mr Philippe Detournay, here represented by Mr Paul Berna, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue
of a power of attorney, given in Luxembourg on 29 October 2008,
(the Sole Shareholder).
Which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents
the entire share capital of LSF5 Giga Investments III S. à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 20 October 2008, not yet published with the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, that has not been amended since, in the course of being registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies Register, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that
it may validly deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 12,500 by an amount of
EUR 4,250, to bring it to an amount of EUR 16,750 by the issuance of 34 new ordinary shares with a par value of EUR
125 and to pay a share premium of an amount of EUR 64.22;
2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company.
This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 12,500
(twelve thousand five hundred euro) represented by 100 (one hundred) ordinary shares with a nominal value of EUR 125
(one hundred and twenty-five euro) by an amount of EUR 4,250 (four thousand two hundred and fifty euro) to an amount
of EUR 16,750 (sixteen thousand seven hundred and fifty euro) by way of the issuance of 34 (thirty-four) new ordinary
shares with a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, and to pay a share premium of an amount
of EUR 64.22 (sixty-four euro and twenty-two cent).
All the 34 (thirty-four) new ordinary shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share
premium has been paid by Lone Star Capital Investments S.à r.l. so that the amount of EUR 4,314.22 (four thousand three
hundred and fourteen euro and twenty-two cent) is at the free disposal of the Company as has been proved to the
undersigned notary who expressly bears witness to it.
As a consequence of the share capital increase, Lone Star Capital Investments S.à r.l. holds 134 (one hundred and
thirty-four) ordinary shares of the Company.
136078
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association
of the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:
" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 16,750 (sixteen thousand seven hundred and fifty
euro), represented by 134 (one hundred and thirty-four) ordinary shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred
and twenty-five euro) each."
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.
The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trente octobre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg.
A COMPARU:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée
par Philippe Detournay, ici représentée par M
e
Paul Berna, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 29 octobre 2008,
(l'Associé Unique).
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'elle représente la totalité du capital social
de la société à responsabilité limitée dénommée LSF5 Giga Investments III S. à r.l. (la Société), société de droit luxem-
bourgeois, constituée selon acte de Maître Martine Schaeffer du 20 octobre 2008, non encore publié auprès du Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, non modifié depuis cette date, en cours d'enregistrement auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital de la Société de son montant actuel de EUR 12.500 par un montant de EUR 4.250 par voie
d'émission de 34 nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125 chacune, pour le porter à un
montant de EUR 16.750 et paiement d'une prime d'émission de EUR 64,22; et
2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.
Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR
12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de
EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune par le biais d'une augmentation de EUR 4.250 (quatre mille deux cent cinquante
euros) à un montant de EUR 16.750 (seize mille sept cent cinquante euros) par voie d'émission de 34 (trente-quatre)
nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, et de payer
une prime d'émission d'un montant de EUR 64,22 (soixante-quatre euros et vingt-deux cents).
L'ensemble des 34 (trente-quatre) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégralement souscrites et
libérées en numéraire et la prime d'émission a été payée par Lone Star Capital Investments S.à r.l., de sorte que la somme
de EUR 4.314,22 (quatre mille trois cent quatorze euros et vingt-deux cents) est à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Suite à cette augmentation de capital, Lone Star Capital Investments S.à r.l. détient 134 (cent trente-quatre) parts
sociales ordinaires de la Société.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à la première résolution, l'Associé Unique de la Société décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société,
dont la version française aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 16.750 (seize mille sept cent cinquante euros)
représenté par 134 (cent trente-quatre) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq
euros) chacune.»
136079
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: P. Detournay et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 7 novembre 2008, LAC/2008/45067. - Reçu vingt et un euros cinquante-sept cents
(EUR 0,5% = 21,57).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008144776/5770/112.
(080170517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Eurfinance SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 38.453.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008143694/1137/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04620. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080168449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2008.
G.P.P. International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 52.323.
Cette mention rectificative annule et remplace la version déposée antérieurement le 11 août 2008 sous le No:
L080118029.04.
Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008142038/534/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV09052. - Reçu 46,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080167371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.
High-Tech Hotel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 111.330,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 91.990.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008142028/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02864. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080166841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
136080
Acergy S.A.
Altrum Sicav
Bakerfin S.A.
BI-Invest Holdings
Bodena
Cesare Fiorucci Luxco
Checkfree Solutions S.A.
CIS Luxembourg S.A.
Compagnie Luxembourgeoise de Participations S.A.
Ellegi S.A.
Eurfinance SA
Eurfinance SA
Euromutuel Sicav
Eurostampa International S.A.
Exante S.à r.l.
Finkerri S.A.
G.P.P. International S.A.
Gruppo Fabbri International S.A.
High-Tech Hotel Investments S.à r.l.
Induserv Holding
Investment Light II S.à r.l.
Investment Light I S.à r.l.
Jost Luxembourg S.à.r.l.
Katoen Natie Group S.A.
KBC Districlick
KBC Renta
Kidsco S.A.
Le Bourgeon SA
Life One
Longford Investments S.à r.l.
LSF5 Giga Investments III S.à r.l.
Merton Finance S.à r.l.
Nordea Alternative Investment
Oakville Invest Limited S.à r.l.
Orion Participations S.A.
Paro S.A.
Photo Video Dichter
Russia International Card Finance S.A.
Sadin Holding S.A.
Shalimar S.A.
Sinvar Holding S.A.
S.M.M. spf S.A.
Société Anonyme des Chaux de Contern
SOCIETE DE PARTICIPATIONS TAMISE, société anonyme de gestion de patrimoine familial
Thaleya S.A.
Thaleya S.A.
Trident Locations S.A.
Triple Crown
UniGarantPlus: Klimawandel (2013)
UT97 Global Fund
Vdo.nrg S. à r.l.
Vdo.nrg S. à r.l.
VR Premium Fonds
WP Roaming III S.à r.l.
WP Roaming S.à r.l.