This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2746
12 novembre 2008
SOMMAIRE
Absolutissimo Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131771
Absolutissimo Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131771
AGEFI Luxembourg - Le Journal Financier
de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131764
Alteus Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131806
AMP Capital Investors (Angel Trains EU
No. 1) S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131805
Architect-Consult/ Zigrand Jean-Paul S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131804
ARISTOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131804
ARISTOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131804
ARISTOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131804
AXA Luxembourg Fund . . . . . . . . . . . . . . . .
131763
Belaton SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131802
Belux Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131762
BHG Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
131803
BN & Partner Platinum Fund . . . . . . . . . . .
131797
Brookstone S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131801
Café Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131802
Capale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131762
C.R.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131776
EcoLive S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131771
Européenne de Santé S.A. . . . . . . . . . . . . . .
131806
Ferentis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131770
Financière Verbois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
131801
Gazelle Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131770
Global Logistics Services S.A. . . . . . . . . . . .
131806
Hambleton Hall S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131802
Hilaire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131806
Hilaire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131805
Immobilière des Dahlias S.A. . . . . . . . . . . . .
131803
Immo Teb SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131762
Institut Financier Européen S.A. . . . . . . . . .
131807
Lipid Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131807
L.S. Lux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131803
"Mikado Management S.A.H." . . . . . . . . . . .
131803
Motus Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131767
Ondicium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131805
Orco Germany S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131768
Oyster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131764
Retail Park Sandweiler S.A. . . . . . . . . . . . . .
131798
Robeco Capital Growth Funds . . . . . . . . . . .
131768
Robeco Interest Plus Funds . . . . . . . . . . . . .
131768
S.I. GROUP Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
131802
Trans IV (Luxembourg) Retail S.à r.l. . . . .
131798
Trust de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131776
UBS Target Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131769
Unicapital Investments IV . . . . . . . . . . . . . . .
131778
UniGarantPlus: BRIC (2014) II . . . . . . . . . .
131776
UniGarantPlus: BRIC (2014) II . . . . . . . . . .
131776
United Consumer Media SE . . . . . . . . . . . . .
131779
Vivier S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131763
Watamar Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
131807
X-Time S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131808
Yakari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131768
Ziska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131770
131761
Capale S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 57.276.
L'Assemblée générale Extraordinaire convoquée pour le 04 novembre 2008 n'ayant pas réuni le quorum exigé par la
loi, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu au siège social de la société le <i>12 décembre 2008i> à 15h00 avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Changement, avec effet rétroactif au 30 septembre 2008, de l'exercice social qui commencera dorénavant le 1
er
octobre pour se terminer le 30 septembre,
- Modification afférente de l'article 18
- Modification de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le dernier vendredi du mois de mars à 15
heures
- Modification afférente de l'article 15
- Modification de l'article 5 concernant le capital autorisé
- Mise à jour des statuts en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi du 25 août 2006 modifiant la loi
modifiée du 10 août 1915.
- Divers.
Pour assister ou être représenté à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2008138368/565/24.
Belux Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 28.394.
L'Assemblée générale Extraordinaire convoquée pour le 04 novembre 2008 n'ayant pas réuni le quorum exigé par la
loi, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu au siège social de la société le <i>12 décembre 2008i> à 15h30 avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Changement, avec effet rétroactif au 30 septembre 2008, de l'exercice social qui commencera dorénavant le 1
er
octobre pour se terminer le 30 septembre,
- Modification afférente de l'article 9
- Modification de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le dernier jeudi du mois de mars à 10 heures
- Modification afférente de l'article 10
- Divers.
Pour assister ou être représenté à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2008138369/565/20.
Immo Teb SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.011.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
131762
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social en date du <i>27 novembre 2008i> à 16.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2008 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 30 juin 2008.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2008139696/1004/18.
Vivier S.A. Holding, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 43.353.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le mardi <i>2 décembre 2008i> à 10.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décharge à l'administrateur et au président du conseil d'administration démissionnaire, M. Cornelius Martin BECH-
TEL, pour l'exercice de ses mandats.
2. Décharge à l'administrateur démissionnaire, Mme Christine SCHWEITZER, pour l'exercice de son mandat.
3. Nomination de M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.
4. Nomination de M. Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2008139697/29/22.
AXA Luxembourg Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 27.225.
Les actionnaires des compartiments World Equities, Small Caps Benelux, International Bond, International Money et
Euro Bond sont convoqués aux
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES
qui se tiendront le <i>12 décembre 2008,i> à partir de 15.30 heures, au siège de Fortis Banque Luxembourg S.A., 50, avenue
J.F. Kennedy à L-2951 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Clôture du compartiment World Equities par apport de tous les actifs et passifs au compartiment European Equities,
dont la dénomination sera changée en Equity Europe, en date du 16 décembre 2008.
- Clôture du compartiment Small Caps Benelux par apport de tous les actifs et passifs au compartiment European
Equities, dont la dénomination sera changée en Equity Europe, en date du 16 décembre 2008.
- Clôture du compartiment International Bond par apport de tous les actifs et passifs au compartiment Maxicav, dont
la dénomination sera changée en Bonds Europe, en date du 16 décembre 2008.
- Clôture du compartiment International Money par apport de tous les actifs et passifs au compartiment Maxicav,
dont la dénomination sera changée en Bonds Europe, en date du 16 décembre 2008.
131763
- Clôture du compartiment Euro Bond par apport de tous les actifs et passifs au compartiment Maxicav, dont la
dénomination sera changée en Bonds Europe, en date du 16 décembre 2008.
- Divers.
Conformément à l'article 5 des statuts, les résolutions à l'ordre du jour ne requièrent pas de quorum de présence et
elles seront adoptées si elles sont votées à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés. Seuls
les actionnaires du compartiment concerné seront admis à l'assemblée de leur compartiment. La décision prise par les
actionnaires d'un compartiment sera sans incidence pour le vote par les actionnaires des autres compartiments.
Les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l'assemblée sont priés de déposer leurs actions, cinq jours au
moins avant l'assemblée, auprès de Fortis Banque Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy à L-2951 Luxembourg ou auprès
du service financier en Belgique, AXA Bank Europe, 25, boulevard du Souverain à B-1170 Bruxelles.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2008139699/755/31.
AGEFI Luxembourg - Le Journal Financier de Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-8311 Capellen, 111B, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 28.850.
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>27 novembre 2008i> à 11h00 par-devant Maître Joëlle BADEN, 17, rue des Bains, L-1212
LUXEMBOURG, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation que le capital social est désormais exprimé en euros (EUR).
2. Constatation que le capital social est libéré à concurrence de EUR 116.200,09
3. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 100.000,00 (cent mille euros) pour le porter
de son montant actuel de EUR 123.946,76 (cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize
centimes), représenté par 5.000 (cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale, à EUR 223.946,76(deux
cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize centimes) par l'émission de 4.034 (quatre mille
trente-quatre) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, contre paiement en espèces
4. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2008134005/506/21.
Oyster, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 55.740.
I. Les actionnaires de la Société sont conviés à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires de la Société qui se tiendra le <i>20 novembre 2008i> à 14 heures par-devant notaire au siège de RBC
Dexia Investor Services Bank S.A. 14, rue Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette en vue de délibérer sur l'ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approuver la version coordonnée des statuts de la Société (les "Statuts") et en particulier les modifications sui-
vantes:
a) Modification de l'article 1
er
des Statuts par insertion d'un paragraphe final, qui aura la teneur suivante:
"Cependant, la Société devra, sur demande de Oyster Asset Management S.A., changer sa dénomination qui ne
contiendra ni le terme "Oyster", ni aucune référence à une société du groupe Syz & Co, dès lors qu'une société
de gestion autre que celle mentionnée à l'Article seize serait désignée par la Société."
b) Modification des dixième et douzième paragraphes de l'article 5 des Statuts qui auront désormais la teneur
suivante:
"Le conseil d'administration pourra décider de fusionner ou de liquider un ou plusieurs compartiment(s) ou une
ou plusieurs classe(s) d'actions soit en annulant les actions de ce(s) compartiment(s) ou de cette(s) classe(s) d'ac-
tions concerné(e)(s) soit en remboursant aux actionnaires de ce(s) compartiment(s) et/ou de cette(ces) classe(s)
d'actions la totalité des actifs nets y afférents soit en leur permettant le passage dans un autre compartiment ou
131764
une autre classe d'actions et en leur attribuant ainsi de nouvelles actions à concurrence de leur participation pré-
cédente si la valeur nette du(des) compartiment(s) et/ou classe(s) d'actions concerné(e)(s) descend en dessous
d'un montant que le conseil d'administration considère comme le niveau minimum en dessous duquel le(s) com-
partiment(s) et/ou classe(s) d'actions concerné(e)(s) ne peuvent plus fonctionner d'une manière économiquement
efficace.
[...]
Le conseil d'administration pourra en outre et ceci dans l'intérêt des actionnaires, décider de prendre une des
décisions ci-dessus (i) en cas de changements défavorables de la situation sociale, économique ou politique ou (ii)
dans le but de réaliser une rationalisation économique."
c) Modification du deuxième paragraphe et du premier alinéa du point c) du troisième paragraphe de l'article 8 des
Statuts qui auront désormais la teneur suivante:
" Notamment, elle pourra limiter ou interdire la propriété d'actions de la Société par tout "ressortissant des Etats-
Unis d'Amérique" tel que défini ci-après. De même, la Société pourra limiter ou interdire la détention directe ou
indirecte sans autorisation préalable par une personne physique ou morale d'actions d'un compartiment repré-
sentant 10% ou plus des actifs de ce compartiment par le biais de souscription."
[...]
" c) procéder au rachat forcé de toutes les actions s'il apparaît qu'une personne qui n'est pas autorisée à détenir
des actions de la Société, soit seule, soit ensemble avec d'autres personnes, est le propriétaire d'actions de la Société
ou procéder au rachat forcé de tout ou d'une partie des actions, s'il apparaît à la Société qu'une ou plusieurs
personnes sont propriétaires d'une proportion des actions de la Société d'une manière à rendre applicables à la
Société des lois fiscales ou autres de juridictions autres que le Luxembourg ou de telle sorte que le maximum de
détention prévu ci-dessus soit atteint. Dans ce cas, la procédure suivante sera appliquée:"
[...]
d) Insertion de deux nouveaux paragraphes après le deuxième paragraphe de l'article 11 et modification de la fin
des actuels troisième et quatrième paragraphes de ce même article 11 des Statuts comme suit:
"Tout actionnaire, pour autant que ces moyens aient été mis en place par la Société, peut participer aux assemblées
des actionnaires par visioconférence ou d'autres moyens de communication similaires qui permet l'identification
de l'actionnaire. La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
assemblée pour le calcul du quorum.
Tout actionnaire peut également voter aux assemblées des actionnaires par correspondance sous réserve que le
formulaire de vote dûment signé par l'actionnaire soit reçu par la Société dans le délai fixé dans l'avis de convocation
et au plus tard la veille de la date de la tenue de l'assemblée des actionnaires concernée par le vote. Ce formulaire
devra mentionner de manière non-équivoque le sens du vote de l'actionnaire ou son éventuelle abstention, sous
réserve d'être déclaré nul. Les actionnaires ayant voté par correspondance seront comptabilisés dans le calcul du
quorum de l'assemblée concernée."
[...]
"Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions au cours
d'une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
Les décisions relatives à un quelconque compartiment ou à une quelconque classe seront également prises, dans
la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, à la majorité simple des voix
exprimées des actionnaires du compartiment (ou de la classe concerné(e))."
e) Ajout d'un nouvel article entre les actuels articles 13 et 14 des Statuts qui aura la teneur suivante et renumé-
rotation subséquente des articles suivants:
"Le conseil d'administration a notamment la possibilité d'émettre des actions de classe P. Ces actions seront ex-
clusivement émises au bénéfice d'investisseurs institutionnels, membres du groupe Syz & Co.
Les détenteurs d'actions de la classe P proposeront une liste de candidats à l'assemblée générale des actionnaires,
à partir de laquelle la majorité des membres du conseil d'administration sera désignée conformément à l'Article
treize ci-avant. La liste de candidats proposée par les détenteurs d'actions de la classe P devra comporter un nombre
de candidats égal au moins au double de sièges à pourvoir pour cette catégorie d'administrateurs. Les candidats de
la liste comptabilisant le plus grand nombre de votes seront élus.
De plus, tout actionnaire qui souhaite proposer un autre candidat au poste de membre du conseil d'administration
lors de l'assemblée générale des actionnaires, devra en informer la Société par écrit au moins deux semaines avant
la date de tenue de l'assemblée générale. Afin d'éviter toute ambiguïté, la liste de candidats des détenteurs d'actions
de la classe P devra respecter les mêmes modalités.
La vacance d'un poste de membre du conseil d'administration de la Classe P ne peut être pourvue que par un
nouveau membre proposé par les détenteurs d'actions de la Classe P.
Cet Article ne peut être amendé ou abrogé si ce n'est par le vote affirmatif des actionnaires représentant au moins
deux-tiers des actions de la Société présentes ou représentées à l'assemblée générale des actionnaires à laquelle
50 % des actions de la Société sont présentes, représentées et votent. Ces quorum et conditions de majorité
doivent être remplis lors de toute assemblée générale d'actionnaires convoquée à cette fin. "
f) Modification des premier et quatrième paragraphes du point F. de l'actuel article 24 des Statuts (futur article 25)
qui auront désormais la teneur suivante:
131765
"F. En vue d'une bonne gestion de ses portefeuilles, la Société peut gérer tout ou partie des actifs d'un ou de
plusieurs compartiments sur une base groupée ("pooling"), soit entre plusieurs compartiments au sein de la Société
soit entre les avoirs d'un ou de plusieurs compartiments de la Société et des avoirs appartenant à d'autres orga-
nismes de placement collectif, dans le respect de leurs politiques d'investissement respectives. Les compartiments
peuvent ainsi prendre une participation dans des groupes d'actifs ("pools") proportionnellement aux actifs qu'ils y
apportent."
[...]
"Les pools seront constitués par transfert de temps à autre de valeurs mobilières, de liquidités et d'autres actifs
permis des compartiments et, le cas échéant, des autres entités qui participent à de tels pools (sous réserve que
de tels actifs conviennent au regard de l'objectif et de la politique d'investissement des compartiments participants).
Par la suite, le conseil d'administration de la Société ou son agent désigné peut de temps à autre faire d'autres
transferts en faveur de chaque pool. Des actifs peuvent aussi être prélevés sur un pool et retransférés au compar-
timent participant à concurrence de sa participation dans celui-ci, qui sera mesurée par référence à des unités de
compte notionnelles dans le ou les pool(s)."
2. Approuver l'ensemble des modifications mineures, formelles et stylistiques, notamment la nouvelle numérotation
des articles, telles que plus amplement reflétées dans le projet de Statuts lequel peut être consulté au siège social
de la Société.
3. Nommer Maître Claude Kremer en tant que membre du conseil d'administration de la Société.
4. Divers.
L'assemblée délibérera valablement sur les points portés à l'ordre du jour ci-dessus si au moins la moitié du capital
social de la Société est représentée; les résolutions, pour être valables, devront réunir au moins deux tiers des voix des
actions présentes ou représentées à l'assemblée.
Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à cette assemblée, un formulaire de procuration donnant le pouvoir de vous
faire représenter par une autre personne est disponible sur demande au siège social de la Société. Il devra être renvoyé
à RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, rue Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette à l'attention du département
Legal Engineering, ou par fax au numéro +352 2460 3331, le 18 novembre 2008 à 12 heures au plus tard.
II. Les actionnaires du compartiment Euro Liquidity (le "Compartiment") sont conviés à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires du Compartiment qui se tiendra le <i>20 novembre 2008i> à 14 heures au siège de RBC Dexia Investor
Services Bank S.A. 14, rue Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approuver le regroupement des actions au sein du Compartiment selon le ratio de 15 anciennes actions contre
une nouvelle action avec effet au 8 décembre 2008.
2. Divers
L'assemblée délibérera valablement sur les points portés à l'ordre du jour ci-dessus si au moins la moitié du capital
social du Compartiment est représentée; les résolutions, pour être valables, devront réunir au moins deux tiers des voix
des actions présentes ou représentées à l'assemblée.
Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à cette assemblée, un formulaire de procuration donnant le pouvoir de vous
faire représenter par une autre personne est disponible sur demande au siège social de la Société. Il devra être renvoyé
à RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, rue Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette à l'attention du département
Legal Engineering, ou par fax au numéro +352 2460 3331, le 18 novembre 2008 à 12 heures au plus tard.
Si vous avez une quelconque question concernant le regroupement d'actions ou la Société, vous pouvez contacter
votre représentant habituel ou RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14 rue Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette.
III. Les actionnaires du compartiment Global Emerging Markets (ci-après le "Compartiment Absorbé") sont conviés à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires du Compartiment Absorbé qui se tiendra le <i>20 novembre 2008i> à 14 heures au siège de RBC Dexia
Investor Services Bank S.A. 14, rue Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette en vue de délibérer sur l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approuver la fusion du Compartiment Absorbé dans le compartiment Emerging Markets Dynamic (ci-après le
"Compartiment Absorbant") avec effet au 22 décembre 2008 conformément à la procédure suivante:
En échange de leurs actions, les actionnaires du Compartiment Absorbé recevront des actions du Compartiment
Absorbant de la même classe et à hauteur du nombre d'actions détenues dans le Compartiment Absorbé multiplié
par le ratio d'échange. Ce ratio d'échange sera calculé en divisant la valeur nette d'inventaire des actions d'une
classe donnée du Compartiment Absorbé calculée le 22 décembre 2008 (la "Date d'Effet de la fusion") par la valeur
nette d'inventaire des actions de la même classe du Compartiment Absorbant calculée le même jour.
131766
Si après calcul, le nombre d'actions à échanger n'est pas entier, les actionnaires recevront des fractions d'actions
du Compartiment Absorbant.
Les frais liés à cette fusion seront à charge du Compartiment Absorbé.
Aucune souscription ou conversion dans le Compartiment Absorbé ne sera acceptée après le 14 novembre 2008,
17 heures, heure de Luxembourg.
2. Divers
L'assemblée délibérera valablement sur le point porté à l'ordre du jour ci-dessus quelque soit le nombre d'actions
présentes ou représentées et cette résolution, pour être valable, devra réunir la majorité simple des voix des actions
présentes ou représentées à l'assemblée.
Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à cette assemblée, un formulaire de procuration donnant le pouvoir de vous
faire représenter par une autre personne est disponible sur demande au siège social de la Société. Il devra être renvoyée
à RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, rue Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette à l'attention du département
Legal Engineering, ou par fax au numéro +352 2460 3331, le 18 novembre 2008 à 12 heures au plus tard.
Si vous avez une quelconque question concernant la fusion ou la Société, vous pouvez contacter votre représentant
habituel ou RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14 rue Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette. Les actionnaires sont
également invités à consulter leur conseiller financier et/ou fiscal sur les éventuelles conséquences de cette fusion.
Luxembourg, le 4 novembre 2008.
<i>Pour le Conseil.i>
Référence de publication: 2008135292/250/159.
Motus Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 79.640.
The Shareholders of the Fund are hereby convened to the:
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders to be held on <i>21stNovember, 2008i> at 2:00 p.m at its registered office located 41, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Board of Director's report and the Independent Auditor's report
2. Approval of the Financial Statements as at June 30th 2008
3. Allocation of results, as proposed by the Board i.e. carrying forward of the results
4. Discharge to the Directors and to the Auditor for the performance of their duties during the financial year ending
on June 30th 2008
5. Statutory appointments and/or re-appointments
6. Any other business
Shareholders are advised that the Meeting does not have to be quorate in order to pass valid resolutions. To be
accepted, valid resolutions only require a majority of shareholders actively present or represented. Shareholder proxies
wishing to take part in the Meeting are kindly requested to inform the Fund at least three clear days prior to the holding
of the Shareholders Meeting of their intention to attend. They shall be admitted subject to verification of their identity.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares shall deposit their shares five clear days before the meeting
with:
For Luxembourg:
Banque de LUXEMBOURG S.A.
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
For Italy
Banca Sella S.p.A
Via Italia 2 13900 Biella - Italy
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San Carlo 156 Torino - Italy
Cassa Centrale Raffeisen dell'Alto Adige S.p.A
ViaLaurin 1 39100 Bolzano - Italy
The Shareholders wishing to be represented at this meeting can obtain a proxy form at the same place. Annual report
as at June 30th 2008 is made available to shareholders free of charge at the head offices of the Fund.
131767
<i>The Board of Directors
i>Signature
Référence de publication: 2008135792/8249/39.
Robeco Interest Plus Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 40.490.
Robeco Capital Growth Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 58.959.
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders to be held on <i>27 November 2008i> , at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg at 2.00 p.m. for Robeco
Interest Plus Funds and at 3.00 p.m. for Robeco Capital Growth Funds.
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and auditors' report
2. Consideration and approval of the annual accounts for the financial year 2007/2008
3. Consideration and approval of the profit appropriation for each of the sub-funds for the financial year ended 30
June 2008
4. Discharge of the Board of Directors
5. Statutory appointments
6. Any other business
The Annual Reports 2007/2008 may be obtained at the registered office of the Corporations. The reports are also
available via www.robeco.com.
The resolutions on the Agenda will not require a quorum and will be taken at a simple majority of the votes of the
Shareholders present or represented at the respective Meetings. Shareholders may vote in person or by proxy. Share-
holders wishing to attend and/or vote at the respective Meetings should inform the respective Corporations through Mrs
V. Delvael, RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg in writing
not later than 22 November 2008 (fax: + 352 24603331).
Luxembourg, 31 October 2008 (12 November 2008).
<i>The Boards of Directors.i>
Référence de publication: 2008135391/584/28.
Yakari, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 97.765.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le <i>21 novembre 2008i> à 11.00 heures, avec l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2008136449/534/16.
Orco Germany S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 102.254.
You are invited to attend the
131768
ORDINARY GENERAL MEETING
to be held extraordinarily (hereinafter the "General Meeting") at the registered office of the Company on <i>Novemberi>
<i>20, 2008i> at 2:00 p.m., and to vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. appointment of new director;
2. miscellaneous.
Attendance to the General Meeting:
• Shareholders wishing to attend the General Meeting shall notify their intent at the latest on November 17, 2008 to
the Company by fax (+352 26 47 67 67) or by email to the following persons: amsemik@orcogroup.com or
ebriquet@orcogroup.com:
• Shareholders wishing to be represented at the General Meeting shall provide the representative of their choice with
proxy including their voting instructions. Such proxy duly filled up with the shareholder name shall be provided to the
Company at the latest on November 17, 2008. This notice and a proxy form will be available either at the registered
office of the Company or by contacting us by fax (+352 26 47 67 67) or on the following website: www.orcogermany.de/
investor-relations:
• Shareholders of bearer shares wishing to attend in person or being represented at the General Meeting shall also
provide a statement of participation (attestation de participation), issued by the financial intermediary holding their se-
curities, such statement indicating the number of shares held. The Shareholders who do not have this statement may not
participate in the vote.
Withholding threshold:
• As reminded in Article 14 of the updated by-laws of the Company, any shareholder is under the obligation to
immediately inform the Company in writing of the crossing either up or down of the thresholds set at 2,5 %, 5 %, 10 %,
15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 % and 66 %.
Shareholders who do not inform the Company will not be able to use their voting right at the General Meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2008135795/1273/32.
UBS Target Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 87.795.
Shareholders are kindly convened to attend the
GENERAL MEETING
of shareholders which will be held at 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, on <i>November 21, 2008i> at 11:00
a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and the Auditor.
2. Approval of the financial statements as of 31 May, 2008.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year
ended 31 May, 2008.
5. Election and Remuneration of the Board Members.
6. Appointment of the Auditor.
7. Notice on the ordinary general meeting of 31 October, 2008, which was not held on the specified statutory date
as it was not convened in due time.
8. Miscellaneous.
<i>Voting:i>
Resolutions on the Agenda may be passed without quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting.
<i>Notes:i>
Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
* in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A.,
which will be issued to them against blocking of their shares, at the latest on 13 November 2008.
131769
* by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as
aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of UBS Target
Fund, c/o UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. at the latest on 13 November 2008.
Shares so blocked will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2008135921/755/33.
Ziska, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 97.986.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à l'
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le <i>21 novembre 2008i> à 11.30 heures, avec l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2008136450/534/16.
Gazelle Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 39.254.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 novembre 2008i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
juin 2008.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2008136452/1023/16.
Ferentis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 74.059.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à l'
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 novembre 2008i> à 16.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 juillet 2008;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs
remplaçants;
5. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1
er
août 2008 à la
date de la présente assemblée;
131770
6. Transfert du siège social;
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2008136461/795/20.
Absolutissimo Fund, Fonds Commun de Placement.
Die Axxion S.A., H.R. Luxembourg B 82 112, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame Anlagen
''Absolutissimo Fund'', der den Bestimmungen des Teil II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen
für gemeinsame Anlagen unterliegt, am 15. Oktober 2008 gegründet. Als Depotbank fungiert die Banque de Luxembourg
S.A., Luxembourg.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 17. September 2008.
Axxion S.A. / Banque de Luxembourg S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2008125808/6633/18.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01520. - Reçu 44,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080148150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2008.
Absolutissimo Fund, Fonds Commun de Placement.
Die Axxion S.A., H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft beschlossen, den Teilfonds ''Xanti'' unter
dem Umbrellafonds ''Absolutissimo Fund'' (Organismus für gemeinsame Anlagen) aufzulegen, der den Bestimmungen des
Teil II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt. Als Depotbank
fungiert die Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg. Zeichnungen sind erstmals am 15. Oktober 2008 möglich.
Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 17. September 2008.
Axxion S.A. / Banque de Luxembourg S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2008125810/6633/18.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01518. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080148149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2008.
EcoLive S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.909.
In the year two thousand eight, on the ninth of October.
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
is held:
an extraordinary general meeting of shareholders of "EcoLive S.A.", a société anonyme having its registered office in
L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number
B 123.909, incorporated under the denomination UNITED MINDS pursuant to a notarial deed dated 22 December 2006,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 523 of 3 April 2007.
The articles of incorporation of the company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 1 August 2008, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting is opened at 11.30 a.m. with Mr Jacques Bonnier, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, in the chair,
131771
who appointed as secretary Mrs Claire Adam, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Bertrand Barthel, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
- Resignation of Mr Jean Quintus and Mr Joseph Winandy as directors of the company. Discharge to be granted.
- Amendments to be made to article 9 paragraph 10 of the articles of incorporation, as follows:
"The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the Board of Directors. Save as otherwise provided in these Articles, decisions shall be taken by the
majority of the votes of the directors present or represented at such meeting."
- Amendments to be made to article 9 paragraph 11 of the articles of incorporation, as follows:
"The decisions hereafter non-exhaustively listed shall be valid only if taken by unanimous vote of all the Directors:
- Any resolution concerning a transaction or a series of transactions with a Party having a cost in aggregate per year
exceeding EUR 1,000,000 (one million euro);
- Any resolution concerning a transaction or a series of transactions for the sale, transfer or other disposal of the
Company's assets (including shares, stock, etc.) having a book value of more than EUR 500,000 (five hundred thousand
euro);
- Any resolution concerning the issuance by the Company of new shares or securities, including but not limited to
securities convertible into shares;
- Any resolution concerning a change of the constitution, memorandum and/or articles of association of the Company
other than where the change is to effect capital increases or reductions with the exception of capital increases or de-
creases;
- Creation or issuance of any class of shares or other securities having preference;
- The grant of any guarantees, encumbrances, mortgages or pledges over real estate and or personal property or over
rights owned by the Company whenever the value of the assets being encumbered exceeds 1 % (one per cent) of the
aggregate amount of the total of the corporate capital of the Company as set out in article 5 of the present articles of
incorporation;
- Mergers, consolidations, divestitures, spin-offs relating to the Company;
- Any loan, credit, other obligation or liability of the Company exceeding EUR 5.000.000,- (five million euro);
- Any decisions to be taken by the Company as shareholder in its subsidiary companies or other companies where it
holds an interest;
- Any decisions to appoint one or more directors representing of the Company in relation to any of its subsidiary
companies or other companies where it holds an interest."
- Amendments to be made to article 12 paragraph 3 of the articles of incorporation, as follows:
"The Company shall be bound towards third parties by the signature of the sole director or, if there is more than one
by the joint signature of any two directors, or by the single signature of any person to whom such signatory power has
been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power."
II.- That the present or represented shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented share-
holders and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled
"ne varietur" by the persons appearing.
III.- That the whole share capital being present or represented at the present meeting, no convening notices were
necessary, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the
agenda prior to this meeting.
IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The general meeting accepts the resignation of Mr Jean Quintus and Mr Joseph Winandy as directors of the company
and by special vote grants them discharge for their mandate up to this date.
Upon resignation of Mr Jean Quintus and Mr Joseph Winandy, the general meeting acknowledges that the board of
directors is now composed by the following five members:
- Anatoly Goncharov, company director, residing at Kutuzovsky props., n° 35/30, ap. 49, Moscow, Russia;
- Alexander Rudik, company director, residing at Ostrovnoy proezd, n° 8, ap. 29-30, Moscow, Russia;
131772
- Dmitry Kotenko, company director, residing at Kostyakowa, n° 6/5, ap. 82, Moscow, Russia;
- Vassily Pozdyshev, company director, with professional address at Grosvenor Place 11, Belgravia, London SW1X
7HH, England;
- Paul Putz, company director, with professional address at Stubenring 18/4, 1010 Vienna, Austria.
<i>Second resolution:i>
The general meeting resolves to amend paragraph 10 of article 9 of the articles of incorporation to be read henceforth
as follows:
"The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the Board of Directors. Save as otherwise provided in these Articles, decisions shall be taken by the
majority of the votes of the directors present or represented at such meeting."
<i>Third resolution:i>
The general meeting resolves to amend paragraph 11 of article 9 of the articles of incorporation to read be as follows:
"The decisions hereafter non-exhaustively listed shall be valid only if taken by unanimous vote of all Directors:
- Any resolution concerning a transaction or a series of transactions with a Party having a cost in aggregate per year
exceeding EUR 1,000,000 (one million euro);
- Any resolution concerning a transaction or a series of transactions for the sale, transfer or other disposal of the
Company's assets (including shares, stock, etc.) having a book value of more than EUR 500,000 (five hundred thousand
euro);
- Any resolution concerning the issuance by the Company of new shares or securities, including but not limited to
securities convertible into shares;
- Any resolution concerning a change of the constitution, memorandum and/or articles of association of the Company
(with the exception of capital increases or decreases);
- Creation or issuance of any class of shares or other securities having preference;
- The grant of any guarantees, encumbrances, mortgages or pledges over real estate and or personal property or over
rights owned by the Company whenever the value of the assets being encumbered exceeds 1 % (one per cent) of the
aggregate amount of the total of the corporate capital of the Company as set out in article 5 of the present articles of
incorporation;
- Mergers, consolidations, divestitures, spin-offs relating to the Company;
- Any loan, credit, other obligation or liability of the Company exceeding EUR 5.000.000,- (five million euro);
- Any decisions to be taken by the Company as shareholder in its subsidiary companies or other companies where it
holds an interest;
Any decisions to appoint one or more directors representing of the Company in relation to any of its subsidiary
companies or other companies where it holds an interest."
<i>Fourth resolution:i>
The general meeting resolves to amend paragraph 3 of article 12 of the articles of incorporation to be read henceforth
as follows:
"The Company shall be bound towards third parties by the signature of the sole director or, if there is more than one
by the joint signature of any two directors, or by the single signature of any person to whom such signatory power has
been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power."
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at one thousand euro (EUR 1,500.00).
Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg, at the registered office of the the company, on the date
named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.
After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le neuf octobre.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie:
131773
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EcoLive S.A.", ayant son siège social à
L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 123.909, constituée sous la dénomination UNITED MINDS suivant acte notarié en date du 22 décembre 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 523 du 3 avril 2007.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 1 août 2008,
en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, 10, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bertrand Barthel, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Lu-
xembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
- Démission de Messieurs Jean Quintus et Joseph Winandy en tant qu'administrateurs de la société. Décharge à ac-
corder.
- Modification de l'alinéa 10 de l'article 9 des statuts comme suit:
"Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du Conseil d'Administration. A moins que les présents statuts n'en disposent
autrement, les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion."
- Modification de l'alinéa 11 de l'article 9 des statuts comme suit:
"Les décisions ci-après non exhaustivement listées seront prises uniquement à l'unanimité des membres du Conseil
d'Administration:
- Toute résolution concernant une transaction ou une série de transactions avec un tiers ayant un coût annuel global
excédant EUR 1.000.000,- (un million d'euros);
- Toute résolution concernant une transaction ou une série de transactions concernant la cession, le transfert ou toute
autre mesure portant sur les actifs de la Société (y compris ses actions et parts, son capital, etc) et ayant une valeur
comptable supérieure à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros);
- Toute résolution concernant l'émission par la Société de nouvelles actions ou titres, y compris mais non limité à
l'émission de titres convertibles en actions;
- Toute résolution concernant un changement de la constitution, du mémorandum et/ou des statuts de la Société (à
l'exception des augmentations et des diminutions de capital);
- Toute résolution concernant la création ou l'émission de toute classe d'actions ou d'autres titres préférentiels;
- Toute résolution concernant l'octroi de toutes garanties, hypothèques ou nantissement sur les biens immobiliers et/
ou personnels ou sur les droits appartenant à la Société si la valeur de ces actifs excède 1 % (un pour cent) du capital
social de la Société tel que fixé dans l'Article 5 des présents Statuts;
- Toute résolution concernant des fusions, acquisitions, regroupements, cessions ou scissions concernant la Société;
- Tout crédit, prêt, obligation ou créance de la Société dépassant EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros);
- Toute résolution à prendre par la Société en tant qu'actionnaire de ses filiales ou dans d'autres sociétés où la Société
détient un intérêt;
- Toute résolution nommant un ou plusieurs administrateurs représentant la Société auprès de toute filiale ou toutes
autres sociétés où la Société détient un intérêt."
- Modification de l'alinéa 3 de l'article 12 des statuts comme suit:
"La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature de l'administrateur unique ou, s'il
y en a plus d'un, par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature unique de tout fondé de pouvoirs
spéciaux auquel un tel pouvoir de signature a été conféré par le Conseil d'Administration et ce dans les limites du pouvoir
qui lui aura été conféré."
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées "ne varietur" par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
131774
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée générale accepte la démission de Messieurs Jean Quintus et Joseph Winandy en tant qu'administrateurs
de la société et par vote spécial leur accorde décharge pour leur mandat jusqu'à ce jour.
Suite à la démission de Messieurs Jean Quintus et Joseph Winandy l'assemblée générale constate que le conseil d'ad-
ministration est désormais composé par les cinq membres suivants:
- Anatoly Goncharov, administrateur de société, demeurant à Kutuzovsky props., n° 35/30, ap. 49, Moscou, Russie;
- Alexander Rudik, administrateur de société, demeurant à Ostrovnoy proezd, n° 8, ap. 29-30, Moscou, Russie;
- Dmitry Kotenko, administrateur de société, demeurant à Kostyakowa, n° 6/5, ap. 82, Moscou, Russie;
- Vassily Pozdyshev, administrateur de société, avec adresse professionnelle à Grosvenor Place 11, Belgravia, Londres
SW1X 7HH, Angleterre;
- Paul Putz, administrateur de société, avec adresse professionnelle à Stubenring 18/4, 1010 Vienne, Autriche.
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée générale décide de modifier le dixième alinéa de l'article 9 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
"Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du Conseil d'Administration. A moins que les présents statuts n'en disposent
autrement, les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion."
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée générale décide de modifier le onzième alinéa de l'article 9 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
"Les décisions ci-après non exhaustivement listées seront prises uniquement à l'unanimité des membres du Conseil
d'Administration:
- Toute résolution concernant une transaction ou une série de transactions avec un tiers ayant un coût annuel global
excédant EUR 1.000.000,- (un million d'euros);
- Toute résolution concernant une transaction ou une série de transactions concernant la cession, le transfert ou toute
autre mesure portant sur les actifs de la Société (y compris ses actions et parts, son capital, etc) et ayant une valeur
comptable supérieure à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros);
- Toute résolution concernant l'émission par la Société de nouvelles actions ou titres, y compris mais non limité à
l'émission de titres convertibles en actions;
- Toute résolution concernant un changement de la constitution, du mémorandum et/ou des statuts de la Société à
l'exception des augmentations et des diminutions de capital;
- Toute résolution concernant la création ou l'émission de toute classe d'actions ou d'autres titres préférentiels;
- Toute résolution concernant l'octroi de toutes garanties, hypothèques ou nantissement sur les biens immobiliers et/
ou personnels ou sur les droits appartenant à la Société si la valeur de ces actifs excède 1 % (un pour cent) du capital
social de la Société tel que fixé dans l'Article 5 des présents Statuts;
- Toute résolution concernant des fusions, acquisitions, regroupements, cessions ou scissions concernant la Société;
- Tout crédit, prêt, obligation ou créance de la Société dépassant EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros);
- Toute résolution à prendre par la Société en tant qu'actionnaire de ses filiales ou dans d'autres sociétés où la Société
détient un intérêt;
- Toute résolution nommant un ou plusieurs administrateurs représentant la Société auprès de toute filiale ou toutes
autres sociétés où la Société détient un intérêt."
<i>Quatrième résolution:i>
L'assemblée générale décide de modifier le troisième alinéa de l'article 12 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
"La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature de l'administrateur unique ou, s'il
y en a plus d'un, par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature unique de tout fondé de pouvoirs
spéciaux auquel un tel pouvoir de signature a été conféré par le Conseil d'Administration et ce dans les limites du pouvoir
qui lui aura été conféré."
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,00).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
131775
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
(Signé): Jacques Bonnier, Claire Adam, Bertrand Barthel et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 octobre 2008. LAC/2008/41986. Reçu 12,- € (douze euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 2008.
J. BADEN.
Référence de publication: 2008134241/7241/248.
(080157765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2008.
UniGarantPlus: BRIC (2014) II, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement, welches am 12. September 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsre-
gister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 1. Oktober 2008.
Union Investment Luxembourg S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2008132732/685/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2008, réf. LSO-CV05297. - Reçu 52,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080154657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.
UniGarantPlus: BRIC (2014) II, Fonds Commun de Placement.
Das Sonderreglement, welches am 12. September 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister
in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 1. Oktober 2008.
Union Investment Luxembourg S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2008132733/685/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2008, réf. LSO-CV05300. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080154656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2008.
Trust de Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-7626 Larochette, 55, Chemin J-A Zinnen.
R.C.S. Luxembourg B 141.297.
C.R.E., Société Anonyme.
Siège social: L-7626 Larochette, 55, Chemin J-A Zinnen.
R.C.S. Luxembourg B 110.718.
PROJET DE FUSION
L'an deux mille huit, le trente octobre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
ONT COMPARU:
1) La société anonyme TRUST DE LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-7626 Larochette, 55, Chemin J-A
Zinnen,représentée par Monsieur Ruslan UMSHVAIF, administrateur, avec adresse professionnelle à L-7626 Larochette,
131776
55, Chemin J-A Zinnen, agissant en tant que mandataire du Conseil d'Administration de cette société en vertu d'un pouvoir
lui conféré par décision du conseil d'administration de la prédite société prise en date du 1
er
octobre 2008.
2) La société anonyme C.R.E. S.A., ayant son siège social à L-7626 Larochette, 55, Chemin J-A Zinnen, représentée
par Monsieur Ruslan UMSHVAIF, administrateur, avec adresse professionnelle à L-7626 Larochette, 55, Chemin J-A
Zinnen, agissant en tant que mandataire du Conseil d'Administration de cette société en vertu d'un pouvoir lui conféré
par décision prise par le conseil d'administration de la prédite société en date du 1
er
octobre 2008;
Une copie certifiée conforme desdites décisions, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire
soussignée restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Lesquelles comparantes ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter les termes et conditions d'un projet
de fusion, à établir par les présentes entre les sociétés précitées par application de l'article 271,1) de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales en la forme notariée, projet dont la teneur est la suivante :
<i>1. Description de la fusioni>
La société anonyme TRUST DE Luxembourg S.A., détenant la totalité des actions de la société C.R.E. S.A., entend
fusionner conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
telle que modifiée (ci-après désignée la "Loi") avec la société anonyme C.R.E. S.A., par absorption de cette dernière.
<i>2. Modalités de la fusioni>
Description des sociétés qui fusionnent:
2.1 La société absorbante
La société anonyme TRUST DE LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-7626 Larochette, 55, Chemin J-A
Zinnen, est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.297, et a été constituée
le 30 juillet 2008 suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro2348 du 25 septembre 2008. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis, (ci-après dénommée "TRUST" ou
la "société absorbante").
2.2 La société absorbée
La société anonyme C.R.E S.A., ayant son siège social à L-7626 Larochette, 55, Chemin J-A Zinnen, inscrite au Registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 0110.718, a été constituée suivant acte reçu par Maître
Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 147 du 21 janvier 2006, dont les statuts ont été modifiés en date du 11 juillet 2008
par le notaire instrumentaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2037 du 22 août 2008.
Les statuts n'ont plus été modifiés depuis (ci-après dénommée "C.R.E." ou la "société absorbée").
La société absorbante et la société absorbée ont été constituées et existent toutes les deux sous la forme de société
anonyme de droit luxembourgeois, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée
(la "Loi").
3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme
accomplies pour le compte de la société absorbante est fixée au 30 octobre 2008.
4. Les deux sociétés n'ont pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux. De plus aucun titre autre que des actions n'a
été émis.
5. Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des conseils d'administration ou aux commissaires aux
comptes des sociétés qui fusionnent.
6. Les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion du premier et dernier exercice de la société absorbante, un
état comptable arrêté à une date qui n'est pas antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet
de fusion au cas ou les comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette
date, seront disponibles pendant un mois au moins avant la tenue des assemblées d'approbation par les actionnaires des
sociétés fusionnant, pour inspection par les actionnaires aux sièges sociaux.
7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit ont
le droit de requérir pendant le même délai comme indiqué ci-avant au point 6) la convocation d'une assemblée générale
de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. L'assemblée doit être convoquée de façon
à être tenue dans le mois de la réquisition.
8. A défaut de convocation d'une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive
un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C (la "Date Effective"), et entraînera de plein droit
les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>9. Effets de la fusioni>
9.1. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la Date
Effective. Décharge entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée.
9.2. Entre les sociétés qui fusionnent, la fusion aura effet à la Date Effective de telle manière que tous les actifs et tous
les passifs de la société absorbée seront censés être transférés à la société absorbante à cette date.
131777
9.2.1. La société absorbante deviendra propriétaire des biens qui lui ont été apportés par la société absorbée dans
l'état où ceux-ci se trouvent à la date effective sans droit de recours contre la société absorbée pour quelque raison que
ce soit.
9.2.2. La société absorbante acquittera à compter de la Date Effective tous impôts, contributions, taxes et redevances,
primes d'assurance et autres, tant ordinaires qu'extraordinaires, qui grèveront ou pourront grever la propriété des biens
apportés.
9.2.3. La société absorbante exécutera tous contrats et tous engagements de quelque nature que ce soit de la société
absorbée tels que ces contrats et engagements existent à la Date Effective.
9.2.4. La société absorbante assumera toutes les obligations et dettes de quelque nature que ce soit de la société
absorbée à compter de la Date Effective.
9.2.5. Les droits et créances compris dans le patrimoine de la société absorbée sont transférés à la société absorbante
avec toutes les garanties tant réelles que personnelles qui y sont attachées. La société absorbante sera ainsi subrogée,
sans qu'il y ait novation, dans les droits réels et personnels de la société absorbée en relation avec tous les biens et contre
tous les débiteurs sans exception.
10. Ainsi par l'effet de la fusion la société absorbée sera dissoute et toutes les actions qu'elle a émises seront annulées.
11. La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la
cession de tous les avoirs et obligations par la société absorbée à la société absorbante. Y sont comprises les formalités,
procédures, conditions et les publications qui sont prévues par les lois et règlements des pays étrangers dans lesquels
des biens patrimoniaux sujets à absorption sont situés. Dans toute la mesure exigée par la loi ou jugée nécessaire ou
utile, des documents de transfert appropriés seront signés par les sociétés qui fusionnent et la société absorbée apportera
tout son concours en vue de réaliser le transfert des actifs et passifs apportés par elle au profit de la société absorbante.
12. Le coût de l'opération de fusion sera supporté par la société absorbante. La société absorbante acquittera le cas
échéant les impôts dus par la société absorbée au titre des exercices non encore imposés définitivement.
13. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société
absorbante.
<i>Pouvoirsi>
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et
faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.
<i>Constatationi>
Le notaire soussignée déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article
271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états
et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Umshvaif et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2008. LAC/2008/44369. - Reçu douze euros (12.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2008.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2008138509/5770/113.
(080163857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2008.
Unicapital Investments IV, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion daté du 20 octobre 2008 et entrant en vigueur le 31 octobre 2008 a été déposé au Registre
de Commerce et de Sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
131778
Luxembourg, le 3 novembre 2008.
<i>Pour la société
i>UNICAPITAL INVESTMENTS IV (Management) S.A.
Signature
Référence de publication: 2008137114/267/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09447. - Reçu 44,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080161405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2008.
United Consumer Media SE, Société Européenne.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 96.549.
In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth day of the month of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of United Consumer Media SE (the "Company"), a
société européenne having its registered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg incorporated as a
société à responsabilité limitée, by deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed dated 13th October 2003 published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1218 of 19th October 2003 and converted
to a société anonyme by deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxem-
bourg on 7th May 2008 published in the Mémorial number 1187 of 16th May 2008. The Company has been converted
to a société européenne by deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, on 25th June 2008 published in the Mémorial
number 1759 of 17th July 2008.
The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by deed of M
e
Joseph Elvinger, prenamed,
on 25th June 2008 published in the Mémorial number 1759 of 17th July 2008.
The meeting was presided by Mr Paul de Haan, accountant, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Mr Dennis Bosje, accountant, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as secretary and
scrutineer.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by
the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain attached to this
document to be filed with the registration authorities.
2. It appears from said attendance list that all one hundred and twenty thousand (120.000) shares in issue are repre-
sented at the present general meeting.
3. All shareholders represented declared having had full knowledge of the agenda of the meeting and waive their rights
to prior notice so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.
4. On 17th July 2008 the board of directors of the Company resolved to propose to the shareholders of the Company
to transfer the registered office of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the United Kingdom.
5. All formalities with respect to the transfer of the registered office of the Company from the Grand Duchy of
Luxembourg to the United Kingdom as provided for by articles 101-2 à 101-9 of the law of 10th August 1915 on com-
mercial companies, as amended (the "Law") and by article 8 of the Council Regulation (EC) N
o
2157/2001 of 8th October
2001 on the Statute for a European company (the "Regulation"), have been complied with, in particular:
a) the board has drawn up a transfer proposal which was published in the Mémorial number 1820 of 24th July 2008,
i.e. at least two months prior to the holding of the present extraordinary general meeting of the shareholders of the
Company;
b) the board has drawn up a board report on the proposed transfer of registered office from the Grand Duchy of
Luxembourg to the United Kingdom in accordance with article 101-4 of the Law and article 8 (3) of the Regulation;
c) the board report and the transfer proposal were available for consultation to the creditors and the shareholders
and the shareholders and the creditors have been duly informed of their right to consult the board report and the transfer
proposal at the registered office of the Company one month prior to the present general meeting;
d) the creditors were duly informed of their right to apply for security to the Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg sitting in commercial matters within a two-month period starting on the date of publication of the transfer
proposal in the Mémorial;
e) the Company has no employees and no bondholders so that the requirements relating thereto are not applicable.
6. The agenda of the meeting was as follows:
131779
A. Presentation and approval of the transfer proposal as published in the Mémorial number 1820 of 24th July 2008
and the board report on the transfer of the registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to the United
Kingdom.
B. Approval of the change of nationality and approval of the transfer of the registered office of the Company from 17,
boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Ludgate House, 245 Blackfriars Road,
London SE1 9UY, United Kingdom.
C. Approval and adoption of new articles of association of the Company compliant with English law the proxyholder
being expressly authorised and empowered to make and agree to such changes and amendments as deemed appropriate.
D. Acceptance of the resignation Mr Jack Groesbeek, Mr Paul de Haan and Mr Dennis Bosje as directors of the
Company with effect from 25th September 2008 and appointment of the following persons as additional directors of the
Company until the annual general meeting of the shareholders of the Company approving the accounts for the financial
year which shall end 31st December 2008:
- Mrs Anne Claire Siddell, company secretary, born on 17th May 1954 in Pinner, United Kingdom, residing at 10 Hearn
Close, Manor Road, Penn, Bucks, HP10 8JT, United Kingdom;
- Mr Andrew Frank Crow, chartered accountant, born on 12th July 1957 in Bromley, United Kingdom, residing at 61
Palace Road, Tulse Hill, London, SW2 3LB, United Kingdom;
- Mr Peter Ian Wrankmore, chartered accountant, born on 10th April 1969 in Eastleigh, United Kingdom, residing at
5 Park Road, Bishops Waltham, Southampton, SO32 1BQ, United Kingdom; and
- Mr Nicolas Michael Perkins, international tax manager, born on 16th September 1969 in Bridgend, United Kingdom,
residing at Flat 1, 46 Islington Park Street, London, N1 1PX, United Kingdom.
E. Acceptance of the resignation of Mrs Valérie Fisson as statutory auditor of the Company with effect from 25th
September 2008.
Thereafter the meeting unanimously passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The transfer proposal relating to the transfer of the registered office of the Company from 17, boulevard Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, United
Kingdom as published in the Memorial number 1820 of 24th July 2008 and the board report thereon were presented to
the meeting.
Thereafter the general meeting carefully considered the terms thereof and resolved to approve such transfer proposal
subject to any amendments which appeared necessary as provided for in the following resolutions.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to change the nationality of the Company from Luxembourg to English and to transfer
the registered office of the Company from 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
to Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, United Kingdom with effect from the date on which the
Company will be registered with the Companies House.
<i>Third resolutioni>
The general meeting noted the proposed articles of association as set out in the transfer proposal published in the
Mémorial number 1820 of 24th July 2008 and noted that the new articles of association of the Company to be adopted
by it further to the transfer of the Company's registered office to the United Kingdom approved hereabove shall comply
with English law.
Therefore, the general meeting resolved to adopt new articles of association of the Company as follows:
"STATUTES
Interpretation
1. In these Statutes:
The following words and expressions have the following meanings:
1.1 "Acts" means the Companies Acts 1985 and 2006 including any statutory modification or re-enactment thereof
for the time being in force.
"address" in relation to an electronic communication includes any number or address used for the purposes of such
communication.
"administrative organ" means the body responsible for the management of the Company, and in these Statutes such
term is used interchangeably with, and should be construed synonymously with, the term "members", meaning the mem-
bers or any of them acting as the administrative organ of the Company. In addition, a reference in the Acts to the board
of directors or the directors shall be construed as a reference to the administrative organ or the members, respectively.
"auditors" means the auditors of the Company.
"clear days" in relation to the period of a notice means that period excluding the day when the notice is given or
deemed to be given and the day for which it is given or on which it is to take effect.
131780
"electronic communication" means the same as in the Electronic Communications Act 2000.
"executed" includes any mode of execution.
"member" means, except where the context otherwise required, a member of the administration organ of the Com-
pany, as such term is used in the Rules and "members" shall be construed accordingly.
"office" means the registered office of the Company.
"Rules" shall collectively mean Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European
Company (SE), Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European Company
with regard to the involvement of employees and The European Public Limited-Liability Company Regulations 2004
(Statutory Instrument 2004 No. 2326).
"secretary" means the secretary of the Company or any other person appointed to perform the duties of the secretary
of the Company, including a joint, assistant or deputy secretary.
"shareholder" in relation to shares means the shareholder whose name is entered in the register of shareholders as
the holder of the shares.
"Statutes" means the statutes of the Company, wherein are set forth, as required by the Rules, the rules for the
operation of the Company.
"uncertificated" in relation to a share means that, by virtue of legislation (other than section 778 of the Companies
Act 2006) permitting title to shares to be evidenced and transferred without a certificate, title to that share is evidenced
and may be transferred without a certificate.
"the United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland.
1.2 Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these Statutes bear the same meaning
as in the Acts or in the Rules as the case may be but excluding any statutory modification thereof not in force when these
Statutes become binding on the Company.
1.3 Powers of delegation shall not be restrictively construed but the widest interpretation shall be given to them.
1.4 No power of delegation shall be limited by the existence or, except where expressly provided by the terms of
delegation, the exercise of that or any other powers of delegation.
1.5 Except where expressly provided by the terms of delegation, the delegation of a power shall not exclude the
concurrent exercise of that power by any other body or person who is for the time being authorised to exercise it under
the Statutes or under another delegation of the power.
1.6 References to a document being executed include references to its being executed under hand or under seal or
by any other method.
1.7 Unless the context otherwise requires, any reference to "writing" or "written" shall include any method of repro-
ducing words or text in a legible and non-transitory form and for the avoidance of doubt shall include email.
1.8 Save where specifically required or indicated otherwise words importing one gender shall be treated as importing
any gender, words importing individuals shall be treated as importing corporations and vice versa, words importing the
singular shall be treated as importing the plural and vice versa, and words importing the whole shall be treated as including
a reference to any part thereof.
1.9 Clause and paragraph headings are inserted for ease of reference only and shall not affect construction.
Name and registered office
2. The Company's name is UNITED CONSUMER MEDIA SE.
3. The Company's registered office is situated at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, United
Kingdom.
Share capital
4. The subscribed capital of the Company shall amount to EUR 120,000.- and shall be divided into 120,000 par value
shares with a nominal value of EUR 1.00 each.
5. Subject to the provisions of the Acts and without prejudice to any rights attached to any existing shares, any share
may be issued with such rights or restrictions as the Company may by ordinary resolution determine.
6. Subject to the provisions of the Acts, shares may be issued which are to be redeemed or are to be liable to be
redeemed at the option of the Company or the shareholders on such terms and in such manner as may be provided by
these Statutes.
7. Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any share upon any trust and
(except as otherwise provided by these Statutes or by law) the Company shall not be bound by or recognise any interest
in any share except an absolute right to the entirety thereof in the holder.
8. The liability of the Company's shareholders is limited.
131781
No share certificates
9. None of the Company's shareholders shall be entitled to receive any share certificate(s) in respect of any shares in
the Company and the register of shareholders of the Company shall be conclusive evidence of a shareholder's title to
any shares of the Company.
Transfer of shares
10. The instrument of transfer of a share may be in any usual form or in any other form which the members may
approve and shall be executed by or on behalf of the transferor and, unless the share is fully paid, by or on behalf of the
transferee.
11. The Company shall be entitled to retain any instrument of transfer which is registered.
Transmission of shares
12. A person becoming entitled to a share in consequence of the merger or consolidation of any shareholder being a
corporation may, upon such evidence being produced as the members may properly require, elect either to become the
shareholder or to have some person nominated by him registered as the transferee. If he elects to become the share-
holder, he shall give notice to the Company to that effect. If he elects to have another person registered, he shall execute
an instrument of transfer of the share to that person. All provisions in the Statutes relating to the transfer of shares shall
apply to the notice or instrument of transfer as if it were an instrument of transfer executed by the shareholder and the
merger or consolidation of the shareholder had no occurred.
13. A person becoming entitled to a share in consequence of the merger or consolidation of any shareholder being a
corporation shall have the rights to which he would be entitled if he were the shareholder, except that he shall not, before
being registered as the shareholder, be entitled in respect of it to attend or vote at any meeting of the Company or at
any separate meeting of the shareholders of any class of shares in the Company.
Alteration of share capital
14. The Company may by ordinary resolution:
(a) increase its share capital by new shares of such amount as the resolution prescribes;
(b) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
(c) subject to the provisions of the Acts, sub-divide its shares, or any of them, into shares of smaller amount and the
resolution may determine that, as between the shares resulting from the sub-division, any of them may have any preference
or advantage as compared with the others; and
(d) cancel shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any
person and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled.
15. Subject to the provisions of the Acts, the Company may by special resolution reduce its share capital, any capital
redemption reserve and any share premium account in any way.
Purchase of own shares
16. Subject to the provisions of the Acts, the Company may purchase its own shares (including any redeemable shares).
General meetings
17. The Company shall hold a general meeting at least once every calendar year within six months of the end of its
financial year.
18. All general meetings other than annual general meetings shall be called general meetings.
19. The members may call general meetings and, on the requisition of shareholders pursuant to the provisions of the
Acts, shall forthwith proceed to convene a general meeting for a date not later than eights weeks after receipt of the
requisition.
Notice of general meetings
20. An annual general meeting shall be called by at least twenty-one clear days' notice. All other general meetings shall
be called by at least fourteen clear days' notice but a general meeting may be called by shorter notice if it is so agreed:
(a) in the case of an annual general meeting, by all the shareholders entitled to attend and vote thereat; and
(b) in the case of any other meeting by a majority in number of the shareholders having a right to attend and vote
being a majority together holding not less than ninety-five per cent in nominal value of the shares giving that right.
21. The notice shall specify the time and place of the meeting and the general nature of the business to be transacted
and, in the case of an annual general meeting, shall specify the meeting as such.
22. Subject to the provisions of the Statutes and to any restrictions imposed on any shares, the notice shall be given
to all the shareholders and to the auditors.
23. The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person
entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.
24. Where for any purpose an ordinary resolution of the Company is required, a special resolution shall also be
effective.
131782
Proceedings at general meetings
25. No business shall be transacted at any meeting unless a quorum is present. One person entitled to vote upon the
business to be transacted, being a shareholder or a proxy for a shareholder or a duly authority representative of a
corporation, shall be a quorum.
26. The shareholders present and entitled to vote at any general meeting shall choose one of their number to preside
as chairman of such meeting.
27. A resolution put to the vote of a meeting shall be decided on a show of hands unless before, or on the declaration
of the result of, the show of hands a poll is duly demanded by the chairman or any member present, in person or by
proxy, or duly authorised representative, and entitled to vote.
28. In the case of an equality of votes the chairman shall be entitled to a casting vote in addition to any other vote he
may have.
Votes of shareholders
29. Subject to any rights or restrictions attached to any shares every shareholder shall have one vote for every share
of which he is the shareholder.
30. Votes may be cast in person or by proxy.
31. A vote given or poll demanded by proxy or by the duly authorised representative of a corporation shall be valid
notwithstanding the previous determination of the authority of the person voting or demanding a poll unless notice of
the determination was received by the Company at the office or at such other place at which the instrument of proxy
was duly deposited or, where the appointment of the proxy was contained in an electronic communication, at the address
at which such appointment was duly received before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which
the vote is given or the poll demanded or (in the case of a poll taken otherwise than on the same day as the meeting or
adjourned meeting) the time appointed for taking the poll.
Numbers of members
32. Unless otherwise determined by ordinary resolution, the number of members shall not be subject to any maximum
but shall be not less than two.
Power of members
33. The Company shall operate under a one-tier system as prescribed by the Rules. Subject to the provisions of the
Rules, the Acts, the Statutes and to any directions given by special resolution, the business of the Company shall be
managed by the members who may exercise all the powers of the Company and the following transactions shall require
an express decision of the administrative organ:
(a) the appointment of any person to be and fulfil the role (as defined by the members) of (i) President; (ii) Vice-
President; (iii) Controller; and (iv) Treasurer for the Company;
(b) the disposal of the whole of the Company's undertaking or property or a substantial part thereof; and
(c) the acquisition of the whole or any substantial part of the undertaking, assets or business of any other company or
any firm or person or the entry into of any joint venture or partnership with any other person.
34. No alteration of the Statutes and no such direction shall invalidate any prior act of the members which would have
been valid if that alteration had not been made or that direction had not been given. The powers given by this Statute 34
shall not be limited by any special power given the members by the Statutes and a meeting of members at which a quorum
is present may exercise all powers exercisable by the members.
35. The members may, by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the agent of the Company for
such purposes and on such conditions as they determine, including authority for the agent to delegate all or any of his
powers.
36. The members shall be under a duty, even after they have ceased to hold office, not to divulge any information
which they have concerning the Company the disclosure of which might be prejudicial to the Company's interests, except
where such disclosure is required or permitted under law or is in the public interest.
Appointment and removal of members
37. Members previously appointed by shareholders' resolution shall continue as members for the duration of the terms
specified in those shareholders' resolutions unless removed earlier by an ordinary resolution of the Company. All mem-
bers shall be appointed (for a term of one year) either:
(i) by an ordinary resolution of the Company; or
(ii) by a decision of the members,
and may be removed prior to the expiration of the term of their appointment by ordinary resolution of the Company.
A member who is appointed by a decision of the members must retire at the next following annual general meeting.
38. A member whose term of appointment shall expire shall be eligible for reappointment once or more than once
but always such that any new appointment shall be for a term of one year and subject to such appointment (and any
131783
subsequent removal prior to the expiration of the term of their appointment) being made by an ordinary resolution of
the Company.
Disqualification and removal of members
39. The office of a member shall be vacated if:
(a) he ceases to be a member by virtue of any provision of the Acts or he becomes prohibited by law from being a
member; or
(b) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
(c) he is, or may be, suffering from mental disorder and either:
(i) he is admitted to hospital in pursuance of an application for admission for treatment under the Mental Health Act
1983 or, in Scotland, an application for admission under the Mental Health (Scotland) Act 1960; or
(ii) an order is made by a court having jurisdiction (whether in the United Kingdom or elsewhere) in matters concerning
mental disorder for his detention or for the apportionment of a receiver, curator bonis or other person to exercise
powers with respect to his property or affairs; or
(d) he resigns his office by notice to the Company.
Remuneration of members
40. The members shall be entitled to a remuneration and the reimbursement of their expenses as the Company by
ordinary resolution determines.
Proceedings of members
41. Subject to the provisions of the Statutes, the members may regulate their proceedings as they think fit. A member
may, and the secretary at the request of a member shall, call a meeting of the members and in any event shall do so at
least every three months to discuss the progress and foreseeable development of the Company's business. Notice of a
meeting of the members shall be deemed to be properly given to a member if it is given to him personally or by word of
mouth or sent in writing or by electronic communication to him at his last known address or any other address given by
him to the Company for this purpose. Any member may waive notice of a meeting and any such waiver may be retro-
spective. Questions arising at a meeting shall be decided by a majority of votes. In this case of an equality of votes, the
chairman shall have a second or casting vote.
42. The quorum for the transaction of the business of the members may be fixed by the members and unless so fixed
at any other number shall be two.
43. The continuing members or a sole continuing member may act notwithstanding any vacancies in their number, but,
if the number of members is less than the number fixed as the quorum, the continuing members of member may act only
for the purpose of calling a general meeting.
44. The members shall appoint one of their number to be chairman of the administrative organ and may at any time
remove him from that office. Unless he is unwilling to do so, the member so appointed shall preside at every meeting of
members at which he is present. If there is no member holding that office, or if the member holding it is unwilling to
preside or is not present within five minutes after the time appointed for the meeting, the members present may appoint
one of their number to be chairman of the meeting.
45. All acts done by a meeting of members, or of a committee of members, or by a person acting as a member shall,
notwithstanding that it be afterwards discovered that there was a defect in the appointment of any member or that any
of them were disqualified from holding office, or had vacated office, or were entitled not to vote, be as valid as if every
such person had been duly appointed and was qualified and had continued to be a member and had been entitled to vote.
46. A resolution in writing signed by all the members entitled to receive notice of a meeting of members or of a
committee of members shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of members or (as the case
may be) a committee of members duly convened and held and may consist of several documents in the like form each
signed by one or more members.
47. The contemporaneous connection of a number of the members not less than the quorum, regardless of the physical
location, by any means of electronic communication shall be deemed to constitute a properly held meeting of the members
so long as the following conditions are met:
(a) throughout the meeting each of the members taking part must be able to:
(i) hear each of the other members taking part; and
(ii) subject as mentioned below, send and receive communications simultaneously to and from all of the other members
taking part;
(b) at the beginning and at the conclusion of the meeting the chairman shall ask all of those who have been a party to
the proceedings to acknowledge their presence and to confirm that they have attended throughout the meeting.
Such a meeting shall be deemed to take place where it is convened to be held or (if no member is present in that
place) where the largest group of those participating is assembled, or, if there is no such group, where the chairman of
the meeting is located. The word "meeting" in the Statutes shall be construed accordingly.
131784
The meeting shall have been validly conducted notwithstanding that a member may have been accidentally disconnected
during the meeting, so long as a quorum of members was connected at all times. A minute of the proceedings shall be
sufficient evidence to the observance of the necessary formalities if certified by a member who was party to them.
48. Subject to such disclosure as is required by the Acts and the Statutes, a member shall be entitled to vote at any
meeting of members or of a committee of members on, and be counted in the quorum present at a meeting in relation
to, any resolution concerning a matter in which he has, directly or indirectly, an interest or duty which is material and
which conflicts or may conflict with the interest of the Company.
49. Each member is entitled to require the administrative organ to provide to him all information submitted to the
administrative organ.
Secretary
50. Subject to the provisions of the Acts, the secretary shall be appointed by the members for such term, at such
remuneration and upon such conditions as they may think fit, and any secretary so appointed may be removed by them.
51. Two or more joint secretaries, each of whom shall have full authority to act alone and independently of each other,
may be appointed pursuant to the provisions of Statute 50.
Minutes
52. The members shall cause minutes to be made in books kept for the purpose:
(a) of all appointments of officers made by the members; and
(b) of all proceedings at meetings of the Company, of the shareholders of any class of shares in the Company, and of
the members, and of committees of members, including the names of the members present at each such meeting.
Notices
53. Any notice to be given to or by any person pursuant to the Statutes (other than a notice calling a meeting of the
members) shall be in writing or shall be given using electronic communications to an address for the time being notified
for that purpose to the person giving the notice.
54. The Company may give any notice to a shareholder either personally or by sending it by post in a prepaid envelope
addressed to the shareholder at his registered address or by leaving it at the address or by giving it using electronic
communications to an address for the time being notified to the Company by the shareholder.
55. A shareholder present, either in person or by proxy, at any meeting of the Company or of the shareholders of
any class of shares in the Company shall be deemed to have received notice of the meeting and, where requisite, of the
purposes for which it was called.
56. Every person who becomes entitled to a share shall be bound by any notice in respect of that share which, before
his name is entered in the register of shareholders, has been duly given to a person from whom he derives his title.
57. Proof that an envelope containing a notice was properly addressed, prepaid and posted shall be conclusive evidence
that the notice was given. Proof that a notice contained in an electronic communication was sent in accordance with
guidance issued by the Institute of Chartered Secretaries and Administrators shall be conclusive evidence that the notice
was given. A notice shall be deemed to be given at the expiration of 48 hours after the envelope containing it was posted
or, in the case of a notice contained in an electronic communication, at the expiration of 48 hours after the time it was
sent.
Procedure for declaring dividends
58. The Company may by ordinary resolution declare dividends, and the members may decide to pay interim dividends.
59. A dividend must not be declared by ordinary resolution unless the members have made a recommendation as to
its amount. Such dividend must not exceed the amount recommended by the members.
60. No dividend may be declared or paid unless;
(a) it appears to the members that the profits available for distribution justify the payment; and
(b) it is in accordance with shareholders' respective rights.
61. Unless the ordinary resolution of the Company or members' decision to declare or pay a dividend, or the terms
on which shares are issued, specify otherwise, it must be paid by reference to each shareholders' holding of shares on
the date of the resolution or decision to declare or pay it.
62. If the Company's share capital is divided into different classes, no interim dividend may be paid on shares carrying
deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential dividend is in arrears.
63. The members may pay at intervals any dividend payable at a fixed rate if it appears to them that the profits available
for distribution justify the payment.
64. If the members act in good faith they do not incur any liability to the holders of shares conferring preferred rights
for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on shares with deferred or non-preferred rights.
Calculation of dividends
65. Except as otherwise provided by these Statutes or the rights attached to shares, all dividends must be:
131785
(a) declared and paid according to the amounts paid up on the shares on which the dividend is paid; and
(b) apportioned and paid proportionately to the amounts paid up on the shares during any portion or portions of the
period in respect of which the dividend is paid.
66. If any share is issued on terms providing that it ranks for dividend as from a particular date, the share ranks for
dividend accordingly.
67. For the purpose of calculating dividends, no account is to be taken of any amount which has been paid up on a
share in advance of the due date for payment of that amount.
Payment of dividends and other distributions
68. Where a dividend or other sum is payable in respect of a share, it must be paid by one or more of the following
means:
(a) transfer to a bank account specified by the distribution recipient in writing or by such other means as the members
decide;
(b) sending a cheque made payable to the distribution recipient by post to the distribution recipient at the distribution
recipient's registered address (if the distribution recipient is a holder of the share), or (in any other case) to an address
specified by the distribution recipient in writing or by such other means as the members decide;
(c) sending a cheque made payable to such person by post to such person at such address as the distribution recipient
has specified in writing or by such other means as the members decide; or
(d) any other means of payment (including by the allotment or transfer of further shares in accordance with these
Statutes) as the members agree with the distribution recipient in writing or by such other means as the members decide.
69. In these Statutes "distribution recipient" means, in the respect of a share in respect of which a dividend or other
sum is payable:
(a) the holder of the share; or
(b) if the share has two or more joint holders, whichever of them is named first in the register of members; or
(c) if the holder is no longer entitled to the share by reason of death or bankruptcy, or otherwise by operation of law,
the transmittee.
Deductions from distributions in respect of sums owed to the company
70. If a share is party paid for any part of the share's nominal value and any premium at which it has been issued, the
members may deduct from any dividend or other sum payable in respect of the share any sum of money which is payable
to the Company in respect of that share.
71. Money so deducted must be used to pay any of the sums payable in respect of that share.
72. The Company must notify the distribution recipient in writing of:
(a) the fact and amount of any such deduction;
(b) any non-payment of a dividend or other sum payable in respect of a share resulting from any such deduction; and
(c) how the money deducted has been applied.
No interest on distributions
73. The Company may not pay interest on any dividend or other sum payable in respect of a share unless otherwise
provided by:
(a) the terms on which the share was issued; or
(b) the provisions of another agreement between the holder of that share and the Company.
Unclaimed distributions
74. All dividends or other sums which are:
(a) payable in respect of shares; and
(b) unclaimed after having been declared or become payable,
must be invested or otherwise made use of by the members for the benefit of the Company until claimed.
75. The payment of such dividend or other sum into a separate account does not make the Company a trustee in
respect of it.
76. If:
(a) twelve years have passed from the date on which a dividend or other sum became due for payment; and
(b) the distribution recipient has not claimed it,
the distribution recipient is no longer entitled to that dividend or other sum and it ceases to remain owing by the
Company.
131786
Non-cash distributions
77. Subject to the terms of issue of the share in question, the Company may, by ordinary resolution on the recom-
mendation of the members, decide to pay all or part of a dividend or other sum payable in respect of a share by transferring
non-cash assets of equivalent value (including, without limitation, shares or other securities in any company).
78. If the shares in respect of which such a non-cash distribution is paid are uncertificated, any shares in the Company
which are issued as a non-cash distribution in respect of them must be uncertificated.
79. For the purpose of paying a non-cash distribution, the members may make whatever arrangement they think fit,
including:
(a) fixing the value of any assets;
(b) paying cash to any distribution recipient on the basis of that value in order to adjust the rights of recipients; and
(c) vesting any assets in trustees.
Waiver of distributions
80. Distribution recipients may waive their entitlement to a dividend or other sum payable in respect of a share by
giving the Company notice in writing to that effect, but if:
(a) the share has more than one holder; or
(b) more than one person is entitled to the share, whether by reason of the death or bankruptcy or one of more joint
holders, or otherwise,
the notice is not effective unless it is expressed to be given and signed, by all the holders or persons otherwise entitled
to the share.
Winding up
81. If the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the Company and any
other sanction required by the Acts, divide among the shareholders in specie the whole or any part of the assets of the
Company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the
shareholders or different classes of shareholders. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part
of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the shareholders as he with the like sanction determines, but
no shareholder shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.
Indemnity
82. Subject to the provisions of the Acts but without prejudice to any indemnity to which a member may otherwise
be entitled, every member or other officer of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against
any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour
or in which he is acquitted or in connection with any application in which relief is granted to him by the court from liability
for negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to the affairs of the Company.
83. Without prejudice to the provisions of Statute 82 and subject to what the Company by ordinary resolution of the
shareholders determines, the members may exercise all the powers of the Company to purchase and maintain insurance
for or for the benefit of any person who is or was a member, other officer or employee or auditor of the Company, or
any body which is or was the holding company or subsidiary undertaking of the Company, or in which the Company or
such holding company or subsidiary undertaking has or had any interest (whether direct or indirect) or with which the
Company or such holding company or subsidiary undertaking is or was in any way allied or associated against any liability
incurred by such person in respect of any act or omission in the actual or purported execution or discharge of his duties
or in the exercise or purported exercise of his powers or otherwise in relation to his duties, powers or officers in relation
to the relevant body or fund.
Exclusion of table A
84. Neither the regulations in Table A in the First Schedule to the Companies Act 1948 nor those in Table A in the
schedule to the Companies (Table A to F) Regulations 1985 as amended from time to time shall apply to the Company.
Objects
85. The Company's objects are to carry on the business of a general commercial company; to subscribe for, take,
purchase, or otherwise acquire, hold, sell, deal with and dispose of, place and underwrite shares, stocks, debentures,
debenture stocks, bonds, obligations or securities issues or guaranteed by any other company constituted or carrying on
business in any part of the world, and debentures, debenture stocks, bonds obligations or securities issued or guaranteed
by any government or authority, municipal, local or otherwise, in any part of the world; to carry on any other trade or
business which may seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the objects specified
in this Statute 85 or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render profitable any of the property,
assets or rights of the Company and to do all such things as are incidental or conducive to the above objects or any of
them."
131787
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting acknowledged and accepted the resignation of Mr Jack Groesbeek, Mr Paul de Haan and Mr
Dennis Bosje as directors of the Company with effect from 25th September 2008 and resolved to appoint the following
persons as additional directors of the Company until the annual meeting of the shareholders of the Company approving
the accounts for the financial year which shall end 31st December 2008:
- Mrs Anne Claire Siddell, company secretary, born on 17th May 1954 in Pinner, United Kingdom, residing at 10 Hearn
Close, Manor Road, Penn, Bucks, HP10 8JT, United Kingdom;
- Mr Andrew Frank Crow, chartered accountant, born on 12th July 1957 in Bromley, United Kingdom, residing at 61
Palace Road, Tulse Hill, London, SW2 3LB, United Kingdom;
- Mr Peter Ian Wrankmore, chartered accountant, born on 10th April 1969 in Eastleigh, United Kingdom, residing at
5 Park Road, Bishops Waltham, Southampton, SO32 1BQ, United Kingdom; and
- Mr Nicolas Michael Perkins, international tax manager, born on 16th September 1969 in Bridgend, United Kingdom,
residing at Flat 1, 46 Islington Park Street, London, N1 1PX, United Kingdom.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting acknowledged and accepted the resignation of Mrs Valérie Fisson as statutory auditor of the
company with effect from 25th September 2008.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the transfer of its registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to the United Kingdom are estimated
at two thousand Euro.
There being no further business on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.
Whereof, done in Luxembourg on the day before mentioned
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le vingt-cinquième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de United Consumer Media SE, (la "Société"), une
société européenne avec siège social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée sous forme d'une
société à responsabilité limitée par acte de Maître Joseph Elvinger, prénommé, du 19 novembre 2003 publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1218 du 19 novembre 2003 et convertie en une société
anonyme par acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
le 7 mai 2008 publié au Mémorial numéro 1187 du 16 mai 2008. La Société a été convertie en une société européenne
par acte de Maître Joseph Elvinger, prénommé, le 25 juin 2008 publié au Mémorial numéro 1759 le 17 juillet 2008.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Joseph Elvinger, prénommé, le 25
juin 2008 publié au Mémorial numéro 1759 le 17 juillet 2008.
L'assemblée a été présidée par M. Paul de Haan, comptable, résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
M. Dennis Bosje, comptable, résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, a été désigné comme secrétaire
et comme scrutateur.
Le président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
1. Les actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présence signée par
le président, le secrétaire et le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste restera annexée au présent acte pour
être soumise aux formalités d'enregistrement.
2. Il ressort de ladite liste que toutes les cent vingt mille (120.000) actions émises par la Société sont représentées à
la présente assemblée générale.
3. Tous les actionnaires représentés déclarent avoir eu une connaissance complète de l'ordre du jour de l'assemblée
et renoncer à leur droit à une convocation préalable de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les
points portés à l'ordre du jour.
4. Le 17 juillet 2008 le conseil d'administration de la Société a décidé de proposer aux actionnaires de la Société de
transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers le Royaume-Uni.
5. Toutes les formalités relatives au transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers le
Royaume-Uni telles que prévues par les articles 101-2 à 101-9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (la "Loi") et par l'article 8 du Règlement CE 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif
au statut de la société européenne (le "Règlement") ont été respectées, notamment:
131788
a) le conseil a établi un projet de transfert lequel a été publié au Mémorial numéro 1820 du 24 juillet 2008, c'est-à-
dire au moins deux mois avant la tenue de la présente assemblée générale des actionnaires de la Société;
b) le conseil a établi un rapport du conseil d'administration sur le transfert proposé du siège social du Grand-Duché
de Luxembourg vers le Royaume-Uni conformément à l'article 101-4 de la Loi et à article 8(3) du Règlement;
c) le rapport du conseil d'administration et le projet de transfert étaient disponibles à la consultation par les créanciers
et les actionnaires et les actionnaires et les créanciers ont été dûment informés de leur droit de consulter le rapport du
conseil d'administration et le projet de transfert au siège social de Société un mois avant la présente assemblée générale;
d) les créanciers ont été dûment informés de leur droit de demander au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg
siégeant en matière commerciale la constitution de sûretés pendant une période de deux mois à partir de la date de
publication du projet de transfert au Mémorial;
e) la Société n'a pas d'employés ni d'obligataires de sorte que les conditions y relatives ne sont pas applicables.
6. Que l'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:
A. Présentation et approbation du projet de transfert tel que publié au Mémorial numéro 1820 du 24 juillet 2008 et
du rapport du conseil d'administration concernant le transfert du siège social du Grand-Duché de Luxembourg vers le
Royaume-Uni.
B. Approbation du changement de nationalité et approbation du transfert du siège social de la société du 17, boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Londres SE1
9UY, Rouyaume-Uni.
C. Approbation et adoption de nouveaux statuts de la Société conformes au droit anglais, le mandataire étant ex-
pressément autorisé et ayant le pouvoir de procéder et de donner son accord aux modifications qui lui sembleront
appropriées.
D. Acceptation de la démission de M. Jack Groesbeek, M. Paul de Haan et M. Dennis Bosje en tant qu'administrateurs
de la Société avec effet au 25 septembre 2008 et nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs supplé-
mentaires de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes
annuels de l'année sociale prenant fin le 31 décembre 2008:
- Mme Anne Claire Siddell, secrétaire de société, née le 17 mai 1954 à Pinner, Royaume Uni, demeurant au 10 Hearn
Close, Manor Road, Penn, Bucks, HP10 8JT, Royaume Uni;
- M. Andrew Frank Crow, expert comptable, né le 12 juillet 1957 à Bromley, Royaume Uni, demeurant au 61 Palace
Road, Tulse Hill, Londres, SW2 3LB, Royaume Uni;
- M. Peter Ian Wrankmore, expert comptable, né le 10 avril 1969 à Eastleigh, Royaume Uni, demeurant au 5 Park Road,
Bishops Waltham, Southampton, SO32 1BQ, Royaume Uni; et
- M. Nicolas Michael Perkins, directeur fiscalité internationale, né le 16 septembre 1969 à Bridgend, Royaume Uni,
demeurant au Appartement 1, 46 Islington Park Street, Londres, N1 1PX, Royaume Uni.
E. Acceptation de la démission de Mme Valérie Fisson en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet
au 25 septembre 2008.
Suite à quoi, l'assemblée a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le projet de transfert concernant le transfert du siège social de la Société du 17, boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Londres SE1 9UY, Royaume-Uni,
tel que publié au Mémorial numéro 1820 du 24 juillet 2008 et du rapport du conseil d'administration y relatif ont été
présentés à l'assemblée.
Ensuite l'assemblée a attentivement examiné leurs termes et a décidé d'approuver le projet de transfert sous réserve
de toutes modifications nécessaires telles que prévues dans les résolutions suivantes.
<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise en anglaise et de transférer
le siège social de la Société du 17, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au Ludgate
House, 245 Blackfriars Road, Londres SE1 9UY, Royaume-Uni avec effet à partir de la date d'immatriculation de la Société
auprès de la Companies House.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée a pris note des statuts proposés tels que figurant au projet de transfert publié au Mémorial numéro 1820
du 24 juillet 2008 et a pris note que les statuts de la Société devant être adoptés suite au transfert du siège social de la
Société vers le Royaume-Uni approuvé ci-dessus doivent être conformes au droit anglais.
Par conséquent, l'assemblée a décidé d'adopter des nouveaux statuts de la Société comme suit:
"STATUTES
Interpretation
1. In these statutes:
131789
The following words and expressions have the following meanings:
1.1 "Acts" means the Companies Acts 1985 and 2006 including any statutory modification or re-enactment thereof
for the time being in force.
"address" in relation to an electronic communication includes any number or address used for the purposes of such
communication.
"administrative organ" means the body responsible for the management of the Company, and in these Statutes such
term is used interchangeably with, and should be construed synonymously with, the term "members", meaning the mem-
bers or any of them acting as the administrative organ of the Company. In addition, a reference in the Acts to the board
of directors or the directors shall be construed as a reference to the administrative organ or the members, respectively.
"auditors" means the auditors of the Company.
"clear days" in relation to the period of a notice means that period excluding the day when the notice is given or
deemed to be given and the day for which it is given or on which it is to take effect.
"electronic communication" means the same as in the Electronic Communications Act 2000.
"executed" includes any mode of execution.
"member" means, except where the context otherwise required, a member of the administration organ of the Com-
pany, as such term is used in the Rules and "members" shall be construed accordingly.
"office" means the registered office of the Company.
"Rules" shall collectively mean Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European
Company (SE), Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European Company
with regard to the involvement of employees and The European Public Limited-Liability Company Regulations 2004
(Statutory Instrument 2004 No. 2326).
"secretary" means the secretary of the Company or any other person appointed to perform the duties of the secretary
of the Company, including a joint, assistant or deputy secretary.
"shareholder" in relation to shares means the shareholder whose name is entered in the register of shareholders as
the holder of the shares.
"Statutes" means the statutes of the Company, wherein are set forth, as required by the Rules, the rules for the
operation of the Company.
"uncertificated" in relation to a share means that, by virtue of legislation (other than section 778 of the Companies
Act 2006) permitting title to shares to be evidenced and transferred without a certificate, title to that share is evidenced
and may be transferred without a certificate.
"the United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland.
1.2 Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these Statutes bear the same meaning
as in the Acts or in the Rules as the case may be but excluding any statutory modification thereof not in force when these
Statutes become binding on the Company.
1.3 Powers of delegation shall not be restrictively construed but the widest interpretation shall be given to them.
1.4 No power of delegation shall be limited by the existence or, except where expressly provided by the terms of
delegation, the exercise of that or any other powers of delegation.
1.5 Except where expressly provided by the terms of delegation, the delegation of a power shall not exclude the
concurrent exercise of that power by any other body or person who is for the time being authorised to exercise it under
the Statutes or under another delegation of the power.
1.6 References to a document being executed include references to its being executed under hand or under seal or
by any other method.
1.7 Unless the context otherwise requires, any reference to "writing" or "written" shall include any method of repro-
ducing words or text in a legible and non-transitory form and for the avoidance of doubt shall include email.
1.8 Save where specifically required or indicated otherwise words importing one gender shall be treated as importing
any gender, words importing individuals shall be treated as importing corporations and vice versa, words importing the
singular shall be treated as importing the plural and vice versa, and words importing the whole shall be treated as including
a reference to any part thereof.
1.9 Clause and paragraph headings are inserted for ease of reference only and shall not affect construction.
Name and registered office
2. The Company's name is UNITED CONSUMER MEDIA SE.
3. The Company's registered office is situated at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, United
Kingdom.
<i>Share capitali>
4. The subscribed capital of the Company shall amount to EUR 120,000.- and shall be divided into 120,000 par value
shares with a nominal value of EUR 1.00 each.
131790
5. Subject to the provisions of the Acts and without prejudice to any rights attached to any existing shares, any share
may be issued with such rights or restrictions as the Company may by ordinary résolution determine.
6. Subject to the provisions of the Acts, shares may be issued which are to be redeemed or are to be liable to be
redeemed at the option of the Company or the shareholders on such terms and in such manner as may be provided by
these Statutes.
7. Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any share upon any trust and
(except as otherwise provided by these Statutes or by law) the Company shall not be bound by or recognise any interest
in any share except an absolute right to the entirety thereof in the holder.
8. The liability of the Company's shareholders is limited.
No share certificates
9. None of the Company's shareholders shall be entitled to receive any share certificate(s) in respect of any shares in
the Company and the register of shareholders of the Company shall be conclusive evidence of a shareholder's title to
any shares of the Company.
Transfer of shares
10. The instrument of transfer of a share may be in any usual form or in any other form which the members may
approve and shall be executed by or on behalf of the transferor and, unless the share is fully paid, by or on behalf of the
transferee.
11. The Company shall be entitled to retain any instrument of transfer which is registered.
Transmission of shares
12. A person becoming entitled to a share in consequence of the merger or consolidation of any shareholder being a
corporation may, upon such evidence being produced as the members may properly require, elect either to become the
shareholder or to have some person nominated by him registered as the transferee. If he elects to become the share-
holder, he shall give notice to the Company to that effect. If he elects to have another person registered, he shall execute
an instrument of transfer of the share to that person. All provisions in the Statutes relating to the transfer of shares shall
apply to the notice or instrument of transfer as if it were an instrument of transfer executed by the shareholder and the
merger or consolidation of the shareholder had no occurred.
13. A person becoming entitled to a share in consequence of the merger or consolidation of any shareholder being a
corporation shall have the rights to which he would be entitled if he were the shareholder, except that he shall not, before
being registered as the shareholder, be entitled in respect of it to attend or vote at any meeting of the Company or at
any separate meeting of the shareholders of any class of shares in the Company.
Alteration of share capital
14. The Company may by ordinary résolution:
(a) increase its share capital by new shares of such amount as the résolution prescribes;
(b) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
(c) subject to the provisions of the Acts, sub-divide its shares, or any of them, into shares of smaller amount and the
résolution may determine that, as between the shares resulting from the sub-division, any of them may have any preference
or advantage as compared with the others; and
(d) cancel shares which, at the date of the passing of the résolution, have not been taken or agreed to be taken by any
person and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled.
15. Subject to the provisions of the Acts, the Company may by special résolution reduce its share capital, any capital
redemption reserve and any share premium account in any way.
Purchase of own shares
16. Subject to the provisions of the Acts, the Company may purchase its own shares (including any redeemable shares).
General meetings
17. The Company shall hold a general meeting at least once every calendar year within six months of the end of its
financial year.
18. All general meetings other than annual general meetings shall be called general meetings.
19. The members may call general meetings and, on the requisition of shareholders pursuant to the provisions of the
Acts, shall forthwith proceed to convene a general meeting for a date not later than eights weeks after receipt of the
requisition.
<i>Notice of general meetingsi>
20. An annual general meeting shall be called by at least twenty-one clear days' notice. All other general meetings shall
be called by at least fourteen clear days' notice but a general meeting may be called by shorter notice if it is so agreed:
(a) in the case of an annual general meeting, by all the shareholders entitled to attend and vote thereat; and
131791
(b) in the case of any other meeting by a majority in number of the shareholders having a right to attend and vote
being a majority together holding not less than ninety-five per cent in nominal value of the shares giving that right.
21. The notice shall specify the time and place of the meeting and the general nature of the business to be transacted
and, in the case of an annual general meeting, shall specify the meeting as such.
22. Subject to the provisions of the Statutes and to any restrictions imposed on any shares, the notice shall be given
to all the shareholders and to the auditors.
23. The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person
entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.
24. Where for any purpose an ordinary résolution of the Company is required, a special résolution shall also be
effective.
Proceedings at general meetings
25. No business shall be transacted at any meeting unless a quorum is present. One person entitled to vote upon the
business to be transacted, being a shareholder or a proxy for a shareholder or a duly authority representative of a
corporation, shall be a quorum.
26. The shareholders present and entitled to vote at any general meeting shall choose one of their number to preside
as chairman of such meeting.
27. A résolution put to the vote of a meeting shall be decided on a show of hands unless before, or on the declaration
of the result of, the show of hands a poll is duly demanded by the chairman or any member present, in person or by
proxy, or duly authorised representative, and entitled to vote.
28. In the case of an equality of votes the chairman shall be entitled to a casting vote in addition to any other vote he
may have.
Votes of shareholders
29. Subject to any rights or restrictions attached to any shares every shareholder shall have one vote for every share
of which he is the shareholder.
30. Votes may be cast in person or by proxy.
31. A vote given or poll demanded by proxy or by the duly authorised representative of a corporation shall be valid
notwithstanding the previous determination of the authority of the person voting or demanding a poll unless notice of
the determination was received by the Company at the office or at such other place at which the instrument of proxy
was duly deposited or, where the appointment of the proxy was contained in an electronic communication, at the address
at which such appointment was duly received before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which
the vote is given or the poll demanded or (in the case of a poll taken otherwise than on the same day as the meeting or
adjourned meeting) the time appointed for taking the poll.
Numbers of members
32. Unless otherwise determined by ordinary résolution, the number of members shall not be subject to any maximum
but shall be not less than two.
Power of members
33. The Company shall operate under a one-tier system as prescribed by the Rules. Subject to the provisions of the
Rules, the Acts, the Statutes and to any directions given by special résolution, the business of the Company shall be
managed by the members who may exercise all the powers of the Company and the following transactions shall require
an express decision of the administrative organ:
(a) the appointment of any person to be and fulfil the role (as defined by the members) of (i) President; (ii) Vice-
President; (iii) Controller; and (iv) Treasurer for the Company;
(b) the disposal of the whole of the Company's undertaking or property or a substantial part thereof; and
(c) the acquisition of the whole or any substantial part of the undertaking, assets or business of any other company or
any firm or person or the entry into of any joint venture or partnership with any other person.
34. No alteration of the Statutes and no such direction shall invalidate any prior act of the members which would have
been valid if that alteration had not been made or that direction had not been given. The powers given by this Statute 34
shall not be limited by any special power given the members by the Statutes and a meeting of members at which a quorum
is present may exercise all powers exercisable by the members.
35. The members may, by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the agent of the Company for
such purposes and on such conditions as they determine, including authority for the agent to delegate all or any of his
powers.
36. The members shall be under a duty, even after they have ceased to hold office, not to divulge any information
which they have concerning the Company the disclosure of which might be prejudicial to the Company's interests, except
where such disclosure is required or permitted under law or is in the public interest.
131792
Appointment and removal of members
37. Members previously appointed by shareholders' résolution shall continue as members for the duration of the terms
specified in those shareholders' resolutions unless removed earlier by an ordinary résolution of the Company. All mem-
bers shall be appointed (for a term of one year) either:
(i) by an ordinary résolution of the Company; or
(ii) by a decision of the members,
and may be removed prior to the expiration of the term of their appointment by ordinary résolution of the Company.
A member who is appointed by a decision of the members must retire at the next following annual general meeting.
38. A member whose term of appointment shall expire shall be eligible for reappointment once or more than once
but always such that any new appointment shall be for a term of one year and subject to such appointment (and any
subsequent removal prior to the expiration of the term of their appointment) being made by an ordinary résolution of
the Company.
Disqualification and removal of members
39. The office of a member shall be vacated if:
(a) he ceases to be a member by virtue of any provision of the Acts or he becomes prohibited by law from being a
member; or
(b) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
(c) he is, or may be, suffering from mental disorder and either:
(i) he is admitted to hospital in pursuance of an application for admission for treatment under the Mental Health Act
1983 or, in Scotland, an application for admission under the Mental Health (Scotland) Act 1960; or
(ii) an order is made by a court having jurisdiction (whether in the United Kingdom or elsewhere) in matters concerning
mental disorder for his detention or for the apportionment of a receiver, curator bonis or other person to exercise
powers with respect to his property or affairs; or
(d) he resigns his office by notice to the Company.
Remuneration of members
40. The members shall be entitled to a remuneration and the reimbursement of their expenses as the Company by
ordinary résolution determines.
Proceedings of members
41. Subject to the provisions of the Statutes, the members may regulate their proceedings as they think fit. A member
may, and the secretary at the request of a member shall, call a meeting of the members and in any event shall do so at
least every three months to discuss the progress and foreseeable development of the Company's business. Notice of a
meeting of the members shall be deemed to be properly given to a member if it is given to him personally or by word of
mouth or sent in writing or by electronic communication to him at his last known address or any other address given by
him to the Company for this purpose. Any member may waive notice of a meeting and any such waiver may be retro-
spective. Questions arising at a meeting shall be decided by a majority of votes. In this case of an equality of votes, the
chairman shall have a second or casting vote.
42. The quorum for the transaction of the business of the members may be fixed by the members and unless so fixed
at any other number shall be two.
43. The continuing members or a sole continuing member may act notwithstanding any vacancies in their number, but,
if the number of members is less than the number fixed as the quorum, the continuing members of member may act only
for the purpose of calling a general meeting.
44. The members shall appoint one of their number to be chairman of the administrative organ and may at any time
remove him from that office. Unless he is unwilling to do so, the member so appointed shall preside at every meeting of
members at which he is present. If there is no member holding that office, or if the member holding it is unwilling to
preside or is not present within five minutes after the time appointed for the meeting, the members present may appoint
one of their number to be chairman of the meeting.
45. All acts done by a meeting of members, or of a committee of members, or by a person acting as a member shall,
notwithstanding that it be afterwards discovered that there was a defect in the appointment of any member or that any
of them were disqualified from holding office, or had vacated office, or were entitled not to vote, be as valid as if every
such person had been duly appointed and was qualified and had continued to be a member and had been entitled to vote.
46. A résolution in writing signed by all the members entitled to receive notice of a meeting of members or of a
committee of members shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of members or (as the case
may be) a committee of members duly convened and held and may consist of several documents in the like form each
signed by one or more members.
47. The contemporaneous connection of a number of the members not less than the quorum, regardless of the physical
location, by any means of electronic communication shall be deemed to constitute a properly held meeting of the members
so long as the following conditions are met:
131793
(a) throughout the meeting each of the members taking part must be able to:
(i) hear each of the other members taking part; and
(ii) subject as mentioned below, send and receive communications simultaneously to and from all of the other members
taking part;
(b) at the beginning and at the conclusion of the meeting the chairman shall ask all of those who have been a party to
the proceedings to acknowledge their presence and to confirm that they have attended throughout the meeting.
Such a meeting shall be deemed to take place where it is convened to be held or (if no member is present in that
place) where the largest group of those participating is assembled, or, if there is no such group, where the chairman of
the meeting is located. The word "meeting" in the Statutes shall be construed accordingly.
The meeting shall have been validly conducted notwithstanding that a member may have been accidentally disconnected
during the meeting, so long as a quorum of members was connected at all times. A minute of the proceedings shall be
sufficient evidence to the observance of the necessary formalities if certified by a member who was party to them.
48. Subject to such disclosure as is required by the Acts and the Statutes, a member shall be entitled to vote at any
meeting of members or of a committee of members on, and be counted in the quorum present at a meeting in relation
to, any résolution concerning a matter in which he has, directly or indirectly, an interest or duty which is material and
which conflicts or may conflict with the interest of the Company.
49. Each member is entitled to require the administrative organ to provide to him all information submitted to the
administrative organ.
Secretary
50. Subject to the provisions of the Acts, the secretary shall be appointed by the members for such term, at such
remuneration and upon such conditions as they may think fit, and any secretary so appointed may be removed by them.
51. Two or more joint secretaries, each of whom shall have full authority to act alone and independently of each other,
may be appointed pursuant to the provisions of Statute 50.
Minutes
52. The members shall cause minutes to be made in books kept for the purpose:
(a) of all appointments of officers made by the members; and
(b) of all proceedings at meetings of the Company, of the shareholders of any class of shares in the Company, and of
the members, and of committees of members, including the names of the members present at each such meeting.
Notices
53. Any notice to be given to or by any person pursuant to the Statutes (other than a notice calling a meeting of the
members) shall be in writing or shall be given using electronic communications to an address for the time being notified
for that purpose to the person giving the notice.
54. The Company may give any notice to a shareholder either personally or by sending it by post in a prepaid envelope
addressed to the shareholder at his registered address or by leaving it at the address or by giving it using electronic
communications to an address for the time being notified to the Company by the shareholder.
55. A shareholder present, either in person or by proxy, at any meeting of the Company or of the shareholders of
any class of shares in the Company shall be deemed to have received notice of the meeting and, where requisite, of the
purposes for which it was called.
56. Every person who becomes entitled to a share shall be bound by any notice in respect of that share which, before
his name is entered in the register of shareholders, has been duly given to a person from whom he derives his title.
57. Proof that an envelope containing a notice was properly addressed, prepaid and posted shall be conclusive evidence
that the notice was given. Proof that a notice contained in an electronic communication was sent in accordance with
guidance issued by the Institute of Chartered Secretaries and Administrators shall be conclusive evidence that the notice
was given. A notice shall be deemed to be given at the expiration of 48 hours after the envelope containing it was posted
or, in the case of a notice contained in an electronic communication, at the expiration of 48 hours after the time it was
sent.
Procedure for declaring dividends
58. The Company may by ordinary résolution declare dividends, and the members may decide to pay interim dividends.
59. A dividend must not be declared by ordinary résolution unless the members have made a recommendation as to
its amount. Such dividend must not exceed the amount recommended by the members.
60. No dividend may be declared or paid unless;
(a) it appears to the members that the profits available for distribution justify the payment; and
(b) it is in accordance with shareholders' respective rights.
61. Unless the ordinary résolution of the Company or members' decision to declare or pay a dividend, or the terms
on which shares are issued, specify otherwise, it must be paid by reference to each shareholders' holding of shares on
the date of the résolution or decision to declare or pay it.
131794
62. If the Company's share capital is divided into different classes, no interim dividend may be paid on shares carrying
deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential dividend is in arrears.
63. The members may pay at intervals any dividend payable at a fixed rate if it appears to them that the profits available
for distribution justify the payment.
64. If the members act in good faith they do not incur any liability to the holders of shares conferring preferred rights
for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on shares with deferred or non-preferred rights.
Calculation of dividends
65. Except as otherwise provided by these Statutes or the rights attached to shares, all dividends must be:
(a) declared and paid according to the amounts paid up on the shares on which the dividend is paid; and
(b) apportioned and paid proportionately to the amounts paid up on the shares during any portion or portions of the
period in respect of which the dividend is paid.
66. If any share is issued on terms providing that it ranks for dividend as from a particular date, the share ranks for
dividend accordingly.
67. For the purpose of calculating dividends, no account is to be taken of any amount which has been paid up on a
share in advance of the due date for payment of that amount.
Payment of dividends and other distributions
68. Where a dividend or other sum is payable in respect of a share, it must be paid by one or more of the following
means:
(a) transfer to a bank account specified by the distribution recipient in writing or by such other means as the members
decide;
(b) sending a cheque made payable to the distribution recipient by post to the distribution recipient at the distribution
recipient's registered address (if the distribution recipient is a holder of the share), or (in any other case) to an address
specified by the distribution recipient in writing or by such other means as the members decide;
(c) sending a cheque made payable to such person by post to such person at such address as the distribution recipient
has specified in writing or by such other means as the members decide; or
(d) any other means of payment (including by the allotment or transfer of further shares in accordance with these
Statutes) as the members agree with the distribution recipient in writing or by such other means as the members decide.
69. In these Statutes "distribution recipient" means, in the respect of a share in respect of which a dividend or other
sum is payable:
(a) the holder of the share; or
(b) if the share has two or more joint holders, whichever of them is named first in the register of members; or
(c) if the holder is no longer entitled to the share by reason of death or bankruptcy, or otherwise by operation of law,
the transmittee.
Deductions from distributions in respect of sums owed to the company
70. If a share is party paid for any part of the share's nominal value and any premium at which it has been issued, the
members may deduct from any dividend or other sum payable in respect of the share any sum of money which is payable
to the Company in respect of that share.
71. Money so deducted must be used to pay any of the sums payable in respect of that share.
72. The Company must notify the distribution recipient in writing of:
(a) the fact and amount of any such deduction;
(b) any non-payment of a dividend or other sum payable in respect of a share resulting from any such deduction; and
(c) how the money deducted has been applied.
No interest on distributions
73. The Company may not pay interest on any dividend or other sum payable in respect of a share unless otherwise
provided by:
(a) the terms on which the share was issued; or
(b) the provisions of another agreement between the holder of that share and the Company.
Unclaimed distributions
74. All dividends or other sums which are:
(a) payable in respect of shares; and
(b) unclaimed after having been declared or become payable,
must be invested or otherwise made use of by the members for the benefit of the Company until claimed.
75. The payment of such dividend or other sum into a separate account does not make the Company a trustee in
respect of it.
131795
76. If:
(a) twelve years have passed from the date on which a dividend or other sum became due for payment; and
(b) the distribution recipient has not claimed it,
the distribution recipient is no longer entitled to that dividend or other sum and it ceases to remain owing by the
Company.
Non-cash distributions
77. Subject to the terms of issue of the share in question, the Company may, by ordinary résolution on the recom-
mendation of the members, decide to pay all or part of a dividend or other sum payable in respect of a share by transferring
non-cash assets of equivalent value (including, without limitation, shares or other securities in any company).
78. If the shares in respect of which such a non-cash distribution is paid are uncertificated, any shares in the Company
which are issued as a non-cash distribution in respect of them must be uncertificated.
79. For the purpose of paying a non-cash distribution, the members may make whatever arrangement they think fit,
including:
(a) fixing the value of any assets;
(b) paying cash to any distribution recipient on the basis of that value in order to adjust the rights of recipients; and
(c) vesting any assets in trustees.
Waiver of distributions
80. Distribution recipients may waive their entitlement to a dividend or other sum payable in respect of a share by
giving the Company notice in writing to that effect, but if:
(a) the share has more than one holder; or
(b) more than one person is entitled to the share, whether by reason of the death or bankruptcy or one of more joint
holders, or otherwise,
the notice is not effective unless it is expressed to be given and signed, by all the holders or persons otherwise entitled
to the share.
Winding up
81. If the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of a special résolution of the Company and any
other sanction required by the Acts, divide among the shareholders in specie the whole or any part of the assets of the
Company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the
shareholders or different classes of shareholders. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part
of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the shareholders as he with the like sanction determines, but
no shareholder shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.
Indemnity
82. Subject to the provisions of the Acts but without prejudice to any indemnity to which a member may otherwise
be entitled, every member or other officer of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against
any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour
or in which he is acquitted or in connection with any application in which relief is granted to him by the court from liability
for negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to the affairs of the Company.
83. Without prejudice to the provisions of Statute 82 and subject to what the Company by ordinary résolution of the
shareholders determines, the members may exercise all the powers of the Company to purchase and maintain insurance
for or for the benefit of any person who is or was a member, other officer or employee or auditor of the Company, or
any body which is or was the holding company or subsidiary undertaking of the Company, or in which the Company or
such holding company or subsidiary undertaking has or had any interest (whether direct or indirect) or with which the
Company or such holding company or subsidiary undertaking is or was in any way allied or associated against any liability
incurred by such person in respect of any act or omission in the actual or purported execution or discharge of his duties
or in the exercise or purported exercise of his powers or otherwise in relation to his duties, powers or officers in relation
to the relevant body or fund.
Exclusion of table A
84. Neither the regulations in Table A in the First Schedule to the Companies Act 1948 nor those in Table A in the
schedule to the Companies (Table A to F) Regulations 1985 as amended from time to time shall apply to the Company.
Objects
85. The Company's objects are to carry on the business of a general commercial company; to subscribe for, take,
purchase, or otherwise acquire, hold, sell, deal with and dispose of, place and underwrite shares, stocks, debentures,
debenture stocks, bonds, obligations or securities issues or guaranteed by any other company constituted or carrying on
business in any part of the world, and debentures, debenture stocks, bonds obligations or securities issued or guaranteed
by any government or authority, municipal, local or otherwise, in any part of the world; to carry on any other trade or
business which may seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the objects specified
131796
in this Statute 85 or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render profitable any of the property,
assets or rights of the Company and to do all such things as are incidental or conducive to the above objects or any of
them."
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale a constaté et accepté la démission de M. Jack Groesbeek, M. Paul de Haan et M. Dennis Bosje
en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 25 septembre 2008 et a décidé de nommer les personnes suivantes
en tant qu'administrateurs supplémentaires de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la
Société qui statuera sur les comptes annuels de l'année sociale prenant fin le 31 décembre 2008:
- Mme Anne Claire Siddell, secrétaire de société, née le 17 mai 1954 à Pinner, Royaume Uni, demeurant au 10 Hearn
Close, Manor Road, Penn, Bucks, HP10 8JT, Royaume Uni;
- M. Andrew Frank Crow, expert comptable, né le 12 juillet 1957 à Bromley, Royaume Uni, demeurant au 61 Palace
Road, Tulse Hill, Londres, SW2 3LB, Royaume Uni;
- M. Peter Ian Wrankmore, expert comptable, né le 10 avril 1969 à Eastleigh, Royaume Uni, demeurant au 5 Park Road,
Bishops Waltham, Southampton, SO32 1BQ, Royaume Uni; et
- M. Nicolas Michael Perkins, directeur fiscalité internationale, né le 16 septembre 1969 à Bridgend, Royaume Uni,
demeurant à l'Appartement 1, 46 Islington Park Street, Londres, N1 1PX, Royaume Uni.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale a constaté et accepté la démission de Madame Valérie Fisson en tant que commissaire aux
comptes de la Société avec effet au 25 septembre 2008.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,
en raison du transfert du siège social du Grand-Duché de Luxembourg vers le Royaume-Uni sont évalués à deux mille
Euros.
Aucun point ne restant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en
langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Paul de Haan, D. Bosje, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 septembre 2008, LAC/2008/39507. — Reçu € 12,- (douze euros).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
Pour copie conforme à l'original délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008138465/211/1018.
(080161991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
BN & Partner Platinum Fund, Fonds Commun de Placement.
AUFLÖSUNG
Gemäß Beschluss des Verwaltungsrates der Hauck Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. vom 16. Oktober 2008
wurde das Sondervermögen BN & Partner Platinum Fund am 6. November 2008 aus wirtschaftlichen Gründen aufgelöst.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, im November 2008.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Référence de publication: 2008139698/1346/11.
131797
Trans IV (Luxembourg) Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 132.498.
Retail Park Sandweiler S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 45.278.
PROJET DE FUSION
L'an deux mille huit, le trente octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
I.- Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,
agissant en tant que mandataire du conseil de gérance de la société à responsabilité limitée "TRANS IV (LUXEM-
BOURG) RETAIL S.à R.L.", établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, R.C.S. Luxembourg
section B numéro 132.498,
constituée initialement sous la dénomination "LuxCo 60 S.à r.l." suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 28 septembre 2007, publié au Mémorial C numéro 2571 du 12 novembre 2007,
et dont la dénomination a été modifiée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire préqualifié, en date du
12 octobre 2007, publié au Mémorial C numéro 2846 du 7 décembre 2007,
ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune;
en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil de gérance, prise en sa réunion du 29 octobre 2008;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
II.- Mademoiselle Françoise HÜBSCH, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route
de Luxembourg,
agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme "RETAIL PARK SANDWEILER S.A.",
établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, R.C.S. Luxembourg section B numéro 45.278,
constituée initialement sous la dénomination "TROBAU S.A.", suivant acte reçu le 28 septembre 1993, publié au Mémorial
C numéro 574 du 3 décembre 1993,
et dont la dénomination a été modifiée dernièrement suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 14 novembre 2007, publié au Mémorial C numéro 166 du 22 janvier 2008,
ayant un capital social d'un million quatre cent mille euros (1.400.000,- EUR), représenté par huit cents (800) actions
avec une valeur nominale de mille sept cent cinquante euros (1.750,- EUR) chacune,
en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 29 octobre 2008;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'acter:
1.- Que la société à responsabilité limitée "TRANS IV (LUXEMBOURG) RETAIL S.à R.L.", préqualifiée, détient la totalité
(100%) des huit cents (800) actions donnant droit de vote, représentant la totalité du capital social de la société anonyme
"RETAIL PARK SANDWEILER S.A.", préqualifiée;
2.- Que la société à responsabilité limitée "TRANS IV (LUXEMBOURG) RETAIL S.à R.L." entend fusionner avec la
société anonyme "RETAIL PARK SANDWEILER S.A.", par absorption de cette dernière;
3.- Que la fusion est faite pour la raison suivante:
La société absorbante ayant comme actif principal la totalité des actions de la société absorbée, le maintien de deux
structures distinctes ne se justifie plus d'un point de vue économique.
4.- Que la société anonyme "RETAIL PARK SANDWEILER S.A." a, à ce jour, pour principal actif le bien immobilier
suivant:
Un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments commerciaux et situé à Sandweiler - Lieu-dit "op der Hohkaul"
et "op dem Kappellenberg" - Route du Luxembourg, cadastré comme suit:
Section A de Sandweiler:
Lieu-dit "op der Hohkaul":
* Parcelle n° 85/4415: 28 ares 76 centiares
* Parcelle n° 85/4416: 27 ares 11 centiares
131798
* Parcelle n° 85/4452: 65 ares 36 centiares
Lieu-dit "op dem Kappellenberg":
* Parcelle n° 10/4367: 45 ares 20 centiares
<i>Titre de propriétéi>
Le bien immobilier ci-avant désigné appartient à la société anonyme "RETAIL PARK SANDWEILER S.A." pour l'avoir
acquis comme suit:
- la parcelle numéro 85/4452 suivant acte de vente reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 29 décembre 1993, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 14 janvier
1994, volume 1365, numéro 129;
- la parcelle numéro 85/4416 suivant acte de vente reçu par Maître Frank BADEN, notaire prénommé, en date du 3
février 1994, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 25 février 1994, volume 1370, numéro 112;
- la parcelle numéro 85/4415 suivant acte de vente reçu par Maître Frank BADEN, notaire prénommé, en date du 29
juillet 1994, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 22 août 1994, volume 1390, numéro 113;
- la parcelle numéro 10/4367 suivant acte de vente reçu par Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de rési-
dence à Luxembourg, en date du 29 juin 2004, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 16 juillet
2004, volume 1867, numéro 33.
Cet ensemble immobilier a été inscrit au bilan de la société absorbée au coût historique de EUR 6.731.397,37.
La valeur nette comptable au 31 mai 2008 de cet ensemble est de EUR 6.051.005,50.
5.- Que la date à partir de laquelle les opérations de la société anonyme "RETAIL PARK SANDWEILER S.A." sont
considérées du point de vue comptable comme accomplies par la société absorbante a été fixée au 31 mai 2008;
6.- Que les apports de la société anonyme "RETAIL PARK SANDWEILER S.A." peuvent être décrits comme suit:
A) Actif apporté
L'actif apporté par la société absorbée à la société absorbante comprendra les éléments suivants:
* Actifs immobilisés:
- Immobilisations corporelles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
6.051.005,50
- Immobilisations incorporelles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5.645,57
* Actifs circulants:
- Créances commerciales et rattachées: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
34.123,23
- Autres créances: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
93.274,64
- Liquidités: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
255.038,87
- Charges constatées d'avance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5.908,35
* Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
6.444.996,16
L'ensemble des éléments d'actif apportés est évalué à EUR 6.444.996,16.
B) Passif pris en charge
Le passif apporté par la société absorbée et qui sera pris en charge par la société absorbante comprendra les éléments
suivants:
* Provisions:
- Provisions pour risques et charges: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
175.000,-
- Provisions pour taxes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
165.343,52
* Dettes:
- Entités affiliées:
Echéance supérieure à un an: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4.064.083,62
- Dettes fiscales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
32.648,94
- Autres dettes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
33.276,30
- Charges à payer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
11.322,41
* Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4.481.674,79
L'ensemble des éléments de passif qui seront pris en charge par la société à responsabilité limitée "TRANS IV (LU-
XEMBOURG) RETAIL S.à R.L." est évalué à EUR 4.481.674,79, comprenant une dette d'un montant de EUR 4.064.083,62
dont le bénéficiaire est la société absorbante.
C) Actif net apporté
La différence entre l'actif apporté et le passif pris en charge, c'est-à-dire, l'actif net apporté par la société absorbée à
la société absorbante, est évalué à:
131799
- Actif apporté: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
6.444.996,16
- Passif pris en charge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4.481.674,79
Soit actif net apporté: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1.963.321,37
En dehors de ce qui précède, la société absorbante prendra à sa charge tous les engagements qui ont pu être contractés
par la société absorbée et qui, en raison de leur caractère éventuel, sont repris "hors bilan" sous les rubriques ci-après:
- cautions, avals, garanties donnés par l'entreprise;
- autres engagements.
7.- Que le mali technique de fusion représente l'écart négatif entre la valeur de l'actif net apporté et la valeur nette
comptable de la participation détenue par la société absorbante dans le capital de la société absorbée telle qu'elle figure
dans les comptes de la société absorbante au 31 mai 2008.
Actif net apporté: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1.963.321,37
Valeur comptable de la participation de la société absorbante dans la société absorbée: . . . . . EUR
8.932.715,78
Mali technique de fusion: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
6.969.394,41
Ce mali de fusion sera inscrit à l'actif du bilan de la société absorbante en tant qu'immobilisation incorporelle à un
compte "fonds commercial".
8.- Qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux organes de direction des sociétés qui fusionnent;
9.- Que la fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales;
10.- Que les associés de la société à responsabilité limitée "TRANS IV (LUXEMBOURG) RETAIL S.à R.L." ont le droit,
pendant un mois à compter de la publication au Mémorial du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social,
des documents indiqués à l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et qu'une copie de ces
documents peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande;
11.- Qu'un ou plusieurs associés de la société à responsabilité limitée "TRANS IV (LUXEMBOURG) RETAIL S.à R.L."
disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des parts du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai,
la convocation d'une Assemblée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion;
12.- Qu'à défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra
définitive comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales;
13.- Que les mandats d'administrateurs de la société absorbée prennent fin à la date de la fusion et que décharge est
accordée aux administrateurs de la société absorbée;
14.- Que la société absorbante procèdera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et
à la cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée;
15.- Que le régime fiscal applicable aux opérations de fusion sera le suivant:
- En matière de droits d'enregistrement, la présente fusion sera enregistrée moyennant le paiement du seul droit fixe
de EUR 12,-.
- Concernant l'imposition de la société absorbée: la fusion sera exonérée sur le fondement de l'article 170 (2) de la
loi sur l'impôt sur le revenu, la société absorbante s'engageant à reprendre dans ses livres les éléments d'actif à leur valeur
comptable telle qu'inscrite dans le dernier bilan de la société absorbée arrêté au 31 mai 2008.
- Concernant l'imposition de la société absorbante: la fusion sera considérée comme "neutre" fiscalement sur le fon-
dement de l'article 171 (1) de la loi sur l'impôt sur le revenu, les actions de la société absorbée étant éliminées à leur
valeur d'exploitation telle que définie à l'article 27 (1) de la loi sur l'impôt sur le revenu.
L'acquisition de ces actions ayant eu lieu récemment (15 février 2008), la valeur d'exploitation est en effet la même
que la valeur d'acquisition.
Si la valeur d'exploitation avait été supérieure à la valeur d'acquisition, la plus-value ainsi obtenue aurait de toute façon
été exonérée en vertu de l'article 171 (3) de la loi sur l'impôt sur le revenu.
16.- Que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société
absorbante.
<i>Formalitési>
La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con-
viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits apportés.
131800
<i>Remise des titresi>
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous
ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs
mobilières ainsi que tous contrats (de prêt, de travail, de fiducie, ....) archives, pièces et autres documents quelconques
relatifs aux éléments et droits apportés.
<i>Frais et droitsi>
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
<i>Election de domicilei>
Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour
toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.
<i>Pouvoirsi>
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et
faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article
271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
(Signé): THILL - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 novembre 2008. Relation GRE/2008/4352. - Reçu Douze euros 12,- €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Junglinster, le 6 novembre 2008.
J. SECKLER.
Référence de publication: 2008138511/231/189.
(080163747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2008.
Brookstone S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 88.436.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05.11.2008.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme - Luxembourg
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
i>Signature
Référence de publication: 2008138239/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09771. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080162167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Financière Verbois S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 83.377.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
131801
Luxembourg, le 05.11.2008.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme - Luxembourg
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
i>Signature
Référence de publication: 2008138240/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09700. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080162164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Hambleton Hall S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 59.019.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05.11.2008.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme - Luxembourg
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
i>Signature
Référence de publication: 2008138241/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09690. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080162161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Belaton SA, Société Anonyme.
Siège social: L-6930 Mensdorf, rue d'Uebersyren.
R.C.S. Luxembourg B 25.996.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2008138228/279/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2008, réf. LSO-CV07516. - Reçu 42,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080162062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Café Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9370 Gilsdorf, 33, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 103.007.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J. F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature
Référence de publication: 2008138221/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2008, réf. DSO-CV00335. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080162091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
S.I. GROUP Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3370 Leudelange, 5, Zoning de Grasbusch.
R.C.S. Luxembourg B 18.321.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
131802
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature
Référence de publication: 2008138222/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2008, réf. DSO-CV00336. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080162087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
L.S. Lux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 92.117.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature
Référence de publication: 2008138220/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2008, réf. DSO-CV00334. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080162093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
"Mikado Management S.A.H.", Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 91.867.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008138224/1268/12.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09953. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080162078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
BHG Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 76, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 121.651.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04/11/2008.
<i>Pour BHG Luxembourg SARL
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Référence de publication: 2008138192/503/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08409. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080162076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Immobilière des Dahlias S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 87.132.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
131803
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008138223/1268/12.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09727. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080162081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Architect-Consult/ Zigrand Jean-Paul S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7210 Walferdange, 1, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 105.759.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature
Référence de publication: 2008138219/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2008, réf. DSO-CV00333. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(080162096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
ARISTOTE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 29.567.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2008.
Henri Aronson
<i>Géranti>
Référence de publication: 2008138296/713/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08486. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080162157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
ARISTOTE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 29.567.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2008.
Henri Aronson
<i>Géranti>
Référence de publication: 2008138297/713/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08484. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080162153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
ARISTOTE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 29.567.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
131804
Luxembourg, le 21 octobre 2008.
Henri Aronson
<i>Géranti>
Référence de publication: 2008138295/713/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08488. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080162160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
AMP Capital Investors (Angel Trains EU No. 1) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 141.767.
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 16 octobre 2008 que, sur base du contrat de transfert
de parts sociales signé en date du 16 octobre 2008, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales
de la société de EUR 1,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
DESIGNATION DE L'ASSOCIE
NOMBRE
DE PARTS
SOCIALES
AMP Capital Investors (Luxembourg n° 1) S. à r.l. , 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg . . . .
8.625
AMP Capital Investors (CIF European Infrastructure n° 3) S. à r.l., 12-14, rue Léon Thyes,
L-2636 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.852
AMP Capital Investors (FDF European Infrastructure n° 3) S. à r.l., 12-14, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.523
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.000
Luxembourg, le 17 octobre 2008.
Bart Zech
<i>Géranti>
Référence de publication: 2008138278/724/26.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2008, réf. LSO-CW00620. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080162554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Ondicium S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 103.378.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 novembre 2008.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008138451/263/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2008, réf. LSO-CV07546. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080161924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Hilaire S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 42.405.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
131805
Luxembourg, le 04 novembre 2008.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008138450/263/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2008, réf. LSO-CV07550. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080161923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Hilaire S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 42.405.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 novembre 2008.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008138449/263/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2008, réf. LSO-CV07551. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080161922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Global Logistics Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 132.580.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2008138441/1267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03446. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080162008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Alteus Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 110.341.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04/11/2008.
Abroad Fiduciaire Sarl
Signature
Référence de publication: 2008138444/6951/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV05028. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080161918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Européenne de Santé S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 125.742.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
131806
Luxembourg, le 04/11/2008.
Abroad Fiduciaire Sarl
Signature
Référence de publication: 2008138443/6951/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV05027. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080161916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Lipid Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 62.212.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 Novembre 2008.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008138445/263/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV05160. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080161920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Institut Financier Européen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 38.180.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008138435/4181/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08389. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080161980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Watamar Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 16.257.
L'an deux mille huit, le six octobre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding WATAMAR HOLD-
ING S.A., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 16.257,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Rambrouch, en date du 26
octobre 1978, publié au Mémorial C numéro 18 du 26 janvier 1979,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 décembre
1985, publié au Mémorial C numéro 46 du 21 février 1986.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée
privée, demeurant à Differdange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à
Herserange (France).
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à
Rodange.
Madame la Présidente expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les MILLE (1.000)
ACTIONS d'une valeur nominale de MILLE DOLLARS US (USD 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital
131807
social de UN MILLION DE DOLLARS US (USD 1.000.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre
du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou des mandataires des actionnaires repré-
sentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités
de l'enregistrement.
2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de la durée de la société pour la rendre à durée illimitée.
2) Modification afférente de l'article 3 des statuts.
3) Divers.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de changer la durée de vie limitée de la société en durée illimitée.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la décision qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modifi-
cation des statuts.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 8 octobre 2008. Relation: EAC/2008/12643. — Reçu douze euros 12,- €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 31 octobre 2008.
Francis KESSELER.
Référence de publication: 2008138460/219/54.
(080162295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
X-Time S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 83.005.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Suite à une assemblée générale extraordinaire enregistrée à Luxembourg, actes civils le 2 octobre 2008, LAC/
2008/40018:
et reçue par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 26 septembre 2008,
acte n° 539, il a été prononcé la clôture de la liquidation de la société "X-TIME S.A.", qui cessera d'exister.
L'assemblée a décidé que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 18, avenue de
la Porte-Neuve à Luxembourg.
Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2008.
Jacques DELVAUX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008138277/208/20.
(080161960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
131808
Absolutissimo Fund
Absolutissimo Fund
AGEFI Luxembourg - Le Journal Financier de Luxembourg
Alteus Holding S.A.
AMP Capital Investors (Angel Trains EU No. 1) S. à r.l.
Architect-Consult/ Zigrand Jean-Paul S.à r.l.
ARISTOTE
ARISTOTE
ARISTOTE
AXA Luxembourg Fund
Belaton SA
Belux Invest S.A.
BHG Luxembourg Sàrl
BN & Partner Platinum Fund
Brookstone S.àr.l.
Café Concept S.à r.l.
Capale S.A.
C.R.E.
EcoLive S.A.
Européenne de Santé S.A.
Ferentis S.A.
Financière Verbois S.A.
Gazelle Holding S.A.
Global Logistics Services S.A.
Hambleton Hall S.A.
Hilaire S.A.
Hilaire S.A.
Immobilière des Dahlias S.A.
Immo Teb SA
Institut Financier Européen S.A.
Lipid Investments S.A.
L.S. Lux SA
"Mikado Management S.A.H."
Motus Sicav
Ondicium S.A.
Orco Germany S.A.
Oyster
Retail Park Sandweiler S.A.
Robeco Capital Growth Funds
Robeco Interest Plus Funds
S.I. GROUP Luxembourg S.A.
Trans IV (Luxembourg) Retail S.à r.l.
Trust de Luxembourg
UBS Target Fund
Unicapital Investments IV
UniGarantPlus: BRIC (2014) II
UniGarantPlus: BRIC (2014) II
United Consumer Media SE
Vivier S.A. Holding
Watamar Holding S.A.
X-Time S.A.
Yakari
Ziska