logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2328

24 septembre 2008

SOMMAIRE

ABF Regents Park Investments S.à r.l.  . . .

111704

Adrenaline Shipping S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

111707

Apax Angel PEC 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

111744

Apax Angel PEC A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

111715

Aqua European Technologists S.A.  . . . . . .

111703

Arcipelagos Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111711

Assenagon Asset Management S.A. . . . . . .

111705

Baldock Holding S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

111710

Bond Holdco I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111698

Bond Subco III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111707

Boval S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111706

BRC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111710

Calfin International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

111700

Catelan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111705

CEB Pantanal S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111708

CFM SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111706

Elefint S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111703

EPI Oakwood LP 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

111712

Euro VI (BC) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111720

Evanio Investments Holding S.A.  . . . . . . . .

111704

Even RX Drei S.à R.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111728

Even RX Vier S.à R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111735

Flagstone Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111702

Gamma III S.C.A., Sicar  . . . . . . . . . . . . . . . .

111710

I.M.A. S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111700

Immovest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111709

Jackpot S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111701

Kenavon Drive Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . .

111744

Limra N°2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111708

Lumina Participation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111706

Lumina White  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111703

MD Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111698

MSI Alpha Phi S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111709

MSI Beta S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111708

Nartal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111707

Neolite Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111701

New Finder S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111699

Novipa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111702

Omnia Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

111701

Orion III European 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

111742

Orion Immobilien 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

111742

Panel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111699

Portfolio B.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111704

PORTUNATO & Cie S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

111706

Property Hof S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111711

PS Tabak S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111698

Randstad Group Luxembourg S.à r.l.  . . . .

111709

Reckitt Benckiser Investments (N°6), S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111716

Sapphire Actipark 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

111698

Secapital S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111709

S.G.C. Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

111700

Sisvel International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111703

Sudinvestments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111712

Vasto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111699

Wallberg Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111708

Wincanton Trans European (Luxembourg)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111699

111697

Bond Holdco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 140.256.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Paul FRIEDERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116794/212/12.
(080135756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Sapphire Actipark 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.800.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116813/220/12.
(080136050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

MD Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 6.621.000,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 138.224.

En date du 16 juin 2008, la société COSMICA S.A., 18, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg a cédé 65 900 parts de la

société MD LUX S.à r.l. à la société FINDUCK S.r.l., Via Minghetti n 

o

 13 I-40057 Granarolo Dell'Emilia.

Luxembourg, le 28 juillet 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008116510/751/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2008, réf. LSO-CT02786. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

PS Tabak S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 34, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 116.987.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2008.

SOFINTER S.A.
''Le Dôme'' - Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008117359/820/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11586. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

111698

Vasto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 75.826.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008116577/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2008, réf. LSO-CU00080. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080134752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Wincanton Trans European (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 83.013.

Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2008.

SOFINTER S.A.
''Le Dôme'' - Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008117360/820/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10311. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Panel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 39.465.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
<i>Cabinet d'experts comptables
Signature

Référence de publication: 2008117361/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02484. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

New Finder S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 133.981.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 9 septembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116816/239/12.
(080135568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

111699

Calfin International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 100.707.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 juin 2008 que:

- Le nombre d'administrateurs a été augmenté de trois à douze;

- Messieurs ALFARO BEJAR Hector, né le 28 décembre 1959 à Chihuaha (Mexique) et demeurant à Monaco 9 avenue

d'Ostende; DEL CAMPO WRIGHT Francisco Jesus, né le 1 

er

 juin 1951 à Mexico et demeurant 17, boulevard Rainier III;

CHOURAQUI Françis Albert, né le 11 février 1945 à Oran (DZA) et demeurant à 16, rue d'alsace 75006 Paris; CAPELLINI
MION Lorenzo, né à Padova (Italie) le 10 février 1977 et demeurant à Milano, via Salasco 1 I-20136; CALABRÓ Giovanni,
Président, né à Reggio Calabria (Italie) le 5 juillet 1969 et demeurant à Flat 101 Perspective Building 100 Westminster
Bridge Road London SE1 7XB; ERGAS Pierre Raphael, né le 20 avril 1950 à Marseille (France) et demeurant à 15B, Murphys
Road Blenheim Marlboro, New Zealand; DE LUCA Roberto, employé privé, né à Luxembourg le 13 avril 1973 et de-
meurant professionnellement à 40 Avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg; CANEPA Michele, employé privé, né à
Genova le 23 novembre 1972 et demeurant professionnellement à Luxembourg 40 Avenue de la Faïencerie L-1510, ont
été nommés nouveaux administrateurs de la société et Madame WESQUY Valérie, employée privée née à Mont Saint
Martin le 6 mars 1968 et demeurant professionnellement à Luxembourg 3, rue Belle Vue L-1227.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre

2013.

Luxembourg, le 03 août 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008116525/5878/28.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07547. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

S.G.C. Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 83.087.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de
publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008116579/534/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12139. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

I.M.A. S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2143 Luxembourg, 105, rue Laurent Ménager.

R.C.S. Luxembourg E 1.737.

Les statuts coordonnés de la société au 20 août 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 août 2008.

Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116776/243/13.
(080135674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

111700

Neolite Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 93.558.

EXTRAIT

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat en

date du 22 août 2008.

Pour extrait conforme
Philippe PENNING

Référence de publication: 2008116507/294/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2008, réf. LSO-CU00211. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080135248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Jackpot S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 131.217.

Résultant de la transformation de la forme juridique de l'actionnaire unique de la société Jackpot S.à r.l., d'une Société

à Responsabilité Limitée à une Société Anonyme, l'actionnaire unique sera modifié comme suit: Kulczyk Investment House
S.A., avec siège social à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

Luxembourg, le 28 août 2008.

ATC Management Luxembourg S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2008116508/751/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2008, réf. LSO-CU01079. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Omnia Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 116.984.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 18 août 2008 que:

- Madame Sylvie Abtal-Cola, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg

et Monsieur Johan Dejans, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg, ont
été nommé administrateurs de classe B avec effet immédiat en remplacement de Monsieur Camille Paulus et Monsieur
Patrick Lorenzato, administrateurs non renouvelés de classe B. Leurs mandats prendront fin lors de la tenue de l'As-
semblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 Décembre 2008.

- Monsieur VANDERKERKEN et Monsieur LONGONI sont reconduits dans leur fonction d'administrateurs. Leurs

mandats prendront fin lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels de
la société au 31 Décembre 2008.

- Monsieur Marcel STEPHANY est reconduit en tant que commissaire au compte. Son mandat prendra fin lors de la

tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 Décembre 2008.

Luxembourg le 19 août 2008.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008116511/751/25.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2008, réf. LSO-CU00195. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

111701

Novipa, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 33.405.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 31 juillet 2008 que:

- Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:

* Mme Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, née le 14/01/1951 à Fès (Maroc), demeurant professionnellement

au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg

* M. Albert Aflalo, administrateur de sociétés, né le 18/09/1963 à Fès (Maroc), demeurant professionnellement au 23,

rue Aldringen à L-1118 Luxembourg

* M. Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, né le 09/10/1959 à Fès (Maroc), demeurant professionnellement au 23,

rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.

Le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane est confirmé pour une durée indéterminée.

- A été réélue au poste de commissaire aux comptes:
* Montbrun Révision Sàrl, immatriculée au RCS sous le N 

o

 67.501, sise «Le Dôme», Espace Pétrusse, 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Leurs mandats se termineront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2014.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2008116515/677/25.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12701. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Flagstone Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 118.871.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la société en date du 21 juillet 2008

<i>1. Administrateurs:

1.1 La démission de M. Peter Zumstein en tant que administrateur est acceptée et confirmée avec effet immédiat,
1.2 Mr. Karl Grieves, ayant pour adresse professionnelle le Goldie House, Upper Church Street, Douglas, Île de Man,

IM1 EB, est nommé administrateur de Classe A avec effet immédiat et jusqu'à la date de l'assemblée générale de l'année
2012.

1.3 Mr. Frederic Traimond, ayant pour adresse professionnelle le 1, rue du Collège, Martigny, CH-1920, Suisse, est

nommé administrateur de Classe A avec effet immédiat et jusqu'à la date de l'assemblée générale de l'année 2012.

1.4 Mr. Patrick Boisvert, ayant pour adresse professionnelle le 1, rue du Collège, Martigny, CH-1920, Suisse, est nommé

administrateur de Classe A avec effet immédiat et jusqu'à la date de l'assemblée générale de l'année 2012.

<i>2. Commissaire aux comptes:

2.1 La démission de Crown Corporate Services en tant que commissaire aux comptes est acceptée et confirmée avec

effet immédiat.

2.2  Deloitte  S.A.,  ayant  pour  adresse  le  560,  rue  de  Neudorf,  L-2220  Luxembourg,  est  nommé  commissaire  aux

comptes, avec effet immédiat et jusqu'à la date de l'assemblée générale de l'année 2012.

Luxembourg, le 1 

er

 août 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008116521/9265/29.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05530. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

111702

Lumina White, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 115.200.

EXTRAIT

La Société informe que ses Associés ont pris, en date du 21 juillet 2008, la résolution suivante :

Ils décident de nommer M. Enrico Grasso, né le 12 décembre 1980 à Cuneo, Italie, ayant son adresse personnelle au

75 Victoria Street, SW1H OHY, Londres, Royaume-Uni en tant que nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat
et cela pour une durée illimitée. Ce dernier remplace M. Mattia Caprioli.

Depuis le 21 juillet 2008, le Conseil de Gérance de la Société est composé comme suit:

- TRIEF Corporation S.A.,
- Monsieur Jean-Yves Hémery,
- Monsieur Enrico Grasso,
- Monsieur Jacques Garaialde.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2008.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008116524/7665/24.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01185. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Sisvel International, Société Anonyme,

(anc. Elefint S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 38.989.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 9 septembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116818/239/13.
(080135588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Aqua European Technologists S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 72.533.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juin 2008 que:

- ALLIANCE Révision S.à.r.l, ayant son siège au 54 avenue pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommé Réviseur en

remplacement de MAYFAIR TRUST S.à.r.l, commissaire démissionnaire. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 19/06/2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008116520/5878/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR09777. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

111703

ABF Regents Park Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 96.789.

<i>Extrait des résolutions écrites date du 13 septembre 2007

Les managers ont décidé:

- De renommer Francois Brouxel, Georges Gudenburg et John Boothman à la fonction de gérant pour une durée

déterminée jusqu'à la prochaine assemblée générale en 2008.

L'adresse de l'associé Soublier Investments Limited est désormais:
- Weston Centre, 10 Grosvenor Street, W1K 4Q9, Londres, Royaume Uni

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09.07.08.

Signature.

Référence de publication: 2008116522/5564/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2008, réf. LSO-CS08791. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080135117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Portfolio B.P., Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 68.029.

RECTIFICATIF

Veuillez noter que l'adresse professionnelle correcte de Monsieur Reginald van LEER est la suivante:

Monsieur Reginald van LEER, Directeur, PRI INVESTMENT, 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2008.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
Amélie PONSIN / Claire-Ingrid BERGE
<i>Mandataire Commercial / Mandataire

Référence de publication: 2008116528/1183/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01874. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Evanio Investments Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 67.949.

La société vous informe du changement d'adresse de ses administrateurs et administrateur délégué comme suit:

- Mr Doeke van der Molen
2-8, avenue Charles de Gaulle, L-2346 Luxembourg

- Luxembourg Corporation Company SA
20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

- TCG Gestion SA
20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

111704

Luxembourg, le 21 juillet 2008.

Luxembourg Corporation Company SA
<i>Administrateur Délégué
Signature

Référence de publication: 2008116501/710/20.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2008, réf. LSO-CT00402. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Assenagon Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 129.914.

<i>Beschluss des Verwaltungsrats im Umlaufverfahren vom 1. Juli 2008

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschließt in Anwendung des Art. 8 letzter Absatz der Satzung der Assenagon

Asset Management S.A. (die „Gesellschaft") einstimmig Folgendes:

Mit Wirkung vom 1. Juli 2008 werden

Herr Michael Löb und
Herr Peter Lohse

zu Prokuristen/Fondés de Pouvoir der Gesellschaft ernannt. Sie sind damit gemäß der Unterschriftenregelung für die

Unterschriftengruppe "A" nach außen zeichnungsberechtigt.

Alle betroffenen Fachbereiche sind angehalten, die erforderlichen Schritte einzuleiten.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Luxemburg, den 1. Juli 2008.

Hans Günther Bonk / Gunnar Homann / Vassilios Pappas.

Référence de publication: 2008116503/8912/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU02920. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Catelan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 74, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 122.261.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 11 février 2008,

les décisions suivantes ont été prises:

1) La démission suivante de sa fonction de président et d'administrateur est acceptée:
- Guy HRYNEN, 74, rue de la Gare, L-8325 Capellen

2) Est nommé jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2009:

<i>Administrateur-Délégué et Administrateur:

- Manette OLSEM, demeurant professionnellement 16, allée Marconi L-2120 LUXEMBOURG

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008116517/504/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12492. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

111705

CFM SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 24.414.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 01 

er

 août 2008, a été nommé jusqu'à l'Assemblée Générale

des actionnaires statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

<i>Administrateur:

Monsieur Michel PESLIER, demeurant rue du Jeu à F-53100 Mayenne en remplacement de Monsieur Thierry LEVAN-

TAL, démissionnaire.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008116516/504/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12490. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080135230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Boval S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 11.041.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 10 juillet 2008 a nommé nouveaux administrateurs de la société

Monsieur Stefan Breitenstein, avocat, Bleicherweg 58, CH-8027 Zurich Monsieur Michael Staub, directeur de société,

Tödistrasse 44, CH-8002 Zurich

en remplacement des administrateurs démissionnaires Messrs. Peter Hafter et Ernst Wickihalder.

Les nouveaux administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs qui viendront à échéance à l'issue de

l'assemblée générale de 2009.

<i>Pour BOVAL S.A., Société Anonyme Holding
Signature

Référence de publication: 2008116526/783/18.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2008, réf. LSO-CU00360. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

PORTUNATO &amp; Cie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 71.148.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008116578/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12136. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Lumina Participation, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 623.500,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 88.254.

EXTRAIT

La Société informe que son Associé unique a pris, en date du 21 juillet 2008, la résolution suivante:

111706

Décide de nommer M. Enrico Grasso, né le 12 décembre 1980 à Cuneo, Italie, ayant son adresse personnelle au 75

Victoria Street, SW1H OHY, Londres, Royaume-Uni en tant que nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat et
cela pour une durée illimitée. Ce dernier remplace M. Mattia Caprioli.

Depuis le 21 juillet 2008, le Conseil de Gérance de la Société est composé comme suit:

- TRIEF Corporation S.A.,
- Monsieur Jean-Yves Hémery,
- Monsieur Enrico Grasso,
- Monsieur Jacques Garaialde.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2008.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008116523/7665/24.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01182. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080135110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Nartal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 46.600.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008116601/8214/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2008, réf. LSO-CU01705. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Adrenaline Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 49.604.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008116600/8214/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2008, réf. LSO-CU01706. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Bond Subco III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 140.251.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Paul FRIEDERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116779/212/12.
(080135709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

111707

Limra N°2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 16.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 123.825.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 25 juillet 2008 entre Ogaru Limited et Blixen Limited, les 500 parts

sociales de la Société sont réparties comme suit:

- Blixen Limited, domiciliée au 151 Thomas Street, Dublin 8, Irlande, détient 500 parts sociales.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

<i>Pour Limra N 

<i>o

<i> 2 S.à r.l.

Représente par Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008116512/683/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU02128. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080135292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Wallberg Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 137.988.

Der Verwaltungsrat der Wallberg Invest S.A. betraut mit Wirkung vom

19. März 2008 Herr Thorsten SCHRIEBER und Herr Matthias SCHIRPKE sowie mit Wirkung vom 24. Juli 2008 Herrn

Christian RAUSCHER

mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft.

Alle Herren mit Geschäftsadresse in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Für Wallberg Invest S.A.
DZ BANK International S.A.
Vera Augsdörfer / Thomas Haselhorst

Référence de publication: 2008116527/9077/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01865. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

CEB Pantanal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 129.766.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 52467 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116821/211/12.
(080135790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

MSI Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.173.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

111708

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116814/5770/12.
(080135512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

MSI Alpha Phi S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.242.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116815/5770/12.
(080135500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Secapital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 108.305.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 52865 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116795/211/11.
(080135783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Randstad Group Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 138.754.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 52404 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116796/211/11.
(080135766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Immovest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 81.644.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 52848 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116797/211/11.
(080135800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

111709

Baldock Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8290 Kehlen, 27, Domaine de Brameschhof.

R.C.S. Luxembourg B 138.147.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 27 juin 2008, que l'Actionnaire a pris les décisions suivantes:

1. Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à compter du 27 juin 2008:

Madame Marian Olde, née le 13 octobre 1962 à Heerlen, aux Pays-Bas, domiciliée 27 domaine de Brameschhof, L-8290

Kehlen, au Luxembourg

2. Démission du Gérant suivant à compter du 27 juin 2008:

Manacor (Luxembourg) S.A., immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le

numéro B9098, dont le siège social se situe 46A, avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

<i>BALDOCK HOLDING S.à r.l.
Marian Olde
<i>Gérant

Référence de publication: 2008116513/683/21.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU02137. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Gamma III S.C.A., Sicar, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investisse-

ment en Capital à Risque.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 126.988.

<i>Extrait de la décision prise par l'associé commandité en date du 27 juin 2008

La société anonyme ERNST &amp; YOUNG, R.C.S. Luxembourg B 47 771, ayant son siège social à L-5365 Münsbach, 7,

Parc d'Activité Syrdall, a été nommée comme réviseur d'entreprises et chargée de l'audit des comptes annuels au 31
décembre 2008.

Luxembourg, le 14/08/08.

<i>Gamma III S.C.A., Sicar
Gamma III S.à r.l.
<i>Associé commandité
Signatures

Référence de publication: 2008116757/8568/19.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2008, réf. LSO-CU01386. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

BRC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 99.842.

EXTRAIT

Il résulte du changement d'adresse de plusieurs gérants que les modifications suivantes sont à enregistrer:

Jorge Paulo LEMANN, Gérant A,
Ancienne adresse:
3729, Av. Brigadeiro Faria Lima, BR-Sao Paolo
Nouvelle adresse:
Rebhalde Street, 35, CH-8645 Jona, Suisse

Carlos Alberto DA VEIGA SICUPIRA, Gérant A,
Ancienne adresse:

111710

3729, Av. Brigadeiro Faria Lima, BR-Sao Paolo
Nouvelle adresse:
Coister Drive, Dockside apt. 01, Paradise Island, Bahamas

Herrmann TELLES, Gérant A, 3
Ancienne adresse:
3729, Av. Brigadeiro Faria Lima, BR-Sao Paolo
Nouvelle adresse:
Harbour Drive, Yolanda Condo Unit 2, Paradise Island, Bahamas

Roberto Moses THOMPSON MOTTA, Gérant B,
Ancienne adresse:
3729, Av. Brigadeiro Faria Lima, BR-Sao Paolo
Nouvelle adresse:
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 15 

o

 andar, 04530-001 Itaim Bibi, Sao Paolo, Brazil

Luxembourg, le 28 août 2008.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008116509/751/35.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2008, réf. LSO-CU01081. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Property Hof S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 104.498.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 11 août 2008

1) M. Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant.
2) M. Nick REID, administrateur de société, né à Addington (Royaume-Uni), le 27 décembre 1964, demeurant à GB-

BT39 9NN Co Antrim, Rushvale Road, 32, Ballyclare, (Royaume-Uni), a été nommé comme gérant pour une durée
indéterminée.

Luxembourg, le 20.8.2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Property Hof S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008116755/6820/19.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2008, réf. LSO-CU01363. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Arcipelagos Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8023 Strassen, 14B, rue des Violettes.

R.C.S. Luxembourg B 98.520.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116777/242/12.
(080135829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

111711

Sudinvestments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 114.793.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116775/5770/12.
(080135517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

EPI Oakwood LP 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 124.666.

In the year two thousand and eight, on the first of august.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of "EPI Oakwood LP 1 S.à r.l.", a "Société à Responsabilité

Limitée", having its registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, incorporated by a notarial deed enacted on
the January 19, 2007, registered at the Luxembourg trade register section B number 124.666, published in the Luxembourg
Mémorial C, number 749 on April 30, 2007 whose articles of association have not yet been amended.

The meeting is presided by Ms Jennifer Balcerzak, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Ms Sonia Almeida, residing professionally in

Luxembourg. The chairman requested the notary to act that:

I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, all the shares representing the entire share capital of the Company, are

represented so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items on the agenda
of which the partners have been informed beforehand.

III.- That the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Appointment of one category A manager and of 2 category B managers
2. Definition of powers of signature of the category A manager and the category B managers
3. Subsequent amendment of article eleven of the articles of association
4. Change of the Company's financial year
5. Subsequent amendment of article sixteen of the articles of association
6. Subsequent amendment of article seventeen of the articles of association
After the foregoing was approved by the meeting, the sole partner unanimously decides what follows:

<i>First resolution

The meeting resolves to appoint Mr. Yves Barthels as category A manager, Mr. Bruno Bagnouls and Mr. Jean-Philippe

Fiorucci as category B managers.

<i>Second resolution

The  meeting  resolves  grant  the  category  A  manager  all  necessary  powers  to  represent  the  Company  by  its  sole

signature. The Company may be further bound by the joint signature of any two category B managers.

<i>Third resolution

In view of the above resolutions, the meeting resolves to amend Article eleven of the Articles of Association to read

as follows:

Art. 11. The Company is managed by at least three managers, appointed by the partner with or without limitation

of their period of office. The managers will constitute a board of managers which will be constituted by one manager of
category A (the "A Manager") and two or more managers of category B (the "B Managers") (The A Manager and the B

111712

Managers are collectively referred to herein as "Managers"). The Managers need not to be partners. The Managers may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the Managers, or in case of plurality of Managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its A Manager or by the joint signature of any two B Managers.
The Managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one several ad hoc agents.
The Managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of

representation and any other relevant conditions of his agency.

The boards of managers will be validly held provided that the majority of Managers be present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the Managers present or

represented.

The powers and remunerations of any Managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first Managers will be determined in the act of nomination."

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to change the financial year of the Company, in order to start on January 1st of each year and

to close on December 31.

Exceptionally, the financial year 2008 shall start on April 1st, 2008 and close on December 31, 2008, the annual accounts

as at March 31, 2008 having already been approved by the shareholders.

<i>Fifth resolution

In view of the above resolution, the meeting resolves to amend Article sixteen of the Articles of Association to read

as follows:

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st."

<i>Sixth resolution

In view of the above resolution, the meeting resolves to amend the first sentence of Article seventeen of the Articles

of Association to read as follows:

Art. 17. Each, year on December 31st, the management will draw up the balance sheet which will contain a record

of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all the commitments and debts of the manager(s) to the company."

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result

of the present deed, are estimated at approximately one thousand Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la version en langue française:

L'an deux mille huit, le premier août.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "EPI Oakwood LP

1 S.à r.l.", ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, constituée suivant acte notarié reçu le 19 janvier
2007 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B sous le numéro 124.666, , publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 749 du 30 avril 2007, dont les statuts n'ont pas été modifiés.

L'assemblée est présidée par Jennifer Balcerzak demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mme Soma Almeida, demeurant

professionnellement à Luxembourg. Le président prie le notaire d'acter que:

111713

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les parts représentant l'intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement
délibérer et décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement
informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Nomination d'un gérant de catégorie A ainsi que de deux gérants de catégorie B.
2.- Définition des pouvoirs de signature du gérant de catégorie A et des gérants de catégorie B.
3.- Modification subséquente de l'article onze des statuts de la Société.
4.- Modification de l'exercice social de la Société.
5.- Modification subséquente de l'article seize des statuts.
6.- Modification subséquente de l'article dix-sept des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé décide ce qui suit:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de nommer M. Yves Barthels en tant que gérant de catégorie A ainsi que M. Bruno Bagnouls et M.

Jean-Philippe Fiorucci en tant que gérants de catégorie B.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de donner tous pouvoirs au gérant de catégorie A de représenter la Société par sa seule signature.

La Société sera également valablement représentée par la signature conjointe de deux gérants de catégorie B.

<i>Troisième résolution

Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article onze des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

« Art. 11. Die Gesellschaft wird durch mindestens drei Geschäftsführern geleitet, welche Gesellschafter oder Nicht-

gesellschafter sein können und welche, mit oder ohne bestimmte Dauer, durch die Gesellschafter ernannt werden. Die
Geschäftsführer bilden einen Verwaltungsrat welcher aus einem Kategorie A Geschäftsführer („A-Geschäftsführer") und
mindestens zwei Kategorie B Geschäftsführern („B-Geschäftsführer") besteht. Die Geschäftsführer können jederzeit ab-
berufen werden, mit oder ohne Grund, mit einem Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter.

Die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse um die Geschäfte der Gesellschaft hinsichtlich des Gesell-

schaftszecks, im Rahmen der Bestimmungen dieses Artikels, durchzuführen und um die Gesellschaft gegenüber Dritten
zu vertreten.

Befugnisse,  welche  laut  Gesetz oder  dieser  Satzung,  nicht  ausdrücklich  der Hauptversammlung der  Gesellschafter

zugestimmt sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.

Die Gesellschaft ist jederzeit durch die Einzelunterschrift des A-Geschäftsführers, oder durch die gemeinsame Unter-

schrift von zwei B-Geschäftsführern verpflichtet.

Der Verwaltungsrat kann spezifische Aufgaben seiner Befugnisse an einen oder mehreren ad hoc Agenten subdele-

gieren.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Verantwortlichkeit und eventuelle Vergütung solcher Agenten, sowie die Dauer

ihres Mandats und alle weiteren Bedingungen ihres Mandats.

Die Versammlungen des Verwaltungsrates können nur mit der Teilnahme von der Mehrheit der Geschäftsführer ge-

halten werden. In diesem Fall sind alle Entscheidungen der Geschäftsführung rechtskräftig, insofern die Mehrheit der
Anwesenden diesen zustimmt.

Alle Befugnisse und Vergütungen der Geschäftsführer, welche eventuell an einem späteren Zeitpunkt ernannt werden,

zusätzlich oder in Ersatz der ersten Geschäftsführer werden im Nominierungsakt festgesetzt.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'exercice social de la Société afin que celui-ci commence le 1 

er

 janvier et termine le

31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, l'exercice social 2008 commence au 1 

er

 avril 2008 et se termine au 31 décembre 2008, les

comptes annuels au 31 mars 2008 ayant déjà été approuvés par les actionnaires.

<i>Cinquième résolution

Ainsi qu'il résulte de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article seize des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

111714

« Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres.»

<i>Sixième résolution

Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article dix-sept des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

« Art. 17. Am 31. Dezember jedes Jahres, erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz welche das Inventar der Guthaben

und Schulden der Gesellschaft, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und eine Anlage mit einer Kurzfassung aller
Verpflichtungen und Schulden der Gesellschaft enthält. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dann
den Gesellschaften vorgelegt.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa contribution, s'élève à environ mille Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: J. BALCERZAK, S. ALMEIDA, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2008. Relation: LAC/2008/32811. — Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 25 août 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008116249/211/173.
(080135364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Apax Angel PEC A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 114.268.

EXTRAIT

1) Le siège social d'Apax WW Nominees Limited, l'associé unique de la Société, a été transféré à l'adresse suivante:
33 Jermyn Street, Londres SW1 Y6DN, Royaume Uni

2) En date du 26 août 2008, Stephen Kempen a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société et Andrew William

Guille, administrateur, demeurant à Elishama, Rue de la Fosse, St Saviour, Guernesey GY7 9SU, né le 22 novembre 1959
à Guernesey, a été nommé en son remplacement en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Il résulte de ce qui précède que le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

- Richard Newton
- Andrew William Guille
- Sophie Laguesse
- Geoffrey Henry
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2008.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008116519/260/25.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01881. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

111715

Reckitt Benckiser Investments (N°6), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.165.529.300,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 132.838.

In the year two thousand and eight, on the sixteenth of July.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

Reckitt Benckiser Investments (N 

o

 5), S.à r.l., a Luxembourg limited liability company, having its registered office at

39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 132.839, (the "Sole Shareholder");

here represented by Ms. Catherine Dessoy, by virtue of a power of attorney given on 15 July, 2008.
Said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the Sole Shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under

the name of Reckitt Benckiser Investments (N°6), S.à r.l., registered with the Luxembourg Trade and Company Register,
section B, under number 132.838, with registered office at 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of October
9, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations no. 2659 of November 20, 2007 and which
Articles of Association have not been amended.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred

twenty-five (125) Ordinary shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid-in.

III. The Sole Shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to amend the Company's accounting year to make it begin on the seventeenth day of

July of each year and terminate on the sixteenth day of July of the following year.

<i>Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolved to amend article 15 of the articles of association

in order to give it the following content:

Art. 15. The Company's financial year ends on the sixteenth day of July of each year."

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to that the current accounting year that started on January 1st 2008 shall end on July

16th 2008.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to cancel the par value of the Company's shares.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved to redenominate the current share capital from EUR to USD at a rate of 1 EUR for

1.459 USD, set conventionally with economic effect as at January 1st 2008, the present share capital of Twelve Thousand
Five Hundred Euro (EUR 12,500) being replaced by a share capital of Eighteen Thousand Two Hundred and Thirty-Seven
US Dollar (USD 18,237).

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolved to decrease the Company's share capital by an amount of Two Hundred and Thirty-

Seven US Dollar (USD 237) in order to lower it from its present amount of eighteen thousand two hundred and thirty-
seven US Dollar (USD 18,237) to eighteen thousand US Dollar (USD 18,000), with reimbursement to the Sole Shareholder
and to reinstate the share capital, the existing one-hundred twenty-five (125) shares being replaced by one hundred eighty
(180) shares with a par value of one hundred US Dollar (USD 100) each.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of five billion one hundred

and sixty-five million five hundred and twenty-nine thousand three hundred US Dollar (USD 5,165,529,300) so as to raise
it from its current amount of eighteen thousand US Dollar (USD 18,000) to five billion one hundred and sixty-five million
five hundred and forty-seven thousand three hundred US Dollar (USD 5,165,547,300) by issuing fifty-one million six
hundred and fifty-five thousand two hundred and ninety-three (51,655,293) new shares with a par value of one hundred

111716

US Dollar (USD 100) each and aggregate par value of five billion one hundred and sixty-five million five hundred and
twenty-nine thousand three hundred US Dollar (USD 5,165,529,300) having the same rights and obligations of the existing
shares, in consideration for the contribution of all its assets and liabilities.

<i>Eighth resolution

<i>Intervention - Subscription - Payment

The Sole Shareholder, (the "Contributor") through its proxyholder, declared to subscribe to the fifty-one million six

hundred and fifty-five thousand two hundred and ninety-three (51,655,293) newly issued shares with a par value of one
hundred US Dollar (USD 100) each, and aggregate par value of five billion one hundred and sixty-five million five hundred
and twenty-nine thousand three hundred US Dollar (USD 5,165,529,300), and fully pay them up by contribution in kind
consisting in the transfer of all its assets and liabilities.

<i>Evaluation

The total value of the contribution is declared to be five billion one hundred and sixty-five million five hundred and

twenty-nine thousand three hundred US Dollar (USD 5,165,529,300). Such value has been decided by the Contributor
by way of a declaration of value, dated July 16, 2008. The managers of the Company have expressly accepted the value
of five billion one hundred and sixty-five million five hundred and twenty-nine thousand three hundred US Dollar (USD
5,165,529,300) and the valuation method by way of resolutions of a board of managers dated July 16, 2008, and in a
managers' valuation report executed by all the managers of the Company issued on July 16, 2008 and transmitted to the
undersigned notary.

<i>Evidence of the contribution existence

Evidence of the transfer of the contributed assets and liabilities and of their value has been given to the undersigned

notary by way of a contribution agreement entered into between the Company and the Contributor.

Said contribution agreement, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Capital duty payment exemption request

Considering that it concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company by a contribution

in kind consisting of all the assets and liabilities (entire property), nothing withheld or excepted, of a company having its
registered office in a member State of the European Union, the Contributor expressly requests the pro rata capital duty
exemption on basis of Article 4.1 of the law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986, which
provides for a fixed rate capital duty perception in such case.

<i>Ninth resolution

The Sole Shareholder resolved that the one hundred and eighty (180) shares having a par value of one hundred US

Dollar (USD 100) each and an aggregate par value of eighteen thousand US Dollar (USD 18,000), it holds in the Company
which are part of the assets contributed further to the present minutes, will be cancelled since such shares will be held
by the Company itself, after the contribution of all the assets and liabilities of the Sole Shareholder.

<i>Tenth resolution

Further to the above resolutions, the Sole Shareholder resolved to restate Article 6 paragraph 1 of the Company's

Articles of Association which shall henceforth read as follows:

Art. 6. The share capital is fixed at five billion one hundred and sixty-five million five hundred and twenty-nine thousand

three hundred US Dollar (USD 5,165,529,300.-) represented by fifty-one million six hundred and fifty-five thousand two
hundred and ninety-three (51,655,293) shares of one hundred US Dollar (USD 100.-) each".

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the presently stated increase of capital are estimated at € 7,000.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,

civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le seize juillet.

111717

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Reckitt Benckiser Investments (N°5), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.839, (l'«Associée Unique»);

ici représentée par Maître Catherine Dessoy, en vertu d'une procuration donnée le 15 juillet 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elle.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de Reckitt Benckiser Investments (N°6) S.à r.l., (la «Société»), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 132.838, ayant son siège social au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 9 octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 2659 du 20 novembre
2007 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500) représenté par cent vingt-cinq

(125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100) chacune, entièrement souscrites et libérées.

III. L'Associée Unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associée Unique décide de modifier l'année sociale de la Société pour la faire débuter le dix-septième jour de juillet

de chaque année et de la faire terminer le seizième jour de juillet de l'année suivante.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'Associée Unique a décidé de modifier l'article 15 des Statuts pour lui donner la

teneur suivante;

Art. 15. L'année sociale de la Société se termine le seizième jour de juillet de chaque année."

<i>Troisième résolution

L'Associée Unique a décidé que l'année sociale en cours ayant commencée le 1 

er

 janvier 2008 se terminera le 16

juillet 2008.

<i>Quatrième résolution

L'Associée Unique a décidé d'annuler la valeur nominale des parts sociales de la Société.

<i>Cinquième résolution

L'Associée Unique a décidé de convertir la devise du capital social de la Société de l'Euro en Dollar U.S. à un taux fixé

conventionnellement à 1 Euro pour 1,459 U.S. Dollar, avec effet au 1 

er

 janvier 2008, le capital social actuel de douze

mille cinq cent Euros (EUR 12.500) étant converti en dix-huit mille deux cent trente-sept US Dollars (USD 18.237).

<i>Sixième résolution

L'Associée Unique a décidé de diminuer le capital social de la Société pour un montant de deux cent trente-sept US

Dollars (USD 237) pour le porter de son montant actuel de dix-huit mille deux cent trente-sept US Dollars (USD 18.237)
à dix-huit mille US Dollars (USD 18.000), avec remboursement à l'Associée Unique et de modifier le capital social de la
façon  suivante,  les  cent  vingt-cinq  (125)  parts  sociales  existantes  étant  remplacées  par  cent  quatre-vingt  (180)  parts
sociales ayant une valeur nominale de cent US Dollars (USD 100) chacune.

<i>Septième résolution

L'Associée Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinq milliards cent soixante

cinq millions cinq cent vingt-neuf mille trois cents US Dollars (USD 5.165.529.300) pour le porter de son montant actuel
de dix-huit mille US Dollars (USD 18.000) à cinq milliards cent soixante-cinq millions cinq cent quarante-sept mille trois
cents US Dollars (USD 5.165.547.300) en émettant cinquante et un millions six cent cinquante-cinq mille deux cent quatre-
vingt-treize (51.655.293) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent US Dollars (USD 100) chacune et d'une
valeur nominale totale de cinq milliards cent soixante-cinq millions cinq cent vingt-neuf mille trois cents US Dollars (USD
5.165.529.300), par l'apport de l'intégralité de ses actifs et passifs.

<i>Huitième résolution

<i>Intervention - Souscription - Paiement

L'Associée Unique (ou l'«Apporteur»), par son représentant, a déclaré souscrire aux cinquante et un millions six cent

cinquante-cinq mille deux cent quatre-vingt-treize (51.655.293) parts sociales nouvellement émises, d'une valeur nominale
de cent US Dollars (USD 100) chacune et d'une valeur nominale totale de cinq milliards cent soixante-cinq millions cinq

111718

cent  vingt-neuf  mille  trois  cents  US  Dollars  (USD  5.165.529.300),  et  les  libérer  intégralement  par  apport  en  nature
consistant en un transfert de l'intégralité de ses actifs et passifs.

<i>Evaluation

La valeur totale de l'apport est déclaré être cinq milliards cent soixante cinq millions cinq cent vingt-neuf mille trois

cents US Dollars (USD 5.165.529.300) ladite estimation a été décidée par l'Apporteur par le biais d'une déclaration de
valeur en date du 16 juillet 2008. Les gérants de la Société ont expressément accepté la valeur de cinq milliards cent
soixante-cinq millions cinq cent vingt-neuf mille trois cents US Dollars (USD 5.165.529.300) et la méthode d'évaluation
par le biais de résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 16 juillet 2008, dans un rapport d'évaluation des
gérants, émis le 16 juillet 2008 et transmis au notaire instrumentaire.

<i>Preuve de l'existence d'un apport

Preuve de l'apport a été donnée au notaire instrumentaire au moyen d'une copie du contrat d'apport signé entre la

Société et l'Apporteur.

Ledit contrat d'apport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,

demeurera joint au présent acte pour être enregistré auprès des autorités.

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Attendu qu'il s'agit de l'augmentation de capital social d'une société luxembourgeoise par un apport en nature de tous

les actifs et passifs (propriété entière), rien n'étant détenu ou exclu, d'une société résidente de l'Union européenne,
l'Apporteur requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.1.
de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du
droit fixe d'enregistrement.

<i>Neuvième résolution

L'Associée Unique a décidé que les cent quatre-vingt (180) parts sociales d'une valeur nominale de cent US Dollars

(USD 100) chacune et une valeur nominale globale de dix-huit mille US Dollars (USD 18.000), qu'elle détient dans la
Société représentant une partie des actifs apportés a la Société suite aux présentes minutes, seront annulées, puisque dés
lors, ces parts sociales seront détenues par la Société elle-même après l'apport de tous les actifs et passifs de l'Associée
Unique.

<i>Dixième résolution

Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'Associée Unique a décidé de reformuler l'article 6 paragraphe 1 

er

 des statuts

de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à cinq milliards cent soixante-cinq millions cinq cent vingt-neuf mille trois cents US

Dollars (USD 5.165.529.300) représenté par cinquante et un millions six cent cinquante-cinq mille deux cent quatre-vingt-
treize (51.655.293) Parts Sociales d'une valeur nominale de cent US Dollars (USD 100,-) chacune».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de € 7.000,-.

Plus rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version Anglaise

fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: C. Dessoy, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/AI. A.C., le 16 juillet 2008, Relation: EAC/2008/9524. — Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008116278/272/211.
(080135296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

111719

Euro VI (BC) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 141.345.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the eighteenth day of August,
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

AIF VI Euro Holdings, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered office at c/o Walkers

SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands, registered with
the Registrar of limited partnerships in Cayman Islands under the number WK-16752,

here represented by Elisabeth Reinard, lawyer, with professional address in 14, rue Edward Steichen, L - 2540 Lux-

embourg-Kirchberg, by virtue of a power of attorney given in New York, on August 15, 2008,

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Euro VI (BC) S.àr.l." (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and in
particular by the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incor-
poration (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the sole manager or the board of managers. The registered office
may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole shareholder or of
the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the sole manager or the board of managers. Where the sole manager or the board of managers determine
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the
Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated
company.

Art. 3. Corporate object.
3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings and issues of debtor equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and any
other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally,
for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company shall not carry
out any regulated activities of the financial sector.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect itself against credit risk, currency
exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may generally carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with

respect to real estate or movable property which directly or indirectly favour or relate to its corporate object.

111720

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), represented by twenty

thousand (20,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.00) each, all subscribed
and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole shareholder or

of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The Company's shares are indivisible and the Company recognises only one owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the sole shareholder or of the

shareholders,  which  sets  the  term  of  their  office.  If  several  managers  are  appointed,  they  will  constitute  a  board  of
managers composed of Class A managers and Class B managers (the Board). The managers need not be shareholder(s).

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the sole shareholder or of

the shareholders.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the sole manager or the Board, who have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the
corporate object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the sole manager or

the Board.

Art. 9. Procedure.
9.1 The Board shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place

indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the Board shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance

of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be
set forth in the convening notice of the meeting of the Board.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the Board of the Company are present or represented

at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.
The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each
member of the Board of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing another manager as his proxy.
9.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of Board are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the Board will be recorded in minutes
signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6 Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference call or by any other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The
participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened
and held.

111721

9.7 In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company will be bound towards third parties in all circumstances (i) by the individual

signature of the sole manager of the Company, in case there is only a single manager and (ii) in case more than one
manager has been appointed, by the joint signatures of any Class A manager and any Class B manager of the Company,
or (iii), as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly
delegated  in  accordance  with article  8.2.  of these  Articles.  For  administrative matters, the Company  shall  be bound
towards third parties by the single signature of any manager for transactions not exceeding a commitment of seven
thousand five hundred euros (EUR 7,500).

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law

IV. General meetings of shareholders and circular resolutions

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. Resolutions of the shareholders are adopted at general meetings of shareholders (the General Meeting(s)) or by

way of circular resolutions (the Circular Resolutions).

12.2. Where resolutions are to be adopted by way of Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all

the shareholders, in accordance with the Articles. The shareholders cast their vote by signing, in one or several coun-
terparts, the Circular Resolutions, all of which taken together constitute one and the same document.

12.3. Where the Company has one shareholder, the latter exercises all powers conferred by the Law to the General

Meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

12.4. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share entitles to one vote.

Art. 13. Notices, quorum, majority and voting procedures.
13.1. The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

of shareholders representing more than one-half of the share capital.

13.2. Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date

of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the
meeting.

13.3. General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
13.4. If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of

the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

13.5. A shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in

order to be represented at any General Meeting.

13.6. Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Circular Resolutions are passed by shareholders

owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written
consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second
time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Circular Resolutions by a majority of the votes cast,
regardless of the proportion of the share capital represented.

13.7. The Articles are only amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

13.8. Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Financial year and annual general meeting of shareholders.
14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of the same

year.

14.2. Each year, the sole manager or the Board must prepare the balance sheet and the profit and loss account in

accordance with the Law, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex
summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Circular

Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 15. Réviseur d'entreprises.
15.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by

law.

111722

15.2. The shareholders appoint the réviseur(s) d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and

the term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseur(s) d'entreprises may be re-elected.

Art. 16. Allocation of profits.
16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

16.2 The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

16.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the sole manager or by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distrib-
utable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the sole shareholder or by the shareholders within

two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

17.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders adopted

by one-half of the shareholders holding three-quarters of the share capital. The sole shareholder or the shareholders
must appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and must determine
their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholder(s), the liquidator(s) has (have)
the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

17.2 The surplus remaining after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the

shareholders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

18.1.Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by telegram,

telefax, e-mail or by any other generally accepted means of electronic communication.

18.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided that signatures in electronic form fulfil all legal

requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. In case of circular resolutions, signatures may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution.

18.4 All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any non waivable legal provisions, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2008.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, AIF VI Euro Holdings, L.P., prenamed and represented as stated above, subscribes to twenty thousand

(20,000) shares in registered form, with a par value of one United States Dollar (USD 1.00,-) each, and agrees to pay
them in full by a contribution in cash in the amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000).

An amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) is at the disposal of the Company, evidence of

which has been given to the undersigned notary.

<i>Costs

For the purpose of registration, the share capital of 20,000.- USD is valued at 13,600.- €.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company resulting connection with

its incorporation are estimated at approximately 1,900.- €.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire

subscribed capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as Class A managers and Class B managers of the Company for an unlimited

period of time:

111723

<i>Class A managers:

- Mrs Wendy F. Dulman, attorney, born in Cleveland, Ohio (USA) on 16 November 1968, having her professional

address at 9 West 57th Street, New York, New York 10019; and

- Mrs Laurie D. Medley, attorney, born in Lubbock, Texas (USA) on 13 July 1957, having her professional address at

9 West 57th Street, New York, NY 10019;

<i>Class B managers:

- Mr Alexis Kamarowsky, companies director, born in Strang (Germany) on 10 April 1947, having his professional

address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg;

- Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino, companies director, born in La Spezia (Italy) on 12 September 1964, having

his professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg; and

- Mr Jean-Marc Debaty, companies director, born in Rocourt (Belgium) on 11 March 1966, having his professional

address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, known to the notary by her surname, given name, civil status

and residence, she signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L'an deux mille huit, le dix-huitième jour d'août,
Par-devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

AIF VI Euro Holdings, L.P., une société en commandite exemptée régie par les lois des Iles Caïmans, dont le siège social

se situe à c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Iles Caïmans,
inscrite au registre des sociétés en commandite, sous le numéro WK-16752,

représentée par Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à 14, rue Edward Steichen, L - 2540

Luxembourg-Kirchberg, en vertu d'une procuration, donnée à New York, le quinze août 2008,

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante

les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "Euro VI (BC) S.àr.l." (la Société). La Société est une société à

responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du gérant unique ou du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand Duché de Luxembourg par une résolution de l'associé unique ou des associés, selon les modalités requises
pour la modification des Statuts.

2.2 II peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du gérant unique ou du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que
des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents,
et que ces développements ou évènements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son
siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement
à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité
de la Société qui, en dépit du transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers

111724

émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et tous autres titres représentatifs
d'emprunts et de participation. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts
et émissions d'obligations ou de valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés.
La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder
des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et,
de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne
doit effectuer aucune activité réglementée du secteur financier.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes les techniques et instruments liés à ses investissements

en vue de leur gestion efficace, en ce compris les techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les
risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut, d'une façon générale, effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles

et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent
ou se rapportent à son objet social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt-mille dollars américains (20.000 USD) représenté par vingt-mille

(20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1 USD) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'associé unique

ou des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification dès Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales de la Société sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée

générale des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de
gérance composé de Gérants A et de Gérants B (le Conseil). Les gérants ne doivent pas être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'associé unique ou des

associés.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués pour des tâches spécifiques par l'associé unique ou le

Conseil à un ou plusieurs agents.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le Conseil se réunit, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation de tout gérant au lieu

indiqué dans l'avis de convocation.

111725

9.2. Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de telles circonstances sont mentionnées dans la convocation
à la réunion du Conseil.

9.3. Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir été dûment informés de la réunion et avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Un gérant peut donner une procuration écrite à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
9.5. Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés.

9.6. Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre

moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre
et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement
convoquée et tenue.

9.7. En cas d'urgence, des résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et engagent la Société comme

si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent
apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et être prouvées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) lorsqu'il y a un gérant

unique, par la signature individuelle de ce gérant unique de la Société et (ii) lorsque plus d'un gérant a été nommé, par
les signatures conjointes d'un Gérant A et d'un Gérant B de la Société, ou (iii) lorsque c'est le cas, par les signatures
conjointes ou la signature unique de toute (s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué conformément
aux dispositions de l'article 8.2. des présents statuts. En matière administrative, pour des affaires ne dépassant pas un
engagement de sept mille cinq cent Euros (7.500 EUR), la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature indivi-
duelle de chaque gérant.

Art. 11. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. Les résolutions des associés sont adoptées en assemblées générales des associés (l' (les) Assemblée(s) Générale

(s)) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires).

12.2. Dans le cas où les résolutions sont adoptées par voie de Résolutions Circulaires, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les associés expriment leur vote en signant les Résolutions
Circulaires sur une ou plusieurs copies, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

12.3. Dans le cas où la Société a un seul associé, ce dernier exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée

Générale. Les décisions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

12.4. Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part

sociale donne droit à un vote.

Art. 13. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
13.1. Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

13.2. Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

13.3. Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
13.4. Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

13.5. Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas nécessairement être un

associé) afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

13.6. Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou
première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale
ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires
à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

13.7.Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant

au moins les trois-quarts du capital social.

111726

13.8. Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation des engagements des associés dans

la Société exige le consentement unanime des associés.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social et assemblée générale annuelle des associés.
14.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier de chaque année et se termine le trente et un (31) décembre

de la même année.

14.2. Chaque année, le gérant unique ou le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes conformément à

la Loi, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements
de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
14.4. Le bilan et le compte de pertes et profits sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par voie de

Résolutions Circulaires dans les six (6) moins à compter de la clôture de l'exercice social.

Art. 15. Réviseur d'entreprises.
15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

15.2. Les associés nomment le(s) réviseur(s) d'entreprises et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée

de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) réviseur(s) d'entreprises peuvent être réélus.

Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée dès que la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

16.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice au paiement

d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

16.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le gérant unique ou par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais réduit par les pertes reportées et les sommes à
affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par l'associé unique ou les associés dans les deux

(2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée par

la moitié des associés détenant les trois-quarts du capital social. L'associé unique ou les associés doivent nommer un ou
plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminer leur nombre, pouvoirs
et rémunération. Sauf disposition contraire prévue par le(s) associé(s), le(s) liquidateur(s) est (sont) investi(s) des pouvoirs
les plus larges pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

17.2.Le boni de liquidation restant après la réalisation des actifs et du paiement des dettes est distribué aux associés

proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

18.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions

circulaires sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou par tout autre moyen de communication électronique
communément accepté.

18.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

18.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques

remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. En cas
de résolutions circulaires, les signatures peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une
résolution identique.

18.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

111727

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2008.

<i>Souscription et libération

Sur ces faits, AIF VI Euro Holdings, L.P., prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt-

mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un dollar américain (1 USD) chacune, et de
les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt-mille dollars américains (20.000 USD).

Le montant de vingt-mille dollars américains (20.000 USD) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au

notaire instrumentant.

<i>Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social de 20.000.- USD est évalué à 13.600.- €.
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à 1.900.- €.

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants A et gérants B de la Société pour une durée indéter-

minée:

<i>Gérants A:

- Mme Wendy Friedman DULMAN, avocat, née à Cleveland, Ohio (Etats-Unis d'Amérique) le 16 novembre 1968, avec

adresse professionnelle à 9 West 57th Street, New York, New York 10019 (Etats-Unis d'Amérique); et

- Mme Laurie D. MEDLEY, avocat, née à Lubbock, Texas (Etats-Unis d'Amérique) le 13 juillet 1957, avec adresse

professionnelle à 9 West 57th Street, New York, NY10019 (Etats-Unis d'Amérique);

<i>Gérants B:

- M. Alexis KAMAROWSKY, administrateur de sociétés, né à Strang (Allemagne) le 10 avril 1947, avec adresse pro-

fessionnelle à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg;

- M. Federigo CANNIZZARO DI BELMONTINO, administrateur de sociétés, né à La Spezia (Italie) le 12 septembre

1964, avec adresse professionnelle à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg; et

- M. Jean-Marc DEBATY, administrateur de sociétés, né à Rocourt (Belgique) le 11 mars 1966, avec adresse profes-

sionnelle à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-

parante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du document faite à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,

ladite personne comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: E. Reinard, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 août 2008. Relation: LAC/2008/34414. — Reçu à 0,50%: soixante-huit euros un

cent (€ 68,01).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au  Mémorial,  Recueil  des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008116239/212/485.
(080134914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Even RX Drei S.à R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 141.341.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the sixteenth of July.
Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

111728

THERE APPEARED:

RX HEALTHCARE IMMOBILIEN S.A., société anonyme, a company incorporated under the laws of Luxembourg by

a deed of undersigned notary on the date hereof (repertorium number 29.582), not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, here represented
by two of its directors Eric VANDERKERKEN and Pascal BRUZZESE, who are themselves here represented by Natalie
O'SULLIVAN-GALLAGHER, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 11th July, 2008.

Which proxy shall be signed "we varietur" by the attorney of the above named person and the undersigned notary

and shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.

The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed

a single member limited liability company and to draw up its Articles of Association as follows:

Title I.- Name - Registered office - Purpose - Duration

Art. 1. There is hereby established a single member limited liability company which will be governed by the laws in

effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies, as amended from time to time,
September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on single member limited liability
companies (hereafter the "Law") as well as by the present articles (hereafter the "Articles").

Art. 2. The name of the company is "EVEN RX DREI S.à R.L.".

Art. 3. The registered office of the company is established in the municipality of Luxembourg. It can be transferred to

any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the manner
provided for amendments to the Articles.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lu-

xembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of real estate, stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the
possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises  and  may  render  any  assistance  by  way  of  loan,  guarantees  or  otherwise  to  subsidiaries,  affiliated  or  group
companies. The corporation may also establish branches in Luxembourg and abroad. The corporation may borrow in
any form against liquid of fixed assets from related or unrelated companies, it may also proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited term.

Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the company.

Title II.- Capital - Parts

Art. 7. The capital of the company is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) divided

into TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) parts of ONE EURO (EUR 1.-) each.

The company shall have an authorised share capital of FIFTEEN MILLION EURO (EUR 15,000,000.-) divided into

FIFTEEN MILLION (15,000,000) parts having a nominal value of ONE EURO (EUR 1.-) each.

The board of managers of the company is hereby authorised to issue further parts, with or without issue premium,

so as to bring the total capital of the company up to the amount of the authorised share capital. The board of managers
is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for such parts from time to time, to accept
subscriptions for such parts, and to accept contributions in cash or in kind as payment of the issue price for such parts.

This authorisation is granted for a period of three (3) years from the date of publication of the present articles, for

purposes of financing the acquisition of real estate property mainly in Germany or to discharge any liability incurred in
or amount due as a result of its formation. The period of this authority may be extended by resolution of the sole
participant or, as the case may be, of the general meeting of participants, in the manner required for amendment of these
articles of association.

The board of managers is further authorized to issue convertible bonds or assimilated instruments, bonds with sub-

scription  rights  attached,  or  any  debt  financial  instruments  convertible  into  parts  under  the  conditions  which  it  will
determine, provided however that these bonds or instruments are not to be issued to the public.

111729

When the board of managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the above provisions, it shall be

obliged to take steps to amend this article in order to record the change. The board of managers is hereby authorised
to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment.

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter

vivos to non-participants may only be made with the prior approval given in general meeting of participants representing
at least three quarters (3/4) of the share capital of the company.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Law.

Art. 9. The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under any

circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any
way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is managed by one or more managers appointed by the participants for an undetermined term.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) may be revoked ad
nutum.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is invested with the broadest powers to

perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those
expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of participants.

Any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by

the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers represented by the manager delegated for this
purpose.

In case of plurality of managers, the company shall be bound by the joint signature of any two members of the board

of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

In case of plurality of managers, the board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of its

members is present either in person or by proxy.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either

in person or by proxy.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device)
to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

Title IV.- General Meeting of Participants

Art. 11. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under

section XII of the law of August 10th, 1915.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall

be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the instigation of the management. Resolutions shall be validly adopted by the participants representing
more than fifty per cent (50%) of the capital.

However, resolutions to alter the Articles of the company may only be adopted by a quorum of at least fifty per cent

(50%) of the existing participants and the affirmative vote of at least two thirds (2/3) of the company's votes present or
represented at the general meeting amending the Articles, further subject to the provisions of the Law.

All general meetings of participants shall take place in Luxembourg.
Each part carries one vote at all meetings of participants.

111730

Any participant may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a participant, to represent him

at a general meeting of participants and to vote in his name and stead.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 12. The financial year of the company starts on the first day of October of each year and ends on the last day of

September of the following year.

Art. 13. Each year on the last day of September an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as

a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the pro-

visions and taxes constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The remainder of the net profit is at the disposal of the general meeting of participants.

Title VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 14. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need

not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by the Law. The liquidator(s) shall
be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse

the contribution made by the participants on the parts of the company.

The final surplus will be distributed to the participants in proportion to their respective participation in the company.

Title VII.- Varia

Art. 15. The parties refer to the existing Law and regulations for all matters not mentioned in the present Articles.

<i>Transitional Provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the company and shall end on the 30th of September

2008.

<i>Subscription

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:

parts

RX HEALTHCARE IMMOBILIEN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500

The parts have been fully paid up to the amount of ONE EURO (EUR 1.-) per part by a contribution in cash of TWELVE

THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-).

As a result, the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) is as of now at the disposal

of the company as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of its organization, are estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000.-).

<i>Extraordinary General Meeting

After the Articles have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an

extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is fixed at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;
2) Have been elected managers (gérants) of the company for an undetermined term:

<i>Board of Managers:

a) Erik VANDERKERKEN, company director, born on January 27th, 1964 in Esch-sur-Alzette, and having his profes-

sional residence at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;

b) Pascal BRUZZESE, company director, born on April 7, 1966 in Esch-sur-Alzette, having his professional residence

at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;

c) Fabien WANNIER, company director, born on July 18, 1977 in Bern (Switzerland), with professional residence at

11 Cours De Rive, CH-1204 Geneva, Switzerland; and

d) Michael LEVY, company director, born on March 7th, 1973 in Geneva, Switzerland, with professional residence at

11 Cours De Rive, CH-1204 Geneva, Switzerland.

111731

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English followed by a German version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and German text, the English version shall prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.

Follows the German version:

Im Jahre zweitausendacht, am sechzehnten Juli.
Vor Maître Paul BETTINGEN, Notar mit dem Amtssitz in Niederanven,

ERSCHIEN:

RX HEALTHCARE IMMOBILIEN S.A., société anonyme, eine nach dem luxemburgischen Recht durch Urkunde des

unterzeichnenden Notars vom heutigen Tage (Repertorium Nummer 29.582), noch nicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations veröffentlicht, gegründete Gesellschaft, die ihren Sitz in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg hat,
und hier durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder Eric VANDERKERKEN und Pascal BRUZZESE vertreten wird, wel-
che durch Natalie O'SULLIVAN-GALLAGHER, attorney-at-law, mit Adresse in Luxemburg auf Grund einer am 11. Juli
2008 erteilten Vollmacht, vertreten werden.

Welche Vollmacht, nachdem sie durch den oben benannten Vertreter und den unterzeichnenden Notar "ne varietur"

gezeichnet wurde, dieser Urkunde beigefügt wird, um zusammen mit ihr registriert zu werden.

Die vorgenannte Partei, vertreten wie vorerwähnt, erklärt ihre Absicht, mit dieser Urkunde eine unipersonale Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen und die folgende Satzung festzulegen:

Titel I- Firma - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgi-

schen  Gesetzen  und  insbesondere  dem  Gesetz  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften  und  dessen
Abänderungen, dem Gesetz vom 18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wie abgeändert, und
dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung (hiernach die "Ge-
setze") und der hiernach folgenden Satzung (die "Satzung") unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft führt die Firma "EVEN RX DREI S.à R.L. ".

Art. 3. Der Gesellschaftssitz ist in der Gemeinde Luxemburg. Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter,

welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Satzungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort
innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Im Falle außergewöhnlicher politischer oder wirtschaftlicher Ereignisse, welche auftreten oder sich dringlich ergeben

und die normale Aktivität oder Kommunikation am Gesellschaftssitz mit dem Ausland erschweren, kann der Gesell-
schaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis diese Ereignisse oder Umstände nicht mehr vorhanden sind.

Eine solche Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Entscheidung wird durch das

Organ der Gesellschaft an Drittparteien bekannt gemacht, welches am besten dafür in der Lage ist.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften,

deren Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder
auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen Immobilien sowie Grundstücken
und anderen Wertpapieren oder Effekten aller Art sowie der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapier
und Immobilienbestands.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller

Gesellschaften beteiligen und kann finanzielle Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder auf sonstige Weise
geben an verbundene Unternehmen oder Unternehmen derselben Gruppe. Die Gesellschaft kann auch Zweigstellen in
Luxemburg oder im Ausland begründen. Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen gegen flüssige oder
fixe Vermögenswerte von verbundenen oder nicht verbundenen Unternehmen, und kann Schuldinstrumente ausgeben.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art finanzieller, beweg-

licher  und  unbeweglicher,  kommerzieller  und  industrieller  Operationen  tätigen,  welche  sie  zur  Verwirklichung  und
Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.

Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines

Gesellschafters aufgelöst.

Titel II.- Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 7.  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  ZWÖLFTAUSEND  FÜNFHUNDERT  EURO  (EUR  12.500,-),  eingeteilt  in

ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT (12.500) Anteile von je EINEM EURO (EUR 1,-).

111732

Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Kapital in Höhe von FÜNFZEHN MILLIONEN EURO (EUR 15.000.000,-) ein-

geteilt in FÜNFZEHN MILLIONEN (15.000.000) Anteile mit einem Nominalwert je Anteil von EINEM EURO (EUR 1,-).

Die Geschäftsführung ist autorisiert, weitere Anteile auszugeben, mit oder ohne Aktienagio, um das Gesamtkapital

der Gesellschaft bis auf den Wert des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Die Geschäftsführung ist autorisiert, die Bedin-
gungen zu bestimmen, welche mit der Zeichnung solcher neuen Anteile zusammenhängen von Zeit zu Zeit, Zeichnungen
für diese Anteile zu akzeptieren, und die Einzahlungen in bar oder als Sacheinlage in Höhe des Ausgabepreises entgegen-
zunehmen.

Diese Autorisierung ist auf eine Zeitperiode von drei (3) Jahren, beginnend mit dem Datum der Veröffentlichung dieser

Satzung und nur für die Zwecke der Finanzierung des Aufkaufes von Immobilien und Grundstücken in Deutschland sowie
für die Einlösung von Verpflichtungen der Gesellschaft im Rahmen der Gründung der Gesellschaft beschränkt. Die Zeit-
periode kann durch den Beschluss des einzigen Gesellschafters oder, im gegebenen Falle, durch Beschluss der General-
versammlung der Gesellschafter, in der Art und Weise wie für die Änderung der Satzung vorgesehen, verlängert werden.

Die Geschäftsführung ist des Weiteren befugt, Wandelschuldanleihen und sonstige Schuldverschreibungen, mit oder

ohne Zeichnungsrechte oder sonstige Schuldinstrumente, welche in Aktien umwandelbar sind, auszugeben, vorausgesetzt,
diese Instrumente werden nicht öffentlich angeboten.

Sofern die Geschäftsführung eine teilweise oder vollständige Kapitalerhöhung beschließt im Rahmen der oben ausge-

führten Absätze, so ist die Geschäftsführung verpflichtet, alle Schritte zu unternehmen, um diesen Artikel entsprechend
abzuändern. Die Geschäftsführung ist hierbei autorisiert, alle Schritte zu unternehmen, um eine solche Änderung auszu-
führen und zu veröffentlichen.

Art. 8. Die Anteile können, solange es nur einen Gesellschafter gibt, von diesem Gesellschafter ohne Beschränkungen

übertragen werden.

Im Falle, dass es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Über-

tragung von Anteilen inter vivos an Nichtgesellschafter kann nur nach Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindes-
tens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, erfolgen.

Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handels-

gesellschaften verwiesen.

Art. 9. Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Sie-

gelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang
der Gesellschaft beeinträchtigen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung be-

ziehen.

Titel III.- Geschäftsführung

Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche von den Gesellschaftern für eine

unbestimmte Dauer gewählt werden, verwaltet. Sofern mehrere Geschäftsführer gewählt sind, bilden sie einen Vorstand.
Die Geschäftsführer können ohne Angabe von Gründen, ad nutum, abgewählt werden.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand ist mit den größtmöglichen Befugnissen

ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesell-
schaftszweck durchführen zu können, wobei ihm alle Befugnisse zustehen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder
diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden.

Sollte die Gesellschaft als Klägerin oder Beklagte in einem Rechtsstreit auftreten, vertritt der Geschäftsführer, oder

im Falle des Vorstands der vom Vorstand dafür autorisierte Geschäftsführer, die Gesellschaft in ihrem eigenen Namen.

Im Falle der Ernennung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei

Mitgliedern des Vorstandes rechtswirksam verpflichtet.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann seine Zuständigkeiten für spezielle

Aufgaben an Unterbevollmächtigte oder an einen oder mehrere ad hoc Vertreter delegieren.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann der Vorstand nur wirksam entscheiden, wenn mindestens die Hälfte seiner

Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Vorstandes benötigen eine Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer.
Alle Treffen des Vorstands finden in Luxemburg statt.
Beschlüsse, welche von allen Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet sind, gelten als genauso wirksam angenommen,

als wenn diese Beschlüsse bei einer korrekt einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung getroffen worden wären.
Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren identischen Kopien erscheinen und sie
können durch Brief, Telefax oder ähnliche Kommunikation nachgewiesen werden.

Außerdem  soll  jedes  Vorstandsmitglied  -  welches  an  einer  Vorstandssitzung  im  Wege  einer  Kommunikationshilfe

(einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den (selbst, durch Vollmacht oder ebenfalls durch eine Kommunikationshilfe)
anwesenden Vorstandsmitgliedern erlaubt, das andere Vorstandsmitglied jederzeit während der Sitzung zu hören und

111733

selbst gehört zu werden - als für diese Vorstandssitzung anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und
mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer solchen Sitzung berücksichtigt werden.

Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst

gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.

Titel IV.- Gesellschafterversammlung

Art. 11. Der einzige Gesellschafter ist mit allen Zuständigkeiten ausgestattet, die der Gesellschafterversammlung nach

Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 eingeräumt werden.

Alle Entscheidungen, welche nicht in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder des Vorstands fallen, können

vom Gesellschafter getroffen werden. Jede solcher Entscheidungen muss schriftlich verfasst, in einem Protokoll festge-
halten und in einem speziellen Register registriert werden.

Sollte mehr als ein Gesellschafter existieren, so werden die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterver-

sammlung gefasst oder durch schriftliche Beratung auf Initiative der Geschäftsführung. Beschlüsse gelten nur als ange-
nommen, wenn Gesellschafter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.

Beschlüsse zur Abänderung dieser Satzung nur wirksam gefasst werden, wenn ein solcher Beschluss von zwei Dritteln

(2/3) der anwesenden oder vertretenen Stimmrechte gefasst wird, wobei mindestens fünfzig Prozent (50%) des existier-
enden  Gesellschaftskapitals  bei  der  Generalversammlung  anwesend  sein  muss,  ergänzt  durch  die  Vorschriften  des
Gesetzes.

Alle Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.
Jeder Gesellschaftsanteil beinhaltet das Recht zur Abgabe einer Stimme auf jeder Gesellschafterversammlung.
Jeder Gesellschafter kann im Wege einer schriftlichen Vollmacht eine andere Person, die kein Gesellschafter sein muss,

autorisieren, ihn auf einer Gesellschafterversammlung zu vertreten und in seinem Namen und auf seine Rechnung abzu-
stimmen.

Titel IV.- Geschäftsjahr - Gewinn - Reserven

Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober eines Jahres und endet am letzten Septembertag

des darauffolgenden Jahres.

Art. 13. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats September, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der

Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.

Das Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und

der Provisionen, stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange ob-

ligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals umfasst. Der Abzug muss allerdings wieder
bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt und
aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde.

Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter zur Verfügung.

Titel VI.- Liquidation - Auflösung

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,

welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit den in den Gesetzen be-
stimmten Mehrheiten, ernannt werden. Der (die) Liquidator(en) verfüg(en) über die weitestgehenden Befugnisse zur
Realisierung des existierenden Vermögens und Begleichung der Verpflichtungen.

Der nach der Begleichung aller Kosten, Schulden und Ausgaben, welche aufgrund der Liquidation entstehen, zur Ver-

fügung stehende Betrag soll verwendet werden, um die von den Gesellschaftern auf Gesellschaftsanteile eingezahlten
Beträge zurückzuzahlen.

Der danach noch bestehende Restbetrag wird an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Gesellschaftsbeteiligung aus-

gezahlt.

Titel VII.- Verschiedenes

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetz-

lichen Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. September 2008.

<i>Zeichnung

Nachdem diese Satzung wie obenstehend verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, wie folgt Anteile der Gesell-

schaft zu zeichnen:

Anteile

RX HEALTHCARE IMMOBILIEN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

GESAMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

111734

Die Anteile wurden vollständig bis zu einem Betrag von EINEM EURO (EUR 1,-) je Anteil durch Barzahlung in Höhe

von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) eingezahlt.

Als Ergebnis steht ab dem jetzigen Zeitpunkt der Gesellschaft der Betrag von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT

EURO (EUR 12.500,-) zur Verfügung, was von dem Notar, welcher diese Urkunde unterzeichnet, bestätigt wird.

<i>Kosten

Die aufgrund dieser Gründung angefallenen Ausgaben, Kosten, Entschädigungen oder Gebühren jeglicher Form, welche

durch die Gesellschaft zu begleichen sind, werden auf ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000,-).

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Nachdem diese Satzung soeben verabschiedet wurde, entscheidet der oben erwähnte einzige Gesellschafter, eine

Gesellschafterversammlung abzuhalten. Nachdem festgestellt wurde, dass die Gesellschafterversammlung wirksam kon-
stitutiert wurde, hat diese die folgenden Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft ist in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;
2) Als Geschäftsführer (gerants) der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer werden folgende Personen ernannt:

<i>Vorstand:

a) Erik VANDERKERKEN, Company director, geboren am 27. Januar 1964 in Esch-sur-Alzette, mit professioneller

Adresse in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;

b) Pascal BRUZZESE, Company director, geboren am 7. April 1966 in Esch-sur-Alzette, mit professioneller Adresse

in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;

c) Fabien WANNIER, Company director, geboren am 18. Juli 1977 in Bern, Schweiz, mit professioneller Adresse in

11 Cours De Rive, CH-1204 Genf, Schweiz; und

d) Michael LEVY, Company director, geboren am 7. März 1973 in Genf, Schweiz, mit professioneller Adresse in 11

Cours De Rive, CH-1204 Genf, Schweiz.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung

der oben erschienenen Partei die vorliegende Satzung in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Version verfasst
ist, und dass auf Hinweis derselben erschienenen Partei im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den sprachlichen
Versionen, die englische Version massgebend sein soll.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der anwesenden Person, welche dem unterzeichneten Notar durch Name, Nachname, Fa-

milienstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die anwesende Person zusammen mit dem Notar diese
Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: O'Sullivan-Gallagher, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 25 juillet 2008. LAC/2008/31011. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents à

0,5%: 62,50 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Für gleichlautende Kopie Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 8. September 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008116244/202/371.
(080134875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Even RX Vier S.à R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 141.340.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the sixteenth of July.
Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

THERE APPEARED:

RX HEALTHCARE IMMOBILIEN S.A., société anonyme, a company incorporated under the laws of Luxembourg by

a deed of undersigned notary on the date hereof (repertorium number 29.582), not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, here represented
by two of its directors Eric VANDERKERKEN and Pascal BRUZZESE, who are themselves here represented by Natalie
O'SULLIVAN-GALLAGHER, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 11th July, 2008.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the attorney of the above named person and the undersigned notary and

shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.

111735

The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed

a single member limited liability company and to draw up its Articles of Association as follows:

Title I. Name - Registered office - Purpose - Duration

Art. 1. There is hereby established a single member limited liability company which will be governed by the laws in

effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies, as amended from time to time,
September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on single member limited liability
companies (hereafter the "Law") as well as by the present articles (hereafter the "Articles").

Art. 2. The name of the company is "EVEN RX VIER S.à R.L.".

Art. 3. The registered office of the company is established in the municipality of Luxembourg. It can be transferred to

any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the manner
provided for amendments to the Articles.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of real estate, stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the
possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises  and  may  render  any  assistance  by  way  of  loan,  guarantees  or  otherwise  to  subsidiaries,  affiliated  or  group
companies. The corporation may also establish branches in Luxembourg and abroad. The corporation may borrow in
any form against liquid of fixed assets from related or unrelated companies, it may also proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited term.

Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the company.

Title II. Capital - Parts

Art. 7. The capital of the company is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) divided

into TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) parts of ONE EURO (EUR 1.-) each.

The company shall have an authorised share capital of FIFTEEN MILLION EURO (EUR 15,000,000.-) divided into

FIFTEEN MILLION (15,000,000) parts having a nominal value of ONE EURO (EUR 1.-) each.

The board of managers of the company is hereby authorised to issue further parts, with or without issue premium,

so as to bring the total capital of the company up to the amount of the authorised share capital. The board of managers
is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for such parts from time to time, to accept
subscriptions for such parts, and to accept contributions in cash or in kind as payment of the issue price for such parts.

This authorisation is granted for a period of three (3) years from the date of publication of the present articles, for

purposes of financing the acquisition of real estate property mainly in Germany or to discharge any liability incurred in
or amount due as a result of its formation. The period of this authority may be extended by resolution of the sole
participant or, as the case may be, of the general meeting of participants, in the manner required for amendment of these
articles of association.

The board of managers is further authorized to issue convertible bonds or assimilated instruments, bonds with sub-

scription  rights  attached,  or  any  debt  financial  instruments  convertible  into  parts  under  the  conditions  which  it  will
determine, provided however that these bonds or instruments are not to be issued to the public.

When the board of managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the above provisions, it shall be

obliged to take steps to amend this article in order to record the change. The board of managers is hereby authorised
to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment.

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter

vivos to non-participants may only be made with the prior approval given in general meeting of participants representing
at least three quarters (3/4) of the share capital of the company.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Law.

111736

Art. 9. The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under any

circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any
way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III. Management

Art. 10. The company is managed by one or more managers appointed by the participants for an undetermined term.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) may be revoked ad
nutum.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is invested with the broadest powers to

perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those
expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of participants.

Any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by

the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers represented by the manager delegated for this
purpose.

In case of plurality of managers, the company shall be bound by the joint signature of any two members of the board

of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

In case of plurality of managers, the board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of its

members is present either in person or by proxy.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either

in person or by proxy.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device)
to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

Title IV. General meeting of participants

Art. 11. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under

section XII of the law of August 10th, 1915.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall

be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the instigation of the management. Resolutions shall be validly adopted by the participants representing
more than fifty per cent (50%) of the capital.

However, resolutions to alter the Articles of the company may only be adopted by a quorum of at least fifty per cent

(50%) of the existing participants and the affirmative vote of at least two thirds (2/3) of the company's votes present or
represented at the general meeting amending the Articles, further subject to the provisions of the Law.

All general meetings of participants shall take place in Luxembourg.
Each part carries one vote at all meetings of participants.
Any participant may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a participant, to represent him

at a general meeting of participants and to vote in his name and stead.

Title V. Financial year - Profits - Reserves

Art. 12. The financial year of the company starts on the first day of October of each year and ends on the last day of

September of the following year.

Art. 13. Each year on the last day of September an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as

a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the pro-

visions and taxes constitute the net profit.

111737

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The remainder of the net profit is at the disposal of the general meeting of participants.

Title VI. Dissolution - Liquidation

Art. 14. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need

not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by the Law. The liquidator(s) shall
be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse

the contribution made by the participants on the parts of the company.

The final surplus will be distributed to the participants in proportion to their respective participation in the company.

Title VII. Varia

Art. 15. The parties refer to the existing Law and regulations for all matters not mentioned in the present Articles.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the company and shall end on the 30th of September

2008.

<i>Subscription

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:

parts

RX HEALTHCARE IMMOBILIEN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500

The parts have been fully paid up to the amount of ONE EURO (EUR 1.-) per part by a contribution in cash of TWELVE

THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-).

As a result, the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) is as of now at the disposal

of the company as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of its organization, are estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000.-).

<i>Extraordinary general meeting

After the Articles have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an

extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is fixed at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;
2) Have been elected managers (gérants) of the company for an undetermined term:

<i>Board of Managers:

a) Erik VANDERKERKEN, company director, born on January 27th, 1964 in Esch-sur-Alzette, and having his profes-

sional residence at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;

b) Pascal BRUZZESE, company director, born on April 7, 1966 in Esch-sur-Alzette, having his professional residence

at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;

c) Fabien WANNIER, company director, born on July 18, 1977 in Bern (Switzerland), with professional residence at

11 Cours De Rive, CH-1204 Geneva, Switzerland; and

d) Michael LEVY, company director, born on March 7th, 1973 in Geneva, Switzerland, with professional residence at

11 Cours De Rive, CH-1204 Geneva, Switzerland.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English followed by a German version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and German text, the English version shall prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.

Follows the German version:

Im Jahre zweitausendacht, am sechzehnten Juli.
Vor Maître Paul BETTINGEN, Notar mit dem Amtssitz in Niederanven,

ERSCHIEN:

111738

RX HEALTHCARE IMMOBILIEN S.A., société anonyme, eine nach dem luxemburgischen Recht durch Urkunde des

unterzeichnenden Notars vom heutigen Tage (Repertorium Nummer 29.582), noch nicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, veröffentlicht, gegründete Gesellschaft, die ihren Sitz in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg hat,
und hier durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder Eric VANDERKERKEN und Pascal BRUZZESE vertreten wird, wel-
che hier durch Natalie O'SULLIVAN-GALLAGHER, attorney-at-law, mit Adresse in Luxemburg, auf Grund einer am 11.
Juli 2008 erteilten Vollmacht, vertreten werden.

Welche Vollmacht, nachdem sie durch den oben benannten Vertreter und den unterzeichnenden Notar "ne varietur"

gezeichnet wurde, dieser Urkunde beigefügt wird, um zusammen mit ihr registriert zu werden.

Die vorgenannte Partei, vertreten wie vorerwähnt, erklärt ihre Absicht, mit dieser Urkunde eine unipersonale Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen und die folgende Satzung festzulegen:

Titel I. Firma - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgi-

schen  Gesetzen  und  insbesondere  dem  Gesetz  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften  und  dessen
Abänderungen, dem Gesetz vom 18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wie abgeändert, und
dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung (hiernach die "Ge-
setze") und der hiernach folgenden Satzung (die "Satzung") unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft führt die Firma "EVEN RX VIER S.à R.L. ".

Art. 3. Der Gesellschaftssitz ist in der Gemeinde Luxemburg. Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter,

welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Satzungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort
innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Im Falle außergewöhnlicher politischer oder wirtschaftlicher Ereignisse, welche auftreten oder sich dringlich ergeben

und die normale Aktivität oder Kommunikation am Gesellschaftssitz mit dem Ausland erschweren, kann der Gesell-
schaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis diese Ereignisse oder Umstände nicht mehr vorhanden sind.

Eine solche Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Entscheidung wird durch das

Organ der Gesellschaft an Drittparteien bekannt gemacht, welches am besten dafür in der Lage ist.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften,

deren Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder
auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen Immobilien sowie Grundstücken
und anderen Wertpapieren oder Effekten aller Art sowie der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapier
und Immobilienbestands.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller

Gesellschaften beteiligen und kann finanzielle Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder auf sonstige Weise
geben an verbundene Unternehmen oder Unternehmen derselben Gruppe. Die Gesellschaft kann auch Zweigstellen in
Luxemburg oder im Ausland begründen. Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen gegen flüssige oder
fixe Vermögenswerte von verbundenen oder nicht verbundenen Unternehmen, und kann Schuldinstrumente ausgeben.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art finanzieller, beweg-

licher  und  unbeweglicher,  kommerzieller  und  industrieller  Operationen  tätigen,  welche  sie  zur  Verwirklichung  und
Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.

Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines

Gesellschafters aufgelöst.

Titel II. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 7.  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  ZWÖLFTAUSEND  FÜNFHUNDERT  EURO  (EUR  12.500,-),  eingeteilt  in

ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT (12.500) Anteile von je EINEM EURO (EUR 1,-).

Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Kapital in Höhe von FÜNFZEHN MILLIONEN EURO (EUR 15.000.000,-) ein-

geteilt in FÜNFZEHN MILLIONEN (15.000.000) Anteile mit einem Nominalwert je Anteil von EINEM EURO (EUR 1,-).

Die Geschäftsführung ist autorisiert, weitere Anteile auszugeben, mit oder ohne Aktienagio, um das Gesamtkapital

der Gesellschaft bis auf den Wert des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Die Geschäftsführung ist autorisiert, die Bedin-
gungen zu bestimmen, welche mit der Zeichnung solcher neuen Anteile zusammenhängen von Zeit zu Zeit, Zeichnungen
für diese Anteile zu akzeptieren, und die Einzahlungen in bar oder als Sacheinlage in Höhe des Ausgabepreises entgegen-
zunehmen.

Diese Autorisierung ist auf eine Zeitperiode von drei (3) Jahren, beginnend mit dem Datum der Veröffentlichung dieser

Satzung und nur für die Zwecke der Finanzierung des Aufkaufes von Immobilien und Grundstücken in Deutschland sowie
für die Einlösung von Verpflichtungen der Gesellschaft im Rahmen der Gründung der Gesellschaft beschränkt. Die Zeit-
periode kann durch den Beschluss des einzigen Gesellschafters oder, im gegebenen Falle, durch Beschluss der General-
versammlung der Gesellschafter, in der Art und Weise wie für die Änderung der Satzung vorgesehen, verlängert werden.

111739

Die Geschäftsführung ist des Weiteren befugt, Wandelschuldanleihen und sonstige Schuldverschreibungen, mit oder

ohne Zeichnungsrechte oder sonstige Schuldinstrumente, welche in Aktien umwandelbar sind, auszugeben, vorausgesetzt,
diese Instrumente werden nicht öffentlich angeboten.

Sofern die Geschäftsführung eine teilweise oder vollständige Kapitalerhöhung beschließt im Rahmen der oben ausge-

führten Absätze, so ist die Geschäftsführung verpflichtet, alle Schritte zu unternehmen, um diesen Artikel entsprechend
abzuändern. Die Geschäftsführung ist hierbei autorisiert, alle Schritte zu unternehmen, um eine solche Änderung auszu-
führen und zu veröffentlichen.

Art. 8. Die Anteile können, solange es nur einen Gesellschafter gibt, von diesem Gesellschafter ohne Beschränkungen

übertragen werden.

Im Falle, dass es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Über-

tragung von Anteilen inter vivos an Nichtgesellschafter kann nur nach Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindes-
tens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, erfolgen.

Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handels-

gesellschaften verwiesen.

Art. 9. Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Sie-

gelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang
der Gesellschaft beeinträchtigen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung be-

ziehen.

Titel III. Geschäftsführung

Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche von den Gesellschaftern für eine

unbestimmte Dauer gewählt werden, verwaltet. Sofern mehrere Geschäftsführer gewählt sind, bilden sie einen Vorstand.
Die Geschäftsführer können ohne Angabe von Gründen, ad nutum, abgewählt werden.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand ist mit den größtmöglichen Befugnissen

ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesell-
schaftszweck durchführen zu können, wobei ihm alle Befugnisse zustehen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder
diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden.

Sollte die Gesellschaft als Klägerin oder Beklagte in einem Rechtsstreit auftreten, vertritt der Geschäftsführer, oder

im Falle des Vorstands der vom Vorstand dafür autorisierte Geschäftsführer, die Gesellschaft in ihrem eigenen Namen.

Im Falle der Ernennung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei

Mitgliedern des Vorstandes rechtswirksam verpflichtet.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann seine Zuständigkeiten für spezielle

Aufgaben an Unterbevollmächtigte oder an einen oder mehrere ad hoc Vertreter delegieren.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann der Vorstand nur wirksam entscheiden, wenn mindestens die Hälfte seiner

Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Vorstandes benötigen eine Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer.
Alle Treffen des Vorstands finden in Luxemburg statt.
Beschlüsse, welche von allen Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet sind, gelten als genauso wirksam angenommen,

als wenn diese Beschlüsse bei einer korrekt einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung getroffen worden wären.
Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren identischen Kopien erscheinen und sie
können durch Brief, Telefax oder ähnliche Kommunikation nachgewiesen werden.

Außerdem  soll  jedes  Vorstandsmitglied  -  welches  an  einer  Vorstandssitzung  im  Wege  einer  Kommunikationshilfe

(einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den (selbst, durch Vollmacht oder ebenfalls durch eine Kommunikationshilfe)
anwesenden Vorstandsmitgliedern erlaubt, das andere Vorstandsmitglied jederzeit während der Sitzung zu hören und
selbst gehört zu werden - als für diese Vorstandssitzung anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und
mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer solchen Sitzung berücksichtigt werden.

Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst

gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.

Titel IV. Gesellschafterversammlung

Art. 11. Der einzige Gesellschafter ist mit allen Zuständigkeiten ausgestattet, die der Gesellschafterversammlung nach

Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 eingeräumt werden.

Alle Entscheidungen, welche nicht in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder des Vorstands fallen, können

vom Gesellschafter getroffen werden. Jede solcher Entscheidungen muss schriftlich verfasst, in einem Protokoll festge-
halten und in einem speziellen Register registriert werden.

Sollte mehr als ein Gesellschafter existieren, so werden die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterver-

sammlung gefasst oder durch schriftliche Beratung auf Initiative der Geschäftsführung. Beschlüsse gelten nur als ange-
nommen, wenn Gesellschafter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.

111740

Beschlüsse zur Abänderung dieser Satzung nur wirksam gefasst werden, wenn ein solcher Beschluss von zwei Dritteln

(2/3) der anwesenden oder vertretenen Stimmrechte gefasst wird, wobei mindestens fünfzig Prozent (50%) des existier-
enden  Gesellschaftskapitals  bei  der  Generalversammlung  anwesend  sein  muss,  ergänzt  durch  die  Vorschriften  des
Gesetzes.

Alle Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.
Jeder Gesellschaftsanteil beinhaltet das Recht zur Abgabe einer Stimme auf jeder Gesellschafterversammlung.
Jeder Gesellschafter kann im Wege einer schriftlichen Vollmacht eine andere Person, die kein Gesellschafter sein muss,

autorisieren, ihn auf einer Gesellschafterversammlung zu vertreten und in seinem Namen und auf seine Rechnung abzu-
stimmen.

Titel IV. Geschäftsjahr - Gewinn - Reserven

Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober eines Jahres und endet am letzten Septembertag

des darauffolgenden Jahres.

Art. 13. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats September, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der

Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.

Das Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und

der Provisionen, stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange ob-

ligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals umfasst. Der Abzug muss allerdings wieder
bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt und
aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde.

Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter zur Verfügung.

Titel VI. Liquidation - Auflösung

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,

welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit den in den Gesetzen be-
stimmten Mehrheiten, ernannt werden. Der (die) Liquidator(en) verfüg (en) über die weitestgehenden Befugnisse zur
Realisierung des existierenden Vermögens und Begleichung der Verpflichtungen.

Der nach der Begleichung aller Kosten, Schulden und Ausgaben, welche aufgrund der Liquidation entstehen, zur Ver-

fügung stehende Betrag soll verwendet werden, um die von den Gesellschaftern auf Gesellschaftsanteile eingezahlten
Beträge zurückzuzahlen.

Der danach noch bestehende Restbetrag wird an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Gesellschaftsbeteiligung aus-

gezahlt.

Titel VII. Verschiedenes

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetz-

lichen Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. September 2008.

<i>Zeichnung

Nachdem diese Satzung wie obenstehend verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, wie folgt Anteile der Gesell-

schaft zu zeichnen:

Anteile

RX HEALTHCARE IMMOBILIEN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500
GESAMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500

Die Anteile wurden vollständig bis zu einem Betrag von EINEM EURO (EUR 1,-) je Anteil durch Barzahlung in Höhe

von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) eingezahlt.

Als Ergebnis steht ab dem jetzigen Zeitpunkt der Gesellschaft der Betrag von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT

EURO (EUR 12.500,-) zur Verfügung, was von dem Notar, welcher diese Urkunde unterzeichnet, bestätigt wird.

<i>Kosten

Die aufgrund dieser Gründung angefallenen Ausgaben, Kosten, Entschädigungen oder Gebühren jeglicher Form, welche

durch die Gesellschaft zu begleichen sind, werden auf ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000,-).

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Nachdem diese Satzung soeben verabschiedet wurde, entscheidet der oben erwähnte einzige Gesellschafter, eine

Gesellschafterversammlung abzuhalten. Nachdem festgestellt wurde, dass die Gesellschafterversammlung wirksam kon-
stitutiert wurde, hat diese die folgenden Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft ist in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;

111741

2) Als Geschäftsführer (gérants) der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer werden folgende Personen ernannt:

<i>Vorstand:

a) Erik VANDERKERKEN, Company director, geboren ara 27. Januar 1964 in Esch-sur-Alzette, mit professioneller

Adresse in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;

b) Pascal BRUZZESE, Company director, geboren am 7. April 1966 in Esch-sur-Alzette, mit professioneller Adresse

in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;

c) Fabien WANNIER, Company director, geboren am 18. Juli 1977 in Bern, Schweiz, mit professioneller Adresse in

11 Cours De Rive, CH-1204 Genf, Schweiz; und

d) Michael LEVY, Company director, geboren am 7. März 1973 in Genf, Schweiz, mit professioneller Adresse in 11

Cours De Rive, CH-1204 Genf, Schweiz.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung

der oben erschienenen Partei die vorliegende Satzung in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Version verfasst
ist, und dass auf Hinweis derselben erschienenen Partei im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den sprachlichen
Versionen, die englische Version massgebend sein soll.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der anwesenden Person, welche dem unterzeichneten Notar durch Name, Nachname, Fa-

milienstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die anwesende Person zusammen mit dem Notar diese
Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: O'SuIlivan-Gallagher, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 25 juillet 2008. LAC/2008/31012. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents à

0,5%: 62,50 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Für gleichlautende Kopie, Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den. 8 September 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008116245/202/371.
(080134868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Orion III European 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Orion Immobilien 2 S.à r.l.).

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 122.514.

In the year two thousand eight, on the second day of September.
Before Us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg-Eich (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in

replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg), who will remain
depositary of the present original deed,

There appeared:

"Orion Master III Luxembourg S.à r.l.", a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), having a
corporate capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B-140.853. (the "Shareholder"),

here represented by Me Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 29 August 2008; said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of

the Shareholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of

"Orion Immobilien 2 S.à r.l.", a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having a corporate capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 6, avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated following a deed of Maître Martine Schaeffer, notary
then residing in Remich (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, prenamed,
on 11 December 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 138 on 8 February
2007, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, number 122.514 and whose
articles of association have never been amended since its incorporation (the "Company").

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

111742

<i>Agenda

1 To change the Company's name into "Orion III European 1 S.à r.l.".
2 To amend the second paragraph of article 1 of the Company's articles of association in order to reflect the resolution

to be adopted under item 1 of the agenda.

has requested the notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolves to change the Company's name into "Orion III European 1 S.à r.l.".

<i>Second resolution

The Shareholder resolves to amend the second paragraph of article 1 of the Company's articles of incorporation which

shall forthwith read as follows:

"The Company will exist under the name of "Orion III European 1 S.à r.l."."
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version and that at the request of the proxy holder of the appearing party and in case of
divergences between the two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary, by his surname, first

name, civil status and residence, said proxy holder signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le deux septembre.
Par-devant Nous, Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg-Eich (Grand-Duché de Luxembourg),

agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute,

a comparu :

" Orion Master III Luxembourg S.à r.l. ", une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant un
capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B -140.853. (l'" Associé"),

représentée aux fins des présentes par Me Laurent Schummer, avocat, de résidence à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 29 août 2008;
ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de l'Associé et le notaire instrumentant

restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de " Orion Immobilien

2 S.à r.l. ", une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital social
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), constituée suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire alors de résidence à Remich (Grand-
Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, prenommé, le 11 décembre 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 138, le 8 février 2007 et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 122.514 et dont les statuts n'ont encore jamais été modifiés
depuis sa constitution (la " Société ").

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été parfaitement informé des décisions à intervenir

sur la base de l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour

1 Modification de la dénomination de la Société en " Orion III European 1 S.à r.l. ".
2 Modification de l'article 1, deuxième alinéa, des statuts de la Société de manière à refléter la résolution à adopter

au point 1 de l'ordre du jour.

a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

<i>Première résolution

L'Associé décide de modifier la dénomination de la Société en " Orion III European 1 S.à r.l. ".

<i>Deuxième résolution

L'Associé décide de modifier l'article 1, deuxième alinéa des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme

suit:

" La Société adopte la dénomination de " Orion III European 1 S.à r.l. ". "

111743

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'a la demande du mandataire

de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'a la demande du
même mandataire et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture  du  présent  acte  faite  et  interprétation  donnée  au  mandataire  de  la  partie  comparante,  connu  du  notaire

instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. SCHUMMER, C. WERSANDT.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 8 septembre 2008. Relation: EAC/2008/11422. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 11 septembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008119129/239/93.
(080138210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Apax Angel PEC 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 114.267.

EXTRAIT

1) Le siège social d'Apax WW Nominees Limited, l'associé unique de la Société, a été transféré à l'adresse suivante:
33 Jermyn Street, Londres SW1 Y6DN, Royaume Uni

2) En date du 26 août 2008, Stephen Kempen a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société et Andrew William

Guille, administrateur, demeurant à Elishama, Rue de la Fosse, St Saviour, Guernesey GY7 9SU, né le 22 novembre 1959
à Guernesey, a été nommé en son remplacement en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Il résulte de ce qui précède que le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

- Richard Newton
- Andrew William Guille
- Sophie Laguesse
- Geoffrey Henry

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2008.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008116518/260/25.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01880. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Kenavon Drive Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.000,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Zone Industrielle Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 124.776.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116786/242/13.
(080135750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

111744


Document Outline

ABF Regents Park Investments S.à r.l.

Adrenaline Shipping S.A.

Apax Angel PEC 1 S.à r.l.

Apax Angel PEC A S.à r.l.

Aqua European Technologists S.A.

Arcipelagos Sicav

Assenagon Asset Management S.A.

Baldock Holding S. à r.l.

Bond Holdco I S.à r.l.

Bond Subco III S.à r.l.

Boval S.A.

BRC S.à r.l.

Calfin International S.A.

Catelan S.A.

CEB Pantanal S.à r.l.

CFM SA

Elefint S.A.

EPI Oakwood LP 1 S.à r.l.

Euro VI (BC) S.à r.l.

Evanio Investments Holding S.A.

Even RX Drei S.à R.L.

Even RX Vier S.à R.L.

Flagstone Finance S.A.

Gamma III S.C.A., Sicar

I.M.A. S.C.I.

Immovest S.A.

Jackpot S.à r.l.

Kenavon Drive Holdings

Limra N°2 S.à r.l.

Lumina Participation

Lumina White

MD Lux S.à r.l.

MSI Alpha Phi S.C.A.

MSI Beta S.à r.l.

Nartal S.A.

Neolite Holding S.A.

New Finder S.A.

Novipa

Omnia Real Estate S.A.

Orion III European 1 S.à r.l.

Orion Immobilien 2 S.à r.l.

Panel S.A.

Portfolio B.P.

PORTUNATO &amp; Cie S.A.

Property Hof S.à r.l.

PS Tabak S.à r.l.

Randstad Group Luxembourg S.à r.l.

Reckitt Benckiser Investments (N°6), S.à r.l.

Sapphire Actipark 1 S.à r.l.

Secapital S.à.r.l.

S.G.C. Luxembourg S.A.

Sisvel International

Sudinvestments S.A.

Vasto S.A.

Wallberg Invest S.A.

Wincanton Trans European (Luxembourg) S.à r.l.