This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2185
9 septembre 2008
SOMMAIRE
Apollo Portland EU II S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
104846
Arcenciel Financial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
104848
ASK Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104847
BELF 5 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104837
Belgravia Swiss 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104837
BlackRock (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . .
104836
Blue Jeans S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104838
Buderus Giesserei Holding S.àr.l. . . . . . . . .
104844
Burdaras Luxembourg Holding S.à r.l. . . .
104844
Canalville S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104839
CARE Canadian Real Estate S.A. . . . . . . . .
104838
Centuria Holding Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . .
104845
Century Properties S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
104836
CEREP Investment Five S.à r.l. . . . . . . . . . .
104860
Chiorino Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104837
ELECTEK Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
104836
Elocap Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104844
Fédération Luxembourgeoise de Massage
Bien-Etre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104875
Fidelity Investments Luxembourg S.A. . . .
104837
Fidis S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104835
FIL (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
104837
Flamierge Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
104845
Fondation Pauline de Faillonnet . . . . . . . . .
104834
Galerie Moderne, s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
104839
GMT Spanext S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104846
Grenache & Cie S.N.C. . . . . . . . . . . . . . . . . .
104870
International Financial Trading Company
B.L.T. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104840
Investment Lux Partners . . . . . . . . . . . . . . .
104845
Iris Garden Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104843
Jordan French Investment Group S.A.H.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104841
K-Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104835
L'Altaï S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104837
LBS Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104843
Lebaras Holding S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104850
Lehwood Ventures S.à. r.l. . . . . . . . . . . . . . .
104843
Liam Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104847
Lime Invest & Co. S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . .
104834
Mobitek S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104836
National Construction S.A. . . . . . . . . . . . . .
104839
New Star Global Property Management
(Luxembourg Two) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
104872
Palazzo Due Funding & Co S.C.A. . . . . . . .
104848
Pegase Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104836
Pegasus Investments Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
104849
Pestana Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104841
PHD Overseas Limited . . . . . . . . . . . . . . . . .
104842
Pizzeria ZIO PEPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104835
Plumeria S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104849
Polish Purple Investments S.à r.l. . . . . . . . .
104849
Poseidon JV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104860
Profilex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104839
Project Shift (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .
104846
Quanlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104842
Redwood Russia 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104880
Restaurant Pepe Bar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
104835
Reuters S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104850
Selwyn S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104847
Services Généraux de Gestion S.A. . . . . . .
104834
Symptom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104838
Tempyr S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104848
Terre Naturelle (Holding) S.A. . . . . . . . . . .
104842
TS Nautilus (Friedrichstrasse) S.à.r.l. . . . .
104841
TS Nautilus (Hahnstrasse) S.à.r.l. . . . . . . . .
104840
TS Nautilus (Liebknechtstrasse) S.à.r.l. . .
104840
Zuucht- an Ausbildungsstall Biwerbaach
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104877
104833
Lime Invest & Co. S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 101.458.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008101336/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2008, réf. LSO-CT00951. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080116747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Services Généraux de Gestion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 65.906.
<i>Mitteilungi>
Der Gesellschaftssitz wird mit Wirkung am 1. August 2008 von seinem gegenwärtigen Platz, 23, avenue Monterey
L-2086 Luxembourg, an 412 F, route d'Esch L-2086 Luxemburg, verlegt.
Luxemburg, den 17. Juli 2008.
<i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
i>Jean-Robert BARTOLINI / Christoph N. KOSSMANN
<i>Directeur / Membre du Comité de Directioni>
Référence de publication: 2008106536/795/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, réf. LSO-CS10963. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080122830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.
Fondation Pauline de Faillonnet.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 21, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg G 96.
BILAN 2007
<i>Comptei>
<i>Actif (€)i>
<i>Passif (€)i>
101 FONDS SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 956 123,07
121 RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
662 338,30
Total classe 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 618 461,37
465 DEBITEURS DIVERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 465 456,14
467 DETTE DOCTRINE CHRETIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 230 553,37
Total classe 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 696 009,51
51221 BGLL- compte courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
343,51
512229 BGL 62-148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 731 565,76
51223 BGL 87-153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 441 381,05
51225 FORTIS 35-162 (contre-parte emprunt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 123 180,56
520 compte titres b10780
4 509 000,00
521 compte titres b10770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 509 000,00
Total classe 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 314 470,88
23 314 470,88 23 314 470,88
Vendredi 4 janvier 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008102277/504/26.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, réf. LSO-CS10986. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080117616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.
104834
K-Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 140.443.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "K-
DEVELOPMENT S.A.", établie et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 140.443, (la "Société"), tenue en date du 23 juillet
2008:
1) que le nombre des administrateurs est augmenté de trois (3) à (4);
2) que Monsieur Eric LUX, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 19 décembre 1967, demeurant profes-
sionnellement à L-8070 Bertrange, ZA Bourmicht, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
2014.
Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour la Société
i>Flavio BECCA
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2008104763/231/23.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05713. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080120554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2008.
Fidis S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.312.
<i>Extrait des résolutions prises par le Gérant Unique en date du 04 août 2008i>
Le Gérant Unique décide:
- De transférer le siège social de la société du 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086
Luxembourg, et ce avec effet au 1
er
août 2008.
- De modifier comme suit l'adresse professionnelle du Gérant Unique et ce avec effet au 1
er
août 2008:
* Madame Betty PRUDHOMME, Gérant Unique, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-
xembourg.
B. PRUDHOMME
<i>Gérant Uniquei>
Référence de publication: 2008106537/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2008, réf. LSO-CT06691. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080122812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.
Pizzeria ZIO PEPE, Société à responsabilité limitée,
(anc. Restaurant Pepe Bar S.à r.l.).
Siège social: L-2265 Luxembourg, 35, rue de la Toison d'Or.
R.C.S. Luxembourg B 78.161.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Emile SCHLESSER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008108622/227/13.
(080125414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
104835
Pegase Investment, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 70.359.
Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2008.
<i>Pour Pegase Investment
i>Pictet Funds S.A.
Grégory Fourez / Marie-Claude Lange
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoiri>
Référence de publication: 2008108620/52/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10250. - Reçu 48,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080125480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Mobitek S.A., Société Anonyme,
(anc. ELECTEK Luxembourg S.A.).
Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 69.325.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 août 2008.
BLANCHE MOUTRIER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2008108641/272/13.
(080125149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
BlackRock (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 27.689.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BlackRock (Luxembourg) S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008108649/1163/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10659. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Century Properties S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 119.339.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22/08/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008108663/6449/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07552. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
104836
BELF 5 Luxembourg, Société à responsabilité limitée,
(anc. Belgravia Swiss 1).
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 134.061.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 août 2008.
BLANCHE MOUTRIER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2008108642/272/13.
(080125134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
FIL (Luxembourg) S.A., Société Anonyme,
(anc. Fidelity Investments Luxembourg S.A.).
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 29.112.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008108643/5770/13.
(080124972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
L'Altaï S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 72.650.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008108653/2948/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT08889. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Chiorino Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 61.973.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 21 juillet 2008i>
Est nommé réviseur d'entreprises, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes consolidés au 31 décembre 2007:
- H.R.T. Révision S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008108797/534/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2008, réf. LSO-CT06861. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
104837
Symptom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 64.202.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2008.
<i>Fiduciaire Joseph Treis S.àr.l.
i>57, avenue de la faïencerie, L-1510 Luxembourg
<i>Expert Comptable, Réviseur d'Entreprise
i>Signature
Référence de publication: 2008108656/601/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2008, réf. LSO-CS09334. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080125070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Blue Jeans S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9225 Diekirch, 11, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 101.706.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 21 août 2008.
<i>Fiduciaire Joseph Treis S.àr.l.
i>57, avenue de la faïencerie, L-1510 Luxembourg
<i>Expert Comptable, Réviseur d'Entreprise
i>Signature
Référence de publication: 2008108657/601/16.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2008, réf. LSO-CS12873. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
CARE Canadian Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 66.051.
<i>Auszug aus der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Juni 2008i>
Nach eingehender Beratung fasst die Hauptversammlung am 10. Juni 2008 einstimmig folgende Beschlüsse:
Änderung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates:
1. Frau Edith MAERTEN mit Berufsanschrift L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle, wird zum ordentlichen
Mitglied des Verwaltungsrates ernannt.
Zeichnungsberechtigung: Einzelzeichnungsrecht
2. Herr Edgar REIFER mit Berufsanschrift in L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle, wird zum ordentlichen
Mitglied des Verwaltungsrates ernannt.
Zeichnungsberechtigung: Einzelzeichnungsrecht
Die Mandate enden bei der Hauptversammlung, die im Jahre 2010 stattfindet.
Luxemburg, 10. Juni 2008.
<i>Für die Versammlung
i>Heike Gottschalk
Référence de publication: 2008108811/680/22.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08250. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
104838
Galerie Moderne, s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6778 Grevenmacher, 4, Schaffmill.
R.C.S. Luxembourg B 4.455.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, le 21 août 2008.
<i>Fiduciaire Joseph Treis S.àr.l.
i>57, avenue de la faïencerie, L-1510 Luxembourg
<i>Expert Comptable, Réviseur d'Entreprise
i>Signature
Référence de publication: 2008108658/601/16.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2008, réf. LSO-CS12875. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080125099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Canalville S.A., Société Anonyme,
(anc. National Construction S.A.).
Siège social: L-3378 Livange, 11, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 40.335.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Livange, le 21 août 2008.
<i>Fiduciaire Joseph Treis S.àr.l.
i>57, avenue de la faïencerie, L-1510 Luxembourg
<i>Expert Comptable, Réviseur d'Entreprise
i>Signature
Référence de publication: 2008108659/601/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2008, réf. LSO-CS09321. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Profilex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 4A, Z.I. in den Allern.
R.C.S. Luxembourg B 103.008.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 6 juin 2008 que:
1 - La société EAST-WEST TRADING COMPANY S.à r.l., ayant son siège social à 50, Esplanade, L-9227 DIEKIRCH.
a été réélue aux fonctions d'administrateur de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale
des actionnaires qui se tiendra en 2009.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 6 juin 2008.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
50, Esplanade, L-9227 Diekirch
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008108866/2602/21.
Enregistré à Diekirch, le 1
er
août 2008, réf. DSO-CT00015. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080125739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
104839
TS Nautilus (Hahnstrasse) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9.022.250,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 121.560.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2008.
ATOZ
Aerogolf Center, Bloc B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2008108686/4170/17.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09348. - Reçu 40,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080125388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
TS Nautilus (Liebknechtstrasse) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.328.200,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 121.561.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2008.
ATOZ
Aerogolf Center, Bloc B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2008108691/4170/17.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09342. - Reçu 38,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
International Financial Trading Company B.L.T. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 61.901.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 10 juillet 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, statuant en matière
commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société INTERNATIONAL FI-
NANCIAL TRADING COMPANY B.L.T. S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 11 A, boulevard Joseph II, de fait
inconnue à cette adresse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 13 août 2008.
Pour extrait conforme
Christophe ANTINORI
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2008109004/1384/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT09716. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080126531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
104840
Jordan French Investment Group S.A.H., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 43.267.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 10 juillet 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, statuant en matière
commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société JORDAN FRENCH IN-
VESTMENT GROUP S.A.H., anciennement EUROSTEP INVEST S.A.H., anciennement FI.NI. VAL S.A.H. Société de
Participations Financières, dont le siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII a été dénoncé en date du 18 août
2000 par la Fiduciaire SASSEL & ZIMMER S.C.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 13 août 2008.
Pour extrait conforme
Christophe ANTINORI
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2008109005/1384/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT09718. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080126534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
TS Nautilus (Friedrichstrasse) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.608.225,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 121.554.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2008.
ATOZ
Aerogolf Center, Bloc B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2008108697/4170/17.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09335. - Reçu 38,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Pestana Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 17.673.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société en date du 4 juillet 2008i>
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
août 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008108844/631/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08668. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
104841
PHD Overseas Limited, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 26.025.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société en date du 4 juillet 2008i>
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
août 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008108840/631/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08629. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080125737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Quanlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 41.592.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société en date du 4 juillet 2008i>
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
août 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008108839/631/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08631. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Terre Naturelle (Holding) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 24.079.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 10 juillet 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, statuant en matière
commerciale, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société TERRE NATURELLE
(HOLDING) S.A., anciennement NATURLAND HOLDING S.A., avec siège social à L-6794 Grevenmacher, 12, route du
Vin, de fait inconnue à cette adresse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 13 août 2008.
Pour extrait conforme
Christophe ANTINORI
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2008109006/1384/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT09721. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080126542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
104842
Iris Garden Finance, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 57.851.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des Associés tenue le 1 i>
<i>eri>
<i> août 2008i>
Les mandats des Gérants et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat des Gérants de Messieurs Noël DIDIER, Joseph
WINANDY, Jean-Pierre WESPI et Vittorio RIPA DI MEANA pour une période d'un an.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de V.O. Consulting
Lux S.A. pour une période d'un an.
Les mandats des Gérants et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.
Extrait sincère et conforme
Noël DIDIER
<i>Géranti>
Référence de publication: 2008109052/1172/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09109. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080126305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
Lehwood Ventures S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 109.954.
Par résolutions signées en date du 29 mai 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de David Scott Broderick, avec adresse professionnelle au 399, Park Avenue, 8th Floor,
NY 10022 New York, Etats-Unis, de son mandat de gérant avec effet immédiat.
- Nomination de Richard Siu avec adresse professionnelle au 399, Park Avenue, NY 10022 New York, Etats-Unis, au
mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008109019/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08705. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080126728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
LBS Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 109.955.
Par résolutions signées en date du 29 mai 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de David Scott Broderick, avec adresse professionnelle au 399, Park Avenue, 8th Floor,
NY 10022 New York, Etats-Unis, de son mandat de gérant avec effet immédiat.
- Nomination de Richard Siu avec adresse professionnelle au 399, Park Avenue, NY 10022 New York, Etats-Unis, au
mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008109020/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08703. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080126723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
104843
Burdaras Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 108.658.
Il convient de noter qu'au cours du mois de septembre 2005, l'associé unique BURDARAS HF, immatriculé auprès du
registre de commerce d'Islande sous le numéro 510169 a changé de nom pour devenir:
STRAUMUR-BURDARAS INVESTMENT BANK HF, Société Anonyme, dont le siège social est au 25 Borgartuni, -105
Reykjavik — ICELAND, immatriculée auprès du registre de commerce d'Islande sous le numéro 701086 1399.
Luxembourg, le 4 août 2008.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2008109048/802/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT06033. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080126412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
Buderus Giesserei Holding S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.000.000,00.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 44, Esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 111.078.
Par résolutions signées en date du 15 mai 2008, les associés ont pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Hanno Schmidt-Gothan, avec adresse au 24, Taimerhofstrasse, 81927 Munich, Alle-
magne, de son mandat de gérant, avec au 15 février 2008.
- acceptation de la démission de Rolf Glessing, avec adresse au 26, Schelmenweg, 89171 Illerkirchberg, Allemagne, de
son mandat de gérant, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008109022/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08695. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080126689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
Elocap Lux S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-4802 Rodange, Site du PED.
R.C.S. Luxembourg B 119.842.
Il résulte du procès-verbal de rassemblée générale ordinaire de la Société du 16 avril 2008 que celle-ci:
- révoque Madame Yael Wilson, née le 21 novembre 1974 en Israël et demeurant à 60972 Kibbutz Yakum (Israël), en
tant que membre du conseil d'administration avec effet immédiat;
- nomme Monsieur Moshe Bar Haim, né le 9 août 1950 à Bucarest (Roumanie) et demeurant à 49945 Neve-Yarak
(Israël), 13, Habrosh st., comme membre du conseil d'administration de la Société, ceci avec effet immédiat et jusqu'à
l'assemblée générale annuelle de la Société se déroulant en l'année 2014.
Pour publication
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008109057/5499/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT08977. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080126033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
104844
Centuria Holding Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 122.806.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique tenue au siège social en date du 15 juillet 2008i>
L'Assemblée Générale a décidé d'accepter la démission de:
- Mme Claudia Schweich, Manager, née le 1
er
août 1979 à Arlon (Belgique), avec adresse professionnelle au 14, rue
du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, en sa qualité de gérant;
L'Assemblée Générale a décidé de nommer un nouveau gérant pour une durée indéterminée:
- M. Thierry Grosjean, Manager, né le 3 août 1975 à Metz (France), avec adresse professionnelle au 14, rue du Marché
aux Herbes, L-1728 Luxembourg, en remplacement de Mme Claudia Schweich, gérant démissionnaire;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2008.
Signature
<i>Un mandanti>
Référence de publication: 2008109069/6654/20.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT04001. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080126620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
Investment Lux Partners, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 98.363.
Constituée en date du 5 décembre 2003 par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, acte publié
au Mémorial C no 197 du 17 février 2004. Les statuts ont été modifiés par acte devant le même notaire en date du
15 novembre 2005, publié au Mémorial C n
o
670 du 1
er
avril 2006.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour INVESTMENT LUX PARTNERS
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008108939/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08481. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080126234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
Flamierge Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 25.315.
Constituée par-devant M
e
Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1986, acte
publié au Mémorial C no 77 du 31 mars 1987, modifiée pour la dernière fois par-devant le même notaire en date
du 21 mars 2000, acte publié au Mémorial C no 553 du 3 août 2000.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FLAMIERGE FINANCE S.A.
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008108940/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08483. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080126231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
104845
Project Shift (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 114.742.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
en date du 22 février 2006, acte publié au Mémorial C no 1026 du 26 mai 2006. Les statuts ont été modifiés par-
devant le même notaire en date du 25 janvier 2007, acte publié au Mémorial C no 599 du 13 avril 2007,
Le bilan consolidé au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PROJECT SHIFT (LUXEMBOURG) S.A.
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008108941/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08485. - Reçu 38,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080126230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
GMT Spanext S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 107.627.
Constituée par-devant M
e
Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du
8 avril 2005, acte publié au Mémorial C n
o
907 du 16 septembre 2005, les statuts ont été modifiés par-devant le
même notaire en date du 26 avril 2005, acte publié au Mémorial C n
o
955 du 28 septembre 2005.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GMT Spanext S.à r.l.
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008108943/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08477. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080126240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
Apollo Portland EU II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 262.400,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 108.193.
Le gérant B de la Société, John Ruane a récemment changé d'adresse comme suit:
Du 127, Sloane Street, Liscartan House, 5
e
étage, SW1X9BA Londres, GB
vers le 1, Knightsbridge, SW1X7LX Londres, Grande-Bretagne
L'associé de la Société, Apollo European Real Estate Fund II (Euro) LP, a récemment changé d'adresse comme suit:
Du 88, Wood Street, EC2V7AJ London, GB
vers le 2, Manhattanville Road, Purchase, NY 10577, Etats-Unis
L'associé de la Société, Grimsby Investments S.à r.l., a récemment changé d'adresse comme suit:
Du 9, rue Schiller, L-2519, Luxembourg
104846
Vers le 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
Luxembourg, le 4 juin 2008.
Anne Delord.
Référence de publication: 2008109179/9168/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT09725. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080126070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
Liam Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 124.814.
Les associés de la Société, Apollo European Real Estate III Cooperatief U.A. et Apollo European Real Estate III (EU)
Cooperatief U.A., ont récemment changé d'adresse et sont désormais domiciliés au:
1, Locatellikade Parnassustoren, 1076 AZ Amsterdam, Pays-Bas.
Le gérant de la Société, Andrea Orlandi, a récemment changé d'adresse et est désormais domicilié au:
1, Knightsbridge, SW1X7LX Londres, Grande-Bretagne.
Il y a lieu de noter que le gérant de la Société, Priscille Fourneaux, a été nommée «Gérant A» et non pas «Gérant» à
compter du 1
er
avril 2008.
Luxembourg, le 9 juin 2008.
Priscille Fourneaux
<i>Manager Ai>
Référence de publication: 2008109186/9168/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT09729. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080126106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
Selwyn S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 93.409.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée des actionnaires de la Société en date du 4 juillet 2008i>
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
Luxembourg, le 1
er
août 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008108817/631/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08368. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
ASK Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 99.111.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société en date du 4 juillet 2008i>
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
104847
Luxembourg, le 1
er
août 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008108819/631/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07477. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Tempyr S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 123.803.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société en date du 4 juillet 2008i>
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
Luxembourg, le 1
er
août 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008108812/631/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07486. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Arcenciel Financial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 110.717.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le gérant unique de la Société en date du 4 juillet 2008i>
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
Luxembourg, le 1
er
août 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008108818/631/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07828. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Palazzo Due Funding & Co S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 127.190.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé commandité de la Société en date du 4 juillet 2008i>
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
104848
Luxembourg, le 1
er
août 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008108820/631/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07349. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Pegasus Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 8.750,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 129.904.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le gérant unique de la Société en date du 4 juillet 2008i>
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
Luxembourg, le 1
er
août 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008108821/631/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07479. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Plumeria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 119.551.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le gérant unique de la Société en date du 4 juillet 2008i>
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
Luxembourg, le 1
er
août 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008108822/631/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07472. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Polish Purple Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.800.000,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 135.020.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le gérant unique de la Société en date du 4 juillet 2008i>
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
104849
Luxembourg, le 1
er
août 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008108823/631/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07440. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Reuters S.A., Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 79.493.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 31 juillet
2008, que:
- Monsieur Venkatesh Gopalan, né le 17 juillet 1971 à Madras (Inde), et demeurant au 15/2, rue du Nant, 1207 Genève,
Suisse, a été nommé comme administrateur de la Société avec pouvoir de signature individuelle.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date
du 31 juillet 2008, que:
- Monsieur Roy Lowrance a démissionné de sa fonction de membre du conseil d'administration; et
- Monsieur Michael Peace a démissionné de sa fonction de membre du conseil d'administration.
Luxembourg, le 8 août 2008.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008108979/1092/22.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08619. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080126370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2008.
Lebaras Holding S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 140.888.
STATUTES
In the year two thousand eight, on the thirtieth day of July.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Lebaras B.V./S.àr.l., a company incorporated under the laws of Netherlands, having its statutory seat in the Netherlands
and its principal office and establishment at 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette, Luxembourg (the Sole Share-
holder),
here represented by Mr Albert Seen, acting in his capacity as manager of the Sole Shareholder, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on June 17, 2008.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "Lebaras Holding S.àr.l." (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).
104850
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established Larochette, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within the municipality by a resolution of the board of managers of the Company (the Board). The registered office may
be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully
paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
104851
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by A managers and B managers appointed by a resolution of the shareholders, which
sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the Board.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two managers, at the place indicated in the convening notice which, in
principle, is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions
of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be represented by the single signature of any A manager of the Company with respect to
transactions not exceeding a commitment of five thousand euro (EUR 5,000) and by the joint signature of any A manager
and any B manager of the Company for transactions in excess of five thousand euro (EUR 5,000).
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to
be read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made
by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
104852
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by
law.
14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the
term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be reappointed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the
date of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
104853
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half of the
shareholders holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need
not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise
decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the
Company.
16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Re-
solutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which
taken together constitute one and the same document.
17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to
any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2008.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon, Lebaras B.V./S.àr.l., prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to the
whole share capital of the Company and to have fully paid up all five hundred (500) shares by contribution in cash, so that
the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately two thousand three hundred (2,300.-) euro.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire sub-
scribed capital, have passed the following resolutions:
1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
<i>- A Managers:i>
(a) Mr Albert Seen, residing at 17, Leedebach, L-7618 Larochette, Luxembourg, and
(b) SuxesKey S.A., a Luxembourg public limited company (société anonyme) having its registered office at 10-12, rue
de Medernach, L-7619 Larochette, Luxembourg.
<i>- B Manager:i>
(a) Mr J.B. Meulman, a Dutch citizen, born in Veendam, the Netherlands, on June 1st, 1967, residing at Ter Borcht 179,
2930 Brasschaat, Belgium.
2. The registered office of the Company is set at 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette, Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned
notary.
104854
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendacht, am dreissigsten des Monats Juli.
Vor Uns, Maître Schaeffer, Notar mit Amtwohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Lebaras B.V./S.à r.l., gegründet gemäß dem Recht der Niederlandae, mit Gesellschaftssitz in den Niederlanden und
Hauptgeschäftsstelle und Niederlassung in 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette, Großherzogtum Luxemburg
(der alleinige Gesellschafter),
vertreten durch Herrn Albert Seen, Geschäftsführer des alleinigen Gesellschafters, wohnhaft in Luxemburg, kraft einer
Vollmacht, die am 17. Juni 2008 ausgestellt wurde.
Die genannte Vollmacht bleibt, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur"
unterzeichnet wurde, dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung beigebogen.
Der Komparent, wie vorstehend vertreten, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée"), die hiermit gegründet wird, wie folgt zu dokumentieren:
I. Bezeichnung - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Bezeichnung. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") unter der
Bezeichnung "Lebaras Holding S.à r.l." (nachstehend die Gesellschaft) gegründet, die dem Luxemburger Recht unterliegt,
insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in letzter Fassung (nachstehend das Gesetz),
sowie der vorliegenden Satzung (nachstehend die Satzung).
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Larochette, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch einen Beschluss der Ge-
schäftsführer der Gesellschaft (nachstehend der Geschäftsführungsrat) an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde
verlegt werden. Des weiteren kann der Sitz durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschaf-
terversammlung gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, an einen anderen Ort im
Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
2.2. Zweigniederlassungen, Filialen und andere Geschäftsräume können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat der
Gesellschaft beschließen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen
oder bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft
oder die Kommunikation zwischen der Gesellschaft und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen würden, kann
der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse. Der-
artige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der vorüber-
gehenden Sitzverlegung des Gesellschaftssitzes eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftsgegenstand.
3.1. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jeder Form an Luxemburger oder ausländischen
Gesellschaften oder Unternehmen, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien,
Anteile und andere Wertpapiere, Rentenwerte, Anleihen, Geldmarkteinlagen und andere Schuldtitel aller Art durch
Zeichnung, Kauf oder Tausch oder sonst wie erwerben, und im Allgemeinen alle Wertschriften und Finanzinstrumente,
die von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Sie kann an der Gründung,
Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht aller Gesellschaften oder Unternehmen teilnehmen. Des weiteren kann sie in den
Erwerb und in die Verwaltung eines Bestands von Patenten oder anderen geistigen Eigentumsrechten jeder Art oder
jeden Ursprungs investieren.
3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeder Art aufnehmen, außer auf dem Wege von öffentlichen Angeboten. Sie kann
jedoch nur über Privatplatzierung, Schuldscheine, Rentenwerte, sowie jede Art von Schuldtiteln und/oder Rentenwerte
ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel verleihen, einschließlich, ohne Begrenzung, die Erlöse aus Kreditverbindlich-
keiten und/oder Emissionen von Schuld- oder Dividendenpapieren an ihre Zweigunternehmen, Die Gesellschaft kann in
Bezug auf ihr gesamtes oder teilweises Vermögen ebenfalls Sicherheiten leisten; sie kann verpfänden, übertragen, belasten
oder sonst wie Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und Vereinbarungen und/oder
den Verpflichtungen und Vereinbarungen jeder anderen Gesellschaft nachzukommen, und sie im Allgemeinen zu eigenem
Nutzen und/oder zum Nutzen jeder anderen Gesellschaft oder Person abzusichern. Um jeden Zweifel zu vermeiden, darf
die Gesellschaft keine geregelten Aktivitäten des Finanzsektors ohne die vorgeschriebenen Genehmigungen vornehmen.
3.3. Mit dem Ziel einer effizienten Verwaltung kann sich die Gesellschaft im Allgemeinen in Bezug auf ihre Anlagen aller
Techniken und Instrumente bedienen, einschließlich der Techniken und Instrumente, die dazu konzipiert sind, die Ge-
sellschaft gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.
3.4. Die Gesellschaft darf alle Handels-, Finanz- und Gewerbetätigkeiten und alle Transaktionen auf unbeweglichem
oder beweglichem Eigentum ausführen, die dazu bestimmt sind, ihren Gesellschaftszweck zu fördern oder die sich auf
ihren Gesellschaftszweck beziehen.
104855
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
4.2. Die Gesellschaft kann wegen Ableben, Aufhebung von Bürgerrechten, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs
oder ein vergleichbares Ereignis, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen, nicht aufgelöst werden.
II. Stammkapital - Gesellschaftsanteile
Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünfhundert
(500) Gesellschaftsanteile in Form von Namenspapieren mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR
25,-); alle Gesellschaftsanteile sind gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrmals durch Beschluss durch die Gesellschafterver-
sammlung gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Eigentümer per Gesellschafts-
anteil an.
6.2. Die Gesellschaftsanteile sind unter Gesellschaftern frei übertragbar.
Im Falle eines alleinigen Gesellschafters können die Gesellschaftsanteile frei an Dritte übertragen werden.
Falls die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, erfordert die Übertragung von Gesellschaftsanteilen (inter
vivos) an Dritte die Einwilligung der Geschäftsführer, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals vertreten.
Die Übertragung eines Gesellschaftsanteils bindet die Gesellschaft oder Dritte nur, wenn eine Mitteilung an die Ge-
sellschaft oder einer Billigung durch die Gesellschaft, gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches (Code civil)
erfolgt ist.
6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschaftsanteilsregister aufbewahrt, das von jedem Gesellschafter auf Ver-
langen eingesehen werden kann.
6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile zurückkaufen, unter der Bedingung, dass die Gesellschaft
zu diesem Zweck genügend ausschüttbare Rücklagen besitzt oder falls die Rücknahme aus einer Herabsetzung des
Stammkapitals stammt.
III. Geschäftsführung - Vertretung
Art. 7. Ernennung und Abberufung der Geschäftsführer.
7.1. Die Gesellschaft wird von A-Geschäftsführern und B-Geschäftsführern geleitet, die durch einen Beschluss der
Gesellschafter ernannt werden, die ihre Amtszeit festlegen. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein.
7.2. Die Geschäftsführer können jederzeit (ohne jeden Grund) durch einen Gesellschafterbeschluss abgesetzt werden.
Art. 8. Geschäftsführungsrat. Falls mehrere Geschäftsführer ernannt werden, bilden sie den Geschäftsführungsrat.
8.1. Vollmachten des Geschäftsführungsrates
(i) Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschafter vor-
behalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführungsrates, der befugt ist, alle Handlungen und
Geschäfte zu tätigen, die dem Gesellschaftszweck dienen.
(i) Die Geschäftsführer können besondere und begrenzte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder
mehreren Bevollmächtigten erteilen.
8.2. Vorgehensweise
(i) Der Geschäftsführungsrat tritt auf Antrag von zwei Geschäftsführern an dem in der Einberufungseinladung be-
zeichneten Ort zusammen, im Prinzip in Luxemburg.
(ii) Schriftliche Mitteilung über jede Geschäftsführungsratssitzung ergeht mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor
dem Tag der Sitzung an alle Geschäftsführer, außer in dringenden Fällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände in der
Einberufungseinladung für die Geschäftsführungsratssitzung anzugeben ist.
(iii) Eine Einberufungseinladung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft
in der Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Sitzung ordnungsgemäß informiert worden zu sein
und volle Kenntnis von der Tagesordnung zu besitzen. Es kann ebenfalls seitens eines Geschäftsführers vor oder nach
einer Sitzung auf eine Einberufungseinladung verzichtet werden. Separate schriftliche Mitteilungen sind nicht notwendig
für Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten abhalten werden, die vorab in einem Terminplan, der zuvor vom Geschäfts-
führungsrat angenommen wurde, festgelegt wurden.
(iv) Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann an jeder Geschäftsführungsratssitzung teilnehmen, indem er einen
anderen Geschäftsführer der Gesellschaft zu seinem Vertreter bestellt.
(v) Der Geschäftsführungsrat kann nur wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwe-
send oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden wirksam mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer, Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden in Pro-
tokollen festgehalten, die von allen in der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werde,
104856
oder falls kein Vorsitzender des Geschäftsführungsrates ernannt wurde, von allen anwesenden oder vertretenen Ge-
schäftsführern.
(vi) Jeder Geschäftsführer kann über Telefon oder Videokonferenz oder durch jedwedes andere vergleichbare Kom-
munikationsmittel an einer Geschäftsführungsratssitzung teilnehmen, das allen an der Sitzung teilnehmenden Personen
ermöglicht, einander zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel ist einer
persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleichgestellt.
(vii) Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern (nachstehend die Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer) un-
terzeichnet werden sind ebenso gültig und verbindlich wie Beschlüsse, die in einer ordentlich einberufenen und
abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst wurden, und das Datum dieser Beschlüsse ist dasjenige der letzten
Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird in Bezug auf Transaktionen, die eine Verpflichtung von fünftausend Euro (EUR 5.000,-) nicht
übersteigen, mit der einzelnen Unterschrift eines A-Geschäftsführers der Gesellschaft vertreten, und mit den gemein-
schaftlichen Unterschriften eines A-Geschäftsführers und eines B-Geschäftsführers der Gesellschaft in Bezug auf Trans-
aktionen, die den Betrag von fünftausend Euro (EUR 5.000,-) übersteigen.
(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift jeder Person verpflichtet, an welche
besondere Vollmachten übertragen wurden.
Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.
9.1. Wird die Gesellschaft von einem alleinigen Geschäftsführer geführt, so ist es angemessen, jedweden Verweis,
welcher sich in diesen Satzungen auf den Geschäftsführungsrat oder auf die Geschäftsführer bezieht, als Verweis auf den
alleinigen Geschäftsführer anzusehen.
9.2. Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift des alleinigen
Geschäftsführers verpflichtet.
9.3. Die Gesellschaft ist außerdem gegenüber Dritten durch die Unterschrift jeder Person, der eine derartige Vollmacht
zur Unterzeichnung erteilt wurde, verpflichtet.
Art. 10. Haftung der Geschäftsführer.
10.1 Die Geschäftsführer sind durch ihr Amt nicht persönlich haftbar für Verpflichtungen, die sie im Namen der
Gesellschaft wirksam eingegangen haben, unter der Bedingung, dass diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit vor-
liegender Satzung sowie den anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes stehen.
IV. Gesellschafter
Art. 11. Gesellschafterversammlung und Umlaufbeschlüsse.
11.1. Befugnisse und Stimmrechte
(i) Gesellschafterbeschlüsse sind entweder in Gesellschafterversammlungen (nachstehend die Gesellschafterversamm-
lungen) oder aufgrund schriftlicher Beratungen über Umlaufverfahren (nachstehend die Umlaufbeschlüsse der Gesell-
schafter) zu fassen.
(ii) Falls Beschlüsse als Umlaufbeschlüsse angenommen werden, soll der Text an alle Gesellschafter, in Übereinstim-
mung mit den Satzungen, gesandt werden. Umlaufbeschlüsse, welche von allen Gesellschaftern unterschrieben wurden,
sind ebenso wirksam und verbindlich, wie Beschlüsse die in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Ge-
sellschafterversammlung gefasst wurden und die das Datum der letzten Unterschrift tragen.
(iii) Jeder Gesellschaftsanteil ist zu einer Stimme (1) berechtigt.
11.2. Form - Beschlussfähigkeit - Mehrheit - Abstimmungsverfahren
(i) Die Gesellschafter werden zur Gesellschafterversammlung einberufen oder schriftlich informiert auf Initiative einer
der Geschäftsführer oder von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals besitzen.
(ii) Eine schriftliche Mitteilung über jede Gesellschafterversammlung ergeht mindestens acht (8) Tage vor dem Tag der
Gesellschafterversammlung an alle Gesellschafter, außer in einem Notfall, in welchem Fall die Art dieser Umstände im
Einberufungsschreiben für die Gesellschafterversammlung anzugeben ist.
(iii) Gesellschafterversammlungen finden an Ort und Zeit statt, die in den Einberufungsschreiben festgelegt wurden.
(iv) Falls alle Gesellschafter der Gesellschaft in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und
erklären, über die Gesellschafterversammlung rechtmäßig informiert worden zu sein und die Tagesordnung zu kennen,
findet die Gesellschafterversammlung ohne Einberufungsschreiben statt.
(v) Jeder Gesellschafter kann mittels einer schriftlichen Vollmacht eine Person zu seinem Vertreter bestellen, die ihn
bei einer Gesellschafterversammlung vertritt. Diese Person muss kein Gesellschafter sein.
(vi) Beschlüsse welche in einer Gesellschafterversammlung oder durch Umlaufbeschlüsse von den Gesellschaftern
genommen werden, werden wirksam gefasst durch die Zustimmung von Gesellschaftern welche mehr als die Hälfte des
Stammkapitals besitzen Wenn diese Mehrheit auf der ersten Gesellschafterversammlung oder in den ersten Umlaufbe-
schlüssen nicht erreicht wird, werden die Gesellschafter mittels eingeschriebenen Briefes zu einer zweiten Gesellschaf-
terversammlung einberufen oder ein zweites Mal konsultiert und die Beschlüsse werden bei dieser Gesellschafterver-
104857
sammlung oder bei diesen Umlaufbeschlüssen mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom
Anteil des vertretenen Stammkapital.
(vii) Die Satzung kann abgeändert werden mit der Zustimmung einer Mehrheit (in Anzahl) der Gesellschafter welche
wenigstens dreiviertel (3/4) des Stammkapitals besitzen.
(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft sowie die Erhöhung der Verpflichtungen der Gesellschafter
verlangt die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
Art. 12. Alleiniger Gesellschafter.
12.1. Ist die Anzahl der Gesellschafter auf einen (1) reduziert, übt der alleinige Gesellschafter alle Befugnisse aus, welche
vom Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
12.2. Jeder, in der Satzung vorgesehenen Verweis auf die Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung oder den
Umlaufbeschlüssen, ist auf Referenz zu solchem alleinigen Gesellschafter oder dessen Beschlüsse wie passend zu deuten.
12.3. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden protokolliert oder schriftlich aufgenommen.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Beaufsichtigung
Art. 13. Geschäftsverteilung und Gewinnverteilung.
13.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember.
13.2. Der Geschäftsführungsrat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten, sowie ein Inventar-
verzeichnis, das den Wert der Aktiva und Passiva der Gesellschaft angibt, erstellen, mit einem Anhang, der alle
Verpflichtungen der Gesellschaft und die Verbindlichkeiten des/der Geschäftsführer(s) und der Gesellschafter gegenüber
der Gesellschaft zusammenfasst.
13.3. Jeder Gesellschafter kann das oben genannte Inventarverzeichnis und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
13.4. Die Bilanz und das Gewinn- und Verlustkonto werden den Gesellschaftern innerhalb der ersten sechs Monate,
nach dem Ende des Geschäftsjahres, während der jährlichen Gesellschafterversammlung oder mittels Umlaufbeschluss,
genehmigt.
Art. 14. Rechnungskommissare.
14.1. Die Aktivitäten der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rechnungskommissaren ("réviseurs d'ent-
reprises") beaufsichtigt, falls dies vom Gesetz vorgeschrieben wird.
14.2. Die Gesellschafter ernennen gegebenenfalls die Rechnungskommissare und bestimmen deren Anzahl, Vergütung
und deren Amtszeit, die sechs (6) Jahre nicht übersteigen darf. Die Rechnungskommissare können wieder ernannt werden.
Art. 15. Gewinnverteilung.
15.1. Ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft wird der gesetzlichen
Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Stammkapital der Gesellschaft erreicht hat.
15.2. Die Gesellschafter können nach freiem Ermessen über den Überschuss verfügen. Insbesondere können sie den
Gewinn zu einer Dividendenzahlung freigeben oder sie der Rücklage zuweisen oder auch als Gewinn vortragen.
15.3. Zwischendividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) Zwischenkonten werden vom dem Geschäftsführungsrat erstellt;
(ii) diese Zwischenkonten müssen genügend Gewinne und andere Reserven (eingeschlossen den Emissionsprämien),
welche zur Ausschüttung verfügbar sind, aufweisen; dies unter dem Vorbehalt, dass der zu ausschüttende Betrag, die
Gewinne welche seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, für welches die jährlichen Konten angenommen wurden, falls
vorhanden, erhöht durch die vertagte Profite und die auschüttbaren Reserven, und vermindert durch vertagten Verluste
und Beträge der vorgeschriebenen Reserve zuzuteilen sind, nicht überschreiten;
(iii) die Entscheidung zur Zahlung von Zwischendividenden wird von den Gesellschaftern innerhalb von zwei (2) Mo-
naten ab dem Datum der Erstellung der Zwischenkonten getroffen;
(iv) eine Zusicherung wurde gegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind; und
(v) falls zu zahlenden Zwischendividenden die ausschüttbaren Gewinne am Ende des Geschäftsjahres übersteigen,
haben die Gesellschafter den Überschuss an die Gesellschaft zurückzuzahlen.
VI. Auflösung - Liquidation
16.1. Durch einen Beschluss der Gesellschafter, welcher von der Hälfte der Gesellschafter, die über drei viertel des
Stammkapitals verfügen, angenommen wird, kann die Gesellschaft zu jeder Zeit aufgelöst werden. Im Falle einer Auflösung
der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, die keine Gesellschafter sein
müssen, und die durch einen Beschluss der Gesellschafter ernannt werden, die ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung
bestimmt. Vorbehaltlich eines abweichenden Beschlusses der Gesellschafter haben die Liquidatoren die umfassendsten
Befugnisse für die Veräußerung der Vermögenswerte und die Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft.
16.2. Der Überschuss nach der Veräußerung der Vermögenswerte und Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft
wird an die Gesellschafter im Verhältnis zu der Anzahl der Gesellschaftsanteile, die jeder Gesellschafter in der Gesellschaft
hält, ausgezahlt.
104858
VII. Allgemeine Bestimmung
17.1. Die Verfassung und der Verzicht von Beschlüssen und Mitteilungen und die Geschäftsführerbeschlüsse, sowie die
Gesellschafterbeschlüsse sind bindend, sei es im Original, als Teigramm, als Faksimile oder als Email, sowie in jeder anderen
Form der elektronischen Kommunikation.
17.2. Vollmachten werden wie vorstehend vergeben. Vollmachten in Verbindung mit den Gesellschafterversammlungen
können von einem Geschäftsführer gewährt werden, entsprechend der Bedingungen, die vom Geschäftsführungsrat fest-
gelegt wurden.
17.3. Unterschriften können handschriftlich sowie elektronisch erstellt werden, vorausgesetzt dass sie allen legalen
Anforderungen gerecht werden, die handschriftlichen Unterschriften gleichkommen. Unterschriften der Geschäftsfüh-
rerbeschlüsse oder der Gesellschafterbeschlüsse, je nach Lage, sind einem Original oder verschiedenen Duplikate
desselben Schriftstücks beigefügt, die alle zusammen ein und dasselbe Schriftstück ausmachen.
17.4. Alle Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich von der Satzung geregelt werden, werden gemäß Gesetz bestimmt
und nach Maßgabe einer nicht abbedingten Bestimmung des Gesetzes, gemäß einer Vereinbarung, die von den Gesell-
schaftern zeitweilig eingegangen wird.
<i>Transitorische Bestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2008.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Daraufhin erklärt Lebaras B.V./S.à r.l., genannt und vertreten wie vorstehend angegeben, fünfhundert (500) Gesell-
schaftsanteile zu zeichnen und diese Gesellschaftsanteile vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von zwölftausend-
fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) einzuzahlen, wie dem unterzeichneten Notar bescheinigt wurde, der dies ausdrücklich
bestätigt.
Der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) steht somit der Gesellschaft zur Verfügung, wie dem
unterzeichneten Notar bescheinigt wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Auslagen jeder Art, die von der Gesellschaft wegen ihrer Gründung zu tragen
sind, werden auf ungefähr zweitausenddreihundert (2.300,-) Euro geschätzt.
<i>Beschlüsse der Gesellschafteri>
Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter der Gesellschaft, die das gesamt gezeichnete
Stammkapital vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
<i>- A - Geschäftsführer:i>
(a) Herr Albert Seen, wohnhaft in 17, Leedebach, L-7618 Luxemburg, und
(b) SuxesKey S.A., eine Luxemburger Aktiengesellschaft ("société anonyme") mit Sitz in 10-12, rue de Medernach,
L-7619 Larochette, Luxemburg.
<i>- B - Geschäftsführer:i>
(a) Herr J.B. Meulman, niederländischer Staatsangehöriger, geboren am 1. Juni 1967 in Veendam, Niederlande, wohnhaft
in Ter Borcht, 179, 2930 Brasschaat, Belgien.
2. Der Sitz der Gesellschaft ist in 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette, Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf
Ersuchen der vorstehend bezeichneten Erschienenen in englischer Sprache abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen
Version, und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Version maß-
geblich ist.
Worüber die vorliegende Urkunde errichtet wurde in Luxemburg, am zu Beginn dieses Dokuments bezeichneten Tag.
Nachdem das Dokument der Erschienenen vorgelesen wurde, haben diese die vorliegende Urkunde gemeinsam mit
dem Notar unterzeichnet.
Signé: A. Seen et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 5 août 2008, LAC/2008/32657. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents (EUR
0,5% = 62,50).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
104859
Luxembourg, le 18 août 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008106847/5770/518.
(080123622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.
Poseidon JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CEREP Investment Five S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 102.535.
In the year two thousand and four, on the fourth of November.
Before the undersigned Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Poseidon JV S.à r.l, having its registered office at
30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Luxembourg Notary Joseph ELVINGER,
prenamed, dated 6 July 2004, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
RCB 100.535 and published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Memorial C"), number
1092 dated 28 October 2004, page 52 391. The name has been changed pursuant to a notarial deed of the Luxembourg
Notary Joseph Elvinger dated 13 October 2004 not yet published in the Mémorial C. The meeting is presided by Mr
Hubert JANSSEN, jurist, residing professionally in Luxembourg, who appoints as secretary Mr Patrick VAN HEES, jurist,
residing professionally in Luxembourg
The meeting elects as scrutineer Mr Patrick VAN HEES, prenamed.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the
proxies "ne varietur" will be registered with this deed.
II. It appears from the attendance list, that the two hundred and fifty (250) Shares, representing the entirety of the
statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly. The Shareholders declare having
been informed on the agenda of the meeting on beforehand and waived all convening requirements and formalities. The
meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting.
III. The agenda of the meeting is the following:
1) Complete amendment and restatement of the articles of association of the Company;
2) Acceptation of the resignation and discharge of liability of the sole Manager of the Company;
3) Decision to appoints the following persons as new Managers of the Company (hereafter the "New Managers"):
- Mr Oussama Daher, European Investment Manager, residing at 1, rue Louvigny L-1946 Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg), Luxembourg,
- Mr Christopher Finn, Managing Director, residing at 19 Randolph Crescent, London, W9 1DP, UK,
- Mr Robert Konigsberg, Principal, residing at 7602 Brittany Parc Ct. Falls Church, VA 22043, USA.
4) Decision to set the duration of the mandate of all the New Managers to six (6) years, ending at the annual general
meeting of shareholders to be held in 2010;
5) Miscellaneous;
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously and in compliance with Article 14 of the articles
of incorporation of the Company:
<i>First resolutioni>
The Shareholders unanimously resolve to entirely amend and restate the Articles as follows:
1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name "Poseidon JV S.à r.l.",
which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law
of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of
incorporation (hereafter the «Articles»).
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3 However, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company
within the City of Luxembourg.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
104860
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole
Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers.
3. Object.
3.1 The Company's object is to acquire and hold interests in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign
entities, by way of, among others, the subscription or acquisition of any securities and rights through participation, con-
tribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or financial debt instruments in any form
whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
3.2 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participa-
tions in subsidiaries of the Company owning such investments.
3.3 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries
or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect
shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the
"Connected Companies" and each as a "Connected Company").
3.4 For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such
other company directly or indirectly owns, is own by, is in control of, is controlled by, or is under common control with,
or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other
fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or
indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of
the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or
otherwise.
3.5 The Company may in particular enter into the following transactions:
3.5.1 to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity instruments, the use of
financial derivatives or otherwise;
3.5.2 to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
3.5.3 to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods,
for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any
director, manager or other agent of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of any applicable
law provision; and
3.5.4 enter into any agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, mar-
keting agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements, cooperation agreement
and other services contracts, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial de-
rivative agreements in relation to its object;
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
3.6 In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions
and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly
or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object
in all areas described above, however without taking advantage of specific tax regime organised by the law of July 31, 1929
on holding companies.
4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II.- Capital, Shares
5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by two hundred fifty
(250) shares. Each Share has a nominal value of fifty Euro (€ 50.-) each (hereafter referred to as the "Shares"). The holders
of the Shares are together referred to as the "Shareholders".
5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
Share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).
5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 Any Shareholder shall have the right to subscribe to any future capital increase made by the Company in proportion
of the number of Shares it owns at the time of the Shareholders meeting deciding on the capital increase.
6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted
per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
104861
7. Transfer of shares.
7.1 Any transfer of Shares to a third party (other than a Person under the Control of a Shareholder) shall require the
prior approval of the Board of Managers. For the purposes of this article, "Person" means an individual, partnership,
corporation, association, trust, joint venture, unincorporated organization, limited liability company, and any government,
governmental department, or agency or political subdivision and "Control" means the possession, directly or indirectly,
of the power to direct or cause the direction of the management and policies of a Person, whether through the ownership
of voting securities, by contract or otherwise.
7.2 In case of plurality of Shareholders, any transfer of Shares to any third party (including to a Person under the
Control of a Shareholder) by way of sale, assignment, pledge, security interest or any other form, must be authorised by
the general meeting of the shareholders who represent at least three quarters of the capital of the Company in accordance
with article 189 of the Law.
7.3 Any transfer of Shares must be recorded by a notarial instrument or by a private document and shall not be valid
vis-à-vis the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with
article 190 of the Law.
7.4 In addition, each Shareholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any Share without the
prior written consent of the Board of Managers.
Chapter III.- Management
8. Management.
8.1 The Company is managed by a board of managers (the "Board of Managers"), composed of two or more managers
(each manager individually, a "Manager"). The Managers need not be a shareholder.
8.2 The Managers may be removed for legitimate reasons only by decision of the extraordinary general meeting of the
Shareholders taken in compliance with Article 16.
8.3 Any decision in connection with the management of the Company shall be taken collectively by the Board of
Managers in compliance with Article 12.
8.4 Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to any Manager as provided
by article 10 of the Articles, and pursuant to article 191bis paragraph 5 of the Law, any deed, agreement or generally any
document executed in compliance with articles 8 and 10 of the present Articles are valid and binding vis-à-vis third parties.
The exercise of the general power of representation by any Manager does not require prior approval by the Board of
Managers acting collectively.
9. Powers of the manager or of the Board of Managers.
9.1 In dealing with third parties, the Board of Managers, without prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles,
will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all administration
and disposition acts and operations consistent with the Company's objects.
9.2 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the
competence of the Board of Managers.
10. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of any
Manager or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any Manager.
11. Delegation and agent of the Board of Managers.
11.1 Any Manager may delegate their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents,
11.2 Any Manager will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period
of representation and any other relevant conditions of its agency.
12. Meeting of the Board of Managers.
12.1 In case of a Board of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager. In case that
all the Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.
12.2 Any member of the Board of Managers may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing
or by telegram or telefax or email or letter another member as his proxy. A member of the Board of Managers may also
appoint another member to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.
12.3 The resolutions by the Board of Managers are validly adopted if approved by more than half of the members of
the Board of Managers, present or represented.
12.4 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
member of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not
using this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall
be authorised to vote by video or by telephone.
12.5 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by more than
half of the Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or
104862
telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers' meetings, physically
held.
12.6 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is
confirmed in writing.
12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the
meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any manager or during a meeting of
the Board of Managers.
12.8 In case of a Sole Manager, the resolutions of the Sole Manager may be documented in writing.
13. Indemnification.
13.1 To the fullest extent permitted by law, the Company shall indemnify and save harmless each Manager from and
against any and all claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses (including amounts paid in satisfaction of judg-
ments, in compromises and settlements, as fines and penalties and legal or other costs and reasonable expenses of
investigating or defending against any claim or alleged claim) of any nature whatsoever, known or unknown, liquidated or
unliquidated, that are incurred by any Manager and arise out of or in connection with his mandate as manager of the
Company; provided that a Manager shall be entitled to indemnification hereunder only to the extent that such Manager's
conduct did not constitute fraud, bad faith, willful misconduct, gross negligence or a material violation of any applicable
law.
13.2 Expenses reasonably incurred by a Manager in defense or settlement of any claim that may be subject to a right
of indemnification hereunder shall be advanced by the Company prior to the final disposition thereof upon receipt of an
undertaking by or on behalf of the Manager to repay such amount to the extent that it shall be determined ultimately
that such Manager is not entitled to be indemnified hereunder. No advances shall be made by the Company under this
Article 13.2 without the prior written approval of the Board of Managers.
13.3 The right of any Manager to the indemnification provided herein shall be cumulative of, and in addition to, any
and all rights to which such Manager may otherwise be entitled by contract or as a matter of law or equity and shall
extend to such Manager's successors, assigns and legal representatives.
13.4 Any Manager entitled to indemnification from the Company hereunder shall first seek recovery under any other
indemnity or any insurance policies by which such Manager is indemnified or covered, as the case may be, but only to the
extent that the indemnitor with respect to such indemnity or the insurer with respect to such insurance policy provides
(or acknowledges its obligation to provide) such indemnity or coverage on a timely basis, as the case may be, and such
Manager shall obtain the written consent of the Board of Managers prior to entering into any compromise or settlement
which would result in an obligation of the Company to indemnify such Manager.
Chapter IV.- General meeting of shareholders
14. Powers of the general meeting of Shareholders - Votes.
14.1 Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he owns.
Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
14.2 In case of one shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general Shareholders'
meeting and its decisions are recorded in writing.
15. Holding of general meetings.
15.1 Shareholders meetings may always be convened by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any
Manager, failing which by Shareholders representing more than half of the capital of the Company.
15.2 The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Shareholders does not exceed
twenty-five. In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.
15.3 Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held
each year.
15.4 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the
Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Sole Manager or,
in case of plurality of managers, to the Board of Managers.
16. Majorities.
16.1 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, and decisions shall be adopted by a
majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.
16.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three-
quarters of the Company's share capital in accordance with any provisions of the Law.
16.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
104863
Chapter V.- Business year
17. Business year.
17.1 The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.
17.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or, in case of
plurality of managers, the Board of Managers and the latest prepare an inventory including an indication of the value of
the Company's assets and liabilities.
17.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
18. Distribution right of shares.
18.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-
ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.
18.2 From the net profit thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That
deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's
nominal capital.
18.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.
18.4 The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by
the general meeting of the Shareholders.
18.5 The Manager, or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may however and to the extent permitted
by law decide to pay interim dividends.
Chapter VI.- Liquidation
19. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
20. Liquidation.
20.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing
three quarters of the Company's share capital.
20.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
Chapter VII.- Applicable Law
21. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is
made in these Articles.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders unanimously resolve to acknowledge and accept, with immediate effect, the resignation by CEREP
S.à r.l.of its mandate as sole manager of the Company, as evidenced by a resignation letter which shall remain attached
to the present minutes and to give full discharge to its duties as sole manager of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders unanimously resolve to appoint the following persons as New Managers of the Company:
- Mr Oussama Daher, European Investment Manager, residing at 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg), Luxembourg,
- Mr Christopher Finn, Managing Director, residing at 19 Randolph Crescent, London, W9 1DP, UK,
- Mr Robert Konigsberg, Principal, residing at 7602 Brittany Parc Ct. Falls Church, VA 22043, USA.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders unanimously resolve to set the duration of the mandate of the New Managers to six (6) years, ending
at the annual general meeting of shareholders to be held in 2010.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille quatre, le quatre novembre.
104864
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Poseidon JV S.à
r.l., ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph
ELVINGER, précité, le 6 juillet 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
100.535 et publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations ( le «Mémorial C»), numéro 1092 du 28
octobre 2004, page 52 391.
Le nom de la Société a été modifié par un acte notarié du notaire Joseph Elvinger en date du 13 octobre 2004 changeant
le nom de la Société, en cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, dé-
signant comme secrétaire, Monsieur Patrick VAN HEES, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg. L'as-
semblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick VAN HEES, prénommé.
Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations «ne varietur», une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II. Il ressort de la liste de présence que les deux cent cinquante (250) actions représentant l'intégralité du capital social
de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés. L'assemblée
est dès lors constituée régulièrement et peut délibérer et décider de l'ordre du jour cité ci-dessous.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Complète modification et refonte des Statuts de la Société;
2) Acceptation de la démission et décharge de responsabilité du gérant unique de la Société;
3) Nomination des personnes suivantes comme nouveaux gérants de la Société (les «Nouveaux Gérants»):
- M. Oussama Daher, European Investment Manager, demeurant au 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg (Grand-
Duché du Luxembourg),
- M. Christopher Finn, Managing Director, demeurant au 19 Randolph Crescent, Londres, W9 1DP, UK,
- M. Robert Konigsberg, Principal, demeurant au 7602 Brittany Parc Ct. Falls Church, VA 22043, USA.
4) Décision de fixer la durée du mandat des Nouveaux Gérants à six (6) ans, prenant fin lors de l'assemblée générale
annuelle des associés devant être tenu en 2010;
5) Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité, conformément à l'article 14 des statuts de la
Société:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident à l'unanimité de procéder à la refonte complète des Statuts de la Société comme suit:
1. Forme - Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Poseidon JV S.à
r.l.» qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915
relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présente statuts de la Société
(ci-après les «Statuts»).
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3 Toutefois, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la Ville de
Luxembourg.
2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Conseil de Gérance.
3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est d'acquérir et de détenir tous intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres
entités luxembourgeoises ou étrangères, commerciales, industrielles ou financières, notamment par voie de souscription
ou d'acquisition de toute valeur mobilière ou de droits au travers de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option,
de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dette, sous quelque forme que ce soit, ainsi que
d'administrer, de développer et de gérer ces intérêts.
104865
3.2 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe
ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.
3.3 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de
garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»).
3.4 Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre
société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlé par ou est sous le contrôle commun avec, la Société,
que ce soit comme bénéficiaire, trustée ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant
une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital
social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce
soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.
3.5 La Société pourra notamment conclure les transactions suivantes:
3.5.1 emprunter sous toute forme ou obtenir toutes formes de crédit et lever des fonds, notamment, par l'émission
d'obligations, de titres de dettes (notes), de billets à ordre (promissory notes), certificats (certificates) et autres instru-
ments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
3.5.2 avancer, prêter, déposer des fonds ou accorder des crédits avec ou à ses filiales ou souscrire ou acquérir tout
titre de dettes émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère dans des termes considérés comme satisfaisantes, avec
ou sans sûreté;
3.5.3 accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engagement
personnel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs (présents ou futurs) de l'entreprise, ou par
l'une ou l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de toute Société
Apparentée, ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de la Société ou de toute Société Apparentée, et
apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites de toute disposition légale; et
3.5.4 conclure tous contrats, et notamment, des contrats d'association, des contrats de souscription, des accords de
distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration et autres contrats de services,
des contrats de vente, en relation avec son objet;
étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités
pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.
3.6 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières
et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir béné-
ficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II.- Capital, Parts
5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500 €) représenté par deux cent cinquante (250)
parts sociales, ayant une valeur nominale de cinquante Euro (50 €), chacune (ci-après les «Parts Sociales»). Les détenteurs
de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés».
5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.
5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4 Tout Associé a le droit de participer à toute future augmentation de capital faite par la Société en proportion du
nombre de Parts Sociales qu'il détient dans la Société au jour de l'assemblée générale d'Associés décidant de l'augmen-
tation de capital.
6. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part
Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société
7. Transfert des parts.
7.1 Tout transfert de Parts Sociales à un tiers (autre qu'une Personne sous le Contrôle d'un Associé) requiert l'accord
préalable du Conseil de Gérance. Pour les besoins de cet article, «Personne» signifie tout personne physique, corporation,
association, trust joint venture, organisme sans personnalité juridique, société à responsabilité limitée, et tout gouver-
nement, département gouvernemental, ou agence ou sous-division politie et «Contrôle» signifie la détention, directe ou
indirecte, du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de la Personne, que ce soit aux moyens de la
détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, out transfert de Parts Sociales à un tiers (autre qu'une Personne sous
le Contrôle d'un Associé) par le biais d'une vente, cession, gage, sûreté ou toute autre forme, doit être autorisée par
104866
l'assemblée générale des associés représentant trois quarts du capital social de la Société en conformité avec l'article
189de la Loi.
7.3 Chaque transfert de Parts Sociales doit être constaté par un acte notarié ou sous-seing privée n'est opposable à
la Société ou aux tiers qu'après qu'il ait été notifié à la Société ou accepté par elle en conformité avec l'article 190 de la
Loi.
7.4 Au surplus, chaque Associé s'engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales qu'il
détient sans le consentement préalable et écrit du Conseil de Gérance.
Titre III.- Gérance
8. Gérance.
8.1 La Société est gérée par un conseil de Gérance (le «Conseil de Gérance»), composé d'au moins deux gérants
(chaque gérant individuellement, un «Gérant»). Les Gérants ne doivent pas être associés.
8.2 Les Gérants pourront être révoqués uniquement pour des motifs légitimes par une résolution des Associés prises
en conformité avec l'Article 16.
8.3 Toute décision en relation avec la gérance de la Société doit être prise par le Conseil de Gérance agissant collec-
tivement en conformité avec l'Article 12.
8.4 Envers les tiers, le pouvoir général de représentation de la Société est conféré à tout Gérant tel que stipulé à
l'article 10 des Statuts, et en vertu de l'article 191bis paragraphe 5 de la Loi, tout acte, contrat ou généralement tout
document exécuté en conformité aux articles 8 et 10 sont valables et créeront des obligations à la charge de la Société
vis-à-vis des tiers. L'exercice du pouvoir général de représentation par un Gérant ne requiert pas l'approbation préalable
du Conseil de Gérance agissant collectivement.
9. Pouvoirs du gérant.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance, sans préjudice des articles 8 et 10 des Statuts, a tous
pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes d'administration et de disposition et
toutes opérations conformes à l'objet social.
9.2 Les compétences non expressément réservées par la loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des associés
tombent dans la compétence du Conseil de Gérance.
10. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la seule signature de tout
Gérant ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué par tout Gérant.
11. Délégation et agent du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.
11.1 Tout Gérant peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Tout Gérant détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout agent, la durée de
son mandat ainsi que toutes autres conditions de son mandat.
12. Réunion du Conseil de Gérance.
12.1 En cas de Conseil de Gérance, le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d'un Gérant. Lorsque tous les
Gérants sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.
12.2 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre membre,
pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre membre pour le représenter, moyennant confir-
mation écrite ultérieure.
12.3 Toute décision du Conseil de Gérance est valablement adoptée lorsqu'elle est approuvée par plus de la moitié
des membres du Conseil de Gérance, présent ou représenté.
12.4 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de
technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou
la vidéo.
12.5 Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées
et approuvées par écrit par plus de la moitié des Gérants. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs
documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même validité
que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil de Gérance physiquement tenue.
12.6 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, e-
mail, télégramme, fac-similé ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés
aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée par un Gérant ou lors d'une
réunion du Conseil de Gérance.
12.8 En cas de Gérant Unique, les résolutions du Gérant Unique pourront être documentées par écrit.
104867
13. Indemnisation.
13.1 Dans la plus large mesure permise par la loi, la Société indemnisera chaque Gérant des ou de toutes les créances,
responsabilités, dommages, pertes, coûts et dépenses (en ce compris les montants payés suite à des jugements, transac-
tions et accords, comme amendes, pénalités, coûts légaux ou autres et dépenses raisonnables d'enquête et de défense
envers une créance ou prétendue créance) de quelque nature que ce soit, connus ou non, liquides ou non, encourus par
un Gérant et survenus en dehors ou en relation avec son mandat de gérant de la Société; à condition que ce Gérant ait
droit à une indemnisation seulement dans la mesure où la conduite du Gérant n'est pas constitutive d'une fraude, d'un
comportement de mauvaise foi, d'une mauvaise conduite, d'une faute lourde ou d'une violation manifeste d'une disposition
légale applicable.
13.2 Les dépenses raisonnables encourues par un Gérant dans le cadre de la défense ou d'un accord relatif à une
créance pouvant faire l'objet d'un droit d'indemnisation tel que dit ci-dessous, seront avancées par la Société, préalable-
ment à l'aboutissement de ce qui précède, dès réception d'un engagement par ou pour le compte du Gérant de
rembourser ce montant dans la mesure où il sera en dernier lieu déterminé que le Gérant n'avait pas droit à une indem-
nisation. Aucune avance ne sera effectuée par la Société sur base de cet article 13.2 sans le consentement préalable et
écrit du Conseil de Gérance.
13.3 Le droit d'un Gérant à une indemnisation, telle que stipulée ci-avant, pourra être cumulé, et additionné, avec les
droits et tous les droits dont ce Gérant pourra bénéficier autrement par contrat, par la loi ou par l'équité et s'étendre à
ces successeurs, légataires et représentants légaux.
13.4 Tout Gérant ayant droit à une indemnisation de la Société cherchera d'abord recouvrement sur base d'une autre
garantie ou de polices d'assurance par lesquelles ce Gérant pourrait, le cas échéant, être indemnisé et couvert, mais
seulement dans la mesure où la caution sur base de la garantie ou l'assureur selon la police d'assurance intervienne (ou
reconnaisse son obligation à intervenir) dans ce dédommagement ou cette couverture sur une base temporelle, le cas
échéant, et ce Gérant devra obtenir le consentement préalable et écrit du Conseil de Gérance avant de conclure toute
transaction ou accord, résultant d'une obligation de la Société d'indemniser ce Gérant.
Titre IV.- Assemblée générale des Associés
14. Pouvoirs de l'assemblée des Associés - Votes.
14.1 Tout Associé peut prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de Parts Sociales qu'il détient.
Chaque Associé a un droit de vote proportionnel à sa participation dans le capital social.
14.2 En cas d'Associé unique, celui-ci exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et
ses décisions sont établies par écrit.
15. Tenue d'assemblées générales.
15.1 Des assemblées générales pourront toujours être convoquées par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par tout Gérant, à défaut par les Associés représentant plus de la moitié du capital de la Société.
15.2 La tenue d'assemblée générale n'est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à vingt-
cinq. Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.
15.3 Lorsqu'il y aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale.
15.4 Quel que soit le nombre d'Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des
Associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge à donner au Gérant Unique ou, en cas de pluralité
de gérants, au Conseil de Gérance.
16. Majorités.
16.1 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié
du capital social les adoptent. Si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première réunion ou consultation par écrit, les
Associées sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la
majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
16.2 Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
16.3 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne peuvent
être décidés qu'avec l'accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.
Titre V.- Exercice social
17. Exercice social.
17.1 L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
17.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou, en cas
de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance et ce dernier prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.
17.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
104868
18. Droit de distribution des parts.
18.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-
sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.
18.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
18.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des
Statuts, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds
disponibles soient distribués.
18.4 La décision de distribuer des dividendes et d'en déterminer le montant sera prise par l'assemblée générale des
Associés.
18.5 Le Gérant Unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra, cependant, et ce dans le cadre
autorisé par la loi, décider de verser des acomptes sur dividendes.
Titre VI.- Liquidation
19. Causes de dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,
d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.
20. Liquidation.
20.1 La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés représentant les
trois quarts du capital social de la Société.
20.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et rémunérations.
20.3 Un Associé peut dissoudre la Société et procéder à sa liquidation, en assumant personnellement le paiement de
tous ses actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.
Titre VII.- Loi applicable
21. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés accusent réception et acceptent, avec effet immédiat, la démission de CEREP S.à r.l. de son mandat de
gérant unique de la Société tel que documentée par la lettre de démission qui devra rester annexée au présent procès-
verbal et de lui donner la pleine et entière décharge de responsabilité pour ses services en sa qualité de gérant de la
Société.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de nommer les personnes suivantes comme Nouveaux Gérants de la Société:
- M. Oussama Daher, European Investment Manager, demeurant au 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg (Grand-
Duché du Luxembourg),
- M. Christopher Finn, Managing Director, demeurant au 19 Randolph Crescent, Londres, W9 1DP, UK,
- M. Robert Konigsberg, Principal, demeurant au 7602 Brittany Parc Ct. Falls Church, VA 22043, USA.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident à l'unanimité de fixer la durée du mandat des Nouveaux Gérants à six (6) ans, leur mandat
prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des associés à tenir en 2010.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est
établie en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. JANSSEN, P. VAN HEES, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 novembre 2004, Vol. 145S, Fol. 62, Case 2. — Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J. MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008110539/211/551.
(080128234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2008.
104869
Grenache & Cie S.N.C., Société en nom collectif.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 133.763.
In the year two thousand and eight, on the tenth of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Was held an extraordinary general meeting of the Partners of "GRENACHE & CIE S.N.C." having its registered office
at 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B. 133.763.
The Partnership was incorporated by notarial deed on the 20 November 2007, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations on 17 December 2007 number 2928 page 140.499.
The meeting is opened at 2.30 p.m under the chairmanship of François-Xavier Rouffiac, residing professionally at 10,
Harewood Avenue, NW1-6AA London, United Kingdom (the "Chairman"), who appoints as secretary Christian Klar, A
Management Committee Member of the Partnership, residing professionally at 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Bruno Bancal, B Management Committee Member of the Partnership, residing profes-
sionally at 3, rue d'Antin, 75002 Paris, France.
All the Partners are present at the meeting and declare having duly received the convening notices in accordance with
clause 8.12 of the constitution of the Partnership (the "Constitution").
Terms not otherwise defined herein shall have the meaning given to them in the Constitution.
The Chairman requests the notary to act that:
The Chairman mentions and the extraordinary meeting of the Partners of the Partnership (the "Meeting") notices that:
- the Partners present or represented and the number of Fractional Interests held by them are entered on an attendance
list attached to these minutes and duly signed by the Partners present, together with the proxies of the represented
Partners;
- all the Partners declare having been informed of the agenda of the meeting beforehand and waived all convening
requirements and formalities. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. To increase the share capital of the Partnership by an amount of EUR 17.075.000 (Euro seventeen million seventy-
five thousand) in order to raise it from its current amount of EUR 1.403.346.000 ( Euro one billion four hundred three
million three hundred and forty six thousand) to EUR 1.420.421.000 (Euro one billion four hundred twenty million four
hundred and twenty one thousand ) by creating and issuing 17.075 ( seventeen thousand seventy-five ) Additional B
Fractional Interests to BNP Paribas, having the same rights and obligations as the existing B Fractional Interests and having
a nominal value of EUR 1,000 (one thousand Euro) each, by incorporating into the share capital of the Partnership an
amount of EUR 17.075.000 which is currently part of the B Capital Reserve; and
2. To amend clauses 6.1 and 6.2 of the Constitution accordingly.
The following resolutions were taken by the Partners:
<i>First resolutioni>
According to clause 9.5 of the Constitution, the Partners decide to incorporate into the B Capital Reserve 100% of
the distributable profit as at June 30, 2008, i.e. EUR 17.075.842,79 (Euro seventeen million seventy-five thousand eight
hundred and forty-two seventy-nine Cents). A balance sheet as per June 30, 2008 will remain attached to the present
deed.
Then the Partners decide to increase the share capital of the Partnership by an amount of EUR 17.075.000 (Euro
seventeen million seventy-five thousand) in order to raise it from its current amount of EUR 1.403.346.000 ( Euro one
billion four hundred three million three hundred and forty six thousand) to EUR 1.420.421.000 (Euro one billion four
hundred twenty million four hundred and twenty one thousand ) by creating and issuing 17.075 (seventeen thousand
seventy-five) Additional B Fractional Interests to BNP Paribas ("B Partner"), having the same rights and obligations as the
existing B Fractional Interests and having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand Euro) each, by incorporating into
the share capital of the Partnership an amount of EUR 17.075.000 (Euro seventeen million seventy-five thousand) which
is currently part of the B Capital Reserve.
<i>Second resolutioni>
The Partners decide to amend clauses 6.1 and 6.2 of the Constitution as follows:
Clause 6.1. The capital of the Partnership shall be an amount of EUR 1.420.421.000 ( Euro one billion four hundred
twenty million four hundred and twenty one thousand) and shall be divided into and represented by 1.420.421 (one million
four hundred and twenty thousand four hundred and twenty-one) fractional interests (parts de société en nom collectif)
(each a "Fractional Interest") of EUR 1,000 (one thousand Euro) nominal value each.
104870
Clause 6.2. The Fractional Interests constitute and represent two (2) separate interests in the Partnership:
(a) 650,000 (six hundred and fifty thousand) Fractional Interests (the "A Fractional Interests") constitute the "A Inter-
est"; and
(b) 770.421 ( seven hundred seventy thousand four hundred and twenty one) together with any Additional B Fractional
Interests (the "B Fractional Interests") constitute the "B Interest".
Any person holding all or part of the A Interest from time to time and who is registered from time to time in the
register of members of the Partnership as the holder of A Fractional Interests is a "A Partner".
Any person holding all or part of the B Interest from time to time and who is registered from time to time in the
register of members of the Partnership as the holder of B Fractional Interests is a "B Partner".
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 6,000.-.
Nothing further being on the agenda and no one asking to speak, the meeting was adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le dix juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société GRENACHE & CIE S.N.C., ayant son
siège social au 10, boulevard Royal, L-2249 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 133.763 ("Société").
La Société a été constituée par acte notarié le 20 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2928, en date du 17 décembre 2007.
La réunion est ouverte à 14.30 heures, sous la présidence de Monsieur François-Xavier Rouffiac, ayant son lieu de
résidence professionnelle au 10, Harewood Avenue, NW1-6AA Londres, Royaume-Uni, ("Président"), qui désigne comme
secrétaire Monsieur Christian Klar, Gérant A de la Société, ayant son lieu de résidence professionnelle au 26B, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg. L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Bruno Bancal, B Management Committee
Member of the Partnership, ayant son lieu de residence professionnelle au 3, rue d'Antin, 75002 Paris, France.
Tous les Associés sont présents à la réunion et déclarent avoir dûment reçu les avis de convocation conformément,
à l'article 8.2 des statuts de la Sociétés ("Statuts").
Les termes utilisés ci-après, sans être par ailleurs définis, doivent avoir le sens qui leur est donné dans les Statuts.
Le Président prie le notaire d'acter ce qui suit:
- Les Associés présents ou représentés et le nombre de Parts Sociales détenues par eux sont renseignés sur une liste
de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le
notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.
- Les Associés déclare avoir eu connaissance de l'ordre du jour et renoncent aux formalités de convocation. L'assem-
blée est dûment constituée, et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
(1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 17.075.000.- (dix-sept millions soixante-quinze
mille euros), de sorte à le porter de son montant actuel de EUR 1.403.346.000,- (un milliard quatre cent trois millions
trois cent quarante six mille Euros) à EUR 1.420.421.000 (un milliard quatre cent vingt millions quatre cent vingt-et-un
mille euros) par la création et l'émission de 17.075 (dix-sept mille soixante-quinze) Parts Sociales B au profit de BNP
PARIBAS ("Associé B"), ayant les mêmes droits et obligations que les Parts Sociales B existantes et ayant une valeur
nominale de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune, par voie d'incorporation dans le capital social de la Société d'un montant
de EUR 17.075.000.- (dix-sept millions soixante-quinze mille euros), faisant actuellement partie de la Réserve du Capital
B.
(2) Modification consécutive des articles 6.1 et 6.2 des Statuts.
Les résolutions suivantes ont été adoptées:
104871
<i>Première résolutioni>
Conformément à l'article 9.5 des Statuts, les Associés décident d'affecter à la Réserve du Capital B 100% des bénéfices
distribuables au 30 juin 2008, i.e. EUR 17.075.842,79 (dix-sept millions soixante-quinze mille huit cent quarante-deux
euros soixante-dix-neuf cents). Le bilan au 30 juin 2008 restera annexé aux présentes.
Les Associés décident ensuite d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 17.075.000.- (dix-sept
millions soixante-quinze mille euros), de sorte à le porter de son montant actuel de EUR 1.403.346.000,- (un milliard
quatre cent trois millions trois cent quarante six mille Euros) à EUR 1.420.421.000.- (un milliard quatre cent vingt millions
quatre cent vingt-et-un mille euros) par la création et l'émission de 17.075 (dix-sept mille soixante-quinze) Parts Sociales
B au profit de BNP Paribas ("Associé B"), ayant les mêmes droits et obligations que les Parts Sociales B existantes et ayant
une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune, par voie d'incorporation dans le capital social de la Société
d'un montant de EUR 17.075.000.- (dix-sept millions soixante-quinze mille euros) faisant actuellement partie de la Réserve
du Capital B.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de modifier les articles 6.1 et 6.2 des Statuts afin de refléter les décisions prises, lesquels articles
seront rédigés comme suit:
Art. 6.1. Le capital social est fixé à EUR 1.420.421.000.- (un milliard quatre cent vingt millions quatre cent vingt-et-un
mille euros) et sera divisé et représenté par 1.420.421 (un million quatre cent vingt mille quatre cent vingt-et-une) parts
de société en nom collectif ("Parts Sociales") d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euros).
Art. 6.2. Les Parts Sociales constituent et représentent deux (2) formes différentes de participation:
(a) 650.000 (six cent cinquante mille) Parts Sociales (les "Parts A") constituent les "Participations A"; et
(a) 770.421 (sept cent soixante-dix mille quatre cent vingt-et-une), ensemble avec toute Part additionnelle B (les "Parts
B") constituent les "Participations B".
Toute personne détenant occasionnellement l'ensemble ou une partie des Participations A et qui est occasionnellement
enregistrée dans le registre des Associés de la Société en tant que titulaire de Parts A, est un "Associé A".
Toute personne détenant occasionnellement l'ensemble ou une partie des Participations B et qui est occasionnellement
enregistrée dans le registre des Associés de la Société en tant que titulaire de Parts B, est un "Associé B".
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison du présent acte, est évalué à environ EUR 6.000.-.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F.-X. ROUFFIAC, C. KLAR, B. BANCAL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 juillet 2008. Relation: LAC/2008/29024. — Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2008.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2008109651/242/151.
(080127162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2008.
New Star Global Property Management (Luxembourg Two) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.655.275,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 114.059.
In the year two thousand and eight, on the twenty-fourth day of July.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared:
New Star Global Property Management (Luxembourg One) S.à r.l, a company incorporated under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg having its registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 114068 (the "Sole Shareholder"),
104872
here represented by Ms. Caroline Apostol, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,
given on 23 July 2008, which proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party is the Sole Shareholder of New Star Global Property Management (Luxembourg Two) S.à r.l., a
société à responsabilité limitée having its registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 114059 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed
of Maître Léon Thomas known as Tom Metzler on 31 January 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 842, on 27 April 2006. The articles of incorporation have been modified for the last time by a
deed of Maître Joseph Elvinger on 15 February 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1089, on 2 May 2008.
The Sole Shareholder took the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of three million
two hundred thousand euro (EUR 3,200,000) from its current amount of four hundred fifty-five thousand two hundred
seventy-five euro (EUR 455,275) up to an amount of three million six hundred fifty-five thousand two hundred seventy-
five euro (EUR 3,655,275) through the issuance of one hundred twenty-eight thousand (128,000) new shares having a par
value of twenty-five euro (EUR 25) each.
<i>Subscription and paymenti>
The one hundred twenty-eight thousand (128,000) new shares have been entirely subscribed by the Sole Shareholder.
The new shares so subscribed have been paid up through a contribution in kind consisting of an unquestioned claim
due for immediate payment of the Sole Shareholder aforementioned, against the Company.
The sole member declares that this contribution in kind really exists and that its value is at least equal to the amount
of the increase of capital.
The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned
notary by a statement of account of the company where the said claim appears, by a certificate of acknowledgement of
claim signed by the manager of the Luxembourg company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the
company.
<i>Second Resolutioni>
As a consequence of the above mentioned capital increase, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation
of the Company is amended, and shall now be read as follows:
" Art. 5. The Company's share capital is set at three million six hundred fifty-five thousand two hundred seventy-five
euro (EUR 3,655,275) represented by one hundred forty-six thousand two hundred eleven (146,211) shares having a par
value of twenty-five euro (EUR 25) each. Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meet-
ings."
<i>Third Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to authorise Mr. Brian Anthony Mc Mahon, Mr. Jean-Louis Camuzat and/or Mr. Gareth
Essex-Cater, acting individually, with full power, including the power of substitution, to make the appropriate amendments
in the shareholders' register of the Company in order to reflect the abovementioned resolutions.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to nineteen thousand euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le vingt-quatre juillet,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
New Star Global Property Management (Luxembourg One) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et
existant suivant les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 114068 (l'«As-
socié Unique»),
104873
ici représentée par M
e
Caroline Apostol, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing
privé donnée à Luxembourg, en date du 23 juillet 2008,
La procuration signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante est l'Associé Unique de la société New Star Global Property Management (Luxembourg Two)
S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 114059 (la «Société») constituée
suivant acte reçu par le notaire Maître Léon Thomas connu sous le nom de Tom Metzler en date du 31 janvier 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 842, le 27 avril 2006. Les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Joseph Elvinger en date du 15 février 2008, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1089 le 2 mai 2008.
La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale
des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées,
a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois millions deux cent mille
euros (EUR 3.200.000) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent cinquante-cinq mille deux cent soixante-
quinze euros (EUR 455.275) à trois millions six cent cinquante-cinq mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 3.655.275)
par l'émission de cent vingt-huit mille (128.000) nouvelles parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.
<i>Souscription et paiementi>
Les cent vingt-huit mille (128.000) nouvelles parts sociales ont été souscrites par l'Associé Unique, susmentionnée,
pour un montant total de trois millions deux cent mille euros (EUR 3.200.000).
Les nouvelles parts sociales ainsi souscrites ont été libérées par un apport en nature consistant en une créance certaine,
liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la société.
L'associé unique déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l'augmentation
de capital.
La justification de l'existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-
mentant par la production d'un état comptable de la société où la dette afférente apparaît, par un certificat de
reconnaissance de dette signé par le gérant de la société luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation
signée par la société.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de l'augmentation de capital social ainsi réalisée, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société
est modifié et aura désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de trois millions six cent cinquante-cinq mille deux cent soixante-quinze
euros (EUR 3.655.275) représentée par cent quarante-six mille deux cent onze (146.211) parts sociales, d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des
assemblées générales ordinaires et extraordinaires."
<i>Troisième Résolutioni>
L'Associé Unique donne pouvoir à M. Anthony Mc Mahon, M. Jean-Louis Camuzat et/ou M. Gareth Essex-Cater,
pouvant agir individuellement, avec plein pouvoir incluant un pouvoir de substitution, aux fins d'apporter les modifications
nécessaires dans le registre des associés de la Société afin de refléter les résolutions qui précèdent.
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à dix-neuf mille euros (EUR 19.000,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. APOSTOL; J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 juillet 2008. Relation LAC/2008/31209. — Reçu seize mille euros (16000,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): FRANCIS SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
104874
Luxembourg, le 04 AOUT 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008106800/211/125.
(080123929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.
FLMBE, Fédération Luxembourgeoise de Massage Bien-Etre, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 2 bis, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg F 7.691.
STATUTS
Art. 1
er
. Constitution. Entre les membres fondateurs soussignés et les personnes qui, remplissant les conditions
fixées à l'article 6 ci-après, auront adhéré aux présents statuts, il est créé une Fédération qui sera régie par la loi du
21.04.1928 et les présents statuts.
Art. 2. Dénomination. La fédération prend pour titre: «Fédération Luxembourgeoise de Massage Bien-Etre».
La dénomination courante sera FLMBE.
Art. 3. Buts et objets. La Fédération a pour objet:
- la défense de l'usager-consommateur des soins de détente, de relaxations, entendues sous le terme générique de
"Bien-Etre", afin que celui-ci puisse être massé où et quand bon lui semble, par qui lui semble bon, sans limitation autre
que ci-après.
- la promotion des techniques de Massage de Bien-être, favorisant l'épanouissement de la personnalité et des facultés
naturelles de l'usager, prodiguées par des praticiens de Massage de Bien-Etre (MBE) enregistrés et agréés par la FLMBE.
- la défense de la pratique du Massage de Bien-Etre, à l'exclusion de toute pratique médicale, paramédicale thérapeu-
tique ou sexuelle.
- la constitution d'un Registre National des praticiens du Massage de Bien-Etre afin de répondre à la demande croissante
du public.
- la prise de position ou l'intervention dans des situations mettant en cause un praticien de Massage de Bien-Etre ou
une institution de formation membre de la Fédération.
- le rapprochement avec des fédérations européennes et internationales ayant pour objectif de développer le Massage
de Bien-Etre.
- la promotion, la réhabilitation et la légalisation du Massage Bien-Etre auprès des pouvoirs publics, comme discipline
distincte de la profession de masseur-kinésithérapeute et de la massokinésithérapie.
- la protection du public contre les pratiques illégales ou tendancieuses du praticien de la FLMBE.
Art. 4. Siège social. Le siège social est fixé, au: 2 bis, rue du brill 4041 ESCH ALZETTE LUXEMBOURG.
Il peut être transféré en tout autre lieu sur simple décision du Conseil d'Administration,
Art. 5. Durée. La durée de la FLMBE est illimitée.
Art. 6. Membres de la Fédération. La FFMBE se compose de membres fondateurs, de membres adhérents actifs,
membres adhérents affiliés, membres adhérents stagiaires, membres d'honneur et de membres bienfaiteurs. Ces membres
peuvent être des personnes physiques ou morales. Les personnes morales (écoles de formation, associations, syndicats...)
peuvent demander leur adhésion à la FLMBE. Le Conseil d'Administration estimera l'opportunité de leur adhésion à la
FLMBE en fonction, notamment, de la cohérence de leurs statuts avec ceux de la Fédération, et des critères fixés au
Règlement intérieur qui sera voté par le Conseil d'administration. Après accord de leur Conseil d'Administration, elles
doivent désigner lors de leur adhésion, la personne physique qui tes représentera au sein de la FLMBE. Sans cette formalité,
le président est le représentant au sein de la FLMBE de chaque personne morale.
Les associations ou écoles de formation dont l'objet est la pratique du massage de Bien-Etre demandent leur adhésion
à la FLMBE selon les modalités prévues par le Règlement intérieur. L'affiliation à la FLMBE peut être refusée si les asso-
ciations ou écoles de formation, personnes physiques ou morales, ne correspondent pas aux critères de sélection fixés
par le Conseil d'Administration. Le refus d'adhésion peut ne pas être motivé auprès du postulant lors de la réponse
apportée par la FLMBE.
A - les membres fondateurs sont les soussignés
B - les membres adhérents actifs, issus ou non d'écoles ou instituts de formation membre de la FFMBE, sont ceux qui,
en raison de l'intérêt qu'ils portent aux buts de la fédération, sont admis en cette qualité par le Conseil d'Administration.
C - Les membres stagiaires.
D - Les membres bienfaiteurs sont ceux qui versent une cotisation annuelle égale ou supérieure à un montant défini
chaque année par le Conseil d'Administration ou qui rendent des services éminents de toute nature à la Fédération.
Art. 7. Radiation. Cessent de faire partie de la FLMBE, sans que leur départ ne puisse mettre fin à celle-ci:
- Les personnes décédées,
104875
- Les personnes qui adressent, par lettre recommandée au Président du Conseil d'Administration, leur lettre de dé-
mission,
- pour défaut de paiement de la cotisation 6 mois après son échéance et après une mise en demeure restée sans effet.
- pour infraction grave aux présents statuts ou au code de déontologie de la FLMBE, l'intéressé ayant été invité par
lettre recommandée à se présenter devant le Conseil d'Administration pour fournir des explications.
Art. 8 Ressources. Les ressources de la FLMBE se composent:
- Des cotisations versées par les membres adhérents,
- Des dons versés par les membres bienfaiteurs,
- Des subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout autre organisme public et, de façon générale,
de toute autre ressource autorisée par les textes législatifs ou réglementaires.
Art. 9. Conseil d'Administration. La FLMBE est dirigée par un Conseil d'Administration (CA) de deux à quatre mem-
bres, élus par l'Assemblée Générale (AG).
Les membres sont rééligibles tous les 3 ans.
En cas de places vacantes, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Le remplacement
définitif intervient à l'AG suivante. Le CA choisit parmi ses membres un Bureau composé d'au minimum un Président et
un trésorier.
Et s'il y a lieu, un Secrétaire, un responsable de la communication
Art. 10. Réunions et attributions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois
tous les six mois, sur convocation du Président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres. Le Conseil
d'Administration ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses Administrateurs sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité.
Le vote par procuration est autorisé. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante. Tout membre du Conseil
qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.
Le Conseil d'Administration:
- veille aux suites des décisions prises en AG;
- contrôle la gestion des membres du Bureau;
- fixe le montant des cotisations;
- porte à l'ordre du jour toutes propositions signées d'un nombre égal au un vingtième des membres.
- a le droit de recevoir la démission des membres.
- défend la politique et les orientations générales de la Fédération;
- arrête les budgets et contrôle leur exécution;
- prononce l'exclusion éventuelle de membres.
Des remboursements de frais pourront être accordés sur justificatif selon les règles fixées par le CA.
Art. 11. Attributions du Bureau. Il assure le bon fonctionnement et la gestion de la Fédération.
Le Président a qualité pour ester en justice au nom de la Fédération. Il représente la Fédération dans tous les actes
de la vie civile et conclut tous les accords. Il préside toutes les Assemblées. En cas d'empêchement, il est remplacé par
un membre du CA ou du Bureau. Le président peut engager l'Asbl par sa seule signature pour les actes ne dépassant pas
500 euros.
Dans le cas de délégation, même partielle, de ses pouvoirs, il en informe le Bureau.
Le Trésorier est chargé de tenir la comptabilité de la Fédération. Il perçoit les recettes et effectue les paiements avec
l'autorisation du Président. En cas d'empêchement, il est remplacé par un Membre du CA ou du Bureau.
Le Secrétaire est chargé de rédiger les procès-verbaux des réunions du CA et de l'AG. En cas d'empêchement, il est
remplacé par une personne désignée par le Bureau.
Art. 12 Assemblée Générale ordinaire. L'AG ordinaire comprend tous les membres à jour de leur cotisation à quelque
titre qu'ils soient affiliés à la Fédération. Elle se réunit une fois par an à la demande du Président ou des deux tiers du CA.
Quinze jours avant la date fixée par le CA, les membres sont convoqués par lettre simple indiquant l'ordre du jour.
Ne seront traitées lors de l'AG, que les questions soumises à l'ordre du jour.
Le Président, assisté le cas échéant, des membres du CA préside l'AG et expose la situation morale de la Fédération.
Le Trésorier rend compte de la gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée,
Il est ensuite procédé à l'examen des autres points de l'ordre du jour puis s'il y a lieu, à l'élection des membres du CA
sortants, au scrutin secret. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents
ou représentés.
L'AG ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des membres la composant sont présents ou représentés.
Le nombre de pouvoirs détenus valablement par les membres n'est pas limité.
104876
Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est convoquée une nouvelle fois dans le mois qui suit la date fixée pour la
première. Elle délibère alors valablement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés. Loi luxembourgeoise de 2007.
Art. 13. Assemblée Générale extraordinaire. L'AG extraordinaire se prononce sur les modifications à apporter aux
statuts et la dissolution éventuelle de la Fédération. Elle se réunit à la demande du Président, ou des un cinquième du CA
ou un cinquième des membres.
Les décisions ne sont prises valablement que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Les
délibérations sont prises à la majorité des deux tiers selon la loi luxembourgeoise de 2007 et publiés dans le mémorial
C recueil des associations.
Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est convoquée une nouvelle fois dans le mois qui suit la date fixée pour la
première. Elle délibère alors valablement à la majorité absolue des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés.
Art. 14. Charte éthique professionnelle et règlement intérieur. Une charte éthique professionnelle et un règlement
intérieur sont établis par le CA. Ils sont destinés à fixer les modalités d'exécution des présents statuts et des activités de
la Fédération.
Art. 15. Dissolution. En cas de dissolution prononcée par l'AG extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nom-
més par celle-ci. L'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à la loi du 21 avril 1928.
Art. 16. Dispositions transitoires. Philippe DANZI en tant que président a tout pouvoir pour effectuer les formalités
de déclaration et de publication prévues par la loi.
Fait à ESCH, le 14 août 2008.
Signature
<i>Le présidenti>
Référence de publication: 2008108787/9189/132.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10367. - Reçu 164,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Zuucht- an Ausbildungsstall Biwerbaach, Société Anonyme.
Siège social: L-6834 Biwer, Maison 5.
R.C.S. Luxembourg B 140.910.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendacht, den fünften August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);
SIND ERSCHIENEN:
1) Frau Claudine BOUS, Bankangestellte, wohnhaft in L-8030 Strassen, 41, rue du Kiem.
2) Frau Jeannine SCHILZ, Bankangestellte, wohnhaft in L-1231 Howald, 32, avenue Berchem.
3) Frau Patricia MORIS, infirmiere psychiatrique, wohnhaft in L-6951 Olingen, 7, op den Ei'en.
Alle sind hier vertreten durch Herrn Hans Peter GREVENSTEIN, Reitlehrer, wohnhaft in L-6834 Biwerbaach, Maison
5, auf Grund von drei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift; welche Vollmachten vom Bevollmächtigten und dem
amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, den beurkundenden Notar ersuchen die Satzung einer Akti-
engesellschaft, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:
Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung "Zuucht- an Ausbildungsstall Biwerbaach", wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegrün-
det.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Biwerbaach, (Großherzogtum Luxemburg).
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-
eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.
104877
Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Dritt-
personen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten
befähigt ist.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist:
- die Zucht, Aufzucht und Ausbildung, sowie der An- und Verkauf von Pferden;
- die Ausbildung und Weiterbildung von Reitern;
- die Organisation von Reitturnieren, reiterlichen Veranstaltungen und Praktika,
- das Vermieten von Pferdeboxen;
- das Vermieten und der An- und Verkauf von jeglichem Material, welches mit den vorbenannten Aktivitäten in Ver-
bindung steht.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf
vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben.
Titel II - Kapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zweiunddreißigtausend Euro (32.000,- EUR), aufgeteilt in dreihundertzwanzig
(320) Aktien mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Die Abtretung von Aktien an Nichtgesellschafter bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des Verwal-
tungsrates. Die Aktien sind frei abtretbar unter den Aktionären verhältnismäßig zu der Zahl zum Kauf angebotener Aktien
die sie im Moment der Abtretung besitzen. Im Falle einer Abtretung von Aktien an einen Nichtgesellschafter, muss diese
Abtretungsabsicht dem Verwaltungsrat mitgeteilt werden, welcher die anderen Aktionäre informieren muss. Diese Aktien
gelten als den anderen Aktionären angeboten, welche demnach ein Vorkaufsrecht genießen, welches innerhalb von 14
Tagen ausgeübt werden muss. Mangels Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Verwaltungsrat sein Einverständnis
zur Abtretung an Dritte geben.
Titel III - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu
sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung der Aktionäre
bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.
Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft
erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Verwaltungsratsbeschlüsse können auch im Umlaufverfahren gefasst werden, wobei die Unterschriften der Verwal-
tungsratsmitglieder auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses gegeben werden dürfen.
Jedes Verwaltungsratsmitglied darf außerdem per Telefon- oder Videokonferenz oder ähnliche Kommunikationsmittel,
welche den Versammlungsteilnehmern erlauben sich gegenseitig zu hören, teilnehmen.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die
Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle
Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung durch
den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.
104878
Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Di-
rektoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen
erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft
vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte
Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.
Titel IV - Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung
der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit,
welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Titel V - Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten des Monats Februar um 20.00 Uhr, am
Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten und der Abschrei-
bungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und
der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben,
wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Titel VII - Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder
mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche
ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.
Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen
Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der
Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2009 statt.
3) Ausnahmsweise kann der erste Vorsitzende sowie der erste Delegierte des Verwaltungsrates von der ersten Ge-
neralversammlung, welche den ersten Verwaltungsrat bestellt, ernannt werden.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:
Aktien
1) Frau Claudine BOUS, vorgenannt, neunzig Aktien, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
2) Frau Jeannine SCHILZ, vorgenannt, einhundertfünfzig Aktien, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
3) Frau Patricia MORIS, vorgenannt, achtzig Aktien, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Total: dreihundertzwanzig Aktien, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von zwei-
unddreißigtausend Euro (32.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.
<i>Bescheinigungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausendfünfhundert-
fünfzig Euro.
104879
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordent-
lichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen, und nachdem sie die ordnungs-
gemäße Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, fassten sie einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6834 Biwerbaach, Maison 5.
2. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Frau Claudine BOUS, Bankangestellte, geboren in Luxemburg, am 24. Oktober 1963, wohnhaft in L-8030 Strassen,
41, rue du Kiem;
b) Frau Jeannine SCHILZ, Bankangestellte, geboren in Echternach, am 24. Juni 1962, wohnhaft in L-1231 Howald, 32,
avenue de Berchem;
c) Herr Hans Peter GREVENSTEIN, Reitlehrer, geboren in Aachen, (Bundesrepublik Deutschland), am 19. September
1956, wohnhaft in L-6834 Biwerbaach, Maison 5.
4. Die Aktiengesellschaft "SALCON S.A.", mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 10, An de Längten, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 107576, wird zum Kommissar der Gesellschaft
ernannt.
5. Gebrauch machend vom durch Punkt 3) der Übergangsbestimmungen vorgesehenen Recht, ernennt die General-
versammlung Herr Hans Peter GREVENSTEIN, vorgenannt, zum:
- Vorsitzenden des Verwaltungsrates, und
- Delegierten des Verwaltungsrates, mit der Befugnis die Gesellschaft in allen Umständen rechtmäßig durch seine
Einzelunterschrift zu verpflichten.
6. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des Delegierten des Verwaltungsrates und des Kommissars enden
sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2014.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparenten, namens handelnd
wie hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe ge-
genwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: GREVENSTEIN; - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 août 2008, Relation GRE/2008/3375. — Reçu cent soixante euros 160 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Junglinster, den 19. August 2008.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2008107386/231/168.
(080124200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.
Redwood Russia 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 128.454.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société en date du 4 juillet 2008i>
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
Luxembourg, le 1
er
août 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008108824/631/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07354. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080125774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
104880
Apollo Portland EU II S.à r.l.
Arcenciel Financial S.à r.l.
ASK Investments S.A.
BELF 5 Luxembourg
Belgravia Swiss 1
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Blue Jeans S.àr.l.
Buderus Giesserei Holding S.àr.l.
Burdaras Luxembourg Holding S.à r.l.
Canalville S.A.
CARE Canadian Real Estate S.A.
Centuria Holding Lux 2 S.à r.l.
Century Properties S.àr.l.
CEREP Investment Five S.à r.l.
Chiorino Group S.A.
ELECTEK Luxembourg S.A.
Elocap Lux S.A.
Fédération Luxembourgeoise de Massage Bien-Etre
Fidelity Investments Luxembourg S.A.
Fidis S. à r.l.
FIL (Luxembourg) S.A.
Flamierge Finance S.A.
Fondation Pauline de Faillonnet
Galerie Moderne, s.à.r.l.
GMT Spanext S.à r.l.
Grenache & Cie S.N.C.
International Financial Trading Company B.L.T. S.A.
Investment Lux Partners
Iris Garden Finance
Jordan French Investment Group S.A.H.
K-Development S.A.
L'Altaï S.A.
LBS Holdings S.à.r.l.
Lebaras Holding S.àr.l.
Lehwood Ventures S.à. r.l.
Liam Finance S.à r.l.
Lime Invest & Co. S.C.A.
Mobitek S.A.
National Construction S.A.
New Star Global Property Management (Luxembourg Two) S.à r.l.
Palazzo Due Funding & Co S.C.A.
Pegase Investment
Pegasus Investments Sàrl
Pestana Luxembourg
PHD Overseas Limited
Pizzeria ZIO PEPE
Plumeria S.à r.l.
Polish Purple Investments S.à r.l.
Poseidon JV S.à r.l.
Profilex S.A.
Project Shift (Luxembourg) S.à r.l.
Quanlux S.A.
Redwood Russia 1
Restaurant Pepe Bar S.à r.l.
Reuters S.A.
Selwyn S.A.
Services Généraux de Gestion S.A.
Symptom S.à r.l.
Tempyr S.à r.l.
Terre Naturelle (Holding) S.A.
TS Nautilus (Friedrichstrasse) S.à.r.l.
TS Nautilus (Hahnstrasse) S.à.r.l.
TS Nautilus (Liebknechtstrasse) S.à.r.l.
Zuucht- an Ausbildungsstall Biwerbaach