This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1799
22 juillet 2008
SOMMAIRE
Aratec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86352
Arvensis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86316
BOWEN HOLDINGS S.à r.l., société de
gestion de patrimoine familial . . . . . . . . . .
86312
BOWEN HOLDINGS S.à r.l., société de
gestion de patrimoine familial . . . . . . . . . .
86308
Centuria Property Management, S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86351
CERE II B Co-Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
86322
CERE II B Co-Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
86311
CEREP Cheapside S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
86322
Cessimoco, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86312
Consulting HDR + Partner S.A. . . . . . . . . . .
86352
CPM Développement S. à r. l. . . . . . . . . . . .
86351
Dahm Gastro-Service Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
86347
Daniel Schlechter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86351
DB Plus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86312
Decopaint SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86313
Decopaint SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86352
Delucs S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86320
Esposa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86316
Eurimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86319
Euro Investment and Finance S.A. . . . . . . .
86318
Euro Investment and Finance S.A. . . . . . . .
86317
Famby International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86319
Fil & Gatti Agence d'Assurances S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86311
Finoinvest Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86314
Finpromotion International Holding S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86320
First Climate Asset Management S.A. . . .
86338
Grandecran Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . .
86316
Grandecran Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . .
86317
GSW-Wolff-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
86322
HEDLAND HOLDINGS S.à r.l., société de
gestion de patrimoine familial . . . . . . . . . .
86334
HEDLAND HOLDINGS S.à r.l., société de
gestion de patrimoine familial . . . . . . . . . .
86306
High Tech Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
86316
Hoxton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86320
Java S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86313
Kamea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86314
Kamea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86329
Kamesis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86314
Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l. . . . . .
86312
Lanchester S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86315
Le Grand Château S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
86352
Magnisense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86315
Magnisense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86331
Marcell Equity S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86314
Marita Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86313
Monteria S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86315
Montrans S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86311
Nebis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86317
Pharmacopole S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86318
Pimlico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86351
Probat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86319
RGI Holdings (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .
86315
RGI Holdings (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .
86334
Ronndriesch 123 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86313
Ronndriesch 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86312
Skipness S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86315
Société de Gestion Ampera S.A. . . . . . . . .
86349
Supreme Entertainment S.A. . . . . . . . . . . .
86318
The World Trust Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
86325
Tialma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86320
TN Espo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86311
TOA (Lux) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86318
Wandpark Gemeng Hengischt S.A. . . . . . .
86321
Wandpark Gemeng Hengischt S.A. . . . . . .
86321
Wandpark Kehmen-Heischent S.A. . . . . . .
86321
Xelex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86319
86305
HEDLAND HOLDINGS S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 133.912.
In the year two thousand eight, on the ninth day of June.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mr Jacek WYSOCKI, company's director, born on June 16th, 1956 in Warszawa (Poland), residing ul. Gebicka 4/4
03-126 Warszawa, Poland,
here represented by Mr Philippe AFLALO, company's director, residing professionally in L-1118 Luxembourg, 23, rue
Aldringen
by virtue of a proxy given on 28 May 2008,
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of HEDLAND HOLDINGS S.á r.l., a Family Asset Management Company ("Société
de Gestion de Patrimoine Familial"), a société à responsabilité limitée, incorporated by a deed of the undersigned notary
on October 30, 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 2 987 of December 22,
2007.
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of ONE HUNDRED SEVEN THOU-
SAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 107,500) to bring it from its present amount of TWELVE THOUSAND FIVE
HUNDRED EUROS (EUR 12,500) to ONE HUNDRED TWENTY THOUSAND EUROS (EUR 120,000) by the issuance
of EIGHT HUNDRED SIXTY (860) new shares with a par value of ONE HUNDRED TWENTY FIVE EUROS (EUR 125)
each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
The sole shareholder, represented as stated here above, declares to subscribe for the EIGHT HUNDRED SIXTY (860)
new shares and to have them fully paid up by contribution in cash, so that the amount of ONE HUNDRED SEVEN
THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 107,500) is from now on at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend the article 6 of the articles of
incorporation, which will henceforth have the following wording:
"Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at ONE HUNDRED TWENTY THOUSAND EURO (120,000.- EUR)
represented by NINE HUNDRED SIXTY (960) shares with a par value of one hundred and twenty-five euro (125.-EUR)
each, all fully paid-up.
The shares are held by the investors as defined hereafter.
An eligible investor within the meaning of this law is any person as follows:
a) an individual acting within the context of managing his/her private asset or
b) a asset management entity acting exclusively in the interests of the personal estate of one or several individuals, or
c) an intermediary acting on behalf of the investors referred to in a) or b) of this paragraph.
Each investor must declare his/her eligibility in writing addressed to the domiciliary agent or, failing this, to the directors
of the SPF."
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides to amend the fourth paragraph of article 12 of the articles of incorporation, which will
henceforth have the following wording:
" Art. 12. fourth paragraph. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of
plurality of managers, by the signature of all members of the board of managers."
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint a new manager for an unlimited period:
Mr Jacek WYSOCKI, company's director, born on June 16th, 1956 in Warszawa (Poland), residing ul. Gebicka 4/4
03-126 Warszawa, Poland.
86306
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately ONE THOUSAND EIGHT
HUNDRED EURO (1,800.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, he signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le neuf juin.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Jacek WYSOCKI, adminstrateur de société, né le 16 juin 1956 à Warszawa (Pologne), demeurant ul. Gebicka
4/4 03-126 Warszawa, Pologne,
ici représenté par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118
Luxembourg, 23, rue Aldringen,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 28 mai 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'il est le seul et unique associé de la société HEDLAND HOLDINGS S.à r.l., Société de Gestion de Patrimoine
Familial, société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 30 octobre 2007,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2 987 du 22 décembre 2007.
- Qu'il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de CENT SEPT MILLE CINQ CENTS
EUROS (EUR 107.500) pour le porter de son montant actuel de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500) à
CENT VINGT MILLE EUROS (EUR 120.000) par l'émission de HUIT CENT SOIXANTE (860) parts sociales nouvelles
d'une valeur nominale de CENT VINGT CINQ EUROS (EUR 125) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que
les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
L'associé unique déclare souscrire les HUIT CENT SOIXANTE (860) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant
apport en espèces de sorte que le montant de CENT SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 107.500) est dès à présent
à la disposition de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique déclare modifier l'article 6 des statuts comme suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à CENT VINGT MILLE EUROS (12 0.000,- EUR) représenté par NEUF CENT
SOIXANTE (960) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.
Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques ou
c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de
la SPF.
Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de
valeur.»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier le quatrième paragraphe de l'article 12 des statuts qui aura la teneur suivante:
86307
« Art. 12. 4
ème
paragraphe. La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité
de gérants, par la signature de tous les membres du conseil de gérance.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de nommer un nouveau gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Jacek WYSOCKI, administrateur de société, né le 16 juin 1956 à Warszawa (Pologne), demeurant ul. Gebicka
4/4 03-126 Warszawa, Pologne,
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ MILLE HUIT CENTS EUROS (EUR 1.800).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire,
Signé: Ph. AFLALO, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juin 2008. LAC/2008/23689. — Reçu cinq cent trente-sept euros cinquantes cents
(537,50 €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): F. SCHNEIDER.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2008087369/220/130.
(080100131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
BOWEN HOLDINGS S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 133.910.
In the year two thousand eight, on the ninth day of June.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mr Boguslaw Jerzy PILSZCZEK, company's director, born on January 6th, 1951 in Chrzanow (Poland), residing UL.
Widna 14 31-464 Kraków, Poland,
here represented by Mr Philippe AFLALO, company's director, residing professionally in L-1118 Luxembourg, 23, rue
Aldringen,
by virtue of a proxy given on 28 May, 2008.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of BOWEN HOLDINGS S.á r.l., a Family Asset Management Company ("Société
de Gestion de Patrimoine Familial"), a société à responsabilité limitée, incorporated by a deed of the undersigned notary
on October 30, 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 2977 of December 21,
2007.
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of ONE HUNDRED TWENTY SEVEN
THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 127,500) to bring it from its present amount of TWELVE THOUSAND
FIVE HUNDRED EUROS (EUR 12,500) to ONE HUNDRED FORTY THOUSAND EUROS (EUR 140,000) by the issuance
of ONE THOUSAND TWENTY (1.020) new shares with a par value of ONE HUNDRED TWENTY FIVE EUROS (EUR
125) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - paymenti>
The sole shareholder, represented as stated here above, declares to subscribe for the ONE THOUSAND TWENTY
(1,020) new shares and to have them fully paid up by contribution in cash, so that the amount of ONE HUNDRED
86308
TWENTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 127,500) is from now on at the disposal of the Company,
evidence of which has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend the article 6 of the articles of
incorporation, which will henceforth have the following wording:
" Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at ONE HUNDRED FORTY THOUSAND EURO (140,000.- EUR)
represented by ONE THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY (1,120) shares with a par value of one hundred and
twenty-five euro (125.- EUR) each, all fully paid-up.
The shares are held by the investors as defined hereafter.
An eligible investor within the meaning of this law is any person as follows:
a) an individual acting within the context of managing his/her private asset or
b) a asset management entity acting exclusively in the interests of the personal estate of one or several individuals, or
c) an intermediary acting on behalf of the investors referred to in a) or b) of this paragraph.
Each investor must declare his/her eligibility in writing addressed to the domiciliary agent or, failing this, to the directors
of the SPF."
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides to amend the fourth paragraph of article 12 of the articles of incorporation, which will
henceforth have the following wording:
" Art. 12. (fourth paragraph). The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of
plurality of managers, by the signature of all members of the board of managers."
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint a new manager for an unlimited period:
Mr Boguslaw Jerzy PILSZCZEK, company's director, residing UL. Widna 14 31-464 Krakow, Poland, born on January
6th, 1951 in Chrzanow (Poland).
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately TWO THOUSAND EURO
(2,000.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, he signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil huit, le neuf juin.
Par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Boguslaw Jerzy PILSZCZEK, administrateur de société, né le 6 janvier 1951 à Chrzanow (Pologne), demeu-
rant à ul. Widna 14 31-464 Kraków, (Pologne),
ici représenté par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118
Luxembourg, 23, rue Aldringen,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 28 mai 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
lequel, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'il est le seul et unique associé de la société BOWEN HOLDINGS S.à r.l., Société de Gestion de Patrimoine
Familial, société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 30 octobre 2007,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2977 du 21 décembre 2007.
- Qu'il a pris les résolutions suivantes:
86309
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de CENT VINGT SEPT MILLE CINQ
CENTS EUROS (EUR 127.500) pour le porter de son montant actuel de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR
12.500) à CENT QUARANTE MILLE EUROS (EUR 140.000) par l'émission de MILLE VINGT (1.020) parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale de CENT VINGT CINQ EUROS (EUR 125) chacune, ayant les mêmes droits et obliga-
tions que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - libérationi>
L'associé unique déclare souscrire les MILLE VINGT (1.020) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport
en espèces de sorte que le montant de CENT VINGT SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 127.500) est dès à présent
à la disposition de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique déclare modifier l'article 6 des statuts comme suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à CENT QUARANTE MILLE EUROS (140.000,- EUR) représenté par MILLE CENT
VINGT (1.120) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.
Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques ou
c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de
la SPF.
Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de
valeur.»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier le quatrième paragraphe de l'article 12 des statuts qui aura la teneur suivante:
« Art. 12. (4
ème
paragraphe). La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité
de gérants, par la signature de tous les membres du conseil de gérance.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de nommer un nouveau gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Boguslaw Jerzy PILSZCZEK, administrateur de société, demeurant à ul. Widna 14 31-464 Kraków, (Pologne),
né le 6 janvier 1951 à Chrzanow (Pologne).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ DEUX MILLE EUROS (EUR 2.000).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Ph. AFLALO, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juin 2008. LAC/2008/23690. - Reçu: six cent quatre-vingt-sept euros cinquante
cents (687,50 €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): F. SCHNEIDER.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2008087370/220/130.
(080100135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
86310
Montrans S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 46.579.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/07/2008.
<i>Pour MONTRANS S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature
Référence de publication: 2008087541/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01888. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080100354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
TN Espo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 139.360.
Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 276/2008 en date du 28 mai 2008
par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Jacques DELVAUX
Boîte Postale 320, L-2013 Luxembourg
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087403/208/14.
(080099924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
CERE II B Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 122.262.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
52263 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Joseph ELVINGER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087412/211/11.
(080100257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Fil & Gatti Agence d'Assurances S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4711 Pétange, 57, rue d'Athus.
R.C.S. Luxembourg B 112.521.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 13 juin 2008, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 04 juillet 2008.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087416/219/13.
(080100262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
86311
Ronndriesch 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 75.770.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Karine REUTER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087424/7851/11.
(080100298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 134.942.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 13 juin 2008, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 04 juillet 2008.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087418/219/13.
(080100063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Cessimoco, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 68, rue de Cessange.
R.C.S. Luxembourg B 8.059.
Les statuts coordonnés de la société au 26 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 juillet 2008.
Marc LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087421/243/13.
(080100322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
BOWEN HOLDINGS S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 133.910.
Statuts coordonnés déposés au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Gérard LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087423/220/12.
(080100137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
DB Plus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7516 Rollingen, 1, rue Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg B 138.598.
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin
2008 le siège social et les bureaux ont été déplacés vers la nouvelle adresse 1, rue Belle-Vue, L-7516 Rollinger/Mersch,
à effet du 1
er
juillet 2008.
86312
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 juin 2008
T.W. van KAMPEN
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2008087569/801128/16.
Enregistré à Diekirch, le 8 juillet 2008, réf. DSO-CS00054. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080100404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Ronndriesch 123 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 84.107.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Karine REUTER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087425/7851/11.
(080100111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Java S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 122.057.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087431/5770/12.
(080099997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Marita Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 47.427.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087432/5770/12.
(080100023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Decopaint SA., Société Anonyme.
Siège social: L-9280 Diekirch, 48, rue de Stavelot.
R.C.S. Luxembourg B 112.336.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 22 maii>
<i>2008 à 11.00 heuresi>
L'assemblée révoque avec effet immédiat Monsieur Steffen JAUCH de son poste d'administrateur et administrateur-
délégué.
L'assemblée décide de nommer en remplacement au poste d'administrateur, Madame Joëlle GROBER, née à Ettelbruck
(L) le 03.12.1965, demeurant à L - 9440 Vianden, 64, rue du Sanatorium. Ce mandat se terminera à l'issue de l'assemblée
générale qui se tiendra en l'année 2011.
86313
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008087580/832/19.
Enregistré à Diekirch, le 30 juin 2008, réf. DSO-CR00391. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080099929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Kamesis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 116.615.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087433/5770/12.
(080100032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Kamea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 95.359.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087434/5770/12.
(080100043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Marcell Equity S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 121.636.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087435/5770/12.
(080099953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Finoinvest Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 51.410.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087436/5770/12.
(080099964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
86314
Magnisense, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 122.697.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087437/5770/12.
(080099833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Skipness S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 88.604.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 8 juillet 2008.
Jean-Joseph WAGNER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087438/239/12.
(080100208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Monteria S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 63.952.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 8 juillet 2008.
Jean-Joseph WAGNER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087439/239/12.
(080100178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
RGI Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 137.391.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 8 juillet 2008.
Jean-Joseph WAGNER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087440/239/12.
(080100193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Lanchester S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 123.746.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations.
86315
Belvaux, le 7 juillet 2008.
Jean-Joseph WAGNER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087441/239/12.
(080099999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
High Tech Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 71.427.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 8 juillet 2008.
Jean-Joseph WAGNER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087442/239/12.
(080099783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Esposa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 40.473.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/07/2008.
<i>Pour ESPOSA S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature
Référence de publication: 2008087544/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01891. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080100345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Arvensis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 73.001.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008087555/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01382. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080100267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Grandecran Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 85.416.
Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
86316
Luxembourg, le 10/07/2008.
<i>Pour GRANDECRAN HOLDING SA
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature
Référence de publication: 2008087548/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01884. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080100290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Grandecran Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 85.416.
Les comptes annuels au 31/12/2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/07/2008.
<i>Pour GRANDECRAN HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature
Référence de publication: 2008087549/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01883. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080100288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Nebis Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 113.146.
Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/07/2008.
<i>Pour NEBIS HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature
Référence de publication: 2008087550/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01882. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080100287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Euro Investment and Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 88.222.
Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/07/2008.
<i>Pour EURO INVESTMENT AND FINANCE S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature
Référence de publication: 2008087551/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01881. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080100285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
86317
Euro Investment and Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 88.222.
Les comptes annuels au 31/12/2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/07/2008.
<i>Pour EURO INVESTMENT AND FINANCE S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature
Référence de publication: 2008087552/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01880. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080100283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
TOA (Lux) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 81.428.
Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/07/2008.
<i>Pour TOA (LUX) S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature
Référence de publication: 2008087553/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01879. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080100274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Pharmacopole S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3345 Leudelange, 15, rue Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg B 57.365.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 juillet 2008.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2008087556/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01432. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080099925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Supreme Entertainment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 116.232.
Constituée par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date
du 26 avril 2006, acte publié au Mémorial C n° 1338 du 11 juillet 2006. Les statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois par-devant le même notaire en date du 20 mars 2008, acte publié au Mémorial C
n° 1031 du 25 avril 2008.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
86318
<i>Pour SUPREME ENTERTAINMENT S.A.
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008087707/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01691. - Reçu 60,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080100612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Eurimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 29.108.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 juillet 2008.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2008087557/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01425. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080099922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Famby International, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 55.372.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 juillet 2008.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2008087558/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01423. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080099914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Xelex, Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 106.916.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WILTZ, le 08/07/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008087600/825/12.
Enregistré à Diekirch, le 4 juillet 2008, réf. DSO-CS00033. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080099896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Probat S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 56.079.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
86319
Luxembourg, le 09 juillet 2008.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2008087560/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01420. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080099912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Tialma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 116.094.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 juillet 2008.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2008087561/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01415. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080099908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Finpromotion International Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 97.124.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 juillet 2008.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2008087562/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01414. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080099905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Hoxton, Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 127.139.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WILTZ, le 08/07/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008087601/825/12.
Enregistré à Diekirch, le 3 juillet 2008, réf. DSO-CS00030. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080099898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Delucs S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 116.271.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
86320
Luxembourg, le 09 juillet 2008.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2008087563/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01412. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080099902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Wandpark Gemeng Hengischt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 2, Kierchestrooss.
R.C.S. Luxembourg B 106.804.
Da die Straßennahmen in der Gemeinde Heinerscheid geändert haben, lautet die Adresse des Sitzes der Gesellschaft
(siège social): 2, Kierchestroos, L-9753 Heinerscheid.
Aus dem gleichen Grund lautet die Privatadresse von Herrn Norbert SCHRUPPEN, Verwaltungsratsmitglied (admi-
nistrateur), wie folgt: 17, Buregaass, L-9753 Heinerscheid.
<i>WANDPARK GEMENG HENGISCHT S.A.
i>Unterschrift
Référence de publication: 2008087571/2480/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07583. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080099954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Wandpark Gemeng Hengischt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 2, Kierchestrooss.
R.C.S. Luxembourg B 106.804.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 10.07.2008.
<i>WANDPARK GEMENG HENGISCHT S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008087573/2480/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07585. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080099951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Wandpark Kehmen-Heischent S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9140 Bourscheid, 1, Schlasswee.
R.C.S. Luxembourg B 98.060.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 10.07.2008.
<i>WANDPARK KEHMEN-HEISCHENT S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008087574/2480/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07582. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080099948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
86321
CEREP Cheapside S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 94.706.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
52262 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Joseph ELVINGER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087406/211/11.
(080100141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
GSW-Wolff-Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 106.945.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 8 juillet 2008.
Paul BETTINGEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087394/202/12.
(080100326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
CERE II B Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.155,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 122.262.
In the year two thousand and eight, on the eighteenth of June,
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CERE II B Co-Invest S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 122.262, incor-
porated by a deed drawn up by Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, on 17 November 2006 and
whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations (the "Mémorial") number 114, dated on 5 February 2007, page 5432. Since the incorporation of the Company, the
Articles have been amended several times and for the last time on 31 May 2007, pursuant to a deed drawn up by Maître
Joseph Elvinger, prenamed, and published in the Mémorial number 2717, dated on 26 November 2007, page 130404.
The meeting elects as president Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Régis Galiotto, jurist, professionally, residing
in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the
proxies signed "ne varietur" will be registered with this deed.
II. It appears from the attendance list that all the 433 shares, representing the entirety of the share capital of the
Company are represented in this extraordinary general meeting. All the shareholders declare having been informed in
advance of the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities, the meeting is thus regularly
constituted and can validly deliberate and decide on the aforementioned agenda of the meeting.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. To resolve to increase the Company's share capital by an amount of six thousand four hundred and ninety-five
British Pounds (GBP 6,495.-) so as to bring the share capital from its current amount of eight thousand six hundred and
sixty British Pounds (GBP 8,660.-) to fifteen thousand one hundred and fifty-five British Pounds (GBP 15,155.-) by changing
86322
the nominal value of the existing shares from twenty British Pound (GBP 20.-) per share to thirty-five British Pounds (GBP
35.-) per share.
2. To resolve to amend article 5.1 of the Company's articles of association in order to reflect the share capital increase
3. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolution was taken unanimously by the general meeting of the unitholders of the
Company:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to increase the Company's share capital by an amount of six thousand four hundred and
ninety-five British Pounds (GBP 6,495.-) so as to bring the share capital from its current amount of eight thousand six
hundred and sixty British Pounds (GBP 8,660.-) to fifteen thousand one hundred and fifty-five British Pounds (GBP
15,155.-) by changing the nominal value of the existing shares from twenty British Pound (GBP 20.-) per share to thirty-
five British Pounds (GBP 35.-) per share.
The contribution of each shareholder will be as follows:
a) Six thousand four hundred and eighty British Pounds (GBP 6,480.-) will be paid by Carlyle Europe Real Estate Master
Co-Investment II B, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the State of Delaware, having its registered
office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of
New Castle, Delaware 19801, USA and registered with the Delaware Division of Corporation under number 4252520,
duly represented by Flora Gibert prenamed by virtue of a proxy, to participate in the unit capital increase; and
b) Fifteen British Pounds (GBP 15.-) will be paid by CERE II B Co-Invest Finance S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 122.282, duly
represented by Flora Gibert prenamed by virtue of a proxy, to participate in the unit capital increase.
Therefore, the global contribution of six thousand four hundred and ninety-five British Pounds (GBP 6,495.-) (the
"Contribution") for the new shares will be entirely allocated to the share capital.
The proof of the existence and of the value of the Contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above-mentioned resolution, article 5.1 of the Articles of the Company is amended and now
reads as follows:
" Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at fifteen thousand one hundred and fifty-five British Pounds (GBP 15,155.-), repre-
sented by four hundred and thirty-three (433) shares of thirty-five British Pounds (GBP 35.-) each (hereafter referred to
as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders"."
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred Euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, said proxyholder of the appearing persons signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le dix-huit juin,
Par-devant M
e
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,
S'est réunie l'assemblée générale des associés de CERE II B Co-Invest S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
constituée et régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 122.262 et constituée selon un acte dressé par M
e
Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 17
novembre 2006, et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
"Mémorial") numéro 114, en date du 5 février 2007, page 5432. Depuis la constitution de la Société, les Statuts ont été
modifies plusieurs fois et pour la dernière fois le 31 mai 2007, selon un acte dressé par Maître Joseph Elvinger, prénommé,
et publié au Mémorial numéro 2717, en date du 26 novembre 2007, page 130404.
L'assemblée est présidée par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.
86323
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme Régis Galiotto, juriste, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence signée par les associés ou leurs mandataires, par le bureau de l'assemblée et le notaire. Cette liste et les
procurations, une fois signées ne varietur, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 433 parts sociales représentant l'intégralité du capital social sont repré-
sentées à la présente assemblée. Tous les associés déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de
l'assemblée et renoncer aux exigences et formalités de la convocation. L'assemblée est donc régulièrement constituée
et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- L'ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décider d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de six mille quatre cent quatre-vingt
quinze Livres Sterling (GBP 6.495-) afin de le porter de son montant actuel de huit mille six cent soixante Livres Sterling
(GBP 8.660-) à quinze mille cent cinquante-cinq Livres Sterling (GBP 15.155-) en changeant la valeur nominale des Parts
Sociales existantes de vingt Livre Sterling (GBP 20-) à trente-cinq Livres Sterling (GBP 35-) par Part Sociale.
2. Décider de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital.
3. Divers.
Après délibération, l'assemblée générale des associés de la Société a décidé à l'unanimité de prendre les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de six mille quatre cent
quatre-vingt quinze Livres Sterling (GBP 6.495-) afin de le porter de son montant actuel de huit mille six cent soixante
Livres Sterling (GBP 8.660-) à quinze mille cent cinquante-cinq Livres Sterling (GBP 15.155-) en changeant la valeur
nominale des Parts Sociales existantes de vingt Livre Sterling (GBP 20-) à trente-cinq Livres Sterling (GBP 35-) par Part
Sociale.
La contribution de chaque associé sera la suivante:
a) Six mille quatre cent quatre-vingt Livres Sterling (GBP 6.480-) seront payées par Carlyle Europe Real Estate Master
Co-Investment II B, L.P., un limited partnership constitué selon les lois de l'état du Delaware, ayant son siège social à c/
o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle,
Delaware 19801, USA et immatriculé auprès de la Delaware Division of Corporation sous le numéro 4252520, dûment
représentée par Flora Gibert, prénommée en vertu d'une procuration, pour participer à l'augmentation de capital; et
b) Quinze Livres Sterling (GBP 15-) seront payées par CERE II B Co-Invest Finance S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, im-
matriculée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 122.282, dûment représenté par Flora
Gibert prénommée en vertu d'une procuration, pour participer à l'augmentation de capital.
L'apport total de six mille quatre cent quatre-vingt quinze Livres Sterling (GBP 6.495-) sera entièrement alloué au
capital social de la Société.
Les documents justificatifs de l'existence et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.
<i>Seconde résolutioni>
Les associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:
" Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à quinze mille cent cinquante-cinq Livres Sterling (GBP 15.155-) représenté par quatre
cent trente-trois (433) parts sociales d'une valeur nominale de trente-cinq Livres Sterling (GBP 35-) chacune (ci-après
définies comme les "Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales sont désignés ensemble comme les "Associés"."
<i>Frais et dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à mille trois cents Euro.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des personnes comparantes, connue du notaire instru-
mentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des personnes comparantes a signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: F. GIBERT, R. GALIOTTO, J. ELVINGER.
86324
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 juin 2008. Relation: LAC/2008/25177. — Reçu quarante euros et quatre-vingt-
quatorze cents (40,94.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008087256/211/150.
(080100250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
The World Trust Fund, Société d'Investissement à Capital Fixe.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 37.154.
In the year two thousand and eight, on the twenty-seventh day of June,
before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of THE WORLD TRUST FUND (the "Fund" or the
"Corporation"), a "société anonyme d'investissement" having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed
of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on the 20th of June 1991, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations of the 14th of August 1991, number 313.
The articles of incorporation of the Corporation were amended from time to time and for the last time by deed of
the undersigning notary on the 21st of June 2002 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of
the 12th of September 2002, number 1325.
The meeting was presided by Jean Faucher, employee, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Dounia Zeroual, employee, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as scrutineer Jean-Baptiste Simba, employee, residing in Luxembourg.
I. The agenda of the meeting is the following:
THAT:
(1) the Fund's share capital be reduced by cancelling all of the Ordinary Shares (i.e. three million one hundred and
seventy thousand and three (3,170,003 shares) held by the Fund in treasury and that paragraph 2 in Article 5 of the Fund's
articles of incorporation (the "Articles") be altered accordingly to reflect the reduction of share capital to the following:
"The Corporation has an issued capital of twelve million three hundred and twenty-three thousand and four hundred
seventy United State Dollars (USD 12,323,470) consisting of six million one hundred and sixty- one thousand and seven
hundred and thirty-five (6,161,735) shares of a par value of two United States Dollars (USD 2,-) each."
(2) second paragraph of Article 20 of the Articles be amended so as to be read as follows:
"Repurchases made pursuant to these articles may be made through, any stock exchange, over-the-counter market
or other regulated market on which the shares in the Corporation are listed or dealt in and at a price calculated in
accordance with any applicable binding rule of such stock exchange or market or any other methodology as deemed
appropriate by the Fund but (i) not exceeding the Net Asset Value per share as determined pursuant to article 22 hereof
and (ii) being not less than the par value of the shares."
(3) - Article 2 of the Articles be amended by the deletion of the two last sentences.
- Article 3, second paragraph, of the Articles be amended by the replacement of the reference to the law of 30th March
1988 regarding collective investment undertakings by the reference to the law of 201 December 2002 regarding collective
investment undertakings.
- Article 4, first paragraph, of the Articles be amended by the insertion of the following wording at the end of the text:
"If and to the extent permitted by law, the Board of Directors may decide to transfer the registered office to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg."
- Article 10, fourth paragraph, of the Articles be amended by the insertion of the following wording after the word
"telex":
"or any other electronic means capable of evidencing such proxy form. Such proxy shall be valid for any reconvened
meeting, unless it specifically revoked. At the Board of Directors' discretion, a shareholder may also participate at any
meeting of shareholders by videoconference, of any other means of telecommunication, allowing to identify such share-
holders. Such means must satisfy technical characteristics which ensure an effective participation in the meeting whose
deliberations shall be online without interruption."
- Article 10, fifth paragraph of the Articles be amended by the replacement of the wording "those present and voting"
by the following wording: "the votes cast. Votes cast shall not include votes in relation to shares represented at a meeting
but in respect of which shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid
vote".
86325
- Article 10, last paragraph, of the Articles be amended by the insertion of the following wording at the end of the
paragraph:
"and for proxies to be validly taken into consideration."
- Article 13, first paragraph, first sentence, of the Articles be amended by the replacement of the word "may" by the
word "shall".
- Article 13, fifth paragraph, second sentence, of the Articles be amended so as to read as follows:
"This notice may be waived by the consent of each Director in writing or by fax, cable, telegram, telex or any other
electronic means capable of evidencing such waiver."
- Article 13, sixth paragraph of the Articles be amended so as to read as follows:
"Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram,
telex or any other electronic means capable of evidencing such proxy, another Director as his proxy. Directors may also
assist at any meeting of the Board of Directors and any meeting of the Board of Directors may be held by telephone link
or telephone conference. A Director may also participate at any meeting of the Board of Directors by videoconference
or any other means of telecommunication, allowing to identify such Director. Such means must allow the Director to
effectively act at such meeting of the Board of Directors, the proceedings of which must be retransmitted continuously
to such Director."
- Article 13, seventh paragraph, first sentence, of the Articles be amended so as to read as follows:
"The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors is present or represented
at the meeting of the Board of Directors."
- Article 13, eighth paragraph, of the Articles be amended by the deletion of the following wording:
"and provided further that no Director shall act in his capacity as such within the United States".
- Article 19, first paragraph, of the Articles be amended by the replacement of the reference to the law of 30th March
1988 regarding collective investment undertakings by the reference to the law of 20th December 2002 regarding collective
investment undertakings.
- Article 29 of the Articles be amended by the replacement of the reference to the law of 30th March 1988 regarding
collective investment undertakings by the reference to the law of 20th December 2002 regarding collective investment
undertakings.
(4) the Fund be authorised to make market purchases of up to 10 per cent, of the Fund's subscribed capital at a price
calculated in accordance with the Articles provided that:
(i) the maximum number of Ordinary Shares hereby authorised to be so acquired is 616,173 shares;
(ii) the minimum price, exclusive of expenses, which may be paid for such Ordinary Shares is USD 2.00 each;
(iii) the maximum price, exclusive of expenses, which may be paid for a share contracted to be purchased on any day,
to be an amount not exceeding the NAV as determined pursuant to article 22 of the Articles, and in any case not more
than the higher of:
(a) five per cent, above the average of the middle market quotations for the ordinary shares of the Fund as taken from
the London Stock Exchange Daily Official List for the five business days immediately preceding the day on which such
share is contracted to be purchased; and
(b) the higher of (1) the price of the last independent trade in ordinary shares of the Fund; and (2) the highest current
independent bid relating thereto on the trading venue where the purchase is carried out;
(iv) the authority hereby conferred shall expire at the conclusion of the annual general meeting of the Fund to be held
in 2009; and
(v) the Fund may make a contract to purchase its own shares under the authority hereby conferred prior to the expiry
of such authority and may make a purchase of its own shares in pursuance of any such contract.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed. The
proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
This meeting was convened by convening notices sent by registered mail to the shareholders on 26 May 2008.
III. Resolutions 1, 2 and 3 require the holders of 50 per cent, of the issued Ordinary Shares to be present (by person
or by proxy) for the meeting to be quorate and then a majority of two-thirds of the votes cast in favour in order to be
passed. Resolution 4 requires no quorum and then a simple majority of the votes cast in favour in order to be passed.
IV. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that out of 6,161,735 outstanding shares, 1,343,781 shares
are duly represented at the present meeting and in consideration of the agenda and of the provisions of article 67 and
67-1 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended, the present meeting is not validly constituted
to deal with items 1, 2 and 3 on the agenda and is accordingly not authorized to deliberate on those items for lack of
quorum. It is therefore required to convene a second extraordinary general meeting to be held on 31 July 2008 by way
of the notices provided by law.
V. As no quorum is required with regard to resolution 4, the latter may be resolved upon at this meeting.
86326
<i>Resolutioni>
The meeting by all votes in favour and none vote against decides that the Fund be authorised to make market purchases
of up to 10 per cent, of the Fund's subscribed capital at a price calculated in accordance with the Articles provided that:
(i) the maximum number of Ordinary Shares hereby authorised to be so acquired is 616,173 shares;
(ii) the minimum price, exclusive of expenses, which may be paid for such Ordinary Shares is USD 2.00 each;
(iii) the maximum price, exclusive of expenses, which may be paid for a share contracted to be purchased on any day,
to be an amount not exceeding the NAV as determined pursuant to article 22 of the Articles, and in any case not more
than the higher of:
(a) five per cent, above the average of the middle market quotations for the ordinary shares of the Fund as taken from
the London Stock Exchange Daily Official List for the five business days immediately preceding the day on which such
share is contracted to be purchased; and
(b) the higher of (1) the price of the last independent trade in ordinary shares of the Fund; and (2) the highest current
independent bid relating thereto on the trading venue where the purchase is carried out;
(iv) the authority hereby conferred shall expire at the conclusion of the annual general meeting of the Fund to be held
in 2009; and
(v) the Fund may make a contract to purchase its own shares under the authority hereby conferred prior to the expiry
of such authority and may make a purchase of its own shares in pursuance of any such contract.
There being no further item on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
name, civil status and residences, the chairman, the secretary and the scrutineer signed together with Us, notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le vingt-sept juin,
par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société THE WORLD TRUST FUND (le "Fonds"
ou la "Société"), une société anonyme d'investissement avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 20 juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations du 14 août 1991, numéro 313.
Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 21 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12 septembre 2002,
numéro 1325.
L'assemblée a été présidée par Jean Faucher, employé, demeurant à Luxembourg.
Le Président a désigné comme secrétaire Dounia Zeroual, employé, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée a élu comme scrutateur Jean-Baptiste Simba, employé, demeurant à Luxembourg.
I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
QUE:
(1) le capital social du Fonds soit réduit par l'annulation de toutes les Actions Ordinaires (i.e. trois millions cent
soixante-dix mille trois actions (3.170.003 actions) détenues par le Fonds en trésorerie et que le paragraphe 2 de l'Article
5 des statuts du Fonds (les "Statuts") soit modifié en conséquence de manière à refléter la réduction du capital social
comme suit:
"La Société a un capital émis de douze millions trois cent vingt-trois mille quatre cent soixante-dix dollars des Etats-
Unis d'Amérique (USD 12.323.470) représenté par six millions cent soixante-et-un mille sept cent trente-cinq (6.161.735)
actions d'une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (USD 2,-) chacune."
(2) le deuxième paragraphe de l'article 20 des statuts soit modifié de manière à le lire comme suit:
"Les rachats effectués suivant les présents statuts peuvent être effectués par l'intermédiaire d'une bourse, d'un marché
de gré à gré ou de tout autre marché réglementé sur lequel les actions de la Société sont cotées ou négociées à un prix
calculé conformément à toute règle contraignante applicable d'une telle bourse ou marché ou toute autre méthodologie
jugée appropriée par le Fonds mais (i) n'excédant pas la Valeur Nette d'Inventaire par action telle que déterminée con-
formément à l'article 22 ci-après et (ii) n 'étant pas moins que la valeur nominale des actions."
(3) - L'article 2 des Statuts soit modifié par la suppression des deux dernières phrases.
86327
- Le deuxième paragraphe de l'article 3 des Statuts soit modifié par le remplacement de la référence à la loi du 30 mars
1988 concernant les organismes de placement collectif par la référence à la loi du 20 décembre 2002 relative aux orga-
nismes de placement collectif.
- Le premier paragraphe de l'article 4 des Statuts soit modifié par l'insertion du texte suivant à la fin de celui-ci:
"Si et dans la mesure permise par la loi, le Conseil d'Administration peut décider de transférer le siège social à tout
autre endroit au Grand-duché du Luxembourg."
- Le quatrième paragraphe de l'article 10 des Statuts soit modifié par l'insertion de ce qui suit après le mot "télex": "ou
tout autre moyen électronique susceptible de prouver une telle procuration. Cette procuration sera valable pour toute
assemblée reconvoquée, à moins qu'elle ait été spécifiquement révoquée. A la discrétion du Conseil d'Administration, un
actionnaire peut participer à toute assemblée des actionnaires par vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécom-
munication, permettant de l'identifier. Ces moyens doivent satisfaire des caractéristiques techniques qui assurent une
participation effective à l'assemblée dont les délibérations doivent être retransmises en ligne sans interruption."
- Le cinquième paragraphe de l'article 10 des Statuts soit modifié par le remplacement du libellé "ceux présents et
votant" par le texte suivant:
"les votes exprimés. Les votes exprimés n 'incluront pas les votes en relation avec des actions représentées à une
assemblée pour lesquelles les actionnaires n 'ont pas pris part au vote ou se sont abstenus, ou ont voté blanc ou nul."
- Le dernier paragraphe de l'article 10 des Statuts soit modifié par l'insertion du texte suivant à la fin du paragraphe:
"et pour que des procurations puissent être valablement prises en considération."
- La première phrase du premier paragraphe de l'article 13 des Statuts soit modifiée par le remplacement de l'expres-
sion "pourra choisir"
par "choisira".
- La deuxième phrase du cinquième paragraphe de l'article 13 des Statuts soit modifiée de manière à la lire comme
suit:
"Chaque administrateur pourra renoncer à ce préavis par écrit ou par fax, câble, télégramme, télex ou tout autre
moyen électronique susceptible de prouver une telle renonciation."
- Le sixième paragraphe de l'article 13 des Statuts soit modifié de manière à le lire comme suit:
"Tout administrateur peut agir à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou par fax, câble,
télégramme, télex ou tout autre moyen électronique susceptible de prouver une telle procuration, un autre Administra-
teur comme son mandataire. Les Administrateurs peuvent aussi assister à toute réunion du Conseil d'Administration et
toute réunion du Conseil d Administration peut être tenue par téléphone ou par conférence téléphonique. Un Adminis-
trateur peut aussi participer à toute réunion du Conseil d'Administration par vidéoconférence ou tout autre moyen de
télécommunication permettant de l'identifier. De tels moyens doivent permettre à l'Administrateur d'agir effectivement
à une telle réunion du Conseil d'Administration dont le contenu doit être retransmis de manière continue à l'Adminis-
trateur."
- La première phrase du septième paragraphe de l'article 13 des Statuts soit modifiée de manière à la lire comme suit:
"Le Conseil d'Administration peut délibérer ou agir valablement si au moins la majorité des Administrateurs est présent
ou représentée à la réunion du Conseil d'Administration."
- Le huitième paragraphe de l'article 13 des Statuts soit modifié par la suppression du texte suivant:
"étant entendu cependant qu'aucun Administrateur ne peut agir comme décrit ci-avant aux Etats-Unis."
- Le premier paragraphe de l'article 19 des Statuts soit modifié par le remplacement de la référence à la loi du 30 mars
1988 relative aux organismes de placement collectif par la référence à la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes
de placement collectif.
- L'article 29 soit modifié par le remplacement de la référence à la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de
placement collectif par la référence à la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.
(4) Le Fonds soit autorisé à procéder à des rachats sur le marché jusqu'à 10 pour cent de son capital souscrit à un
prix calculé conformément avec les Statuts pour autant que:
(i) le nombre maximum d'actions ordinaires pouvant être acquis est de 616,173 actions;
(ii) le prix minimum, hors frais, qui peut être payé pour de telles Actions Ordinaires, est de 2 dollars américains chacune;
(iii)le prix maximum, hors frais, qui peut être payé pour une action devant être achetée un jour donné, doit être un
montant n'excédant pas la VNI telle que déterminées selon l'article 22 des Statuts et en toute hypothèse pas plus que le
plus élevé de:
(a) cinq pour cent au-dessus de la moyenne des cotations sur le marché des entreprises moyennes pour les actions
ordinaires du Fonds telles que fournies par la Liste Officielle Quotidienne de la Bourse de Londres pendant les cinq jours
ouvrables immédiatement précédant le jour où l'action fait l'objet d'un contrat d'achat; et
(b) le plus élevé (1) de la dernière transaction indépendante sur les actions ordinaires du Fonds; et (2) le prix de vente
indépendant actuel le plus élevé sur le lieu de transaction où l'achat est effectué;
(iv) l'autorisation conférée expirera à la fin de l'assemblée générale ordinaire du Fonds devant avoir lieu en 2009; et
86328
(v) le Fonds peut passer un contrat pour acheter ses propres actions sur la base de la présente autorisation avant
l'expiration de cette dernière et peut faire un achat de ses propres actions en vertu de tout contrat quelconque.
II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur
une liste de présence signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. La liste de présence, ainsi
que les procurations demeurent jointes à ce document.
III. Pour être adoptées, les résolutions 1, 2 et 3 requièrent qu'un quorum de 50 pour cent des détenteurs d'Actions
Ordinaires émises soit présent (en personne ou par procuration) à l'assemblée et une majorité des deux-tiers des voix
exprimées en faveur. La résolution 4 n'exige aucun quorum et une majorité simple des voix exprimées en faveur pour
être adoptée.
IV. Il résulte de la liste de présence mentionnée ci-dessus que, des 6.161.735 actions en circulation, 1.343.781 actions
sont représentées à la présente assemblée et que, en considération de l'ordre du jour et des dispositions de l'article 67
et 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, la présente assemblée n'est pas
valablement constituée pour se prononcer sur les points 1, 2 et 3 de l'ordre du jour et, par conséquent, n'est pas autorisée
à délibérer sur ces points de l'ordre du jour pour défaut de quorum. Il est donc nécessaire de convoquer une deuxième
assemblée générale extraordinaire le 31 juillet 2008 par des avis tels que prévus par la loi.
V. Etant donné qu'aucun quorum n'est requis concernant le point 4, ce dernier peut être voté lors de la présente
assemblée.
<i>Résolutioni>
L'assemblée, par tous les votes pour et aucun vote contre, décide que le Fonds soit autorisé à procéder à des rachats
sur le marché jusqu'à 10 pour cent de son capital souscrit à un prix calculé conformément avec les Statuts pour autant
que:
(i) le nombre maximum d'actions ordinaires pouvant être acquis est de 616.173 actions;
(ii) le prix minimum, hors frais, qui peut être payé pour de telles Actions Ordinaires, est de 2 dollars américains chacune;
(iii) le prix maximum, hors frais, qui peut être payé pour une action devant être achetée un jour donné, doit être un
montant n'excédant pas la VNI telle que déterminées selon l'article 22 des Statuts et en toute hypothèse pas plus que le
plus élevé de:
(a) cinq pour cent au-dessus de la moyenne des cotations sur le marché des entreprises moyennes pour les actions
ordinaires du Fonds telles que fournies par la Liste Officielle Quotidienne de la Bourse de Londres pendant les cinq jours
ouvrables immédiatement précédant le jour où l'action fait l'objet d'un contrat d'achat; et
(b) le plus élevé (1) de la dernière transaction indépendante sur les actions ordinaires du Fonds; et (2) le prix de vente
indépendant actuel le plus élevé sur le lieu de transaction où l'achat est effectué;
(iv) l'autorisation conférée expirera à la fin de l'assemblée générale ordinaire du Fonds devant avoir lieu en 2009; et
(v) le Fonds peut passer un contrat pour acheter ses propres actions sur la base de la présente autorisation avant
l'expiration de cette dernière et peut faire un achat de ses propres actions en vertu de tout contrat quelconque.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Jean Faucher, Dounia Zeroual, Jean-Baptiste Simba, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1
er
juillet 2008. LAC/2008/26714. - Reçu € 12.- (douze euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 7 juillet 2008.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2008086949/202/266.
(080099048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2008.
Kamea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 95.359.
L'an deux mille huit, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussi-
gnée.
86329
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KAMEA S.A.", ayant son siège
social à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg section B numéro 95.359, constituée suivant
acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 août 2003, publié au Mémorial C
numéro 983 du 24 septembre 2003.
L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutatrice, Madame Sylvie DUPONT, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Monsieur le président déclare et requiert le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste
de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être sou-
mises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Annulation des catégories d'administrateur A et B de la Société et modification en conséquence de l'article 5 des
statuts;
2) Acceptation de la démission d'un administrateur;
3) Nomination d'un nouvel administrateur;
4) Divers.
IV. Que la présente assemblée représentant la totalité du capital social est régulièrement constituée et pourra vala-
blement délibérer suivant l'ordre du jour.
Après avoir discuté de ces motifs et après avoir dûment délibéré, l'assemblée, à l'unanimité, décide des résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'annuler les catégories d'administrateur A et B de la Société et décide en conséquent
de modifier l'article 5, dernier paragraphe des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 5. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques."
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée accepte la démission de:
- Madame CAFISSI Simonetta
avec effet immédiat et l'assemblée lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée nomme Monsieur Vincent WILLEMS, employé privé, né à Liège le 30 septembre 1975, demeurant pro-
fessionnellement à 1510 - Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie, comme nouvel Administrateur de la Société.
Son mandat prendra fin à l'issu de l'assemblée générale annuelle de 2009
En conséquent, le Conseil d'Administration est désormais constitué comme suit:
- Monsieur Riccardo MORALDI;
- Monsieur Andrea DE MARIA;
- Mademoiselle Annalisa CIAMPOLI;
- Monsieur Vincent WILLEMS.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à neuf cents euros (900.- EUR) sont à charge de la
Société.
86330
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,
prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Thill, C. Petit, S. Dupont et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juin 2008. LAC/2008/26230. - Reçu douze euros (12.- €).
<i>Le receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008087296/5770/73.
(080100040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Magnisense, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 122.697.
In the year two thousand and eight, on the tenth of June.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
1) MIRA CETI LTD, a limited liability company organized and registered under the laws of the Island of Bermuda, with
registered office at Milner House, 18, Parliament Street, Hamilton HM12 Bermuda, registered at the Commercial Register
of Bermuda under the number 33.589,
2) ALSTONIA INVESTMENTS LIMITED, a limited liability company incorporated under the laws of the British Virgin
Islands, with registered office at Mill Mall, Road Town, Tortola, BVI, registered at the Commercial Register of the British
Virgin Islands under the number 189.184,
both here represented by Mr Keimpe REITSMA, private employee, with professional address at 66, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg,
by virtue of proxies given in a shareholder's meeting held on April 7, 2008.
A copy of the said meeting after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Said appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
- The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company ("société à responsabilité
limitée") existing under the name of "MAGNISENSE", R.C. B Number 122 697, with registered office in Luxembourg,
transferred from the British Virgin Islands to Luxembourg, pursuant to a deed of Maître Paul DECKER, then residing in
Luxembourg-Eich, dated December 11, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number
186 of February 15, 2007.
- The Company's capital is set at thirty-seven thousand (37,000.-) euro (EUR), represented by five hundred (500) shares
of a par value of seventy-four (74.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.
- The agenda is worded as follows:
1. Change of the par value of the shares from EUR 74.- to EUR 0.74 by correspondent increase of the number of
shares from 500 to 50,000.
2. Increase of the capital of the company by an amount of 11,470.- euro so as to bring it from its present amount of
37,000.- euro to 48,470.- euro by the issue of 15,500 new shares of a par value of 0.74. euro each.
3. Subscription of the new shares by different subscribers and payment of the new shares by the contribution in kind
consisting of loans of the subscribers against the company.
4. Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation.
The shareholders then passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The par value of the shares is changed from EUR 74.- to EUR 0.74 by correspondent increase of the number of shares
from 500 to 50,000.-.
<i>Second resolutioni>
The corporate capital of the Company is increased by eleven thousand four hundred and seventy (11,470.-) euro so
as to raise it from its present amount of thirty-seven thousand (37,000.-) euro to forty-eight thousand four hundred and
seventy (48,470.-) euro by the creation and issue of fifteen thousand five hundred (15,500) new shares of a par value of
zero point seventy-four (0.74) euro each.
86331
The new shares have been entirely subscribed and paid-up in the following manner:
- 6,750 shares by PROVESTIS SAS, a partnership organized and registered under the laws of France, with registered
office at 26, avenue des Tilleuls, Chatou 78400 France, registered as Versailles RCS 479 041 824, paid-up by a contribution
in kind consisting of a loan against MAGNISENSE in an amount of EUR 1,350,000.-, of which an amount of EUR 4,995 is
allocated to the capital, the remaining amount being EUR 1,345,005.- is allocated to a share premium.
- 750 shares by Mr Jacques WENIG, accountant, residing in 24, avenue de Suffren, F-75015 Paris, France, paid-up by
a contribution in kind consisting of a loan against MAGNISENSE in an amount of EUR 150,000.-, of which an amount of
EUR 555.- is allocated to the capital, the remaining amount being EUR 149,445.- is allocated to a share premium.
- 2,500 shares by GERMEX Ltd, a company organized and registered under the laws of the Cayman Islands, with
registered office at Windward 1, 2nd Floor, regatta Office Park, West Bay Road, P.O. Box 31106 SMB Grand Cayman,
Cayman Islands, British West Indies, registered under the number CC 167624, paid-up by a contribution in kind consisting
of a loan against MAGNISENSE in an amount of EUR 500,000.-, of which an amount of EUR 1,850.- is allocated to the
capital, the remaining amount being EUR 498,150.- is allocated to a share premium.
- 500 shares by Mr Michel FEDOROFF, businessman, residing in 74, boulevard d'Italie, 98000 Monaco, paid-up by a
contribution in kind consisting of a loan against MAGNISENSE in an amount of EUR 100,000.-, of which an amount of
EUR 370.- is allocated to the capital, the remaining amount being EUR 99,630.- is allocated to a share premium.
- 2,000 shares by MIRA CETI Ltd, a company organized and registered under the laws of Bermuda, with registered
office at Milner House, 18, Parliament Street, Hamilton HM12 Bermuda, registered at the Commercial Register of Ber-
muda under the number 33.589, paid-up by a contribution in kind consisting of a loan against MAGNISENSE in an amount
of EUR 400,000.-, of which an amount of EUR 1,480.- is allocated to the capital, the remaining amount being EUR 398,520.-
is allocated to a share premium.
- 500 shares by NORMAFIN S.à r.l., a company organized and registered under the laws of France, with registered
office at 29, rue des Gravilliers, F-75003 Paris, registered at the Commercial Register of Paris under the number 485 137
202, paid-up by a contribution in kind consisting of a loan against MAGNISENSE in an amount of USD 60,000.-, corre-
sponding at a rate of conversion of 1EUR=1.5466 USD, to EUR 38,794.77 of which an amount of EUR 370.- is allocated
to the capital, the remaining amount being EUR 38,424.77 is allocated to a share premium.
- 1,250 shares by SYNERGY ASSET MANAGEMENT, a company organized and registered under the laws of the British
Virgin Islands, with registered office at Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered at the Commercial Register
of the British Virgin Islands under the number 315417, paid-up by a contribution in kind consisting of a loan against
MAGNISENSE in an amount of EUR 250,000.-, of which an amount of EUR 925.- is allocated to the capital, the remaining
amount being EUR 249,075.- is allocated to a share premium.
- 1,250 shares by CHUKKAS TRUST, a settlement made under the laws of the Republic of Cyprus, with registered
office in Limassol, paid-up by a contribution in kind consisting of a loan against MAGNISENSE in an amount of EUR
250,000.-, of which an amount of EUR 925.- is allocated to the capital, the remaining amount being EUR 249,075.- is
allocated to a share premium.
The reality and value of the different loans has been proved to the undersigned notary by a declaration signed by the
two directors of MAGNISENSE on June 2, 2008 and by a balance sheet of the company as at December 31, 2007.
Such declaration and balance sheet, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
As a consequence of this increase of capital, Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth
have the following wording:
" Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at forty-eight thousand four hundred and seventy (48,470.-)
euro (EUR), represented by sixty-five thousand five hundred (65,500) shares of a par value of zero point seventy-four
(0.74) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up in cash or in kind."
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, this person signed together
with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille huit, le dix juin.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,
ONT COMPARU:
1) MIRA CETI LTD, une société à responsabilité limitée régie par les lois des Iles des Bermudes, et ayant son siège
social à Milner House, 18, Parliament Street, Hamilton HM12 Bermudes, inscrite au Registre de Commerce des Bermudes
sous le numéro 33 589,
86332
2) ALSTONIA INVESTMENTS LIMITED, une société à responsabilité limitée régie par les lois des Iles Vierges Britan-
niques, ayant son siège social à Mill Mall, Road Town, Tortola, BVI, inscrite au Registre des BVI sous le numéro 189.184,
toutes les deux ici représentées par Monsieur Keimpe REITSMA, employé privé, avec adresse professionnelle au 66,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
en vertu de procurations données par une assemblée en date du 7 avril 2008.
Une copie de cette assemblée, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera
annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de "MAGNI-
SENSE", R.C. B Numéro 122 697, ayant son siège social à Luxembourg, transférée des Iles Vierges Britanniques vers le
Luxembourg suivant reçu par Maître Paul DECKER, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 11 décembre 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 186 du 15 février 2007.
- Le capital social de la Société est fixé à trente-sept mille (37.000,-) euros (EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de soixante-quatorze (74,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.
- L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. Changement de la valeur nominale des parts de EUR 74,- à EUR 0,74 par augmentation correspondante du nombre
des parts de 500 à 50.000.
2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de 11.470,- euros pour le porter de son montant actuel
de 37.000,- euros à 48.470,- euros par l'émission de 15.500 nouvelles parts d'une valeur de 0,74 euros chacune.
3. Souscription des nouvelles parts par différents souscripteurs et libération des nouvelles parts par l'apport en nature
consistant en des créances des souscripteurs envers la société.
4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
Les associés ont abordé l'ordre du jour et ont pris ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La valeur nominale des parts est changée de EUR 74,- à EUR 0,74 par augmentation correspondante du nombre des
parts de 500 à 50.000.
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de onze mille quatre cent soixante-dix (11.470,-) euros
pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille (37.000,-) euros à quarante-huit mille quatre cent soixante-dix
(48.470,-) euros par la création et l'émission de quinze mille cinq cents (15.500) parts sociales nouvelles d'une valeur
nominale de zéro virgule soixante-quatorze (0,74) euros chacune.
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées de la manière suivante:
- 6.750 parts sociales par PROVESTIS SAS, un partnership constitué suivant la loi française, avec siège social au 26,
avenue des Tilleuls, Chatou 78400 France, inscrite au Registre de Commerce de Versailles sous le numéro 479 041 824,
libérées par un apport en nature d'une créance envers MAGNISENSE d'un montant de EUR 1.350.000,-, duquel un
montant de EUR 4.995,- est alloué au capital, le solde, soit EUR 1.345.005,- est alloué à une prime d'émission.
- 750 parts sociales par Monsieur Jacques WENIG, comptable, demeurant au 24, avenue de Suffren, F-75015 Paris,
France, libérées par un apport en nature d'une créance envers MAGNISENSE d'un montant de EUR 150.000,-, duquel un
montant de EUR 555,- est alloué au capital, le solde, soit EUR 149.445,- est alloué à une prime d'émission.
- 2,500 parts sociales par GERMEX Ltd, une société existent sous la loi des Iles Cayman, avec siège social au Windward
1, 2nd Floor, regatta Office Park, West Bay Road, P.O. Box 31106 SMB Grand Cayman, Cayman Islands, British West
Indies, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro CC 167624, libérées par un apport en nature d'une créance
envers MAGNISENSE d'un montant de EUR 500.000,-, duquel un montant de EUR 1.850,- est alloué au capital, le solde,
soit EUR 498.150,- est alloué à une prime d'émission.
- 500 parts sociales par Monsieur Michel FEDOROFF, entrepreneur, demeurant au 74, boulevard d'Italie, 98000 Mo-
naco, libérées par un apport en nature d'une créance envers MAGNISENSE d'un montant de EUR 100.000,-, duquel un
montant de EUR 370,- est alloué au capital, le solde, soit EUR 99.360,- est alloué à une prime d'émission.
- 2,000 parts sociales par MIRA CETI Ltd, une société de droit des Bermudes, avec siège social au Milner House, 18,
Parliament Street, Hamilton HM12 Bermudes, inscrite au Registre des Bermudes sous le numéro 33.589, libérées par un
apport en nature d'une créance envers MAGNISENSE d'un montant de EUR 400.000,-, duquel un montant de EUR 1.480,-
est alloué au capital, le solde, soit EUR 398.520,- est alloué à une prime d'émission.
- 500 parts sociales par NORMAFIN S.à r.l., une société de droit français, avec siège social au 29, rue des Gravilliers,
F-75003 Paris, inscrite au Registre de Commerce de Paris sous le numéro 485 137 202, libérées par un apport en nature
d'une créance envers MAGNISENSE d'un montant de USD 60.000,-, correspondant à un taux de conversion de
1EUR=1,5466 USD, à EUR 38.794,77 duquel un montant de EUR 370,- est alloué au capital, le solde, soit EUR 38.424,77
est alloué à une prime d'émission.
86333
- 1,250 parts sociales par SYNERGY ASSET MANAGEMENT, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec
siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre de Commerce des Iles Vierges Britan-
niques sous le numéro 315417, libérées par un apport en nature d'une créance envers MAGNISENSE d'un montant de
EUR 250.000,-, duquel un montant de EUR 925,- est alloué au capital, le solde, soit EUR 249.075,- est alloué à une prime
d'émission.
- 1,250 parts sociales par CHUKKAS TRUST, un trust constitué suivant la loi de la République de Chypre, avec siège
social à Limassol, libérées par un apport en nature d'une créance envers MAGNISENSE d'un montant de EUR 250.000,-,
duquel un montant de EUR 925,- est alloué au capital, le solde, soit EUR 249.075,- est alloué à une prime d'émission.
La réalité et la valeur des différentes créances a été prouvée au notaire instrumentaire par une déclaration en date du
2 juin 2008 signée par les deux gérants de MAGNISENSE et par un bilan de la société au 31 décembre 2007.
Ces déclaration et bilan, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront
annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.
Suite à cette augmentation du capital social, l'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-huit mille quatre cent soixante-dix (48.470,-) euros (EUR), représenté par
soixante-cinq mille cinq cents (65.500) parts sociales d'une valeur nominale de zéro virgule soixante-quatorze (0,74) euros
(EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces ou en nature."
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: K. Reitsma et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 juin 2008. LAC/2008/24741. — Reçu quinze mille cent quatre-vingt-treize euros
quatre-vingt-dix-sept cents Eur 0,50% = 15.193,97.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008087314/5770/189.
(080099827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
HEDLAND HOLDINGS S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 133.912.
Statuts coordonnés déposés au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Gérard LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087422/220/12.
(080100132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
RGI Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 244.711.818,80.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 137.391.
In the year two thousand and eight, on the sixteenth of June.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
"Stanpeak Limited", a limited liability company organized under the laws of the Republic of Cyprus, having its registered
office at Julia House, 3 Themistocles Dervis Street, Nicosia, CY-1066 Cyprus, registered with the Cyprus Trade and
Companies Register under number HE179639 ("Stanpeak Limited"),
86334
here represented by Mr Mathieu LAURENT, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Nicosia on
11 June 2008.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of "RGI Holdings (Luxembourg) S.à r.l.", a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 22, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137.391,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 20 March 2008, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations on 24 April 2008, number 1013 (hereinafter the "Company").
The appearing party, represented as above mentioned, recognised to be fully informed of the resolutions to be taken
on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To increase the Company's share capital by an amount of two hundred forty-four million seven hundred eleven
thousand eight hundred eighteen euro and eighty cents (EUR 244,711,818.80), so as to raise it from its present amount
of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to two hundred forty-four million seven hundred twenty-four
thousand three hundred eighteen euro and eighty cents (EUR 244,724,318.80) by the issue of twenty-four billion four
hundred seventy-one million one hundred eighty-one thousand eight hundred eighty (24,471,181,880) shares (hereinafter
referred as the "Shares"), having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each and having the same rights and obligations
as the existing shares.
The total contribution of one billion two hundred twenty-three million five hundred fifty-nine thousand ninety-four
euro (EUR 1,223,559,094.-) will be allocated as follows (i) two hundred forty-four million seven hundred eleven thousand
eight hundred eighteen euro and eighty cents (EUR 244,711,818.80) to the Company's share capital; (ii) nine hundred
fifty-four million three hundred seventy-six thousand ninety-three euro and thirty-two cents (EUR 954,376,093.32) to
the share premium account and (iii) twenty-four million four hundred seventy-one thousand one hundred eighty-one
euro and eighty-eight cents (EUR 24,471,181.88) to the legal reserve of the Company.
2. To reduce the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) by
the cancellation of one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares, having each a nominal value of one euro
cent (EUR 0.01), held by the Company on itself subsequently to the contribution by Stanpeak Limited of all its assets and
liabilities.
3. To amend the article 5.1 of the articles of incorporation of the Company according to the above resolutions.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of two hundred forty-four million
seven hundred eleven thousand eight hundred eighteen euro and eighty cents (EUR 244,711,818.80), so as to raise it from
its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to two hundred forty-four million seven
hundred twenty-four thousand three hundred eighteen euro and eighty cents (EUR 244,724,318.80) by the issue of twenty-
four billion four hundred seventy-one million one hundred eighty-one thousand eight hundred eighty (24,471,181,880)
shares (hereinafter referred as the "Shares"), having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each and having the same
rights and obligations as the existing shares.
The twenty-four billion four hundred seventy-one million one hundred eighty-one thousand eight hundred eighty
(24,471,181,880) new shares have been subscribed by Stanpeak Limited, prenamed, paid up by a contribution in kind
consisting in all the assets and liabilities of Stanpeak Limited.
The total contribution of one billion two hundred twenty-three million five hundred fifty-nine thousand ninety-four
euro (EUR 1,223,559,094.-) will be allocated as follows (i) two hundred forty-four million seven hundred eleven thousand
eight hundred eighteen euro and eighty cents (EUR 244,711,818.80) to the Company's share capital; (ii) nine hundred
fifty-four million three hundred seventy-six thousand ninety-three euro and thirty-two cents (EUR 954,376,093.32) to
the share premium account and (iii) twenty-four million four hundred seventy-one thousand one hundred eighty-one
euro and eighty-eight cents (EUR 24,471,181.88) to the legal reserve of the Company.
Evidence of the transfer of all assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a copy of a contribution
agreement and of a valuation report.
Said contribution agreement and valuation report, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the
appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to reduce the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500.-) by the cancellation of one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares, having each a
nominal value of one euro cent (EUR 0.01), held by the Company on itself subsequently to the contribution by Stanpeak
Limited of all its assets and liabilities.
86335
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above-mentioned resolutions, article 5 of the articles of incorporation of the Company is
amended and now reads as follows:
'' Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at two hundred forty-four million seven hundred eleven thousand eight hundred
eighteen euro and eighty cents (EUR 244,711,818.80) represented by twenty-four billion four hundred seventy-one million
one hundred eighty-one thousand eight hundred eighty (24,471,181,880) shares, having each a nominal value of one euro
cent (EUR 0.01) (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the
"Shareholders"."
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to seven thousand euro.
Insofar as:
(1) the contribution in kind consists of all the assets and liabilities constituting an entire branch of activity of a company;
(2) the contribution is made exclusively against the allotment of new shares and share premium; and
(3) all the companies enclosed have their registered office in the European Union,
such contribution qualifies under the terms of Article 4-1 of the law dated December 29th, 1971, as amended, which
provides for capital duty exemption.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le seize juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
"Stanpeak Limited", une société à responsabilité limitée régie par les lois de Chypre, ayant son siège social au Julia
House, 3 Themistocles Dervis Street, Nicosie, CY-1066 Chypre, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Chypre sous le numéro HE179639 ("Stanpeak Limited"),
ici représentée par Monsieur Mathieu LAURENT, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous
seing privé donnée à Nicosie, le 11 juin 2008.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de "RGI Holdings (Luxembourg) S.à r.l.", une société à responsabilité
limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 22, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 137.391, constituée selon un acte notarié par-devant le notaire soussigné en date du 20 mars 2008, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 24 avril 2008, numéro 1013 (ci-après la "Société").
Laquelle partie comparante, représentée comme mentionné précédemment, reconnaît avoir été pleinement informée
des résolutions devant être prises sur base de l'agenda suivant:
<i>Agenda:i>
1. Augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent quarante-quatre millions sept cent onze mille
huit cent dix-huit euros et quatre-vingt cents (EUR 244.711.818,80), afin de le porter de son montant actuel de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) jusqu'à deux cent quarante-quatre millions sept cent vingt-quatre mille trois cent
dix-huit euros et quatre-vingt cents (EUR 244.724.318,80) par l'émission de vingt-quatre milliards quatre cent soixante
et onze millions cent quatre-vingt-un mille huit cent quatre-vingt (24.471.181.880) nouvelles parts sociales d'une valeur
d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (désignées ci-après comme les "Parts Sociales").
L'apport total de un milliard deux cent vingt-trois millions cinq cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-quatorze euros
(EUR 1.223.559.094.-) est alloué comme suit (i) deux cent quarante-quatre millions sept cent onze mille huit cent dix-
huit euros et quatre-vingt cents (EUR 244.711.818,80) au capital social de la Société; (ii) neuf cent cinquante-quatre millions
trois cent soixante-seize mille quatre-vingt treize euros et trente-deux cents (EUR 954.376.093,32) au compte de prime
d'émission et (iii) vingt-quatre millions quatre-cent soixante et onze mille cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-huit
cents (EUR 24.471.181,88) à la réserve légale de la Société.
86336
2. Réduire le capital social de la Société par un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par l'annulation
d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01)
chacune, détenues par la Société en propre suite à l'apport par Stanpeak Limited de l'ensemble de ses actifs et passifs.
3. Modifier l'article 5.1 des statuts de la Société suivant les résolutions mentionnées ci-dessus.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent quarante-quatre millions
sept cent onze mille huit cent dix-huit euros et quatre-vingt cents (EUR 244.711.818,80), afin de le porter de son montant
actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) jusqu'à deux cent quarante-quatre millions sept cent vingt-quatre
mille trois cent dix-huit euros et quatre-vingt cents (EUR 244.724.318,80) par l'émission de vingt-quatre milliards quatre
cent soixante et onze millions cent quatre-vingt-un mille huit cent quatre-vingt (24.471.181.880) nouvelles parts sociales
d'une valeur d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (désignées ci-après comme les "Parts Sociales").
Les vingt-quatre milliards quatre cent soixante et onze millions cent quatre-vingt-un mille huit cent quatre-vingt
(24.471.181.880) parts sociales nouvelles sont souscrites par "Stanpeak Limited", prénommée, payées par un apport en
nature consistant en l'apport de l'ensemble du passif et de l'actif de Stanpeak Limited.
L'apport total d'un milliard deux cent vingt-trois millions cinq cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-quatorze euros
(EUR 1.223.559.094,-) est alloué comme suit (i) deux cent quarante-quatre millions sept cent onze mille huit cent dix-
huit euros et quatre-vingt cents (EUR 244.711.818,80) au capital social de la Société; (ii) neuf cent cinquante-quatre millions
trois cent soixante-seize mille quatre-vingt-treize euros et trente-deux cents (EUR 954.376.093,32) au compte de prime
d'émission et (iii) vingt-quatre millions quatre-cent soixante et onze mille cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-huit
cents (EUR 24.471.181,88) à la réserve légale de la Société.
Une copie du contrat d'apport et du rapport d'évaluation mettant en évidence le transfert de l'intégralité de l'actif et
du passif de Stanpeak Limited a été remise au notaire instrumentant.
Le contrat d'apport et le rapport d'évaluation signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le
notaire soussigné resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
L'actionnaire unique décide de réduire le capital social de la Société par un montant de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-) par l'annulation d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales, d'une valeur nominale
d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, détenues par la Société en propre suite à l'apport par Stanpeak Limited de
l'ensemble de ses actifs et passifs.
<i>Troisième résolutioni>
A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 5 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme
suit:
" Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à deux cent quarante-quatre millions sept cent onze mille huit cent dix-huit euros
et quatre-vingt cents (EUR 244.711.818,80) représenté par vingt-quatre milliards quatre cent soixante et onze millions
cent quatre-vingt-un mille huit cent quatre-vingt (24.471.181.880) parts sociales (les "Parts Sociales"), d'une valeur no-
minale d'un centime d'euro (EUR 0,01). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les "Associés"."
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à sept mille euros.
Dans la mesure où:
(1) l'apport en nature consiste dans l'intégralité de l'actif et du passif comprenant la branche d'activité d'une société;
(2) l'apport est fait exclusivement contre distribution des nouvelles part sociales et prime d'émission; et
(3) toutes les sociétés concernées ont leur siège social dans l'Union Européenne,
un tel apport entre dans le champ d'application de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, tel que modifiée, qui
prévoit l'exemption de droit d'apport.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. LAURENT, J.J. WAGNER.
86337
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 juin 2008, Relation: EAC/2008/8330. — Reçu douze Euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Belvaux, le 08 juillet 2008.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2008087317/239/186.
(080100189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
First Climate Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 139.808.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the nineteenth day of June.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
appears:
First Climate AG, having its registered office in D-61118 Bad Vilbel - Frankfurt/Main, Industriestrasse 10, recorded
with the trade register of Frankfurt/Main, Germany, under the number HRB 80.273, referred to hereafter as the "Sole
Shareholder",
here represented by Martin Schulte, director, residing professionally in D-61118 Bad Vilbel - Frankfurt/Main, Indus-
triestrasse 10,
by virtue of a proxy given under private seal in Bad Vilbel, Germany, on 10 June 2008,
which proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated above, requested the undersigned notary to draw up the articles of in-
corporation of a société anonyme as follows:
Chapter I. Name, Registered office, Object, Duration
1. Form, Name. The Company is hereby formed as a Luxembourg public limited liability company (société anonyme)
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on
commercial companies (the "1915 Law")), the amended law dated 5 April 1993 on the financial sector (the "1993 Law")
and by the present articles (the "Articles").
The Company exists under the name of First Climate Asset Management S.A.
2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Lux-
embourg).
It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the
sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting of
its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The board of directors of the Company (the "Board of Directors") is authorized to change the address of the Company
inside the municipality of the Company's registered office.
Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely
to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.
The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Object.
3.1 The Company's object is the carrying out, under any form, of the activities of a private portfolio manager within
the scope of article 24-3 of the 1993 Law, the activities of a distributor of shares within the scope of article 24-7 of the
1993 Law, the activities of a financial sector administrative agent within the scope of article 29-2 of the 1993 Law and the
activities of a corporate domiciliation agent within the scope of article 29 of the 1993 Law.
3.2 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or
operation and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its objects as well as all operations con-
nected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.
4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
86338
Chapter II. CAPITAL.
5. Capital. The subscribed capital is set at one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000), divided into twelve
thousand five hundred (12,500) registered shares with a nominal value of ten euro (EUR 10) each, fully paid up.
6. Form of the shares. The shares are in principle in registered form, or at the request of the Shareholders in bearer
form and subject to legal conditions.
7. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and
upon conditions, which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will
be charged equally on all outstanding shares, which are not fully paid up.
8. Modification of capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the
Shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.
The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.
Chapter III. Directors, Board of directors, Independent auditors
9. Board of directors or Sole Director. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board
of Directors consisting of at least three members, who need not be shareholders.
In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of
shareholders, it is established that all the shares of the Company are held by one single shareholder, the Company may
be managed by one single director (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders
acknowledging the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors
or may be the Sole Director of the Company. In such case, such legal entity must designate a permanent representative
who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its
permanent representative if it appoints its successor at the same time.
The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding
six (6) years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without any indication
on the term of his mandate, he is deemed to be elected for six (6) years from the date of his election.
In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining
Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.
10. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall elect a Chairman from among its members. The
first Chairman may be appointed by the first general meeting of Shareholders. If the Chairman is unable to be present,
he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.
The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the Directors
are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.
The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented
by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by telegram or telefax
another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed
in writing at a later stage.
All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a
casting vote.
The use of video-conferencing equipment and conference call means allowing the identification of each participating
Director shall be allowed. These means must comply with technical features which guarantee an effective participation
to the meeting allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation of such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to
a participation in person at such meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held
at the registered office of the Company. Each participating Director shall be authorised to vote by video or by telephone.
Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all Directors
in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These
resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened.
Votes may also be cast by fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.
The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman of the Board of Directors or by
any two Directors. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.
11. General powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform
all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law to the
general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.
Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that
of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the
86339
meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution
is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest
conflicting with that of the company.
If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and
its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company. The provisions of the preceding paragraphs
are not applicable when the decisions of the Board of Directors of the Company or of the Director concern day-to-day
operations engaged in normal conditions.
12. Delegation of powers. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and
affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or
members of the Board, Directors, managers, officers or other agents, legal or physical person, who need not be Share-
holders of the Company, under such terms and with such powers as the Board shall determine.
The Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any person who need not be Directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
13. Representation of the Company. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a
Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the joint signatures
of any two (2) Directors or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by
any two (2) directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.
Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case a managing director has been appointed
in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such
power.
14. Independent auditor. The Company is supervised by one or more independent auditors.
The Board of Directors appoints the independent auditor(s) and determines their number, their remuneration and
the term of their office. The appointment may, however, not exceed a period of six (6) years. In case the independent
auditors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for six (6) years from
the date of their election.
The independent auditors are re-eligible.
Chapter IV. General meeting of shareholders
15. Powers of the sole shareholder / General meeting of shareholders. The Company may have a sole shareholder at
the time of its incorporation or when all of its shares come to be held by a single person. The death or dissolution of the
sole shareholder does not result in the dissolution of the company.
If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Share-
holders and takes the decisions in writing.
In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.
Any general meeting shall be convened by the Board of Directors by means of convening notice sent to each registered
Shareholder in compliance with the law. It must be convened following the request of shareholders representing at least
ten per cent (10%) of the Company's share capital. In case all the Shareholders are present or represented and if they
declare that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and
formalities of publication. Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may
request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must
be addressed to the Company's registered office be registered mail at least five (5) days before the date of the meeting.
Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to
the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and
which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the
decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour, against, or
abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.
Voting forms, which show neither a vote in favour, nor against the resolution, nor an abstention, shall be void. The
Company will only take into account voting forms received three (3) calendar days prior to the general meeting of
shareholders they relate to.
A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.
The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means
allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
transmitted in a continuing way.
86340
Unless otherwise provided for by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of
Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.
When the Company has a sole shareholder, its resolutions shall be taken in writing.
An extraordinary general meeting convened to amend any provision of the Articles shall not validly deliberate unless
at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the
first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or
by law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting.
The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital present or represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders present or
represented.
However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased
only by the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
16. Place and date of the annual general meeting of Shareholders. The annual general meeting of Shareholders is held
in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting on the first Wednesday of June at
11:00 a.m. Luxembourg time. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be
held on the next following bank business day.
17. Other general meetings. Any Director or the independent auditors may convene other general meetings of share-
holders. A general meeting has to be convened at the request of the Shareholders which together represent one tenth
of the capital of the Company.
18. Votes. Each Share is entitled to one (1) vote. A Shareholder may act at any general meeting, including at the annual
general meeting of Shareholders, by appointing another person as its proxy in writing or by telegram, telex or telefax.
Chapter V. Business year, Distribution of profits
19. Business year. The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the thirty-first of
December of each year.
The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents
together with a report of the operations of the Company at least one (1) month prior to the annual general meeting of
Shareholders to the independent auditors who shall make a report containing comments on such documents.
20. Distribution of profits. Each year at least five per cent (5 %) of the net profits has to be allocated to the legal reserve
account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth (10 %)
of the capital of the Company.
After allocation to the legal reserve, the general meeting of Shareholders determines the appropriation and distribution
of net profits.
The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
21. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of Shareholders
voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
general meeting of Shareholders.
Chapter VII. Applicable Law
22. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law
and the 1993 Law."
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, the above-named First Climate AG, represented as stated above, declares
to subscribe for all the twelve thousand five hundred (12,500) shares.
All these Shares have been fully paid up, so that the amount of one hundred and twenty-five thousand euro (EUR
125,000) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law been
fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about three thousand five hundred (EUR
3,500).
86341
<i>Transitional provisionsi>
- The first business year shall start on the day of the incorporation of the Company and end on 31 December 2008.
- The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2009.
<i>First extraordinary general meeting of sole shareholderi>
The above named party, representing the entire subscribed capital and acting as Sole Shareholder of the Company,
immediately takes the following resolutions:
1. The Company's registered office is fixed in 4, place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
2. The following have been elected as Directors, their mandate expiring on occasion of the annual general meeting of
the Sole Shareholder to be held in 2010:
- Mr Markus Hüwener, director, residing professionally in D-61118 Bad Vilbel - Frankfurt/Main, Industriestraße 10.
- Mr Thomas Stetter, director, residing professionally in CH-8004 Zürich, Stauffacherstraße 45.
- Mr Martin Schulte, director, residing professionally in D-61118 Bad Vilbel - Frankfurt/Main, Industriestraße 10.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same
appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will
prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg at the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder signed together
with the notary the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendacht, am neunzehnten Juni.
Vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
erscheint:
First Climate AG, mit dem Gesellschaftssitz in D-61118 Bad Vilbel - Frankfurt/Main, Industriestraße 10, eingetragen
im Handelsregister von Frankfurt/Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 80.273, im folgenden "Alleinige Aktionärin"
genannt,
hier vertreten durch Herrn Martin Schulte, Direktor, mit Berufsanschrift in D-61118 Bad Vilbel - Frankfurt/Main,
Industriestraße 10,
handelnd aufgrund einer am 10. Juni 2008 in Bad Vilbel, Deutschland, erteilten privatschriftlich Vollmacht,
welche nach "ne varietur" Paraphierung von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichnenden Notar der vorliegenden
Urkunde beigefügt bleibt, um gleichzeitig bei den Einregistrierungsbehörden eingereicht zu werden.
Die erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichnenden Notar die Satzung einer Aktienge-
sellschaft wie folgt zu beurkunden:
Kapitel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
1. Form, Name. Die Gesellschaft wird hiermit als Luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet,
welche den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 1915"), dem Gesetz vom 5. April 1993 über den
Finanzsektor (das "Gesetz von 1993") und dieser Satzung (die "Satzung") untersteht.
Die Gesellschaft existiert unter dem Namen First Climate Asset Management S.A.
2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg) errichtet.
Er kann durch Beschluss der Alleinigen Aktionärin oder wenn es mehrere Aktionäre gibt durch Beschluss einer au-
ßerordentlichen Generalversammlung ihrer Aktionäre, die wie in den Anhängen zu dieser Satzung beschrieben berat-
schlagt, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") ist hingegen berechtigt, die Anschrift der Gesellschaft
innerhalb der Gemeinde in der der satzungsmäßige Sitz der Gesellschaft liegt, zu verlegen.
Sollte eine Situation entstehen oder als unmittelbar bevorstehend erscheinen, die eine normale Tätigkeit am Sitz der
Gesellschaft oder die Kommunikation mit dem Ausland aus politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Gründen
verhindert, darf der Sitz der Gesellschaft vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis sich die Situation wieder voll-
ständig normalisiert. Solche eine Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche unabhängig
von einer Verlegung des Sitzes eine Luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung zu einer Verlegung des Sitzes
ins Ausland wird vom Verwaltungsrat getroffen.
Die Gesellschaft darf Büros und Zweigstellen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten.
86342
3. Gesellschaftszweck.
3.1 Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung, in jeglicher Form, der Aktivitäten eines Vermögensverwalters im Sinne
von Artikel 24-3 des Gesetzes von 1993, der Aktivitäten eines Vermarkters von Anteilen im Sinne von Artikel 24-7 des
Gesetzes von 1993, der Aktivitäten einer Verwaltungsstelle des Finanzsektors im Sinne von Artikel 29-2 des Gesetzes
von 1993 und der Aktivitäten eines Domizilgewährers für Gesellschaften im Sinne von Artikel 29 des Gesetzes von 1993.
3.2 Zusätzlich zu dem Vorangehenden kann die Gesellschaft alle rechtlichen, gewerblichen, technischen und finanziellen
Investitionen oder Tätigkeiten ausführen und im Allgemeinen alle Transaktionen tätigen, die erforderlich oder nützlich
sind um ihren Zweck zu erfüllen und auch alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit allen oben beschriebenen
Bereichen verbunden sind, um die Erfüllung ihres Zweckes zu fördern.
4. Dauer. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.
Kapitel II - KAPITAL
5. Kapital. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000), aufgeteilt in zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Namensaktien mit einen Nennwert von jeweils zehn Euro (EUR 10), welche voll eingezahlt
sind.
6. Form der Aktien. Grundsätzlich haben die Aktien die Form von Namensaktien, auf Anforderung der Aktionäre und
bei Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen auch in Form von Inhaberaktien.
7. Bezahlung der Aktien. Die Bezahlung von Aktien, die zur Zeit der Zeichnung nicht vollständig bezahlt werden, darf
zu der Zeit und den Bedingungen erfolgen, die der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt. Jeder zur Einzahlung aufge-
rufene Betrag wird auf alle nicht voll eingezahlten Aktien zu gleichen Teilen berechnet.
8. Veränderungen des Kapitals. Das Kapital der Gesellschaft darf durch Beschluss der Aktionäre unter den rechtlichen
Voraussetzungen einer Satzungsänderung erhöht oder reduziert werden.
Die Gesellschaft darf innerhalb der vom Gesetz gesetzten Grenzen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
Kapitel III. Verwaltungsratsmitglieder, Verwaltungsrat, unabhängige Wirtschaftsprüfer
9. Verwaltungsrat oder Alleiniges Verwaltungsratsmitglied. Falls es mehrere Aktionäre gibt, muss die Gesellschaft von
einem aus mindestens drei (3) Mitgliedern bestehenden Verwaltungsrat geführt werden, welche keine Aktionäre zu sein
brauchen.
Falls die Gesellschaft von einem alleinigen Aktionär gegründet wird oder wenn anlässlich einer Aktionärsversammlung
festgestellt wird, dass sich alle Aktien in der Hand eines alleinigen Aktionärs befinden, kann die Gesellschaft durch ein
alleiniges Verwaltungsratsmitglied (das "Alleinige Verwaltungsratsmitglied") geführt werden, bis die nächste Aktionärs-
versammlung die Existenz von mehr als einem Aktionär bestätigt.
Mitglied des Verwaltungsrates oder Alleiniges Veiwaltungsratsmitglied der Gesellschaft darf eine juristische Person
sein. In einem solchen Fall muss die juristische Person einen ständigen Vertreter ernennen, welcher diese Funktion im
Namen und im Auftrag der juristischen Person wahrnimmt. Die fragliche juristische Person darf ihren ständigen Vertreter
nur absetzen, wenn sie zugleich einen Nachfolger ernennt.
Die Verwaltungsratsmitglieder oder das Alleinige Verwaltungsratsmitglied werden durch die Aktionärsversammlung
für einen Zeitraum von höchstens sechs (6) Jahren ernannt und können wiedergewählt werden. Sie dürfen jederzeit durch
Beschluss der Aktionärsversammlung abgesetzt werden. Sie nehmen ihre Funktion wahr, bis ihre Nachfolger ernannt
worden sind. Falls ein Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, ohne einen Hinweis auf die Laufzeit seines Mandats, gilt er
für sechs Jahre ab dem Datum seiner Wahl ernannt.
Im Falle eines Ausscheidens eines Verwaltungsratsmitgliedes durch Tod, Ruhestand oder anderen Grund, dürfen die
übrigen Verwaltungsratsmitglieder in einer Sitzung durch Mehrheitsbeschluss ein Verwaltungsratsmitglied wählen, um die
Vakanz bis zur nächsten Aktionärsversammlung, welche beauftragt wird, die Wahl zu bestätigen, auszufüllen.
10. Sitzungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat wird einen Vorsitzenden aus seinen Mitgliedern wählen. Der
erste Vorsitzende darf durch die erste Aktionärsversammlung ernannt werden. Wenn es dem Vorsitzenden unmöglich
ist, persönlich anwesend zu sein, wird er durch ein Verwaltungsratsmitglied ersetzt, welches zu diesem Zweck aus den
bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern gewählt wird.
Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden durch den Vorsitzenden oder durch ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied
einberufen. Wenn alle Verwaltungsratsmitglieder persönlich anwesend oder vertreten sind können sie auf alle Einberu-
fungserfordernisse und -formalitäten verzichten.
Der Verwaltungsrat kann nur dann rechtsgültig zusammentreten und Entscheidungen treffen, wenn die Mehrheit seiner
Mitglieder persönlich anwesend oder per Vollmacht vertreten sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied darf sich bei Sitzungen
des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlichen oder durch Telegram oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein an-
deres Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied darf auch ein anderes Verwaltungsratsmit-
glied dazu bestimmen, es per Telefon zu vertreten, was schriftlich zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt werden muss.
Alle Beschlüsse des Verwaltungsrates erfordern eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
86343
Vorrichtungen für Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen können verwendet werden, wenn sie die Identifizierung
aller teilnehmenden Verwaltungsratsmitglieder erlauben. Diese Vorrichtungen müssen die technischen Eigenschaften auf-
weisen, welche die Möglichkeit einer effektiven Teilnahme an der Sitzung garantieren, indem sie es allen an der Sitzung
teilnehmenden Personen ermöglichen, einander kontinuierlich zu hören und eine effektive Teilnahme an der Sitzung
ermöglichen. Die Teilnahme an einer Sitzung mit Hilfe einer solchen Vorrichtung kommt einer persönlichen Teilnahme
an einer solchen Sitzung gleich. Eine Sitzung, die mit Hilfe solcher Kommunikationsvorrichtungen stattfindet, gilt als am
Sitz der Gesellschaft abgehalten. Jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied ist zur Stimmabgabe per Video oder Telefon
berechtigt.
Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch per Umlaufbeschluss gefasst werden, wenn sie schriftlich
genehmigt und von allen Verwaltungsratsmitgliedern persönlich unterzeichnet werden. Eine solche Genehmigung darf in
einem gemeinsamen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten erfolgen, welche per Fax, E-Mail, Telegram
oder Telex verschickt werden. Diese Beschlüsse haben dieselbe Wirksamkeit wie Beschlüsse, die auf ordnungsgemäß
einberufenen Sitzungen des Verwaltungsrates getroffen werden.
Stimmen dürfen per Fax, E-Mail oder Telefon abgegeben werden, in letzterem Fall unter der Voraussetzung, dass die
Stimmabgabe schriftlich bestätigt wird.
Das Protokoll einer Sitzung des Verwaltungsrates ist vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei beliebigen
Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen. Auszüge sollen durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von
zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern beglaubigt werden.
11. Allgemeine Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist mit den weitest gehenden Befugnissen aus-
gestattet, um alle Verwaltungshandlungen zu tätigen und Verfügungen zu treffen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz der Aktionärsversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zustän-
digkeit des Verwaltungsrates.
Ein Verwaltungsratsmitglied, das in einem Vorgang, welcher dem Verwaltungsrat zur Zustimmung vorgelegt wird, ein
Interesse hat, welches dem der Gesellschaft entgegensteht, muss den Verwaltungsrat davon in Kenntnis setzen und ver-
anlassen, dass ein Vermerk dieses Hinweises dem Sitzungsprotokoll angefügt wird. Es darf an den betreffenden Beratungen
nicht teilnehmen. In der nächsten Aktionärsversammlung muss, bevor irgend ein anderer Beschluss zur Abstimmung
gebracht wird, ein besonderer Bericht über alle Vorgänge vorgelegt werden, bezüglich derer ein beliebiges Verwaltungs-
ratsmitglied ein Interesse gehabt haben könnte, welches dem der Gesellschaft entgegensteht.
Falls es nur einen alleinigen Aktionär gibt braucht das Protokoll nur die Vorgänge zwischen der Gesellschaft und dem
Alleinigen Verwaltungsratsmitglied zu erwähnen, der ein Interesse hat, welches dem der Gesellschaft entgegensteht. Die
Bestimmungen des vorangehenden Abschnitts sind nicht anwendbar, wenn die Entscheidungen des Verwaltungsrates der
Gesellschaft oder des Verwaltungsratsmitgliedes die tägliche Geschäftsführung unter normalen Umständen betreffen.
12. Die Delegation von Befugnissen. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse, die täglichen Geschäfte und Angele-
genheiten der Gesellschaft zu führen und die Vertretung der Gesellschaft bei diesen täglichen Geschäften und Angele-
genheiten, an ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied oder beliebige Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer,
Handlungsbevollmächtigten oder anderen Beauftragten, sei es eine juristische oder natürliche Person, welche kein Akti-
onär der Gesellschaft zu sein braucht, delegieren, unter den Voraussetzungen und mit solchen Befugnissen, wie der
Verwaltungsrat bestimmen wird.
Der Verwaltungsrat darf auch alle Befugnisse und besondere Vollmachten auf eine beliebige Person übertragen, die
nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht; er darf alle Handlungsbevollmächtigten und Angestellten ernennen und
entlassen und deren Bezüge festlegen.
13. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft unter allen Umständen, falls es ein Alleiniges
Verwaltungsratsmitglied gibt, durch dessen alleinige Unterschrift gebunden, im Fall von mehreren Verwaltungsratsmit-
gliedern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die alleinige
Unterschrift einer beliebigen Person, welcher dieses Recht zur Unterschrift von beliebigen zwei (2) Verwaltungsratsmit-
gliedern oder dem Alleinigen Verwaltungsratsmitglied eingeräumt wurde, jedoch nur innerhalb der Grenzen dieses Rechts.
Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft unter allen Umständen, falls ein täglicher Geschäftsführer ernannt wurde um
die täglichen Geschäfte und Angelegenheiten zu führen und die Gesellschaft bei diesen täglichen Geschäften und Ange-
legenheiten zu vertreten, durch dessen alleinige Unterschrift gebunden, jedoch nur innerhalb der Grenzen dieses Rechts.
14. Der unabhängige Wirtschaftsprüfer. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschafts-
prüfer überwacht.
Der Verwaltungsrat ernennt den oder die unabhängigen Wirtschaftsprüfer und legt deren Anzahl, Vergütung und die
Dauer ihrer Amtszeit fest. Die Ernennung darf jedoch einen Zeitraum vom sechs (6) Jahren nicht überschreiten. Falls die
unabhängigen Wirtschaftsprüfer ohne Festlegung ihrer Amtszeit ernannt werden, gelten sie als für die Dauer von sechs
(6) Jahren ab dem Datum ihrer Ernennung ernannt.
Die unabhängigen Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden.
86344
Kapitel IV. Die Aktionärsversammlung
15. Befugnisse des alleinigen Aktionärs / der Aktionärsversammlung. Die Gesellschaft darf zur Zeit ihrer Gründung,
oder wenn alle Aktien in der Hand einer einzigen Person zusammen fallen, einen alleinigen Aktionär haben. Der Tod oder
die Auflösung des alleinigen Aktionärs führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.
Falls es nur einen alleinigen Aktionär gibt, fallen diesem alleinigen Aktionär alle Befugnisse der Aktionärsversammlung
zu. Er trifft alle Entscheidungen in Schriftform.
Falls es mehrere Aktionäre gibt, vertritt die Aktionärsversammlung die Gesamtheit der Aktionäre gegenüber der
Gesellschaft. Sie hat die weitest gehenden Befugnisse Handlungen in bezug auf die Tätigkeit der Gesellschaft anzuordnen,
auszuführen oder zu bestätigen.
Jede Aktionärsversammlung muss durch den Verwaltungsrat durch Einberufungsschreiben einberufen werden, welche
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an jeden registrierten Aktionär versendet wird. Wenn ein Antrag von Aktionären
vorliegt, die mindestens zehn (10) Prozent des Gesellschaftskapitals halten, muss eine Aktionärsversammlung einberufen
werden. Falls alle Aktionäre persönlich anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, über die Tagesordnung der
Sitzung informiert worden zu sein, können sie auf alle Einberufungsvorschriften und Veröffentlichungsformalitäten ver-
zichten. Aktionäre, die mindestens zehn (10) Prozent des Kapitals der Gesellschaft halten, können die Aufnahme eines
oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung einer Aktionärsversammlung beantragen. Ein solcher Antrag muss per Ein-
schreiben mindestens fünf (5) Tage vor dem Tag der Sitzung an den Sitz der Gesellschaft geschickt werden.
Jeder Aktionär darf durch Abstimmungsvordruck, welcher per Post oder per Fax an den Sitz der Gesellschaft oder
die Adresse, welche im Einberufungsschreiben angegeben ist, zu schicken ist, abstimmen. Die Aktionäre dürfen nur von
der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Abstimmungsvordrucke verwenden, welche mindestens Ort, Datum und Zeit
der Sitzung, die Tagesordnung, den Entscheidungsvorschlag und für jeden Entscheidungsvorschlag drei Felder enthalten
muss, so dass der Aktionär für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abstimmen oder sich enthalten kann, indem
er das betreffende Feld ankreuzt.
Abstimmungsvordrucke, welche weder die Stimmabgabe für oder gegen den Beschluss noch eine Enthaltung beinhalten
sind, ungültig. Die Gesellschaft wird nur solche Abstimmungsvordrucke berücksichtigen, die drei (3) Kalendertage vor
der betreffenden Aktionärsversammlung eingegangen sind.
Ein Aktionär darf sich bei einer Aktionärsversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich (oder per Fax oder E-Mail
oder auf ähnliche Weise) einen Vertreter ernennt, welcher selbst kein Aktionär zu sein braucht, und daher zur Stimm-
abgabe per Vollmacht berechtigt ist.
Die Aktionäre sind berechtigt, an der Sitzung durch Videokonferenz oder Telekommunikationsvorrichtungen teilzu-
nehmen, die ihre Identifikation erlaubt. Sie gelten dann als anwesend für die Beschlussfähigkeit und die Mehrheitserfor-
dernisse. Diese Vorrichtungen müssen die technischen Eigenschaften aufweisen, welche die Möglichkeit einer effektiven
Teilnahme an der Sitzung garantieren, deren Beratungen kontinuierlich übertragen werden.
Wenn es nicht vom Gesetz oder dieser Satzung anders angeordnet wird, müssen alle Entscheidungen der jährlichen
oder ordentlichen Aktionärsversammlung durch Beschluss mit einfacher Mehrheit getroffen werden, unabhängig von dem
Anteil des vertretenen Kapitals.
Falls die Gesellschaft einen alleinigen Aktionär hat, sind dessen Beschlüsse schriftlich abzufassen.
Eine außerordentliche Aktionärsversammlung, welche einberufen ist, um Bestimmungen dieser Satzung zu ändern,
können nicht rechtsgültig beraten, wenn nicht mindestens die Hälfte des Kapitals vertreten ist und die Tagesordnung auf
die vorgeschlagenen Satzungsänderungen hinweist. Wenn die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite
Sitzung einberufen werden, wie in dieser Satzung oder von Gesetzes wegen vorgeschrieben. Ein solches Einberufungs-
schreiben muss die Tagesordnung wiedergeben und auf das Datum und die Ergebnisse der vorhergehenden Sitzung
hinweisen. Diese zweite Sitzung kann unabhängig von dem Anteil des anwesenden oder vertretenen Kapitals rechtsgültig
beraten. Bei beiden Sitzungen müssen Beschlüsse, um verabschiedet werden zu können, von einer Zwei-Drittel-Mehrheit
der persönlich anwesenden oder vertretenen Aktionäre verabschiedet werden.
Die Nationalität der Gesellschaft darf jedoch nur verändert werden, und die Verpflichtungen der Aktionäre dürfen
nur ausgeweitet werden durch einstimmigen Beschluss aller Aktionäre und in Übereinstimmung mit jeglichen rechtlichen
Voraussetzungen.
16. Ort und Datum der jährlichen Aktionärsversammlung. Die jährliche Aktionärsversammlung wird in Luxemburg-
Stadt am ersten Mittwoch im Juni um 11.00 Uhr Luxemburger Zeit an einem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort
abgehalten. Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag in Luxemburg sein, wird die jährliche Aktionärsversammlung an
dem darauf folgenden Arbeitstag abgehalten werden.
17. Andere Aktionärsversammlungen. Ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied oder die unabhängigen Wirtschaftsprüfer
dürfen andere Aktionärsversammlungen einberufen. Eine Aktionärsversammlung muss auf Antrag von Aktionären, die
zusammen zehn (10) Prozent des Gesellschaftskapitals halten, einberufen werden.
18. Stimmen. Jede Aktie berechtigt zu einer (1) Stimme. Ein Aktionär darf sich bei jeder beliebigen Aktionärsver-
sammlung, auch bei der jährlichen Aktionärsversammlung, durch einen von ihm per Telegram, Telex oder Telefax
ernannten Bevollmächtigten vertreten lassen.
86345
Kapitel V. Gesellschaftsjahr, Gewinnverteilung
19. Gesellschaftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt in jedem Jahr am ersten Januar und endet am ein-
undreissigsten Dezember.
Der Verwaltungsrat fertigt die Bestandsaufnahme an sowie die Gewinn-und Verlustrechnung. Er übermittelt diese
Dokumente, zusammen mit dem Bericht über die Tätigkeit der Gesellschaft, mindestens einen (1) Monat vor der jährlichen
Aktionärsversammlung an die unabhängigen Wirtschaftsprüfer, welche einen Bericht erstellen, welcher diese Dokumente
kommentiert.
20. Gewinnverteilung. Mindestens fünf (5) Prozent des Nettogewinns muss in jedem Jahr für die gesetzliche Rücklage
verwendet werden. Diese Verwendung ist nicht mehr verpflichtend, falls und solange wie die gesetzliche Rücklage min-
destens zehn (10) Prozent des Gesellschaftskapitals beträgt.
Nach dieser Zuteilung an die gesetzliche Rücklage bestimmt die Aktionärsversammlung über die Verteilung und Ver-
wendung des Nettogewinns.
Der Verwaltungsrat darf beschließen, zwischenzeitliche Gewinnausschüttungen in Übereinstimmung mit den gesetz-
lichen Vorgaben vorzunehmen.
Kapitel VI. Auflösung. Liquidation
21. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch eine Entscheidung der Aktionärsversammlung aufgelöst wer-
den. Für einen solchen Beschluss gelten die selben Anwesenheits- und Mehrheitserfordernisse wie für eine Satzungsän-
derung.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, welche durch
die Aktionärsversammlung ernannt werden, durchgeführt.
Kapitel VII. Anwendbares Recht
22. Anwendbares Recht. Alle Angelegenheiten, die in dieser Satzung nicht geregelt sind, richten sich nach dem Gesetz
von 1915 und dem Gesetz von 1993."
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nachdem die Satzung so errichtet worden ist, erklärt die oben genannte First Climate AG, vertreten wie vorgenannt,
alle zwölftausendfünfhundert (12.500) Aktien zu zeichnen.
All diese Aktien werden voll in bar eingezahlt, so daß der Gesellschaft von nun an der Betrag von hundertfünfund-
zwanzigtausend Euro (EUR 125.000) zur freien Verfügung steht, wie dies dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
<i>Erklärungi>
Der Notar, welcher die vorliegende Urkunde erstellt, erklärt, dass die Voraussetzungen von Artikel 26 des Gesetzes
von 1915 erfüllt sind und bezeugt ausdrücklich die Tatsache ihrer Erfüllung.
<i>Kostenvoranschlagi>
Die Parteien schätzen die Kosten, Auslagen, Gebühren und Spesen, in welcher Form auch immer, die von der Gesell-
schaft zu tragen sind, oder die ihr in Verbindung zu ihrer Gründung in Rechnung gestellt werden sollen auf dreitausend-
fünfhundert Euro (EUR 3.500).
<i>Übergangsbestimmungeni>
- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.
- Die erste jährliche Aktionärsversammlung wird im Jahre 2009 abgehalten.
<i>Erste ausserordentliche Aktionärsversammlungi>
Die oben genannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft vertritt und als alleiniger Aktionär
handelt, fasst unverzüglich folgende Beschlüsse:
1. Der Sitz der Gesellschaft wird in 4, place de Strasbourg, L-2562 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg festgelegt.
2. Die folgenden Personen werden zu Verwaltungsratsmitgliedern ernannt:
- Herr Markus Hüwener, Direktor, mit Berufsanschrift in D-61118 Bad Vilbel - Frankfurt/Main, Industriestraße 10.
- Her Thomas Stetter, Direktor, mit Berufsanschrift in CH-8004 Zürich, Stauffacherstraße 45.
- Herr Martin Schulte, Direktor, mit Berufsanschrift in D-61118 Bad Vilbel - Frankfurt/Main, Industriestraße 10.
Ihre Amtszeit endet anlässlich der jährlichen Aktionärsversammlung des alleinigen Aktionärs im Jahr 2010.
Der unterzeichnende Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage des Vollmacht-
nehmers der erschienenen Partei, diese Urkunde auf Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Anfrage
desselben Vollmachtnehmers und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text wird dem
englischen Text Vorrang eingeräumt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
86346
Nachdem das Dokument dem Vollmachtnehmer der erschienenen Partei vorgelesen wurde, hat dieser zusammen mit
dem Notar diese Originalurkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Martin Schulte und Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juin 2008. LAC/2008/26166. — Reçu six cent vingt-cinq euros à 0,5 %: 625 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG der Gesellschaft auf Begehr erteilt, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. Juli 2008.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2008087341/7241/499.
(080099968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Dahm Gastro-Service Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3961 Ehlange, 1A, rue de Roedgen.
R.C.S. Luxembourg B 139.809.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendacht, den fünften Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.
Sind erschienen:
1.- Herr Horst DAHM, Kaufmann, geboren in Prüm (Deutschland), am 20. September 1950, wohnhaft in D-54595
Prüm, Rudolf-Diesel-Straße 5b (Deutschland);
2.- Herr Reinhard DAHM, Kaufmann, geboren in Prüm (Deutschland), am 8. September 1959, wohnhaft in D-54595
Prüm, Rudolf-Diesel-Straße 5a (Deutschland).
Diese Komparenten ersuchen den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Die vorbenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Be-
zeichnung "DAHM GASTRO-SERVICE SARL".
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Reckange/Mess.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Lebensmitteln jeglicher Art.
Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-
zunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen
errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder
denselben fördern kann, ausüben.
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhundert
(100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen
und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Le-
benden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindes-
tens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.
Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden
von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Ums-
tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.
86347
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die,
in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum
Buchwert an den Nachfolger auszuzahlen.
Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstellen
den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern
ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Vorübergehende Bestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteilei>
Die einhundert (100) Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
Anteile
1.- Herr Reinhard Dahm, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Herr Horst Dahm, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
TOTAL: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen
wurde.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-
sammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Herren Reinhard DAHM und Horst DAHM, beide vorgenannt, werden zu Geschäftsführern auf unbestimmte
Dauer ernannt.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.
2.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-3961 Ehlange, 1A, rue de Roedgen.
Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Horst Dahm, Reinhard Dahm, Paul Bettingen.
86348
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 13 juin 2008, LAC/2008/24086. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents à
0,5%: 62,50 €.
<i>Pr Le Receveur ff.i> (signé): Franck Schneider.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 7. Juli 2008.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2008087342/202/101.
(080099988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Société de Gestion Ampera S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 80.340.
L'an deux mille huit, le seize juin.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE GESTION AM-
PERA S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 80.340, constituée à la suite de la scission de la société anonyme
SOCIETE DE GESTION AMPERA, le projet de scission publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
875 du 6 décembre 2000 ayant été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société
suivant procès-verbal dressé par Maître Marthe Thyes-Walch, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8
janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 707 du 31 août 2001, et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, prénommée, en date du 13 décembre 2002, publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 120 du 6 février 2003.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Françoise DUMONT, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Larissa ZANIN, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Romain BORDAGE, employé privé, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les CINQ CENT CINQUANTE (550) actions représentant
l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou re-
présentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur
a été communiqué au préalable.
Les cinq cent cinquante (550) actions sont détenues comme suit:
DEUX CENT QUATRE-VINGT-SIX (286) actions par NOMEN FIDUCIARA S.r.l, et
DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE (264) actions par GABRIEL FIDUCIARA S.r.l.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Approbation de la situation comptable au 31.05.08
2.- Transfert du siège social du Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la nationalité italienne.
3.- Fixation du siège social à I-10121 Torino - Galleria San Federico 54- Italia
4.- Modification de la dénomination en AMPERA- S.P.A.
5.- Démission des administrateurs et du commissaire actuellement en fonction et décharge.
6.- Nomination des administrateurs et nomination du collège des commissaires.
7.- Pouvoirs à conférer à Monsieur Guido MANASSERO, pour représenter la société vis-à-vis des instances adminis-
tratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant.
8.- Adoption des statuts selon la législation italienne.
9.- Pouvoirs à conférer à Madame Françoise DUMONT ou Monsieur Christian FRANCOIS pour représenter la société
vis-à-vis des instances administratives et fiscales à Luxembourg à la suite du transfert de siège et du changement de
nationalité comme dit ci-avant et en vue d'accomplir toutes les formalités requises.
10.- Divers.
86349
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée approuve la situation comptable au 31 mai 2008.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la nationalité de la Société et de transférer le siège social de la Société en Italie, sans
dissolution préalable de la Société, laquelle continuera l'activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et
continuera d'exister sous la nationalité italienne.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer le siège social à I-10121 Torino - Galleria San Federico 54, Italie.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en AMPERA-S.P.A.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire actuellement en fonction et leur
accorde pleine décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes comme administrateurs:
Madame Pierina BRUNO, Présidente, née à Turin, le 27 octobre 1919, demeurant à Turin, Strada Superga, 124.
Monsieur Guido MANASSERO, Consigliere, né à Turin, le 14 août 1946, demeurant à Turin, Strada Superga, 124.
Monsieur Stefano MANASSERO, né à Turin, le 21 mai 1974, demeurant à Turin, Via Dominzoni, 14.
L'assemblée décide de nommer comme membres du collège des commissaires (Collegio Sindacale):
DEL BELLO Dott.ssa Flavia, Presidente, née à Quilnes, le 12 avril 1955, demeurant à Moncalieri, Strada Moncalvo 13,
BAROLO Dott. Franco, Sindaco Effettivo, né à Manta, le 13 décembre 1949, demeurant à Saluzzo (CN), via San
Bernardino n. 3,
GIORDANO Paola Lucia, Sindaco Effettivo, née à Asti, le 30 avril 1962, demeurant à Asti, via Emanuele Filiberto n.
23,
GAMBARUTO Vincenzo, Sindaco Supplente; né à Turin, le 23 décembre 969, demeurant à Turin, corso Stati Uniti n.
15,
FARMESIO Gennaro, Sindaco Supplente, né à Napoli (NA), le 21 avril 1970, demeurant à Galleria San Federico 54,
10121 Turin,
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Guido MANASSERO, prénommé, pour représenter la Société devant
toutes les instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité
comme dit ci-avant et en vue de l'inscription de la Société par les autorités italiennes compétentes.
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée approuve les statuts annexés, modifiés dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation
italienne.
Le texte des statuts en langue italienne, tels qu'établis par la Société et approuvés par l'Assemblée, est joint en annexe
au présent acte.
<i>Neuvième résolutioni>
L'Assemblée confère tous pouvoirs à Madame Françoise DUMONT, ou Monsieur Christian FRANCOIS, tous deux
demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, pour représenter la société vis à vis des
instances administratives et fiscales à Luxembourg à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme
dit ci- avant et en vue d'accomplir toutes les formalités requises, notamment pour faire constater par-devant notaire la
réalisation de la condition suspensive ci-après.
<i>Condition suspensivei>
Les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société par les autorités ita-
liennes compétentes.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. DUMONT, L. ZANIN, R. BORDAGE et H. HELLINCKX.
86350
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juin 2008, Relation: LAC/2008/25483. — Reçu douze euros (12 €).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2008.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2008087362/242/107.
(080099875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
CPM Développement S. à r. l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Centuria Property Management, S.à r.l.).
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 112.217.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 8 juillet 2008.
Paul BETTINGEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087397/202/13.
(080100337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Pimlico, Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 128.363.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WILTZ, le 08/07/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008087602/825/12.
Enregistré à Diekirch, le 3 juillet 2008, réf. DSO-CS00028. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080099900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Daniel Schlechter S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9412 Vianden, 12, rue de la Frontière.
R.C.S. Luxembourg B 103.868.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 22 maii>
<i>2008 à 10.00 heuresi>
L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Claude KREMER de son poste d'administrateur avec effet à
ce jour, le remercie pour ses services rendus à la société et lui donne décharge.
Est nommé au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur Claude KREMER jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en l'année 2013, Monsieur Claude COLLARINI, né le 18.11.1962 à Villerupt (France), avec adresse
professionnelle à L - 2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
Vianden, le 22 mai 2008.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008087582/832/20.
Enregistré à Diekirch, le 30 juin 2008, réf. DSO-CR00389. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080099927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
86351
Decopaint SA., Société Anonyme.
Siège social: L-9280 Diekirch, 48, rue de Stavelot.
R.C.S. Luxembourg B 112.336.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature
Référence de publication: 2008087584/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 30 juin 2008, réf. DSO-CR00386. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(080099923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Aratec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 79, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 121.309.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053, ETTELBRUCK
Signature
Référence de publication: 2008087586/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 30 juin 2008, réf. DSO-CR00383. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080099926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Consulting HDR + Partner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 82.439.
Les comptes annuels établis au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07.07.2008.
<i>Pour la société CONSULTING HDR + Partner S.A.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
Référence de publication: 2008086397/745/15.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2008, réf. LSO-CS00393. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Le Grand Château S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 129.340.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008087427/5770/12.
(080100487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
86352
Aratec S.à r.l.
Arvensis S.A.
BOWEN HOLDINGS S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial
BOWEN HOLDINGS S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial
Centuria Property Management, S.à r.l.
CERE II B Co-Invest S.à r.l.
CERE II B Co-Invest S.à r.l.
CEREP Cheapside S.à r.l.
Cessimoco, S.à r.l.
Consulting HDR + Partner S.A.
CPM Développement S. à r. l.
Dahm Gastro-Service Sàrl
Daniel Schlechter S.A.
DB Plus S.à r.l.
Decopaint SA.
Decopaint SA.
Delucs S.A.
Esposa S.A.
Eurimmo S.A.
Euro Investment and Finance S.A.
Euro Investment and Finance S.A.
Famby International
Fil & Gatti Agence d'Assurances S. à r.l.
Finoinvest Spf S.A.
Finpromotion International Holding S.A.
First Climate Asset Management S.A.
Grandecran Holding SA
Grandecran Holding SA
GSW-Wolff-Luxembourg
HEDLAND HOLDINGS S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial
HEDLAND HOLDINGS S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial
High Tech Finance S.A.
Hoxton
Java S.A.
Kamea S.A.
Kamea S.A.
Kamesis S.A.
Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l.
Lanchester S.A.
Le Grand Château S.à.r.l.
Magnisense
Magnisense
Marcell Equity S.C.A.
Marita Spf S.A.
Monteria S.A.
Montrans S.A.
Nebis Holding S.A.
Pharmacopole S.A.
Pimlico
Probat S.A.
RGI Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
RGI Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Ronndriesch 123 S.A.
Ronndriesch 1 S.A.
Skipness S.A.
Société de Gestion Ampera S.A.
Supreme Entertainment S.A.
The World Trust Fund
Tialma S.A.
TN Espo S.A.
TOA (Lux) S.A.
Wandpark Gemeng Hengischt S.A.
Wandpark Gemeng Hengischt S.A.
Wandpark Kehmen-Heischent S.A.
Xelex