This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1640
3 juillet 2008
SOMMAIRE
AFD Le Pouzin A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
78719
Agence de l'Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78683
Alimar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78679
Analisis de Procesos Financieros Procesan-
do Luxemburgo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
78709
Aphrodite Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
78684
Array Holding Company S.A. . . . . . . . . . . .
78682
A Tasquinha S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78720
Aviador Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
78687
Bakery Equity Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
78686
Bau & Boden Consulting S.A. . . . . . . . . . . .
78720
Bau Komplett Service S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
78683
B & B Interinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78677
Bifin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78684
Brisants 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78675
Café Montalegre s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
78720
Calilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78675
Coiffure Martine S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
78676
Corbis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78681
David Morrisson S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
78674
Delux-Bau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78683
EastNets Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78684
Electrum S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78680
Enra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78679
Euraussie Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78675
Expersoft Systems S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
78678
Finance Immobilière Holding . . . . . . . . . . .
78680
GCAT Flight Academy Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78707
Growth Yield Return S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
78685
H.A.C.O. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78684
HarbourVest VIII-Mezzanine S.à r.l. . . . . .
78697
Immobilière 2F S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78677
Implant-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78685
Implant-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78685
Ingersoll-Rand Lux Finance Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78714
International Data Processing Luxem-
bourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78685
International Mode Investment S.A. . . . . .
78678
International Mode Investment S.A. . . . . .
78676
Kanelle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78686
Kanelle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78686
L'électricien Haag S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . .
78686
LUX-DL-Baumanagement S. à r. l. . . . . . .
78682
Macarena International S.à r.l. . . . . . . . . . .
78707
Maintenance Générale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78683
Matanera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78675
Matanera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78678
Matanera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78679
Matanera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78679
Oxford Aviation Academy Luxembourg
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78707
Palatum Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
78680
Paritex Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78676
Partum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78682
Pinchote S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78674
Powercom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78677
Powercom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78674
R3 Capital Partners (Luxembourg I), S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78694
Regenbogenzwei S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78676
Semerca Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
78681
Silkhouse S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78674
Société Financière de Placements . . . . . . .
78680
Stellarium Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78682
Stork Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78677
Topsin Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
78681
Victor Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78678
VisionAd S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78681
78673
Powercom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 65.218.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008076490/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04451. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080086120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Silkhouse S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 69.532.
Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
<i>SILKHOUSE S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008076500/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05090. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Pinchote S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 109.500.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008076496/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04438. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
David Morrisson S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.
R.C.S. Luxembourg B 46.221.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>PKF Weber et Bontemps
<i>Réviseur d'Entreprises
Experts Comptables et Fiscaux
i>Signatures
Référence de publication: 2008076600/592/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05623. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
78674
Euraussie Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 112.935.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2008076525/1172/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04159. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080086195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Brisants 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 118.533.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
10, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
Signatures
Référence de publication: 2008076523/1172/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04166. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Calilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 108.230.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2008076527/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04154. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080086191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Matanera S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 38.997.
Le bilan au 31 mai 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MATANERA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008076510/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03923. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
78675
International Mode Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 53.129.
Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
<i>INTERNATIONAL MODE INVESTMENT SA
i>Signature
Référence de publication: 2008076508/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05134. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080086142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Paritex Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 109.359.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>PARITEX HOLDING S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008076509/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03899. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Regenbogenzwei S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 112.032.
Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
<i>REGENBOGENZWEI S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2008076505/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05110. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Coiffure Martine S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8541 Nagem, 10, Pullgaass.
R.C.S. Luxembourg B 96.782.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008076483/1420/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01732. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
78676
Stork Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 131.618.
Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
<i>STORK INVEST S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008076503/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05104. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080086152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Immobilière 2F S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 68.776.
Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
<i>IMMOBILIERE 2F S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008076504/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05107. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Powercom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 65.218.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008076494/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04446. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
B & B Interinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 110.357.
Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
<i>B & B INTERINVEST S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008076501/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05095. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
78677
Victor Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 122.742.
Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
<i>VICTOR FINANCE S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008076506/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05113. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080086145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
International Mode Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 53.129.
Le bilan au 31 décembre 2006 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
<i>INTERNATIONAL MODE INVESTMENT SA
i>Signature
Référence de publication: 2008076507/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05130. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Matanera S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 38.997.
Le bilan au 31 mai 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MATANERA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008076511/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03921. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Expersoft Systems S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Munsbach, 134, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 82.740.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008076479/1420/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01765. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
78678
Matanera S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 38.997.
Le bilan au 31 mai 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MATANERA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008076512/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03918. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080086133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Matanera S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 38.997.
Le bilan au 31 mai 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MATANERA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008076513/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03916. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Alimar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 69.022.
Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
<i>ALIMAR S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008076502/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05098. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Enra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 23.794.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008076480/1420/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01764. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
78679
Société Financière de Placements, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 1.279.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2008076522/1172/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04168. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080086202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Finance Immobilière Holding, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 17.944.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2008076528/1172/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04151. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Electrum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 42, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 27.781.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008076481/1420/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01762. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Palatum Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 64.439.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008076897/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05531. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
78680
Semerca Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 64.444.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008076898/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05529. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080086951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Topsin Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 64.405.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008076896/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05534. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Corbis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 79.329.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008076900/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05525. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
VisionAd S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6790 Grevenmacher, 7, rue des Tanneurs.
R.C.S. Luxembourg B 112.662.
Le bilan au 31. Dezember 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 18.06.08.
Signature.
Référence de publication: 2008076886/5318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04195. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
78681
Stellarium Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 84.129.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour STELLARIUM SARL
i>Emmanuel KARP / Tilly KLEIN
Référence de publication: 2008076910/597/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03388. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080086983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Partum S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 71.652.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008076902/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05523. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
LUX-DL-Baumanagement S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 109.829.
Le bilan au 31. Dezember 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 18.06.08.
Signature.
Référence de publication: 2008076883/5318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04423. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Array Holding Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 78.074.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WILSON ASSOCIATES
11, boulevard Royal, B.P. 742, L-2017 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008077034/803/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05789. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
78682
Agence de l'Energie, Société Anonyme.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 37.462.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19.06.2008.
<i>AGENCE DE L'ENERGIE, Société anonyme
i>Signature
Référence de publication: 2008077778/2480/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05048. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080087863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.
Maintenance Générale, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4385 Ehlerange, 6, Z.A.R.E. Est.
R.C.S. Luxembourg B 112.604.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17/06/2008.
<i>Pour la société
i>Weber Bontemps & Mouwannes
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2008077138/8390/16.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03129. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Delux-Bau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
R.C.S. Luxembourg B 81.100.
Le bilan au 31. Dezember 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 18.06.08.
Signature.
Référence de publication: 2008076884/5318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04329. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Bau Komplett Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 114.602.
Le bilan au 31. Dezember 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 18.06.08.
Signature.
Référence de publication: 2008076885/5318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04339. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
78683
Bifin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 51.408.
Par la présente, j'ai le regret de vous informer que je démissionne de mon poste d'administrateur de votre société,
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 4.01.2008.
Romaine SCHEIFER-GILLEN.
Référence de publication: 2008076664/545/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03617. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080087680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
H.A.C.O. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7662 Medernach, 34, rue d'Ermsdorf.
R.C.S. Luxembourg B 99.651.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008076478/1420/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01767. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
Aphrodite Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 113.758.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16/06/2008.
<i>Pour Aphrodite Investments S.A.
i>Luxembourg International Consulting S.A.
Signature
Référence de publication: 2008077132/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03182. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
EastNets Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 127.657.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2008.
STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2008077156/792/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03303. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
78684
International Data Processing Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 22.236.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2008.
STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2008077157/792/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03305. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080087570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Growth Yield Return S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 123.401.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2008.
STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2008077158/792/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03308. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Implant-Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 112.536.
Le bilan au 31. Dezember 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 18.06.08.
Signature.
Référence de publication: 2008076880/5318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04384. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Implant-Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 112.536.
Le bilan au 31. Dezember 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 18.06.08.
Signature.
Référence de publication: 2008076879/5318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04388. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
78685
Kanelle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 115.620.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2008.
MERCURIA SERVICES
8-10, rue Mathias Hardt, B.P.3023, L-1030 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008077159/1005/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05957. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080087689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Kanelle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 115.620.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2008.
MERCURIA SERVICES
8-10, rue Mathias Hardt, B.P.3023, L-1030 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008077160/1005/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05952. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
L'électricien Haag S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 108.372.
Le bilan au 31. Dezember 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 18.06.08.
Signature.
Référence de publication: 2008076887/5318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04211. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Bakery Equity Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.
R.C.S. Luxembourg B 90.296.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008076682/1053/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05569. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
78686
Aviador Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 139.332.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendacht, den dreißigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Herr Conrado Dornier, geboren am 25. Juli 1953 in Madrid, Spanien, mit beruflicher Adresse in Faistenberg 1,
D-82547 Eurasburg, Deutschland,
ordnungsgemäß vertreten durch Ute Bräuer, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft
Vollmacht; und
2) Frau Martine Dornier-Tiefenthaler, geboren am 21. August 1954 in München, Deutschland, mit beruflicher Adresse
in Faistenberg 1, D-82547 Eurasburg, Deutschland,
ordnungsgemäß vertreten durch Ute Bräuer, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft
Vollmacht.
Nachdem die Vollmachten durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet
worden sind, sollen diese dieser Urkunde angehängt bleiben, um mit derselben eingetragen zu werden.
Solch erschienene Parteien haben den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer société à responsabilité limitée
aufzunehmen, welche sie gründen möchten und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten soll:
A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz
Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die
künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft In Form einer société à responsabilité limitée unter der Firma "Aviador
Holding S.à r.l." (die "Gesellschaft").
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen
Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird, wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
Art. 3. Zweck.
3.1 Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus
Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.
3.2 Die Gesellschaft kann außerdem;
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-
gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
bindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines
Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie
auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren;
und
- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in
welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.
3.3 Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. In-
nerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:
- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-
papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;
- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland beteiligen; und
- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes
beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft liegt in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
78687
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-
rerrats verlegt werden.
4.3 Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg
verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird, wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich
ist.
4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch
einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.
B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Ge-
schäftsanteilen
Art. 5. Stammkapital.
5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) bestehend aus zwölftau-
sendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil.
5.2 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Gesell-
schafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erfor-
derlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Alle neuen Geschäftsanteile, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden den bestehenden/dem bestehenden
Gesellschafter(n) zuerst angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden solche Geschäftsanteile den
Gesellschaftern im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Stammkapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Geschäft-
santeile angeboten. Der Geschäftsführerrat bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses bevorzugte Anteilsbezugs-
recht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines
an die Gesellschafter/den Gesellschafter gesendeten Einschreibens betragen, welches die Eröffnung der Zeichnung an-
kündigt. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann jedoch die Gesellschafterversammlung, welche einberufen wurde, um
über eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft zu bestimmen, das bevorzugte Anteilsbezugsrecht der bestehen-
den Gesellschafter/des bestehenden Gesellschafters begrenzen oder aufheben. Ein solcher Beschluss muss in der Weise
gefasst werden, wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig
(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.
6.3 Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl
der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.
6.4 Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betreffend
den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.
6.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurück-
gekauften oder zurückgenommenen Geschäftsanteile werden sofort gelöscht und das Stammkapital entsprechend
herabgesetzt.
6.6 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.
Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.
7.1 Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-
schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem
Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.
7.2 Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung
mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.
Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.
8.1 Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-
schafterverzeichnis erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Gesellschafters werden Zertifikate dieser
Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.
8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-
sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum
mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.
78688
8.3 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter
Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden
Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit
gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf NichtGesellschafter nur mit Ein-
willigung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte
der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.
8.4 Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des Falles
in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber der
Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft
zur Übertragung wirksam, gemäß derer jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das Gesell-
schafterverzeichnis eintragen kann.
8.5 Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen und
diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen Do-
kument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.
C. Gesellschafterversammlung
Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1 Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe
der Gesellschaft bildet.
9.2 Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-
terversammlung aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Gesellschafter" nicht
ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
"Gesellschafterversammlung" als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter" gelesen werden.
9.3 Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich
verliehenen Befugnisse.
9.4 Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,
statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.
Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
10.1 Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die
satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.
10.2 Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-
sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zei-
traums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.
10.3 Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit
der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.
10.4 Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass
sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.
Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen -Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1 In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden, bestehend aus einem Präsi-
denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.
11.2 In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3 Quorum und Stimmabgabe
11.3.1 Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.3.2 Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-
schafterbeschlüsse bei der ersten Abstimmung wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
78689
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.
11.4 Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,
Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.
11.5 Es wird davon ausgegangen, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkon-
ferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser
Gesellschafter eindeutig bestimmt werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegen-
seitig durchgehend akustisch wahrnehmen und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammen-
setzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist.
11.6 Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein zuvor unterzeichnetes
Stimmformular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den einge-
tragenen Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter
können nur solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest
den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung
sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Gesellschafter ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder
gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt.
Die Gesellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie
sich beziehen, erhalten hat.
11.7 Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden
müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.
Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag
durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (Ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.
Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
13.1 Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern sowie
von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.
13.2 Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Beschlüsse
aufnehmen und unterzeichnen.
13.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen
oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.
D. Geschäftsführung
Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
14.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein
müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Es bestehen zwei Kategorien von Geschäftsführern, die
Geschäftsführer der Kategorie A und die Geschäftsführer der Kategorie B. Soweit anwendbar und wo der Begriff "allei-
niger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsver-
trag genannter Verweis auf den "Geschäftsführerrat" als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer" gelesen werden.
14.2 Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.
14.3 Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts
können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Ge-
schäftsführerrats festgesetzt.
14.4 Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede
Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.
Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten
des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des
Geschäftsführerrats sein muss.
78690
Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
16.1 Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit
festlegt.
16.2 Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen
werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.
Art. 17. Einberufung von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
17.1 Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner
Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.
17.2 Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung
anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einvers-
tändnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunika-
tionsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist. Auch
ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort stattfinden
sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann nicht
erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von schrift-
lichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.
Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1 Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner Ab-
wesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen
18.2 Quorum
Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
an der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
18.3 Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder
vertretenen Mitglieder der Geschäftsführer der Kategorie A und der Geschäftsführer der Kategorie B gefasst. Der Prä-
sident soll keine entscheidende Stimme haben.
18.4 Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein
anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.
18.5 Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Vi-
deokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und
effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird
vermutet, dass eine durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft
abgehalten wurde.
18.6 Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in
einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.
18.7 Jeder Geschäftsführer, der an einem Geschäftsabschluss, der dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt,
direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft im Widerspruch
steht, muss den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll
der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über den
in Frage stehenden Geschäftsabschluss teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft von einem einzigen
Geschäftsführer geleitet wird und dieser bei einem zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Geschäftsabschluss
ein direktes oder indirektes vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Widers-
pruch steht, muss dieser Interessenskonflikt im Protokoll über den betreffenden Geschäftsabschluß aufgenommen
werden. Dieser Artikel 18.7 ist nicht anwendbar auf laufende Geschäfte.
Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
19.1 Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung
des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.
78691
19.2 Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
19.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden
sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.
Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame
Unterschrift von je einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B oder durch die
Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jed-
weder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder den
alleinigen Geschäftsführer übertragen worden ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen einer
Übertragung der Führung des Tagesgeschäfts gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden,
dem/denen die Befugnis in Verbindung mit der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde.
E. Aufsicht
Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - unabhängige(r) Buchprüfer.
21.1 Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder
mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.
21.2 Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und
ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.
21.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung
abberufen werden.
21.4 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Geschäfte
der Gesellschaft.
21.5 Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten
der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.
21.6 Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher
aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von
Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.
21.7 Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/
werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.
F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 23. Gewinne.
23.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamt-
summe der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.
23.2 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage
zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.
23.3 Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt
werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.
23.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen wird die Gesellschafterversammlung beschließen, wie der verbleibende Rest
des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden
soll.
Art. 24. Zwischendividenden. Die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden zahlen unter der Vorausse-
tzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (Ii) der auszuschüttende
Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der
Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu
diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die
gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (Iii) der Buchprüfer der Gesell-
schaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen
erfüllt sind.
78692
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-
toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse der und die Zahlung an die Liquidatoren bestimmt.
H. Anwendbares Recht
Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-
burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2008.
2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zeichnenden Gesellschafter haben die auszugebenden Geschäftsanteile wie folgt gezeichnet:
1) Herr Conrado Dornier, vorbenannt,
zahlte sechstausendzweihunderteinundfünfzig Euro (EUR 6.251) gegen Zeichnung von sechstausendzweihundertei-
nundfünfzig (6.251) Geschäftsanteilen; und
2) Frau Martine Dornier-Tiefenthaler, vorbenannt,
zahlte sechstausendzweihundertneunundvierzig Euro (EUR 6.249) gegen Zeichnung von sechstausendzweihundert-
neunundvierzig (6.249) Geschäftsanteilen.
Gesamt: zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezahlt für zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile.
Alle Geschäftsanteile sind ganz in Bar eingezahlt worden, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500) von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Auslageni>
Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang
mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden
sollen, werden auf EUR 1.800,- geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Die Gründungsgesellschafter, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren und die sich selbst als ord-
nungsgemäß geladen erachten, haben sofort eine Gesellschafterversammlung abgehalten. Nachdem die Gesellschafter-
versammlung zunächst überprüft hat, ordnungsgemäß konstituiert zu sein, hat sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.
1. Die Zahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats wird auf drei (3) festgesetzt.
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder des Geschäftsführerrats der Gesellschaft für eine unbestimmte Zeit
ernannt:
<i>als Geschäftsführer der Kategorie A:i>
a) Herr Conrado Dornier, geboren am 25. Juli 1953 in Madrid, Spanien, mit beruflicher Adresse in Faistenberg 1,
D-82547 Eurasburg, Deutschland;
b) Frau Martine Dornier-Tiefenthaler, geboren am 21. August 1954 in München, Deutschland, mit beruflicher Adresse
in Faistenberg 1, D-82547 Eurasburg, Deutschland,
<i>und als Geschäftsführer der Kategorie B:i>
c) Herr François Lanners, geboren in Mersch, am 03. Oktober 1948, mit beruflicher Adresse in 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxemburg.
3. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 23, avenue Monterey, L-2068 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Tage wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, hat der Bevoll-
mächtigte diese originale Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: U. BRÄUER - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juin 2008, LAC/2008/23254. — Reçu à 0,50%: soixante-deux euros cinquante cents
(EUR 62,50).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Franck SCHNEIDER.
FÜR GLEICHLAUTENDE ABLICHTUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations erteilt.
78693
Luxemburg, den neunzehnten Juni zweitausendacht.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2008078310/242/396.
(080088679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.
R3 Capital Partners (Luxembourg I), S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 138.703.
In the year two thousand and eight, on the twenty-third day of May.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of R3 Capital Partners (Luxembourg
I) S.à r.l., incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and in process of registration with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (the Company). The Company has been incorporated on May 14, 2008
pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles)
have not been amended so far.
THERE APPEARED:
R3 Capital Partners Master, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered office at c/o
Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands, regis-
tered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under the number WK-25892 (the Sole
Shareholder),
here represented by Claire-Marie Darnand, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
The Meeting has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. (i) Change of the functional currency of the Company's share capital from Euro (EUR) to United States Dollars
(USD), (ii) conversion of the amount of the Company's share capital in an amount expressed in United States Dollars
(USD), and (iii) change of the par value of the shares of the Company to bring it at one United States Dollar (USD 1) per
share and increase of the number of shares accordingly, in order to set, as a result of the changes listed under items (i)
to (iii) here above, the Company's share capital at approximately the equivalent in United States Dollars of twelve thousand
five hundred Euro (EUR 12,500), with all the shares having each a par value of one United States Dollar (USD 1), at the
official exchange rate of the European Central Bank publicly available at the date preceding the Meeting (the Converted
Share Capital);
2. Increase of the Converted Share Capital in order to bring it to twenty-five thousand United States Dollars (USD
25,000), represented by twenty-five thousand (25,000) shares, having par value of one United States Dollar (USD 1) each,
by way of the issue of new shares, having a par value of one United States Dollar (USD 1)each;
3. Subsequent amendment to article 5.1 of the Articles in order to reflect the changes specified in items 2. and 3.
above;
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, any employee of Citco (Luxembourg) S.A., and any lawyer or employee
of Loyens & Loeff, each of such persons acting individually under his/her sole signature on behalf of the Company, (i) to
proceed with the registration of the issue of new shares in the register of shareholders of the Company and (ii) to see
to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of doubt the filing and publication of documents
with relevant Luxembourg authorities); and
5. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves:
i. to change the functional currency of the Company from euro (EUR) to United States Dollars (USD) with immediate
effect;
78694
ii. to convert the amount of the Company's share capital in an amount expressed in United States Dollars (USD) at
the official exchange rate of the European Central Bank dated as of May 22, 2008 (i.e. EUR 1 = USD 1,5755); and
iii. to change the par value of the shares of the Company by bringing it at one United States Dollar (USD 1) per share
and to increase the number of shares accordingly,
in order to set, as a result of the changes listed under items (i) to (iii) here above, the Company's share capital at
nineteen-thousand six hundred ninety-three United States Dollars (USD 19,693), represented by nineteen thousand six
hundred ninety-three (19,693) shares, having a par value of United States Dollar (USD 1) each. The conversion excess
shall be allocated to a reserve account of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase the Company's share capital by five thousand three hundred seven United States
Dollars (USD 5,307) in order to bring it from its present amount of nineteen-thousand six hundred ninety-three United
States Dollars (USD 19,693), represented by nineteen thousand six hundred ninety-three (19,693) shares, having a par
value of United States Dollar (USD 1) each, to twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000), represented by
twenty-five thousand (25,000) shares, having par value of one United States Dollar (USD 1) each, by way of the issue of
five thousand three hundred seven (5,307) new shares, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to and full payments of the share capital increase
as follows:
<i>Subscription - paymenti>
R3 Capital Partners Master, L.P., represented as stated above, declares to subscribe to five thousand three hundred
seven (5,307) shares in the share capital of the Company, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each,
and to fully pay up such shares by a contribution in cash in the amount of five thousand three hundred seven United States
Dollars (USD 5,307).
The contribution in cash in an amount of five thousand three hundred seven United States Dollars (USD 5,307) is to
be allocated to the nominal share capital account of the Company; and
As a consequence of the above, R3 Capital Partners Master, L.P. shall be the sole shareholder of twenty-five thousand
(25,000) shares in the share capital of the Company, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles which will henceforth read as follows:
" Art. 5. Capital. The share capital is set at twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000), represented by
twenty-five thousand (25,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollars (USD 1) each,
all subscribed and fully paid-up."
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company, any employee of Citco (Luxembourg) S.A., and any
lawyer or employee of Loyens & Loeff, each of such persons acting individually under his/her sole signature on behalf of
the Company, (i) to proceed with the registration of the issue of new shares in the register of shareholders of the Company
and (ii) to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of doubt the filing and publication
of documents with relevant Luxembourg authorities).
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 1,000.- (one thousand euro).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le vingt-troisième jour du mois de mai.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de R3 Capital Partners (Luxem-
bourg I) S.à r.l., constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (la Société). La Société a été constituée le 14 mai 2008 suivant un acte de
78695
Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, pas encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés jusqu'à présent.
A COMPARU:
R3 Capital Partners Master, L.P., une société en commandite exonérée constituée selon les lois des Iles Cayman, ayant
son siège social à c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,
les Iles Cayman, immatriculée au Registre des Sociétés en Commandite des Iles Cayman sous le numéro WK-25892
(l'Associé Unique),
ici représentée par Claire-Marie Darnand, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter comme suit les
statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
L'Assemblée a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. (i) Modification de la devise fonctionnelle du capital social de la Société de l'euro (EUR) en dollars américains (USD),
(ii) conversion du montant du capital social de la Société en un montant exprimé en dollars américains (USD), et (iii)
modification de la valeur nominale des parts sociales de la Société afin de la porter à un dollar américain (USD 1) par part
sociale et augmentation du nombre de parts sociales en conséquence, afin de fixer, suite aux modifications indiquées aux
points (i) à (iii) ci-dessus, le capital social de la Société à l'équivalent en dollars américains de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500), avec toutes les parts sociales ayant chacune une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1), au taux
de change officiel de la Banque Centrale Européenne disponible publiquement à la date précédant celle de l'Assemblée
(le Capital Social Converti);
2. Augmentation du Capital Social Converti afin de le porter à vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000), re-
présenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, par
l'émission de nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune;
3. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter les modifications indiquées aux points 2. et 3.
ci-dessus;
4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, tout employé de Citco (Luxembourg) S.A., et tout avocat ou employé de Loyens &
Loeff, chacune de ces personnes agissant individuellement sous sa signature individuelle pour le compte de la Société, (i)
pour procéder à l'inscription de l' émission des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la
Société et (ii) de veiller à toutes les formalités qui s'y rattachent (en ce compris, en tout état de cause, le dépôt et la
publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises concernées); et
5. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide:
i. de modifier la devise fonctionnelle de la Société de l'euro (EUR) en dollars américains (USD) avec effet immédiat;
ii. de convertir le montant du capital social de la Société en un montant exprimé en dollars américains (USD) au taux
de change de la Banque Centrale Européenne du 22 mai 2008 (i.e. EUR 1 = USD 1,5755); et
iii. de modifier la valeur nominale des parts sociales de la Société en la portant à un dollar américain (USD 1) par part
sociale, et d'augmenter le nombre de parts sociales en conséquence,
afin de fixer, suite aux modifications listées aux points (i) à (iii) ci-dessus, le capital social de la Société à dix-neuf mille
six cent quatre-vingt treize dollars américains (USD 19.693), représenté par dix-neuf mille six cent quatre-vingt treize
(19.693) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune. L'excédent de conversion sera
affecté à un compte de réserve de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinq mille trois cent sept dollars
américains (USD 5.307) afin de le porter de son montant actuel de dix-neuf mille six cent quatre-vingt treize dollars
américains (USD 19.693) représenté par dix-neuf mille six cent quatre-vingt treize (19.693) parts sociales ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, à vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000), représenté vingt-
cinq mille (25.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, par l'émission de cinq
mille trois cent sept (5.307) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune.
78696
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes à et la libération intégrale de l'augmentation
du capital social comme suit:
<i>Souscription - libérationi>
R3 Capital Partners Master, L.P., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cinq mille trois cent sept
(5.307) parts sociales dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune,
et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de cinq mille trois cent sept dollars américains
(USD 5.307).
L'apport en numéraire d'un montant de cinq mille trois cent sept dollars américains (USD 5.307) est à affecter de la
manière suivante au compte capital social nominal de la Société; et
En conséquence de ce qui précède, R3 Capital Partners Master, L.P. sera l'associé unique de vingt-cinq mille (25.000)
parts sociales dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Capital. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000), représenté
par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD
1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout employé de Citco (Luxembourg) S.A., et tout avocat ou
employé de Loyens & Loeff, chacune de ces personnes agissant individuellement sous sa signature individuelle pour le
compte de la Société, (i) pour procéder à l'inscription de l'émission des parts sociales nouvellement émises dans le registre
des associés de la Société et (ii) de veiller à toutes les formalités qui s'y rattachent (en ce compris, en tout état de cause,
le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises concernées).
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société en raison du présent acte
s'élèvent approximativement à EUR 1.000.-(mille euros).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'à la requête de la même partie comparante, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte original.
Signé: C.-M. DARNAND et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 mai 2008. Relation: LAC/2008/21190
Reçu seize euros quatre-vingt-six cents
(0,50% = 16,86.- EUR)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): F. SCHNEIDER.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2008.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2008077258/242/206.
(080088110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.
HarbourVest VIII-Mezzanine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 139.324.
STATUTES
In the year two thousand eight, on the fifth day of June,
before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
HarbourVest Partners VIII Mezzanine and Distressed Debt Fund L.P., a limited partnership organised under the laws
of Delaware with registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801,
78697
represented by Ms Flora Gibert, jurist, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on May
29, 2008,
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration. Such appearing party, represented as stated here-above,
has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company
(société a responsabilité limitéé), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société á responsabilité limitéé) under the name
"HarbourVest VIII-Mezzanine S.à r.l." (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in
particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the reg-
istered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2 The Company may exercise managerial functions through management decisions vis-à-vis its subsidiaries. The
Company may grant sub-licenses, any kind of debt, equity and hybrid financing and render any kind of services, including,
without limitation, engineering services, in particular to any of its subsidiaries and to third party sublicensees.
3.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by five hundred (500)
shares in registered form, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
78698
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-
quarters of the rights owned by the survivors. A share transfer is only binding upon the Company or third parties following
a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
7.3. The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A managers and one or
several Class B managers.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which,
in principle, is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions
of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the
single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several Class B
managers, at least one (1) A manager and one (1) B manager (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour
of the resolution. The chairman shall not be entitled to a second or casting vote.
(vi) The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman
has been appointed, by all the managers present or represented.
(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) Subject to article 8.3 (iii), the Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any
two (2) managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
(iii) If the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several
Class B managers, the Company will be bound towards third parties by (i) the single signature of one Class A manager
or by (ii) the joint signature of one Class A manager and one Class B manager.
78699
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to
be read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made
by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles.
Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting
duly convened and held and bear the date of the last signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital.
If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened
by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the
General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion
of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
78700
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by
law.
14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the
term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distrib-
utable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the
date of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half of the
shareholders holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need
not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise
decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the
Company.
16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Res-
olutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which
taken together constitute one and the same document.
17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to
any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
VI. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2008.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, HarbourVest Partners VIII Mezzanine and Distressed Debt Fund L.P., prenamed and represented as stated
above, declares to subscribe for 500 (five hundred) shares in registered form, with a nominal value of EUR 25 (twenty-
five Euro) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to EUR 12,500 (twelve thousand five
hundred Euro) which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.
The amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) is at the disposal of the Company, as has been proved
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
78701
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following person is appointed as A manager of the Company for an indefinite period:
- Ms. Martha D. Vorlicek, Managing Director and Chief Operating Officer of HarbourVest Partners, LLC, born on May
28, 1959 in Maine, USA, with professional address at One Financial Center, Boston, MA 02111.
2. The following person is appointed as B manager of the Company for an indefinite period:
- Mr Patrice Gallasin, lawyer, born on December 9, 1970 at Villers-Semeuse (France), with professional address at 1,
rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
3. The registered office of the Company is set at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le cinquième jour du mois de juin,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
HarbourVest Partners VIII Mezzanine and Distressed Debt Fund L.P., une société en commandite organisée selon les
lois du Delaware avec siège social à c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801,
représentée par Flora Gibert, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
le 29 mai 2008,
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter de la façon
suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination "HarbourVest VIII-
Mezzanine S.à r.l." (ci-après la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les
Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
les limites de la commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la
modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
78702
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut exercer des fonctions de gestion par le biais de décisions de gestion vis-à-vis de ses filiales. La
Société peut accorder des sous-licences, toute sorte de financement par dette, par capital et financement hybride et
rendre toutes sortes de services, y compris, sans limitation, des services d'ingénierie, en particulier à l'une de ses filiales
et à des tiers titulaires de sous-licences.
3.3. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou bien créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et
celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En
tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'au-
torisation requise.
3.4. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à la gestion efficace de ses investisse-
ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.5. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales
sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-
quarts des droits détenus par les survivants.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-
santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée
de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une résolution des associés.
7.3. L'associé unique ou les associés peuvent décider de nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs
gérants de Classe B.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
78703
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en
principe, est au Luxembourg.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont exposées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à
une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant à des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à condition
que, si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de
Classe B, au moins un (1) gérant A et un (1) gérant B (dans chaque cas, que ce soit en personne ou par procuration) vote
en faveur de la décision. Le président n'aura pas droit à un second vote ou vote prépondérant.
(vi) Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si
aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler mutuellement. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion
valablement convoquée et tenue.
(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) Sous réserve de l'article 8.3 (iii), la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures
conjointes de deux (2) gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
(iii) Si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérant(s) de Classe A et un ou plusieurs gérant(s)
de Classe B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par (i) la signature individuelle d'un gérant de Classe A ou par (ii)
la signature conjointe d'un gérant de Classe A et d'un gérant de Classe B.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est administrée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit
être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Quand les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est com-
muniqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale dûment
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
78704
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont exposées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure indiqués dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vi) Les résolutions à adopter aux Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées
par des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première
Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde
Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les résolutions sont adoptées à l'Assemblée Générale ou par
Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, indépendamment de la proportion du capital social
représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les
trois-quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Lorsque le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi
à l'Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des
Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1
er
) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque
année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des
actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.
13.3. Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de résultats sont approuvés à l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires
des Associés endéans les six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice social.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par
la loi.
14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, le cas échéant, et fixent leur nombre, rémunération et la durée
de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises sont rééligibles.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent affecter ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.
15.3. Des acomptes sur dividende peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
78705
(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividende doit être adoptée par les associés endéans les deux (2) mois
suivant la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividende qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,
les associés doivent reverser l'excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié des associés
détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, pour
réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les
liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, et respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des
Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même docu-
ment, qui ensemble, constituent un seul et même document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et se termine le 31 décembre 2008.
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ce, HarbourVest Partners VIII Mezzanine and Distressed Debt Fund L.P., prénommé et représenté comme indiqué
ci-dessus, déclare souscrire à 500 (cinq cents) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de EUR
25 (vingt-cinq euros) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de EUR 12.500
(douze mille cinq cents euros) qui sera affecté au compte capital social nominal de la Société.
Le montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille cinq cents Euro.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
- Mme Martha D. Vorlicek, Administratrice Déléguée et Directrice Générale de HarbourVest Partners, LLC, née le
28 mai 1959 dans le Maine, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle à One Financial Center, Boston,
MA 02111.
2. La personne suivante est nommée gérant de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Patrice Gallasin, avocat, né le 9 décembre 1970 à Villers-Semeuse (France), ayant son adresse professionnelle au
1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite à la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
78706
Enregistré à Luxembourg A.C., le 09 juin 2008, Relation LAC/2008/23176. — Reçu soixante-deux euros cinquante
cents (62,50 €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRANCK SCHNEIDER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 13 juin 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008077295/211/512.
(080088375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.
Macarena International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 122.537.
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
06 juin 2008 à 14.30 h
a été nommé gérant unique Heinrich J. M. Meijers, né le 12 octobre 1965 à Geleen, Pays-Bas, et demeurant Hoofdstraat
62, NL-6333 BK Schimmert, Pays-Bas,
à effet du 1
er
juillet 2008
en remplaçant Jan Herman van Leuvenheim.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 09 juin 2008.
<i>MACARENA INTERNATIONAL Sàrl
i>Jan H. van Leuvenheim
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2008076672/816/20.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05929. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Oxford Aviation Academy Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GCAT Flight Academy Luxembourg S.à r.l.).
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 123.624.
In the year two thousand and eight, on the thirtieth day of the month of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "GCAT Flight Academy Luxembourg S.à r.l." (the
"Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 123.624, and incorporated
on 12th January 2007 by deed of the undersigned notary published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial") number 407 of 20 March 2007.
The articles of incorporation have been amended for the last time on 27 June 2007 by deed of the undersigned notary,
not yet published in the Mémorial.
The meeting was presided by M
e
Antoine Daurel, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer M
e
Habiba Boughaba, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by
the proxy holder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain attached
to these minutes to be filed with the registration authorities.
The meeting was convened by notices sent by registered mail to all the shareholders of the Company on 19th May
2008.
It appeared from said attendance list that 71,968 class A shares, 702,806 class B shares and 135,317 class C shares in
issue in the Company were represented at the general meeting so that the meeting was validly constituted and able to
validly decide on the items on the agenda.
2. The agenda of the meeting is as follows:
78707
Change of name of the Company into "Oxford Aviation Academy Luxembourg S.à r.l." and consequential amendment
of article 1 of the articles of incorporation.
After deliberation the meeting unanimously resolved as follows:
<i>Sole resolutioni>
The meeting resolved to change the name of the Company into "Oxford Aviation Academy Luxembourg S.à r.l." and
to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
" Art. 1. Name. Between the initial subscribers and those who become holders of the Shares (parts sociales) thereafter,
a limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Oxford Aviation Academy Luxembourg S.à
r.l." (the "Company") is constituted and existing, governed by these Articles of Association and the relevant legislation."
Nothing further being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Whereas the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the prenamed members of the board signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trentième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de "GCAT Flight Academy Luxembourg S.à r.l." (la "So-
ciété"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.624 et constituée le 12 janvier
2007 par acte du notaire soussigné publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro
407 du 20 mars 2007.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 27 juin 2007 suivant acte du notaire soussigné, non encore publié
au Mémorial.
L'assemblée a été présidée par M
e
Antoine Daurel, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Il fut nommé comme secrétaire et scrutateur M
e
Habiba Boughaba, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont repris dans une liste de présence
signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste restera annexée au
présent acte pour être soumise aux autorités de l'enregistrement.
L'assemblée a été convoquée par des avis envoyés en recommandé à tous les associés de la Société en date du 19 mai
2008.
Il appert de ladite liste de présence que 71.968 parts sociales de classe A, 702.806 parts sociales de classe B et 135.317
parts sociales de classe C émises dans la Société étaient représentées à la présente assemblée générale de sorte que
l'assemblée était valablement constituée et pouvait valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.
2. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
Changement de dénomination de la Société en "Oxford Aviation Academy Luxembourg S.à r.l." et modification sub-
séquente de l'article 1
er
des statuts.
Après délibération, l'assemblée a décidé à l'unanimité ce qui suit:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée a décidé de changer la dénomination de la Société en "Oxford Aviation Academy Luxembourg S.à r.l." et
de modifier en conséquence l'article 1
er
des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
" Art. 1
er
. Dénomination. Il est créé et existe entre les souscripteurs initiaux et tous ceux qui deviendront détenteurs
de Parts Sociales par la suite une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Oxford Aviation Academy
Luxembourg S.à r.l." (la "Société") régie par les présents Statuts et la loi applicable."
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes,
le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande des mêmes parties com-
parantes, en cas divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent procès-verbal, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. DAUREL, H. BOUGHABA et H. HELLINCKX.
78708
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juin 2008. Relation: LAC/2008/22704. - Reçu douze euros (12,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): F. SCHNEIDER.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2008.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2008078176/242/86.
(080088951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.
Analisis de Procesos Financieros Procesando Luxemburgo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.
R.C.S. Luxembourg B 139.328.
STATUTES
In the year two thousand eight, on the thirtieth of May.
Before Maître Alex WEBER, notary residing at Bascharage.
THERE APPEARED:
1) The company "Analisis de Procesos Financieros Procesando SL", with registered office in 48901 Barakaldo (Vizcaya),
Spain, Herriko Plaza, 9, with trade register number B95513131.
2) Mr Daniel Aldasoro Olabegoya, financial advisor, born in Getxo (Spain) on January 30th, 1975, residing at 48901
Barakaldo (Vizcaya), Spain, Herriko Plaza, 9.
3) Mr Angel Larrauri Zubieta, financial advisor, born in Bilbao (Spain) on April 10th, 1953, residing at 48901 Barakaldo
(Vizcaya), Spain, Herriko Plaza, 9.
4) Mr Juan Carlos de Rio Alvarez, programmer, born in Madrid (Spain) on September 19th, 1961, residing at 48901
Barakaldo (Vizcaya), Spain, Herriko Plaza, 9,
all represented by Mr. Carlos Alberto Morales Lopez, companies manager, with professional address in L-2354 Lux-
embourg, 19, rue Eugène Ruppert, by virtue of four proxies dated of May 22nd, 2008.
Said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.
Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may become
partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws
pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10th, 1915 on commercial companies, as well as by
the present articles (hereafter the "Company").
Art. 2. The object of the company is to carry out investment advisor activities for the exclusive benefit to the fund A4
FUND SIF, a Luxembourg investment fund regulated by the law of the 13th February 2007 related to the specialized
investment fund; and this in conformity with the article 72 (2) j) of the Luxembourg law of the 13 July 2007 related to
the financial market instruments.
In this respect, the company will never act as a professional of the financial sector, nor as investment consulting or
distributor of OPC shares which would be supervised by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF).
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name "ANALISIS DE PROCESOS FINANCIEROS PROCESANDO LUXEMBURGO
S. à r.l."
Art. 5. The registered office is established in Clemency.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (€ 12,500,-) represented
by one thousand two hundred and fifty (1.250) shares with a nominal value of ten euros (€ 10,-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders
meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
78709
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements
of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners
will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholders meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
individual signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a
general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of
the board of managers.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may
subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state
that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any
manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex
another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the
board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing
in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly.
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of
shareholders representing the three quarters of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
Every meeting shall be held in Clemency or such other place as the managers may from time to time determine.
In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and
the result of the vote shall be drawn up by the notarial minute, the whole by and at the request of the management or
by any other duly authorised person delegated by the management.
78710
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Art. 16. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
Art. 17. Each year, with reference to December 31st, the Company's accounts are established and the manager, or in
case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.
Art. 19. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners
or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Reference is made to the provisions of the law of August 10th, 1915, as amended, for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares have been subscribed as follows:
Shares
a) The company "Analisis de Procesos Financieros Procesando SL", prenamed, one hundred and twenty-five
shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
b) Mr Daniel Aldasoro Olabegoya, prenamed, three hundred and seventy-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375
c) Mr Angel Larrauri Zubieta, prenamed, two hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
d) Mr Juan Carlos del Rio Alvarez, prenamed, five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: one thousand two hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,250
The shares subscribed have been fully paid up by a payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred
euros (€ 12,500,-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on December 31st, 2008.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euros (€ 1,500,-).
<i>Decisions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation, the shareholders, representing the entire subscribed capital of the Company, have
herewith adopted the following resolutions:
1) The number of managers is set at one.
The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period of time: Mr Daniel Aldasoro Olabegoya,
prenamed.
2) The company shall be bound in any circumstances by the individual signature of the sole manager.
3) The registered office is established at L-4963 Clemency, 8, rue Haute.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn at Bascharage, at the notary's office, on the year and day first above
written.
The document having been read to the proxyholder, the same signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trente mai.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
78711
ONT COMPARU:
1) La société "Analisis de Procesos Financieros Procesando SL", ayant son siège social à 48901 Barakaldo (Vizcaya),
Espagne, Herriko Plaza, 9, inscrite au registre de commerce sous le numéro B95513131.
2) Monsieur Daniel Aldasoro Olabegoya, conseiller financier, né à Getxo (Espagne) le 30 janvier 1975, demeurant à
48901 Barakaldo (Vizcaya), Espagne, Herriko Plaza, 9.
3) Monsieur Angel Larrauri Zubieta, conseiller financier, né à Bilbao (Espagne) le 10 avril 1953, demeurant à 48901
Barakaldo (Vizcaya), Espagne, Herriko Plaza, 9.
4) Monsieur Juan Carlos de Rio Alvarez, programmeur, né à Madrid (Espagne) le 19 septembre 1961, demeurant à
48901 Barakaldo (Vizcaya), Espagne, Herriko Plaza, 9,
tous ici représentés par Monsieur Carlos Alberto Morales Lopez, companies manager, demeurant professionnellement
à L-2354 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, en vertu de quatre procurations données le 22 mai 2008.
Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire soussigné,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire soussigné de dresser acte d'une société à responsabilité
limitée que les parties déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir associés
par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
Art. 2. La Société a pour objet l'activité de consultant en investissements au bénéfice exclusif du "A4 FUND SIF", un
fonds d'investissement luxembourgeois soumis aux dispositions de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investis-
sement spécialisés; et ce conformément à l'article 72 (2) j) de la loi luxembourgeoise du 13 juillet 2007 relative aux
marchés d'instruments financiers.
A ce titre, la Société n'exercera en aucune manière une activité de professionnel du secteur financier, de conseiller en
investissement ou de distributeur de parts d'organismes de placement collectif qui relèverait de la surveillance de la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de "ANALISIS DE PROCESOS FINANCIEROS PROCESANDO LUXEM-
BURGO S. à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi à Clemency.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) représenté par mille deux
cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (€ 10.-) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'assemblée des associés, confor-
mément à l'article 14 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil
de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.
78712
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature individuelle de l'un quelconque des membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi
ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le
cadre des compétences du Conseil de gérance.
L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence.
On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils
déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil
de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil
de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par
écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil
de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les
résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date
de la dernière signature.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément
formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées a la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représentée.
Toute assemblée se tiendra à Clemency ou a tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du
scrutin fera l'objet d'un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute autre
personne a ce déléguée par la gérance.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés a responsabilité limitée.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
Art. 16. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 17. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Art. 18. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.
78713
Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de
la loi du 10 août 1915.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales ont été souscrites ainsi qu'il suit:
Parts
sociales
a) La société "Analisis de Procesos Financieros Procesando SL", préqualifiée, cent vingt-cinq parts sociales . .
125
b) Monsieur Daniel Aldasoro Olabegoya, préqualifié, trois cent soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . .
375
c) Monsieur Angel Larrauri Zubieta, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
d) Monsieur Juan Carlos del Rio Alvarez, préqualifié, cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement à mille cinq cents euros (€ 1.500.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
1) Le nombre de gérants est fixé à un.
Monsieur Daniel Aldasoro Olabegoya est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2) La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
3) Le siège de la société est établi à L-4963 Clemency, 8, rue Haute.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: MORALES LOPEZ, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 3 juin 2008, Relation: CAP/2008/1736. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents 12.500,00
à 0,5% = 62,50.
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 13 juin 2008.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2008077289/236/304.
(080088482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.
Ingersoll-Rand Lux Finance Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.000.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 138.705.
In the year two thousand and eight, on the thirtieth day of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Ingersoll-Rand Lux Finance Holding
Sàrl, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg, with
78714
registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under the number B 138.705 (the Company), incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary, on May 14, 2008, in the process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
Here appeared:
Ingersoll-Rand (Gibraltar) Holding Limited, a limited company, existing under the laws of Gibraltar, having its registered
office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered with the Registrar of Companies of Gibraltar under number 100757,
here represented by Maître Mélanie Sauvage, attorney at law, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that one thousand (1,000) shares of the Company having a par value of twenty-five US dollars (USD 25) each,
representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred million US dollars (USD 100,000,000)
in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twenty-five thousand US dollars (USD
25,000) represented by one thousand (1,000) shares in registered form, having a par value of twenty-five US dollars (USD
25) each, to one hundred million twenty five thousand US dollars (USD 100,025,000), by the issuance of four million
(4,000,000) new shares having a par value of twenty-five US dollars (USD 25) each, having the same rights as the existing
shares;
2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above, it being understood that an
amount of one billion six hundred million US dollars (USD 1,600,000,000) shall be allocated to the share premium reserve
of the Company;
3. Reduction of the share capital of the Company by an amount of twenty-five thousand US dollars (USD 25,000) in
order to bring the share capital of the Company from one hundred million twenty five thousand US dollars (USD
100,025,000) represented by four million one thousand (4,001,000) shares of the Company having a par value of twenty-
five US dollars (USD 25) each, to one hundred million US dollars (USD 100,000,000) by way of the cancellation of one
thousand (1,000) shares held by the Company in its share capital subsequent to the contribution by Ingersoll-Rand (Gi-
braltar) Holding Limited of all its assets and liabilities;
4. Subsequent amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect
the increase of the share capital adopted under items 1. and 3. above;
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority to any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg and to any employee of AIB to proceed on behalf
of the Company with the registration of the newly issued shares and the cancelled shares in the register of shareholders
of the Company;
6. Miscellaneous.
These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Meeting, duly represented, unanimously
resolves on the following:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of one
hundred million US dollars (USD 100,000,000) in order to bring the share capital of the Company from its present amount
of twenty-five thousand US dollars (USD 25,000) represented by one thousand (1,000) shares in registered form, having
a par value of twenty-five US dollars (USD 25) each, to one hundred million twenty five thousand US dollars (USD
100,025,000), by the issuance of four million (4,000,000) new shares having a par value of twenty-five US dollars (USD
25) each, having the same rights as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase
as follows:
<i>Subscription and paymenti>
Ingersoll-Rand (Gibraltar) Holding Limited, represented as stated above (Gibco), declares that it subscribes to four
million (4,000,000) new shares having a par value of twenty-five US dollars (USD 25) each, having the same rights as the
existing shares, in the Company and to fully pay up such shares by a contribution in kind consisting of all its assets and
liabilities, except for those assets and liabilities that are simultaneously contributed to Ingersoll-Rand Worldwide Capital
Sàrl, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg, with
78715
registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 89 900 (IR WWC) (the Gibco Assets).
Such contribution in kind of the Gibco Assets to the Company is made simultaneously with the contribution by Gibco
of its other assets and liabilities to IR WWC, in exchange for an issue of new shares of IR WWC on the occasion of an
extraordinary general meeting of the shareholders of IR WWC respectively, it being understood that the contributions
made by Gibco to the Company and to IR WWC constitute simultaneous contributions of all the assets and liabilities of
Gibco. The assets number 17. and 18. and the liabilities will be contributed to the Company and the assets number 1. to
16. will be contributed to IR WWC, as such numbering is mentioned and described in the balance sheet attached hereto
in Schedule 1.
The extraordinary general meeting of the shareholders of IR WWC is held simultaneously to the present Meeting
before the undersigned notary.
The contribution in kind of the Gibco Assets to the Company, in an aggregate amount of one billion seven hundred
million US dollars (USD 1,700,000,000) is to be allocated as follows:
(i) an amount of one hundred million US dollars (USD 100,000,000) is to be allocated to the nominal share capital
account of the Company, and
(ii) an amount of one billion six hundred million US dollars (USD 1,600,000,000) is to be allocated to the premium
reserve of the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Gibco Assets to the Company is evidenced by, inter alia, a balance
sheet of Gibco dated May 30, 2008 and signed for approval by the management of Gibco, which shows that the net asset
value of assets and liabilities contributed to the Company is worth at least one billion seven hundred million US dollars
(USD 1,700,000,000).
It results furthermore from a certificate dated May 30, 2008, issued by the management of Gibco that:
"1. the assets and liabilities (the Assets and Liabilities) contributed by Gibco to the Company are shown on the attached
balance sheet as per May 30, 2008;
2. based on generally accepted accountancy principles the net worth of the Assets and Liabilities contributed to the
Company per the attached balance sheet is valued at least at one billion seven hundred million US dollars (USD
1,700,000,000) and since the balance sheet date no material changes have occurred which would have depreciated the
contribution made to the Company;
3. the Assets and Liabilities contributed to the Company are freely transferable by Gibco and they are not subject to
any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;
4. all formalities to transfer the legal ownership of the Assets and Liabilities contributed to the Company have been
or will be accomplished by the management of Gibco."
A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the
appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of twenty-five thousand US dollars
(USD 25,000) in order to bring the share capital of the Company from one hundred million twenty five thousand US
dollars (USD 100,025,000) represented by four million one thousand shares (4,001,000) shares of the Company having
a par value of twenty-five US dollars (USD 25) each, to one hundred million US dollars (USD 100,000,000) by way of the
cancellation of one thousand (1,000) shares held by the Company in its share capital subsequent to the contribution of
the Gibco Assets.
The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital, as follows:
shares
Ingersoll-Rand (Gibraltar) Holding Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000,000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000,000
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles in order to
reflect the above changes, so that it shall henceforth read as follows:
"5.1. The share capital is set at one hundred million US dollars (USD 100,000,000), represented by four million
(4,000,000) shares in registered form, having a par value of twenty-five US dollars (USD 25) each, all subscribed and fully
paid-up."
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
and empowers and authorizes any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg and any employee of AIB to proceed
on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares and the cancelled shares in the register of
shareholders of the Company.
78716
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 8,000.- (eight thousand euro).
<i>Capital Duty exemptioni>
Insofar as the contribution in kind consists of a contribution of all the assets and liabilities of a company having its
statutory seat as well its principal establishment (siège de direction effective) in an European Union Member State (i.e.
Gibraltar) to two other companies having their statutory seat as well their principal establishment in an European Union
Member State (i.e. the Grand Duchy of Luxembourg), the Company refers to article 4-1 of the law dated 29 December
1971, as amended, which provides for capital duty exemption.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the said proxy holder signed together
with the notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trentième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés d'Ingersoll-Rand Lux Finance Holding
Sàrl, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de Luxembourg, avec siège social au 16, avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 138.705 (la Société), constituée suivant un acte du notaire instrumentant, le 14 mai 2008, en cours de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
A comparu:
Ingersoll-Rand (Gibraltar) Holding Limited, une société par actions (limited company), existant selon les lois de Gi-
braltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, immatriculée au Registre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro
100757,
Ici représentée par Maître Mélanie Sauvage avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
La partie, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire d'acter:
I. que mille (1.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq dollars US (USD 25) chacune, représentant
l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent
valablement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour reproduit ci-après;
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent millions de dollars US (USD 100.000.000) afin de
porter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt-cinq mille dollars US (USD 25.000) représenté par
mille (1.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq dollars US (USD 25) chacune, à cent millions vingt-
cinq mille dollars US (USD 100.025.000), par l'émission de quatre millions (4.000.000) nouvelles parts sociales ayant une
valeur nominale de vingt-cinq dollars US (USD 25) chacune, avec les mêmes droits que les parts sociales existantes;
2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social déterminée au point 1
er
. ci-dessus, étant entendu
qu'un montant d'un milliard six cent millions dollars US (USD 1.600.000.000) sera affecté à la réserve prime d'émission
de la Société;
3. Réduction du capital social de la Société d'un montant de vingt-cinq mille dollars US (USD 25.000) afin de porter le
capital social de la Société de cent millions vingt-cinq mille dollars US (USD 100.025.000) représenté par quatre millions
et mille (4.001.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq dollars US (USD 25) chacune, à cent millions
de dollars US (USD 100.000.000) par l'annulation de mille (1.000) parts sociales détenues par la Société dans son capital
social suite à l'apport effectué par Ingersoll-Rand (Gibraltar) Holding Limited de tout ses actifs et passifs;
4. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital social et la réduction
de capital social adoptées aux points 1
er
. et 3. ci-dessus;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité
à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg et à tout employé de AIB pour procéder pour le compte de la
Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises et des parts sociales annulées dans le registre des associés
de la Société;
6. Divers.
78717
Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, l'Assemblée, dûment représentée, prend à l'unanimité
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblé décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société à concurrence de cent
millions de dollars US (USD 100.000.000) pour porter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt-cinq
mille dollars US (USD 25.000) représenté par mille (1.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq dollars
US (USD 25) chacune, à cent millions vingt-cinq mille dollars US (USD 100.025.000), par l'émission de quatre millions
(4.000.000) de nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq dollars US (USD 25) chacune, ayant les
mêmes droits que les parts sociales existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation de
capital social comme suit:
<i>Souscription et libérationi>
Ingersoll-Rand (Gibraltar) Holding Limited, représentée comme indiqué ci-dessus (Gibco), déclare souscrire aux quatre
millions (4.000.000) de nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq dollars US (USD 25) chacune,
ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes, dans la Société et de libérer ces parts sociales par un apport en
nature se composant de tous ses actifs et passifs, sauf les actifs et passifs apportés simultanément à Ingersoll-Rand World-
wide Capital Sàrl, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de Luxembourg, avec siège social au 16,
avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 89.900 (IR WWC) (les Actifs Gibco).
Ledit apport en nature des Actifs Gibco à la Société est effectué simultanément avec l'apport par Gibco de ses autres
actifs et passifs à IR WWC, en échange de l'émission de nouvelles parts sociales de IR WWC, à l'occasion d'une assemblée
générale extraordinaire des associés de IR WWC, étant entendu que les apports effectués par Gibco à la Société ainsi
qu'à IR WWC constituent des apports simultanés de tous les actifs et passifs de Gibco. Les actifs numéros 17 et 18 et
les passifs seront apportés à la Société et les actifs numéros 1. à 16. seront apportés à IR WWC, laquelle numérotation
est mentionnée et décrite au bilan annexé ci-joint en Annexe 1
ère
.
L'assemblée générale extraordinaire des associés de IR WWC est tenue en même temps que la présente Assemblée
devant le notaire instrumentant.
L'apport en nature des Actifs Gibco à la Société d'un montant total d'un milliard sept cent millions de dollars US (USD
1.700.000.000) sera affecté comme suit:
(i) un montant de cent millions de dollars US (USD 100.000.000) sera affecté au compte capital social de la Société;
et
(ii) un montant d'un milliard six cent millions de dollars US (USD 1.600.000.000) sera affecté à la réserve prime
d'émission de la Société.
La valeur de l'apport en nature des Actifs Gibco à la Société est documentée, entre autres, par un bilan de Gibco daté
du 30 mai 2008 et signé pour approbation par la direction de Gibco, qui indique que la valeur nette des actifs et passifs
apportés à la Société est d'au moins un milliard sept cent millions de dollars US (USD 1.700.000.000).
Il ressort par ailleurs d'un certificat daté du 30 mai 2008 émis par la direction de Gibco que:
"1. les actifs et passifs (les Actifs et Passifs) apportés par Gibco à la Société sont indiqués sur le bilan au 30 mai 2008
ci-joint;
2. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette des Actifs et Passifs apportés à la Société
d'après le bilan annexé est évaluée à au moins un milliard sept cent millions de dollars US (USD 1.700.000.000) et depuis
la date du bilan aucune modification matérielle n'a eu lieu qui aurait déprécié l'apport effectué à la Société;
3. les Actifs et Passifs apportés à la Société sont librement cessibles par Gibco et ne sont soumis à aucune restriction
ou ne sont grevés d'aucun gage ou lien limitant leur cession ou réduisant leur valeur;
4. Toutes les formalités pour le transfert de la propriété juridique des Actifs et Passifs apportés à la Société ont été
ou seront accomplies par la direction de Gibco."
Une copie des documents mentionnés ci-dessus, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte
de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de vingt-cinq mille dollars US (USD 25.000)
afin de porter le capital social de la Société de cent millions vingt-cinq mille dollars US (USD 100.025.000) représenté par
quatre millions et mille (4.001.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq dollars US (USD 25) chacune,
à cent millions de dollars US (USD 100.000.000) par l'annulation de mille (1.000) parts sociales détenues par la Société
dans son capital social suite à l'apport des Actifs Gibco.
L'Assemblée décide d'enregistrer l'actionnariat dans la Société, à la suite de l'augmentation de capital, de la manière
suivante
78718
parts
sociales
Ingersoll-Rand (Gibraltar) Holding Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des Statuts afin d'y refléter
les modifications ci-dessus, de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:
"6. Le capital social de la Société est fixé à cent millions de dollars US (USD 100.000.000) représenté par quatre millions
(4.000.000) de parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq dollars US (USD 25) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées."
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
pouvoir et autorité à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg et à tout employé de AIB pour procéder
pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises et les parts sociales annulées dans le
registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approxi-
mativement à la somme de EUR 8.000,- (huit mille euros).
<i>Exonération du droit d'apporti>
Etant donné que l'apport en nature se compose de tous les actifs et passifs d'une société ayant son siège social et son
siège de direction effective dans un état membre de l'Union Européenne (i.e. Gibraltar) à deux autres sociétés ayant leur
siège social et leur siège de direction effective dans un état membre de l'Union Européenne (i.e. le Grand-Duché de
Luxembourg), la Société s'en réfère à l'article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit l'exoné-
ration du droit d'apport.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: M. SAUVAGE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juin 2008, Relation: LAC/2008/23256. — Reçu douze euros (12,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): F. SCHNEIDER.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2008.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2008078175/242/272.
(080088942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.
AFD Le Pouzin A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 822.250,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 112.939.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale du 6 mars 2008 que les mandats de tous les gérants sont dorénavant d'une durée
déterminée qui prendra fin le jour de l'Assemblée Générale de l'année 2008 qui approuvera les comptes annuels de la
Société au 31 décembre 2007.
A noter que:
- L'adresse professionnelle de Monsieur Mohammed CHOWDHURY est au Villa 15, Gate 30, avenue 35, Janabiyah
561, Bahrain.
- Le prénom de Monsieur THOMPSON, Gérant B, est Henry A.
78719
Munsbach, le 6 juin 2008.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2008076185/1337/22.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03323. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080086819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.
A Tasquinha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9170 Mertzig, 17, rue de Michelbouch.
R.C.S. Luxembourg B 102.984.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 18 juin 2008.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
50, Esplanade - L-9227 Diekirch
<i>Un mandataire
i>Signature
Référence de publication: 2008077153/2602/17.
Enregistré à Diekirch, le 13 juin 2008, réf. DSO-CR00186. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080087635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Bau & Boden Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 117.919.
Le bilan au 31. Dezember 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 18.06.08.
Signature.
Référence de publication: 2008076878/5318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04369. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080087220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Café Montalegre s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9168 Mertzig, 13, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 127.249.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 18 juin 2008.
<i>Pour la Société
i>COFINOR S.A.
50, Esplanade - L-9227 Diekirch
<i>Un mandataire
i>Signature
Référence de publication: 2008077152/2602/17.
Enregistré à Diekirch, le 17 juin 2008, réf. DSO-CR00216. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080087637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
78720
AFD Le Pouzin A S.à r.l.
Agence de l'Energie
Alimar S.A.
Analisis de Procesos Financieros Procesando Luxemburgo S.à r.l.
Aphrodite Investments S.A.
Array Holding Company S.A.
A Tasquinha S.à r.l.
Aviador Holding S.à r.l.
Bakery Equity Luxembourg S.A.
Bau & Boden Consulting S.A.
Bau Komplett Service S.à r.l.
B & B Interinvest S.A.
Bifin S.A.
Brisants 1 S.A.
Café Montalegre s.à r.l.
Calilux S.à r.l.
Coiffure Martine S.àr.l.
Corbis S.A.
David Morrisson S.à r.l.
Delux-Bau S.à r.l.
EastNets Europe S.A.
Electrum S.à r.l.
Enra S.à r.l.
Euraussie Finance S.A.
Expersoft Systems S.à.r.l.
Finance Immobilière Holding
GCAT Flight Academy Luxembourg S.à r.l.
Growth Yield Return S.A.
H.A.C.O. S.A.
HarbourVest VIII-Mezzanine S.à r.l.
Immobilière 2F S.A.
Implant-Lux S.A.
Implant-Lux S.A.
Ingersoll-Rand Lux Finance Holding S.à r.l.
International Data Processing Luxembourg S.A.
International Mode Investment S.A.
International Mode Investment S.A.
Kanelle S.à r.l.
Kanelle S.à r.l.
L'électricien Haag S. à r. l.
LUX-DL-Baumanagement S. à r. l.
Macarena International S.à r.l.
Maintenance Générale
Matanera S.A.
Matanera S.A.
Matanera S.A.
Matanera S.A.
Oxford Aviation Academy Luxembourg S.à r.l.
Palatum Investments S.A.
Paritex Holding S.A.
Partum S.A.
Pinchote S.A.
Powercom S.A.
Powercom S.A.
R3 Capital Partners (Luxembourg I), S.àr.l.
Regenbogenzwei S.A.
Semerca Investments S.A.
Silkhouse S.A.
Société Financière de Placements
Stellarium Sàrl
Stork Invest S.A.
Topsin Investments S.A.
Victor Finance S.A.
VisionAd S.à r.l.