logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 896

11 avril 2008

SOMMAIRE

A & A Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42991

Arado Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42975

Armstral Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42977

Ascania I Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

42994

Ascania I S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42994

Ascania I Trading S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

42994

Bartella S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42977

Black Lion Beverages Luxembourg  . . . . . .

42996

Bombardier Luxembourg Finance S.A. . . .

43002

Bombardier Luxembourg Investments

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43003

Clerical Medical Europe Financial Services

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43002

DB Finance (Luxembourg)  . . . . . . . . . . . . . .

42982

DB Finance (Luxembourg)  . . . . . . . . . . . . . .

42962

Delamain S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42993

Derma Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42976

Egmo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42983

Elektro Schäfer S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42992

enNefF INFORMATIQUE S.A.  . . . . . . . . . .

42962

enNefF INFORMATIQUE S.A.  . . . . . . . . . .

42962

enNefF INFORMATIQUE S.A.  . . . . . . . . . .

42962

E.P.M. European Portfolio Management

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42995

Fabor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42975

Fonds de Pension - Députés au Parlement

Européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43001

Fortimat Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

42975

Global Garden Products B S.à r.l. . . . . . . . .

42996

Gwenael SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42986

HeidelbergCement Holding S.à r.l.  . . . . . .

42995

JP Residential VI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43002

Lanchester S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43004

LGA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42986

LGA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42975

Lofin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43005

LSF6 Lux Investments II S. à r.l.  . . . . . . . . .

42963

LSF6 Lux Investments I S. à r.l. . . . . . . . . . .

42986

LSREF Lux Investments I S. à r.l.  . . . . . . . .

42977

Lurgi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42997

Lux Auto S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42976

Ma.Lo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43006

M-F LUX S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43008

Nordea Bank S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43005

Nordea Bank S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43005

Pollux Finance AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42968

PTH Lux S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43007

Sodipro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43008

Solaia Re S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43004

Solaia Re S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43004

Solaia Re S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43003

StarPlus Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43007

Synchan Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

42976

Tissart S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42976

Wasaby S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43007

XL (International) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

43001

42961

enNefF INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 39, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 74.430.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2008.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008038670/1218/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00633. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080040868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2008.

enNefF INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 39, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 74.430.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2008.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008038671/1218/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00636. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2008.

enNefF INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 39, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 74.430.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2008.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008038672/1218/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00639. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2008.

DB Finance (Luxembourg), Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 34.631.

Société anonyme constituée sous la dénomination de CL BELGIUM-FINANCE, suivant acte reçu par Maître Frank BA-

DEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 août 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations C No 410 du 6 novembre 1990. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Georges
d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 3 août 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C No 840 du 11 novembre 1999. La société a été dissoute suivant acte reçu par le même notaire en
date du 29 février 2008, acte non encore publié.

42962

Le bilan final de liquidation au 29 février 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2008.

DB FINANCE (LUXEMBOURG), Société anonyme dissoute
Signatures

Référence de publication: 2008039362/546/20.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02967. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

LSF6 Lux Investments II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 137.059.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-first of January.
Before Ms Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Lone Star Capital Investments S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of Luxembourg, with registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with
the Luxembourg trade and companies register under number B 91.796, represented by Mr Philippe Detournay, here
represented by Julie Chartrain-Hecklen, attorney-at-law, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 14
January 2008.

Said proxy, after having been signed «ne varietur» by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the

laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(the Companies Act), as well as by the present articles (hereafter the Company).

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the creation, acquisition, holding

and/or disposal, in any form and by any means, of participations, rights and interests in, and obligations of, any form of
Luxembourg and foreign companies and enterprises, and the administration, management, control and/or development
of those participations, rights, interests and obligations.

The Company may, by any means whatsoever, use its funds to establish, manage, develop and/or dispose of all of its

assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and/or dispose of any kinds of property, tangible
and intangible, movable and immovable, to participate in the creation, acquisition, development and/or control of any
form of Luxembourg and foreign companies and enterprises, to acquire by any means, establish, own, manage, develop
and/or dispose of any portfolio of securities and intellectual property rights of whatever origin and to realise them by
way of sale, transfer, assignment, exchange or otherwise.

The Company may give guarantees and/or grant security in favour of third parties to secure its obligations and/or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies and any other company, pledge, transfer, encumber or otherwise create
security over some or all of its assets and grant loans, advances and/or assistance, in any form whatsoever, to its subsid-
iaries, affiliated companies and third parties.

The Company may take any measure and carry out any operation, including but not limited to commercial, industrial,

financial, personal and real estate operations, which are directly or indirectly connected with, or may favour the devel-
opment of, its corporate purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name of «LSF6 Lux Investments II S. à r.l.».

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of
the board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

42963

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred euro),

represented by 100 (one hundred) shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) per
share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders

meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements

of article 189 of the Companies Act.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) are appointed, revoked and
replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one A manager and one B manager or by the sole signature of one A manager. The board of managers
may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts
within the limits of the powers of the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-

delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented,
and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of
managers. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram,
telefax or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their votes by telephone confirmed in writing. The
board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at
a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be
passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each
and every manager. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

42964

Art. 16. Each year, with reference to thirty-first December, the Company's accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.

Art. 18. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Companies Act, for all matters for which no specific provision is

made in these articles of association.

<i>Subscription and payment

All 100 (one hundred) shares have been subscribed and fully paid-up via contribution in cash by Lone Star Capital

Investments S. à r.l., prequalified, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is at the free disposal
of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2008.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,800 (one thousand eight hundred euro).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at three. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

<i>as A managers:

- Michael Duke Thomson, attorney, whose professional address is at 1434, Kirby Road, USA, VA 22101 Mc Lean, USA;
- Mr Philippe Detournay, company director, whose professional address at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxem-

bourg;

<i>as B manager:

- Philippe Jusseau, accountant, whose professional address is at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
2. The registered office is established at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove

mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Lone Star Capital Investments S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 91.796 représentée par M. Philippe Detournay, ici représentée par Julie Chartrain-Hecklen,
avocat, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 14 janvier 2008.

Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

42965

La partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi

qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et

notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) ainsi que les présents
statuts (ci-après, la Société).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la constitution,

l'acquisition, la détention et/ou la cession, sous quelque forme que ce soit et selon tous les moyens, de participations,
droits et intérêts et obligations, dans toute société et entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, droits, intérêts et obligations.

La Société peut utiliser ses fonds par tous les moyes pour constituer, administrer, développer et vendre ses porte-

feuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés,
corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement
et le contrôle de toute société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, pour acquérir par tout moyen, établir,
détenir, gérer, développer et cendre tout portefeuille de valeurs mobilières et de brevets de n'importe quelle origine,
pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever
de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses
avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société est dénommée «LSF6 Lux Investments II S. à r.l.»

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Il peut être transféré dans la commune de Luxembourg par une décision du conseil de gérance.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par

100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée

des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article

189 de la Loi de 1915.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas

fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil

de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B ou par la seule signature d'un gérant A. Le conseil de gérance peut
élire parmi les membres un gérant délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il
agisse dans le cadre de compétence du conseil de gérance.

42966

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion,
sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de
gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre

gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également émettre leur vote par téléphone, moyennant une confir-
mation écrite. Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir validement que si au moins la majorité des membres du
conseil est présente ou représentée au conseil de gérance.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts

qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas
de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par
des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 15. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de

la Loi de 1915.

<i>Souscription et libération

Toutes les 100 (cent) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par apport en espèces par Lone Star

Capital Investments S. à r.l., précitée, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cent euros) se trouve dès
maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.800 (mille huit cents euros).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit ont

pris les résolutions suivantes:

42967

1. Le nombre de gérants est fixé à trois. Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:
en tant que gérant «A»
- Michael Duke Thomson, avocat, dont l'adresse professionnelle est à 1434, Kirby Road, USA, VA 22101 Mc Lean;
- M. Philippe Detournay, directeur de sociétés, dont l'adresse professionnelle est au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530

Luxembourg;

en tant que gérant «B»
- M. Philippe Jusseau, comptable, dont l'adresse professionnelle est au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
2. Le siège social de la société est établi au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: J. Chartrain-Hecklen et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, LAC/2008/3708. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents Eur 1%

= 62,50.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008039365/5770/284.
(080042392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

Pollux Finance AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 137.069.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the fifth day of March.
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

The  public  limited  company  "Econex  Finance  AG",  recorded  in  the  Trade  Register  of  Zürich  under  number

020.3.006.900-7, with registered office at CH-8489 Wildberg, Stöcklerstrasse,

represented by Mr Paul MARX, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Said power of attorney signed by the notary and the attorney will be registered together with the present deed.
Such appearing party, represented by Mr Paul MARX, pre-named, has stated that it has formed a public limited company

and requested the notary to document its articles of association as follows:

TITLE 1. Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of "Pollux Finance AG".

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the city of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participa-

tions in whichever form in domestic and foreign companies with focus on renewable energy but not limited to. The

42968

company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which
it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of

securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-six thousand Euro (EUR 36.000.-) divided into three hundred and sixty

(360) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership

of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent
such share(s) towards the company.

The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

Title III. Management

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors who need not be

shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall de-
termine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years
and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive
terms of office.

In case the company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that

the company only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director
until the next annual general meeting at which it is noted that the company has (again) more than one shareholder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed

at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced

by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following
the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,

as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile

another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if a majority of the directors is present or represented at a

meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie

in votes, the vote of the chairman of the meeting will be decisive.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed

on several exemplars of the board resolution in writing.

Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders  fall  within  the  competence  of  the  board  of  directors.  The  board  of  directors  may  pay  interim  dividends,  in
compliance with the legal requirements.

42969

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or in case of sole

director by his sole signature, unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of
delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the extra-
ordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch

to one or more managers, and give special powers for detemined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. General meeting

Art. 13. The general meeting of shareholders of the company represents all the shareholders of the company. It has

the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company, unless the present
articles of association provide otherwise.

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the seventeenth of

March at 9.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Other general meetings of shareholders may be held at such places and dates as may be specified in the respective

notices of meeting.

Each share entitles one vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in

writing, by telecopy, email or any other similar means of communication, another person as his proxy-holder.

If all shareholders are present or represented at a meeting of the shareholders, and if they declare knowing the agenda,

the meeting may be held without convening notice or prior publication.

If the company only has one sole shareholder, the latter exercises the powers devolving on the general meeting.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on October 1 and shall terminate on September 30 of the

following year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will

be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders,
which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the whole capital.
All the three hundred and sixty (360) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each have been

paid up to the extent of 100% (one hundred percent) by payment in cash, so that the amount of thirty-six thousand Euro
(EUR 36,000.-) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Transitory provisions

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on September 30, 2008.
The first annual meeting will be held in 2009.

42970

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915

on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The above named person, representing the entire subscribed capital, has taken the following resolutions:
1. The number of directors is fixed at 3 and the number of auditors at 1.
2. The following are appointed directors:
- Mr Cornelius Martin BECHTEL, company director, born in Emmerich (Germany), on March 11, 1968, residing pro-

fessionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, chairman of the board of directors;

- Mr Jean FELL, company director, born in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg), on April 9, 1956, residing

professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Mrs Christine SCHWEITZER, company director, born in Thionville (France), on June 20, 1971, residing professionally

at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, with its registered office at L-1331

Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. The terms of office of the directors will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2013.
The terms of office of the statutory auditor will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2013.
5. The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte.

<i>Declaration

The undersigned notary who knows English and German, states herewith that on request of the attorney, the present

incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same attorney and in case of
divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the attorney, the latter signed together with the notary the present deed.

Deutsche Version der Satzung

Im Jahre zweitausendacht, am fünften März.
Vor dem unterzeichneten Jean SECKLER, Notar im Amtswohnsitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Aktiengesellschaft "Econex Finance AG", eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Nummer

020.3.006.900-7, mit Sitz in CH-8489 Wildberg, Stöcklerstrasse,

vertreten durch Herrn Paul MARX, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Diese Vollmacht wird nach Unterzeichnung durch den Notar und den Bevollmächtigten mit dieser Urkunde einre-

gistriert werden.

Die Komparentin, vertreten durch Herrn Paul MARX, vorbenannt, erklärte eine Aktiengesellschft gegründet zu haben

und ersuchte den Notar dessen Satzung wie folgt zu beurkunden:

TITEL I - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung "Pollux Finance AG" wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-

eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsange-
hörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden,
welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.

Art. 3 . Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

42971

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteiligungen

in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften im Bereich erneuerbare Energie aber nicht aus-
schliesslich. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede
Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Des weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte

erwerben, verwerten und veräußern.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl

in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbewegli-

cher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

Titel II - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt sechsundreissigtausend Euro (EUR 36.000,-) aufgeteilt in dreihundertsechzig

(360) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

An  Stelle  von  Einzelaktien  können  Zertifikate  über  eine  Mehrzahl  von  Aktien  ausgestellt  werden,  nach  Wahl  der

Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer je Aktie an. Wenn eine oder mehrere Aktie(n) gemeinschaftlich be-

sessen werden oder wenn das Eigentum dieser Aktie(n) bestritten wird, dann müssen diejenigen, die ein Recht auf diese
Aktie(n) fordern, eine Person bestimmen, welche diese Aktie(n) der Gesellschaft gegenüber vertritt. Andernfalls sind die
Rechte aus dieser/ diesen Aktie(n) ausgesetzt.

Titel III - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären anlässlich einer Generalver-
sammlung ernannt, welche ihre Zahl, ihre Vergütung sowie die Laufzeit ihres Mandates bestimmt. Diese Laufzeit darf
sechs Jahre nicht überschreiten und die Verwaltungsratsmitglieder bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Die
Verwaltungsratsmitglieder dürfen für mehrere aufeinander folgende Laufzeiten wiedergewählt werden.

Wenn die Gesellschaft von einem Aktionär gegründet worden ist oder wenn anlässlich einer Generalversammlung

festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur mehr einen Aktionär hat, dann darf der Verwaltungsrat bis zur nächsten jähr-
lichen Generalversammlung, anlässlich welcher festgestellt wird, dass die Gesellschaft wiederum mehr als einen Aktionär
hat, auf ein Mitglied begrenzt sein.

In diesem Fall übt das alleinige Verwaltungsratsmitglied die Befugnisse des Verwaltungsrates aus.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gewählt. Jedes

Mitglied darf zu jeder Zeit mit oder ohne Angabe von Gründen durch die Generalversammlung abberufen werden.

Wird ein Verwaltungsratsmandat durch den Tod eines Verwaltungsratsmitgliedes, seine Versetzung in den Ruhestand

oder sonstwie frei, dann darf dieses Mandat provisorisch bis zur nächsten Generalversammlung gemäss den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen besetzt werden.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Wenn dieser verhindert ist,

wird er durch das älteste Verwaltungsratsmitglied ersetzt. Der erste Vorsitzende wird von der ausserordentlichen Ge-
neralversammlung der Aktionäre, welche auf die Gründung der Gesellschaft folgt, ernannt werden.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder vom ältesten Verwaltungsratsmitglied, falls dieser verhindert ist, so

oft einberufen wie es das Interesse der Gesellschaft verlangt. Er muss einberufen werden, wenn zwei Verwaltungsrats-
mitglieder dies fordern.

Jedes Verwaltungsratsmitglied darf sich anlässlich jeder Sitzung des Verwaltungsrates durch ein anderes Mitglied, wel-

ches  es  schriftlich  durch  Telegramm,  Telex  oder  Fax  bestimmt  hat,  vertreten  lassen.  Jedes  Verwaltungsratsmitglied
darfeinen oder mehrere Kollegen vertreten.

Der Verwaltungsrat kann nur beraten und rechtsgültig handeln, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder in der Sitzung

anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der Stimmen der in dieser Sitzung anwesenden oder ver-

tretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Sitzungsvorsitzenden ausschlag-
gebend.

Verwaltungsratsbeschlüsse dürfen auch im Zirkularverfahren getroffen werden, wobei die Unterschriften der ver-

schiedenen Mitglieder auf mehrere Exemplaren des schriftlichen Beschlusses gesetzt werden dürfen.

42972

Jedes Verwaltungsratsmitglied darf an einer Verwaltungsratssitzung per Telefon-, Videokonferenzschaltung oder an-

dere  ähnliche  Kommunikationsmittel  teilnehmen,  welche  allen  Teilnehmern  erlauben,  sich  gegenseitig  zu  hören.  Die
Teilnahme an einer Sitzung aufgrund dieser Mittel ist mit einer persönlichen Teilnahme an dieser Sizung gleichzusetzen.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig ver-

pflichtet oder im Falle eines Verwalters durch dessen Einzelunterschrift, ausser, wenn spezielle Beschlüsse vorliegen über
die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung durch den Verwaltungsrat im
Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen. Das (die) erste(n)
delegierte(n) Verwaltungsratsmitglied(er) kann (können) von der ausserordentlichen Generalversamlung der Aktionäre,
welche auf die Gründung der Gesellschaft folgt, ernannt werden.

Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Di-

rektoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten
erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft

vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte
Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV - Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung

der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit,
welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V - Generalversammlung

Art. 13. Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die

ausgedehntesten Befugnisse, um Anweisungen zu geben und Handlungen im Zusammenhang mit Operationen der Ge-
sellschaft auszuführen und zu ratifizieren, insofern diese Sazung keine gegenteiligen Bestimmungen diesbezüglich enthält.

Die jährliche Generalversammlung wird in Luxemburg am siebzehnten März um 9.00 Uhr an dem im Einberufungs-

schreiben angegebenen Ort stattfinden.

Wenn  dieser  Tag  ein  gesetzlicher  Feiertag  ist,  dann  wird  die  Generalversammlung  am  darauffolgenden  Arbeitstag

stattfinden.

Andere Generalversammlungen dürfen an dem in dem jeweiligen Einberufungsschreiben angegebenen Ort und Datum

stattfinden.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär darf an Generalversammlungen teilnehmen indem er einer anderen

Person schriftlich, per Fax, E-mail oder jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel Vollmacht erteilt.

Wenn alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, die Tagesordnung zu

kennen, dann darf die Versammlung ohne Einberufungsschreiben oder vorherige Veröffentlichung erfolgen.

Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, dann übt dieser die Befugnisse der Generalversammlung aus.

Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Oktober bis zum 30. September des folgenden Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-

schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen
und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrie-
ben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII - Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder

mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche
ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

42973

Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der

Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt die Komparentin, das gesamte Kapital zu zeichnen.
Sämtliche dreihundertsechzig (360) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) wurden zu 100%

(hundert Prozent) in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von
sechsundreissigtausend Euro (EUR 36.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und wird am 30. September 2008 enden.
Die erste jährliche Generalversammlung wird im Jahre 2009 stattfinden.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Art. 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften

vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausendfünfhundert
Euro.

<i>Beschlüsse der alleinigen Gesellschafterin

Alsdann fasste die Komparentin, die das gesamte Aktienkapital vertritt, folgende Beschlüsse:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 und diejenige der Kommissare auf 1 festgelegt.
2. Folgende Personen werden in dem Verwaltungsrat berufen:
- Herr Cornelius Martin BECHTEL, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Emmerich (Deutschland) am 11. März

1968, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Vorsitzender des Verwal-
tungsrates;

- Herr Jean FELL, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg) am 9. April

1956, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Frau Christine SCHWEITZER, Verwalterin von Gesellschaften, geboren in Thionville (Frankreich) am 20. Juni 1971,

beruflich wohnhaft in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Zum Kommissar wird ernannt:
Die  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  COMCOLUX  S.à  r.l.,  H.G.R.  Luxemburg  B  58.545,  mit  Sitz  in  L-1331

Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder wird am Ende der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2013

enden.

Die Amtszeit des Kommissars wird am Ende der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2013 enden.
5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische und deutsche Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag des Bevoll-

mächtigten, dass diese Gründungsurkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag
des Bevollmächtigten und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes, ist die englische Fassung
maßgebend.

WORAUFHIN diese notarielle Urkunde in Luxemburg an dem zu Beginn erwähnten Tag erstellt wurde.
Nachdem die Urkunde dem Bevollmächtigten vorgelesen worden war, wurde sie von diesem und dem Notar unter-

zeichnet.

Gezeichnet: MARX; SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 mars 2008, Relation GRE/2008/1178. — Reçu cent quatre vingt euros 0,50%: 180

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Junglinster, den 18. März 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008039381/231/353.
(080042644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

42974

LGA, Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 110.836.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2008.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2008039358/8782/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2008, réf. LSO-CO05482. - Reçu 97,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080042276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

Fabor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3341 Huncherange, 8, route de Noertzange.

R.C.S. Luxembourg B 51.335.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19/03/08.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008039359/1321/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03452. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

Arado Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 100.828.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2008.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008039360/1321/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03447. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

Fortimat Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 99.533.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008039346/4185/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01416. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

42975

Tissart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 25.365.

Le bilan au 30.06.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>TISSART S.A., Société Anonyme
Guy HORNICK / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008039345/45/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04568. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080042761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

Synchan Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 122.983.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SYNCHAN S.A R.L.
Matteo Cirla / Claude Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008039349/45/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04147. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

Lux Auto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 123.965.

Le bilan de liquidation au 20 novembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008039347/4185/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01417. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

Derma Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.320.

Le bilan au 30.06.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>DERMA FINANCE S.A. société anonyme
Thierry FLEMMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008039350/45/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04562. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

42976

Bartella S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 122.865.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2007 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BARTELLA S.A.
Claude SCHMITZ / Thierry FLEMING
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008039351/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04564. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080042772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

Armstral Finance S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 31.871.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour ARMSTRAL FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008039352/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04565. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

LSREF Lux Investments I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 137.051.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-first of January.
Before Ms Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Lone Star Capital Investments S.àr.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of Luxembourg, with registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with
the Luxembourg trade and companies register under number B 91.796, represented by Mr Philippe Detournay, here
represented by Julie Chartrain-Hecklen, attorney-at-law, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 14
January 2008.

Said proxy, after having been signed «ne varietur» by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the

laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(the Companies Act), as well as by the present articles (hereafter the Company).

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the creation, acquisition, holding

and/or disposal, in any form and by any means, of participations, rights and interests in, and obligations of, any form of
Luxembourg and foreign companies and enterprises, and the administration, management, control and/or development
of those participations, rights, interests and obligations.

42977

The Company may, by any means whatsoever, use its funds to establish, manage, develop and/or dispose of all of its

assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and/or dispose of any kinds of property, tangible
and intangible, movable and immovable, to participate in the creation, acquisition, development and/or control of any
form of Luxembourg and foreign companies and enterprises, to acquire by any means, establish, own, manage, develop
and/or dispose of any portfolio of securities and intellectual property rights of whatever origin and to realise them by
way of sale, transfer, assignment, exchange or otherwise.

The Company may give guarantees and/or grant security in favour of third parties to secure its obligations and/or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies and any other company, pledge, transfer, encumber or otherwise create
security over some or all of its assets and grant loans, advances and/or assistance, in any form whatsoever, to its subsi-
diaries, affiliated companies and third parties.

The Company may take any measure and carry out any operation, including but not limited to commercial, industrial,

financial, personal and real estate operations, which are directly or indirectly connected with, or may favour the deve-
lopment of, its corporate purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name of «LSREF Lux Investments I S. à r.l.».

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of
the board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred euro),

represented by 100 (one hundred) shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) per
share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders

meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements

of article 189 of the Companies Act.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) are appointed, revoked and
replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one A manager and one B manager or by the sole signature of one A manager. The board of managers
may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts
within the limits of the powers of the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-

delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

42978

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented,
and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of
managers. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram,
telefax or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their votes by telephone confirmed in writing. The
board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at
a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be
passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each
and every manager. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, with reference to thirty-first December, the Company's accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.

Art. 18. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Companies Act, for all matters for which no specific provision is

made in these articles of association.

<i>Subscription and payment

All 100 (one hundred) shares have been subscribed and fully paid-up via contribution in cash by Lone Star Capital

Investments S. à r.l., prequalified, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is at the free disposal
of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2008.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,800 (one thousand eight hundred euro).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at three. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

<i>as A managers:

- Michael Duke Thomson, attorney, whose professional address is at 1434, Kirby Road, USA, VA 22101 Mc Lean, USA;
- Mr Philippe Detournay, company director, whose professional address at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxem-

bourg;

<i>as B manager:

- Philippe Jusseau, accountant, whose professional address is at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

42979

2. The registered office is established at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove

mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Lone Star Capital Investments S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 91.796 représentée par M. Philippe Detournay, ici représentée par Julie Chartrain-Hecklen,
avocat, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 14 janvier 2008.

Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi

qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et

notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) ainsi que les présents
statuts (ci-après, la Société).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la constitution,

l'acquisition, la détention et/ou la cession, sous quelque forme que ce soit et selon tous les moyens, de participations,
droits et intérêts et obligations, dans toute société et entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, droits, intérêts et obligations.

La Société peut utiliser ses fonds par tous les moyes pour constituer, administrer, développer et vendre ses porte-

feuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés,
corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement
et le contrôle de toute société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, pour acquérir par tout moyen, établir,
détenir, gérer, développer et cendre tout portefeuille de valeurs mobilières et de brevets de n'importe quelle origine,
pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever
de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses
avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société est dénommée «LSREF Lux Investments I S. à r.l.»

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Il peut être transféré dans la commune de Luxembourg par une décision du conseil de gérance.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par

100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée

des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

42980

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article

189 de la Loi de 1915.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas

fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil

de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B ou par la seule signature d'un gérant A. Le conseil de gérance peut
élire parmi les membres un gérant délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il
agisse dans le cadre de compétence du conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion,
sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de
gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre

gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également émettre leur vote par téléphone, moyennant une confir-
mation écrite. Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir validement que si au moins la majorité des membres du
conseil est présente ou représentée au conseil de gérance.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts

qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas
de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par
des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 15. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution

42981

d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de

la Loi de 1915.

<i>Souscription et libération

Toutes les 100 (cent) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par apport en espèces par Lone Star

Capital Investments S.àr.l., précitée, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cent euros) se trouve dès
maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.800 (mille huit cents euros).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit ont

pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à trois. Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:

<i>en tant que gérant «A»:

- Michael Duke Thomson, avocat, dont l'adresse professionnelle est à 1434, Kirby Road, USA, VA 22101 Mc Lean;
- M. Philippe Detournay, directeur de sociétés, dont l'adresse professionnelle est au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530

Luxembourg;

<i>en tant que gérant «B»:

- M. Philippe Jusseau, comptable, dont l'adresse professionnelle est au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
2. Le siège social de la société est établi au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: J. Chartrain-Hecklen et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, LAC/2008/3704. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents Eur 1%

= 62,50.

<i>Le Receveur (signé) Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008039368/5770/284.
(080042317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

DB Finance (Luxembourg), Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 34.631.

Société anonyme constituée sous la dénomination de CL BELGIUM-FINANCE, suivant acte reçu par Maître Frank BA-

DEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 août 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations C No 410 du 6 novembre 1990. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Georges
d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 3 août 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C No 840 du 11 novembre 1999.

42982

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2008.

<i>DB FINANCE (LUXEMBOURG), Société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008039361/546/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02972. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

Egmo, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 90, route de Burange.

R.C.S. Luxembourg B 137.067.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend acht, den fünften März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Herr Egbert MONTAG, Industriemeister, geboren in Trier, (Bundesrepublik Deutschland), am 27. Mai 1966, wohnhaft

in D-54636 Idenheim, im Hohlweg 1,

welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche

er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den geltenden Gesetzen und ins-

besondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung
unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung "Egmo" an.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen

in  irgendwelcher  Form  an  andern  in-  und  ausländischen  Gesellschaften.  Sie  kann  auch  Anleihen  aufnehmen  und  den
Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder
Sicherheit gewähren.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüber hinaus kann die Gesell-
schaft  Patente  und  Lizenzen,  sowie  davon  abgeleitete  oder  dieselben  ergänzende  Rechte  erwerben,  verwerten  und
veräussern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl

in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbewegli-

cher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fordern oder ergänzen.

Art. 4.  Der  Sitz  der  Gesellschaft  ist  in  Düdelingen.  Er  kann  in  irgendeine  andere  Ortschaft  des  Großherzogtums

Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, welche

die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerte Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit dem
Ausland gefährden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der außergewöhnlichen
Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die
Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft übermittelt, welches
sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 20.150,-(zwanzigtausendeinhundertfünfzig Euro) festgesetzt, dargestellt

durch 403 (vierhundertunddrei) Anteile von je EUR 50.- (fünfzig Euro), welche alle von Herrn Egbert Montag, vorbenannt,
gezeichnet worden sind.

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne

von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen, die
Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. jeder Beschluss des allgemeinen Gesellschafters sowie jeder
Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Bestimmungen über die Gene-
ralversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.

42983

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden und

das Kapital verhältnismäßig herabgesetzt wird.

Art. 7.  Die  Anteile  sind  unteilbar  gegenüber  der  Gesellschaft,  die  fur  jeden  Anteil  nur  einen  einzigen  Eigentümer

anerkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden Rechte
in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso verhält es
sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem "nackten" Eigentümer oder zwischen dem durch
Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten Anteile werden jedoch
nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.

Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer

Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Ge-

neralversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches
den überlebenden Teilhabern gehört.

Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben, an den überlebenden Gatten

oder an Frau Karin ALBRECHT, geboren in Brenzlau, (Bundesrepublik Deutschland), am 15. Februar 1953, im Falle vom
Sterbefall von Herrn Egbert MONTAG, übertragen werden.

Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, haben die verbleibenden Teilhaber ein

Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber

über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden. Das Nicht-
ausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages nach sich.

Art. 9. Außer seiner Gesellschaftseinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilhaber,

der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein spezielles
Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu einem Satz
welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen werden als
allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.

Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als

zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der
Gesellschaft anerkannt.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die

Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen
den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Aktiva und Doku-

mente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungs-
handlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber

oder Nichtteilhaber sein können. Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die
Generalversammlung bestimmt. Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung durch die Generalversamm-
lung, welche mehrheitlich berät, anvertraut.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen

und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-

nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Art. 13. In der Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsge-

mäss im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines
Mandates verantwortlich.

Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des

Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit
der Teilhaber getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten.

Zwischendividende können unter folgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
- eine Zwischenbilanz ist auf halb- oder vierteljähriger Basis zu erstellen,
- die Zwischenbilanz muss genügende Gewinne, einschließlich vorgetragener Gewinne ausweisen,
- den Beschluss Zwischendividende auszuzahlen nimmt eine außerordentliche Generalversammlung der Teilhaber.

Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember.

42984

Art. 16. Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teilhabern

unterbreiten.

Art. 17. Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den 15 Tagen vor seiner Annahme

einsehen.

Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten, der Sozialabgaben,

der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des
Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind
nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder
einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus
welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Teilhaber.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die

Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.

Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im Ver-

hältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte, Zahl-

ungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die geltenden gesetzlichen

Bestimmungen.

Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern

selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Sämtliche 403 (vierhundertunddrei) Anteile wurden voll eingezahlt durch eine Sacheinlage von 403 (vierhundertund-

drei) Namensaktien der Gesellschaft "LURGI", mit Gesellschaftssitz in L-3429 Düdelingen, 90, route de Burange, mit
einem Kapital von EUR 50.450.-(fünfzigtausendvierhundertfünfzig Euro), aufgeteilt in 1.009 (eintausendund neun) Aktien
mit einem Nennwert von je EUR 50,- (fünfzig Euro), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde, und welche auf EUR 20.150
(zwanzigtausendeinhundermndfünfzig Euro) geschätzt wurden.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr ein tausend zwei hundert
Euro.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Der alleinige Gesellschafter. der das gesamte Kapital vertritt, hat sofort nach der Gründung der Gesellschaft folgende

Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Herr Egbert MONTAG, Industriemeister, geboren in Trier, (Bundesrepublik Deutschland), am 27. Mai 1966, wohnhaft

in D-54636 Idenheim, im Hohlweg 1, wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt.

Er hat die Befugnis die Gesellschaft durch seine einzelne Unterschrift zu verpflichten.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-3429 Düdelingen, 90, route de Burange.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: MONTAG; SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 mars 2008, Relation GRE/2008/1171. — Reçu douze euros 12€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Junglinster, den 18. März 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008039379/231/153.
(080042628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

42985

Gwenael SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 50.822.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GWENAEL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008039356/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04138. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080042762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

LGA, Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 110.836.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2008.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2008039357/8782/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2008, réf. LSO-CO05480. - Reçu 105,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

LSF6 Lux Investments I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 137.049.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-first of January.
Before Ms Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Lone Star Capital Investments S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of Luxembourg, with registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with
the Luxembourg trade and companies register under number B 91.796, represented by Mr Philippe Detournay, here
represented by Julie CHARTRAIN-HECKLEN, attorney-at-law, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg,
on 14 January 2008.

Said proxy, after having been signed «ne varietur» by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the

laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(the Companies Act), as well as by the present articles (hereafter the Company).

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the creation, acquisition, holding

and/or disposal, in any form and by any means, of participations, rights and interests in, and obligations of, any form of
Luxembourg and foreign companies and enterprises, and the administration, management, control and/or development
of those participations, rights, interests and obligations.

42986

The Company may, by any means whatsoever, use its funds to establish, manage, develop and/or dispose of all of its

assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and/or dispose of any kinds of property, tangible
and intangible, movable and immovable, to participate in the creation, acquisition, development and/or control of any
form of Luxembourg and foreign companies and enterprises, to acquire by any means, establish, own, manage, develop
and/or dispose of any portfolio of securities and intellectual property rights of whatever origin and to realise them by
way of sale, transfer, assignment, exchange or otherwise.

The Company may give guarantees and/or grant security in favour of third parties to secure its obligations and/or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies and any other company, pledge, transfer, encumber or otherwise create
security over some or all of its assets and grant loans, advances and/or assistance, in any form whatsoever, to its subsi-
diaries, affiliated companies and third parties.

The Company may take any measure and carry out any operation, including but not limited to commercial, industrial,

financial, personal and real estate operations, which are directly or indirectly connected with, or may favour the deve-
lopment of, its corporate purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name of «LSF6 Lux Investments I S. à r.l.».

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of
the board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred euro),

represented by 100 (one hundred) shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five euro) per
share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders

meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements

of article 189 of the Companies Act.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) are appointed, revoked and
replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one A manager and one B manager or by the sole signature of one A manager. The board of managers
may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts
within the limits of the powers of the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-

delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

42987

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented,
and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of
managers. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram,
telefax or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their votes by telephone confirmed in writing. The
board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at
a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be
passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each
and every manager. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, with reference to thirty-first December, the Company's accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.

Art. 18. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Companies Act, for all matters for which no specific provision is

made in these articles of association.

<i>Subscription and payment

All 100 (one hundred) shares have been subscribed and fully paid-up via contribution in cash by Lone Star Capital

Investments S.àr.l., prequalified, so that the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) is at the free disposal
of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2008.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,800.- (one thousand eight hundred euro).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at three. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

<i>as A managers:

- Michael Duke Thomson, attorney, whose professional address is at 1434, Kirby Road, USA, VA 22101 Mc Lean, USA;
- Mr Philippe Detournay, company director, whose professional address at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxem-

bourg;

<i>as B manager:

- Philippe Jusseau, accountant, whose professional address is at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

42988

2. The registered office is established at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove

mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Lone Star Capital Investments S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 91.796 représentée par M. Philippe Detournay, ici représentée par Julie CHARTRAIN-
HECKLEN, avocat, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 14 janvier 2008.

Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi

qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et

notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) ainsi que les présents
statuts (ci-après, la Société).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la constitution,

l'acquisition, la détention et/ou la cession, sous quelque forme que ce soit et selon tous les moyens, de participations,
droits et intérêts et obligations, dans toute société et entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, droits, intérêts et obligations.

La Société peut utiliser ses fonds par tous les moyes pour constituer, administrer, développer et vendre ses porte-

feuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés,
corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement
et le contrôle de toute société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, pour acquérir par tout moyen, établir,
détenir, gérer, développer et cendre tout portefeuille de valeurs mobilières et de brevets de n'importe quelle origine,
pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever
de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses
avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société est dénommée «LSF6 Lux Investments I S. à r.l.»

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Il peut être transféré dans la commune de Luxembourg par une décision du conseil de gérance.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par

100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée

des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

42989

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article

189 de la Loi de 1915.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas

fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil

de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B ou par la seule signature d'un gérant A. Le conseil de gérance peut
élire parmi les membres un gérant délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il
agisse dans le cadre de compétence du conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion,
sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de
gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre

gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également émettre leur vote par téléphone, moyennant une confir-
mation écrite. Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir validement que si au moins la majorité des membres du
conseil est présente ou représentée au conseil de gérance.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts

qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas
de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par
des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 15. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution

42990

d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de

la Loi de 1915.

<i>Souscription et libération

Toutes les 100 (cent) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par apport en espèces par Lone Star

Capital Investments S. à r.l., précitée, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cent euros) se trouve dès
maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.800 (mille huit cents euros).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit ont

pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à trois. Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:

<i>en tant que gérant «A»:

- Michael Duke Thomson, avocat, dont l'adresse professionnelle est à 1434, Kirby Road, USA, VA 22101 Mc Lean;
- M. Philippe Detournay, directeur de sociétés, dont l'adresse professionnelle est au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530

Luxembourg;

<i>en tant que gérant «B»:

- M. Philippe Jusseau, comptable, dont l'adresse professionnelle est au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
2. Le siège social de la société est établi au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a requis de docu-

menter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais et
le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: J. Chartrain-Hecklen et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, LAC/2008/3707. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents Eur 1%

= 62,50.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008039366/5770/284.
(080042305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

A &amp; A Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 106.037.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>A&amp;A COMPANY S.A.
EFFIGI SARL / N. PICCIONE

42991

<i>Administrateur / Administrateur
J.-R. BARTOLINI / -
<i>Représentant permanent / -

Référence de publication: 2008039342/795/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04838. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

Elektro Schäfer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 13, rue de Macher.

R.C.S. Luxembourg B 137.071.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am sechsten März.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche MOUTRIER, mit dem Amtssitz zu Esch/Alzette,

Sind erschienen:

1.- Die deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Elektro Schäfer GmbH", mit Sitz in D-66693 Mettlach-Be-

thingen, Friedhofstrasse 4A, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Saarbrücken unter der Nummer HRB 3763
(Merzig),

hier vertreten durch Herrn Hans-Jürgen SCHÄFER, Elektroinstallateurmeister, wohnhaft in D-66693 Mettlach-Be-

thingen, Friedhofstrasse 4A,

handelnd in seiner Funktion als alleiniger Geschäftsführer, welcher die Gesellschaft rechtsgültig durch seine alleinige

Unterschrift vertreten kann.

2.- Frau Katja TEMMES geborene SCHÄFER, Elektroinstallateur, geboren am 10. August 1982 zu Saarburg (D), wohn-

haft in D-66663 Merzig-Schwemlingen, Elsterweg 1.

Welche Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, die instrumentierende Notarin ersuchten, die Satzung einer

von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die obengenannten Komparenten errichten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "Elektro Schäfer S.à r.l.".

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.
Durch einfachen Beschluss können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum

Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Elektroinstallationsbetriebes sowie der Gross- und Einzel-

handel mit Elekromaterial und -geräten.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer  Natur  tätigen,  die  mittelbar  oder  unmittelbar  mit  dem  Hauptzweck  in  Zusammenhang  stehen  oder  zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500.-) und ist aufgeteilt in hundert

(100) Anteile von je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125.-).

Die Geschäftsanteile werden gezeichnet wie folgt:

1.- Die Gesellschaft "Elektro Schäfer GmbH", vorbenannt, siebzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.- Frau Katja TEMMES geborene SCHÄFER, vorbenannt, dreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
TOTAL: HUNDERT ANTEILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

All diese Anteile wurden voll und in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO

(EUR 12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies der unterzeichneten Notarin ausdrücklich
nachgewiesen wurde.

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Im Sterbefall können die Anteile nur mit der Zu-

stimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Art. 7. Tod oder Verlust der Geschäftsfähigkeit lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 8. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so ist dieser zur

alleinigen Vetretung und Geschäftsführung berechtigt.

42992

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Ge-

schäftsführer  in  Gemeinschaft  mit  einem  Prokuristen  vertreten.  Die  Gesellschafterver-  Sammlung  kann  einzelnen
Geschäftsführern auch Einzelvertretungsbe- fugnis einräumen.

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.

Art. 10. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Jeder der Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn-

und Verlustrechnung nehmen.

Art. 11. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibender Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent (5%) dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des

Gesellschafts- kapitals erreicht hat.

Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 12. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestim-

mungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften

erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in jeglicher Form, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden

abgeschätzt auf TAUSEND EURO (EUR 1.000.-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Im Anschluss an die Gründung haben sich die Gesellschafter zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-

sammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Zu Geschäftsführern für eine unbestimmte Dauer werden ernannt:
a) Herr Patrick TEMMES, Informationselektroniker, geboren am 24. Oktober 1976 zu Merzig (D), wohnhaft in D-66663

Merzig-Schwemlingen, Elsterweg 1.

b) Herr Hans-Jürgen SCHÄFER, Elektroinstallateurmeister, geboren am 12. Mai 1956 zu Bethingen (D), wohnhaft in

D-66693 Mettlach-Bethingen, Friedhofstrasse 4A

2.- Die Gesellschaft ist in allen Fällen rechtsgültig vertreten durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers.
3.- Die Anschrift des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft lautet: L-5550 Remich, 13, rue de Macher.

Worüber Urkunde aufgenommen in Esch/Alzette, in der Amtsstube der instrumentierenden Notarin.
Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung der Urkunde haben die anwesenden Personen, der Notarin nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit der Notarin unterschrieben.

Signé: H.-J. Schäfer, K. Temmes, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 07 mars 2008. Relation: EAC/2008/3351.
Reçu soixante-deux euros cinquante cents 12.500.- à 0,5% = 62,50.-. Le receveur (signé): A. Santoni.
Pour copie conforme délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 17 mars 2008.

Blanche Moutrier.

<i>Notaire

Référence de publication: 2008039383/272/87.
(080042652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

Delamain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 129.696.

Suite à un transfert de part sociales intervenu en date du 13 juin 2007, G.O. IB - Luxembourg Three S.à r.l. a cédé

6.125 parts sociales de Classe A d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune à Pirelli &amp; C. Real Estate S.p.A. dont
le siège social se situe à Via Gaetano Negri n 

o

 10, Milan (Italie).

42993

Luxembourg, le 29 février 2008.

Marjoleine VAN OORT
<i>Manager

Référence de publication: 2008039428/275/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO04012. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Ascania I S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.588.

Il résulte de la décision de l'Associé Unique prise au siège social de la société en date du 29 janvier 2008, que la décision

suivante a été prise:

Election du Réviseur d'Entreprise, VAN GEET DERICK &amp; CO, Réviseur d'Entreprises S.à r.l., avec siège social au 6,

rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg avec effet au 15 mars 2007 pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>ASCANIA I S. à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manager
Signatures

Référence de publication: 2008039423/683/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07311. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Ascania I Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.604.

Il résulte de la décision de l'Associé Unique prise au siège social de la société en date du 21 janvier 2008, que la décision

suivante a été prise:

Election du Réviseur d'Entreprise, VAN GEET DERICK &amp; CO, Réviseur d'Entreprises S.à r.l., avec siège social au 6,

rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg avec effet au 15 mars 2007 pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>ASCANIA I HOLDINGS S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manager
Signatures

Référence de publication: 2008039424/683/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07305. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Ascania I Trading S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.328.

Il résulte de la décision de l'Associé Unique prise au siège social de la société en date du 29 janvier 2008, que la décision

suivante a été prise:

Election du Réviseur d'Entreprise, VAN GEET DERICK &amp; CO, Réviseur d'Entreprises S.à r.l., avec siège social au 6,

rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg avec effet au 15 mars 2007 pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

42994

<i>ASCANIA I TRADING S. à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manager A
Signatures

Référence de publication: 2008039425/683/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07324. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

HeidelbergCement Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.300.000.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.709.

Il résulte de la décision de l'associé unique en date du 29 octobre 2007 de la société HeidelbergCement Holding S.à

r.l. que l'associé a pris les décisions suivantes:

1. Démission du Gérant B suivant en date du 27 septembre 2007:
Madame Susanne Kortekaas, née le 11 mars 1967 à Roosendaal en Nispen, Pays-Bas, demeurant à 46A, avenue J. F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant B de la société.

2. Nomination du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à compter du 27 septembre 2007:
Monsieur Daan den Boer, ne le 3 août 1966 à Ede, Pays-Bas, demeurant à 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg en qualité de Gérant B de la société.

3. Nomination du nouveau Gérant A pour une durée indéterminée à compter du 24 octobre 2007:

Monsieur Phillip Kaplan, ne le 1 

er

 avril 1967 à Ixelles, Belgique, demeurant à rue Eugène Denis 23, B-1160 Bruxelles,

Belgique en qualité de Gérant A de la société.

4. Nomination du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à compter du 24 octobre 2007:
Monsieur Martinus Weijermans, ne le 26 août 1970 à 's-Gravenhage, Pays-Bas, demeurant à 46A, avenue J. F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg en qualité de Gérant B de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>HeidelbergCement Holding S.à r.l.
Frank Welman
<i>Gérant B

Référence de publication: 2008039427/683/28.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02887. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

E.P.M. European Portfolio Management S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 92.089.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13

mars 2008 à 11.30 heures a été nommé gérant unique Monsieur Johannes A.H. Wagemans, entrepreneur, né le 11 février
1957  à  Eindhoven,  Pays-Bas  demeurant  Dorpsstraat  48,  NL-8171  BR  Vaassen,  Pays-Bas  à  effet  du  13  mars  2008  en
remplaçant Monsieur Theodorus W. van Kampen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

E.P.M. EUROPEAN PORTFOLIO MANAGEMENT S.à.r.l.
J.A.H. Wagemans

Référence de publication: 2008039438/816/16.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04266. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

42995

Black Lion Beverages Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.494.100,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 113.100.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 7 février 2008

En date du 7 février 2008, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- de nommer Monsieur Luis BACH, né le 20 décembre 1955 à Barcelone, Espagne, résidant au: 15-21, Santissima

Trinitat del Mont, 08017 Barcelone, Espagne, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 7 février 2008 et ce
pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
- Monsieur John SUTHERLAND, gérant de Catégorie A1
- Monsieur David Scott BLITZER, gérant de Catégorie A1
- Monsieur Matthew TOOTH, gérant de Catégorie A1
- Monsieur Paul LAMBERTS, gérant de Catégorie A2
- Monsieur Lyndon LEA, gérant de Catégorie A2
- Monsieur Javier FERRAN, gérant de Catégorie A2
- Madame Margaret Lu Yan WONG, gérant
- Monsieur Marie-Bernard TRANNOY, gérant
- Monsieur Kevin Robert PRATT, gérant
- Monsieur Luis BACH, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2008.

BLACK LION BEVERAGES LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008039433/250/30.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03734. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Global Garden Products B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.805.050,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 96.424.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 8 octobre 2007 que la société Global Garden Products

Luxembourg S.A., ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.423 a transféré, avec effet au 17 décembre 2007, sept cent cinquante-
deux mille deux cent deux (752.202) parts sociales de la Société à la société Viridis S.p.A., une société de droit italien,
ayant son siège social à c/o Studio Maffeis Vanzetta, Via Montenapoleone n.21, 20121 Milan, Italie, inscrite au Registre de
Commerce de Milan sous le numéro 05505780964.

Il en résulte que Viridis S.p.A. est l'associé unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2008.

<i>Pour Global Garden Products B S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008039432/250/22.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03731. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

42996

Lurgi, Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 90, route de Burange.

R.C.S. Luxembourg B 137.066.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend acht, den fünften März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "AJO INDUSTRIE S.à r.L", mit Sitz L-3429 Düdelingen, 90, route de

Burange, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 115.876,

hier rechtmäßig vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer, Herrn Alain STRICKROTH, Ingenieur, wohnhaft in

L-3429 Düdelingen, 90, route de Burange.

2.-  Herr  Egbert  MONTAG,  Industriemeister,  geboren  in  Trier,  (Bundesrepublik  Deutschland),  am  27.  Mai  1966,

wohnhaft in D-54636 Idenheim, im Hohlweg 1.

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, ersuchten den Notar nachstehenden, durch alle Parteien vereinbarten

Gesellschaftsvertrag wie folgt zu beurkunden:

Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung "LURGI" ivird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Düdelingen.
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Düdelingen verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geei-

gnet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit
nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches
unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Herstellung, die Montage und der Vertrieb von duroplastischen und ther-

moplastischen Kunststoffen, der allgemeine Anlagenbau und das Anlagenengineering, sowie die Unternehmensberatung.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteili-

gungen in irgendwelcher Form an andern in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Vorschuss oder Sicherheit
gewähren.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräußern. Darüber hinaus kann die Gesell-
schaft  Patente  und  Lizenzen,  sowie  davon  abgeleitete  oder  dieselben  ergänzende  Rechte  erwerben,  verwerten  und
veräußern.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl

in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbewegli-

cher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

Titel II - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 41.200,- (einundvierzigtausendzweihundert Euro), aufgeteilt in 824 (ach-

thundertundvierundzwanzig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 50,- (fünfzig Euro).

An  Stelle  von  Einzelaktien  können  Zertifikate  über  eine  Mehrzahl  von  Aktien  ausgestellt  werden,  nach  Wahl  der

Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesell-

schaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit
Vorstand und Aufsichtsrat ("société anonyme à directoire et conseil de surveillance") und die Einmannaktiengesellschaft
"société anonyme unipersonneile"). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als "Alleingesellschafter" be-
zeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher

42997

Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.

Art. 6. Die Aktien sind frei übertragbar unter Aktionären.
1. Sollte ein Aktionär beabsichtigen, seine Aktien ganz oder teilweise an Nicht-Aktionäre abzutreten, so muss er sie

den anderen Aktionären im Verhältnis zu Ihrer jeweiligen Aktienbeteiligung anbieten.

Falls sich die Aktionäre nach Ablauf einer sechswöchigen Frist noch immer bezüglich des Abtretungspreises uneinig

sind, wird letzterer von einem Kollegium von drei Sachverständigen auf der Grundlage des Veräußerungswertes der
Aktien festgelegt.

Der abtretungswillige Aktionär ("der Zedent") und der/die erwerbswillige(n) Aktionär(e) wählen jeweils einen Sach-

verständigen. Der dritte Sachverständige wird von den zwei ersternannten Sachverständigen bestimmt. Die Aktionäre
werden von der Gesellschaft mittels Einschreiben über das Ergebnis des Sachverständigengutachtens benachrichtigt mit
der Aufforderung, der Gesellschaft innerhalb einer sechswöchigen Frist mitzuteilen, ob sie zum Erwerb bzw. zur Abtretung
der Aktien zum festgelegten Preis bereit sind. Die Nichtbeantwortung seitens der Aktionäre innerhalb dieser Frist gilt als
Ablehnung.

Sollten mehrere Aktionäre ihre Absicht bekunden, Aktien zu erwerben, so werden die zum Verkauf angebotenen

Aktien den erwerbswilligen Aktionären zu deren jeweiligen Aktienbeteiligung angeboten.

Falls keiner der Aktionäre bereit ist, die Gesamtheit der Aktien zu erwerben, kann der Zedent sie Nichtaktionären

("Drittinteressenten") anbieten, wobei als vereinbart gilt, dass den anderen Aktionären ein Vorkaufsrecht im Verhältnis
zu ihren jeweiligen Aktienbeteiligungen während einer weiteren vierwöchigen Frist, gerechnet ab Datum der Mitteilung
der mit Drittinteressenten getroffenen Abmachung, zu den Bedingungen dieser Abmachung vorbehalten sind. Der Zedent
ist verpflichtet, auf Antrag den Nachweis für das Angebot eines solchen Drittinteressanten zu erbringen.

Sollten die Aktionäre, oder einer oder mehrere von ihnen die betroffenen Aktien nicht innerhalb der vorgegebenen

Frist übernommen haben, entscheidet der Verwaltungsrat über die Bewilligung des vom Zedenten vorgeschlagenen Drit-
tinteressenten.

Der Verwaltungsrat muss dem Zedenten seinen Entschluss innerhalb eines Monats nach Ablauf der vorerwähnten

vierwöchigen Frist mitteilen. Das Schweigen des Verwaltungsrates gilt als Zustimmung.

Im Falle der Ablehnung ist der Verwaltungsrat verpflichtet, innerhalb von drei Monaten nach seinem Ablehnungsbes-

chluss  den  Erwerb  der  zum  Verkauf  angebotenen  Aktien  zu  einem  nicht  geringeren  als  dem  vom  vorerwähnten
Drittinteressenten angenommenen Preis (oder, falls zuvor ein Preis von Sachverständigen festgelegt worden war, zu einem
nicht geringeren als dem niedrigsten dieser beiden Preise) zu veranlassen, ansonsten die Abtretung an den Drittinteres-
senten als genehmigt gilt.

Im Falle der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bewilligung des Drittinteressenten gemäß den vorerwähnten Mo-

dalitäten, muss die Abtretung an diesen Drittinteressenten innerhalb von zwei Monaten und zu den anderen Aktionären
mitgeteilten Bedingungen erfolgen; ansonsten ist das vorerwähnte Verfahren vor jeder Abtretung zu wiederholen.

Falls der Zedent seinerseits den von den Sachverständigen festgesetzten Preis ablehnen sollte, gilt dies als verzichtete

er schlicht und einfach auf jede Abtretung, und er bleibt folglich Inhaber der betroffenen Aktien.

Die Sachverständigenkosten und -honorare gehen zur Hälfte zu Lasten des Zedenten und zur Hälfte zu Lasten des

Aktionärs/der Aktionäre der/die die Sachverständigenbestellung beantragt hatte(n).

Sollte der Zedent nach der Bestellung der Sachverständigen auf jede Abtretung verzichten, so gehen sämtliche Sach-

verständigenkosten und -honorare zu seinen Lasten.

2. Von den obenerwähnten Beschränkungen ausgeschlossen sind, vorbehaltlich der vorherigen Benachrichtigung des

Verwaltungsrates, sämtliche Aktienabtretungen an Aktionär- oder Nichtaktionärgesellschaften der gleichen Gruppe wie
der Zedent, so wie sämtliche Aktienübertragungen aufgrund der Fusion, der Übernahme oder der Aufspaltung einer der
Aktionärgesellschaften.

Zwecks Anwendung dieser Bestimmung gilt als zur Gruppe des Zedenten gehörig:
- jede Gesellschaft, die direkt oder indirekt die Mehrheit des Kapitals und der Stimmrechte des Zedenten besitzt;
- jede Gesellschaft, deren Zedent oder die Muttergesellschaft des Zedenten direkt oder indirekt die Mehrheit des

Kapitals und der Stimmrechte besitzt.

Ebenfalls von diesen Beschränkungen befreit sind sämtliche Aktienübertragungen im Falle von entgeltlichen, unent-

geltlichen oder auf dem Erbwege getätigte Abtretungen an Ehegatten oder Deszendenten, oder an in einem zwischen den
bestehenden Aktionären vereinbarten Gesellschafterabkommen bestimmte Personen.

3. Sämtliche im vorliegenden Artikel vorgesehenen Anzeigen, Mitteilungen und Zustellungen müssen per Einschreiben

mit Empfangsbestätigungen erfolgen.

Die im vorliegenden Artikel aufgezählten Bestimmungen finden Anwendung auf die Abtretungen von Bezugsrechten

im Falle einer Kapitalerhöhung oder eine Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Aktienbezugsrecht. Die im vorstehen-
den Paragraphen 1. vorgesehene Bewilligung findet ebenfalls Anwendung im Falle der Zeichnung durch einen Nichtaktionär
von jungen Aktien oder jungen Schuldverschreibungen mit Aktienbezugsrecht.

42998

Titel III - Verwaltung

Art. 7. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-

schafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt
werden und von ihr wieder abberufen werden können. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter
oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt,
kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter "admi-
nistrateur  unique")  bezeichnet  wird,  dies  bis  zur  nächsten  auf  die  Feststellung  der  Existenz  von  mehr  als  einem
Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.
Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft

erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die

Einzelunterschrift  des  delegierten  Verwaltungsratsmitgliedes  oder  durch  die  Einzelunterschrift  des  Alleinverwalters
rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im
Falle  der  Befugnisübertragung  oder  Vollmachterteilung  durch  den  Verwaltungsrat  im  Rahmen  des  Artikels  10  dieser
Satzung.

Art. 11. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen

und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen erteilen ; dieselben brau-
chen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 12. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft

vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte
Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV - Aufsicht

Art. 13. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung

der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit,
welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V - Generalversammlung

Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 17. (sieb-

zehnten) November des Jahres um 10.00 Uhr.

Ist dieser Tag ein Feiertag, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden

Befugnisse aus.

Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Juli bis zum 30. Juni des nächsten Jahres.

Art. 16. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abs-

chreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen
und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrie-
ben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII - Auflösung, Liquidation

Art. 17. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder

mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche
ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

42999

Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen

Art. 18. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der

Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 30. Juni 2009.
2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2009 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, das genannte Kapital wie folgt zu zeichnen und

einzuzahlen:

1. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "AJO INDUSTRIE S.à r.l.", vorgenannt, 421 (vierhunderteinundzwanzig)

Aktien durch eine Bareinlage von EUR 21.050,- (einundzwanzigtausendundfünfzig Euro), so wie dies dem Notar durch
das Sperrzertifikat einer Bank nachgewiesen wurde.

2. Herr Egbert MONTAG, vorgenannt, 403 (vierhundertunddrei) Aktien durch eine Sacheinlage der gesamtem Stam-

meinlage von DEM 101.000.- (EUR 51.640,48) der Gesellschaft "VER MO PLAST GmbH", Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit Sitz in D-54634 Bitburg, (Bundesrepublik Deutschland), eingetragen beim Amtsgericht Wittlich im Handel-
register  unter  der  Nummer  B  32142,  welche  auf  EUR  20.150  (zwanzigtausendeinhunderrandfiinfzig  Euro)  geschätzt
wurden.

<i>Bericht des Wirtschaftsprüfers

Da es sich um eine Sachanlage gemäß Artikel 26-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften handelt, wird dieses

Einbringen durch ein Gutachten des unabhängigen Wirtschaftsprüfers "INTERAUDIT", mit Sitz in Luxemburg, bescheinigt
dessen Schlussfolgerung wir folgt lautet:

"Ergebnis unserer Prüfung
Auf der Grundlage unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Wert der Sacheinlage mindestens dem

Nennwert der 403 auszugebenden Aktien im Gegenwert von EUR 20.150, entspricht.

Luxemburg, den 3. März 2008.
Dieses Gutachten, von den Komparenten und dem instrumentierendem Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleibt

gegenwärtiger Urkunde beigebogen und mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 1.650,- EUR zu deren
Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentli-

chen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen. Sie fassten, nachdem sie die
ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 und diejenige der Kommissare auf 1 festgelegt.
2. Folgende Personen werden in dem Verwaltungsrat berufen:
- Herr Alain STRICKROTH, Ingenieur, geboren in Düdelingen, am 17. Mai 1965, wohnhaft in L-3429 Düdelingen, 90,

route de Burange;

- Herr Egbert MONTAG, Industriemeister, geboren in Trier, (Bundesrepublik Deutschland), am 27. Mai 1966, wohn-

haft in D-54636 Idenheim, im Hohlweg 1;

- Frau Karin ALBRECHT, Facharbeiterin, geboren in Brenzlau, (Bundesrepublik Deutschland), am 15. Februar 1953,

wohnhaft in D-54636 Idenheim, im Hohlweg 1.

3. Frau Jeanne KOEHL, Hotelfachfrau, geboren in Sarreguemines, (Frankreich), am 9. Mai 1965 wohnhaft in L-3429

Düdelingen, 90, route de Burange, wird zum Kommissar ernannt.

4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-

sammlung von 2013.

5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3429 Düdelingen, 90, route de Burange.
6.- Der Verwaltungsrat ist befugt ein oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten seines Verwaltungsrates zu

ernennen.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

43000

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: STRICKROTH; MONTAG; SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 mars 2008, Relation GRE/2008/1170. — Reçu deux cent six euros 206 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Hinterlegung beim RCS Luxemburg.

Junglinster, den 18. März 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008039378/231/228.
(080042620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

Fonds de Pension - Députés au Parlement Européen, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 46.910.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 29 novembre 2007

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Monsieur Dariusz GRABOWSKI, député au Parlement Européen, demeurant à ul. Wiejska 16/23, 00-490 Warszawa

(Pologne), a été coopté en tant qu'administrateur de la SICAV, en remplacement de Monsieur Ryszard CZARNECKI,
avec effet immédiat.

Son élection définitive interviendra lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
- Monsieur Richard BALFE a été nommé président du conseil d'administration de la SICAV; et
- Madame Astrid LULLING a été nommée vice-président du conseil d'administration de la SICAV.

Luxembourg, le 4 mars 2008.

Pour extrait conforme
Pr Alex SCHMITT emp. &amp; Guy ARENDT
<i>Avocat à la Cour
Alex SCHMITT
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008039429/275/23.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO04013. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

XL (International) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 82.523.

Il résulte de la décision de l'associé unique en date du 29 février 2008 de la société XL (International) S.à r.l. que

l'associé a pris les décisions suivantes:

1. Nomination du nouveau Gérant A pour une durée indéterminée à compter du 29 février 2008:
Monsieur Mervyn Peter Skeet, né le 11 février 1964 à Croydon, Grande-Bretagne demeurant à Oakhurst Barn, Brook

Street, Woodchurch, TN26 3SX, Grande-Bretagne en qualité de Gérant A de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

XL (International) S.à r.l.
Pamela Valasuo
<i>Gérant B

Référence de publication: 2008039422/683/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02919. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080042080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

43001

Clerical Medical Europe Financial Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 81.063.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la Société tenue le 30 mars 2006

Les associés de la Société ont élu John Stephen Edwards, avec adresse professionnelle à Heidelberger Lebensversi-

cherung AG, Forum 7, 69126 Heidelberg, Germany, en tant que gérant de la Société pour une période indéterminée.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance de la Société tenue le 24 mai 2007

Les gérants de la Société ont pris acte de la démission des personnes suivantes en tant que gérants de la Société:
1. Michael Stewart Robinson, en date du 30 juin 2006,
2. Lee Robinson, en date du 14 août 2006.
A la date du 24 mai 2007, John Stephen Edwards est gérant unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Clerical Medical Europe Financial Services S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008039430/267/20.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08428. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Bombardier Luxembourg Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 73.989.

<i>Extraits des résolutions prises en date du 27 février 2008

En date du 27 février 2008, l'Assemblée Générale de la Société a pris la résolution suivante:
de prolonger les mandats de:
- Madame Tine Kehler-Hvid, administrateur de catégorie A
- Monsieur Olivier Guitton, administrateur de catégorie A
- Madame Ailbhe Jennings, administrateur de catégorie B
avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011
de prolonger le mandat du commissaire, ERNST &amp; YOUNG avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2009

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2008.

BOMBARDIER LUXEMBOURG FINANCE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008039434/250/22.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03738. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

JP Residential VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 110.830.

RECTIFICATIF

<i>Dépôt rectificatif du 26 février 2008 sous le numéro L080030686.04

Suite à une erreur matérielle lors du dépôt effectué le 26 février 2008, il y a lieu de procéder à la correction suivante:

les comptes déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg portent sur l'exercice clos au 31 décembre
2006 en lieu et place des comptes portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

43002

RESIDENTIAL VI S.À R.L.
Signatures

Référence de publication: 2008039431/250/17.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03730. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Bombardier Luxembourg Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 76.981.

<i>Extraits des résolutions prises en date du 27 février 2008

En date du 27 février 2008, l'Assemblée Générale de a Société a pris résolution suivante:
de prolonger les mandats de:
- Madame Tine Kehler-Hvid, administrateur de catégorie A
- Monsieur Olivier Guitton, administrateur de catégorie A
- Madame Ailbhe Jennings, administrateur de catégorie B
avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011
de prolonger le mandat du commissaire, ERNST &amp; YOUNG avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2009

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2008.

BOMBARDIER LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.
Signature

Référence de publication: 2008039435/250/22.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03741. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Solaia Re S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 134.805.

Suite à un transfert de parts sociales en date du 20 décembre 2007 par lequel Pirelli &amp; C. Real Estate S.p.A. a cédé 325

parts sociales de la Société à G.O. II - Luxembourg One S.à r.l. et à l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre
2007 suivant laquelle Pirelli &amp; C. Real Estate S.p.A. et G.O. II - Luxembourg One S.à r.l. ont souscrit respectivement à 7
et 13 parts sociales de la Société, le capital social de la Société se repartit dorénavant comme suit:

Associés

Nombre

de parts

sociales

Pirelli C. Real Estate S.p.A.: 10, Via Gaetano Negri, I-20123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182

G.o. II- Luxembourg One S.à r.l.: 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

338

Luxembourg, le 3 mars 2008.

p. Alex SCHMITT emp.
Signature

Référence de publication: 2008039443/275/22.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02751. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

43003

Solaia Re S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 134.805.

Suite à un transfert de parts sociales intervenu en date du 20 décembre 2007, Pirelli &amp; C. Real Estate S.p.A., avec siège

social au 10, Via Gaetano Negri, I-20123 Milan, a cédé 325 parts sociales de SOLAIA RE S.à r.l. d'une valeur nominale de
vingt-cinq Euros (25.- EUR) chacune à G.O. II - Luxembourg One S.à r.l., avec siège social au 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg.

Luxembourg, le 14.01.2008.

Geraldine Schmit
<i>Gérante

Référence de publication: 2008039442/275/17.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, réf. LSO-CM10798. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080041663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Solaia Re S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 134.805.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 20 décembre 2007

Il résulte dudit procès-verbal que:

- M. Martin Görge, avec adresse professionnelle au 7, Fabrikstraße, D-24103 Kiel;

- Mme Marjoleine Van Oort, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;

- Mme Géraldine Schmitt, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L- 1116 Luxembourg; et

- M. Joseph Mayor, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L- 1116 Luxembourg;

ont été nommés avec effet au 20 décembre 2007 en tant que gérants de la Société, pour une période illimitée.

Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Pour extrait conforme
Alex SCHMITT
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008039444/275/21.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, réf. LSO-CM10799. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Lanchester S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 123.746.

Par décision du Conseil d'Administration du 28 janvier 2008, Monsieur Thomas MULLIEZ a démissionné de ses fonc-

tions d'administrateur de catégorie C et Monsieur Giovanni CRESPI, né le 11 mars 159 à Milan, demeurant à Viale Bianca
21, 20122 Milan, Italie a été nommé en son remplacement.

Le mandat du nouvel administrateur s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.

43004

Luxembourg, le 5 mars 2008.

<i>Pour LANCHESTER S.A., Société Anonyme
Experta Luxembourg, Société Anonyme
Catherine Royemans / Liette Heck

Référence de publication: 2008039441/1017/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03407. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Nordea Bank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 14.157.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 20 février 2008

Il résulte desdites résolutions que KPMG Audit S.à r.l., 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommée réviseur

indépendant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mars 2009.

Luxembourg, le 28 février 2008.

Pour extrait conforme
Nordea Bank S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008039436/36/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01202. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Nordea Bank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 14.157.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 février 2008

Il résulte dudit procès-verbal que
Monsieur Jhon Mortensen avec adresse 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg a été nommé comme «Managing

Director and Chief Executive Officer» avec effet du 20 février 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2008.

Nordea Bank S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008039437/36/17.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01208. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Lofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 58.995.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 13 décembre 2007 à 11:00 heures.

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La démission de ProServices Management S.à r.l., R.C.S. Luxembourg N° B 105.263 avec siège social au 47, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur et Administrateur-délégué de la Société est acceptée avec effet
à partir de la date de la réunion;

2. La démission de Luxroyal Management S.A., R.C.S. Luxembourg N° B 57.636 avec siège social au 47, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur et Administrateur-délégué de la Société est acceptée avec effet
à partir de la date de la réunion;

43005

3. La démission de Tradman Netherlands B.V., R.C. d'Amsterdam N° 33228837 avec siège social au 8, Laan van Kro-

nenburg, 1183 Amstelveen en tant que Administrateur et Administrateur-délégué de la Société est acceptée avec effet à
partir de la date de la réunion;

4. La nomination de Matthijs BOGERS, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 24 novembre 1966, avec l'adresse professionnelle

au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société est acceptée à la date de la réunion,
celui-ci terminant le mandat de son prédécesseur;

5. La nomination de Julien FRANCOIS, né à Messancy, Belgique, le 18 juin 1976, avec l'adresse professionnelle au 47,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société est acceptée à la date de la réunion, celui-
ci terminant le mandat de son prédécesseur;

6. La nomination de Stéphane HEPINEUZE, né à Dieppe, France, le 18 juillet 1977, avec l'adresse professionnelle au

47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société est acceptée à la date de la réunion,
celui-ci terminant le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Pour publication
REQUISITION
Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
Matthijs BOGERS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008039445/1084/37.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04693. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Ma.Lo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 48.326.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 13 décembre 2007 à 12.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. La démission de ProServices Management S.à r.l., R.C.S. Luxembourg N 

o

 B 105.263 avec siège social au 47, boulevard

Royal L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur et Administrateur-délégué de la Société est acceptée avec effet à
partir de la date de la réunion;

2. La démission de Luxroyal Management S.A., R.C.S. Luxembourg N 

o

 B 57.636 avec siège social au 47, boulevard

Royal L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur et Administrateur-délégué de la Société est acceptée avec effet à
partir de la date de la réunion;

3. La démission de Tradman Netherlands B.V., R.C. d'Amsterdam N 

o

 33228837 avec siège social au 8, Laan van

Kronenburg, 1183 Amstelveen en tant que Administrateur et Administrateur-délégué de la Société est acceptée avec
effet à partir de la date de la réunion;

4. La nomination de Matthijs BOGERS, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 24 novembre 1966, avec l'adresse professionnelle

au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société est acceptée à la date de la réunion,
celui-ci terminant le mandat de son prédécesseur;

5. La nomination de Julien FRANCOIS, né à Messancy, Belgique, le 18 juin 1976, avec l'adresse professionnelle au 47,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société est acceptée à la date de la réunion, celui-
ci terminant le mandat de son prédécesseur;

6. La nomination de Stéphane HEPINEUZE, né à Dieppe, France, le 18 juillet 1977, avec l'adresse professionnelle au

47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société est acceptée à la date de la réunion,
celui-ci terminant le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Pour publication - REQUISITION
Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Mandataire
Mr. Matthijs BOGERS

43006

<i>Administrateur

Référence de publication: 2008039446/1084/36.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04692. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Wasaby S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 130.255.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2008, la démission de Monsieur Gianantonio BIS-

SARO de ses fonctions d'administrateur de catégorie A a été acceptée et Monsieur Claudio GRECO, né le 29 juin 1951
à Turin, demeurant à Via Piero Capponi n 

o

 5, I-20145 Milan, Italie a été nommé en son remplacement.

Le mandat du nouvel administrateur s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.

Luxembourg, le 5 mars 2008.

<i>Pour WASABY S.A., Société Anonyme
Experta Luxembourg, Société Anonyme
Catherine Day-Royemans / Liette Heck
<i>Vice-President / -

Référence de publication: 2008039440/1017/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03412. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

StarPlus Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 72.359.

Herr Kai-Arne Jordan hat mit Datum vom 19. Dezember 2007 sein Verwaltungsratsmandat niedergelegt.
Der Verwaltungsrat der StarPlus Sicav fasst in Anbetracht des Vorgenannten den nachfolgenden Beschluss:
In Einklang mit dem luxemburgischen Gesetz und der Satzung der StarPlus Sicav beschließen die verbleibenden Mit-

glieder des Verwaltungsrates, den vakanten Posten bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
im Wege einer Kooptierung durch Herrn Holger Gachot neu zu besetzen.

Der Verwaltungsrat setzt sich nun wie folgt zusammen:
Herr Julien Zimmer, Vorsitzender
Herr Peter E. Huber, Mitglied
Herr Bernhard Singer, Mitglied
Herr Holger Gachot, Mitglied
Alle Mitglieder mit Geschäftsadresse 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 26. Februar 2008.

<i>Für StarPlus Sicav
DZ BANK International S.A.
V. Augsdörfer / T. Haselhorst

Référence de publication: 2008039448/1239/25.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO02013. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

PTH Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 57.878.

Rücktritt als Geschäftsführerin: Christel Zimmermann, geb. 30.09.1954

43007

Hiermit gebe ich Ihnen meinen Rücktritt als Administrative Geschäftsführerin der PTH LUX S.à.r.l. zum 10.03.2008

bekannt. Ich bitte Sie dieses im Handelsregister einzutragen.

Christel Zimmermann.

Référence de publication: 2008039447/8779/13.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05138. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Sodipro, Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 106.042.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 28 février 2008

<i>Conseil d'administration:

Les Membres du Conseil d'Administration constatent que Madame Candice KATZ, a remis sa démission de ses fonc-

tions  d'administrateur  de  la  société  SODIPRO,  prédésignée,  avec  effet  immédiat.  Le  nombre  des  Administrateurs
composant le Conseil d'Administration de la société anonyme SODIPRO SA, prédésignée, est dès lors de 1 administrateur
telle que la loi le permet eu égard au fait que la société n'a plu qu'un seul et unique actionnaire.

Luxembourg, le 28 février 2008.

Référence de publication: 2008039455/7430/16.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04513. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

M-F LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 46, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 85.643.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Procès-verbal  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  qui  s'est  déroulée  au  siège  social  de  Esch-sur-AIzette,  le  24

décembre 2007 à 10.00 heures.

Le conseil d'Administration a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Est nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2013 statuant sur

les comptes de l'exercice social 2012:

la société à responsabilité limitée Bureau MODUGNO s.à. r.l., avec siège social à L-3313 BERGEM, 130, Grand-Rue,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 35.889,

en remplacement de

la société M.C. CONSULTING. S.à r.l., avec siège social à L-1750 LUXEMBOURG, 81, avenue Victor Hugo, inscrite

au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 34.016.

Et Lecture faite, le Conseil d'Administration a signé.

Esch-sur-AIzette, le 24 décembre 2007.

Le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2008039454/1044/24.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03162. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080041826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

43008


Document Outline

A &amp; A Company S.A.

Arado Invest S.A.

Armstral Finance S.A.

Ascania I Holdings S.à r.l.

Ascania I S. à r. l.

Ascania I Trading S. à r.l.

Bartella S.A.

Black Lion Beverages Luxembourg

Bombardier Luxembourg Finance S.A.

Bombardier Luxembourg Investments S.A.

Clerical Medical Europe Financial Services S.à r.l.

DB Finance (Luxembourg)

DB Finance (Luxembourg)

Delamain S.à r.l.

Derma Finance S.A.

Egmo

Elektro Schäfer S.à r.l.

enNefF INFORMATIQUE S.A.

enNefF INFORMATIQUE S.A.

enNefF INFORMATIQUE S.A.

E.P.M. European Portfolio Management S.à.r.l.

Fabor S.A.

Fonds de Pension - Députés au Parlement Européen

Fortimat Properties S.A.

Global Garden Products B S.à r.l.

Gwenael SA

HeidelbergCement Holding S.à r.l.

JP Residential VI S.à r.l.

Lanchester S.A.

LGA

LGA

Lofin S.A.

LSF6 Lux Investments II S. à r.l.

LSF6 Lux Investments I S. à r.l.

LSREF Lux Investments I S. à r.l.

Lurgi

Lux Auto S.A.

Ma.Lo S.A.

M-F LUX S.A.

Nordea Bank S.A.

Nordea Bank S.A.

Pollux Finance AG

PTH Lux S.à.r.l.

Sodipro

Solaia Re S.à r.l.

Solaia Re S.à r.l.

Solaia Re S.à r.l.

StarPlus Sicav

Synchan Management S.à r.l.

Tissart S.A.

Wasaby S.A.

XL (International) S.à r.l.