This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 202
25 janvier 2008
SOMMAIRE
5 Square Churchill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9691
Alpha Management Services (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9682
Angel S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9689
Aquatrans Cargo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9696
Aquatrans RhineShipping S.A. . . . . . . . . . . .
9669
Architect-Consult/ Zigrand Jean-Paul S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9695
Batiferm S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9663
Bond Capital Partners (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9683
Cartom S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9663
Catalyst Alpha 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9663
Cellamare S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9682
Fenera Holding International S.A. . . . . . . .
9696
Intereuropean Finance S.A. . . . . . . . . . . . . .
9695
LBREP III River S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9655
Oakwood Global Finance S.C.A. . . . . . . . . .
9656
Parc Breidfeld sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9672
PATRIZIA Lux 30 N S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
9650
RP XXII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9676
RP XXI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9683
Schuch Immobilien S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
9670
Silverside Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9655
Sodwana Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9695
Thomak Protect S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9696
Universum F.O. Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . .
9676
UT Luxembourg Holding II S.à r.l. . . . . . . .
9691
UT Luxembourg Holding I S.à r.l. . . . . . . .
9690
World Power Holdings Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9676
9649
PATRIZIA Lux 30 N S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 134.723.
STATUTEN
Im Jahr zweitausend und sieben, am dreiundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Paul Frieders mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
PATRIZIA LUXEMBOURG S.àr.l., eine société à responsabilité limitée mit Sitz in 4, Grand-rue, L-1660 Luxemburg,
eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 122.906, hier rechtmäßig vertreten durch Andreas
Heinzmann, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in Luxemburg, im Wege einer privatschriftlich erteilten Vollmacht.
Die von dem Gesellschafter ausgestellte Vollmacht, welche von der anwesenden Partei und dem Notar ne varietur
paraphiert wurden, bleibt der Urkunde beigeheftet, um zusammen mit dieser registriert zu werden.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, hat den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung société à responsabilité limitée, welche die Partei gründet, wie folgt zu beurkunden:
Titel I.- Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgi-
schen Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, dem Gesetz vom
18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung mit nur einem Gesellschafter und ihren jeweiligen Abänderungen sowie dieser Satzung
unterliegt.
Art. 2. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRIZIA LUX 30 N S.àr.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere
politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen oder eingetreten sind, welche die normale Ge-
schäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten
beeinträchtigen, kann die Gesellschaft ihren Sitz nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorüber-
gehend bis zum Ende dieser Ereignisse in einen anderen Staat verlegen.
Eine solche Sitzverlegung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft welche Luxemburgisch bleibt. Die
Erklärung der Sitzverlegung soll Dritten durch jenes Organ der Gesellschaft bekannt gemacht werden, welches angesichts
der herrschenden Umstände am besten dazu in der Lage ist.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften,
der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder auf
andere Weise von Grundeigentum, Geschäftsanteilen, Aktien, Schuldverschreibungen, Pfandbriefen, Schuldscheinen oder
anderen Wertpapieren jeglicher Art, und der Besitz, die Verwaltung sowie das Management und Verwertung ihres Port-
folios.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller
Gesellschaften beteiligen und kann Tochtergesellschaften sowie anderen verbundenen Unternehmen durch Kredite, Ga-
rantien oder auf andere Art jegliche Unterstützung geben.
Die Gesellschaft kann sich auf jede mögliche Art und Weise verschulden.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art finanzieller, beweg-
licher und unbeweglicher, kommerzieller und industrieller Operationen tätigen, welche sie zur Verwirklichung und
Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.
Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines
Gesellschafters aufgelöst.
Titel II.- Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-) und ist eingeteilt in acht hundert (800)
Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Art. 8. Solange nur ein Anteilsinhaber besteht, kann dieser die Anteile frei übertragen.
Für den Fall mehrerer Gesellschafter sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Abtretung von
Anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter kann nur nach vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern, welche min-
destens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, erfolgen.
Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handels-
gesellschaften verwiesen.
9650
Art. 9. Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Sie-
gelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang
der Gesellschaft beeinträchtigen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung be-
ziehen.
Titel III.- Verwaltung
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, die Gesellschafter sein können. Der
(Die) Geschäftsführer werden von dem alleinigen Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung bestellt, die sie
auch jederzeit wieder abberufen können. Die Geschäftsführer sind ermächtigt, Teilbefugnisse einem oder mehreren Be-
vollmächtigten zu übertragen.
Art. 11. Die Anzahl, die Amtszeit und die jeweilige Entschädigung der Geschäftsführer werden von dem alleinigen
Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung festgelegt.
Der Posten eines Geschäftsführers gilt als zu besetzen, wenn:
- der Geschäftsführer von seinem Posten durch schriftliche Anzeige gegenüber der Gesellschaft zurücktritt, oder
- der Geschäftsführer seinen Posten kraft Gesetzes aufgeben muss oder wenn er aufgrund Gesetzes von der Eigenschaft
als Geschäftsführer ausgeschlossen wird,
- der Geschäftsführer insolvent wird, oder
- der Geschäftsführer durch den alleinigen Anteilsinhaber oder die Gesellschafterversammlung abgewählt wird.
Art. 12. Jeder Geschäftsführer ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung
und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesellschaftszweck durchführen zu können. Alle Befugnisse,
die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden, fallen
in den Aufgabenbereich des/der Geschäftsführer(s). Der/Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft in ihrem eigenen
Namen gegenüber Dritten in jeder Rechtsstreitigkeit entweder als Klägerin oder Beklagte.
Art. 13. Die Gesellschaft wird rechtlich in jeder Hinsicht durch die Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden. Dies
gilt auch für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer bestellt sind es sei denn, dass eine gesonderte Entscheidung getroffen
wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertretungsbefugnis nach Artikel 10 dieser Satzung durch Entscheidung des/
der Geschäftsführer(s) an andere Personen delegiert wurde.
Titel IV.- Gesellschafterversammlung
Art. 14. Solange die Gesellschaft nur einen Anteilsinhaber hat, übt dieser die Rechte der Gesellschafterversammlung
gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften aus.
Alle Entscheidungen, die Kompetenzen der/des Geschäftsführer(s) überschreiten, werden von dem alleinigen Anteils-
inhaber oder der Gesellschafterversammlung getroffen. Solche Beschlüsse müssen schriftlich gefasst werden und werden
in einem speziellen Register der Gesellschaft eingetragen.
Für den Fall mehrerer Gesellschafter, werden die Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung gefasst oder durch
schriftliche Beratung auf Initiative der/ des Geschäftsführer (s). Beschlüsse gelten nur als angenommen, wenn Gesell-
schafter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.
Die Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.
Titel V.- Geschäftsjahr, Gewinn, Reserven
Art. 15. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Dezembertag eines jeden
Jahres mit der Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches mit der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31.
Dezember 2007 endet.
Art. 16. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der
Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.
Die Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und
der Provisionen, stellen den Nettogewinn dar.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange ob-
ligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Abzug muss allerdings wieder
bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt und
aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde.
Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht dem alleinigen Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung
zur Verfügung.
Art. 17. Die Gesellschafterversammlung verabschiedet jedes Jahr einen Geschäftsplan, einschließlich eines Haushalt-
splans, mit Blick auf das darauffolgende Jahr oder die darauf folgenden Jahre.
9651
Titel VI.- Liquidation, Auflösung
Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,
welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit der in Artikel 142 des
Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen Abänderungsgesetzen bestimmten Mehrheit, ernannt werden. Der (Die) Li-
quidator(en) verfügt/verfügen über die weitestgehenden Befugnisse zur Veräußerung der Aktiva und Begleichung der
Verpflichtungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sollen alle Auszahlungen, die nach dem Gesetz vorgeschrieben sind, in der Art
und Weise erfolgen, wie sie von den Gesellschaftern vereinbart ist.
Titel VII.- Verschiedenes
Art. 19. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetz-
lichen Bestimmungen.
<i>Zeichnungi>
Nachdem die oben erwähnte Satzung festgelegt wurde, erklärt die erschienene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital
wie folgt zu zeichnen:
Anteile
PATRIZIA LUXEMBOURG S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
Gesamt: achthundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
Alle Anteile wurden zum vollen Betrag von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil durch Barzahlung von zwan-
zigtausend Euro (EUR 20.000,-) vollständig bezahlt, so dass nunmehr die Summe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-)
der Gesellschaft zur Verfügung steht, was auch dem Notar gegenüber nachgewiesen wurde.
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen und sonstigen Aufwendungen, welche die Gesellschaft aufgrund ihrer Grün-
dung tragen muß, belaufen sich auf ungefähr EUR 1.700,-.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Die oben benannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft als alleiniger Anteilshalter reprä-
sentiert, beschließt sofort im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft eine außerordentliche Gesellschafterversamm-
lung abzuhalten.
Nach der Feststellung, dass sich die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengefunden hat, beschließt
der alleinige Anteilsinhaber folgendes:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 4, Grand-rue, L-1660 Luxemburg;
2) Als Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Dauer folgende Personen ernannt:
- Dr. Bernhard Engelbrecht, Diplom-Kaufmann, geboren in München am 21. Dezember 1967 mit beruflicher Anschrift
in 4, Grand-rue, L-1660 Luxemburg;
- Dr. Georg Erdmann, Diplom-Kaufmann, geboren in Opladen am 12. Juli 1970 mit beruflicher Anschrift in Fuggerstraße
26, 86150 Augsburg.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache verstehen und sprechen kann, erklärt, dass die vorstehende
Urkunde auf Verlangen der Partei in deutscher Sprache verfasst und auch in die englische Sprache übersetzt worden ist.
Die Parteien legen fest, dass im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen, die deutsche Version Vorrang hat.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar durch Vorname, Name, Stand und Wohnort
bekannt ist, vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.
Es folgt die englische Übersetzung:
In the year two thousand seven, on November twenty-third.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
PATRIZIA LUXEMBOURG S.àr.l., a société à responsabilité limitée organised under the laws of Luxembourg with
registered office at 4, Grand-rue, L-1660 Luxembourg registered with the Luxembourg trade and companies register
under number 122.906, here represented by Mr. Andreas Heinzmann, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal.
Which powers of attorney, after being signed ne varietur by the attorney-in-fact and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing party, represented as here-above stated, has requested the notary to inscribe as follows the articles
of association of a «société à responsabilité limitée»:
9652
Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect
and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, the law of September
18, 1933 on limited liability companies, as amended and the law of December 28, 1992 on unipersonal limited liability
companies as well as by the present articles of association.
Art. 2. The name of the company is PATRIZIA LUX 30 N S.àr.l.
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg-City. If extraordinary political or economic
events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy
communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad
provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company that is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-
embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of real estate, stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the
possession, the administration, the development, the management and the exploitation of its portfolio.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated or group companies.
The company may borrow in any form.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The company is established for an unlimited period.
Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole shareholder or, as the case may be, of one of the shareholders
does not trigger the dissolution of the company.
Title II.- Capital - Shares
Art. 7. The capital of the company is fixed at twenty thousand euro (EUR 20.000,-) divided into eight hundred (800)
shares of twenty-five euro (EUR 25,-) each.
Art. 8. Shares can be freely transferred by the sole shareholder, as long as there is only one shareholder.
In case there is more than one shareholder, shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares
inter vivos to non-shareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing at least three-
quarters of the capital.
For all other matters pertaining to transfers of shares, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August
10, 1915 on commercial companies as amended.
Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general
meetings.
Title III.- Management
Art. 10. The company is managed by one or several managers, whether shareholders or not, who are appointed by
the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders, which may at any time remove
any or all of them; Each manager may give special powers for certain matters to one or more proxy-holders.
Art. 11. The number of managers, their term of office and their remuneration are fixed by the sole shareholder or, as
the case may be, by the general meeting of the shareholders.
The office of a manager shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited, or disqualified by law from being a manager,
or
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of
the shareholders.
Art. 12. Each manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment
of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. Each manager
9653
represents the company towards third parties and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant,
will be handled in the name of the corporation by à manager.
Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the signature of one manager even in case that several
managers have been appointed unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of
delegation of powers or proxies given by the manager(s) pursuant to article 10 of the present articles of association.
Title IV.- General meeting of shareholders
Art. 14. The sole shareholder shall exercise all the powers vested in the general meeting of the shareholders under
section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole shareholder or, as the case may be,
by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special
register.
In case there is more than one shareholder, decisions of shareholders shall be taken in a general meeting or by written
consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg.
Title V.- Financial year - Profits - Reserves
Art. 15. The accounting year of the company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the incorporation
of the company and shall terminate on the 31st of December
Art. 16. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company together
with a balance sheet and a profit and loss account shall be prepared.
The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions constitute
the net profit.
After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortization, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation,
but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve
falls below 10% of the capital of the corporation.
The balance is at the disposal of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 17. Each year, the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall adopt a
business plan in respect of the forthcoming year(s), which shall include a budget.
Title VI.- Liquidation - Dissolution
Art. 18. In case of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need
not be shareholders, designated by the sole shareholder or, as the case may be, by the meeting of shareholders in
accordance with the majority condition set out under Article 142 of the law of August 10,1915 on commercial companies,
as amended.
The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.
In the event of a liquidation distributions shall be made, subject to law, in such manner as agreed by the shareholders
as the case may be.
Title VII.- Varia
Art. 19. The parties refer to the existing legal provisions for all matters not provided for in the present articles of
incorporation.
<i>Subscriptioni>
The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital as
follows:
Shares
PATRIZIA LUXEMBOURG S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
Total: eight hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
The shares have been fully paid up to the amount of twenty-five euro (EUR 25.-) per share by a contribution in cash
of twenty thousand euro (EUR 20,000.-).
As a result the amount of twenty thousand euro (EUR 20,000.-) is as of now at the disposal of the company as has
been certified to the notary executing this deed.
9654
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 1,700.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
After the articles of incorporation have thus been drawn up, the above named shareholder has immediately proceeded
to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:
1. The registered office of the company is established at 4, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
2. The following are appointed as managers (gérant) of the company for an unlimited period:
- Dr. Bernhard Engelbrecht, Diplom-Kaufmann, born in Munich on 21st December 1967, residing professionally at 4,
Grand-rue, L-1660 Luxembourg;
- Dr. Georg Erdmann, Diplom-Kaufmann, born in Opladen on 12th July 1970, residing professionally at Fuggerstraße
26, 86150 Augsburg.
The undersigned notary, who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in German and followed by an English version. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the German and the English text, the German version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by surname, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Gezeichnet: A. Heinzmann, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007. LAC/2007/38621. — Reçu 200 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxemburg, den 31. Dezember 2007.
P. Frieders.
Référence de publication: 2008006928/212/295.
(080001980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
Silverside Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 99.545.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Référence de publication: 2008007300/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2007, réf. DSO-CL00089. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080001879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
LBREP III River S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 130.996.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
49507 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008007338/211/11.
(080001942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
9655
Oakwood Global Finance S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 122.047.
In the year two thousand seven, on the twelfth of October.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing at Luxembourg.
1) Michael Charles Culhane, born on October 19, 1968, in Leicester, United Kingdom, residing at 139 Oakwood Court,
London W14 8JS, United Kingdom,
2) OAKWOOD GLOBAL FINANCE MANAGEMENT S.A., a société anonyme, with registered office at 6, rue Philippe
II, L-2340 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 121.891,
3) Jason Miller, born on January 14, 1969, in Ohio, United States, residing at 20 Hale House, 34 De Vere Gardens,
London, W8 5AQ United Kingdom,
4) Roger Lansdowne, born on September 1, 1962, in Bristol, United Kingdom, residing at The Duck House, Scantleberry
Close, Downend, Bristol BS16 6DQ, United Kingdom,
5) Laurence Morey, born on June 7, 1974, in South Africa, residing at 17 Burlington Avenue Kew Gardens, London
TW9 4DF, United Kingdom,
6) Richard Klemmer, born on November 1, 1960, in Michigan, United States, residing at Burchetts Place, Burchetts
Green Road, Burchetts Green, Maidenhead Berkshire SL6 6QZ, United Kingdom,
7) MERRILL LYNCH CREDIT PRODUCTS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of
the State of Delaware, with address at c/o MERRILL LYNCH & CO. INC., 4 World Finance Center, New York, N10080,
United States,
8) THE OAKWOOD EMPLOYEE BENEFIT TRUST, a trust governed by Jersey law, with address at 31/33 New Street,
St Helier, Jersey JE48YW,
9) CIR INTERNATIONAL S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg, with registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under Section B, number 15.381,
10) PYXIS INVESTMENT STRATEGIES LLP, a limited liability partnership, organized and existing under the laws of
England and Wales, with registered office at 42 Portman Road, Reading, Berkshire RG30 1EU, United Kingdom,
11) GLENBROOK CAPITAL L.P., a limited partnership organized under the law of the state of Nevada, with registered
office at 430 Cambridge Avenue, Suite 100, Palo Alto, CA 94306, United States,
12) CIR INVESTMENT AFFILIATE S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, recorded with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 129.942,
all duly represented by Mr. Bob Calmes, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of twelve proxies given on October
5th, 10th and 11th, 2007,
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached
to this document in order to be registered therewith.
The appearing parties are the Sole Shareholders of OAKWOOD GLOBAL FINANCE S.C.A., a société en commandite
par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B,
number 122.047, incorporated pursuant to the deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg on the 16th of November 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations date 4th of January 2007, number 3. The articles of association have been amended for the last time on
12th of July 2007 pursuant to the deed of Maître Martine Schaeffer, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (hereafter the «Company»),
The appearing parties representing the whole corporate capital then deliberate upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the share capital of the Company by thirty-eight thousand six hundred eighty-seven euro and fifty cents
(EUR 38,687.50) from five hundred seven thousand twenty-three euro seventy-five cents (EUR 507,023.75) to five hun-
dred forty-five thousand seven hundred eleven euro and twenty-five cents (EUR 545,711.25) through the issue of thirty
thousand nine hundred fifty (30,950) new shares of a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, divided
into ten (10) classes of Class B ordinary shares;
2. Subsequent amendment of the paragraph 1 of Article 6 of the articles of incorporation of the Company.
After having reviewed the items of the agenda, the appearing parties, representing the whole corporate capital, require
the notary to act the following resolutions:
9656
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to increase the share capital of the Company by thirty-eight thousand six hundred eighty-
seven euro and fifty cents (EUR 38,687.50) from five hundred seven thousand twenty-three euro seventy-five cents (EUR
507,023.75) to five hundred forty-five thousand seven hundred eleven euro and twenty-five cents (EUR 545,711.25)
through the issue of thirty thousand nine hundred fifty (30,950) new shares of a par value of one euro and twenty-five
cents (EUR 1.25) each, divided consisting of:
a) 3,095 Class B1 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each;
b) 3,095 Class B2 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each;
c) 3,095 Class B3 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each;
d) 3,095 Class B4 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each;
e) 3,095 Class B5 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each;
f) 3,095 Class B6 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each;
g) 3,095 Class B7 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each;
h) 3,095 Class B8 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each;
i) 3,095 Class B9 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each; and,
j) 3,095 Class B10 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.
The shares newly issued have been entirely subscribed as follows:
1) MERRILL LYNCH CREDIT PRODUCTS LLC, aforementioned, has subscribed for a global amount of EUR 18,637.50
as follows:
a) 1,491 Class B1 Ordinary Shares
b) 1,491 Class B2 Ordinary Shares
c) 1,491 Class B3 Ordinary Shares
d) 1,491 Class B4 Ordinary Shares
e) 1,491 Class B5 Ordinary Shares
f) 1,491 Class B6 Ordinary Shares
g) 1,491 Class B7 Ordinary Shares
h) 1,491 Class B8 Ordinary Shares
i) 1,491 Class B9 Ordinary Shares
j) 1,491 Class B10 Ordinary Shares.
2) CIR INTERNATIONAL S.A., aforementioned, has subscribed for a global amount of EUR 13,850.- as follows:
a) 1,108 Class B1 Ordinary Shares
b) 1,108 Class B2 Ordinary Shares
c) 1,108 Class B3 Ordinary Shares
d) 1,108 Class B4 Ordinary Shares
e) 1,108 Class B5 Ordinary Shares
f) 1,108 Class B6 Ordinary Shares
g) 1,108 Class B7 Ordinary Shares
h) 1,108 Class B8 Ordinary Shares
i) 1,108 Class B9 Ordinary Shares
j) 1,108 Class B10 Ordinary Shares.
3) CIR INVESTMENT AFFILIATE S.A., aforementioned, has subscribed for a global amount of EUR 4,787.50 as follows:
a) 383 Class B1 Ordinary Shares
b) 383 Class B2 Ordinary Shares
c) 383 Class B3 Ordinary Shares
d) 383 Class B4 Ordinary Shares
e) 383 Class B5 Ordinary Shares
f) 383 Class B6 Ordinary Shares
g) 383 Class B7 Ordinary Shares
h) 383 Class B8 Ordinary Shares
i) 383 Class B9 Ordinary Shares
j) 383 Class B10 Ordinary Shares.
4) PYXIS INVESTMENT STRATEGIES LLP, aforementioned, has subscribed for a global amount of EUR 1,412.50 as
follows:
a) 113 Class B1 Ordinary Shares
9657
b) 113 Class B2 Ordinary Shares
c) 113 Class B3 Ordinary Shares
d) 113 Class B4 Ordinary Shares
e) 113 Class B5 Ordinary Shares
f) 113 Class B6 Ordinary Shares
g) 113 Class B7 Ordinary Shares
h) 113 Class B8 Ordinary Shares
i) 113 Class B9 Ordinary Shares
j) 113 Class B10 Ordinary Shares.
The thirty thousand nine hundred fifty (30,950) new shares have been fully paid up by a payment in cash so that the
total amount of thirty-eight thousand six hundred eighty-seven euro and fifty cents (EUR 38,687.50) is at the disposal of
the Company as it has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, the shareholders resolve to modify the paragraph 1 of Article 6 of the articles
of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:
« 6.1 Subscribed Capital. The Company has a subscribed capital of five hundred forty-five thousand seven hundred
eleven euro and twenty-five cents (EUR 545,711.25) represented by fully paid up Shares, consisting of:
a) 10,000 Class A1 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
A1 Ordinary Shares»):
b) 10,000 Class A2 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
A2 Ordinary Shares»);
c) 10,000 Class A3 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
A3 Ordinary Shares»);
d) 10,000 Class A4 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
A4 Ordinary Shares»);
e) 10,000 Class A5 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
A5 Ordinary Shares»);
f) 10,000 Class A6 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
A6 Ordinary Shares»);
g) 10,000 Class A7 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
A7 Ordinary Shares»);
h) 10,000 Class A8 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
A8 Ordinary Shares»);
i) 10,000 Class A9 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
A9 Ordinary Shares»);
j) 10,000 Class A10 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
A10 Ordinary Shares»);
k) 33,657 Class B1 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
B1 Ordinary Shares»);
I) 33,657 Class B2 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
B2 Ordinary Shares»);
m) 33,657 Class B3 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
B3 Ordinary Shares»);
n) 33,657 Class B4 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
B4 Ordinary Shares»);
o) 33,657 Class B5 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
B5 Ordinary Shares»);
p) 33,657 Class B6 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
B6 Ordinary Shares»);
q) 33,657 Class B7 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
B7 Ordinary Shares»);
r) 33,657 Class B8 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
B8 Ordinary Shares»);
s) 33,656 Class B9 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
B9 Ordinary Shares»);
9658
t) 33,656 Class B10 Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class
B10 Ordinary Shares»); and,
u) 1 Management Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) (the «Management
Share»).
All Shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders
of any separate class of Shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter. No Shares of any class
shall be entitled to any pre-emptive rights with respect to any Shares of the Company, except as may be required by law,
or as is otherwise provided in any agreement entered into between the Company and the Shareholders.
During a period ending five (5) years after the date of publication of the Shareholders' resolution to create the au-
thorised capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is
authorised to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within
the limits of the authorised capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as
the Manager may in its sole discretion determine, more specifically in respect of the subscription and payment of the new
shares to be subscribed and issued, such as to determine the time of issue and the amount of the new shares to be
subscribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium and, to
determine to what extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other
than cash. When realising the authorised capital in full or in part, the Manager is expressly authorised to limit or to waive
the preferential subscription right reserved to existing Shareholders provided that any share issuance (including the terms
of the same) by the Company must comply with any agreement entered into between the Securityholders and the
Company. The Manager may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly
authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or
all of such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required
form by the Managers, the present article is, as a consequence, to be adjusted.»
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of
the same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version
will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said person appearing signed together
with the notary, this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le douze octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Michael Charles Culhane, né le 19 octobre 1968, à Leicester, Royaume-Uni, demeurant à 139 Oakwood Court,
London W14 8JS, Royaume-Uni,
2) OAKWOOD GLOBAL FINANCE S.C.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 121.891,
3) Jason Miller, né le 14 janvier 1969, dans l'Ohio, Etats-Unis, demeurant au 20 Hale House, 34 De Vere Gardens,
London, W8 5AQ, Royaume-Uni,
4) Roger Lansdowne, né le 1
er
septembre 1962, à Bristol, Royaume-Uni, demeurant à The Duck House, Scantleberry
Close, Downend, Bristol BS16 6DQ, Royaume-Uni,
5) Laurence Morey, né le 7 juin 1974, en Afrique du Sud, demeurant au 17 Burlington Avenue Kew Gardens, London
TW9 4DF, Royaume-Uni,
6) Richard Klemmer, né le 1
er
novembre 1960, au Michigan, Etats-Unis, demeurant à Burchetts Place, Burchetts Green
Road, Burchetts Green, Maidenhead Berkshire SL6 6QZ, Royaume-Uni,
7) MERRILL LYNCH CREDIT PRODUCTS LLC, une limited liability company gouvernée par les lois de l'Etat du
Delaware, Etats-Unis, ayant comme adresse c/o MERRILL LYNCH & CO. INC., 4 World Finance Center, New York, NY
10080, Etats-Unis,
8) THE OAKWOOD EMPLOYEE BENEFIT TRUST, un trust gouverné par les lois de Jersey, ayant comme adresse
les 31/33 New Street, St Helier, Jersey JE48YW,
9) CIR INTERNATIONAL S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B, numéro 15.382,
10) PYXIS INVESTMENT STRATEGIES LLP, une limited liability partnership, régie par les lois d'Angleterre et du Pays-
de-Galles, ayant comme adresse 42 Portman Road, Reading, Berkshire RG30 1EU, Royaume-Uni,
9659
11) GLENBROOK CAPITAL L.P. une limited partnership régie par les lois de l'Etat du Nevada, ayant son siège social
au 430 Cambridge Avenue, Suite 100, Palo Alto, CA 94306, Etats-Unis,
12) CIR INVESTMENT AFFILIATE S.A. a société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, numéro 129.942,
tous dûment ici représentés par M. Bob Calmes, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu de douze procurations
faites le 5, 10, 11 octobre 2007.
Les procurations signées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les comparants sont les seuls actionnaires de OAKWOOD GLOBAL FINANCE S.C.A., une société en commandite
par actions, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Philippe II,
L-2340 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro
122.047, constituée suivant acte de André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg le 16 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 4 janvier 2007,
numéro 3. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 12 juillet 2007 suivant acte de Maître Martine Schaeffer,
pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).
Les comparants représentant la totalité du capital social délibèrent selon l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trente-huit mille six cent quatre-vingt-sept euros et
cinquante centimes (EUR 38.687,50) pour le porter de son montant actuel de cinq cent sept mille vingt-trois euros et
soixante-quinze centimes (EUR 507.023,75) à cinq cent quarante-cinq mille sept cent onze euros et vingt-cinq centimes
(EUR 545.711,25) par l'émission de trente mille neuf cent cinquante (30.950) actions nouvelles d'une valeur nominale
d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, réparties en dix (10) classes d'actions ordinaires de catégorie B;
2. Modification subséquente du paragraphe 1
er
de l'article 6 des statuts de la Société.
Après avoir passé en revue les points à l'ordre du jour, les comparants, représentant la totalité du capital social, ont
demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-huit mille six cent quatre-vingt-
sept euros et cinquante centimes (EUR 38.687,50) pour le porter de son montant actuel de cinq cent sept mille vingt-
trois euros et soixante-quinze centimes (EUR 507.023,75) à cinq cent quarante-cinq mille sept cent onze euros et vingt-
cinq centimes (EUR 545.711,25) par l'émission de trente mille neuf cent cinquante (30.950) actions nouvelles d'une valeur
nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, réparties comme suit:
a) 3.095 Actions ordinaires de catégorie B1 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
b) 3.095 Actions ordinaires de catégorie B2 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
c) 3.095 Actions ordinaires de catégorie B3 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
d) 3.095 Actions ordinaires de catégorie B4 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
e) 3.095 Actions ordinaires de catégorie B5 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
f) 3.095 Actions ordinaires de catégorie B6 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
g) 3.095 Actions ordinaires de catégorie B7 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
h) 3.095 Actions ordinaires de catégorie B8 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
i) 3.095 Actions ordinaires de catégorie B9 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
et
j) 3.095 Actions ordinaires de catégorie B10 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune.
Les actions nouvellement émises ont été entièrement souscrites comme suit:
1) MERRILL LYNCH CREDIT PRODUCTS LLC, susmentionnée, a souscrit pour un montant total de EUR 18.637,50
comme suit:
a) 1.491 actions ordinaires de catégorie B1,
b) 1.491 actions ordinaires de catégorie B2,
c) 1.491 actions ordinaires de catégorie B3,
d) 1.491 actions ordinaires de catégorie B4,
e) 1.491 actions ordinaires de catégorie B5,
f) 1.491 actions ordinaires de catégorie B6,
g) 1.491 actions ordinaires de catégorie B7,
h) 1.491 actions ordinaires de catégorie B8,
i) 1.491 actions ordinaires de catégorie B9,
9660
j) 1.491 actions ordinaires de catégorie B10.
2) CIR INTERNATIONAL S.A., susmentionnée, a souscrit pour un montant total de EUR 13.850,- comme suit:
a) 1.108 actions ordinaires de catégorie B1,
b) 1.108 actions ordinaires de catégorie B2,
c) 1.108 actions ordinaires de catégorie B3,
d) 1.108 actions ordinaires de catégorie B4,
e) 1.108 actions ordinaires de catégorie B5,
f) 1.108 actions ordinaires de catégorie B6,
g) 1.108 actions ordinaires de catégorie B7,
h) 1.108 actions ordinaires de catégorie B8,
i) 1.108 actions ordinaires de catégorie B9,
j) 1.108 actions ordinaires de catégorie B10.
3) CIR INVESTMENT AFFILIATE S.A., susmentionnée, a souscrit pour un montant total de EUR 4.787,50 comme suit:
k) 383 actions ordinaires de catégorie B1,
I) 383 actions ordinaires de catégorie B2,
m) 383 actions ordinaires de catégorie B3,
n) 383 actions ordinaires de catégorie B4,
o) 383 actions ordinaires de catégorie B5,
p) 383 actions ordinaires de catégorie B6,
q) 383 actions ordinaires de catégorie B7,
r) 383 actions ordinaires de catégorie B8,
s) 383 actions ordinaires de catégorie B9,
t) 383 actions ordinaires de catégorie B10.
4) PYXIS INVESTMENT STRATEGIES LLP, susmentionnée, a souscrit pour un montant total de EUR 1.412,50 comme
suit:
a) 113 actions ordinaires de catégorie B1,
b) 113 actions ordinaires de catégorie B2,
c) 113 actions ordinaires de catégorie B3,
d) 113 actions ordinaires de catégorie B4,
e) 113 actions ordinaires de catégorie B5,
f) 113 actions ordinaires de catégorie B6,
g) 113 actions ordinaires de catégorie B7,
h) 113 actions ordinaires de catégorie B8,
i) 113 actions ordinaires de catégorie B9,
j) 113 actions ordinaires de catégorie B10.
Les trente mille neuf cent cinquante (30.950) actions nouvellement émises ont été libérées par un paiement en nu-
méraire, de sorte que la somme de trente-huit mille six cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes (38.687,50)
se trouve à la disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, qui
aura désormais la teneur suivante:
« 6.1. Capital souscrit. La Société dispose d'un capital souscrit de cinq cent quarante-cinq mille sept cent onze euros
et vingt-cinq centimes (EUR 545.711,25) constitué d'Actions libérées, ainsi décomposées:
a) 10.000 Actions ordinaires de catégorie A1 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie A1»);
b) 10.000 Actions ordinaires de catégorie A2 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie A2»);
c) 10.000 Actions ordinaires de catégorie A3 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie A3»);
d) 10.000 Actions ordinaires de catégorie A4 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie A4»);
e) 10.000 Actions ordinaires de catégorie A5 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie A5»);
9661
f) 10.000 Actions ordinaires de catégorie A6 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune
(les «Actions ordinaires de catégorie A6»);
g) 10.000 Actions ordinaires de catégorie A7 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie A7»);
h) 10.000 Actions ordinaires de catégorie A8 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie A8»);
i) 10.000 Actions ordinaires de catégorie A9 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune
(les «Actions ordinaires de catégorie A9»);
j) 10.000 Actions ordinaires de catégorie A10 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie A10»);
k) 33.657 Actions ordinaires de catégorie B1 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie B1»);
I) 33.657 Actions ordinaires de catégorie B2 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune
(les «Actions ordinaires de catégorie B2»);
m) 33.657 Actions ordinaires de catégorie B3 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie B3»);
n) 33.657 Actions ordinaires de catégorie B4 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie B4»);
o) 33.657 Actions ordinaires de catégorie B5 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie B5»);
p) 33.657 Actions ordinaires de catégorie B6 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie B6»);
q) 33.657 Actions ordinaires de catégorie B7 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie B7»);
r) 33.657 Actions ordinaires de catégorie B8 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune
(les «Actions ordinaires de catégorie B8»);
s) 33.656 Actions ordinaires de catégorie B9 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune
(les «Actions ordinaires de catégorie B9»);
t) 33.656 Actions ordinaires de catégorie B10 d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (les «Actions ordinaires de catégorie B10»); et
u) 1 Action ordinaire de Management d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) (les «Actions
de Management»).
Toutes les Actions votent en tant que catégorie unique et, sauf exigence de la loi ou disposition des présents Statuts,
les détenteurs de catégories-d'Actions distinctes n'ont pas le droit de voter séparément en tant que catégorie sur une
question. Aucune Action d'une catégorie ne bénéficie d'un droit de préemption concernant toute Action de la Société,
sauf de la manière requise par la loi ou autrement stipulée dans tout accord conclu entre la Société et les Actionnaires.
Au cours d'une période prenant fin cinq (5) ans après la date de publication de la résolution des Actionnaires de créer
le capital autorisé dans la Gazette Officielle du Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le Gérant
est autorisé à augmenter une fois, ou à plusieurs reprises, le capital souscrit en faisant émettre de nouvelles actions par
la Société, dans les limites du capital autorisé. Ces nouvelles actions peuvent être souscrites selon les termes et conditions
que le Gérant peut de manière entièrement discrétionnaire déterminer, plus particulièrement concernant la souscription
et le paiement des nouvelles actions devant être souscrites et émises: le Gérant peut par exemple définir la date d'émission
et le montant des nouvelles actions souscrites, déterminer si les nouvelles actions doivent être souscrites avec ou sans
prime et préciser la mesure dans laquelle le paiement des actions nouvellement souscrites est acceptable en espèces ou
en d'autres actifs que les espèces. Lors de la réalisation totale ou partielle du capital autorisé, le Gérant est expressément
autorisé à limiter le droit de souscription préférentiel réservé aux Actionnaires existants, ou à y renoncer, étant entendu
que toute émission d'action (comprenant les termes de cette émission) par la Société doit respecter tout accord conclu
entre les détenteurs de Titres et la Société. Le Gérant peut déléguer à un administrateur ou dirigeant dûment autorisé
de la Société ou à toute autre Personne dûment autorisée, les tâches d'acceptation des souscriptions et de perception
des paiements au titre des nouvelles actions représentant une partie ou la totalité de ces augmentations de capital. Après
chaque augmentation du capital souscrit, réalisée dans la forme légalement requise par les Gérants, le présent article doit,
en conséquence, être corrigé.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande du mandataire des comparants, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants celui-ci a signé le présent acte avec Nous
notaire.
9662
Signé: B. Calmes, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, LAC/2007/31821. — Reçu 386,88 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2008.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2008006956/5770/396.
(080001890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
Cartom S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8058 Bertrange, 5, Beim Schlass.
R.C.S. Luxembourg B 113.174.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Référence de publication: 2008007294/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2007, réf. DSO-CL00073. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080001867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
Batiferm S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7737 Colmar-Berg, 19, Zone Industrielle Piret.
R.C.S. Luxembourg B 79.023.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Référence de publication: 2008007295/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2007, réf. DSO-CL00072. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080001870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
Catalyst Alpha 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 134.794.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the seventeenth of December.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CATALYST ALPHA 1 S.à r.l., company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered
office in L-1882, Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, whose registration with the Luxembourg Register is in process,
here represented by Mrs Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, issued in Lux-
embourg under private seal.
The said power of attorney, initialled ne varietur by the proxy holders of the appearing party and the notary, will
remain attached to this deed in order to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») the articles of incorporation of
which shall be as follows:
A. Purpose, Duration, Name, Registered office
Art. 1. There is hereby established by the subscribers of the shares («parts sociales») created hereafter and among all
those who may become shareholders («associés») in future, a private limited liability company («société à responsabilité
9663
limitée») (hereinafter the «Company») which shall be governed by the Luxembourg Company Act dated August 10th, (as
amended), as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale; exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding
of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, pro-
motion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem
useful in accomplishment of these purposes.
The Company may also acquire, hold or manage any real estate property or rights in Luxembourg or abroad, either
directly or indirectly and carry out any activities related thereto.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of CATALYST ALPHA 5 S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers. In the event that the
board of managers determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are im-
minent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg company.
B. Share capital, Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares of one euro (EUR 1.-) each. Each share is entitled to one vote at ordinary and
extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder
is subject to the approval of such transfer given by the other shareholders, at a majority of three-quarters of the share
capital. In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by a board of managers composed of at least 2 managers («gérants») who need not
be shareholders.
The managers shall be elected by the shareholders at the general meeting which shall determine their remuneration
and term of office. The managers are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any manager may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders. In the event of a vacancy
in the office of a manager following death, resignation, retirement or otherwise, the remaining managers may temporarily
appoint a manager.
In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose.
9664
The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any two managers.
Art. 12. The Company is managed by a board of managers which may choose from among its members a chairman
and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint
another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile, e-mail or any other similar means of communication, another manager as his proxy. Any manager may represent
one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and such meetings are deemed to
be held at the registered office of the Company.
The board of managers can deliberate or act validly only if the majority of managers are present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented
at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution. Such resolutions are deemed taken at the registered office of the Company.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by any two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any two managers or by any person duly appointed to
that effect by the board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
Art. 16. The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by
the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to
be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established
by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole shareholder, Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by shareholders owning more than half of the share capital. The shareholders may not change the nationality of
the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the
approval of a majority of shareholders representing three-quarters of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as
amended.
E. Financial year, Annual accounts, Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.
9665
Art. 21. Each year on December 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
F. Dissolution, Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation
of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the
Luxembourg Company Act dated August 10th, 1915, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by CATALYST ALPHA 1 S.à r.l.. All the shares
so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), is as of
now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31st,
2008.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euros.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The appearing party, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has immediately
passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be in L-1882 Luxembourg-City, 5, rue Guillaume Kroll (Grand Duchy of
Luxembourg);
2. The number of managers is set at two and the following persons are appointed managers of the Company for an
indefinite period:
Mr Gérard Becquer, Réviseur d'Entreprises, born in Briey on 29 April 1956, professionally residing in L-1882 Luxem-
bourg-City, 5, rue Guillaume Kroll (Grand Duchy of Luxembourg);
Mrs Charlotte Bastin, Chartered Accountant, born in Charleroi on 10 July 1978, professionally residing in L-1882
Luxembourg-City, 5, rue Guillaume Kroll (Grand Duchy of Luxembourg);
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le dix-sept décembre
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CATALYST ALPHA 1 S.à r.l., société créée et régie par les lois de l'Etat du Grand-duché du Luxembourg ayant son
siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, ici représentée par Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée sous seing privé.
La procuration paraphée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Laquelle partie comparante,
représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée
qu'il déclare constituée et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet, Durée, Dénomination, Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée), ainsi que par les présents statuts.
9666
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-duché de Lu-
xembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de
participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans
l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle
estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.
La Société pourra également acquérir, posséder ou gérer toute propriété immobilière ou droits immobiliers au Grand-
duché de Luxembourg ou à l'étranger, de manière directe ou indirecte et exercer toute activité y relative.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination CATALYST ALPHA 5 S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré
dans la même commune par décision du conseil de gérance.
Il peut être créé, par simple décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché de
Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
B. Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux gérants qui n'ont pas besoin d'être
associés.
Les gérants seront élus par les associés à l'assemblée générale qui fixera leur rémunération et le terme de leur mandat.
Les gérants sont élus par un vote à la majorité simple des parts sociales présentes ou représentées. Tout gérant peut
être révoqué avec ou sans motif par l'assemblée générale des associées. En cas de vacance d'un poste de gérant suite à
un décès, une démission, un départ à la retraite ou autrement, les gérants restants peuvent provisoirement nommer un
gérant.
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.
9667
Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi les gérants président, un vice-président.
Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance. Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux
gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la
Société à moins que l'avis de convocation n'en dispose autrement.
Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces
réunions.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil
de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, un autre gérant comme son
mandataire.
Chaque gérant peut représenter plusieurs un ou plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Ces réunions sont présumées tenues au siège social de la Société.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité sont présents ou représentés à la
réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à
cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions sont
présumées prises au siège de la Société.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès- verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
Art. 16. L'assemblée générale des associés peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des
sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l'associé unique, Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les présents statuts, les décisions collectives ne sont
valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale, Bilan, Répartition
Art. 20. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
9668
Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
F. Dissolution, Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
CATALYST ALPHA 1 S.à r.l. prénommé, a souscrit l'ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2008.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société,
ou qui est mis à charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, ont
pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi L-1882 Luxembourg-Ville, 5, rue Guillaume Kroll (Grand-Duché de Luxem-
bourg);
2. Le nombre des gérants est fixé à deux et sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
M. Gérard Becquer, Réviseur d'Entreprises, né le 29 avril 1956 à Briey, demeurant professionnellement à L-1882
Luxembourg-Ville, 5, rue Guillaume Kroll (Grand-Duché de Luxembourg); et
Mme Charlotte Bastin, Expert-Comptable, née le 10 juillet 1978 à Charleroi, demeurant professionnellement à L-1882
Luxembourg-Ville, 5, rue Guillaume Kroll (Grand-Duché de Luxembourg);
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007, Relation: LAC/2007/41639. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): R. Jungers.
Pour copie conforme à l'original délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2008.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2008007365/211/339.
(080002813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.
Aquatrans RhineShipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 118.276.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
9669
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Référence de publication: 2008007302/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2007, réf. DSO-CL00092. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080001881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
Schuch Immobilien S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9177 Niederfeulen, 22, route de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 134.791.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsieben, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre Probst, mit dem Amtssitz in Ettelbrück.
Sind erschienen:
1) Herr Stefan Schuch, Kaufmann, wohnhaft im Brecht 1, D-67278 Bockenheim;
2) Herr Christopher Schuch, Kaufmann, wohnhaft Franz Kirrmeierstrasse 7 in D-67346 Speyer.
Diese Erschienenen, vertreten wie erwähnt, ersuchen den Notar, wie folgt die Satzungen einer anonymen Gesellschaft
zu beurkunden, die sie untereinander gründen:
Kapitel I. Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine anonyme Gesellschaftgegründet unter der Bezeichnung SCHUCH IMMOBILIEN S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Feulen.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz an jedwelchen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg
verlegt werden. Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen,
welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.
Eine solche Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung von
einer solchen Verlegung des Gesellschaftssitzes wird vorgenommen und Dritten zu Kenntnis gebracht durch das Organ
der Gesellschaft, welches unter den gegebenen Zuständen am besten hierzu befähigt ist.
Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf, die Verwertung und Vermietung von jedweden Immobilien
und Mobilien sowohl im In- wie auch im Ausland.
Sie kann im Allgemeinen alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen, die mit diesem Gegenstand
mittelbar oder unmittelbar in Verbindung stehen, tätigen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf jede Art und
Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen
oder die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnten.
Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreißigtausend Euro (31.000,- €) eingeteilt in dreihundertzehn
(310) Aktien zu je hundert (100,-) Euro.
Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei
oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre. Die Aktien bleiben jedoch Namensaktien bis
zu ihrer vollständigen Zeichnung.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz Vorgesehenen Umfang
und Bedingungen
Die Abtretung und der Verkauf von Gesellschaftsaktien an Aktionäre oder Nicht-Aktionäre sind in jedem Fall an ein
Vorkauf recht anteilig zu ihrem Besitz und die schriftliche Zustimmung der anderen Aktionäre gebunden.
In jedem Fall werden die Abtretung und der Verkauf der Aktien zu dem vom Käufer und dem Verkäufer festgesetzten
Preis getätigt.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
9670
Kapitel III. Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre
der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch die
Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.
Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden durch die Gene-
ralversammlung der Aktionäre festgesetzt.
Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung durch den Vorsitzenden, so oft das Interesse der Gesellschaft
es verlangt. Jedes Mal wenn zwei Vorstandsmitglieder es verlangen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden.
Art. 8. Dieser Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck
zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.
Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-
versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates. Mit dem
Einverständnis der statutarischen Kommissare kann der Verwaltungsrat, unter den gesetzlichen Bestimmungen, Vor-
schüsse auf Dividenden auszahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird verpflichtet unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Ver-
waltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwalters, es sei denn, dass spezielle
Entscheidungen getroffen wurden über Bevollmächtigung und Stellvertretung des Verwaltungsrates, so wie vorgesehen
in Artikel 10 der gegenwärtigen Satzung.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Vollmacht in Bezug auf die tägliche Gesellschaftsführung der Gesellschaft an
eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen; diese haben den Titel eines geschäftsführenden Ver-
walters.
Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung der Gesellschaft oder eine bestimmte Abzwei-
gung davon an einen oder mehrere Geschäftsführer übertragen, oder für bestimmte Anliegen Sondervollmachten an einen
oder mehrere, von ihm ausgewählten Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktionäre der
Gesellschaft zu sein brauchen.
Art. 11. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-
tungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.
Kapitel IV. Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Kommissaren, die ernannt werden durch die
Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht über-
schreiten darf, festlegt.
Kapitel V. Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt am Gesellschaftssitz oder an dem in der Einberufung vorgese-
henen Ort, am dritten Donnerstag im Monat April um 16.00 Uhr.
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-
ben.
Art. 14. Die Generalversammlung kann eine Abänderung der vorliegenden Satzungen nur dann beschließen, wenn alle
Aktionäre anwesend oder vertreten sind und die Änderungen in der Tagesordnung angezeigt wurden. Für die Annahme
der Änderungen müssen mindestens drei Viertel aller anwesenden oder vertretenen Aktionäre ausdrücklich und formell
ihr Einverständnis bekunden.
Kapitel VI. Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes
Art. 15. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines
jeden Jahres, mit Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.
Art. 16. Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss welcher verbleibt nach Abzug von der Bilanz von sämtlichen
Kosten und Abschreibungen der Gesellschaft. Von diesem Reingewinn werden mindestens fünf Prozent (5%) dem ge-
setzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10%)
des Gesellschaftskapitals darstellt. Falls jedoch der Reservefonds, aus welchem Grunde es auch sei, benutzt werden sollte,
so sind die jährlichen Zuführungen wieder aufzunehmen bis der Reservefonds ganz wieder hergestellt ist.
Der Überschuss steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Kapitel VII. Auflösung, Liquidation
Art. 17. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden.
9671
Gelangt die Gesellschaft vorzeitig zur Auflösung, so erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren,
die sowohl physische Personen als auch Gesellschafter sein können, und ernannt werden durch die Generalversammlung
der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre Bezüge festsetzt.
Kapitel VIII. Allgemeines
Art. 18. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, die Gesamtheit (100%) des
Kapitals wie folgt zu zeichnen:
1. Herr Stefan Schuch, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2. Herr Christopher Schuch, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Diese Anteile wurden zu 100 Prozent und bar eingezahlt, so dass die Summe von einunddreissigtausend (31.000,-)
euro der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich
bestätigt wurde,
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft
im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr eintausendfünfhundert Euro
(1.500,- €).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Die vorbenannten Erschienenen, die das gesamte gezeichnete Kapital darstellen und sich als ordentlich einberufen
betrachten, haben sich sofort zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden.
Nach Feststellung ihrer rechtsmäßigen Zusammensetzung haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei, diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf einen.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Stefan Schuch, vorbenannt;
b) Herr Christopher Schuch, vorbenannt
c) Herr Bernd Horn, Betriebswirt, wohnhaft in D-67346 Speyer, Sanddornweg, 23
3. Zum Kommissar wird ernannt:
- Die Gesellschaft FINPART S.A. mit Sitz in L-1215 Luxemburg, 32, rue de la Barrière.
Die Generalversammlung bestimmt, dass zwei Verwaltungsratsmitglieder durch ihre gemeinsame jeweilige Unterschrift
die Gesellschaft verpflichten können und dies ohne finanzielle Beschränkung.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars endet bei der jährlichen Generalversammlung des
Jahres 2013.
4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9177 Feulen, route de Bastogne 22.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnetes: S. Schuch, C. Schuch, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 24 décembre 2007, DIE/2007/8425. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
Für gleichlautende Abschrift, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Ettelbrück, den 7. Januar 2008.
P. Probst.
Référence de publication: 2008007586/4917/143.
(080002789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.
Parc Breidfeld sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.
R.C.S. Luxembourg B 134.790.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbrück.
9672
Ont comparu:
1) La société anonyme IMMOBILIERE BEIM DREIECK SA établie et ayant son siège social à L-9147 Erpeldange, 7, rue
Laduno,
constituée par acte du notaire Marc Cravatte, alors notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 10 septembre 1993,
publié au Mémorial C, page 29466 de l'année 1992, changée en société anonyme suivant acte passé par-devant Maître
Roger Arrensdorff, alors notaire de résidence à Wiltz en date du 24 juillet 1998, publié au Mémorial C de l'année 1998
à la page 39517;
inscrite au registre de commerce sous le numéro B 92.068;
comparant par son administrateur délégué, Monsieur Rudy Peters, administrateur de sociétés, (Matricule: 1937 04 18
171), né le 18 avril 1937 à Crombach, Belgique, demeurant à L-9147, Erpeldange/ Ettelbruck.
2) La société anonyme IMMO C. JANS & ASSOCIES S.A., établie et ayant-son siège social à L-96-51 Eschweiler/Wiltz,
4, rue Tom,
constituée par acte passé par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, en date du 3 février
1998, publié au Mémorial C des Sociétés et Associations à la page 17253 de l'année 1998,
inscrite au registre de commerce sous le numéro B 102.762,
comparant par Monsieur Claude Jans, entrepreneur, demeurant à Eschweiler/Wiltz, 5, rue Tom, administrateur-dé-
légué, pouvant engager la société par sa seule signature suivant l'article 6 des statuts,
3) Monsieur Rudy Peters, préqualifié, agissant en nom personnel,
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont
ils ont arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination PARC BREIDFELD
sàrl, qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée par la suite et par les présents statuts.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Eschweiler/Wiltz. Il peut être transféré dans les limites de la commune
par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés
délibérant comme en matière de modification des statuts.
Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales,
filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société qui restera une société
luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social. La société a pour objet la profession d'agent immobilier, de promoteur immobilier, l'administration
de biens immobiliers et la profession de syndic immobilier, ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.
Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
La société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de
tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à quatorze mille euros (EUROS 14.000,-), représenté par 100 parts sociales
sous forme nominative d'une valeur nominale de euros 140,- chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la société en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Envers la société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la société.
Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
9673
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné,
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi précitée.
Un registre des associés sera tenu au siège social de la société conformément aux dispositions de la loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des
associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera
la durée de leur mandat.
Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des
associés par la loi ou les présents statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil
de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par tout/deux gérant(s).
Art. 9. Procédure. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation
d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la société sont présents ou
représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informé de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi
être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée.
Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.
Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la
réunion.
Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme
si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature du
gérant, en cas de gérant unique ou de deux gérants, lorsqu'ils sont plusieurs, ou par les signatures conjointes ou la signature
unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8
des statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la loi à l'assemblée
générale des associés.
Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la société en désignant par écrit,
soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des
associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original,
soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution
circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution
identique, envoyées par lettre ou téléfax.
9674
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions prises pour la modification des statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la société
seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.
Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la société.
Art. 15. Affectation des bénéfices. Les profits bruts de la société repris dans les comptes annuels, après déduction des
frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice
net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital social de la société.
L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel.
Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui
fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par
la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes
de la société.
Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la société sera attribué à
l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la société.
VII. Disposition générale
Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents statuts, il est fait référence à la loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2008.
<i>Souscription - Libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux parts sociales créées de la manière suivante:
Parts
sociales
1) La société anonyme IMMOBILIERE BEIM DREIECK, préqualifiée, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . .
40
2) La société anonyme IMMO C. JANS & ASSOCIES, préqualifiée, cinquante parts sociales
50
3) Monsieur Rudy Peters, préqualifié, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Les comparants déclarent avoir souscrit à l'endèreté du capital social de la Société et avoir entièrement libéré les 100
parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de euros 14.000,- est à la disposition de la Société, ce
qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ neuf cents euros (900,- €).
<i>Assemblée généralei>
Et aussitôt, les associés préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, Messieurs Rudy Peters et Claude Jans, préqualifiés,
avec pouvoir d'engager la société par leurs signatures conjointes.
3. Le siège social de la société est établi à L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants tous connus du notaire par noms, prénoms, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Peters, C. Jans, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 24 décembre 2007, DIE/2007/8416. — Reçu 140 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
9675
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 7 janvier 2008.
P. Probst.
Référence de publication: 2008007588/4917/176.
(080002787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.
Universum F.O. Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 133.655.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2008.
E. Schlesser
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008007345/227/12.
(080002217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
World Power Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 111.503.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
50025 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008007346/211/12.
(080002171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
RP XXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 134.763.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the seventeenth day of the month of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
RP S.àr.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg and having its registered office in 6C,
Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, and being registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des
Sociétés under number B123958 here represented by Flora Gibert employee, residing in Luxembourg, pursuant to a
proxy dated December 2007 (such proxy to be registered together with the present deed).
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of association of a limited liability Company RP XXII S.à r.l. («société à responsabilité limitée») which is hereby established
as follows:
Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name RP XXII S.à r.l. (the «Company») is
hereby formed by the appearing parties and all persons who will become members thereafter. The Company will be
governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. The object of the Company is the acquisition and management of real estate either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad. Furthermore the Company may take participations interests in other companies having a similar
object.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. The Company has its registered office in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.
9676
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. The issued share capital of the Company is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into
500 (five hundred) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five) each. The capital of the Company may be increased
or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for the amendment of these articles of
association.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-
members is subject to the consent of members, expressed in accordance with article 189 of the law of 10th August 1915
on commercial companies, as amended, representing at least seventy five percent of the Company's capital.
Art. 7. The Company is managed by one or several managers who need not be members.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an
undetermined period. The managers may be reelected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. The board may choose among
its members a chairman. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to
communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. Decisions adopted by conference
call or other similar means of communication shall be valid only if recorded in minutes signed by the managers who
participated in the conference. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a par-
ticipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation).
In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and
one class B manager acting together (including by way of representation).
9677
Art. 8. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,
they are responsible for the performance of their duties.
Art. 9. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares
he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.
Art. 10. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg company
law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of members of the
Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to members to their address appearing in
the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses inscribed
in the register of members held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the reso-
lutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However,
decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members (ii) repre-
senting at least three quarters of the issued share capital.
Art. 11. The accounting year begins on May 1st, of each year and ends on April 30th, of the following year.
Art. 12. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case
may be, the board of managers.
Art. 13. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.
Art. 14. Out of the net profit five per cent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to
be compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company.
The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The
general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.
Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may
be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their
powers and remunerations.
Art. 16. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member
company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1
and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legislation.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
500 shares with a par value of EUR 25 each
Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The single member has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at
6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.
2. The following persons are named managers who shall jointly constitute the board of managers of the Company for
an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company:
9678
<i>A Manager:i>
Mr Stewart Kam Cheong, Independent auditor, 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, 22 July 1962, Port Louis
(Mauritius)
<i>B Manager:i>
Mr Gregory J. Hartman, Company Director, 155 Prospect Avenue, Woodside CA 94062, USA, 26 January 1959,
California, USA
Mr Brian Borg, Investment Manager, 2, Clover Mews, SW3 4JH London (United Kingdom), 29 December 1973, Omaha,
Nebraska, USA
<i>Special dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on April 30, 2008.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal
knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes:
Im Jahre zweitausendbundsieben, den siebenzehnten Tag des Monats Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar M
e
Joseph Elvinger, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
RP S.àr.l., eine Gesellschaft eingetragen nach und bestehend unter Luxemburgischem Recht, mit eingetragenem Sitz in
6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, und registriert beim Luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer
B 123.958, vertreten durch Flora Gibert wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom Dezember 2007 (welche
gleichzeitig mit der vorliegenden Urkunde einzutragen ist).
Die erschienene Partei, handelnd gemäß ihrer vorstehend aufgeführten Eigenschaften, hat den Notar gebeten, die
folgende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») RP XXII S.àr.l. festzu-
stellen, welche hiermit wie folgt gegründet wird.
Art. 1. Es besteht zwischen den Erschienenen und all denjenigen, die Inhaber der nachfolgend erwähnten Geschäfts-
anteile werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma RP XXII S.àr.l. («société à responsabilité
limitée»). Die Gesellschaft wird geregelt durch diese Satzung und die anwendbare Gesetzesgebung.
Art. 2. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Anschaffung und die Verwaltung von Immobilien aller Art im
Grossherzogum Luxemburg oder im Ausland. Die Gesellschaft wird darüber hinaus die Beteiligung an luxemburgischen
oder ausländischen Gesellschaften mit dem selben Unternehmenszweck zum Gegenstand haben.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach, Gemeinde Schuttrange. Der eingetragene
Sitz kann durch Beschluß der außerordentlichen Versammlung von all seinen Gesellschaftern beratend in der Art und
Weise wie angemessen zur Änderung der Satzung, verlegt werden. Die Adresse des eingetragenen Sitzes kann durch
Beschluß des Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführung abgeändert werden. Die Gesellschaft kann Nie-
derlassungen und Zweigstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.
Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder bevorstehen, welche nach
Meinung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführung die normale Geschäftstätigkeit am eingetragenen Sitz oder den
reibungslosen Verkehr zwischen diesem eingetragenen Sitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der ein-
getragene Sitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Ereignisse ins Ausland verlegt
werden; diese vorläufige Maßnahme hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet
der vorübergehenden Verlegung ihres eingetragenen Sitzes weiterhin luxemburgisch bleibt. Solch vorläufige Maßnahmen
werden von dem Geschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführung getroffen und den jeweils betroffenen Par-
teien zugestellt.
Art. 5. Das Kapital der Gesellschaft beträgt EUR12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) und ist in fünfhundert (500)
Geschäftsanteile aufgeteilt mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (€ 25). Das Kapital der Gesellschaft
kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Entscheidung der außerordentlichen Versammlung der Gesellschafter,
gemäß den erforderlichen Bestimmungen zur Änderung der Satzung.
Verfügbare Anteileprämien sind verteilbar.
9679
Art. 6. Die Geschäftsanteile können frei zwischen unter Gesellschafter übertragen werden. Vorbehaltlich anderer
gesetzlicher Bestimmungen erfordert die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter die Zustimmung
von Gesellschafter welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals besitzen, festgestellt gemäß Artikel 189 des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
Art. 7. Die Gesellschaft wird von einen oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Inhaber von Anteilen
sein können.
Diese werden durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen, welchen
ihren Aufgabenbereich und die Dauer ihres Mandates bestimmt. Im Falle wo keine Dauer angegeben ist, sind die Ge-
schäftsführer auf unbestimmte Dauer bestellt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre
Bestellung zu jedem Zeitpunkt (ad nutum) kann begründet oder unbegründet widerrufen werden.
Falls es mehrere Geschäftsführer gibt, bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann einen Vorsitzen-
den aus seiner Mitte wählen. Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung telefonisch
oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, soweit alle teilnehmenden Mitglieder der Sitzung zuhören
und von allen anderen Mitgliedern der Geschäftsführung, die an dieser Sitzung teilnehmen, gehört werden können und
alle Mitglieder sich miteinander verständigen können. Eine Sitzung kann auch nur telefonisch abgehalten werden. Be-
schlüsse welche durch telefonische Sitzung getroffen werden oder ähnliche Kommunikationsmittel sind nur wirksam, falls
sie in einem Protokoll festgehalten sind welches von den Geschäftsführern die an dieser telefonischen Sitzung teilgenom-
men haben, unterzeichnet ist. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung durch derartige Mittel ist gleichwertig zu
einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung oder dem Abhalten einer Sitzung in Person.
Die Geschäftsführer können von einem anderen Geschäftsführer bei den Sitzungen der Geschäftsführung vertreten
werden ohne Einschränkung betreffend der Anzahl von Vollmachtsformularen welche ein Geschäftsführer annehmen und
wählen darf.
Eine schriftliche Einladung zu einer Sitzung der Geschäftsführung muss den Geschäftsführern mindestens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor dem geplannten Datum der Sitzung gegeben werden, mit Ausnahme von Notfällen, in welchem
Fall die Art und Weise und die Gründe des Notfalls in der Einladung erwähnt werden. Die Einladung kann im Falle einer
Zustimmung aller Geschäftsführer, die schriftlich, telefonisch, per Telegramm, Telex, Email oder Telefax oder mittels
einem sonstigen Kommunikationsmittel ausgedrückt wird, unterlassen werden. Eine spezielle Einladung wird nicht erfor-
derlich sein für eine Sitzung der Geschäftsführung, die an jener Zeit und an jenem Ort stattfindet, wie im Voraus durch
einen Beschluss der Geschäftsführung bestimmt wurde.
Die Generalversammlung der Gesellschafter kann beschliessen, Geschäftsführer von zwei unterschiedlichen Katego-
rien zu ernennen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Jede solche Klassifi-
zierung von Geschäftsführern wird im Protokoll der relevanten Sitzung ordnungsgemäß festgehalten und die
Geschäftsführer werden hinsichtlich der Kategorie, zu der sie gehören, identifiziert.
Beschlüsse der Geschäftsführung werden wirksam gefasst durch die Mehrheitszustimmung der Geschäftsführer der
Gesellschaft (einschließlich im Wege der Vertretung). Im Falle der Ernennung durch die Generalversammlung der Ge-
sellschafter von Geschäftsführern unterschiedlicher Kategorien (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und der
Kategorie B), werden die Beschlüsse der Geschäftsführung nur durch die Mehrheitszustimmung der Geschäftsführer
wirksam gefasst darunter mindestens einen Geschäftsführer der Kategorie A und einen Geschäftsführer der Kategorie B
(die vertreten werden können).
Die Geschäftsführung kann auch einstimmig Beschlüsse fassen durch ein oder mehrere gleichartige Dokumente im
Wege eines Rundschreibens, wenn die Zustimmung schriftlich, telefonisch oder per Telefax oder mittels einem sonstigen
Kommunikationsmittel ausgedrückt wird.
Die Gesamtheit solcher Dokumente werden ordnungsgemäß durchgeführte Runddokumente bilden die den Beschluss
nachweisen. Die Beschlüsse der Geschäftsführer, einschließlich der Rundschreiben, werden entscheidend bescheinigt sein
oder ein Auszug davon kann ausgestellt werden unter der individuellen Unterschrift eines Geschäftsführers.
Die Gesellschaft wird, im Falle eines einzelnen Geschäftsführers, durch die Unterschrift dieses Geschäftsführers ge-
bunden sein, und im Falle einer Geschäftsführung, durch die alleinige Unterschrift jedes einzelnen Geschäftsführers,
vorausgesetzt dass im Falle der Ernennung durch die Generalversammlung der Gesellschafter von Geschäftsführern un-
terschiedlicher Kategorien (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B), die Gesellschaft wird wirksam
gebunden sein nur durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers
der Kategorie B (einschließlich im Wege der Vertretung). In allen Fällen wird die Gesellschaft wirksam gebunden durch
die alleinige Unterschrift jeder Person oder Personen an die eine Unterschriftsvertretungsvollmacht vom einem Ge-
schäftsführer übertragen ist, oder im Falle der Kategorien von Geschäftsführern, durch einen Geschäftsführer der
Kategorie A und einen Geschäftsführer der Kategorie B, die zusammen handeln (einschließlich im Wege der Vertretung).
Art. 8. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für die Verschuldung der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesell-
schaft haften sie für die Leistung ihrer Aufgaben.
Art. 9. Jedes Mitglied darf an den kollektiven Beschlüssen teilnehmen. Es hat eine Anzahl an Stimmen gleichwertig zur
Anzahl der Anteile die es besitzt und darf rechtswirksam handeln in jeder Versammlung der Mitglieder durch spezielle
Vollmacht.
9680
Art. 10. Die Beschlüsse der Mitglieder werden in der Form und mit der Mehrheit getroffen die vom luxemburgischen
Gesetz über die Handelsgesellschaften vorgeschrieben ist (in dem Ausmaß als gesetzlich erlaubt) oder abgehalten in
Versammlungen. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter, oder jeder schriftlicher wirksamer
Beschluss (je nach Fall) vertritt das gesamte Gesellschaftsorgan der Gesellschaft.
Versammlungen werden einberufen durch Einladung, per eingeschriebenen Brief an den Gesellschaftern an die einge-
tragene Adresse im Gesellschaftsregister der Gesellschaft, mindestens acht (8) Tage vor dem Datum der Versammlung
zur Gesellschafterversammlung. Falls das gesamte Gesellschaftskapital bei der Versammlung vertreten ist, kann die Ver-
sammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Im Falle schriftlicher Beschlüsse, wird deren Text den Mitgliedern zugesandt welche im Gesellschaftsregister einge-
tragen sind, mindestens acht (8) Tage vor dem tatsächlich vorgeschlagenen Datum der Beschlüsse. Die Beschlüsse werden
nach Billigung der Stimmenmehrheit wirksam gemäß dem Gesetz für Kollektivbeschlüsse (oder vorbehaltlich der Erfüllung
der Mehrheitsvorschriften, an dem Datum darin aufgeführt). Einheitliche schriftliche Beschlüsse können jederzeit getroffen
werden ohne vorherige Einberufung.
Kollektivbeschlüsse sind nur dann wirksam, wenn sie durch eine Stimmenmehrheit welche mehr als die Hälfte des
Kapitals vertritt, getroffen werden. Jedoch werden Beschlüsse welche die Änderung der Satzung betreffen durch (i) eine
Mehrheit der Gesellschafter (ii) welche mehr als drei Viertel des Stammkapitals vertreten getroffen.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Mai jeden Jahres und endet am 30 April des darauffolgenden Jahres.
Art. 12. Jedes Jahr am Ende des Geschäftsjahres stellt der Geschäftsführer oder gegebenenfalls die Geschäftsführung
die Jahresabschlüsse auf.
Art. 13. Der Finanzbericht ist erhältlich für die Gesellschafter am eingetragenen Sitz der Gesellschaft.
Art. 14. Fünf Prozent (5 %) des jährlichen Reingewinns der Gesellschaft werden zur Bildung der gesetzlichen Rücklage
verwendet. Diese Entnahme ist dann nicht mehr zwingend, wenn die Rücklage zehn Prozent (10 %) des Stammkapitals
erreicht hat.
Aufgrund der von dem Geschäftsführer oder gegebenenfalls Gesellschaftsführern angefertigten Kontoabschlüssen,
können die Gesellschafter beschließen Abschlagszahlungen auf Dividenden zu tätigen, welche vorzeigen dass genügend
Gelder zur Ausschüttung vorhanden sind, vorausgesetzt dass der auszuschüttende Betrag nicht den erzielten Gewinn seit
dem Ende des letzten Geschäftsjahres erhöht durch den vorgetragenen Gewinn und auszuschüttende Reserven aber
erniedrigt durch die vorgetragenen Verluste und Summen welche in eine gesetzlich zu errichtende Reserve zu verteilen
sind, überschreiten darf.
Der Saldo kann an die Gesellschafter ausgeschüttet werden durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter.
Das Aktienprämiumkonto kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an die Gesellschafter ausge-
schüttet werden.
Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann beschließen jeglichen Betrag aus dem Aktienprämiumkonto an die
gesetzliche Rücklage zu verteilen.
Art. 15. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft obliegt die Abwicklung der Gesellschaft einem oder mehreren Liqui-
datoren welche Gesellschafter sein können aber nicht müssen sein, und welche von der Hauptversammlung der
Gesellschafter ernannt werden und deren Befugnisse und Vergütung auch von der Hauptversammlung der Gesellschaft
bestimmt werden.
Art. 16. Falls, und solange als ein Gesellschafter alle Anteile der Gesellschaft besitzt, existiert die Gesellschaft als
Einzelteilnehmergesellschaft, gemäß Artikel 179 (2) des Gesetzes vom 10 August über die Handelsgesellschaften; in diesem
Falle sind unter anderem Artikel 200-1 und 200-2, dieses Gesetzes anwendbar.
Art. 17. Für alles das nicht von der vorliegenden Satzungen bestimmt wird, berufen die Gesellschafter sich auf das
anwendbare Recht.
<i>Übernahme und Einzahlungi>
Da solchermaßen die Satzung der Gesellschaft durch die erschienene Partei aufgestellt worden ist, hat die vorbe-
zeichnete Vertragspartei die folgenden Anteile der Gesellschaft wie folgt übernommen und gänzlich gezahlt:
500 Anteile mit einem Nennwert von EUR 25 per Anteil
Nachweis wurde dem Notar gegeben der Zahlung des Übernahmebetrags.
<i>Abschätzung der Kosteni>
Die Parteien haben die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen ungeachtet ihrer Form, welche von der Gesell-
schaft zu tragen sind, oder ihr in Verbindung mit der Gründung belastet werden auf ein tausend fünf hundert Euro
geschätzt.
<i>Erste ausserordentliche Hauptversammlungi>
Der alleinige Gesellschafter hat unmittelbar die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in 6C, Parc d'activités Syrdall, L-5365 Schuttrange.
9681
2. Die nachfolgenden Personen wurden Geschäftsführer ernannt, welche gemeinsam die Geschäftsführung der Ge-
sellschaft bilden, auf unbestimmte Dauer, vorbehaltlich der Satzung der Gesellschaft
<i>Geschäftsführer A:i>
Herr Stewart Kam Cheong, Selbständiger Buchsachverständiger, 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, 22 Juli
1962, Port Louis (Mauritius)
<i>Geschäftsführer B:i>
Herr Gregory J. Hartman, Geschäftsführer, 155 Prospect Avenue, Woodside CA 94062, USA, 26 Januar 1959, Kali-
fornien, USA
Herr Brian Borg, Geschäftsführer, 2, Clover Mews, SW3 4JH, (Vereinigtes Königreich), 29 Dezember 1973, Omaha,
Nebraska, USA
<i>Spezielle Bestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 30. April 2008.
Woraufhin die vorliegende Urkunde in Luxemburg erstellt wurde, am Tag wie zu Beginn des Dokumentes aufgeführt.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben-
genannten erschienenen Personen, diese vorliegende Ausfertigung in Englisch abgefaßt ist, welcher eine deutsche
Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen dem eng-
lischen und dem deutschen Wortlaut, wird der englische Wortlaut massgebend sein.
Hierauf wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg erstellt, an dem Tag wie zu Beginn in diesem Doku-
ment eingetragen.
Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, welche dem Notar bekannt sind durch ihre
Namen, Vornamen, zivilen Status und ihrer Herkunft, haben die Vorsitzende, der Sekretär und der Aufsichtsbeauftragte
zusammen mit Uns, dem Notar, vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007. Relation: LAC/2007/41638. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): R. Jungers.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2008.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2008007360/211/333.
(080002563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.
Alpha Management Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 40.140.
En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé
au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008007319/777/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, réf. LSO-CM00370. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080001815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
Cellamare S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 83.542.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2008007320/777/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, réf. LSO-CM00371. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080001816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
9682
Bond Capital Partners (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 132.224.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2008.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008007342/5770/12.
(080001898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
RP XXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 134.764.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the seventeenth day of the month of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
RP S.àr.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg and having its registered office in 6C,
Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, and being registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des
Sociétés under number B123958 here represented by Flora Gibert, employee, residing in Luxembourg, pursuant to a
proxy dated December 2007 (such proxy to be registered together with the present deed).
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of association of a limited liability Company RP XXI S.à r.l. («société à responsabilité limitée») which is hereby established
as follows:
Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name RP XXI S.à r.l. (the «Company») is
hereby formed by the appearing parties and all persons who will become members thereafter. The Company will be
governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. The object of the Company is the acquisition and management of real estate either in the Grand-Duchy of
Luxembourg or abroad. Furthermore the Company may take participations interests in other companies having a similar
object.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. The Company has its registered office in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. The issued share capital of the Company is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into
500 (five hundred) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five) each. The capital of the Company may be increased
or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for the amendment of these articles of
association.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-
members is subject to the consent of members, expressed in accordance with article 189 of the law of 10th August 1915
on commercial companies, as amended, representing at least seventy five percent of the Company's capital.
9683
Art. 7. The Company is managed by one or several managers who need not be members.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an
undetermined period. The managers may be reelected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. The board may choose among
its members a chairman. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to
communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. Decisions adopted by conference
call or other similar means of communication shall be valid only if recorded in minutes signed by the managers who
participated in the conference. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a par-
ticipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation).
In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and
one class B manager acting together (including by way of representation).
Art. 8. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,
they are responsible for the performance of their duties.
Art. 9. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares
he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.
Art. 10. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg company
law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of members of the
Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to members to their address appearing in
the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses inscribed
in the register of members held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the reso-
lutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However,
decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members (ii) repre-
senting at least three quarters of the issued share capital.
Art. 11. The accounting year begins on May 1st, of each year and ends on April 30th, of the following year.
9684
Art. 12. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case
may be, the board of managers.
Art. 13. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.
Art. 14. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to
be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The
general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.
Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may
be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their
powers and remunerations.
Art. 16. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member
company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1
and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legislation.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
500 shares with a par value of EUR 25 each
Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The single member has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.
2. The following persons are named managers who shall jointly constitute the board of managers of the Company for
an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company:
<i>A Manager:i>
Mr Stewart Kam Cheong, Independent auditor, 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, 22 July 1962, Port Louis
(Mauritius)
<i>B Manager:i>
Mr Gregory J. Hartman, Company Director, 155 Prospect Avenue, Woodside CA 94062, USA, 26 January 1959,
California, USA
Mr Brian Borg, Investment Manager, 2, Clover Mews, SW3 4JH London (United Kingdom), 29 December 1973, Omaha,
Nebraska, USA
<i>Special dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on April 30, 2008.
In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal
knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes:
Im Jahre zweitausendbundsieben, den siebenzehnten Tag des Monats Dezember.
9685
Vor dem unterzeichneten Notar M
e
Joseph Elvinger, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
RP S.àr.l., eine Gesellschaft eingetragen nach und bestehend unter Luxemburgischem Recht, mit eingetragenem Sitz in
6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, und registriert beim Luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer
B123958, vertreten durch Flora Gibert, wohnhaft in Luxembourg, aufgrund einer Vollmacht vom Dezember 2007 (welche
gleichzeitig mit der vorliegenden Urkunde einzutragen ist).
Die erschienene Partei, handelnd gemäß ihrer vorstehend aufgeführten Eigenschaften, hat den Notar gebeten, die
folgende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») RP XXI S.àr.l. festzu-
stellen, welche hiermit wie folgt gegründet wird.
Art. 1. Es besteht zwischen den Erschienenen und all denjenigen, die Inhaber der nachfolgend erwähnten Geschäfts-
anteile werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma RP XXI S.àr.l. («société à responsabilité
limitée»). Die Gesellschaft wird geregelt durch diese Satzung und die anwendbare Gesetzesgebung.
Art. 2. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Anschaffung und die Verwaltung von Immobilien aller Art im
Grossherzogum Luxemburg oder im Ausland. Die Gesellschaft wird darüber hinaus die Beteiligung an luxemburgischen
oder ausländischen Gesellschaften mit dem selben Unternehmenszweck zum Gegenstand haben.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach, Gemeinde Schuttrange. Der eingetragene
Sitz kann durch Beschluß der außerordentlichen Versammlung von all seinen Gesellschaftern beratend in der Art und
Weise wie angemessen zur Änderung der Satzung, verlegt werden. Die Adresse des eingetragenen Sitzes kann durch
Beschluß des Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführung abgeändert werden. Die Gesellschaft kann Nie-
derlassungen und Zweigstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.
Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder bevorstehen, welche nach
Meinung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführung die normale Geschäftstätigkeit am eingetragenen Sitz oder den
reibungslosen Verkehr zwischen diesem eingetragenen Sitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der ein-
getragene Sitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Ereignisse ins Ausland verlegt
werden; diese vorläufige Maßnahme hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet
der vorübergehenden Verlegung ihres eingetragenen Sitzes weiterhin luxemburgisch bleibt. Solch vorläufige Maßnahmen
werden von dem Geschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführung getroffen und den jeweils betroffenen Par-
teien zugestellt.
Art. 5. Das Kapital der Gesellschaft beträgt EUR12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) und ist in fünfhundert (500)
Geschäftsanteile aufgeteilt mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (€ 25). Das Kapital der Gesellschaft
kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Entscheidung der außerordentlichen Versammlung der Gesellschafter,
gemäß den erforderlichen Bestimmungen zur Änderung der Satzung.
Verfügbare Anteileprämien sind verteilbar.
Art. 6. Die Geschäftsanteile können frei zwischen unter Gesellschafter übertragen werden. Vorbehaltlich anderer
gesetzlicher Bestimmungen erfordert die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter die Zustimmung
von Gesellschafter welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals besitzen, festgestellt gemäß Artikel 189 des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
Art. 7. Die Gesellschaft wird von einen oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Inhaber von Anteilen
sein können.
Diese werden durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen, welchen
ihren Aufgabenbereich und die Dauer ihres Mandates bestimmt. Im Falle wo keine Dauer angegeben ist, sind die Ge-
schäftsführer auf unbestimmte Dauer bestellt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre
Bestellung zu jedem Zeitpunkt (ad nutum) kann begründet oder unbegründet widerrufen werden.
Falls es mehrere Geschäftsführer gibt, bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann einen Vorsitzen-
den aus seiner Mitte wählen. Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung telefonisch
oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, soweit alle teilnehmenden Mitglieder der Sitzung zuhören
und von allen anderen Mitgliedern der Geschäftsführung, die an dieser Sitzung teilnehmen, gehört werden können und
alle Mitglieder sich miteinander verständigen können. Eine Sitzung kann auch nur telefonisch abgehalten werden. Be-
schlüsse welche durch telefonische Sitzung getroffen werden oder ähnliche Kommunikationsmittel sind nur wirksam, falls
sie in einem Protokoll festgehalten sind welches von den Geschäftsführern die an dieser telefonischen Sitzung teilgenom-
men haben, unterzeichnet ist. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung durch derartige Mittel ist gleichwertig zu
einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung oder dem Abhalten einer Sitzung in Person.
Die Geschäftsführer können von einem anderen Geschäftsführer bei den Sitzungen der Geschäftsführung vertreten
werden ohne Einschränkung betreffend der Anzahl von Vollmachtsformularen welche ein Geschäftsführer annehmen und
wählen darf.
9686
Eine schriftliche Einladung zu einer Sitzung der Geschäftsführung muss den Geschäftsführern mindestens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor dem geplannten Datum der Sitzung gegeben werden, mit Ausnahme von Notfällen, in welchem
Fall die Art und Weise und die Gründe des Notfalls in der Einladung erwähnt werden. Die Einladung kann im Falle einer
Zustimmung aller Geschäftsführer, die schriftlich, telefonisch, per Telegramm, Telex, Email oder Telefax oder mittels
einem sonstigen Kommunikationsmittel ausgedrückt wird, unterlassen werden. Eine spezielle Einladung wird nicht erfor-
derlich sein für eine Sitzung der Geschäftsführung, die an jener Zeit und an jenem Ort stattfindet, wie im Voraus durch
einen Beschluss der Geschäftsführung bestimmt wurde.
Die Generalversammlung der Gesellschafter kann beschliessen, Geschäftsführer von zwei unterschiedlichen Katego-
rien zu ernennen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Jede solche Klassifi-
zierung von Geschäftsführern wird im Protokoll der relevanten Sitzung ordnungsgemäß festgehalten und die
Geschäftsführer werden hinsichtlich der Kategorie, zu der sie gehören, identifiziert.
Beschlüsse der Geschäftsführung werden wirksam gefasst durch die Mehrheitszustimmung der Geschäftsführer der
Gesellschaft (einschließlich im Wege der Vertretung). Im Falle der Ernennung durch die Generalversammlung der Ge-
sellschafter von Geschäftsführern unterschiedlicher Kategorien (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und der
Kategorie B), werden die Beschlüsse der Geschäftsführung nur durch die Mehrheitszustimmung der Geschäftsführer
wirksam gefasst darunter mindestens einen Geschäftsführer der Kategorie A und einen Geschäftsführer der Kategorie B
(die vertreten werden können).
Die Geschäftsführung kann auch einstimmig Beschlüsse fassen durch ein oder mehrere gleichartige Dokumente im
Wege eines Rundschreibens, wenn die Zustimmung schriftlich, telefonisch oder per Telefax oder mittels einem sonstigen
Kommunikationsmittel ausgedrückt wird.
Die Gesamtheit solcher Dokumente werden ordnungsgemäß durchgeführte Runddokumente bilden die den Beschluss
nachweisen. Die Beschlüsse der Geschäftsführer, einschließlich der Rundschreiben, werden entscheidend bescheinigt sein
oder ein Auszug davon kann ausgestellt werden unter der individuellen Unterschrift eines Geschäftsführers.
Die Gesellschaft wird, im Falle eines einzelnen Geschäftsführers, durch die Unterschrift dieses Geschäftsführers ge-
bunden sein, und im Falle einer Geschäftsführung, durch die alleinige Unterschrift jedes einzelnen Geschäftsführers,
vorausgesetzt dass im Falle der Ernennung durch die Generalversammlung der Gesellschafter von Geschäftsführern un-
terschiedlicher Kategorien (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B), die Gesellschaft wird wirksam
gebunden sein nur durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers
der Kategorie B (einschließlich im Wege der Vertretung). In allen Fällen wird die Gesellschaft wirksam gebunden durch
die alleinige Unterschrift jeder Person oder Personen an die eine Unterschriftsvertretungsvollmacht vom einem Ge-
schäftsführer übertragen ist, oder im Falle der Kategorien von Geschäftsführern, durch einen Geschäftsführer der
Kategorie A und einen Geschäftsführer der Kategorie B, die zusammen handeln (einschließlich im Wege der Vertretung).
Art. 8. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für die Verschuldung der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesell-
schaft haften sie für die Leistung ihrer Aufgaben.
Art. 9. Jedes Mitglied darf an den kollektiven Beschlüssen teilnehmen. Es hat eine Anzahl an Stimmen gleichwertig zur
Anzahl der Anteile die es besitzt und darf rechtswirksam handeln in jeder Versammlung der Mitglieder durch spezielle
Vollmacht.
Art. 10. Die Beschlüsse der Mitglieder werden in der Form und mit der Mehrheit getroffen die vom luxemburgischen
Gesetz über die Handelsgesellschaften vorgeschrieben ist (in dem Ausmaß als gesetzlich erlaubt) oder abgehalten in
Versammlungen. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter, oder jeder schriftlicher wirksamer
Beschluss (je nach Fall) vertritt das gesamte Gesellschaftsorgan der Gesellschaft.
Versammlungen werden einberufen durch Einladung, per eingeschriebenen Brief an den Gesellschaftern an die einge-
tragene Adresse im Gesellschaftsregister der Gesellschaft, mindestens acht (8) Tage vor dem Datum der Versammlung
zur Gesellschafterversammlung. Falls das gesamte Gesellschaftskapital bei der Versammlung vertreten ist, kann die Ver-
sammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Im Falle schriftlicher Beschlüsse, wird deren Text den Mitgliedern zugesandt welche im Gesellschaftsregister einge-
tragen sind, mindestens acht (8) Tage vor dem tatsächlich vorgeschlagenen Datum der Beschlüsse. Die Beschlüsse werden
nach Billigung der Stimmenmehrheit wirksam gemäß dem Gesetz für Kollektivbeschlüsse (oder vorbehaltlich der Erfüllung
der Mehrheitsvorschriften, an dem Datum darin aufgeführt). Einheitliche schriftliche Beschlüsse können jederzeit getroffen
werden ohne vorherige Einberufung.
Kollektivbeschlüsse sind nur dann wirksam, wenn sie durch eine Stimmenmehrheit welche mehr als die Hälfte des
Kapitals vertritt, getroffen werden. Jedoch werden Beschlüsse welche die Änderung der Satzung betreffen durch (i) eine
Mehrheit der Gesellschafter (ii) welche mehr als drei Viertel des Stammkapitals vertreten getroffen.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Mai jeden Jahres und endet am 30 April des darauffolgenden Jahres.
Art. 12. Jedes Jahr am Ende des Geschäftsjahres stellt der Geschäftsführer oder gegebenenfalls die Geschäftsführung
die Jahresabschlüsse auf.
Art. 13. Der Finanzbericht ist erhältlich für die Gesellschafter am eingetragenen Sitz der Gesellschaft.
9687
Art. 14. Fünf Prozent (5 %) des jährlichen Reingewinns der Gesellschaft werden zur Bildung der gesetzlichen Rücklage
verwendet. Diese Entnahme ist dann nicht mehr zwingend, wenn die Rücklage zehn Prozent (10 %) des Stammkapitals
erreicht hat.
Aufgrund der von dem Geschäftsführer oder gegebenenfalls Gesellschaftsführern angefertigten Kontoabschlüssen,
können die Gesellschafter beschließen Abschlagszahlungen auf Dividenden zu tätigen, welche vorzeigen dass genügend
Gelder zur Ausschüttung vorhanden sind, vorausgesetzt dass der auszuschüttende Betrag nicht den erzielten Gewinn seit
dem Ende des letzten Geschäftsjahres erhöht durch den vorgetragenen Gewinn und auszuschüttende Reserven aber
erniedrigt durch die vorgetragenen Verluste und Summen welche in eine gesetzlich zu errichtende Reserve zu verteilen
sind, überschreiten darf.
Der Saldo kann an die Gesellschafter ausgeschüttet werden durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter.
Das Aktienprämiumkonto kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an die Gesellschafter ausge-
schüttet werden.
Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann beschließen jeglichen Betrag aus dem Aktienprämiumkonto an die
gesetzliche Rücklage zu verteilen.
Art. 15. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft obliegt die Abwicklung der Gesellschaft einem oder mehreren Liqui-
datoren welche Gesellschafter sein können aber nicht müssen sein, und welche von der Hauptversammlung der
Gesellschafter ernannt werden und deren Befugnisse und Vergütung auch von der Hauptversammlung der Gesellschaft
bestimmt werden.
Art. 16. Falls, und solange als ein Gesellschafter alle Anteile der Gesellschaft besitzt, existiert die Gesellschaft als
Einzelteilnehmergesellschaft, gemäß Artikel 179 (2) des Gesetzes vom 10 August über die Handelsgesellschaften; in diesem
Falle sind unter anderem Artikel 200-1 und 200-2, dieses Gesetzes anwendbar.
Art. 17. Für alles das nicht von der vorliegenden Satzungen bestimmt wird, berufen die Gesellschafter sich auf das
anwendbare Recht.
<i>Übernahme und Einzahlungi>
Da solchermaßen die Satzung der Gesellschaft durch die erschienene Partei aufgestellt worden ist, hat die vorbe-
zeichnete Vertragspartei die folgenden Anteile der Gesellschaft wie folgt übernommen und gänzlich gezahlt:
500 Anteile mit einem Nennwert von EUR 25 per Anteil
Nachweis wurde dem Notar gegeben der Zahlung des Übernahmebetrags.
<i>Abschätzung der Kosteni>
Die Parteien haben die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen ungeachtet ihrer Form, welche von der Gesell-
schaft zu tragen sind, oder ihr in Verbindung mit der Gründung belastet werden auf eintausendfünfhundert Euro geschätzt.
<i>Erste ausserordentliche Hauptversammlungi>
Der alleinige Gesellschafter hat unmittelbar die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in 6C, Parc d'activités Syrdall, L-5365 Schuttrange.
2. Die nachfolgenden Personen wurden Geschäftsführer ernannt, welche gemeinsam die Geschäftsführung der Ge-
sellschaft bilden, auf unbestimmte Dauer, vorbehaltlich der Satzung der Gesellschaft
<i>Geschäftsführer A:i>
Herr Stewart Kam Cheong, Selbständiger Buchsachverständiger, 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, 22 Juli
1962, Port Louis (Mauritius)
<i>Geschäftsführer B:i>
Herr Gregory J. Hartman, Geschäftsführer, 155 Prospect Avenue, Woodside CA 94062, USA, 26 Januar 1959, Kali-
fornien, USA
Herr Brian Borg, Geschäftsführer, 2, Clover Mews, SW3 4JH, (Vereinigtes Königreich), 29 Dezember 1973, Omaha,
Nebraska, USA
<i>Spezielle Bestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 30. April 2008.
Woraufhin die vorliegende Urkunde in Luxemburg erstellt wurde, am Tag wie zu Beginn des Dokumentes aufgeführt.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben-
genannten erschienenen Personen, diese vorliegende Ausfertigung in Englisch abgefaßt ist, welcher eine deutsche
Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen dem eng-
lischen und dem deutschen Wortlaut, wird der englische Wortlaut massgebend sein.
Hierauf wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg erstellt, an dem Tag wie zu Beginn in diesem Doku-
ment eingetragen.
9688
Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, welche dem Notar bekannt sind durch ihre
Namen, Vornamen, zivilen Status und ihrer Herkunft, haben die Vorsitzende, der Sekretär und der Aufsichtsbeauftragte
zusammen mit Uns, dem Notar, vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007. Relation: LAC/2007/41637. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): R. Jungers.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2008.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2008007361/211/331.
(080002566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.
Angel S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8184 Kopstal, 24, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 134.800.
STATUTS
L'an deux mille sept, le dix décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Madame Anna Palmisano, ouvrière, née à Sammichele Di Bari (Italie), le 5 avril 1959, demeurant à L-8184 Kopstal,
24, rue de Luxembourg;
2.- Monsieur Hamid Naccache, étudiant, né à Luxembourg, le 5 novembre 1986, demeurant à L-8184 Kopstal, 24, rue
de Luxembourg.
Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une
société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: ANGEL S. à r.l.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite restau-
ration.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.
Art. 3. Le siège social est établi à Kopstal.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-
mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois
quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
9689
Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.
<i>Souscriptioni>
Le capital a été souscrit comme suit:
1.- Madame Anna Palmisano, prénommée, soixante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.- Monsieur Hamid Naccache, prénommé, trente-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes ces parts ont été libérées intégralement par les apports en nature suivants qui sont à disposition de la société:
un téléviseur «privilege», un canapé, une cuisine, un frigo-vitrine, des marchandises, des fournitures d'entretien et du petit
matériel ainsi que le premier loyer avec la caution.
Les comparants évaluent cet apport à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-).
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (€ 1.000,-).
<i>Décisionsi>
Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité
des voix ils ont pris les décisions suivantes:
I.- Est nommé gérant technique de la société:
Monsieur Hamid Naccache, prénommé,
II.- Est nommé gérant administratif de la société:
Madame Anna Palmisano, prénommée.
III.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
IV.- Le siège social de la société se trouve à L-8184 Kopstal, 24, rue de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: H. Naccache, A. Palmisano, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 2007. Relation: EAC/2007/15660. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2007.
F. Kesseler.
Référence de publication: 2008007349/219/77.
(080002864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.
UT Luxembourg Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 103.593.
Le bilan au 30 novembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2008007306/799/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM01148. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080001824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
9690
UT Luxembourg Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 119.325,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 103.594.
Le bilan au 30 novembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2008007307/799/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM01146. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080001825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
5 Square Churchill, Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 134.796.
STATUTS
L'an deux mille sept, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) M. André Elvinger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
2) M. Jean Hoss, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenté par M. André Elvinger, prénommé, aux termes
d'une procuration en date du 17 décembre 2007; et
3) M. Yves Prussen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La procuration prémentionnée, signée par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée à
ce document pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.
Les parties comparantes, ès qualités qu'elles agissent, ont demandé au notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une
société qu'elles forment entre elles:
Art. 1
er
. Forme, dénomination. Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une
société anonyme sous la dénomination de 5 SQUARE CHURCHILL.
Art. 2. Durée. La Société est établie pour une période illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée
générale statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 19 ci-après.
Art. 3. Objet.
1. La Société a pour objet
1) la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères,
l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou de toute autre
manière d'actions, d'obligations, titres d'emprunt, bonds de caisse et d'autres valeurs, ainsi que la propriété, l'adminis-
tration et le développement de son portefeuille,
2) l'acquisition, la vente, la gestion et l'administration de biens immobiliers sous toutes les formes,
3) l'acquisition de tous biens, équipement, installations, logiciels ou autres biens mobiliers.
2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d'emprunt.
3. D'une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de
contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le dévelop-
pement de son objet.
Art. 4. Siège social.
1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être
transféré à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par
simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à
l'étranger.
2. Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
9691
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
Art. 5. Capital.
1. Le capital souscrit de la Société est fixé à soixante mille Euros (€ 60.000,-) représenté par six mille (6.000) actions
d'une valeur nominale de dix Euros (€ 10,-) par action.
2. Le capital autorisé de la Société est fixé à trois millions d'Euros (€ 3.000.000,-), y compris le capital souscrit, à
représenter par trois cent mille (300.000) actions d'une valeur nominale de dix Euros (€ 10,-) par action.
Art. 6. Actions - cessibilité en actions.
1. Les actions sont émises exclusivement sous la forme nominative.
Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d'actions nominatives se fera
par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire,
ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance du cer-
tificat d'action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.
2. Les actions sont librement cessibles aux actionnaires, que ce soit entre vifs ou à cause de mort.
Les actions ne sont cessibles entre vifs à des non-actionnaires qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des
actionnaires représentant les deux tiers du capital.
Les actions ne sont transmissibles pour cause de mort à des non-actionnaires (à l'exception du conjoint survivant
auquel le transfert est libre) qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des actionnaires représentant les deux tiers
des actions appartenant aux actionnaires survivants.
Une telle assemblée devra être convoquée de sorte qu'elle se tienne dans les trois (3) mois de la demande d'agrément
ou dans les six (6)mois de la notification à la Société du ou des héritiers.
Les cessionnaires auxquels l'agrément a été refusé et, en cas de décès d'un actionnaire, les ayant-cause par succession
ou donation (à l'exclusion du conjoint), qui n'ont pas demandé leur agrément ou auxquels l'agrément aura été refusé,
seront rachetés par la Société ou, à défaut, par les actionnaires, en proportion de leurs actions, dans les trois (3) mois
de l'assemblée, à la valeur comptable réévaluée suivant les modes d'usage et, entre autres, en fonction du rendement des
avoirs de la société, et à défaut d'accord sur cette valeur, par arbitrage conformément à l'article 1224 du Code civil.
3. Si des actionnaires décident de vendre à un ou plusieurs non-actionnaires des actions permettant à ce(s) tiers de
détenir directement ou indirectement au moins deux tiers des actions de la Société, ils sont obligés d'obtenir du ou des
tiers acquéreurs que ces tiers acquéreurs acquièrent toutes les actions des autres actionnaires, sur demande de ceux-ci,
aux mêmes conditions et au même prix par action.
Dans le cas où des actionnaires décident de vendre à un ou plusieurs non-actionnaires des actions représentant
ensemble au moins deux tiers des actions de la Société, les autres actionnaires sont obligés de vendre leurs actions aux
tiers acquéreurs aux mêmes conditions et au même prix si ceux-ci en font la demande. Par «vendre», le présent article
comprend tout transfert ou cession à titre gratuit ou onéreux en ce compris tout apport et toute mise en gage ou autre
opération de sûreté et tout transfert résultant de toute voie d'exécution.
4. Dans les limites prévues par la loi, la Société peut racheter ses propres actions.
Art. 7. Augmentation du capital.
1. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant
dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l'article 18 ci-
après.
2. Le conseil d'administration est en droit et chargé d'émettre des actions futures à concurrence de l'intégralité du
capital autorisé, en une fois ou en tranches périodiques, endéans une période expirant le cinquième anniversaire de la
publication des présents statuts au Mémorial C des présents statuts, ceci par décision d'émettre des actions représentant
la totalité ou une partie de l'augmentation du capital et par acceptation au fur et à mesure des souscriptions pour ces
actions. Le conseil d'administration est en outre autorisé et chargé de déterminer les conditions de pareilles souscriptions.
Dans le cadre du capital autorisé le conseil d'administration est autorisé à supprimer le droit préférentiel de souscri-
ption des actionnaires existants prévu par la loi. Dans un tel cas, le conseil d'administration devra pour toute émission
d'actions offrir les nouvelles actions en souscription préférentielle:
- d'abord aux actionnaires existants pendant une période de 10 jours ouvrables en proportion de leur participation
dans le capital;
- ensuite, pour le surplus, aux actionnaires ayant accepté de souscrire pour tout leur pourcentage, pendant une période
de 10 jours ouvrables, jusqu'à épuisement.
S'il reste des actions non souscrites les droits préférentiels de souscription qui n'auront pas été repris deviendront
caducs.
3. A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le conseil d'administration dans le
cadre de l'autorisation précitée, l'article 5 des statuts sera modifié de manière à correspondre à cette augmentation; le
9692
conseil d'administration prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires afin d'obtenir la constatation et la publication
de cette modification conformément à la loi.
Art. 8. Assemblées des actionnaires - Généralités.
1. L'assemblée des actionnaires dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier
tous actes en rapport avec les opérations de la Société.
2. Les quorum et le délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires
de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.
3. Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une
autre personne comme son représentant par écrit, télécopie ou voie électronique.
4. Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront
adoptées à la majorité simple des présents et votants.
5. Le conseil d'administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer
à l'assemblée des actionnaires.
6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des actionnaires.
1. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit à
Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième lundi du mois de mai à 12.00 heures et pour la première
fois en 2009.
Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire
suivant.
2. Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de
convocation.
Art. 10. Conseil d'administration.
1. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins.
2. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale pour une période se terminant lors de l'assemblée annuelle
pour un maximum de six ans.
3. Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les adminis-
trateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions
attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 11. Procédures des réunions du conseil.
1. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs
vice-présidents.
2. Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
3. Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du
conseil d'administration. En son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité un
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.
4. Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins 2 jours avant
l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit, par télécopie ou
par voie électronique de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le
conseil d'administration.
5. Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par
télécopie ou voie électronique un autre administrateur comme son représentant. Des votes peuvent également être émis
par écrit, par télécopie ou par voie électronique, ou par téléphone pourvu que dans ce dernier cas ce vote soit confirmé
par écrit.
6. Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou re-
présentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
7. Les administrateurs agissant à l'unanimité par résolution circulaire peuvent exprimer leur accord en un ou plusieurs
instruments par écrit, par télécopie ou par voie électronique, qui ensemble constituent le procès-verbal de la prise de
cette décision.
Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil.
1. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou par l'administrateur
qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.
9693
2. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou
par deux administrateurs.
Art. 13. Pouvoirs du conseil.
1. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition
dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou par les présents
statuts sont de la compétence du conseil d'administration.
2. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la
représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires à chacun des membres du conseil d'administration qui
peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer
tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs,
nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs émoluments.
Art. 14. Signatures autorisées. La Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
les signatures conjointes ou la signature individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement
délégués par le conseil d'administration.
Art. 15. Commissaire.
1. Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire. Le commissaire est élu par l'assemblée générale
annuelle des actionnaires pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
2. Le premier commissaire est élu par l'assemblée générale qui suit immédiatement la constitution de la Société et
restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
3. Le commissaire peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.
Art. 16. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera
le 31 décembre de la même année. Toutefois le premier exercice commencera à la date de la constitution et prendra fin
le 31 décembre 2008.
Art. 17. Affectation des bénéfices.
1. L'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera disposé du bénéfice annuel net et des bénéfices
reportés.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués dans les conditions prévues par la loi sur décision du conseil
d'administration.
Art. 18. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un
ou de plusieurs liquidateurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, et qui seront nommés par l'assemblée
générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 19. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par
une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembour-
geoise.
Art. 20. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent
aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.
<i>Souscriptionsi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Souscripteur
Nombre Libération
d'actions
1) André Elvinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000
20.000
2) Jean Hoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000
20.000
3) Yves Prussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000
20.000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000
60.000
Ces actions ont toutes été libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire soussigné.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à deux mille Euro.
<i>Constatationsi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été observées.
9694
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Les personnes prémentionnées, représentant l'entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une
convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.
Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée
générale annuelle:
- Jean Hoss, avocat, demeurant à Luxembourg, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Yves Prussen, avocat, demeurant à Luxembourg, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Jacques Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommé commissaire: Pit Reckinger, avocat, demeurant à Luxembourg, 2 Place Winston Churchill.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social est fixé au n
o
5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.
Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2007. Relation: LAC/2007/41655. — Reçu 600 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): R. Jungers.
Pour copie conforme à l'original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2008.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2008007396/211/228.
(080002820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.
Sodwana Finance, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 133.751.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
K. Reuter
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008007343/7851/11.
(080002059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
Architect-Consult/ Zigrand Jean-Paul S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7210 Walferdange, 1, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 105.759.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Référence de publication: 2008007296/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2007, réf. DSO-CL00067. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080001872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
Intereuropean Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9053 Ettelbrück, 45, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 12.266.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
9695
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Référence de publication: 2008007297/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2007, réf. DSO-CL00065. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080001874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
Aquatrans Cargo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 118.275.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Référence de publication: 2008007301/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2007, réf. DSO-CL00090. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080001880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
Fenera Holding International S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 40.424.
Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FENERA HOLDING INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008007303/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, réf. LSO-CM00077. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080001820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.
Thomak Protect S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 34, rue Zénon Bernard.
R.C.S. Luxembourg B 75.994.
CLOTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 6 décembre 2007, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société suivante:
- THOMAK PROTECT s.à r.l. (B 75.994), ayant eu son siège social à L-4031 Esch-sur-Alzette, 34, rue Zénon Bernard,
de fait inconnue à cette adresse
Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
M
e
M. Ries
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2008007660/2630/19.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2007, réf. LSO-CL05316. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080002828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
9696
5 Square Churchill
Alpha Management Services (Luxembourg) S.A.
Angel S. à r.l.
Aquatrans Cargo S.A.
Aquatrans RhineShipping S.A.
Architect-Consult/ Zigrand Jean-Paul S.à r.l.
Batiferm S.A.
Bond Capital Partners (Luxembourg) S.A.
Cartom S.àr.l.
Catalyst Alpha 5 S.à r.l.
Cellamare S.A.
Fenera Holding International S.A.
Intereuropean Finance S.A.
LBREP III River S.à r.l.
Oakwood Global Finance S.C.A.
Parc Breidfeld sàrl
PATRIZIA Lux 30 N S.àr.l.
RP XXII S.à r.l.
RP XXI S.à r.l.
Schuch Immobilien S.A.
Silverside Shipping S.A.
Sodwana Finance
Thomak Protect S.à r.l.
Universum F.O. Soparfi S.A.
UT Luxembourg Holding II S.à r.l.
UT Luxembourg Holding I S.à r.l.
World Power Holdings Luxembourg S.à r.l.