This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2648
20 novembre 2007
SOMMAIRE
AELF Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
127066
Albaha Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127088
Athena Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127058
Calzedonia Finanziaria S.A. . . . . . . . . . . . . .
127068
Carolus Investment Corporation . . . . . . . .
127064
Cegyco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127104
Clearstream Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127101
Datagest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127099
Dexia Protected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127063
Digital Assets Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
127065
Dominos Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
127087
Flipo Participations S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
127102
Foncier & Participations S.A. . . . . . . . . . . . .
127102
Franklin Templeton Investment Funds . . .
127062
GELF Management (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . .
127066
GEM2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127059
Gemmy Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127061
George and Dragon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127088
Goodman European Logistics Fund . . . . . .
127068
Grands Magasins Porte Ouverte . . . . . . . . .
127103
Historia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127061
Hot Stuff S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127103
HVB Bonus Fonds DJ EURO STOXX®
12/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127065
Immobilière de la Ville Haute S.A. . . . . . . .
127103
Immobilière Espace Kirchberg A S.A. . . . .
127101
Immo Teb SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127065
Interas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127102
Internacional de Desarollos Portuarios
(I.D.P.) S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127093
Inventum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127099
IVG European Core+ Office . . . . . . . . . . . . .
127074
IVG European Core+ Office . . . . . . . . . . . . .
127085
Jetcom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127101
KBC Institutionals - I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127074
L.T.T. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127058
Lux-Avantage Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127060
Lux-Croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127062
Luxequip Bail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127100
Lux-Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127060
Lux-Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127059
Maga S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127103
Merc Finck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127092
Plena Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127092
Portfolio Selection Sicav . . . . . . . . . . . . . . . .
127069
Presta-Gaz S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127104
PVM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127086
Sichel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127102
Sifter Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127064
Solar Generation Holdings S.à r.l. . . . . . . .
127093
Spanimmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127064
Sports Group Development S.A. . . . . . . . .
127063
Sungard Availability Services (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127092
Tadler Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
127058
Tarlot Holding S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
127088
Tarlot Holding S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
127091
Tasaco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127100
Terravera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127086
Tower Automotive Holdings VII S.à r.l. . .
127088
Tower Automotive Holdings VII S.à r.l. . .
127091
Transbella Participation & Finance S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127104
Trief Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127073
Truth 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127087
X-Trem Bananas S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
127086
127057
L.T.T. Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 67.920.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 décembre 2007i> à 11.30 heures dans les bureaux de l'Etude Tabery & Wauthier, 10 rue Pierre
d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Demande de remboursement formulée par COMPANY MORASTO JALOP (CMJ) BV en liquidation des fonds
relatifs à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 décembre 2003 suite à son annulation et à l'ouverture de crédit
du 27 décembre 1999 suite à sa dénonciation;
2. Examen des conditions et modalités possibles pour procéder à ce remboursement; recours éventuel à un expert
pour déterminer la valeur des actifs de la société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007130586/322/17.
Tadler Investments S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 55.293.
La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 15 novembre 2007 à 11.00 heures n'ayant pu
délibérer sur les points de l'ordre du jour faute de quorum de présence, une nouvelle
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
se tiendra le jeudi <i>27 décembre 2007i> à 11.45 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Mise en liquidation de la société,
- Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill.
Cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire prendra les décisions quelle que soit la proportion de capital
représentée à l'Assemblée, les résolutions pour être valables devront réunir au moins deux tiers des voix des actionnaires
présents ou représentés.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007131286/755/19.
Athena Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 47.027.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>7 janvier 2008i> à 11.00 heures, en l'étude de M
e
Gérard Lecuit, 31, boulevard du Prince Henri, à L-1724
Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
Le quorum requis pour voter les points inscrits à l'ordre du jour lors de la première assemblée générale du 14 no-
vembre 2007 n'ayant pas été atteint, une seconde Assemblée est convoquée en date du 7 janvier 2008 et pourra délibérer
valablement quelle que soit la proportion du capital présent ou représenté sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 3 (deuxième paragraphe) des statuts et coordination de tous les articles, afin de soumettre
la ATHENA SICAV (à la partie I) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
2. Modification de l'article 5 (cinquième paragraphe) des statuts.
3. Modification de l'article 6 (quatrième paragraphe) des statuts.
127058
4. Modification de l'article 10 (premier paragraphe) des statuts.
5. Modification de l'article 19 des statuts.
6. Modification de l'article 25 des statuts.
7. Modification de l'article 26 (premier paragraphe) des statuts.
8. Modification de l'article 28 des statuts.
9. Modification de l'article 30 des statuts.
10. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007129891/660/26.
Lux-Garantie, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 55.646.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG à Luxembourg,
1, rue Zithe, le lundi <i>17 décembre 2007i> à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30
septembre 2007.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2007; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du réviseur d'entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée
Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets
d'un des agents payeurs ci-après:
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
FORTUNA BANQUE S.C.
Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont
autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007131894/755/30.
GEM2, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.859.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav GEM2 à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>12 décembre 2007i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
- Approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2007
- Affectation des résultats
- Quitus aux Administrateurs
- Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises
- Nominations statutaires.
127059
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007131896/755/22.
Lux-Avantage Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 46.041.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG à Luxembourg,
1, rue Zithe, le jeudi <i>20 décembre 2007i> à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30
septembre 2007.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2007; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée
Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets
d'un des agents payeurs ci-après:
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
FORTUNA BANQUE S.C.
Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont
autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007131897/755/30.
Lux-Equity, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 45.423.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG à Luxembourg,
1, rue Zithe, le jeudi <i>13 décembre 2007i> à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30
septembre 2007.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2007; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du réviseur d'entreprises.
6. Divers.
127060
Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée
Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets
d'un des agents payeurs ci-après:
Pour le Luxembourg:
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
Pour l'Allemagne:
DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main
Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont
autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Des formules de procuration sont disponibles au siège social de la Société.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>L e i>
<i>Conseil d'Administrationi> .
Référence de publication: 2007131899/755/33.
Gemmy Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 77.621.
Les actionnaires sont convoqués à une
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>24 décembre 2007i> à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
Une première assemblée générale a été tenue le 15 octobre 2007, les conditions de quorum de présence requises par
l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer valablement sur la disso-
lution de la société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée
pourra délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007131895/29/18.
Historia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 113.796.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>30 novembre 2007i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007126093/755/19.
127061
Lux-Croissance, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 38.527.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG à Luxembourg,
1, rue Zithe, le lundi <i>10 décembre 2007i> à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30
septembre 2007.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2007; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée
Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets
d'un des agents payeurs ci-après:
Pour le Luxembourg:
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
Pour l'Allemagne:
DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main
Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont
autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007131898/755/32.
Franklin Templeton Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 35.177.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders (the «Meeting») of FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (the «Company») will be held
at the registered office of the Company on <i>November 30, 2007i> at 2.30 p.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
- Presentation of the Report of the Board of Directors;
- Presentation of the Report of the Auditors;
- Approval of the Financial Statements of the Company for the accounting year ended June 30, 2007;
- Approval of the Remuneration of the Directors of the Company;
- Discharge of the Board of Directors;
- Reelection of the following twelve present Directors: The Honorable Nicholas F. Brady, The Honorable Trevor
Trefgarne, His Grace The Duke of Abercorn KG James Hamilton, The Right Reverend Michael A. Mann, Dr J.B.
Mark Mobius, Messrs Gregory E. Johnson, Mark G. Holowesko, Gregory E. McGowan, Richard Frank, Geoffrey A.
Langlands , David E. Smart and James Hung;
- Reelection of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as Auditors;
- Approval of the payment of dividends for the accounting year ended June 30, 2007;
- Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.
127062
<i>Votingi>
Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes
expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.
<i>Voting arrangementsi>
Holders of Registered Shares who cannot attend the Meeting may vote by proxy by returning the Form of Proxy sent
to them to the offices of FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A., 26, boulevard Royal, B.P. 169,
L-2011 Luxembourg, no later than November 23, 2007 at 5.00 p.m.
Holders of Bearer Shares who wish to attend the Meeting or vote at the Meeting by proxy should deposit their Share
certificates with J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves L-2633
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, no later than November 23, 2007 at 5.00 p.m. The Shares so deposited
will remain blocked until the day after the Meeting.
<i>Venue of the meetingi>
Shareholders are hereby advised that the Meeting may be held at such other place in Luxembourg than the registered
office of the Company if exceptional circumstances so require in the absolute and final judgment of the Chairman of the
Meeting. In such latter case, the Shareholders present at the registered office of the Company on November 30, 2007,
at 2.30 p.m., will be duly informed of the exact venue of the Meeting, which will then start at 3.30 p.m.
To attend the Meeting, Shareholders shall be present at the registered office of the Company at 1.30 p.m.
Please note that all references to time in this notice means Luxembourg time.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007126387/755/42.
Sports Group Development S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 59.579.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>29 novembre 2007i> à 11.30 heures à l'Etude de Maître Joëlle Baden avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport du Commissaire à la liquidation, la Fiduciaire Glacis,
- Décharge au Liquidateur et au Commissaire à la Liquidation,
- Clôture de la Liquidation,
- Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007125711/755/17.
Dexia Protected, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 84.728.
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires («l'Assemblée») de DEXIA PROTECTED aura lieu au siège social de la société le <i>28 novembre 2007i>
à 14.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et acceptation des rapports suivants:
a) rapport annuel du Conseil d'Administration
b) rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des changements des actifs nets pour l'exercice 2006/2007,
3. Affectation des résultats,
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice 2006/2007,
5. Election du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises pour l'exercice 2007/2008,
6. Divers.
127063
Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les
décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de
s'inscrire jusqu'au 20 novembre 2007 auprès de DEXIA PROTECTED, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, à l'attention
de Isabelle Belmon (Fax N° +352 / 2460-3331).
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007128056/755/24.
Spanimmo, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 28.692.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra vendredi, le <i>30 novembre 2007i> à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2007.
3. Affectation des résultats au 30 septembre 2007.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Démission de Madame Monique Juncker de son mandat d'administrateur et décharge.
6. Nomination de Monsieur Sinan Sar, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
le 5 juin 1980, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007127710/29/20.
Carolus Investment Corporation, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 16.100.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le mardi <i>27 novembre 2007i> à 15.10 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert de siège.
2. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007128621/1267/13.
Sifter Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 93.438.
The Shareholders are hereby invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office on <i>November 28th, 2007i> at 3.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors,
2. Approval of the annual accounts as at August 31, 2007 and allocation of the results,
3. Discharge to be granted to the Directors,
4. Statutory appointments,
127064
5. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the
registered office of the SICAV.
In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at least on November 26th, 2007
with KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007128057/755/20.
Immo Teb SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 107.011.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social en date du <i>29 novembre 2007i> à 16.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2007 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 30 juin 2007.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007128618/1004/18.
Digital Assets Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 89.977.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le mardi <i>27 novembre 2007i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert de siège.
2. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007128622/1267/13.
HVB Bonus Fonds DJ EURO STOXX® 12/2013, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement sowie das Sonderreglement des Fonds HVB BONUS FONDS DJ EURO STOXX® 12/2013,
in Kraft getreten am 1. Oktober 2007, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg-Stadt hinterlegt.
Hinsweis zur Bekanntmachung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 1. Oktober 2007.
HVB STRUCTURED INVEST S.A.
S. Lieser / S. Mayers
Référence de publication: 2007122064/755/13.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007, réf. LSO-CJ03202. - Reçu 56 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070137739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.
127065
GELF Management (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. AELF Management S.à r.l.).
Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.
R.C.S. Luxembourg B 121.702.
In the year two thousand and seven, the eleventh of October.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
GOODMAN EUROPE (AUST) PTY LIMITED, a company with registered address at Level 10, 60 Castlereagh Street,
Sydney NSW 2000, Australia,
hereby represented by Mr Craig Williamson, employee, with professional address at 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg,
by virtue of one proxy given under private seal dated 10th October 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the party appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities
Such appearing party is the sole partner of AELF MANAGEMENT S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée) with registered office at 8, rue Heine, L-1720, Luxembourg, registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register under the number B 121.702 (the Company). The Company has been
incorporated pursuant to a notarial deed on 20 November 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 2264 of December 4, 2006.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from AELF MANAGEMENT S.à r.l. to GELF
MANAGEMENT (LUX) S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the articles of association, which shall read henceforth as follows:
« Art. 1. There exists hereby formed by the present and all persons and entities who may become Shareholders in
future a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of GELF MANAGEMENT (LUX) S.à
r.l. (hereinafter referred to as the «Management Company»).»
Follows the German translation of this article:
«Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen GELF MANAGEMENT (LUX) S.à r.l.
(nachstehend «Verwaltungsgesellschaft» genannt) gegründet.»
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Daniel Peeters, residing at Looiweg 163, B-2310 Rijkevorsel, Belgium, as
Manager of the Company with immediate effect and for an unlimited duration.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Michael O'Sullivan, residing at Greenlawns, 21 Broad Highway, Cobham,
Surrey KT11 2RR, United Kingdom, as Manager of the Company with immediate effect and for an unlimited duration.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder resolves to remove Mr Jeffrey Pulsford as Manager of the Company with immediate effect and
gives him full and complete discharge.
<i>Sixth resolutioni>
The sole shareholder resolves to remove Mr Robert Wilkinson as Manager of the Company with immediate effect
and gives him full and complete discharge.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le onze octobre.
127066
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
GOODMAN EUROPE (AUST) PTY LIMITED, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au Level 10, 60
Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australie,
représentée par Monsieur Craig Williamson, employé privé, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720
Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 10 octobre 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle partie comparante est l'associée unique de AELF MANAGEMENT S.à r.I., une société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois avec siège social au 8, rue Heine, L-1720, Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.702, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 20 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2264 du 4 décembre 2006.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de AELF MANAGEMENT S.à r.I. en GELF MANAGE-
MENT (LUX) S.à r.I.
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 1
er
des Statuts afin de refléter ce changement de dénomination sociale,
de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GELF MANAGEMENT (LUX) S.à
r.I. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915
relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société
(ci-après les «Statuts»).»
Suit la traduction allemande de cet article.
«Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen GELF MANAGEMENT (LUX) S.à r.I.
(nachstehend «Verwaltungsgesellschaft» genannt) gegründet.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Daniel Peeters, employé privé, demeurant Looiweg 163, B-2310 Rij-
kevorsel, Belgique, comme gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Michael O'Sullivan, employé privé, demeurant Greenlawns, 21 Broad
Highway, Cobham, Surrey KT11 2RR, Royaume Uni, comme gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter la démission de Monsieur Jeffrey Pulsford comme gérant de la Société avec effet
immédiat et lui accorde pleine et entière décharge.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter la démission de Monsieur Robert Wilkinson comme gérant de la Société avec effet
immédiat et lui accorde pleine et entière décharge.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Williamson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 15 octobre 2007. Relation: EAC/2007/12576. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
127067
Luxembourg, le 19 octobre 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007126288/239/108.
(070145979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2007.
Goodman European Logistics Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Le règlement de gestion du fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé, GOODMAN EUROPEAN
LOGISTICS FUND a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2007.
<i>Pour GELF MANAGEMENT (LUX) S.à r.l.
Société de Gestioi> <i>n
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007129273/1092/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ07794. - Reçu 172 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070148239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2007.
Calzedonia Finanziaria S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 80.171.
L'an deux mille sept, le seize octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
I.- Monsieur Régis Donati, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beau-
mont,
agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme CALZEDONIA FINANZIARIA S.A.,
ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 80.171, issue de
la scission de la société anonyme CALZEDONIA LUXEMBOURG S.A. suivant acte de scission reçu par le notaire ins-
trumentant en date du 12 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 678 du 27 août 2001, et dont les statuts ont
été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 834 du 1
er
juin 2002;
- en date du 27 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 295 du 13 mars 2004;
- en date du 18 janvier 2005, publié au Mémorial C numéro 609 du 24 juin 2005;
- en date du 13 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 526 du 4 avril 2007,
en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 20 août 2007;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion est resté annexé au projet de fusion ci-après mentionné.
II.- Monsieur Lorenzo Gianello, juriste, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme T.F.E. S.A., ayant son siège social à
L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 116.398, constituée suivant acte reçu par
Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 21 avril 2006, publié au Mémorial C numéro 1414
du 22 juillet 2006, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Paul Bettingen en date du
25 juillet 2006, publié au Mémorial C numéro 2044 du 31 octobre 2006,
avec un capital social de un million cinq cent cinquante et un mille euros (1.551.000,- EUR), représenté par quinze mille
cinq cent dix (15.510) actions avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune,
en vertu d'un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 20 août 2007;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion est resté annexé au projet de fusion ci-après mentionné.
Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'acter:
I.- Qu'en application des articles 278 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales, la société anonyme CALZE-
DONIA FINANZIARIA S.A. prédésignée, a fusionné avec la société anonyme T.F.E. S.A., prédésignée, par absorption de
cette dernière conformément au projet de fusion passé par acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, en remplacement du notaire instrumentant en date du 28 août 2007, et publié au Mémorial C numéro 1980
du 14 septembre 2007.
127068
II.- Que cette fusion a été réalisée suivant les prescriptions de l'article 279 de la loi susvantée et qu'aucune assemblée
générale d'approbation n'est nécessaire, aucun actionnaire des sociétés concernées n'ayant requis de convocation d'as-
semblée et la fusion s'opérant de plein droit par l'écoulement du délai d'un mois à dater de la publication au Mémorial
du projet de fusion.
III.- Que par conséquent, la fusion de trouve réalisée, entraînant de plein droit et simultanément les effets visés à
l'article 274, notamment la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard
des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante et la dissolution de la
société absorbée T.F.E. S.A..
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations du présent acte s'élève approximativement à huit cent cinquante
euros.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Donati, R. Gianello, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2007, Relation: GRE/2007/4748. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 novembre 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007127868/231/57.
(070152913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.
Portfolio Selection Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 56.144.
Im Jahre zweitausendsieben, den dritten September.
Vor der unterzeichnenden Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Luxemburg, in Vertretung ihres verhin-
derten Kollegen Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), in dessen
Besitz und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt,
sind die Aktionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital PORTFOLIO SELECTION SICAV (die «Gesell-
schaft») mit Sitz in Luxemburg und eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 56.144 zu einer
außerordentlichen Hauptversammlung erschienen. Die Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde vom 9. September
1996 gegründet, welche am 30. September 1996 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial»),
veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt durch notarielle Urkunde vom 4. November 2003,
veröffentlicht im Mémorial am 28. November 2003 geändert.
Die Versammlung wird um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Céline Parmentier, Angestellte, beruflich wohnhaft
in Luxemburg, eröffnet.
Die Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Antoinette Farese, Angestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Christelle Vaudémont, Angestellte, beruflich wohnhaft in
Luxemburg.
Die Vorsitzende ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:
I. Die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Erweiterung des Gesellschaftszwecks und entsprechende Neufassung von Artikel 4 der Satzung wie folgt:
« Art. 4. Gesellschaftsziel. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in
Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem
Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und Aus-
führung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz vom
20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (hiernach «Gesetz vom 20. Dezember 2002»).»
2. Erweiterung der Möglichkeiten in Hinblick auf verschiedene Aktienkategorien und entsprechende Änderung der
Artikel 5 und 11 der Satzung.
3. Einführung der Möglichkeit, Zertifikate für Inhaberaktien auszugeben und entsprechende Änderung von Artikel 6
der Satzung.
4. Erweiterung der Bewertungsregeln und entsprechende Änderung von Artikel 11 der Satzung.
127069
5. Änderung des Zeitpunkts der jährlichen Hauptversammlung und entsprechende Änderung von Artikel 22 der Sa-
tzung.
6. Anpassung an durch das Gesetz vom 25. August 2006 geänderte gesetzliche Vorschriften und entsprechende Än-
derung der Artikel 14 und 22 der Satzung.
7. Redaktionelle Änderungen der Satzung.
8. Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes.
9. Verschiedenes.
II. Die persönlich anwesenden Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter sowie die jeweilige Anzahl der Aktien
gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären oder deren bevollmächtigten Vertre-
tern und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die von den bevollmächtigten
Vertretern und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichneten Vollmachten bleiben vorliegender Urkunde beigefügt,
um mit ihr zusammen registriert zu werden.
III. Die Einladung zu dieser außerordentlichen Hauptversammlung wurde am 4. August 2007 sowie am 17. August 2007
im Mémorial, in den Tageszeitungen «Luxemburger Wort» und im «Tageblatt» veröffentlicht.
VI. Aus der Anwesenheitsliste und dem Auszug aus dem Aktienregister geht hervor, dass von den 1.188.745,11 (eine
Million einhundertachtundachtzigtausend siebenhundertfünfundvierzig Komma elf) Aktien, die das gesamte Kapital der
Gesellschaft repräsentieren, 32.063,369 (zweiunddreissigtausenddreiundsechzig Komma dreihundertneunundsechzig)
Aktien in dieser Hauptversammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten sind.
V. Die Vorsitzende teilt der Hauptversammlung mit, dass eine erste außerordentliche Hauptversammlung für den 30.
Juli 2007 einberufen worden war, und dass diese Hauptversammlung nicht beschlussfähig war, da die notwendige Anwe-
senheitsquote nicht erreicht war.
Gegenwärtige Hauptversammlung ist daher gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften unab-
hängig von der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Aktionäre beschlussfähig.
Nach Beratung fasst die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, den Gesellschaftszweck zu erweitern und dementsprechend den Wortlaut von
Artikel 4 der Satzung neu wie folgt zu fassen:
« Art. 4. Gesellschaftsziel. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in
Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem
Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und Aus-
führung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz vom
20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (hiernach «Gesetz vom 20. Dezember 2002»).»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, die Möglichkeiten in Hinblick auf verschiedene Aktienkategorien zu erweitern und
dementsprechend Artikel 5 sowie Artikel 11 Nr. IV der Satzung zu ändern.
Artikel 5 Absatz 4 lautet Künftig wie folgt:
«Zusätzlich können durch Beschluss des Verwaltungsrates verschiedene Aktienkategorien innerhalb eines Teilfonds
definiert werden, um
(i) einer bestimmten Ausschüttungspolitik, die nach Berechtigung oder Nichtberechtigung zur Ausschüttung unter-
scheidet und/oder
(ii) einer bestimmten Gestaltung von Verkaufs- und Rücknahmeprovision und/oder
(iii) einer bestimmten Gebührenstruktur im Hinblick auf die Verwaltung oder Anlageberatung und/oder
(iv) einer bestimmten Zuordnung von Dienstleistungsgebühren für die Ausschüttung, Dienstleistungen für Aktionäre
oder sonstiger Gebühren und/oder
(v) unterschiedlichen Währungen oder Währungseinheiten, auf welche die jeweilige Aktienklasse lauten soll und welche
unter Bezugnahme auf den Wechselkurs im Verhältnis zur Fondswährung des jeweiligen Teilfonds gerechnet werden,
und/oder
(vi) der Verwendung unterschiedlicher Sicherungstechniken, um Vermögenswerte und Erträge, welche auf die Wäh-
rung der jeweiligen Aktienklasse lauten, gegen langfristige Schwankungen gegenüber der Fondswährung des jeweiligen
Teilfonds abzusichern und/oder
(vii) sonstigen Charakteristika, wie sie von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat im Einklang mit den gesetzlichen Bestim-
mungen festgelegt werden,
(die «Aktienkategorien»), ausgegeben werden.»
Artikel 11 Nr. IV Absatz 1 lautet Künftig wie folgt:
127070
«IV. Falls Aktienkategorien in einer Aktienklasse ausgegeben werden, wird der Nettovermögenswert pro Aktie der
betreffenden Aktienklasse gerechnet, indem der Nettovermögenswert, der jeder Aktienkategorie zuzurechnen ist, durch
die Gesamtheit der sich in Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Aktienkategorie geteilt.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, dass künftig Zertifikate für Inhaberaktien ausgegeben werden können, und de-
mentsprechend Artikel 6 der Satzung zu ändern.
Der erste Absatz von Artikel 6 lautet künftig wie folgt:
«Der Verwaltungsrat legt fest, ob die Gesellschaft Aktien als Inhaberaktien und / oder als Namensaktien ausgibt. Falls
der Verwaltungsrat entschieden hat, Zertifikate für Namensaktien auszugeben und ein Aktionär nicht ausdrücklich Zer-
tifikate zu erhalten wünscht, kann ihm anstelle dieser Zertifikate eine Bestätigung seines Aktieneigentums ausgehändigt
werden. Im Falle einer Ausgabe von Inhaberaktienzertifikaten werden diese in der vom Verwaltungsrat vorgeschriebenen
Stückelung ausgestellt.»
Artikel 6 Absatz 7 letzter Satz lautet künftig wie folgt:
«Im Falle von Inhaberaktien werden nur Zertifikate für ganze Aktien ausgegeben.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, die Bewertungsregeln zu erweitern und dementsprechend Artikel 11 der Satzung
zu ändern.
In Artikel 11 Nr. I., bei den Bewertungsregeln, wird ein neuer Punkt 5) eingefügt, welcher wie folgt lautet:
«5) Anteile oder Aktien von Zielfonds werden zum letzten verfügbaren Rücknahmepreis bewertet.»
Der bisherige Punkt 5) wird zu Punkt 6).
Hinter Punkt 6) wird Punkt 7) neu eingeführt, der wie folgt lautet:
«7.) Wertpapiere und Derivate, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber aktiv im geregelten Freiverkehr oder
an einem anderen organisierten Wertpapiermarkt gehandelt werden, insbesondere alle OTC-Kontrakte wie z.B. Con-
tracts of Differences, Zins-, Währungs-, Total Return-, Credit Default Swaps, Kreditderivate im allgemeinen, Optionen
und Forwards werden zu dem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur
Zeit der Bewertung sein darf und den der Verwaltungsrat für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere
verkauft oder gekauft werden können.»
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, dass die jährliche Hauptversammlung künftig am dritten Freitag des Monats Februar
stattfindet, und dementsprechend Artikel 22 der Satzung zu ändern.
Der vierte Absatz von Artikel 22 lautet künftig wie folgt:
«Die jährliche Hauptversammlung tritt entsprechend luxemburgischem Recht in der Stadt Luxemburg an einem Ort,
der in der Versammlungsmitteilung angegeben wird, am dritten Freitag des Monats Februar um 11.00 Uhr zusammen.»
<i>Sechster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, die Satzung an die durch das Gesetz vom 25. August 2006 geänderten gesetzliche
Vorschriften anzupassen und dementsprechend Artikel 14 und 22 der Satzung zu ändern.
Artikel 22 Absatz 3 lautet künftig wie folgt:
«Eine Hauptversammlung kann auch auf Anfrage von Aktionären, die mindestens ein Zehntel des gesamten ausste-
henden Aktienkapitals darstellen, einberufen werden.»
Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 lautet künftig wie folgt:
«Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden sowie mehrere stellvertretende Vorsitzende
wählen.»
<i>Siebter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt die folgenden redaktionellen Änderungen in der gesamten Satzung:
In den Artikelüberschriften fällt künftig der abschließende Punkt weg.
Vor einem Doppelpunkt sowie vor einem Semikolon fällt künftig die Leerstelle weg.
Die Hauptversammlung beschließt weitere geringe redaktionelle Änderungen in den Artikeln 1, 10, 11, 13, 14, 19 und
23:
Artikel 1 lautet künftig wie folgt:
«Zwischen den Zeichnern und allen zukünftigen Aktionären besteht eine Aktiengesellschaft («société anonyme») in
Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital («société d'investissement à capital variable») unter der Be-
zeichnung PORTFOLIO SELECTION Sicav (nachfolgend die «Gesellschaft»).»
Artikel 10 Nr. 3 (a) Satz 1 lautet künftig wie folgt:
«die Gesellschaft stellt dem Aktieninhaber, der solche Aktien besitzt, eine Anzeige zu (die «Rückkaufanzeige») unter
Angabe der Anzahl der zurückzukaufenden Aktien, des dafür zu zahlenden Preises (der «Rückkaufpreis») und des Rück-
127071
zahlungsortes. Diese Rückkaufanzeige kann dem Aktieninhaber mittels eines frankierten Einschreibebriefs an die letztbe-
kannte oder in den Büchern der Gesellschaft eingetragene Adresse des Aktieninhabers zugeschickt werden.»
Artikel 11 Nr. I. 3) lautet künftig wie folgt:
«3) sämtliche Finanzinstrumente, Obligationen, Terminforderungen, Depositenzertifikate, Zeichnungsrechte, Optio-
nen, Wertpapiere und ähnliche Aktiva, die der Gesellschaft zustehen;»
Artikel 11 Nr. I. 5) lautet künftig wie folgt:
«5) sämtliche aufgelaufenen Zinsen auf alle verzinslichen Aktiva im Besitz der Gesellschaft, außer in dem Maße, wie
diese Zinsen bereits im Kapitalbetrag des Aktivpostens enthalten sind;»
In Artikel 11 Nr. I., bei den Bewertungsregeln, lautet Punkt 2) Satz 3 künftig wie folgt:
«Sollte die Liquidation eines Kontraktes an einem Bewertungstag nicht möglich sein, so wird eine Bewertung heran-
gezogen, die der Verwaltungsrat als fair und angemessen erachtet.»
Artikel 13 Absatz 3 lautet künftig wie folgt:
«Im Falle eines freigewordenen Verwaltungsratsmitgliedpostens können die übrigen Verwaltungsratsmitglieder diese
Stelle vorübergehend neu besetzen; die Aktieninhaber fassen auf ihrer nächsten Versammlung einen Beschluss über die
definitive Bestellung dieses freigewordenen Verwaltungsratsmitgliedpostens.»
Artikel 14 Absatz 4 lautet künftig wie folgt:
«Alle Verwaltungsratsmitglieder müssen spätestens vierundzwanzig Stunden vor dem für das Zusammentreten der
Versammlung anberaumten Zeitpunkt schriftlich benachrichtigt werden, außer in Notfällen, wobei die Umstände des
jeweiligen Notfalls in der Versammlungsmitteilung angegeben werden müssen. Auf eine solche Benachrichtigung kann
durch eine schriftliche Mitteilung oder eine per Telegramm, Telefax oder ein ähnliches Kommunikationsmittel übermit-
telte Mitteilung verzichtet werden. Für Versammlungen, die zu einem Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden,
der in einem vom Verwaltungsrat gefassten Beschluss festgelegt worden ist, ist keine getrennte Benachrichtigung erfor-
derlich.»
Artikel 14 Absatz 5 lautet künftig wie folgt:
«Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei einer Versammlung vertreten lassen, indem es schriftlich, per Telegramm,
Telefax oder mit Hilfe eines ähnlichen Kommunikationsmittels ein anderes Verwaltungsratsmitglied zu seinem Stellver-
treter ernennt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten. »
Artikel 14 letzter Absatz lautet künftig wie folgt:
«Schriftliche Beschlüsse, die die Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder finden und von ihnen unterzeichnet wer-
den, haben dieselbe Kraft wie Beschlussfassungen bei Verwaltungsratssitzungen; jedes Verwaltungsratsmitglied muss
einem solchen Beschluss schriftlich, per Telegramm, Telefax oder mit Hilfe eines anderen ähnlichen Kommunikations-
mittels zustimmen. Eine solche Zustimmung wird schriftlich bestätigt und die Gesamtheit dieser Unterlagen dienen als
Beleg dafür, dass dieser Beschluss gefasst wurde.»
Artikel 19 Absatz 3 lautet künftig wie folgt:
«Der Begriff «zuwiderlaufenden Interesse», wie er im vorstehenden Absatz verwendet wird, findet keine Anwendung
auf jedwede Beziehung und jedwedes Interesse, die zwischen der Gesellschaft einerseits und dem Anlageberater, der
Depotbank oder anderen von der Gesellschaft benannten Personen, Gesellschaften oder Körperschaften, andererseits
bestehen.»
Artikel 23 Absatz 1 lautet künftig wie folgt:
«Jede Aktie irgendeines Teilfonds ist in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht und dieser Satzung zu einer
Stimme berechtigt. Ein Aktieninhaber kann bei einer Aktionärsversammlung entweder persönlich auftreten oder einer
anderen Person, die kein Aktionär der Gesellschaft sein muss, eine schriftliche Vollmacht oder eine Vollmacht über
Telegramm oder Telefax geben.»
<i>Achter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt Herrn Lucien Euler als Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, um Herrn Antoine
Gilson de Rouvreux zu ersetzen, der am 16. Februar 2007 sein Amt als Verwaltungsratsmitglied niedergelegt hat.
Da die Tagesordnung erschöpft ist und kein Aktionär weiter das Wort ergreift, wird die Hauptversammlung um 11.30
Uhr geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Stadt, am Sitz der Gesellschaft, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen - dem Notar den Namen, Vornamen, sowie
Stand und Wohnort nach bekannt - haben dieselben mit dem Notar gemeinsam die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Parmentier, A. Farese, C. Vaudémont, M. Schaeffer.
Einregistriert in Esch an der Alzette, am 6. September 2007, Relation: EAC/2007/10631. — Erhalten 12 Euro.
<i>Der Einnehmer ff.i> (gezeichnet): Oehmen.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und
Vereinigungen.
127072
Beles, den 21. September 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007131237/239/204.
(070153545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Trief Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 50.162.
PROJET DE FUSION
entre:
TRUTH 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2,
rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 131.259 (la
«Société Absorbée»),
et
TRIEF CORPORATION S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue
Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
50.612 (la «Société Absorbante», ensemble avec la Société Absorbée, les «Sociétés Fusionnantes»).
1. Les Sociétés Fusionnantes ont l'intention de réaliser le ou vers le 21 décembre 2007 la fusion entre la Société
Absorbante et la Société Absorbée conformément aux dispositions des articles 261 à 276 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).
2. Les détenteurs de parts sociales dans la Société Absorbée recevront en échange de leurs parts sociales un nombre
d'actions dans la Société Absorbante égal au nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société Absorbée multiplié
par la parité de conversion. Sur base des chiffres actuellement disponibles, la parité de conversion correspondra à une
(1) action de la Société Absorbante en échange de vingt-sept mille trois cent vingt-neuf (27.329) parts sociales de la Société
Absorbée. Dans le cas où la parité de conversion des actions aurait pour conséquence l'apparition de rompus, les dé-
tenteurs de parts sociales dans la Société Absorbée recevront une soulte en espèces.
3. Les droits attachés aux nouvelles actions émises par la Société Absorbante aux associés de la Société Absorbée
seront à tous égards identiques aux droits attachés aux actions de la Société Absorbante, notamment en ce qui concerne
les droits aux dividendes.
4. Les détenteurs des parts sociales de la Société Absorbée seront retirés du registre des associés de la Société
Absorbée et inscrits dans le registre des actionnaires de la Société Absorbante pour le nombre d'actions qu'ils recevront
à la date d'entrée en vigueur de la fusion.
5. Il n'existe aucun actionnaire ayant des droits spéciaux ou des détenteurs de sûretés autres que des actions, auxquels
la Société Absorbante entend conférer des droits spéciaux et aucun avantage ne sera accordé aux reviseurs indépendants
en charge d'établir les rapports de fusion, aux membres du conseil d'administration ou membre du conseil de gérance
ou aux auditeurs statutaires des Sociétés Fusionnantes.
6. Conformément à l'Article 263 de la Loi de 1915, la fusion sera approuvée par les assemblées générales de chacune
des Sociétés Fusionnantes et, le cas échéant, par les porteurs de titres autres que des actions.
7. La fusion entrera en vigueur et aura les effets prévus par l'article 274 de la Loi de 1915 une fois qu'elle aura été
approuvée par les assemblées générales des actionnaires de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.
8. Le 23 octobre 2007 est à considérer comme la date de départ pour l'accomplissement par la Société Absorbante
des opérations de comptabilité de la Société Absorbée. A partir de cette date, les nouvelles actions participeront aux
résultats de la Société Absorbante. La fusion doit être neutre fiscalement et comptablement.
9. Sur la base des développements décrits ci-dessus et en raison du fait que les chiffres et parités stipulés dans ce projet
de fusion ne peuvent être évalués que de façon approximative à ce jour, le conseil de gérance de la Société Absorbée et
le conseil d'administration de la Société Absorbante sont à tout moment autorisés à procéder à des ajustements, le cas
échéant, en ce qui concerne les valeurs et hypothèses considérées dans ce projet de fusion et soumettre les chiffres et
parités révisés à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ou associés.
10. Le livre de comptes et les documents de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société
Absorbante aussi longtemps que prescrit par la loi luxembourgeoise.
<i>TRIEF CORPORATION S.A.
i>J.-Y. Hémery
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2007131727/250/54.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04350. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070157405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.
127073
KBC Institutionals - I, Fonds Commun de Placement.
The amendment to the management regulations of KBC INSTITUTIONALS I, was deposited with the Registre de
Commerce et des Sociétés of Luxembourg.
For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 7 November 2007.
KBC ASSET MANAGEMENT S.A.
L'acte modificatif au règlement de gestion de KBC INSTITUTIONNALS I, a été déposé au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2007.
KBC ASSET MANAGEMENT S.A.
Référence de publication: 2007129274/526/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK01756. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070153795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
IVG European Core+ Office, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 117.225.
In the year two thousand and seven, on the nineteenth day of October.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of IVG EUROPEAN CORE+OFFICE, Société d'inves-
tissement à capital variable - Fonds d'investissement spécialisé (the «Fund»), organised as a société anonyme, having its
registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg under number B 117.225 and incorporated pursuant to a deed dated
20 June 2006 drawn up by the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Number 1319 on 7 July 2006, whose articles of incorporation were changed pursuant to a deed dated 13 October 2006
drawn up by the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 2045
on 31 October 2006.
The meeting elects Mr Jacques Schroeder, lawyer, residing in Luxembourg, as chairman.
The chairman designates as secretary Mr Pierre-Alexandre Delagardelle, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Jean-Claude Michels, lawyer, residing in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the
proxies signed ne varietur will be registered with this deed.
II. It appears from the attendance list, that thirty one (31) shares of no par value each representing the entirety of the
share capital of the Company are represented in this extraordinary general meeting.
III. All the shareholders respectively their proxy holders declare having been informed in advance on the agenda of
the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can
validly deliberate and decide on the afore cited agenda of the meeting.
IV. The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of the definitions of the terms «Fund», «Initial Price», «Institutional Investor», «Investment Advisory
Committee», «NAV», «Net Asset Value par Share», «Prohibited Person», «Share, «Subsidiary», addition of the definitions
of the terms «Law of 13 February 2007» and «Regulated Market» and deletion of the definition of the term «Law of 19
July 1991».
2. Amendment of Article 1 of the Fund's articles of incorporation in order to reflect the Fund's status as «fonds
d'investissement specialisé».
3. Amendment of Article 3 of the Fund's articles of incorporation in order to extend the Fund's term and to detail the
requirements for the anticipated termination or extension of term.
4. Amendment of Article 4, last paragraph of the Fund's articles of incorporation in order to give it the following
wording:
«The Fund may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and
development of its purpose to the largest extent permitted under the Law of 13 February 2007.»
127074
5. Amendment of Article 5, last paragraph of the Fund's articles of incorporation in order to adapt it the rules set forth
by the Law of 13. February 2007.
6. Amendment of Article 6, section (1) second paragraph of the Fund's articles of incorporation in order to insert a
reference to Share Classes.
7. Amendment of Article 7 first sentence and Article 10, section (2) paragraph (i) of the Fund's articles of incorporation
in order to make minor adaptations of purely formal nature.
8. Amendment of Article 11 section (2), paragraphs 2 and 3 of the Fund's articles of incorporation in order to replace
the references to the «promoter» by references to the «initiator».
9. Amendment of Article 13 of the Fund's articles of incorporation in order to change the maximum term of the
Directors to three years and to make purely formal adaptations.
10. Amendment of Article 14 of the Fund's articles of incorporation in order to adapt it to the new wording of the
Law of 10 August 1915 and to make purely formal adaptations.
11. Amendment of Article 20, sixth paragraph of the Fund's articles of incorporation in order to adapt the voting
powers of the Investment Advisory Committee Representatives to one vote per 10,000.- Euro of Commitments.
12. Amendment of the four last paragraphs of Article 21 of the Fund's articles of incorporation in order to replace
the references to the «promoter» by references to the «initiator» respectively to adapt them to the new wording of the
Law of 10 August 1915.
13. Amendment of Article 22 of the Fund's articles of incorporation in order to replace the references to the «pro-
moter» by references to the «initiator».
14. Amendment of Article 23, second paragraph, Article 28, second paragraph, Article 29, second paragraph and Article
34 of the Fund's articles of incorporation in order to replace the references to the Law of 19 July 1991 by references to
the law of 13 February 2007.
15. Amendment of Article 25, second paragraph of the Fund's articles of incorporation in order to change the date of
the Fund's annual General Meeting to 9 November.
16. Amendment of Article 30, second hyphen of the Fund's articles of incorporation in order to replace the reference
to the «promoter» by a reference to the «initiator».
17. Amendment of Article 31, first paragraph of the Fund's articles of incorporation in order to extend the Fund's
term.
18. Decision to hold the Fund's first annual General Meeting in 2007.
19. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously by the general meeting of the shareholders of
the Fund:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to amend the definitions of the terms «Fund», «Initial Price», «Institutional Investor», «Investment
Advisory Committee», «NAV», «Net Asset Value», «Prohibited Person», «Share» and «Subsidiary», to add definitions of
the terms «Law of 13 February 2007» and «Regulated Market» and to delete the definition of the term «Law of 19 July
1991». The new respectively the amended definitions shall read as follows:
«Fund» IVG EUROPEAN CORE+ OFFICE, société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé
«Initial Price» the price at which the Shares are issued during the Initial Offering Period, as described in more details
in the Prospectus
«Institutional Investor» an institutional investor within the meaning of article 10 of these Articles of Incorporation and
Section 3.5 of the Prospectus.
«Investment Advisory Committee» the committee to assist the Board, which will consist of representatives of selected
Investors of the Fund, formally appointed by the Board in accordance with the provisions set out herein and in the
prospectus
«Law of 13 February 2007» the Luxembourg law of 13 February 2007 on specialised investment funds, as amended
from time to time
«Net Asset Value per Share or «NAV» per Share» the net asset value par Share of each Class, as determined by the
Fund's Central Administration
«Net Asset Value» or «NAV» the net asset value of the Fund as determined in accordance with article 11 of these
Articles of Incorporation and section 17.1 of the Prospectus
«Prohibited Person» any person, firm, partnership or corporate body, if in the sole opinion of the Fund such person's
holding of Shares may be detrimental to the interests of the existing Shareholders or of the Fund, or if it may result in a
breach of any law or regulation, whether Luxembourg or otherwise, or if as a result thereof the Fund may become
exposed to tax disadvantages, fines or penalties that it would not have otherwise incurred. The term «Prohibited Person»
is also including any entity which is not exempt from French 3% tax arising under article 990D of the French Tax Code
(as amended from time to time) (the French 3% Tax) and the annual tax of 3% calculated on a property value determined
127075
by the Greek tax authorities (the «Greek 3% Tax»); as a result of which the Fund or any Investment Structure or entity
in the Fund structure may be liable to pay any French or Greek 3% Tax as a result of ownership of Shares by this entity
and there are no reasonably satisfactory alternative arrangements for the payment of such French or Greek 3% Tax by
the relevant non-exempt Shareholder. The term «Prohibited Person» includes any investor which does not meet the
definition of Institutional Investor, natural persons and entities in which one or several natural person(s) hold an interest,
unless such entity qualifies as a corporation from a German tax perspective and any U.S. Person
«Regulated Market» a market operating regularly, regulated, recognised and open to the public
«Shares» the shares in the capital of the Fund
«Subsidiary» a company a majority of more than 75% of the share capital is held, directly or indirectly, by the Fund as
further detailed in section 4.1 of the Prospectus
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 1 of the Fund's articles of incorporation in order to give it the following wording:
« Art. 1. Name. There exists among the subscribers and all those who may become owners of Shares hereafter issued,
a public limited company («société anonyme») qualifying as an investment company with variable share capital - specialized
investment fund («société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé») under the name of IVG
EUROPEAN CORE+ OFFICE.»
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 3 of the Fund's articles of incorporation in order to give it the following wording:
« Art. 3. Duration. The Fund is incorporated for a limited period and will terminate on 30 September 2021.
However, the Board may propose to the General Meeting to terminate the Fund at any date after 30 September 2019.
Moreover, the Board may propose to the General Meeting to extend the term of the Fund or to change the Fund's
Articles of Incorporation in order to provide for an undetermined duration in the event of a contemplated exit by public
offering of the Shares. Any anticipated termination or extension request by the Board requires the approval of the General
Meeting of Shareholders deliberating in the manner required for amending the Articles of Incorporation.»
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 4, last paragraph of the Fund's articles of incorporation in order to give it the
following wording:
«The Fund may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and
development of its purpose to the largest extent permitted under the Law of 13 February 2007.»
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 5, last paragraph of the Fund's articles of incorporation in order to give it the
following wording:
«The minimum share capital shall be as required by law, i.e. one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR
1,250,000.-); this amount has to be reached within a period of 12 months following the approval of the Fund by the
Luxembourg regulator, and thereafter may not be lees than this amount.»
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 6, section (1), second paragraph of the Fund's articles of incorporation in order
to give it the following wording:
«All issued registered Shares of the Fund shall be registered in the register of Shareholders which shall be kept by the
Fund or by one or more persons designated thereto by the Fund, and such register shall contain the name of each owner
of registered Shares, his residence or elected domicile as indicated to the Fund as well as the number and Class of
registered Shares held by him.»
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 7, first sentence and Article 10, section (2) paragraph (i) of the Fund's articles
of incorporation in order to give it the following wording:
« Art. 7. first sentence. Shares of the Fund are offered to Institutional Investors only.»
Art. 10. section (2) paragraph (i) : «(i) is a financial intermediary or other Institutional Investor, which term includes
insurance companies, social insurance carriers, pension funds, investment funds, foundations or credit institutions with
adequate resources to meet the obligations related to the transferred Shares and a demonstrated ability to meet any
remaining funding obligations at any time, provided such transferee qualifies as an Institutional Investor and»
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 11, section (2), paragraphs 2 and 3 of the Fund's articles of incorporation in
order to give it the following wording:
127076
«In determining the amount of such liabilities the Fund shall take into account all expenses payable by the Fund which
may comprise, as more fully described in the Prospectus, organizational expenses, formation expenses, operating expenses
that the Fund must bear, fees payable to its advisors and managers, including any management and advisory fees and
performance fees as well as acquisition fees, sales fees and finance arrangement fees, property management fees and
expenses payable to its accountants, Custodian and its correspondents, domiciliary, administrative, registrar and transfer
agents, any paying agent, any distributors and permanent representatives in places of registration, as well as any other
agent employed by the Fund, the remuneration of the Directors and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance
coverage and reasonable travelling costs in connection with Board meetings, costs payable in connection with any com-
mittees created by the Board (such as the Investment Advisory Committee), including reasonable accommodation and
out-of-pocket expenses members of such committees attending meetings, fees and expenses for legal and auditing services
(including due diligence expenses relating to potential investments), payments or reimbursements to the Fund's initiator
of all out-of-pocket legal, accounting and other expenses of the Fund and of the Fund's initiator in connection with the
organisation of the Fund and the offering of Shares of the Fund, any fees and expenses involved in registering and main-
taining the registration of the Fund with any governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg
and in any other country, reporting and publishing expenses, including the cost of preparing, printing, advertising and
distributing prospectuses, explanatory memoranda, periodical reports or registration statements, the cost of printing
certificates, and the costs of any reports to Shareholders, expenses incurred in determining the Fund's net asset value,
the cost of convening and holding Shareholders' and Board' meetings, all taxes, duties, governmental and similar charges,
and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, the cost of publishing the issue and
redemption prices, if any, interest, bank charges, currency conversion costs, and brokerage, postage, telephone and telex.
The Fund will moreover pay all other expenses, liabilities and obligations incurred by the Fund, the Fund's investment
advisor(s), investment manager(s) or the Fund's initiator, directly related to the operation of the Fund to the extent such
expenses, liabilities and obligations are of such nature not covered by any fees paid to the Fund's investment advisor(s)
or investment manager(s), incurred in compliance with the Fund documents and, where required, with the approval of
the investment advisor or the Board, as may be applicable, including, without limitation, (i) all reasonable costs and
expenses related to the acquisition, development, construction, management, and disposition of investments, whether
or not any such transaction is successfully completed, (ii) all reasonable costs and expenses of financings and refinancings
for the Fund and the Projects Investments, whether or not any such transaction is successfully completed, (iii) all rea-
sonable costs and expenses related to the identification and due diligence evaluation of potential investments, whether
or not any such transaction is approved or successfully completed, (iv) reasonable legal, accounting and other expenses
incurred in connection with the operation of the Fund, (v) all routine administrative expenses of the Fund, including, but
not limited to, the cost of the preparation of the annual audit, periodic financial reports, tax returns, cash management
expenses and insurance and legal expenses, (vi) the reasonable cost of consultants and other professionals, (vii) all value
added tax, capital duty and other similar taxes and duties, (viii) any fees payable to Directors which are not employees
or officers of the Fund's initiator or of one of its Affiliates; (ix) any premiums relating to the insurances covering the
liabilities of the Fund's Directors.»
<i>Ninth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 13 of the Fund's articles of incorporation in order to give it the following
wording:
« Art. 13. Directors. The Fund shall be managed by a Board composed of not less than three but no more than five
members, who need not be Shareholders of the Fund. They shall be elected for a term not exceeding three years. The
Directors shall be elected by the Shareholders at a General Meeting which shall also determine the number of Directors
and their remuneration.
Directors shall be elected by the General Meeting. Any Director may be removed with or without cause at any time
by a resolution passed by a majority of the votes of the Shares present or represented at a General Meeting.
In the event of a vacancy in the office of Director, the remaining Directors may temporarily fill such vacancy; the
Shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next General Meeting.»
<i>Tenth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 14 of the Fund's articles of incorporation in order to give it the following
wording:
« Art. 14. Board meetings. The Board will choose from among its members a chairman, and may choose from among
its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall write
and keep the minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders. The Board shall meet upon call by the
chairman or any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at the meetings of the Directors and of the Shareholders. In his absence, the Shareholders
or the Directors shall decide by a majority vote that another Director, or in case of a General Meeting, that any other
person shall be in the chair of such meetings. Resolutions of the Board shall be taken by a majority vote of the Directors
present or represented. In case of an equality of votes, the chairman shall have a casting vote. The Board may appoint
any officers, including a general manager and any assistant general managers as well as any other officers that the Fund
127077
deems necessary for the operation and management of the Fund. Such appointments may be cancelled at any time by the
Board. The officers need not be Directors or Shareholders of the Fund. The officers shall have the rights and duties
conferred upon them by the Board.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all Directors at least five Bank Business Days prior to the
date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall
be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or any
other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed
in a resolution adopted by the Board.
Any Director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or telefax or any other similar means
of communication another Director as his proxy. A Director may represent several of his colleagues.
Any Director may participate in a meeting of the Board by conference call or similar means of communications equip-
ment whereby all persons participating in the meeting can hear each other and participating in a meeting by such means
shall constitute presence in person at such meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at
the registered office of the Company.»
<i>Eleventh resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 20, seventh paragraph of the Fund's articles of incorporation in order to give
it the following wording:
«Each Investment Advisory Committee Representative shall have one vote per 10.000,- Euro of Commitments entered
into by the Investor by whom he has been appointed. Decisions of the Investment Advisory Committee will require a
simple majority vote.»
<i>Twelfth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the four last paragraphs of Article 21 of the Fund's articles of incorporation in order
to give them the following wording:
«The term «conflict of interests», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without
interest in any matter, position or transaction involving the Fund's initiator, its property manager(s), its investment advisor
(s) or investment manager(s), the Custodian, the Central Administration as well as any other person, company or entity
as may from time to time be determined by the Board on its discretion.
In the event that the Fund is presented with an investment proposal involving a property owned (in whole or in part)
by a Shareholder, a Director, the Fund's initiator or any Affiliate thereof, or with an investment proposal which was or
is advised by a Shareholder, a Director, the Fund's initiator or any Affiliate thereof or involving any portfolio company
whose shares are held by, or which has borrowed funds from a Shareholder, a Director, the Fund's initiator or any Affiliate
thereof, including any investment funds managed, advised, or promoted by the Fund's initiator or a Shareholder or a
Director or any of its Affiliates, the Shareholder, the Director and the Fund's initiator or any of its Affiliates as applicable
will fully disclose this conflict of interest to the Board who will revert to the Investment Advisory Committee for rec-
ommendations prior to the Board making a decision on such investment.
If the Shareholder has a conflict, his representative is not entitled to vote in the Investment Advisory Committee
making the investment recommendation.
The above proceedings shall not be applicable to the acquisition by the Fund of initial investments, as described in the
Prospectus. Moreover, the provisions of the preceding paragraphs are not applicable when the decisions of the Board
concern day-to-day operations engaged in normal conditions.»
<i>Thirteenth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 22 of the Fund's articles of incorporation in order to give it the following
wording:
« Art. 22. Indemnification of Directors and officers. The Fund will indemnify, out of the assets of the Fund only, the
Board, the Fund's initiator, its investment advisor(s) and investment manager(s), and their officers, directors and em-
ployees, and each Investment Advisory Committee Representative for any claims, damages and liabilities to which they
may become subject because of their status as member of the Board, the Fund's investment advisor, investment manager,
initiator or as an officer, director or employee thereof, or as an Investment Advisory Committee Representative or by
reason of any action taken or omitted to be taken by them in connection with the Fund, except to the extent caused by
their gross negligence, fraud or wilful misconduct.
The initiator will indemnify the Fund for any claims, damages, liabilities and losses incurred by the Fund as a result of
the gross negligence, fraud, wilful misconduct or breach of any Fund document by the Fund's investment advisor.»
<i>Fourteenth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 23, second paragraph, Article 28, second paragraph, Article 29 second para-
graph and Article 34 of the Fund's articles of incorporation in order to give them the following wording:
« Art. 23. second paragraph. The auditors shall fulfil all duties prescribed by the law of 13 February 2007.»
127078
« Art. 28. second paragraph. No distribution may be made if, after the declaration of such distribution, the Fund's
capital is less than the minimum capital imposed by the Law of 13 February 2007.»
« Art. 29 second paragraph. The Custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the law of 13
February 2007.»
Article 34:
« Art. 34. Applicable law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Law of 10 August 1915 and the Law of 13 February 2007.»
<i>Fifteenth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 25, second paragraph of the Fund's articles of incorporation in order to change
the date of the Fund's annual General Meeting to 9 November, and in order to give it the following wording:
«The annual General Meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at Luxembourg City at a place specified
in the notice of meeting, on 9 November at 11.30 a.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual
General Meeting shall be held on the next following Bank Business Day at the same time.»
<i>Sixteenth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 30, second hyphen of the Fund's articles of incorporation in order to give it
the following wording:
«- or a sale of the Fund's investments at market price (subject to any applicable regulations) to another undertaking
for collective investments initiated by the initiator;»
<i>Seventeenth resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 31 of the Fund's articles of incorporation in order to give it the following
wording:
« Art. 31. Dissolution. The Fund is incorporated for a limited period and will terminate on 30 September 2021.
However, the Board may propose to the General Meeting to terminate the Fund at any date after 30 September 2019.»
<i>Eighteenth resolutioni>
The Meeting resolves to Decision to hold the Fund's first annual General Meeting in 2007.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German version, and in case of divergences between the
English and the German texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundsieben, am neunzehnten Oktober.
Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, Grossherzogtum Luxemburg).
Sind die Aktionäre der société d'investissement à capital variable IVG EUROPEAN CORE+OFFICE, société d'inves-
tissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé (der «Fonds»), bestehend als société anonyme, mit Sitz in
2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, eingetragen beim Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer
B 117.225, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 20 Juni 2006, veröffentlicht
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1319 am 7. Juli 2006, deren Satzung durch Akte des
unterzeichneten Notars aufgenommen am 13. Oktober 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Nummer 2045 am 31. Oktober 2006 abgeändert wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung
zusammengetreten.
Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Herr Jacques Schroeder, rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Schriftführer wird bestellt Herrn Pierre-Alexandre Delagardelle, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Jean-Claude Michels, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende berichtet und die Versammlung stellt fest:
I. Die Aktionäre die zugegen oder vertreten sind, und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer
Anwesenheitsliste, welche durch die Aktionäre, deren Bevollmächtigten, dem Büro der Versammlung und dem Notar
unterzeichnet wurden, eingetragen. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne
varietur paraphiert wurden, werden der gegenwärtigen Akte, beigefügt bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.
II. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, das gesamte Aktienkapital, bestehend aus einunddreißig (31) Aktien ohne
Nennwert, bei der gegenwärtigen Versammlung vertreten ist.
127079
III. Alle Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter erklären, dass sie im voraus von der Tagesordnung unterrichtet
wurden und auf die gesetzliche und statutarische Einberufung verzichten. Die gegenwärtige Versammlung ist somit
rechtsgültig zusammengetreten und befugt, über nachstehende Tagesordnung zu beschließen,
IV. Die gegenwärtige Versammlung hat zur Tagesordnung:
Tagesordnung:
1. Abänderung der Definitionen der Begriffe «Fonds», «Erstemissionspreis», «Institutioneller Investor», «Anlageaus-
schuss», «NAV», «Nettoinventarwert je Aktie», «Prohibited Person», «Aktie», «Tochtergesellschaft», Einfügung der
Definition der Begriffe «Gesetz vom 13. Februar 2007» und «Geregelter Markt»; Streichung des Begriffs «Gesetz vom
19. Juli 1991».
2. Abänderung von Artikel 1 der Satzung des Fonds, um den Status des Fonds als «fonds d'investissement specialisé»
widerzuspiegeln.
3. Abänderung von Artikel 3 der Satzung des Fonds, um die Dauer des Fonds zu verlängern und die Erfordernisse zur
vorzeitigen Auflösung oder Verlängerung der Dauer aufzuführen.
4. Abänderung von Artikel 4, letzter Absatz der Satzung des Fonds, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Der Fonds ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte abzuschließen, die er zur Erfüllung und Entwicklung
seines Geschäftszwecks für nützlich hält, soweit dies nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 zulässig ist.»
5. Abänderung von Artikel 5, letzter Absatz der Satzung des Fonds, um ihn an die durch das Gesetz vom 13. Februar
2007 vorgesehenen Regeln anzupassen.
6. Abänderung von Artikel 6, Kapitel (1) der Satzung des Fonds, um eine Referenz auf Aktienklassen einzufügen.
7. Abänderung von Artikel 7, erster Satz und Artikel 10, Kapitel (2), Absatz (i) der Satzung des Fonds, um geringfügige
Anpassungen rein formeller Art vorzunehmen.
8. Abänderung von Artikel 11, Kapitel (2), Absätze 2 und 3 der Satzung des Fonds, um die Referenzen auf den «Pro-
motor» durch Referenzen auf den «Initiator» zu ersetzen.
9. Abänderung von Artikel 13 der Satzung des Fonds, um die maximale Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmit-
glieder auf drei Jahre zu ändern und rein formelle Anpassungen vorzunehmen.
10. Abänderung von Artikel 14 der Satzung des Fonds, um ihn an den neuen Wortlaut des Gesetzes vom 10. August
1915 anzupassen und rein formelle Anpassungen vorzunehmen.
11. Abänderung von Artikel 20, sechster Absatz der Satzung des Fonds, um die Stimmrechte der Vertreter im Anla-
geausschuss auf eine Stimme je 10 Millionen Kapitalzusage anzupassen.
12. Abänderung der letzten vier Absätze von Artikel 21 der Satzung des Fonds, um die Referenzen auf den «Promotor»
durch Referenzen auf den «Initiator» zu ersetzen beziehungsweise um sie an den neuen Wortlaut des Gesetzes vom 10.
August 1915 anzupassen.
13. Abänderung von Artikel 22 der Satzung des Fonds, um die Referenzen auf den «Promotor» durch Referenzen auf
den «Initiator» zu ersetzen.
14. Abänderung von Artikel 23, zweiter Absatz, Artikel 28, zweiter Absatz, Artikel 29, zweiter Absatz und Artikel 34
der Satzung des Fonds, um die Referenzen auf das Gesetz vom 19. Juli 1991 durch Referenzen auf das Gesetz vom 13.
Februar 2007 zu ersetzen.
15. Abänderung von Artikel 25, zweiter Absatz der Satzung des Fonds, um das Datum der ordentlichen Aktionärs-
versammlung auf den 9. November zu verlegen.
16. Abänderung von Artikel 30, zweiter Gedankenstrich der Satzung des Fonds, um die Referenz auf den «Promotor»
durch Referenz auf den «Initiator» zu ersetzen.
17. Abänderung von Artikel 31 der Satzung des Fonds, um die Dauer des Fonds zu verlängern.
18. Beschluss, die erste ordentliche Aktionärsversammlung des Fonds im Jahre 2007 abzuhalten.
19. Verschiedenes.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung der Gesellschaft dann einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, die Definitionen der Begriffe «Fonds», «Erstemissionspreis», «Institutioneller
Investor», «Anlageausschuss», «NAV», «Nettoinventarwert», «Prohibited Person», «Aktie» und «Tochtergesellschaft»
abzuändern, Definitionen der Begriffe «Gesetz vom 13. Februar 2007» und «Geregelter Markt» einzufügen und die De-
finition des Begriffs «Gesetz vom 19. Juli 1991» zu streichen. Die neuen beziehungsweise geänderten Definitionen haben
demzufolge folgenden Wortlaut:
«Aktien» Die Aktien des Kapitals der Gesellschaft.
«Anlageausschuss» Der Ausschuss zur Beratung des Verwaltungsrats, der sich aus Vertretern von ausgewählten Ak-
tionären des Fonds zusammensetzt und formell vom Verwaltungsrat gemäss der in dieser Satzung und im Prospekt
festgelegten Regeln bestellt wird.
127080
«Erstemissionspreis» Der Preis, zu dem die Aktien während der Erstemissionsphase ausgegeben werden, wie näher
im Prospekt beschrieben.
«Fonds» IVG EUROSELECT CORE+ OFFICE, société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spé-
cialisé.
«Geregelter Markt» Ein Markt, der geregelt, anerkannt und dem Publikum zugänglich ist und ordnungsgemäß funkti-
oniert.
«Gesetz vom 13. Februar 2007» Das luxemburgische Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds,
in seinen neuesten Fassung.
«Institutioneller Investor» Ein institutioneller Investor im Sinne der Bestimmungen des Artikels 10 dieser Satzung und
Ziffer 3.5 des Prospekts.
«Nettoinventarwert je Aktie» oder «NAV je Aktie» Der Nettovermögenswert einer Aktie in einer Aktienklasse, wie
er durch die Zentralverwaltung des Fonds berechnet wird.
«Nettoinventarwert» oder «NAV» Der gemäß Artikel 11 dieser Satzung sowie Ziffer 17.1 des Verkaufsprospekts des
Fonds bestimmte Nettoinventarwert des Fonds.
«Prohibited Person» Jede Person, Firma, «Partnership» oder Gesellschaft, falls nach freiem ermessen des Verwal-
tungsrats des Fonds der Besitz von Aktien durch eine solche Person den Interessen der bestehenden Aktionären des
fonds schaden könnte, oder falls ein solche Besitz luxemburgische oder andere Gesetze oder durch die Verwaltung
erlassenen Bestimmungen brechen könnte, oder falls sie zum Resultat haben könnte, dass der Fonds steuerlichen Nach-
teilen, Bußgeldern oder Strafen ausgesetzt werden könnte, welchen er sonst nicht ausgesetzt sein würde. Der Begriff
«Prohibited Person» schließt jede rechtliche Einheit ein, welche nicht von der auf Artikel 990D des Französischen Steu-
ergesetzbuchs (ggf. in der jeweils abgeänderten Fassung) begründeten Französischen 3% Steuer (die «Französische 3%
Steuer») und der jährlichen Steuer von 3%, welche auf den Wert einer Immobilie durch die Griechische Steuerbehörden
festgesetzt wird (die «Griechische 3% Steuer») ausgenommen ist, und der Fonds oder eine Anlagestruktur oder eine
rechtliche Einheit einer Anlagestruktur infolge des Besitzes von Aktien durch eine solche Einheit zur Zahlung der Fran-
zösischen 3% Steuer oder der Griechischen 3% Steuer verpflichtet würde und es keine vernünftige zufriedenstellende
alternative Strukturen zur Zahlung der Französischen 3% Steuer oder der Griechischen 3% Steuer durch den betreffenden
nicht-steuerbefreiten Aktionärs gibt. Der Begriff «Prohibited Person» schließt US Persons Investoren, welche nicht als
Institutionelle Investoren gelten sowie natürliche Personen sowie rechtliche Einheiten, an denen eine oder mehrere
natürliche Personen beteiligt sind, ein außer wenn eine solche rechtliche Einheit laut dem deutschen Steuerrecht als
Gesellschaft gilt;
«Tochtergesellschaft» Eine Gesellschaft, deren Aktienkapital direkt oder indirekt zu mehr als 75% durch den Fonds
gehalten wird, wie in Ziffer 4.1 des Prospekts näher beschrieben.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 1 der Satzung des Fonds abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu
geben:
« Art. 1. Name. Zwischen den Zeichnern und denjenigen, welche Eigentümer von zukünftig ausgegebenen Aktien
werden können, besteht eine Aktiengesellschaft («société anonyme») in Form einer spezialisierten Investmentgesellschaft
mit variablem Kapital («societé d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé») mit dem Namen
IVG EUROPEAN CORE+ OFFICE.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 3 der Satzung des Fonds abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu
geben:
Art. 3. Laufzeit. Der Fonds ist für einen begrenzten Zeitraum errichtet und endet am 30. September 2021.
Jedoch kann der Verwaltungsrat der Aktionärsversammlung vorschlagen, den Fonds zu jedem Datum ab dem 30.
September 2019 aufzulösen. Weiterhin kann der Verwaltungsrat der Aktionärsversammlung vorschlagen, die Laufzeit des
Fonds zu verlängern oder, im Falle eines öffentlichen Angebots der Aktien, die Satzung des Fonds dahingehend abzuändern,
um eine unbegrenzte Laufzeit vorzusehen. Ein solcher Vorschlag des Verwaltungsrats zur vorzeitigen Auflösung oder zur
Verlängerung der Dauer des Fonds bedarf der Zustimmung durch die Aktionärsversammlung, welche gemäss den für
Satzungsänderungen vorgesehenen Bedingungen entscheidet.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 4, letzter Absatz der Satzung des Fonds abzuändern, um ihm folgenden
Wortlaut zu geben:
«Der Fonds ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte abzuschließen, die er zur Erfüllung und Entwicklung
seines Geschäftszwecks für nützlich hält, soweit dies nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 zulässig ist.»
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 5, letzter Absatz der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu
geben:
127081
«Das Mindestkapital des Fonds beträgt, wie gesetzlich erfordert, eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR
1.250.000,- ) dieser Betrag muss innerhalb von zwölf Monaten ab dem Tag der Zulassung des Fonds durch die Luxem-
burgische Aufsichtbehörde erreicht werden und darf nach diesem Zeitpunkt diesen Betrag nicht mehr unterschreiten.»
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 6, Kapitel (1), zweiter Absatz der Satzung des Fonds abzuändern, um ihm
folgenden Wortlaut zu geben:
«Alle von dem Fonds ausgegebenen Aktien werden im Aktienregister eingetragen, das von dem Fonds bzw. von einer
oder mehreren von dem Fonds ernannten natürlichen oder juristischen Personen geführt wird. Dieses Verzeichnis enthält
den Namen von jedem Aktionär, die Anzahl der von ihm in jeder Klasse gehaltenen Aktien sowie seine Adresse oder
sein gewähltes Domizil, den er dem Fonds angegeben hat.»
<i>Siebenter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 7, erster Satz und Artikel 10, Kapitel (2), Absatz (i) der Satzung des Fonds
abzuändern, um ihnen folgenden Wortlaut zu geben:
« Art. 7. erster Satz. Die Aktien des Fonds werden ausschließlich Institutionellen Investoren angeboten.»
« Art. 10. Kapitel (2), Absatz (i) :
(i) ein Finanzintermediär oder sonstiger Institutioneller Investor ist, wie beispielsweise eine Versicherungsgesellschaft,
ein Sozialversicherungsträger, Pensionsfonds, Investmentfonds, eine Stiftung oder ein Kreditinstitut mit ausreichenden
Mitteln, um die mit den übertragenen Aktien verbundenen Verpflichtungen einhalten zu können und unter der weiteren
Voraussetzung, dass ein solcher Übertragungsempfänger die Voraussetzungen eines Institutionellen Investors erfüllt,»
<i>Achter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 11, Kapitel (2) Absätze 2 und 3 der Satzung des Fonds abzuändern, um
ihnen folgenden Wortlaut zu geben:
«Bei der Festlegung der Höhe dieser Verbindlichkeiten berücksichtigt der Fonds sämtliche von diesem zu zahlenden
Aufwendungen, die im Prospekt detailliert beschrieben sind. Sie umfassen beispielsweise Gründungskosten, Kosten für
den Aufbau des Geschäfts und die operativen Kosten, die der Fonds zu tragen hat, vom Fonds zu tragende Gebühren für
Berater und Verwalter, einschließlich Beratungs- und Verwaltungsgebühren sowie Erwerbskosten und Gebühren für
Verkäufe und die Transaktionsstrukturierungen, Immobilienverwaltungskosten und Gebühren und Aufwendungen, die an
die Wirtschaftsprüfer, Depotbank und Korrespondenzbanken, die Domiziliar-, Verwaltungs-, Register und Transferstelle,
Zahl- und Vertriebsstellen sowie ständige Vertreter an den Registrierungsorten des Fonds zu zahlen sind sowie an andere
von der Gesellschaft eingesetzte Vertreter zu zahlende Gebühren und Aufwendungen, die Honorare der Mitglieder des
Verwaltungsrats und deren angemessene Spesen, Versicherungsprämien und angemessene Reisekosten in Verbindung mit
Verwaltungsratssitzungen, Kosten, die in Verbindung mit vom Verwaltungsrat begründeten Gremien (wie dem Anlage-
ausschuss) entstehen, einschließlich angemessener Kosten für die Unterbringung und Spesen der Mitglieder solcher
Ausschüsse, wenn sie an Sitzungen teilnehmen, Gebühren und Aufwendungen für Rechtsberatung, Steuerberatung, Wirt-
schaftsprüfer, einschließlich der Due-Diligence-Aufwendungen im Zusammenhang mit potenziellen Investitionen, Zahl-
ungen oder Erstattungen sämtlicher Spesen für Rechts-, Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und andere Kosten der
Gesellschaft und des Initiators in Verbindung mit der Gründung der Gesellschaft und der Ausgabe von Aktien der Ge-
sellschaft, Gebühren und Aufwendungen in Verbindung mit der Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung
des Fonds bei staatlichen Stellen oder Börsen im Großherzogtum Luxemburg und in anderen Ländern, Berichts- und
Veröffentlichungskosten, einschließlich der Kosten für die Zusammenstellung, den Druck, die Werbung und Verteilung
von Prospekten, erklärenden Memoranden, regelmäßigen Berichten oder Eintragsauszügen, die Kosten für den Druck
von Anteilscheinen sowie die Kosten von Berichten für die Aktionäre, Kosten, die im Zusammenhang mit der Feststellung
des Nettoinventarwerts des Fonds entstehen, die Kosten für die Einberufung und Durchführung von Aktionärsversamm-
lungen und Verwaltungsratssitzungen, sämtliche Steuern, Zölle, staatliche und ähnlich Abgaben, sowie alle sonstigen
operativen Aufwendungen, einschließlich Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, Konten für die etwaige
Veröffentlichung von Ausgabe- und Rücknahmepreisen, Zinsen, Bankgebühren, Devisenumtauschkosten und Porto-, Te-
lefon- und Telexgebühren.
Der Fonds übernimmt ferner alle sonstigen Aufwendungen, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen, die entweder dem
Fonds selbst oder einem seiner Anlageberater, Anlageverwalter oder seinem Initiator entstanden sind und direkt mit dem
Betrieb des Fonds verbunden sind, soweit solche Aufwendungen, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen nicht bereits
durch die Gebühren gedeckt sind, die der Fonds dem Anlageberater oder dem Investment Manager zahlt und die im
Einklang mit den Fondsdokumenten entstanden sind und gegebenenfalls vom Anlageberater bzw. dem Verwaltungsrat
genehmigt wurden. Hierzu gehören beispielsweise (i) alle angemessenen Kosten und Auslagen im Zusammenhang mit
dem Erwerb, der Erschließung, dem Bau, der Verwaltung, der Restrukturierung und der Veräußerung von Anlagen, un-
geachtet dessen, ob eine derartige Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde, (ii) alle angemessen Kosten für die
Finanzierung und Refinanzierung des Fonds und der Projektbeteiligungen, ungeachtet dessen, ob eine derartige Transak-
tion erfolgreich abgeschlossen wird, (iii) alle angemessenen Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem
Identifikationsprozess und der Due-Diligence-Bewertung bei neuen potenziellen Investments, ungeachtet dessen, ob eine
127082
derartige Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird, (iv) angemessene Kosten für die Rechts- und Steuerberatung sowie
sonstige Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem operativen Geschäft des Fonds entstanden sind, (v) alle routi-
nemäßigen Verwaltungskosten des Fonds, wie beispielsweise Kosten für die Vorbereitung der Jahresprüfung, der
periodischen Finanzberichte und Steuererklärungen, Kosten für das Cash Management sowie Aufwendungen für Versi-
cherungen und Rechtsbelange, (vi) angemessene Kosten für Berater und sonstige Profis, (vii) sämtliche Mehrwertsteuern,
Steuern auf Veräußerungsgewinne oder ähnliche Steuern und Abgaben, (viii) Honorare für Verwaltungsratsmitglieder, die
keine Mitarbeiter oder leitenden Angestellten des Initiators des Fonds oder eines seiner verbundenen Unternehmen sind,
(ix) Prämien für Haftpflichtversicherungen der Verwaltungsratsmitglieder.»
<i>Neunter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 13 der Satzung des Fonds abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu
geben:
« Art. 13. Verwaltungsratsmitglieder. Der Fonds wird von einem Verwaltungsrat geführt, der sich aus mindestens drei
und höchstens fünf Mitgliedern zusammensetzt. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen keine Aktionäre des Fonds sein.
Die Amtszeit der Veraltungsratsmitglieder beträgt maximal drei Jahre. Gewählt werden die Verwaltungsratsmitglieder
von den Aktionären auf der Aktionärsversammlung, die auch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder und deren Bezüge
bestimmt.
Die Aktionärsversammlung wählt die Verwaltungsratsmitglieder. Sie können durch einen mit Stimmenmehrheit der
bei einer Aktionärsversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gefassten Beschluss jederzeit mit oder ohne wich-
tigen Grund abberufen werden.
Sollte die Position eines Verwaltungsratsmitglieds vakant werden, kann diese Position vorübergehend von den restli-
chen Mitgliedern des Verwaltungsrats besetzt werden; die letztendliche Entscheidung über eine solche Nominierung
treffen die Aktionäre auf ihrer nächsten Aktionärsversammlung.»
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 14 der Satzung des Fonds abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu
geben:
« Art. 14. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat wird aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen und kann
aus seiner Mitte einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen. Er kann auch einen Schriftführer ernennen,
der kein Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Aktionärs-
versammlungen verfasst und für die Aufbewahrung sorgt. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder von zwei
seiner Mitglieder einberufen; er tagt an dem in der Einladung angegebenen Ort.
Der Vorsitzende hat auf den Verwaltungsratssitzungen und den Aktionärsversammlungen den Vorsitz. Im Falle der
Abwesenheit des Vorsitzenden bestimmen die Aktionäre oder die Verwaltungsratsmitglieder durch Mehrheitsbeschluss,
dass ein anderes Verwaltungsratsmitglied bzw. eine beliebige andere Person den Vorsitz bei derartigen Versammlungen
oder Sitzungen führt. Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen
Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Im Falle der Stimmengleichheit hat der Vorsitzende die ausschlaggebende Stimme.
Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte, einschließlich eines Generaldirektors und stellvertretenden General-
direktors sowie andere leitende Angestellte ernennen, die der Fonds für die Geschäftstätigkeit und die Leitung des Fonds
für notwendig erachtet. Der Verwaltungsrat kann diese Ernennungen jederzeit wieder rückgängig machen. Bei den lei-
tenden Angestellten muss es sich nicht um Verwaltungsratsmitglieder oder Aktionäre des Fonds handeln. Die leitenden
Angestellten haben die ihnen vom Verwaltungsrat übertragenen Rechte und Pflichten.
Alle Verwaltungsratsmitglieder erhalten spätestens drei Bankarbeitstage vor dem für eine Sitzung angesetzten Datum
eine schriftliche Mitteilung, außer bei Gefahr im Verzug, wobei dann die Umstände, woraus sich die besondere Dring-
lichkeit ergibt, in der Einberufungsmitteilung anzugeben sind. Auf die Notwendigkeit einer Mitteilung kann per Telegramm,
Telefax oder anderes gleichwertiges Kommunikationsmittel in Schriftform verzichtet werden. Sofern ein Verwaltungs-
ratsbeschluss über Zeit und Ort von Verwaltungsratssitzungen vorliegt, erübrigt sich die gesonderte Mitteilung.
Verwaltungsratsmitglieder können sich untereinander per Telegramm, Telex, Telefax oder ein gleichwertiges Kom-
munikationsmittel Vertretungsmacht für Verwaltungsratssitzungen erteilen. Mehrfachvertretung ist zulässig.
Die Teilnahme an Verwaltungsratssitzungen durch Konferenzschaltungen oder ähnliche kommunikationstechnische
Einrichtungen, bei denen eine gegenseitige Verständigung aller Teilnehmer gewährleistet ist, ist zulässig. Teilnehmer, wel-
che solchermaßen der Sitzung beigewohnt haben, werden als persönlich anwesend gezählt. Die Teilnahme an einer
Verwaltungsratssitzung durch eine dieser Kommunikationstechniken wird einer persönlichen Anwesenheit bei der be-
treffenden Sitzung gleichgestellt. Eine Verwaltungsratssitzung, welche durch diese Kommunikationstechniken abgehalten
wurde, gilt als am Gesellschaftssitz des Fonds abgehalten.
Die Verwaltungsratsmitglieder können nur im Rahmen von ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen
handeln. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch ihre Einzelunterschrift verpflichten, wenn
nicht ein Verwaltungsratsbeschluss sie speziell dazu ermächtigt hat.
Der Verwaltungsrat ist nur beratungs- und beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglie-
der anwesend oder vertreten ist.
127083
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, die vom Vorsitzenden unterzeichnet werden.
Abschriften der oder Auszüge aus solchen Protokollen, die in Rechtsstreitigkeiten oder an anderer Stelle vorgelegt wer-
den, bedürfen gegebenenfalls der Unterschrift des Vorsitzenden der Sitzung oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.
Schriftliche, von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigte und unterzeichnete Beschlüsse haben dieselbe Rechts-
wirksamkeit wie Beschlüsse, die bei der Verwaltungsratssitzung durch Stimmabgabe gefasst wurden. Jedes Verwaltungs-
ratsmitglied genehmigt einen solchen Beschluss schriftlich per Telegramm, Telex, Telefax oder gleichwertiges
Kommunikationsmittel. Diese Beschlüsse in ihrer Gesamtheit fungieren als Niederschrift, mit der bewiesen wird, dass
eine solche Entscheidung getroffen wurde.»
<i>Elfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 20, siebenter Absatz der Satzung des Fonds abzuändern, um ihm folgenden
Wortlaut zu geben:
«Je 10.000,- Euro der Kapitalzusage des Aktionärs, der den Vertreter im Anlageausschuss eingesetzt hat, steht diesem
Vertreter eine Stimme zu. Beschlüsse des Anlageausschusses werden mit einfacher Mehrheit gefasst.»
<i>Zwölfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, die letzten vier Absätze von Artikel 21 der Satzung des Fonds abzuändern, um
ihnen folgenden Wortlaut zu geben:
«Nicht als «Interessenkonflikt» im Sinne des vorhergehenden Satzes werden Beziehungen zum Initiator des Fonds,
dessen Immobilienverwalter, Anlageberater oder Anlageverwalter, zur Depotbank, Zentralverwaltung oder anderen Per-
sonen, Unternehmen oder Rechtsträgern, die der Verwaltungsrat jeweils nach eigenem Ermessen bestimmt, gewertet -
unabhängig davon, ob ein Interesse an den Angelegenheiten, Positionen oder Transaktionen der genannten Personen
besteht.
Aktionäre, Verwaltungsratsmitglieder, der Initiator des Fonds sowie dessen verbundene Unternehmen haben dem
Verwaltungsrat Interessenskonflikte offen zu legen, wann immer dem Fonds Investitionsvorschläge über Vermögenswerte
vorgelegt werden, die (ganz oder teilweise) im Eigentum der Aktionäre, der Verwaltungsratsmitglieder, dem Initiator des
Fonds oder verbundener Unternehmen stehen, oder wenn ihm Vorschläge über Investitionsobjekte vorgelegt werden,
die von einer dieser Personen beraten werden oder eine Gesellschaft betreffen, die im Portfolio einer der genannten
Personen gehalten werden oder der eine der genannten Personen Kredite gewährt hat. Dies schließt auch Investment-
fonds ein, die vom Initiator oder einem Aktionär, Verwaltungsratsmitglied oder verbundenen Unternehmen verwaltet,
beraten oder gefördert werden. In solchen Fällen trifft der Verwaltungsrat seine Investitionsentscheidung nach Einholen
eines Vorschlags vom Anlageausschuss.
Liegt beim Aktionär ein Interessenskonflikt vor, so ist dessen Vertreter in dem Anlageausschuss, der die Anlageemp-
fehlung ausspricht, nicht stimmberechtigt.
Die obigen Verfahrensweisen finden keine Anwendung, soweit es sich um Käufe des Fonds im Rahmen der Erstanlage
(wie im Prospekt beschrieben) handelt. Weiterhin sind die Bestimmungen der vorstehenden Abschnitte nicht auf Ent-
scheidungen anwendbar, welche Geschäfte betreffen, die der Verwaltungsrat im Rahmen der täglichen Geschäftsführung
und unter normalen Bedingungen eingeht.»
<i>Dreizehnter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 22 der Satzung des Fonds abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu
geben:
« Art. 22 . Freistellung und Entschädigung. Der Fonds wird den Verwaltungsrat, den Initiator des Fonds, dessen
Anlageberater und Anlageverwalter, leitende Angestellte, Verwaltungsratsmitglieder und Mitarbeiter sowie jeden Ver-
treter im Anlageausschuss für alle Forderungen, Schäden und jegliche Haftung, denen diese unter Umständen auf Grund
ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratmitglieder, Anlageberater des Fonds, Anlageverwalter, Initiator oder leitender An-
gestellter, Verwaltungsratsmitglied oder Mitarbeiter oder als ein Vertreter im Anlageausschuss oder auf Grund einer von
ihnen im Zusammenhang mit dem Fonds vorgenommenen oder unterlassenen Handlung unterliegen, aus dem Vermögen
des Fonds entschädigen bzw. entsprechend freistellen, soweit dies nicht durch ihre grobe Fahrlässigkeit, Betrug oder
vorsätzliches Fehlverhalten verursacht wurde.
Für jegliche Forderungen, Schäden, Haftung und Verluste, die dem Fonds durch grobe Fahrlässigkeit, Betrug, vorsätz-
liches Fehlverhalten oder Verstoß gegen Bestimmungen in den Fondsunterlagen durch den Anlageberater des Fonds
entstehen, wird der Initiator den Fonds entschädigen bzw. entsprechend freistellen.»
<i>Vierzehnter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 23, zweiter Absatz, Artikel 28, zweiter Absatz, Artikel 29, zweiter Absatz
und Artikel 34 der Satzung des Fonds abzuändern, um ihnen folgenden Wortlaut zu geben:
« Art. 23. Zweiter Absatz. Die Wirtschaftsprüfer erfüllen alle Pflichten, die das Gesetz vom 13. Februar 2007 vor-
schreibt.»
« Art. 28. Zweiter Absatz. Wenn das Kapital des Fonds nach Beschluss einer solchen Dividende unter die Mindest-
kapitalgrenze gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 sinken würde, sind keine Ausschüttungen zulässig.»
127084
« Art. 29. Zweiter Absatz. Die Depotbank hat ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten gemäß dem Gesetz vom 13.
Februar 2007 zu erfüllen.»
Artikel 34:
« Art. 34. Maßgebliches Recht. Alle nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten werden im Einklang mit dem
Gesetz vom 10. August 1915 und dem Gesetz vom 13. Februar 2007 entschieden.»
<i>Fünfzehnter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 25, zweiter Abschnitt der Satzung des Fonds abzuändern, und das Datum
der ordentlichen Aktionärsversammlung auf den 9. November zu verlegen, und besagtem Abschnitt folgenden Wortlaut
zu geben:
«Die ordentliche Aktionärsversammlung findet nach den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts jährlich am 9.
November um 11.30 Uhr an einem in der Einladung zur Aktionärsversammlung anzugebenden Ort statt. Sollte dieser Tag
kein Bankarbeitstag sein, ist die ordentliche Aktionärsversammlung zur gleichen Uhrzeit am nächstfolgenden Banka-
rbeitstag abzuhalten.»
<i>Sechzehnter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 30, zweiter Gedankenstrich der Satzung des Fonds abzuändern, um ihm
folgenden Wortlaut zu geben:
«- einen Verkauf der Anlagen des Fonds zum Marktpreis (vorbehaltlich geltender Bestimmungen) an einen anderen
Organismus für gemeinsame Anlagen, der vom Initiator ins Leben gerufen wurde,»
<i>Siebenzehnter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 31 der Satzung des Fonds abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu
geben:
« Art. 31. Auflösung. Der Fonds wurde für einen begrenzten Zeitraum gegründet und endet am 30. September 2021.
Der Verwaltungsrat kann jedoch der Aktionärsversammlung die Beendigung des Fonds zu einem beliebigen Datum nach
dem 30. September 2019 vorschlagen.»
<i>Achtzehnter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, die erste ordentliche Aktionärsversammlung im Jahre 2007 abzuhalten.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit dass auf Anfrage der oben erwähnten
Personen diese Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Fassung, verfasst wurde; auf Anfrage derselben
erschienen Personen wird im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische
Fassung maßgebend sein.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, welche dem instrumentierenden Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben zusammen mit uns, dem
Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Schroeder, P. A. Delagardelle, J.-C. Michels, J.-J. Wagner.
Einregistriert in Esch an der Alzette, am 25. Oktober 2007, Relation: EAC/2007/13116. — Reçu 12 euros.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Santioni.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung in Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und
Vereinigungen.
Beles, den 30 Oktober 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007129494/239/649.
(070154927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.
IVG European Core+ Office, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 117.225.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
127085
Belvaux, le 30 octobre 2007.
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007129496/239/13.
(070154931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.
PVM S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 51.001.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 18 octobre 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour insuffisance, respectivement absence d'actif les opérations de liquidation de la société
PVM S.A. ayant eu son siège social 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Les frais ont été mis à la charge du
Trésor.
M. Peters
<i>Le liquidateur judiciairei>
Référence de publication: 2007130596/8278/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00668. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070151253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.
Terravera S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 57.073.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 18 octobre 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour insuffisance, respectivement absence d'actif les opérations de liquidation de la société
TERRAVERA S.A. ayant eu son siège social au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg. Les frais ont été mis à la
charge du Trésor.
M. Peters
<i>Le liquidateur judiciairei>
Référence de publication: 2007130597/8278/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00671. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070155841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2007.
X-Trem Bananas S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 76.388.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 18 octobre 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour insuffisance, respectivement absence d'actif les opérations de liquidation de la société
X-TREM BANANAS S.à r.l. ayant eu son siège social au 34B, rue de Kreuzerbuch, L-8370 Hobscheid. Les frais ont été
mis à la charge du Trésor.
M. Peters
<i>Le liquidateur judiciairei>
Référence de publication: 2007130598/8278/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00670. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070151255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.
127086
Dominos Luxembourg S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 50.993.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 18 octobre 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour insuffisance, respectivement absence d'actif les opérations de liquidation de la société
DOMINOS LUXEMBOURG S.A. ayant eu son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Les frais
ont été mis à la charge du Trésor.
M. Peters
<i>Le liquidateur judiciairei>
Référence de publication: 2007130599/8278/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00669. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070151254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.
Truth 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 403.759.560,00.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 131.259.
PROJET DE FUSION
entre:
TRUTH 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2,
rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 131.259 (la
«Société Absorbée»),
et
TRIEF CORPORATION S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue
Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
50.612 (la «Société Absorbante», ensemble avec la Société Absorbée, les «Sociétés Fusionnantes»).
1. Les Sociétés Fusionnantes ont l'intention de réaliser le ou vers le 21 décembre 2007 la fusion entre la Société
Absorbante et la Société Absorbée conformément aux dispositions des articles 261 à 276 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).
2. Les détenteurs de parts sociales dans la Société Absorbée recevront en échange de leurs parts sociales un nombre
d'actions dans la Société Absorbante égal au nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société Absorbée multiplié
par la parité de conversion. Sur base des chiffres actuellement disponibles, la parité de conversion correspondra à une
(1) action de la Société Absorbante en échange de vingt-sept mille trois cent vingt-neuf (27.329) parts sociales de la Société
Absorbée. Dans le cas où la parité de conversion des actions aurait pour conséquence l'apparition de rompus, les dé-
tenteurs de parts sociales dans la Société Absorbée recevront une soulte en espèces.
3. Les droits attachés aux nouvelles actions émises par la Société Absorbante aux associés de la Société Absorbée
seront à tous égards identiques aux droits attachés aux actions de la Société Absorbante, notamment en ce qui concerne
les droits aux dividendes.
4. Les détenteurs des parts sociales de la Société Absorbée seront retirés du registre des associés de la Société
Absorbée et inscrits dans le registre des actionnaires de la Société Absorbante pour le nombre d'actions qu'ils recevront
à la date d'entrée en vigueur de la fusion.
5. Il n'existe aucun actionnaire ayant des droits spéciaux ou des détenteurs de sûretés autres que des actions, auxquels
la Société Absorbante entend conférer des droits spéciaux et aucun avantage ne sera accordé aux reviseurs indépendants
en charge d'établir les rapports de fusion, aux membres du conseil d'administration ou membre du conseil de gérance
ou aux auditeurs statutaires des Sociétés Fusionnantes.
6. Conformément à l'Article 263 de la Loi de 1915, la fusion sera approuvée par les assemblées générales de chacune
des Sociétés Fusionnantes et, le cas échéant, par les porteurs de titres autres que des actions.
7. La fusion entrera en vigueur et aura les effets prévus par l'article 274 de la Loi de 1915 une fois qu'elle aura été
approuvée par les assemblées générales des actionnaires de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.
8. Le 23 octobre 2007 est à considérer comme la date de départ pour l'accomplissement par la Société Absorbante
des opérations de comptabilité de la Société Absorbée. A partir de cette date, les nouvelles actions participeront aux
résultats de la Société Absorbante. La fusion doit être neutre fiscalement et comptablement.
127087
9. Sur la base des développements décrits ci-dessus et en raison du fait que les chiffres et parités stipulés dans ce projet
de fusion ne peuvent être évalués que de façon approximative à ce jour, le conseil de gérance de la Société Absorbée et
le conseil d'administration de la Société Absorbante sont à tout moment autorisés à procéder à des ajustements, le cas
échéant, en ce qui concerne les valeurs et hypothèses considérées dans ce projet de fusion et soumettre les chiffres et
parités révisés à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ou associés.
10. Le livre de comptes et les documents de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société
Absorbante aussi longtemps que prescrit par la loi luxembourgeoise.
<i>TRUTH 1 S.à r.l.
i>TRIEF CORPORATIONS S.A.
<i>Gérant Unique
i>J.-Y. Hémery
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2007131728/250/57.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2007, réf. LSO-CK04230. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070157412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2007.
George and Dragon, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 217, rue Albert Unden.
R.C.S. Luxembourg B 21.833.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007127300/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05537. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070146853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Albaha Holdings S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 60.044.
Par jugement rendu en date du 18 octobre 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour insuffisance, respectivement absence d'actif les opérations de liquidation de la société
ALBAHA HOLDINGS S.A. ayant eu son siège social au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg. Les frais ont
été mis à la charge du Trésor.
M. Peters
<i>Le liquidateur judiciairei>
Référence de publication: 2007130600/8278/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00667. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070151252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2007.
Tower Automotive Holdings VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Tarlot Holding S. à r. l.).
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 131.226.
In the year two thousand and seven, on the twenty-fifth day of July, at 06.00 p.m.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
TOWER AUTOMATIVE, LLC, a company incorporated and existing under the laws of Delaware, having its registered
office at 299, Park Avenue, New York, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of
Delaware under number 4336502,
duly represented by Mr Sigurdur Gudmannsson, maître en droit, residing in Luxembourg,
127088
by virtue of a proxy given in New York, on 23 July 2007.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact that it is the
sole partner of TARLOT HOLDING S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée, incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg trade and companies register, incorporated pursuant to a notarial
deed, on the 26 of June 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of
incorporation of the Company have not been amended since the date of incorporation.
The appearing party acting in its said capacity and representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner resolves to change the name of the Company from TARLOT HOLDING S.à r.l. into TOWER AU-
TOMATIVE HOLDINGS VII S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the general meeting decides to amend Article 1 of the articles of incorpo-
ration so that it shall read as follows:
« Art. 1. There exists a «Société à responsbilité limitée», private limited liability company under the name TOWER
AUTOMATIVE HOLDINGS VII S.à r.l. (the «Company») governed by the present articles of incorporation and by current
laws, and in particular the law of August 10th , 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»).»
<i>Third resolutioni>
The sole partner resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seven hundred seventy-four
thousand three hundred five euro (EUR 774,305.-) to bring it from its present amount of twelve thousand and five hundred
euro (EUR 12,500.-) up to the amount of seven hundred eighty-six thousand eight hundred and five euro (EUR 786,805.-)
by the issue of seventy-seven million four hundred thirty thousand five hundred (77,430,500) new shares, having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each.
<i>Subscription - Paymenti>
There appeared Mr Sigurdur Gudmannsson, previously named, who declares to subscribe in the name and for the
account of TOWER AUTOMATIVE, LLC, pre-named, on the basis of a proxy dated 23 July 2007, to the seventy-seven
million four hundred thirty thousand five hundred (77,430,500) new shares.
The shares subscribed by TOWER AUTOMATIVE, LLC, have been fully paid up by a contribution in kind consisting
of hundred and eighty (180) shares, with a par value of one euro (EUR 1.-) each, of TOWER AUTOMATIVE HOLDINGS
VI B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Oude
Utrechtsweg 16, 3743 KN Baarn, The Netherlands, registered with the trade and companies register of the Netherlands
under number 32125107 0000.
The value of the contribution in kind made by TOWER AUTOMATIVE, LLC, is set at seven hundred seventy-four
thousand three hundred five euro (EUR 774,305.-).
The proof of the existence and of the value of the contribution in kind made by TOWER AUTOMATIVE, LLC, in a
total amount of seven hundred seventy-four thousand three hundred five euro (EUR 774,305.-) has been produced to
the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the sole partner decides to amend the first paragraph of article 5 of
the Company's articles of incorporation, which shall now read as follows:
« Art. 5. (first paragraph). The capital is set at seven hundred eighty-six thousand eight hundred and five euro (EUR
786,805.-) represented by seventy-eight million six hundred eighty thousand five hundred (78,680,500) shares with a
nominal value of one cent (EUR 0.01) each.»
<i>Capital duty exemption requesti>
Considering that the present deed documents a capital increase of a Luxembourg company by a contribution in kind
consisting of one per cent (1%) of the shares of a company having its registered office in an European Union Member
State of which the Company already holds the remaining ninety-nine per cent (99%) of the shares, the Company requests
in accordance with Article 4-2 of the law of 29 December 1971, as amended, exemption from the capital duty.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to two thousand five hundred euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
127089
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-cinq juillet, à 18.00 heures.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
TOWER AUTOMATIVE, LLC, une société constituée et existant selon les lois de Delaware, ayant son siège social au
299, Park Avenue, New York, Etats-Unis, enregistrée auprès du Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro
4336502,
ici représentée par Monsieur Sigurdur Gudmannsson, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à New York, le 23 juillet 2007.
La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire pour acter qu'elle est l'associé unique de TARLOT
HOLDING S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 46A, avenue J. F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, non encore immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, consti-
tuée suivant acte notarié en date du 26 juin 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis la date de la constitution.
La comparante, agissant en sa qualité susmentionnée et représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la société de TARLOT HOLDING S.à r.l. en TOWER
AUTOMATIVE HOLDINGS VII S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination TOWER AUTOMATIVE HOLDINGS
VII S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en
particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de sept cent soixante-quatorze mille trois cent cinq
euros (EUR 774.305,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un montant
de sept cent quatre-vingt-six mille huit cent cinq euros (EUR 786.805,-) par l'émission de soixante-dix sept millions quatre
cent trente mille cinq cents (77.430.500) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un cent (EUR 0,01) chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
A comparu Monsieur Sigurdur Gudmannsson, prénommé, qui déclare souscrire au nom et pour le compte de TOWER
AUTOMATIVE, LLC, pré-mentionnée, sur base d'une procuration du 23 juillet 2007, les soixante-dix sept millions quatre
cent trente mille cinq cents (77.430.500) nouvelles parts sociales.
Les parts sociales souscrites par TOWER AUTOMATIVE, LLC, ont été entièrement libérées par un apport en nature
consistant en cent quatre-vingt (180) actions, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, de TOWER AU-
TOMATIVE HOLDINGS VI B.V., une société constituée et existant conformément au droit des Pays-Bas, ayant son siège
social à Oude Utrechtsweg 16, 3743 KN Baarn, Pays-Bas, inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés des
Pays-Bas sous le numéro 32125107 0000.
Le montant de la contribution en nature effectuée par TOWER AUTOMATIVE, LLC, est fixé à sept cent soixante-
quatorze mille trois cents cinq euros (EUR 774.305,-).
La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport en nature effectué par TOWER AUTOMATIVE, LLC, d'un montant
total de sept cent soixante-quatorze mille trois cents cinq euros (EUR 774.305,-) a été soumise au notaire soussigné.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier le premier alinéa l'article 5 des statuts de la Société,
pour lui donner la teneur suivante:
127090
« Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à la somme de sept cent quatre-vingt-six mille huit cent cinq euros
(EUR 786.805,-) représenté par soixante-dix huit millions six cent quatre-vingt mille cinq cents (78.680.500) parts sociales
d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune.»
<i>Requête d'exonération du droit d'apporti>
Compte tenu du fait que le présent acte documente l'augmentation de capital d'une société luxembourgeoise par
apport d'un pour cent (1%) des parts sociales/actions d'une société ayant son siège dans un pays membre de la Commu-
nauté Européenne, dont la Société détient déjà quatre-vingt dix-neuf pourcent (99%) des parts sociales/actions, la Société
requiert conformément à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, l'exonération du droit d'apport.
<i>Frais et Dépensesi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison du présent acte à environ deux mille cinq cents euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec Nous
notaire le présent acte.
Signé: S. Gudmannsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juillet 2007, Relation: EAC/2007/9043. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 septembre 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007128661/239/144.
(070149036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.
Tower Automotive Holdings VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Tarlot Holding S. à r. l.).
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 131.226.
RECTIFICATIF
L'an deux mille sept, le deux août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Sigurdur Gudmannsson, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'associé unique de la société à responsabilité limitée ci-avant dénommée
TARLOT HOLDING S.à r.l., ayant son siège social à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle procuration est restée annexée à un procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire, reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 juillet 2007, numéro 18203 de son répertoire.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses
déclarations et constatations:
- Que la Société TARLOT HOLDING S.à r.l. a été constituée suivant un acte notarié le 26 juin 2007, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;
- Qu'une assemblée générale extraordinaire tenue par-devant le notaire instrumentant, en date du 25 juillet 2007,
enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 juillet 2007, EAC/2007/9043, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, a décidé entre autre une modification de la dénomination sociale de la Société et une augmen-
tation du capital social de la Société;
- Que par suite d'une erreur matérielle, le nom de l'associé unique a été indiqué tant dans la version anglaise que dans
la version française comme étant TOWER AUTOMATIVE LLC alors que le nom correct est TOWER AUTOMOTIVE
LLC
- Que par ailleurs il a été erronément indiqué tant dans la version anglaise que dans la version française que l'assemblée
modifiait la dénomination sociale de TARLOT HOLDING S.à r.l. en TOWER AUTOMATIVE HOLDINGS VII S.à r.l. alors
que le nom adoptée par l'assemblée est TOWER AUTOMOTIVE HOLDINGS VII S.à r.l.
- Que par conséquent l'acte du 25 juillet 2007 est à modifier partout où besoin en sera par l'indication correcte des
dénominations tant de l'associé que de la société.
127091
- Que toutes les autres dispositions figurant au dit acte du 25 juillet 2007, demeureront inchangées.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Gudmannsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2007. Relation: EAC/2007/9604. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007128662/239/42.
(070149036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.
Plena Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 24.590.
L'adresse du commissaire aux comptes de la société est la suivante depuis le 1
er
septembre 2007:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le mandat de commissaire aux comptes de MONTBRUN FIDUCIAIRE S.à r.l. n'a pas été renouvelé lors de l'assemblée
générale du 13 juin 2003.
Luxembourg, le 9 octobre 2007.
Pour avis
Signatures
Référence de publication: 2007127264/534/16.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2007, réf. LSO-CJ05809. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070146526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Merc Finck, Fonds Commun de Placement.
The management regulations of MERCK FINCK, was deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of
Luxembourg.
For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 14 November 2007.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Le règlement de gestion de MERCK FINCK, a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2007.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2007131711/526/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, réf. LSO-CK03621. - Reçu 76 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070156514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2007.
Sungard Availability Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 60.752.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale de la Société du 15 octobre 2007, que:
1. les mandats de Messieurs Michael J. Ruane, Keith Tilley, et Loic de Montgolfier en tant qu'administrateurs de la
Société ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale statuant en l'année 2008;
2. le mandat de la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprises de la Société a été
renouvelé jusqu'à l'assemblée générale statuant en l'année 2008.
127092
Pour extrait conforme
C. Jungers
Référence de publication: 2007126964/5499/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2007, réf. LSO-CJ06789. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070146533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Internacional de Desarollos Portuarios (I.D.P.) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 106.109.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution de l'associé unique de la Société INTERNACIONAL DE DESAROLLOS PORTUARIOS
(I.D.P.) S.à.r.l., prise en date du 27 juillet 2007, que le siège social de la Société est transféré du 67, rue Michel Welter,
L-2730 Luxembourg au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>INTERNACIONAL DE DESAROLLOS PORTUARIOS (I.D.P.) S.AR.Li> .
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007127263/1211/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2007, réf. LSO-CH03138. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070146888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Solar Generation Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 132.733.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh day of September.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS LP, an English limited partnership, incorporated and existing under the laws of
the United Kingdom, having its registered office at Broughton House, 6-8 Sackville Street, London W1S 3DG, United
Kingdom, registered under number LP 10697,
and
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS S.C.A., a partnership limited by shares, incorporated and existing under the laws
of Luxembourg, with registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg
Trade and Company Register under number B 110.337,
here represented by Ms Laure Gerard, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of two proxies given on September 26, 2007.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing persons, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the
articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
127093
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.
In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take
any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with
its purposes or which are liable to promote their development or extension.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be
convertible.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name SOLAR GENERATION HOLDINGS S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or
in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500) represented by five hundred (500)
shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.
The authorized capital, including the subscribed capital is fixed at two million two hundred fifty thousand Euro (€
2,250,000.-) represented by ninety thousand (90,000) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.
The manager or board of managers is also authorized to issue convertible instruments within the limits of the au-
thorized capital. The manager or board of managers will determine the terms and conditions of the convertible
instruments.
Furthermore, the manager or board of managers is authorized, during a period of five (5) years from the date hereof,
to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital. These increases of capital
may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by
conversion of convertible instruments, by incorporation of claims or in any other way to be determined by the manager
or board of managers. The manager or board of managers is specifically authorized to proceed to such issues without
reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The manager or
board of mangers may delegate to any duly authorized manager or officer of the Company, or to any other duly authorized
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital.
Every time the manager or board of managers acts to render effective an increase of the subscribed capital, the present
article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.
The Company may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements.
Art. 7. The subscribed and the authorized capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder
or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in
direct proportion to the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers, composed of Category A manager(s) and of category B manager(s).
The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.
127094
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its
single manager.
In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the joint signatures
of at least one category A manager and at least one category B manager.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of (i) the
managers present or represented, and (ii) the consent of at least one Category B Manager, with at least the presence or
the representation of at least one Category A Manager and at least one Category B Manager. A meeting attended by a
majority of Managers who are residents from one jurisdiction, which is not Luxembourg is not quorate.
Any meetings of the board of managers must take place in Luxembourg.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the
basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his
powers to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.
Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of
December of each year.
Art. 18. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Board of Managers (or the
sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-
first of December 2008.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, IMPAX NEW ENERGY INVESTORS LP, prenamed, declared
to subscribe four hundred (400) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of ten thousand
Euro (€ 10,000.-) and IMPAX NEW ENERGY INVESTORS SCA prenamed, declared to subscribe one hundred (100)
shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of two thousand five hundred Euro (€ 2,500.-).
127095
The amount of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to
the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at two thousand Euro (€ 2,000.-).
<i>Resolutions of the Shareholdersi>
1) The shareholders resolve to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited period of
time:
<i>Category A Managers:i>
- Mr Peter Rossbach, Investment Manager, born on May 10, 1958 in New York City, United States of America, with
professional address at Broughton House, 6-8 Sackville St, London W1S 3DG.
- Mr Joe Berry, investment manager, born on March 27, 1973 in Falkirk, Scotland, Great Britain, with professional
address at Broughton House, 6-8 Sackville St, London W1S 3DG.
<i>Category B Managers:i>
- Mr Marcel Stephany, chartered accountant, born on September 4, 1951 in Luxembourg, residing at 23, Cité Aline
Mayrisch, L-7268 Bereldange;
- Mr Charles Meyer, chartered accountant, born on April 19, 1969 in Luxembourg, with professional address at 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
The Company will be validly bound towards third parties by the joint signatures of at least one manager of category
A and at least one manager of category B.
2) The shareholders resolve to fix the address of the Company at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-septième jour de septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS LP, une société en commandite simple de droit anglais, ayant son siège social au
Broughton House, 6-8 Sackville Street, London W1S 3DG, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro LP 10697 et
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS S.C.A., une société en commandite par actions, constituée et établie sous les lois
du Luxembourg, avec siège social à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg N
o
B 110.337,
ici représentées par Melle Laure Gerard, employée privée, avec adresse professionnelle à 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, en vertu de deux procurations données le 26 septembre 2007.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
d'une Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
16, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
127096
En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou
immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres ins-
truments qui pourront être convertibles.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination SOLAR GENERATION HOLDINGS S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales
d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.
Le capital autorisé, y inclus le capital souscrit est fixé à deux million deux cent cinquante mille Euro (€ 2.250.000,-)
représenté par quatre-vingt-dix mille (90.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.
Le gérant ou conseil de gérance est aussi autorisé à émettre des instruments convertibles dans les limites du capital
autorisé. Le gérant ou conseil de gérance déterminera les termes et conditions de ces instruments convertibles.
En outre le gérant conseil de gérance est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de ce jour, autorisé à augmenter
en temps qu'il appartienne le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme de parts sociales avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en
nature ou en numéraire, par conversion d'instruments convertibles, par compensation ou de toute autre manière à
déterminer par le gérant ou conseil de gérance. Le gérant ou conseil de gérance est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux associés antérieurs un droit préférentiel de souscription des parts sociales à émettre.
Le gérant ou conseil de gérance peut déléguer toute personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et
recevoir paiement du prix des parts sociales représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le gérant ou conseil de gérance aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales, sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Le capital souscrit et la capital autorisé peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique
ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par parts sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique; en cas de pluralité de
gérants, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants, dont, au moins, la signature d'un
gérant de catégorie A et la signature d'un gérant de catégorie B.
Toutes réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Luxembourg.
127097
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité de (i) tous les gérants
présents ou représentés, et (ii) le vote favorable d'au moins un gérant de catégorie B, avec au moins la présence ou la
représentation d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B. Une réunion à laquelle une majorité des gérants
sont des résidents d'une seule juridiction qui n'est pas le Luxembourg, ne réunit pas le quorum nécessaire.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du Conseil de Gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes
sur base d'un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie
de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 16. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la
même année.
Art. 18. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil
de Gérance) prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être
distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2008.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, IMPAX NEW ENERGY INVESTORS LP, désignée ci-dessus, déclare
souscrire quatre cents (400) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en numéraire de dix
mille Euro (€ 10.000,-) et IMPAX NEW ENERGY INVESTORS SCA, désignée ci-dessus, déclare souscrire cent (100)
parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en numéraire de deux mille cinq cents Euro (€
2.500,-).
Un montant de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à
présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euro (€ 2.000,-).
127098
<i>Décisions des Associési>
1) Les associés décident de nommer les personnes suivantes en leur qualité de gérants de la Société pour une durée
indéterminée:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Monsieur Peter Rossbach, Gérant en investissement, né le 10 mai 1958 à New York, Etats-Unis d'Amérique, avec
adresse professionnelle à Broughton House, 6-8 Sackville St, Londres W1S 3DG, Royaume Uni;
- Monsieur Joe Berry, Gérant en investissement, né le 27 mars 1973 à Falkirk, Ecosse, Grande-Bretagne, avec adresse
professionnelle à Broughton House, 6-8 Sackville St, Londres W1S 3DG, Royaume Uni.
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur Marcel Stephany, expert-comptable, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, demeurant à 23, Cité Aline
Mayrisch, L-7268 Bereldange;
- Monsieur Charles Meyer, expert-comptable, né le 19 avril 1969 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
La Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'au moins un gérant de catégorie A et d'au moins un
gérant de catégorie B.
2) Les associés décident de fixer l'adresse du siège social à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: L. Gerard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2007, Relation: LAC/2007/28911 — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007127773/211/329.
(070147397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2007.
Inventum S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 113.775.
L'adresse du commissaire aux comptes de la société est la suivante depuis le 1
er
septembre 2007:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 octobre 2007.
Pour avis
Référence de publication: 2007127266/534/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2007, réf. LSO-CJ05821. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070146516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Datagest, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 42.842.
L'adresse de l'associé inscrit au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 70 422 est désormais la suivante:
COMPAGNIE FIDUCIAIRE GROUP Société à responsabilité limitée, 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg
127099
Luxembourg, le 5 octobre 2007.
Pour avis
Signature
Référence de publication: 2007127272/534/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ04809. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070146492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Luxequip Bail S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.-F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 81.019.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue le 14 septembre 2007i>
- L'Assemblée Générale renouvelle à l'unanimité le mandat des administrateurs pour une durée de un an:
J. Hausler, Directeur Général de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, demeurant professionnelle-
ment à F-57021 Metz, 3, rue François de Curel.
B. Wurm, Secrétaire Général de BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, demeurant professionnellement
à F-57021 Metz, 3, rue François de Curel.
B. Moreau, Directeur Général Adjoint de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, demeurant profes-
sionnellement à F-57021 Metz, 3, rue François de Curel.
Leurs fonctions d'administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de
l'année 2007.
- L'Assemblée Générale renouvelle à l'unanimité le cabinet PKF ABAX AUDIT, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg
en tant que réviseur d'entreprises pour une durée de un an renouvelable.
Sa fonction de réviseur d'entreprises prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de
l'année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>PKF WEBER ET BONTEMPS
Signature
Référence de publication: 2007127767/592/27.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03936. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070147166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2007.
Tasaco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 96.915.
<i>Auszug aus den Protokollbeschlüssen der alleinigen Gesellschafterini>
Gemäß dem Protokoll der Beschlüsse vom 5. Juli 2007 hat die alleinige Gesellschafterin der TASACO S. à r. I. be-
schlossen,
(i) den Rücktritt des Geschäftsführers Thomas Smith mit sofortiger Wirkung anzunehmen,
(ii) den Rücktritt des Geschäftsführers Charles William Simmons mit sofortiger Wirkung anzunehmen,
(iii) Herr John May, «Company Director», geboren am 11.Mai 1953 in Sheffield, U.K., wohnhaft at Bushel Barn, Pickwick
Lodge, Corsham, SN13 OPS, U.K., zum neuen Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer zu ernennen
Den 23. August 2007.
Unterschrift.
Référence de publication: 2007127275/534/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2007, réf. LSO-CI07169. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070146486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
127100
Clearstream Services, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 60.911.
Le bilan de CLEARSTREAM SERVICES au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2007.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007127292/2229/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06130. - Reçu 52 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070147029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Jetcom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 132, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 49.339.
Constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M
e
Jean Seckler, notaire alors de résidence
à Junglinster, en date du 2 décembre 1994, publié au Mémorial C no 83 du 1
er
mars 1999, modifié par-devant M
e
Jean Seckler, en date du 23 décembre 1998, publié au Mémorial C no 227 du 1
er
avril 1999. Le capital a été converti
en EUR en date du 17 septembre 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C no 396 du 12 mars 2002, modifiée
par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2006, l'avis afférent a été publié au Mémorial C no 365 du 13 mars
2007.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2007.
<i>Pour JETCOM S.àr.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007127336/1261/21.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2007, réf. LSO-CJ06856. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070146506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Immobilière Espace Kirchberg A S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 77.897.
Le bilan de IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG A au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2007.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007127293/2229/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06127. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070147032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
127101
Flipo Participations S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 115.658.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2007.
FLIPO PARTICIPATIONS S.A.R.L.
Signature
Référence de publication: 2007127294/2051/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2007, réf. LSO-CJ05097. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070146933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Interas S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 19.920.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 mai 2007i>
- Les démissions des sociétés FINDI S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, LOUV Sà rl, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec
siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et MADAS Sà rl, société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg de leur mandat d'Administrateur sont
acceptées.
- Madame Isabelle Schul, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, Monsieur Jean-François Detaille, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg et Mademoiselle Noëlle Piccione, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg sont nommés comme nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leur mandat viendra à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.
Luxembourg, le 21 mai 2007.
Certifié sincère et conforme
<i>INTERAS S.A.
i>N. Piccione / J.-F. Detaille
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007127750/795/25.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2007, réf. LSO-CJ05738. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070147590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2007.
Foncier & Participations S.A., Société Anonyme,
(anc. Sichel S.A.).
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 5.322.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>FONCIER & PARTICIPATIONS S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2007127295/2059/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2007, réf. LSO-CI00345. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070146936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
127102
Grands Magasins Porte Ouverte, Société Anonyme.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.
R.C.S. Luxembourg B 10.539.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>GRANDS MAGASINS PORTE OUVERTE S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2007127296/2051/13.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2007, réf. LSO-CJ05096. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070146937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Immobilière de la Ville Haute S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 84.314.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IMMOBILIERE DE LA VILLE HAUTE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007127297/2060/13.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2007, réf. LSO-CJ05100. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070146939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Hot Stuff S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 83.899.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>L'Administrateur-Déléguéi>
Référence de publication: 2007127347/2741/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07330. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070146306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Maga S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 89.362.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAGA S.A.
Signature
Référence de publication: 2007127298/1981/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2007, réf. LSO-CI00341. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070146942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
127103
Presta-Gaz S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue des Chemins de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 9.648.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRESTA-GAZ S.A.
Signature
Référence de publication: 2007127299/2061/13.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2007, réf. LSO-CJ05102. - Reçu 38 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070146944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Cegyco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7740 Colmar-Berg, avenue T.G. Smith.
R.C.S. Luxembourg B 58.432.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration de CEGYCO tenus le 5
juin 2007:
que
- Monsieur André Baldauff, administrateur, 75, rue François Boch, L-1244 Luxembourg
a pris la retraite au 31 août 2006
- le conseil d'administration de la société se compose comme suit:
MM. Eric Mauer, administrateur, L-7209 Walferdange, rue G.-D. Charlotte, 18
Nestor Didelot, administrateur, L-8295 Keispelt, rue de Kehlen, 110
Hermann Lange, président et administrateur L-9142 Burden, Im Rothfeld, 21
Pascal Pixius, administrateur, L-8508 Redange, rue de la Piscine, 10
Carlo Polidori, administrateur, L-3332 Fennange, rue des Alouettes, 3
Louis Reiles, administrateur, L-9068 Ettelbruck, rue Philippe Manternach, 24
les personnes responsables de la gestion journalière sont:
MM. Eric Mauer, L-7209 Walferdange, rue G.-D. Charlotte, 18
Pascal Pixius, L-8508 Redange, rue de la Piscine, 10
- le mandat de révision est confié à ERNST & YOUNG DE LUXEMBOURG, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach
La durée du mandat est d'une année, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2007.
Strassen, le 19 octobre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007127523/2846/28.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07732. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070146706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Transbella Participation & Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R.C.S. Luxembourg B 109.329.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 24 octobre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007127437/3004/12.
Enregistré à Diekirch, le 15 octobre 2007, réf. DSO-CJ00133. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070146608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
127104
AELF Management S.à r.l.
Albaha Holdings S.A.
Athena Sicav
Calzedonia Finanziaria S.A.
Carolus Investment Corporation
Cegyco S.A.
Clearstream Services
Datagest
Dexia Protected
Digital Assets Group S.A.
Dominos Luxembourg S.A.
Flipo Participations S.àr.l.
Foncier & Participations S.A.
Franklin Templeton Investment Funds
GELF Management (Lux) S.à r.l.
GEM2
Gemmy Holding S.A.
George and Dragon
Goodman European Logistics Fund
Grands Magasins Porte Ouverte
Historia S.A.
Hot Stuff S.A.
HVB Bonus Fonds DJ EURO STOXX® 12/2013
Immobilière de la Ville Haute S.A.
Immobilière Espace Kirchberg A S.A.
Immo Teb SA
Interas S.A.
Internacional de Desarollos Portuarios (I.D.P.) S.à.r.l.
Inventum S.A.
IVG European Core+ Office
IVG European Core+ Office
Jetcom S.à r.l.
KBC Institutionals - I
L.T.T. Holding S.A.
Lux-Avantage Sicav
Lux-Croissance
Luxequip Bail S.A.
Lux-Equity
Lux-Garantie
Maga S.A.
Merc Finck
Plena Holding S.A.
Portfolio Selection Sicav
Presta-Gaz S.A.
PVM S.A.
Sichel S.A.
Sifter Fund
Solar Generation Holdings S.à r.l.
Spanimmo
Sports Group Development S.A.
Sungard Availability Services (Luxembourg) S.A.
Tadler Investments S.A.
Tarlot Holding S. à r. l.
Tarlot Holding S. à r. l.
Tasaco S.à r.l.
Terravera S.A.
Tower Automotive Holdings VII S.à r.l.
Tower Automotive Holdings VII S.à r.l.
Transbella Participation & Finance S.A.
Trief Corporation S.A.
Truth 1 S.à r.l.
X-Trem Bananas S.àr.l.