This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1878
4 septembre 2007
SOMMAIRE
214 Wilson S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90124
4Climate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90142
Accounting Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
90139
Agrion d'Or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90137
Anglo American Ferrous Investments . . .
90142
Anglo American International . . . . . . . . . . .
90143
Anglo American Investments 6 . . . . . . . . . .
90143
Anglo American Investments 7 . . . . . . . . . .
90142
Anglo Coal Cerrejon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90129
Auto Media Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
90136
Balo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90123
Bartz Constructions S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
90141
Cadanor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90130
Capellen Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90144
CB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90144
Centre Comptable S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
90139
Cobelpin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90139
Constant Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
90123
Damode-MG Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
90130
diffusion saint-paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90127
Eurostar Overseas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
90141
Fondation Pauline de Faillonnet . . . . . . . . .
90126
Fortis Luxembourg-Vie S.A. . . . . . . . . . . . .
90141
Framsteget S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90137
Gallo S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90138
Gallo S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90127
Gallo Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90138
HAWK Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90140
HAWK Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
90140
Hobbes Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90140
Itstream S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90125
Jack (Cologne 20) S. à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
90138
Jack (Cologne 21) S. à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
90139
Jumbio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90144
Kiffer Impress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90128
Kruger Brent Luxembourg Holding S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90124
Lumedia Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90129
Luxlorbois, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90144
Marbre Investissements S.A. . . . . . . . . . . . .
90142
Matrix Dynamic Real Estate Portfolio S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90098
MGP Europe (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
90128
MGP Europe Parallel (Lux) S.à r.l. . . . . . . .
90129
MGP Pope S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90128
Montemar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90136
MYTransfer Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
90141
North & South Airlogistics . . . . . . . . . . . . . .
90124
Omaha International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
90138
Permalux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90136
Pharos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90125
Quadriga Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
90123
Restaurant-Brasserie des Bateliers S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90127
Resultatsystem Internationell . . . . . . . . . . .
90137
SBS European Pay TV Services . . . . . . . . . .
90130
STEPEC PROMOTION Luxembourg
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90143
Transnational Financial Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90127
Universal Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . .
90098
Valessore Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
90142
Videofin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90137
White Knight S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90123
Wong's S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90128
WSC S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90098
90097
Universal Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5402 Assel, 31, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 117.359.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Weber
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007087360/236/11.
(070096759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
WSC S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 65, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 110.040.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Weber
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007087362/236/11.
(070096757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Matrix Dynamic Real Estate Portfolio S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 125.011.
In the year Two Thousand and Seven, on the twenty-fourth of May,
Before Us, Maître Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MATRIX DYNAMIC REAL ESTATE PORTFOLIO S.A.,
a «société anonyme» having its registered office at 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituted by a deed of
the undersigned notary on 24 January 2007, not yet published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
(hereinafter referred to as the «Company»).
The meeting was opened by Mr Jacques De Patoul, lawyer, residing professionally in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Nicolas Ronzel, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Creation of three classes of shares (A Shares, B Shares and C Shares) having different rights relating to the ap-
pointment of directors of the Company and of members of the Investment Committee of the Company;
2. Conversion of the existing 24,800 (Twenty-four Thousand Eight Hundred) shares with a par value of EUR 1.25 (One
Euro and Twenty-Five Cents) each into 800 (Eight Hundred) B Shares and 24,000.- (Twenty-Four Thousand) C Shares
with a par value of EUR 1.25 (One Euro and Twenty-Five Cents) each;
3. Allocation of these new Shares to the current shareholders of the Company as follows:
- 800 (Eight Hundred) B Shares to MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT LLP; and
- 24,000 (Twenty-Four Thousand) C Shares to MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED.
4. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 89,000.- (Eighty-Nine Thousand Euro),
in order to raise the subscribed share capital from its current amount of EUR 31,000.- (Thirty-One Thousand Euro) to
EUR 120,000.- (One Hundred and Twenty Thousand Euro) by the issuance of 48,000 (Forty-Eight Thousand) A Shares
and 23,200 (Twenty-Three Thousand Two Hundred) B Shares with a par value of EUR 1.25 (One Euro and Twenty-Five
Cents) each, being 71,200 (Seventy-One Thousand and Two Hundred) new Shares in total to be fully paid-up at their par
value;
5. Waiver, to the extent necessary, by the existing shareholders of their preferential subscription right, subscription
and full payment of the newly issued Shares by means of contribution in cash as follows:
90098
- UBERIOR EUROPE LIMITED will subscribe for 48,000 (Forty-Eight Thousand) A Shares with a par value of EUR 1.25
(One Euro and Twenty-Five Cents) each; and
- MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT LLP will subscribe for 23,200 (Twenty-Three Thousand Two Hundred)
B Shares with a par value of EUR 1.25 (One Euro and Twenty-Five Cents) each;
6. Subsequent full restatement of the articles of association of the Company, including also, amongst others, the
following amendments:
- Change of the fiscal year of the Company, and change of the date of the holding of the Annual General Meeting of
the Company;
- Amendment of the modalities of appointment and removal of the directors of the Company;
- Modification of the procedures of the meetings of the board of directors of the Company;
- Establishment of an Investment Committee, nomination and appointment of its members, determination of their
competences and duties, and adoption of rules of procedure for the Investment Committee;
- Amendment of the modalities of transfer of shares.
7. Appointment, with immediate effect of the following persons as directors of the Company with the following des-
ignations:
- Derek McDonald as A Director;
- Ian Blake as B Director;
- Hille-Paul Schut as C Director;
- François Pfister, Jacques de Patoul, and such other person as may be nominated to a list of proposed Board candidates
by the A Shareholder as D Directors;
8. Appointment, with immediate effect of KPMG as Statutory Auditor of the Company in replacement of Pricewater-
houseCoopers;
9. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy-holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy-holders of the
represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list that all the 24,800 (Twenty-Four Thousand Eight Hundred) shares repre-
senting the whole share capital of EUR 31,000.- (Thirty-One Thousand Euro) are present or represented at the present
extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously and separately took the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general shareholders' meeting resolves to create three classes of shares (A Shares, B Shares and C Shares) having
different rights relating to the appointment of directors of the Company and of members of the Investment Committee,
as described in the restated articles below.
<i>Second resolutioni>
The general shareholders' meeting resolves to convert the existing 24,800 (Twenty-Four Thousand Eight Hundred)
shares with a par value of EUR 1.25 (One Euro and Twenty-Five Cents) each into 800 (Eight Hundred) B Shares and
24,000 (Twenty-Four Thousand) C Shares with a par value of EUR 1.25 (One Euro and Twenty-Five Cents) each, having
different rights relating to the appointment of directors of the Company and of members of the Investment Committee.
<i>Third resolutioni>
The general shareholders' meeting resolves to allocate these new Shares to the current shareholders of the Company
as follows:
- 800 (Eight Hundred) B Shares to MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT LLP; and
- 24,000 (Twenty-Four Thousand) C Shares to MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED.
<i>Fourth resolutioni>
The general shareholders' meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of
EUR 89,000.- (Eighty-Nine Thousand Euro), in order to raise the subscribed share capital from its current amount of EUR
31,000.- (Thirty-One Thousand Euro) to EUR 120,000.- (One Hundred and Twenty Thousand Euro) by the issuance of
48,000 (Forty-Eight Thousand) A Shares and 23,200 (Twenty-Three Thousand Two Hundred) B Shares with a par value
of EUR 1.25 (One Euro and Twenty-Five Cents) each, being 71,200 (Seventy-One Thousand and Two Hundred) new
Shares in total to be fully paid-up at their par value.
90099
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared the existing shareholders («Current Shareholders») of the Company:
- MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT LLP, a limited liability partnership incorporated in England and Wales
having its registered office at One Jermyn Street, London, SW1Y 4UH; and
- MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, a company incorporated in Guernsey with
registered number 41754 and having its registered office at Investec House, 2a Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1
3RD;
MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT LLP and MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY)
LIMITED here both represented by Mr. Jacques de Patoul, employee, residing in Luxembourg, acting by virtue of two
proxies given on 22nd May 2007.
as well as the following additional subscriber («Additional Subscriber»):
- UBERIOR EUROPE LIMITED, a private limited company incorporated in Scotland under the Companies Acts under
number SC299325 and having its registered office at 4th Floor, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh, EH12 5HD
(UBERIOR).
Here represented by Mr Nicolas Ronzel, prenamed,
acting by virtue of a proxy given on 23rd May 2007,
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Current Shareholders, represented as stated hereinabove, declare to waive partially their preferential subscription
rights in favor of the Additional Subscriber for as much as necessary.
MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT LLP and the Additional Subscriber, represented as stated hereinabove,
have declared to subscribe for the number of newly issued Shares with a par value of EUR 1.25 (One Euro Twenty-Five
Cents) each and to have paid them fully up by contribution in cash, in the proportion as indicated opposite to their names
in the table below:
Subscribers
Number
Type
Amount
of shares
of
paid in
subscribed
shares
Euro
UBERIOR EUROPE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48,000
A Shares
60,000.-
MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT LLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23,200
B Shares
29,000.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71,200
N/A
89,000.-
Evidence of the payment of the newly issued Shares has been given to the undersigned notary by means of a bank
certificate, so that the amount of Eighty-Nine Thousand Euro (89,000.- EUR) is from now on at the disposal of the
Company.
<i>Fifth resolutioni>
The general shareholders' meeting resolves to proceed to a complete restatement of the articles of association, in
order to reflect the above resolutions and to proceed, among others, to (i) the amendment of the modalities of appoint-
ment and removal of the directors of the Company, (ii) the modification of the procedures of the meetings of the board
of directors of the Company, (iii) the establishment of an Investment Committee, the nomination and appointment of its
members, the determination of their competences and duties, and the adoption of rules of procedure for the Investment
Committee and (iv) the amendment of the modalities of transfer of shares, so that the articles of association shall hence-
forth read as follows:
MATRIX DYNAMIC REAL ESTATE PORTFOLIO S.A.
Coordinated articles
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the
shares hereafter issued a Company in the form of a société anonyme, under the name of MATRIX DYNAMIC REAL
ESTATE PORTFOLIO S.A., which will be governed by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (hereafter the «Law») as well as by the present articles of association.
Art. 2. Definitions. In addition to the other terms defined in other clauses of these articles of association, the following
words and terms shall have the following meanings if and when written with capital letters:
«A Shareholder» means UBERIOR EUROPE LIMITED, a private limited company incorporated in Scotland under the
Companies Acts under number SC299325 and having its registered office at 4th Floor, Citypoint, 65 Haymarket Terrace,
Edinburgh, EH125HD, or any person to whom its A Shares are transferred from time to time in accordance with these
Articles and/or any shareholders agreement which might have been entered into by all Shareholders from time to time;
«A Shares» means the ordinary shares of class A and «A Share» means any of them;
«Affiliate» means, in relation to any specified person:
90100
(a) any other person directly or indirectly controlling or controlled by, or under direct or indirect common Control
with, the specified person; or
(b) any other person or fund managed by the specified person.
«Articles» means these articles of association in their present form and as amended from time to time in accordance
with any shareholders' agreement which might have been entered into by all shareholders from time to time (and «Article»
shall be construed accordingly);
«B Shares» means the ordinary shares of class B and «B Share» means any of them;
«B Shareholder» means MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT LLP, a limited liability partnership incorporated
in England and Wales having its registered office at One Jermyn Street, London, SW1Y 4UH, or any person to whom its
B Shares are transferred from time to time in accordance with these Articles and/or any shareholders agreement which
might have been entered into by all Shareholders from time to time;
«Business» means the business of the Company described in Article 4;
«Business day» means any calendar day (other than a Saturday or a Sunday) on which banks are open for business in
Luxembourg.
«Business Plan» means the financial business plan for the Group relating to the financial year of the Company ending
on 30 June 2008, and four succeeding financial years of the Company (in a format approved from time to time by the
Board of Directors) to be updated annually or any other business plan prepared in accordance with any shareholders
agreement entered into by the Company and each of the Shareholders from time to time;
«C Shareholder» means MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, a company incorpo-
rated in Guernsey with registered number 41754 and having its registered office at Investec House, 2a Plaiderie, St Peter
Port, Guernsey GY1 3RD, or any person to whom its C Shares are transferred from time to time in accordance with
these Articles and/or any shareholders agreement which might have been entered into by all Shareholders from time to
time;
«C Shares» means the ordinary shares of class C and «C Share» means any of them;
«Company» means the société anonyme MATRIX DYNAMIC REAL ESTATE PORTFOLIO S.A. governed by these
Articles;
«Company Act» means the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to
time;
«Control» means the possession, direct or through one or more intermediaries or together with persons acting in
concert of the power to direct or cause the direction of the management of any person (including but not limited to the
power to appoint or remove a majority of the board of any company or otherwise direct full control of the board of any
company) and, without limitation, an interest in shares in the capital of a company conferring in excess of 50% or more
of the total voting rights conferred by all the issued shares in the capital of that company shall be deemed to confer control
of that company;
«Group» means the Company and any directly or indirectly wholly owned subsidiary of it from time to time and the
expression «member of the Group» shall be construed accordingly;
«Shareholders» means the holders of Shares of any class and «Shareholder» means any of them;
«Shareholders Register» means the register of the Shareholders of the Company;
«Shares» means the shares of any class and «Share» means any of them;
«Unwanted Call Shares» means, in respect of any Offer Notice served in terms of Clause 6.3.2.3, any Call Shares
offered to any Offeree as its pro rata share in terms of Clause 6.3.2.3 which the relevant Offeree has not stated its
willingness to purchase before the expiry of such Offer Notice.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 4. Object.
4.1. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind
(including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of
its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
4.2. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type
of equity or debt instruments (convertible or not).
4.3. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, companies under
a common control with the Company or any other company it deems fit (including but not limited to the granting of any
type of loans, guarantees or security), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation,
which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
4.4. In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance,
whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of
90101
the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company
and of any of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest, or any director, manager
or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies, within the limits of any applicable law provision.
4.5. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions
relating directly or indirectly to real estate or movable property.
4.6. The Company may further act as a director for other companies and manage such companies, which must not
necessarily be subsidiaries of the Company.
Art. 5. Registered office.
5.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office of the Company
may be transferred within the City of Luxembourg by decision of the Board of Directors. Branches or other offices may
be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.
5.2. If the Board of Directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which
are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with abroad,
the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned
to normal. Such measures will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such provisional transfer
of the registered office, if any, remain a Luxembourg company.
Art. 6. Capital - Authorised Capital - Shares and Share Certificates.
6.1. Capital
The Company's subscribed corporate capital is set at EUR 120,000.- (One Hundred and Twenty Thousand Euros)
divided into 96,000 (Ninety-Six Thousand) shares of EUR 1.25 (One Euro Twenty-Five Cents) each, divided into:
(a) 48,000 (Forty-Eight Thousand) A Shares with a par value of EUR 1.25 (One Euro Twenty-Five Cents) each, and
(b) 24,000 (Twenty-Four Thousand) B Shares with a par value of EUR 1.25 (One Euro Twenty-Five Cents) each
(c) 24,000 (Twenty-Four Thousand) C Shares with a par value of EUR 1.25 (One Euro Twenty-Five Cents) each.
6.2. Authorised Capital
6.2.1. Besides and apart from the subscribed capital, the authorised capital of the Company is set at EUR 120,000.-
(One Hundred and Twenty Thousand Euros) to be divided into 48,000 (Forty-Eight Thousand) Class A Shares with a par
value of EUR 1.25 (One Euro Twenty-Five Cents) each, 24,000 (Twenty-Four Thousand) Class B Shares with a par value
of EUR 1.25 (One Euro Twenty-Five Cents) each and 24,000 (Twenty-Four Thousand) Class C Shares with a par value
of EUR 1.25 (One Euro Twenty-Five Cents) each.
6.2.2. The Board of Directors is authorised, during a period of five years, ending on 24 January 2012, to issue convertible
debt or equity instruments and/or to increase once or several times the subscribed capital within the limits of the au-
thorised capital, following the conversion of the debt or equity instruments as applicable, up to a total amount of EUR
240,000.- (Two Hundred and Forty Thousand Euros). Such increased amount of capital may be subscribed by and issued
to with or without an issue premium, as the Board of Directors may from time to time determine.
6.2.3. The Board of Directors is especially authorised to proceed to such issues without reserving to the existing
shareholders a preferential right to subscribe the Shares so issued.
6.2.4. Further, the Board of Directors is authorised and empowered to carry out any increase of the capital within the
limits of the authorised share capital in one or several successive tranches, against payment in cash or in kind, by conversion
of claims, integration of reserved profits or any other manner and to determine the place and date of the issue or the
successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new Shares.
6.2.5. The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company, or to any other
duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Shares representing part or all
of such increased amount of capital.
Upon each increase of the share capital of the Company by the Board of Directors within the limits of the authorised
share capital, the amount of the authorised share capital specified in Article 6.2.1 of the Articles shall be deemed to be
decreased by an amount corresponding to such capital increase. Therefore the amounts specified in Articles 6.1 and 6.2.1
of the Articles will be amended accordingly pursuant to each notarial deed recording the relevant increase of the share
capital under Article 6.2 of the Articles.
6.3. Shares and Transfer of Shares
6.3.1. Shares
The Shares shall be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the register of shareholders as
the full owner of such Shares.
Certificates stating such inscription shall be delivered to the Shareholders. Transfers of registered Shares shall be
effected by declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons granted suitable powers of attorney to that effect.
6.3.2 Transfer Restrictions
90102
6.3.2.1 Conditions applicable to Transfers
Completion of any transfer of Share pursuant to this Article 6.3.2 shall be done in compliance with any shareholders'
agreement which might have been entered into by the Company and all shareholders from time to time subject to the
condition that any transferee, who is not already a Shareholder shall first have executed and delivered a deed of adherence
(the «Deed of Adherence») in a legally binding manner providing that such transferee will become party to any such
shareholders' agreement and that any hares held by such transferee will be subject to the provisions of any such share-
holders' agreement.
6.3.2.2. Permitted Transfers
During a period of five years from the date the shareholders become parties to a shareholders agreement (the «Five
Year Period»), as the case may be, Shares shall not be transferred by a Shareholder without the consent of the other
Shareholders, except (i) for a transfer of shares effected in accordance with a shareholders agreement which might have
been entered into by the Company and the Shareholders from time to time and (ii) except for a transfer of Shares effected
in compliance with Article 6.3.2.3.
After the Five Year Period the Shareholder wishing to sell any of its Shares must first give notice of such fact to the
other Shareholders of the Company setting out the details of the Shares to be transferred and of the price per Share as
have been offered by a bona fide third party. The other Shareholders shall have the right, but not the obligation, to
purchase (pro rata to their own shareholding in the Company), the relevant Shares on the same terms and conditions as
have been offered by the bona fide offeror. These other Shareholders are free to accept the offer by exercising their pre-
emption right, within 14 days after receipt of the notice. After this period, the offer to the other Shareholders will collapse
and the Shareholder wishing to sell its Shares may conclude with the bona fide third party upon no less favourable terms
than those on which the shares were offered to the other Shareholders.
6.3.2.3. Call Option
6.3.2.3.1 Where a Default Event (as defined in a shareholders agreement the Company may have entered into from
time to time) has occurred in respect of a Shareholder (the «Defaulting Shareholder»), then that Defaulting Shareholder
grants to the other Shareholders (the «Non Defaulting Shareholders») an option (the «Call Option») entitling the Non
Defaulting Shareholders to acquire from the Defaulting Shareholder all the Shares held by the Defaulting Shareholder
(the «Call Shares») at the Fair Value (as defined in a shareholders agreement the Company may have entered into from
time to time) of those Call Shares (the «Default Price») and on the terms of this Clause 6.3.2.3. Such Call Option shall
be exercisable by any Non-Defaulting Shareholder serving written notice on the Defaulting Shareholder, the Company
and each other Shareholder to the effect that they wish to exercise the Call Option hereunder («Call Notice»). Once
given a Call Notice cannot be withdrawn except with the written consent of all the Shareholders.
6.3.2.3.2 Where a Call Notice has been served in accordance with Clause 6.3.2.3.1., the Company shall give an offer
notice (the «Offer Notice») to all the Shareholders that have been granted with the Call Option in accordance with this
Clause 6.3.2.3 within ten (10) Business Days after the later of:
- the date that the Fair Value is agreed or determined (as the case may be); and
- receipt by the Company of the copy of the Call Notice.
6.3.2.3.3 Where the Call Option is exercised, any Call Shares held by the Defaulting Shareholders specified in column
(1) in the table below shall be offered to the Shareholders (the «Offerees») as follows:
- in the first instance to all persons in the category set out in the corresponding line in column (2) in the table below
pro rata in accordance with their shareholdings; and
- to the extent not exercised by persons in column (2), to all persons in the category set out in the corresponding line
in column (3) in the table below pro rata in accordance with their shareholdings;
but any Defaulting Shareholder in respect of whom a Call Notice has been given and which Call Notice is contempo-
raneously subsisting will not be entitled to exercise the Call Option:
(1)
(2)
(3)
Class of Sale Shares
First Stage Option
Second Stage Option
Call Shares held by Defaulting A Shareholders . . . . . . . . . . . . . . . . .
B Shareholder(s) and
N/A
C Shareholder(s)
Call Shares held by Defaulting B Shareholders . . . . . . . . . . . . . . . . .
C Shareholder(s)
A Shareholder(s)
Call Shares held by Defaulting C Shareholders . . . . . . . . . . . . . . . . .
B Shareholder(s)
A Shareholder(s)
6.3.2.3.4 The Company shall invite each of the Offerees as aforesaid to state in writing within fifteen (15) Business
Days after service of the Offer Notice whether it is willing to purchase any proportion of the Call Shares each of the
offerees has the option to acquire and, if so, the maximum proportion it is willing to purchase.
6.3.2.3.5 The Company shall at that time also enquire from each of the Offerees:
- whether or not it is interested in acquiring any Unwanted Call Shares; and
- if so, the proportion of Unwanted Call Shares which it is willing to purchase.
90103
6.3.2.3.6 If the Company shall pursuant to the above provisions of this Clause 6.3.2.3. find Offerees willing to exercise
the Call Option so as to acquire all of the Call Shares within the period prescribed by Clause 6.3.2.3.4, the Company shall
within five (5) Business Days of the expiry date of the Offer Notice:
- allocate such Call Shares to and amongst such Offerees in accordance with the above provisions of this Clause 6.3.2.3.,
provided that none of the Offerees shall be obliged to acquire more Call Shares that the maximum specified by it under
Clauses 6.3.2.3.4. or 6.3.2.3.5; and
- forthwith give notice in writing (a «Sale Notice») to the Defaulting Shareholder, to each person to whom the Call
Shares have been allocated (each a «Purchasing Shareholder») and to each and any other Shareholder specifying:
- the name and address of the relevant Purchasing Shareholder(s);
- the proportion of the Call Shares agreed to be purchased by the relevant Purchasing Shareholder;
- the total price payable by the relevant Purchasing Shareholder; and
- that completion of the sale and purchase will take place twenty (20) Business Days after (and excluding) the date of
such Sale Notice.
6.3.2.3.7 Completion of a sale and purchase of Call Shares pursuant to a Sale Notice shall take place at the registered
office of the Company at the time specified in the Sale Notice when the Defaulting Shareholder shall, upon payment to
it by a Purchasing Shareholder of the Default Price in respect of the Call Shares allocated to that Purchasing Shareholder,
duly execute a transfer to that Purchasing Shareholder of the relevant proportion of the Call Shares (and/or any other
documentation or waivers required to effect the transfer of the Call Shares, as may be required under the constitutional
documents of the Company or by Luxembourg law). The Call Shares shall be sold together with all rights, attaching
thereto as at the date of the Call Notice, including the right to any distribution declared or payable on those Call Shares
in the Company after that date.
6.3.2.3.8 If the Defaulting Shareholder fails for any reason to duly execute an assignment in respect of any Call Shares
(and/or any other documentation or waivers required to effect the transfer of the Call Shares, as may be required under
the constitutional documents of the Company or by Luxembourg law) when required pursuant to this Clause 6.3.2.3.:
- the Company may receive the purchase money for such Call Shares from the Purchasing Shareholder(s) and shall
upon receipt register the Purchasing Shareholder(s) as the holder of such Call Shares;
- the Company shall hold such purchase money in a separate bank account on trust for the Defaulting Shareholder
but shall not be bound to earn or pay interest on any money so held;
- the Company's receipt for such purchase money shall be a good discharge to the Purchasing Shareholder(s) who
shall not be bound to see to the application of it; and
- after the name of the Purchasing Shareholder(s) has been entered in the shareholders register in purported exercise
of the power conferred by this Clause 6.3.2.3., the validity of the proceedings shall not be questioned by any person.
6.3.2.3.9 If the Company shall pursuant to the above provisions of this Clause 6.3.2.3. find Offerees willing to purchase
all of the Call Shares, the Defaulting Shareholder shall be obliged to sell or procure that there is sold (and the Purchasing
Shareholder(s) shall become bound to purchase in the same proportions as the Call Shares) any and all loans made by
the Defaulting Shareholder to the Company (if any and whether in certificated form or not) at par, together with accrued
interest thereon, if any. Such sale and purchase shall be completed at the same time as the sale and purchase of the Default
Shares pursuant to Clause 6.3.2.3.7 and, to the extent appropriate, the provisions of Clauses 6.3.2.3.7 and 6.3.2.3.8 shall
apply mutatis mutandis to the sale of such loans.
6.3.2.3.10 If the Call Option has not been exercised with respect to all of the Call Shares pursuant to the above
provisions of this Clause 6.3.2.3. within the period prescribed by Clause 6.3.2.3.4:
- the Company shall within five (5) Business Days of the expiry date of the Offer Notice notify each Shareholder
accordingly; and
- the provisions of a shareholders' agreement the Company may have entered into from time to time shall apply.
Art. 7. Increase of Capital.
7.1. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the
manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 8 hereof.
7.2. The Company may proceed to the repurchase of its own Shares within the limits set out by the Company Act.
Art. 8. Meetings of Shareholders - General.
8.1. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders
of the Company.
The general meeting of Shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Company.
In particular, the general meeting of Shareholders shall have competence in all matters where the Board of Directors, in
its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of Shareholders.
8.2. Any general meeting shall be convened by means of a convening notice sent, to each Shareholder, by any two
Directors in compliance with the Company Act.
90104
8.3. Except as otherwise required by Company Act and by the Articles, the quorum for any general meeting of Share-
holders shall be two Shareholders, provided that one of those Shareholders must be the A Shareholder.
8.4. Each Shareholder is entitled to one vote for each Share it holds. A Shareholder may act at any meeting of Share-
holders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.
8.5. Except as otherwise required by Company Act and by the Articles, resolutions at any meeting of Shareholders
duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting, regardless of the proportion of the capital
represented.
However, following decisions can only be made with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance
with any other legal requirement:
a. the change of the nationality of the Company;
b. the increase of the commitments of its Shareholders;
c. the amendments to the Articles;
d. the amendments to the share capital of the Company, including the reduction, purchase or redemption of any share
capital or the creation of any options, subscription rights or conversion rights over any share capital of the Company,
except for any capital increase decided by the Board of Directors within the limits of the authorized capital.
e. any resolution to wind up the Company.
f. the making of a general agreement with creditors to avoid bankruptcy (concordat préventif de la faillite), agreeing
to become subject to controlled management (gestion contrólée), agreeing to deferral of payment terms (sursis de
paiement), resolving to become subject to judicial liquidation (liquidation judiciaire), making a declaration of bankruptcy
in respect of the Company, the Company entering into a general arrangement or settlement with its creditors, or applying
for any other similar legal procedure, liquidation, bankruptcy or insolvency proceedings in respect of the Company or
applying for a court appointed manager (commissaire à la gestion contrólée), a judicial liquidator (liquidation judiciaire),
a trustee or receiver in bankruptcy (curateur), a commissaire or any similar officer to be appointed in respect of the
Company.
g. the variation of the agreed cap as defined in the shareholders agreement which may have been entered into by the
Company and its shareholders from time to time.
8.6. The Board of Directors may by unanimous decision determine any other conditions that must be fulfilled by the
Shareholders for them to take part in any general meeting of Shareholders.
8.7. If all of the Shareholders are present or represented at a general meeting of Shareholders, and if they state that
they have received prior information of the agenda of the meeting, the Shareholders may validly waive any convening
formalities.
Art. 9. Board of Directors.
9.1. The Company is managed by a board of Directors, composed of six members (each a «Director»), who need not
be Shareholders of the Company.
9.2. The Directors shall be appointed by the general meeting of Shareholders in accordance with the following rules:
9.2.1. One Director shall be appointed from a list of at least two candidates proposed by the A Shareholder (the «A
Directors»);
9.2.2. One Director shall be appointed from a list of at least two candidates proposed by the B Shareholder (the «B
Director»).
9.2.3. One Director shall be appointed from a list of at least two candidates proposed by the C Shareholder (the «C
Director»).
9.2.4. Three Directors shall be appointed by the general meeting of Shareholders of the Company in accordance with
the provisions of the Articles and the Company Act (the «D Directors»).
9.3. The Directors shall be appointed for a period of maximum six years and shall hold office until their successors
are elected.
9.4. Any Director may be removed with or without cause by resolution adopted by the general meeting of Shareholders
and replaced at any time. In the event a Director is removed or replaced or in the event a Director resigns, dies, retires
or in the event of any other vacancy, his/her successor shall be appointed in compliance with the provisions of Article
9.2 above.
9.5. In the event of one or more vacancies on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the
remaining Directors must appoint within thirty Business Days one or more successors to fill such vacancy until the next
meeting of Shareholders.
9.6. The Directors shall not be compensated for their services as Director, unless otherwise resolved upon by the
general meeting of Shareholders. The Company shall reimburse the Directors for reasonable expenses incurred through
their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings of the Board.
90105
Art. 10. Procedures of Meeting of the Board of Directors.
10.1. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman and may choose a vice-chairman. It
may also choose a secretary, who need not be a Director and who shall be responsible for keeping the minutes of the
meeting of the Board of Directors and of the Shareholders.
10.2. The Board of Directors shall meet at least quarterly per calendar year upon call by the chairman or two Directors
at the place indicated in the convening notice, but in any case in Luxembourg. The convening notice, containing, inter alia,
an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting shall be sent by letter (sent by express
mail or special courier), telegram, fax, electronic mail to each Director at least seven (7) Business Days before the date
set for the meeting, except in cases where the majority of the Directors agree to shorten notice, or in circumstances of
emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case
notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set forth for such meeting by telefax and/or telegram shall be
sufficient. The Board of Directors may validly deliberate and take decisions without prior notice if all the Directors are
present or represented and have waived the convening requirements and formalities in writing or by fax, telegram or
electronic mail of each Director. All reasonable efforts will be provided so that, sufficiently in advance of any meeting of
the Board of Directors, each Director is provided with a copy of the documents and/or material to be discussed or
resolved upon by the Board of Directors at such meeting.
10.3. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by fax, or telegram
or electronic mail another Director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be
allowed and the Directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video
or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided
that in such latter case such vote is confirmed in writing.
10.4. The quorum for the transaction of business at any meeting of the Board of Directors shall exist if a majority of
Directors are present or represented by another Director, which majority shall include at least one (1) A Director and
at least either one (1) B Director or C Director. Subject to the foregoing, if a quorum of Directors is not present at the
meeting of the Directors within 1 hour from the time set for the meeting or, if during the meeting a quorum ceases to
be present, it shall be adjourned to the following fifth Business Day at the same time and place.
10.5. Without prejudice to the requirements set out in this Article as regards the Major Decisions, decisions shall be
taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. In case of a tie, the chairman
does not have the casting vote.
In addition, the decisions pertaining to the matters listed in this second paragraph of Article 10.5 (the «Major Deci-
sions») require the unanimity of the Directors present or represented at the Board of Directors Meeting:
1. Other than pursuant to the facility agreements as amended from time to time) that the Company would have entered
into before the adoption of these Articles, the issue of any debt instrument or incurring of any indebtedness or borrowings
in the nature of indebtedness.
2. Borrowing any monies.
3. Creating any mortgage, pledge, lien, charge, assignment by way of security, trust arrangement or other encumbrance
or arrangement having the effect of security on its undertaking, property or assets, present or future, or any part thereof.
4. Mortgaging any interest in immovable property.
5. In any material way departing from the ordinary course of the day to day business of the Company either as regards
the nature or the scope or the manner in which it conducts the same.
6. Making any loans or payments or granting any credit or giving any guarantees or other commitment of the Company
otherwise than in the normal course of the business of the Company.
7. Selling, licensing, transferring or otherwise disposing of its business, assets or undertaking or any substantial part
thereof other than in the normal course of the business of the Company.
8. Entering into, terminating or altering any service contract or other terms of service with an executive Director or
officer of the Company.
9. Expanding or developing the business of the Company except through itself, or a member of the Group.
10. Entering into a service or any other agreement with any Director or connected person, or materially changing
such an agreement.
11. Adjusting or altering the accounting policies and bases upon which the annual profit and loss account and balance
sheet of the Company and the Group are based.
12. Modifying or terminating any banking facilities or taking any action to do so or allowing them to cease to become
available.
13. Modifying the terms of any management agreement that the Company enters into from time to time;
14. Establishing any pension, bonus, profit sharing or other incentive scheme of plan for Directors and/or employees
of the Company.
15. Taking any steps to have any member of the Group wound up.
90106
16. Subscribing for, purchasing or acquiring any shares, debentures or other interest in any other company, trust
partnership or other body.
17. Entering into any joint venture, partnership, consortium or other similar arrangement.
18. Other than as set out in these Articles or any shareholders agreement which is entered into by the Company and
all the Shareholders from time to time appointing any committee of its Board of Directors or other committee of the
Company.
19. Employing or agreeing to employ any employee.
20. Agreeing to any variation or waiver of any of the provisions of a shareholders agreement which the Company may
have entered into from time to time.
21. Varying or amending the terms of the Business Plan.
22. Entering into any transaction or doing any thing in respect of any Investment Committee Matter which has not
been approved by a majority of the Investment Committee.
10.6 Notwithstanding the above, the following decisions shall require the prior advice (the «Investment Committee
Advice») of the Investment Committee as defined hereinafter:
1. The acquisition of any new property interest (whether directly or indirectly through the acquisition of shares or
any other interest)
2. The sale of any property interest or the sale of any shares in any member of the Group.
3. The grant or renewal of any leasehold interest where the total value of the lease (being any premium and the rent
payable over the term) exceeds 20% of the acquisition costs of the entire property out of which the leasehold interest
is being granted.
4. The entry into of a contract regarding any capital assets (other than a property interest).
5. The undertaking of any other businesses or activities other than the Business.
6. Approval of the Business Plan or any amendments thereto, from time to time.
The Investment Committee Advice shall not be binding on the Board of Directors.
10.7 Resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as resolutions taken
during a meeting.
10.8 For the purposes of the Articles, «Business Day» means any calendar day (other than a Saturday or a Sunday) on
which banks are open for business in Luxembourg.
10.9. In the event that any Director or officer of the Company may have any adverse personal interest in any transaction
of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and unless
otherwise determined by the unanimous approval of the Shareholders, shall not consider, or vote on such transaction,
and such Directors', or officers' interest therein shall be reported by the Board of Directors to the next succeeding
meeting of Shareholders subject to the responsibility of the Board of Directors.
Art. 11. Minutes of Meetings of the Board.
11.1. The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in the minutes, to be signed by all the Directors
present at the meeting and recorded in the corporate books of the Company.
11.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the chairman, by the secretary or by any two Directors.
Art. 12. Powers of the Board.
12.1. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Company Act or by the Articles for the general meeting
of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.
12.2. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company
and the representation of the Company for such management and affairs, to one of the members of the Board of Directors
who shall be called the managing director. It may also confer all powers and special mandates to any person who need
not be a Director, appoint and dismiss all officers and employees and determine their emoluments.
Art. 13. Binding signature. The Company will be bound by the joint signature of two (2) Directors of the Company,
or by the joint or single signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated with the
unanimous approval of the members of the Board of Directors.
Art. 14. Investment Committee.
14.1 The Company shall have an investment committee (the «Investment Committee») which shall initially consist of
up to four (4) members, who shall not be Directors of the Company. The appointment of the Investment Committee
and any matter relating to the procedures thereof shall be governed by the terms of any shareholders' agreement entered
into by the Company and all the Shareholders from time to time, failing which terms, the provisions of Articles 14.2 to
14.7 shall apply.
90107
14.2 The members of the Investment Committee (the «Committee Members») shall be appointed by the general
meeting of Shareholders in accordance with the following rules:
14.2.1. Two Committee Members shall be appointed on a list of four candidates proposed by the A Shareholder;
14.2.2. One Committee Member shall be appointed on a list of two candidates proposed by the B Shareholder;
14.2.3. One Committee Member shall be appointed on a list of two candidates proposed by the C Shareholder.
14.3 The Investment Committee shall choose from among its members a chairman (the «President»). It shall also
choose a secretary, who need not be a Committee Member and who shall be responsible for keeping the minutes of the
meeting of the Investment Committee.
14.4 The term of office for each member of the Investment Committee shall be two (2) years, which may be extended
for two (2) further year periods.
14.5 Any Member of the Investment Committee shall be removed by the general meeting of Shareholders if the
Shareholders who had initially proposed his or her appointment so request.
14.6 The Committee Members shall not be compensated for their services as Committee Member. The Company
shall reimburse the Committee Members for reasonable expenses incurred through their office, including reasonable
travel and living expenses incurred for attending meetings of the Investment Committee.
14.7 Meetings of the Investment Committee shall be held at the offices of the Company unless the Committee Members
unanimously decide to hold the meeting at some other place in Luxembourg.
14.8 Any Member of the Investment Committee, any Director or any director of any member of the Group may call
the meetings of the Investment Committee. Meetings of the Investment Committee shall be held as often as the business
of the Company so requires, but at least quarterly per calendar year. Every member of the Investment Committee as
well as any member of the Board of Directors or any director or manager of a Subco (as defined in a shareholders
agreement the Company may have entered into from time to time) can demand that a meeting be called. Meetings shall
be called in writing. The convening notice, containing, inter alia, an agenda identifying in reasonable detail the matters to
be discussed at the meeting and accompanied by copies of any relevant papers to be discussed at the meeting, shall be
sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, fax, electronic mail to each Member at least seven (7)
Business Days before the date set for the meeting except in cases where the majority of the Committee Members agree
to shorten notice, or in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in
the convening notice and in which case notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set forth for such
meeting by telefax and/or telegram shall be sufficient. The notice period shall begin to run on the day following the day
on which the invitation is mailed. The day of the meeting shall not count as a part of the notice period.
14.9 Absent members of the Investment Committee may be represented by other members and non-members which
have been granted a written power of attorney.
14.10 Members of the Board of Directors, experts and other persons can be invited by the President, or any member
authorized accordingly by the President, to participate in the meeting. However, only the Committee Members have the
right to vote at meetings of the Investment Committee.
14.11 The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the Committee Members
using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone. After delib-
eration, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided that in such latter case
such vote is confirmed in writing.
14.12 Minutes are to be kept (for the purpose of furnishing proof) at every meeting of the Investment Committee,
setting out the place and the date of the meeting, the participants, the items of the agenda and the essential content of
the resolutions of the Investment Committee. The minutes shall be signed by the President or any other Committee
Member to whom the President delegates this office. A copy of the minutes shall be sent to every Shareholder and each
member of the Investment Committee and to every member of the Board of Directors.
14.13 Resolutions of the Investment Committee shall be passed at meetings of the Investment Committee. However,
resolutions of the Investment Committee may be adopted outside meetings in writing, per facsimile or per video con-
ference under waiver of any provisions set forth herein with regard to the notice period of such meetings if every member
of the Investment Committee participates in the voting.
14.14 A meeting of the Investment Committee may adopt resolutions only if at least two (2) Committee Members,
one of whom must be a Committee Member appointed on the recommendation of the A Shareholder and one of whom
must be a Committee Member appointed on the recommendation of the B Shareholder or the C Shareholder. In the
absence of this quorum, the meeting of the Investment Committee shall be adjourned for 48 hours.
14.15 Resolutions of the Investment Committee shall be adopted pursuant to a simple majority vote of its members
present at such meeting. In case of a tie, the President shall not have a casting vote.
14.16 The Committee Members appointed on the recommendation of the A Shareholders shall have an aggregate of
two votes irrespective of the number of Committee Members appointed by the A Shareholder or the number who are
in attendance at any meeting and the Committee Members appointed on the recommendation of the B Shareholder and
the C Shareholder shall have an aggregate of two votes irrespective of the number of Committee Members appointed
by the B Shareholder and/or the C Shareholder or the number who are in attendance.
90108
14.17 Neither the Investment Committee nor their members or the Shareholders shall be held liable for advices or
recommendations provided to the Board of Directors. The Board of Directors shall be solely responsible for any action
taken on the recommendation of the Investment Committee. Neither the members of the Investment Committee nor
the Shareholders shall under any circumstances be considered directors, directors in fact, managers, employees, body,
agent or representatives of the Company.
15. Statutory auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as
foreseen by the Company Act who need not be (a) Shareholder(s). The statutory auditors shall be appointed by the
general meeting of Shareholders, which determine their number and the term of their mandate.
16. Appropriation of profits.
16.1 Legal Reserve
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the
Company Act. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per
cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
16.2 Dividends
16.2.1 The general meeting of Shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, shall determine how
the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without
ever exceeding the amounts proposed by the Board of Directors.
16.2.2 Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by the Company Act, upon decision
of the Board of Directors and report by the statutory auditors.
17. Dissolution and Liquidation.
17.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of Shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles as prescribed in Article 8 hereof.
17.2 In the event of dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by one or several liquidators named
by the general meeting of Shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and compen-
sation.
18. Annual General Meeting of Shareholders.
18.1 The annual general meeting of the Shareholders shall resolve on the approval of the accounts of the Company.
18.2 The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with the Company Act at the registered
office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the twentieth
of November of each year, at 4.00. P.M.
18.3 If the day scheduled for the annual general meeting is not a Business Day, the annual general meeting shall be held
on the following Business Day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final unanimous
judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.
18.4 Other meetings of Shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be
specified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place in Luxem-
bourg.
19. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of July and shall terminate on
the last day of June of each year, except the current accounting year which started on the date of the incorporation of
the Company and shall end on 30 June 2008.
20. Governing law. All matters not governed by the Articles shall be determined in accordance with the Company Act.
<i>Sixth resolutioni>
The general shareholders' meeting resolves to appoint, with immediate effect, the following persons as Directors with
the following designations:
- Derek McDonald, born on 9 August 1967 in Paisely, Scotland, Director, with professional address at 4th Floor,
Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh, EH12 5RD, as A Director;
- Ian Blake, born on 29 January 1963 in Stafford (United Kingdom), with professional address at One Jermyn Street,
London, SW1Y 4UH, United Kingdom, as B Director;
- Hille-Paul Schut, born on 29 September 1977 in The Hague (The Netherlands), with professional address at 20, rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg as C Director;
- François Pfister, born on 25 October 1961 in Uccle (Belgium), with professional address at 20, avenue Monterey,
L-2016 Luxembourg as D Director;
- Jacques de Patoul, born on 10 January 1980 in Luxembourg, with professional address at 20, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg as D Director;
- Godfrey Abel, born on 2 July 1960 in Brixworth, Northampton, England, with professional address at 30, rue de
Crecy, L-1364 Luxembourg as D Director;
90109
Unless renewed, their term of office will expire after the annual meeting of shareholders in relation to the approval
of the annual accounts of the Company for the year ended 30 June 2008.
<i>Seventh resolutioni>
The general shareholders' meeting resolves to appoint KPMG AUDIT, having its registered office at 31, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, as Statutory Auditor of the Company.
Unless renewed, its term of office will expire after the annual meeting of shareholders in relation to the approval of
the annual accounts of the Company for the year ended 30 June 2008.
<i>Costsi>
The total costs, expenses and charges in whatever form that the company incurs or which are charged to it by virtue
of this extraordinary general meeting is estimated without prejudice at the sum of EUR 5,000.-.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundsieben, am vierundzwanzigsten Mai.
Wurde vor uns, Maître Hellinckx, unterzeichnender Notar mit dem Amtssitz in Luxembourg, Grossherzogtum Lu-
xemburg.
Die ausserordentliche Generalversammlung der MATRIX DYNAMIC REAL ESTATE PORTFOLIO S.A., eine «société
anonyme» mit Gesellschaftssitz in 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, abgehalten, begründed durch eine Urkunde
des unterzeichnenden Notars am 24. Januar 2007, noch nicht veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (nachfolgend die «Gesellschaft»).
Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Jacques De Patoul, Jurist, beruflich wohnhaft in Lu-
xemburg.
Er bestellt als Schriftführer Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung ernennt zum Stimmenzähler Herrn Nicolas Ronzel, Jurist, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Nachdem das Versammlungsbüro so gebildet worden ist, stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden
Notar zu beurkunden:
II. Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1. Entscheid drei Arten von Aktien zu bilden (Aktien der Klasse A, Aktien der Klasse B und Aktien der Klasse C)
welche verschiedene Rechte betreffend die Ernennung des Geschäftsführers und des Investmentkomitees haben
2. Entscheid die 24.800 (vierundzwanzigtausendachthundert) bestehenden Stammaktien alle mit einem Nennwert von
EUR 1,25 (ein Euro und fünfundzwanzig) in 800 (achthundert) Aktien der Klasse B und 24.000 (vierundzwanzigtausend)
Aktien der Klasse C, alle mit einem Nennwert von EUR 1,25 (ein Euro und fünfundzwanzig) umzuwandeln;
3. Reklassifizierung der Aktien, welche gegenwärtig durch die Aktionäre in der Gesellschaft gehalten werden, wie folgt:
- MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED hält 800 (achthundert) Aktien der Klasse B;
und
- MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED hält 24.000 (vierundzwanzigtausend) Aktien
der Klasse C.
4. Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals der Gesellschaft um den Betrag von EUR 89.000,- (neunundachzigtausend
Euro), um das gezeichnete Aktienkapital von seinem gegenwärtigen Betrag von EUR 31.000,- (einundreissigtausend), auf
EUR 120.000,- (einhundertundzwanzigtausend) durch die Ausgabe von 48.000 (achtundvierzigtausend) Aktien der Klasse
A und 23.200 (dreiundzwanzigtausendzweihundert) Aktien der Klasse B, alle mit einem Nennwert von EUR 1,25 (ein
Euro und fünfundzwanzig), es sei 71.200 (einundsiebzigtausend) neu ausgegebenen Stammaktien die voll zum Nennwert
einzuzahlen sind.
5. Verzicht der bestehenden Aktionäre im nötigen Ausmass auf ihr vorzugberechtigtes Aktienbezugsrecht, Zeichnung
und volle Bezahlung der neu ausgegebenen Aktien durch Barzahlung wie folgt:
- UBERIOR EUROPE LIMITED wird für EUR 48.000,- (achtundvierzigtausend) Aktien der Klasse A zeichnen, alle mit
einem Nennwert von EUR 1,25 (ein Euro und fünfundzwanzig); und
- MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT LLP wird für EUR 23.200,- (dreiundzwanzigtausend zweihundert)
Aktien der Klasse B zeichnen, alle mit einem Nennwert von EUR 1,25 (ein Euro und fünfundzwanzig);
90110
6. Nachträgliche vollständige Neuformulierung der Statuten der Gesellschaft, einschliesslich auch unter anderem der
folgenden Änderungen:
- Änderung des Geschäftsjahrs der Gesellschaft und Änderung des Datums der Abhaltung der ordentlichen General-
versammlung der Gesellschaft;
- Änderung der Modalitäten der Ernennung und Absetzung des Geschäftsführers der Gesellschaft;
- Änderung des Ablaufs der Verwaltungsratssitzungen der Gesellschaft;
- Gründung eines Investmentkomitees, Nominierung und Ernennung seiner Mitglieder, Festlegung ihrer Kompetenzen
und Pflichten und Übernahme der Verfahrensregeln für das Investmentkomitee;
- Änderung der Modalitäten des Aktientransfers.
7. Ernennung mit sofortiger Wirkungder folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft mit
den folgenden Bezeichnungen:
- Derek McDonald als A-Mitglied des Verwaltungsrates;
- Ian Blake als B-Mitglied des Verwaltungsrates B;
- Hille-Paul Schut als C-Mitglied des Verwaltungsrates;
- François Pfister, Jacques de Patoul, und jede Person, welche vom Aktionär der Klasse A als Mitglieder des Verwal-
tungsrates auf einer Vorschlagsliste eingeführt wurde, als D-Mitglied des Verwaltungsrates;
8. Ernennung mit sofortiger Wirkung, von KPMG als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft als Ersatz für Pricewater-
houseCoopers;
9. Verschiedenes.
II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Stimmrechtsinhaber der vertretenen Aktionäre und die Anzahl
ihrer Aktien sind auf der Anwesenheitsliste aufgeführt; diese von den Aktionären, den Stimmrechtsinhabern der vertre-
tenen Aktionären, dem Versammlungsbüro und dem unterzeichneten Notar unterzeichnete Anwesenheitsliste bleibt der
gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigelegt.
Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben der gegenwärtigen Urkunde ebenfalls als Anlage beigelegt.
III. Wie aus der Anwesenheitsliste zu schliessen ist, sind alle 24.800 (vierundzwanzigtausend achthundert) Aktien,
welche das ganze Stammkapital von EUR 31.000,- (einundreissigtausend Euros) darstellen, an der gegenwärtigen Gene-
ralversammlung präsent oder räpresentiert, so dass die Versammlung rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte
entscheiden kann.
Nachdem das Vorangehende durch die Generalversammlung genehmigt worden ist, hat die Generalversammlung ein-
stimmig und separat die folgenden Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst drei Arten von Aktien zu bilden, welche verschiedene Rechte betreffend die
Ernennung des Geschäftsführers der Gesellschaft und der Mietglieder des Investmentkomitees haben, wie hier folgend
beschrieben.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, die 24.800 (vierundzwanzigtausend achthundert) bestehenden Stammaktien mit
einem Nennwert von EUR 1,25 (ein Euro und fünfundzwanzig) in 800 (achthundert) Aktien der Klasse B und 24.000
(vierundzwanzigtausend) Aktien der Klasse C umzuwandeln, alle mit einem Nennwert von EUR 1,25 (ein Euro und fünf-
undzwanzig), welche mit verschiedenen Rechten betreffend die Ernennug der Mitglieder des Verwaltungsrates der
Gesellschaft und der Mitglieder des Investmentkomitees verbunden sind.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, die gegenwärtig von den Aktionären in der Gesellschaft gehaltenen Aktien wie
folgt neu zu klassifizieren:
- MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED hält 800 (achthundert) Aktien der Klasse B;
und
- MATRIX EPH, LLC hält 24.000 (vierundzwanzigtausend) Aktien der Klasse C.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft um den Betrag EUR 89.000,-
(neunundachzigtausend Euro) zu erhöhen, um das gezeichnete Aktienkapital von seinem gegenwärtigen Betrag von EUR
31.000,- (einundreissigtausend) bis auf EUR 120.000,- (einhundertzwanzigtausend) zu erhöhen, durch die Ausgabe von
48.000 (achtundvierzigtausend) Aktien der Klasse A und 23.200 (dreiundzwanzigtausendzweihundert) Aktien der Klasse
B, alle mit einem Nennwert von EUR 1,25, es sei 71.000 (einundsiebzigtausend) neue Stammaktien. welche voll zum
Nennwert einzuzahlen.
<i>Intervention - Zeichnung - Bezahlungi>
Darauf erschienen die bestehenden Aktionäre («Bestehenden Aktionäre») der Gesellschaft:
90111
- MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT LLP, eine in England und Wales registrierte Gesellschaft mit Gesell-
schaftssitz in One Jermyn Street London, SW1Y 4UH; und
MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, eine in Guernsey registrierte Gesellschaft mit
Registrierungsnummer 41754 und mit Gesellschaftssitz in Investec House, 2a Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 3RD;
(MPFM); MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT LLP und MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GU-
ERNSEY) LIMITED, hier beide vertreten durch Mr. Jacques de Patoul, Angestellter, wohnhaft in Luxembourg, welcher
aufgrund von zwei am 22. Mai 2007 erteilten Vollmachten handelt.
Sowie der folgende zusätzliche Unterzeichner («zusätzliche Unterzeichner»):
- UBERIOR EUROPE LIMITED, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, registriert in Schottland unter dem Com-
panies Acts unter Nummer SC299325 und mit Gesellschaftssitz in 4th Floor, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh,
EH12 5HD (UBERIOR).
Hier vertreten durch Herrn Nicolas Ronzel, vorgenannt,
welcher aufgrund von einer am 23. Mai 2007 erteilten Vollmacht handelt.
Die genannten Vollmachten werden ne varietur durch die erschienenen Parteien und den unterzeichnenden Notar
unterzeichnet und bleiben dem vorliegenden Dokument für die Registrierung beigeheftet.
10. Die bestehenden Aktionäre, wie obgenannt vertreten, erkären, teilweise im nötigen Ausmass zugunsten der Zu-
sätzlichen Zeichnenden auf ihre vorzugberechtigten Aktienbezugsrechte zu verzichten.
MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT LLP und der zusätzliche Unterzeichner, wie obgenannt vertreten, haben
erklärt, für die Anzahl der neu ausgegebenen Aktien mit einem Nennwert von EUR 1,25 (ein Euro und fünfundzwanzig
Cents) zu zeichnen und haben sie voll einbezahlt durch Barzahlung und proportional, wie in der untenstehenden Tabelle
neben ihren Namen dargestellt:
Zeichnende
Anzahl der
Art Betrag zu
gezeichneten
der
bezahlen
Aktien
Aktien
in Euro
UBERIOR EUROPE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.000
Aktien der Klasse A
60.000,-
MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT LLP . . . . . . . . . . . .
23.200
Aktien der Klasse B
29.000,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.200
N/A
89.000,-
Die Zahlungsbestätigung der neu ausgebebenen Stammakten wurde dem unterzeichnenden Notar in Form eines
Bankzertifikats übergeben, so dass der Betrag von neunundachzigtausend Euro (89.000,- EUR) von nun an der Gesellschaft
zur Verfügung steht.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, zu einer kompletten Neuformulierung der Statuten fortzuschreiten, um die ob-
genannten Beschlüsse wiederzuspiegeln und um unter anderem, (i) zur Änderung der Modalitäten der Ernennung und
Absetzung der Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft, (ii) der Änderung des Ablaufs der Verwaltungsratssit-
zungen der Gesellschaft, (iii) der Gründung eines Investment Komitees, der Nominierung und Ernennung seiner
Mitglieder, der Festlegung ihrer Kompetenzen und Pflichten und Übernahme der Verfahrensregeln für das Investment
Komitee und (iv) die Änderung der Modalitäten des Aktientransfers fortzuschreiten, so dass die Statuten künftig folgen-
dermassen lauten:
MATRIX DYNAMIC REAL ESTATE PORTFOLIO S.A.
Koordinierte Satzung
Art. 1. Rechtsform, Firma. Hiermit wird zwischen dem Unterzeichner und allen, die eventuell Inhaber von nach diesem
Datum ausgegebenen Aktien werden, eine Gesellschaft in der Form einer société anonyme oder Aktiengesellschaft unter
der Firma MATRIX DYNAMIC REAL ESTATE PORTFOLIO S.A. gegründet, die dem Gesetz vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden «Gesetz») sowie der vorliegenden Satzung unter-
liegt.
Art. 2. Definitionen. Zusätzlich zu den weiteren in anderen Bestimmungen dieser Satzung definierten Begriffen haben
die nachstehenden Wörter und Begriffe die nachstehenden Bedeutungen, sofern und soweit sie mit Großbuchstaben
beginnend geschrieben sind:
«A-Aktionär» die UBERIOR EUROPE LIMITED, eine in Schottland gemäß dem Companies Act gegründete und unter
Nummer SC299325 eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz an der Anschrift 4th
Floor, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh, EH125HD, oder eine Person, an die ihre A-Aktien im Einklang mit
dieser Satzung von Zeit zu Zeit übertragen werden.
«A-Aktien» die Stammaktien der Klasse A und «A-Aktie» eine davon.
«Verbundene Person» im Verhältnis zu einer bestimmten Person:
(c) eine andere Person, die direkt oder indirekt die bestimmte Person kontrolliert oder von ihr kontrolliert wird oder
gemeinsam mit der bestimmten Person direkt oder indirekt kontrolliert wird; oder
90112
(d) eine sonstige Person oder ein sonstiger Fonds, die bzw. der von der bestimmten Person verwaltet wird.
«Satzung» diese Satzung in ihrer vorliegenden Form und in der zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Fassung, die nach
Maßgabe einer von allen Aktionären zum jeweiligen Zeitpunkt getroffenen Vereinbarung geändert wurde (und Artikel ist
entsprechend auszulegen);
«B-Aktien» die Stammaktien der Klasse B und «B-Aktie» eine davon.
«B-Aktionär» MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT LLP, eine in England und Wales gegründete Limited Lia-
bility Partnership (Personengesellschaft mit beschränkter Haftung) mit eingetragenem Sitz an der Anschrift One Jermyn
Street, London, SW1Y 4UH oder eine Person, an die ihre B-Aktien von Zeit zu Zeit im Einklang mit dieser Satzung und/
oder einer etwaigen von allen Aktionären von Zeit zu Zeit geschlossenen Vereinbarung übertragen werden.
«Geschäft» das Geschäft der in Artikel 4 beschriebenen Gesellschaft;
«Geschäftstag» ein Kalendertag (außer Samstag oder Sonntag), an dem die Banken in Luxemburg geöffnet sind;
«Geschäftsplan» der finanzielle Geschäftsplan für den Konzern bezüglich des am 30. Juni 2008 ablaufenden Geschäfts-
jahrs der Gesellschaft und der vier darauf folgenden Geschäftsjahre der Gesellschaft (in einem von Zeit zu Zeit von dem
Board of Directors genehmigten Format), der jährlich auf den neuesten Stand zu bringen ist, oder ein anderer im Einklang
mit einer Vereinbarung, die die Gesellschaft und jeder der Aktionäre von Zeit zu Zeit geschlossen haben, erstellter
Geschäftsplan;
«C-Aktionär» MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, eine in Guernsey gegründete
unter der Nummer 41754 eingetragene Gesellschaft mit eingetragenem Sitz an der Anschrift Investec House, 2a Plaiderie,
St Peter Port, Guernsey GY1 3RD oder eine Person, an die ihre C-Aktien von Zeit zu Zeit im Einklang mit dieser Satzung
und/oder einer etwaigen von allen Aktionären von Zeit zu Zeit geschlossenen Vereinbarung übertragen werden.
«C-Aktien» die Stammaktien der Klasse C und «C-Aktie» eine davon;
«Gesellschaft» die société anonyme MATRIX DYNAMIC REAL ESTATE PORTFOLIO S.A., die dieser Satzung unter-
liegt;
«Gesetz über Handelsgesellschaften» das luxemburgerische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften
in der jeweils geltenden Fassung;
«Kontrolle» die Macht, direkt oder über einen oder mehrere Intermediäre oder zusammen mit konzertiert handelnden
Personen die Geschäftsführung einer Person zu steuern oder steuern zu lassen (insbesondere die Macht, eine Mehrheit
der Mitglieder des Verwaltungsrats einer Gesellschaft zu ernennen oder abzusetzen oder auf sonstige Weise vollständige
Kontrolle über den Verwaltungsrat einer Gesellschaft auszuüben); insbesondere gilt, dass Aktien einer Gesellschaft, die
mehr als 50% sämtlicher mit den ausgegebenen Aktien dieser Gesellschaft verbundenen Stimmrechte ausmachen, Kon-
trolle über diese Gesellschaft verleihen;
«Konzern» die Gesellschaft und jede Tochtergesellschaft, die ihr von Zeit zu Zeit direkt oder indirekt zu 100 % gehört,
und der Ausdruck «Mitglied des Konzerns» ist entsprechend auszulegen;
«Aktionäre» die Inhaber der Aktien einer Klasse und «Aktionär» einer von ihnen;
«Aktionärsverzeichnis» das Verzeichnis der Aktionäre;
«Aktien» die Aktien einer Klasse und «Aktie» eine davon;
«Nicht gefragte aufgerufene Aktien» bezeichnet bei einer gemäß Klausel 6.3.2.3. einem Angebotsempfänger zugestellten
Angebotsanzeige, seinen proportionalen Anteil gemäß Klausel 6.3.2.3, zu deren Kauf der betreffende Empfänger sich nicht
vor Ablauf des dieser Angebotsanzeige bereit erklärt hat.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Gegenstand.
4.1. Der Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeder Art an luxemburgischen und ausländischen
Unternehmen, der Erwerb von Aktien, Anleihen, Obligationen, Schuldverschreibungen und anderen Beteiligungs- oder
Schuldtitel (wandelbar oder nicht) irgendeiner Art (insbesondere synthetischer Wertpapiere) durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise sowie die Übertragung derselben durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie Besitz, Verwal-
tung, Entwicklung und Management ihres Portfolios. Die Gesellschaft sich auch an Personengesellschaften beteiligen.
4.2. Die Gesellschaft kann auf jegliche Art und Weise Darlehen und Anleihen, Schuldverschreibungen sowie jede andere
Art von Beteiligungs- oder Schuldtiteln (wandelbar oder nicht) aufnehmen und gewähren.
4.3. Sie kann im Allgemeinen unmittelbar oder mittelbar verbundenen Unternehmen oder Konzernunternehmen, Un-
ternehmen unter gemeinsamer Kontrolle der Gesellschaft oder einem anderen als passend angesehenen Unternehmen
Unterstützung gewähren (insbesondere Darlehen, Bürgschaften oder Sicherheiten jeglicher Art), etwaige Kontroll- und/
oder Aufsichtsmaßnahmen sowie jegliche geschäftliche Tätigkeit vornehmen, die sie für die Realisierung und Förderung
ihres Gesellschaftszwecks als nützlich erachtet.
4.4. Die Gesellschaft kann insbesondere in eine Bürgschaft, Verpfändung oder irgendeine andere Form der Sicherheit
oder Unterstützung eintreten, ob durch persönliche Verpflichtung oder durch eine Hypothek oder Belastung auf alle oder
einen Teil der (gegenwärtigen oder künftigen) Immobilien und etwaige andere Vermögenswerte des Unternehmens oder
durch alle oder eine dieser Methoden, um Verträge oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft und eines ihrer verbundenen
90113
Unternehmen oder eines Konzernunternehmens oder eines Unternehmens, an dem die Gesellschaft beteiligt ist, oder
eines Mitglieds des Verwaltungsrats, eines leitenden Angestellten oder anderen Vertreters der Gesellschaft oder eines
ihrer verbundenen Unternehmen oder Konzernunternehmen im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften zu erfüllen.
4.5. Die Gesellschaft kann ferner jede gewerbliche, industrielle oder finanzielle Geschäftstätigkeit sowie Transaktionen
vornehmen, die sich unmittelbar oder mittelbar auf Grundbesitz oder bewegliches Vermögen beziehen.
4.6. Die Gesellschaft kann ferner als Mitglied des Verwaltungsrats für andere Gesellschaften handeln und solche Ge-
sellschaften leiten, die nicht unbedingt Tochtergesellschaften der Gesellschaft sein müssen.
Art. 5. Eingetragener Sitz.
5.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Ver-
waltungsrats an einen anderen Ort in der Stadt Luxemburg verlegt werden. Niederlassungen oder andere Geschäftsstellen
können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des Verwaltungsrats eingerichtet
werden.
5.2. Ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ereignisse eingetreten
sind oder einzutreten drohen, die sich auf die normalen Tätigkeiten am eingetragenen Sitz oder auf die Kommunikation
vom eingetragenen Sitz mit dem Ausland wahrscheinlich negativ auswirken werden, kann der eingetragene Sitz vorüber-
gehend so lange ins Ausland verlegt werden, bis sich die Lage völlig normalisiert hat. Derartige Maßnahmen werden die
Staatsangehörigkeit der Gesellschaft nicht berühren, die trotz einer etwaigen vorübergehenden Verlegung des eingetra-
genen Sitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
Art. 6. Kapital - Genehmigtes Kapital - Aktien und Aktienzertifikate.
6.1. Kapital
Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft ist auf EUR 120.000,- (Einhundertzwanzigtausend Euro) festgesetzt,
aufgeteilt in 96.000 (Sechsundneunzigtausend) Aktien zu jeweils EUR 1,25 (Ein Euro Fünfundzwanzig Cents), aufgeteilt in:
(d) 48.000 (Achtundvierzigtausend) A-Aktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,25 (Ein Euro Fünfundzwanzig
Cents) und
(e) 24.000 (Vierundzwanzigtausend) B-Aktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,25 (Ein Euro Fünfundzwanzig
Cents)
(f) 24.000 (Vierundzwanzigtausend) C-Aktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,25 (Ein Euro Fünfundzwanzig
Cents).
6.2. Genehmigtes Kapital
6.2.1. Neben und außer dem gezeichneten Kapital ist das genehmigte Kapital der Gesellschaft auf EUR 120.000,- (Ein-
hundertzwanzigtausend Euro) festgesetzt, aufgeteilt in 48.000 (Achtundvierzigtausend) Aktien der Klasse A zu EUR 1,25
(Ein Euro Fünfundzwanzig Cents) je Aktie und 24.000 (Vierundzwanzigtausend) Aktien der Klasse B zu EUR 1,25 (Ein
Euro Fünfundzwanzig Cents) je Aktie und 24.000 (Vierundzwanzigtausend) Aktien der Klasse C zu EUR 1,25 (Ein Euro
Fünfundzwanzig Cents) je Aktie.
6.2.2. Der Verwaltungsrat ist befugt, während einer Frist von fünf Jahren, die am 24. Januar 2012 abläuft, wandelbare
Schuldtitel oder Beteiligungstitel zu begeben und nach der Wandlung der Schuldtitel bzw. Beteiligungstitel das gezeichnete
Kapital im Rahmen des genehmigten Kapitals einmal oder mehrmals bis auf einen Gesamtbetrag von EUR 240.000,-
(Zweihunderteinundvierzigtausend Euro) zu erhöhen. Der Verwaltungsrat kann jeweils bestimmen, ob der Betrag der
Kapitalerhöhung über pari gezeichnet und emittiert werden darf.
6.2.3. Der Verwaltungsrat ist insbesondere befugt, derartige Emissionen vorzunehmen, ohne den bestehenden Akti-
onären ein Vorzugszeichnungsrecht für die auf dieses Weise ausgegebenen Aktien einzuräumen.
6.2.4. Der Verwaltungsrat ist ferner befugt und ermächtigt, eine Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Grund-
kapitals in einer oder mehreren sukzessiven Tranchen gegen Barzahlung oder Sacheinlage, durch Umwandlung von
Forderungen, Einbindung von Gewinnrücklagen oder auf sonstige Weise vorzunehmen und Ort und Datum der Emission
oder der sukzessiven Emissionen, den Emissionspreis, die Bedingungen für Zeichnung und Bezahlung der jungen Aktien
festzusetzen.
6.2.5. Der Verwaltungsrat kann die Pflichten der Entgegennahme von Zeichnungen und Zahlungen für Aktien, die ganz
oder teilweise den Betrag der Kapitalerhöhung repräsentieren, an ein ordnungsgemäß befugtes Mitglied des Verwal-
tungsrates oder einen leitenden Angestellten der Gesellschaft oder an eine sonstige ordnungsgemäß befugte Person
delegieren.
Jedes Mal, wenn der Verwaltungsrat das Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen des genehmigten Grundkapitals
erhöht, gilt der in Artikel 6.2.1 der Satzung angegebene Betrag des genehmigten Grundkapitals um den dieser Kapitaler-
höhung entsprechenden Betrag reduziert. Deshalb werden die in Artikel 6.1. und 6.2.1. der Satzung angegebenen Beträge
nach Maßgabe jeder notariellen Urkunde, in der die betreffende Erhöhung des Grundkapitals gemäß Artikel 6.2 der Satzung
festgehalten ist, abgeändert werden.
6.3. Aktien und Übertragung von Aktien
6.3.1. Aktien
Die Aktien werden Namensaktien sein.
90114
Die Gesellschaft wird die Person, in deren Namen die Aktien im Aktionärsverzeichnis eingetragen sind, als vollbe-
rechtigten Eigentümer dieser Anteile ansehen.
Zertifikate mit Angabe dieser Eintragung werden dem Aktionär übermittelt. Übertragungen eingetragener Aktien er-
folgen durch eine Übertragungserklärung, die in dem Aktionärsverzeichnis eingetragen, mit Datum versehen und von dem
Veräußerer und dem Erwerber oder von Personen unterzeichnet ist, denen entsprechende Vollmachten erteilt wurden.
6.3.2. Übertragungsbeschränkungen
6.3.2.1. Für Übertragungen geltende Bedingungen
Eine Aktienübertragung gemäß diesem Artikel 6.3.2 erfolgt in Übereinstimmung mit einer etwaigen, von Zeit zu Zeit
von der Gesellschaft und allen Aktionären geschlossenen Vereinbarung, unter der Bedingung, dass jeder Erwerber, der
nicht bereits ein Aktionär ist, zunächst eine Urkunde des Beitritts (die «Beitrittsurkunde») in rechtsverbindlicher Weise
ausgefertigt und zugestellt hat, in der vorgesehen ist, dass dieser Erwerber Partei einer solchen Vereinbarung der Akti-
onäre wird, und dass etwaige von diesem Erwerber gehaltene Aktien den Bestimmungen einer solchen Vereinbarung der
Aktionäre unterliegen.
6.3.2.2. Zulässige Übertragungen
Während einer Frist von fünf Jahren ab dem Tag, an dem die Aktionäre gegebenenfalls Parteien einer Vereinbarung
der Aktionäre werden (die «Fünfjahresfrist»), darf ein Aktionär die Aktien nicht ohne Einwilligung der anderen Aktionäre
übertragen, es sei denn, (i) die Übertragung von Aktien erfolgt im Einklang mit einer Vereinbarung der Aktionäre, die
unter Umständen von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft und den Aktionären geschlossen worden ist, und (ii) die Über-
tragung von Aktien erfolgt im Einklang mit Artikel 6.3.2.3.
Nach der Fünfjahresfrist müssen die Aktionäre, die Aktien verkaufen wollen, diesen Umstand den anderen Aktionären
der Gesellschaft mitteilen und im Einzelnen angeben, welche Aktien übertragen werden sollen und welcher Preis je Aktie
von einem gutgläubigen Dritten angeboten worden ist. Die übrigen Aktionäre sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, die
betreffenden Aktien (proportional zu ihrem eigenen Anteil an der Gesellschaft) zu den gleichen Bedingungen zu kaufen,
die von dem gutgläubigen Kaufinteressenten angeboten wurden. Den übrigen Aktionären steht es frei, das Angebot an-
zunehmen und ihr Vorkaufsrecht binnen 10 Tagen nach Empfang der Mitteilung auszuüben. Nach Ablauf der Frist ist das
Angebot an die übrigen Aktionäre hinfällig, und der Aktionär, der seine Aktien verkaufen möchte, kann sie dem gutgläu-
bigen Dritten zu den gleichen Bedingungen verkaufen, die er den übrigen Aktionären angezeigt hatte.
6.3.2.3. Kaufoption
6.3.2.3.1 Gerät ein Aktionär in Verzug (wie in der Vereinbarung mit den Aktionären definiert, die die Gesellschaft
unter Umständen von Zeit zu Zeit mit den Aktionären geschlossen hat), gewährt dieser Aktionär (der «in Verzug geratene
Aktionär») den übrigen Aktionären (den «nicht in Verzug geratenen Aktionären») eine Option (die «Kaufoption»), die
die nicht in Verzug geratenen Aktionäre berechtigt, die von dem in Verzug geratenen Aktionär gehaltenen Aktien ( «Auf-
gerufene Aktien») zum Verkehrswert (wie in der Vereinbarung mit den Aktionären definiert, die die Gesellschaft unter
Umständen von Zeit zu Zeit mit den Aktionären geschlossen hat) dieser Aufgerufene Aktien (dem «Preis bei Verzug»)
und zu den Bedingungen dieser Klausel 6.3.2.3 zu kaufen. Diese Kaufoption kann von den nicht in Verzug geratenen
Aktionär ausgeübt werden, indem sie dem in Verzug geratenen Aktionär, der Gesellschaft und jedem anderen Aktionär
schriftlich ankündigen, dass sie die in diesem Vertrag vorgesehene Kaufoption ausüben möchten («Ankündigung der Op-
tionsausübung»). Diese Ankündigung der Optionsausübung kann nicht zurückgezogen werden, es sei denn, dass alle
Aktionäre schriftlich ihre Einwilligung dazu erteilen.
6.3.2.3.2 Wurde eine Ankündigung der Optionsausübung gemäß Klause 6.3.2.3.1 zugestellt, zeigt die Gesellschaft allen
Aktionären, denen gemäß Klausel 6.3.2.3 eine Kaufoption erteilt wurde, das Angebot an (die «Angebotsanzeige»), und
zwar binnen zehn (10) Geschäftstagen ab dem der späteren beiden Termine:
- dem Termin, an dem der Verkehrswert vereinbart (bzw. ermittelt) wird; und
- dem Termin, an dem das Exemplar der Ankündigung der Optionsausübung bei der Gesellschaft einging.
6.3.2.3.3 Wird die Kaufoption ausgeübt, werden alle von den in Verzug geratenen Aktionären gehaltenen Aufgerufenen
Aktien, die in Spalte (1) der nachstehenden Tabelle angegeben sind, den Aktionären (den «Angebotsempfängern») wie
folgt angeboten:
- zuerst allen Personen in der ersten Kategorie, die in der entsprechenden Zeile in Spalte (2) der nachstehenden Tabelle
angegeben sind, und zwar proportional zu ihrem Aktienbesitz; und
- soweit nicht von den Personen in Spalte (2) ausgeübt, allen Personen in der entsprechenden Zeile in Spalte (3), und
zwar proportional zu ihrem Aktienbesitz;
doch jeder in Verzug geratene Aktionär, hinsichtlich dessen die Ankündigung der Optionsausübung erfolgte und noch
gleichzeitig besteht, ist nicht zur Ausübung der Kaufoption berechtigt.
(1)
(2)
(3)
Klasse der zu verkaufenden Aktien
Kaufoption,
Kaufoption,
erste Phase
zweite Phase
Aufgerufene Aktien, die in Verzug geratenen A-Aktionären gehören . . . .
B-Aktionär(e) und
entfällt
C-Aktionär(e)
90115
Aufgerufene Aktien, die in Verzug geratenen B-Aktionären gehören . . . .
C-Aktionär(e)
A-Aktionär(e)
Aufgerufene Aktien, die in Verzug geratenen C-Aktionären gehören . . . .
B-Aktionär(e)
B-Aktionär(e)
6.3.2.3.4 Wie erwähnt, wird die Gesellschaft jeden Angebotsempfänger auffordern, binnen fünfzehn (15) Geschäftsta-
gen nach Zustellung der Angebotsanzeige schriftlich zu erklären, ob er willens ist, einen Teil der Aufgerufenen Aktien zu
kaufen, die jeder Angebotsempfänger kaufen kann, und, wenn ja, den Teil anzugeben, den er maximal zu kaufen bereit ist.
6.3.2.3.5 Zu diesem Zeitpunkt wird die Gesellschaft sich auch bei jedem Angebotsempfänger erkundigen,
- ob er am Kauf etwaiger nicht gefragter Aufgerufener Aktien interessiert ist oder nicht, und
- wenn ja, welchen Anteil an nicht gefragten Aufgerufenen Aktien er zu kaufen bereit ist.
6.3.2.3.6 Wenn die Gesellschaft nach den obigen Bestimmungen dieser Klausel 6.3.2.3 Angebotsempfänger findet, die
zur Ausübung der Option bereit sind, so dass alle Aufgerufenen Aktien während der in Klausel 6.3.2.3.4 vorgeschriebenen
Frist erworben werden, teilt die Gesellschaft binnen fünf (5) Geschäftstagen ab Ablauf der Angebotsanzeige
- diese Aufgerufene Aktien den Angebotsempfängern gemäß den obigen Bestimmungen dieser Klausel 6.3.2.3 zu, mit
der Maßgabe, dass keiner der Angebotsempfänger verpflichtet ist, mehr Aufgerufene Aktien zu erwerben als den maxi-
malen Teil, den er gemäß Klauseln 6.3.2.3.4 oder 6.3.2.3.5 angegeben hat, und
- unverzüglich dem in Verzug geratenen Aktionär, jeder Person, der Aufgerufene Aktien zugeteilt worden sind (jeder
ein «Kaufender Aktionär») und jedem sonstigen Aktionäre schriftlich mitteilen («Verkaufsanzeige»):
- Name und Anschrift des (der) betreffenden Kaufenden Aktionärs (Aktionäre);
- den Teil der Aufgerufenen Aktien, zu deren Kauf der betreffende Kaufende Aktionär sich verpflichtet hat;
- dass der Abschluss des Verkaufs und des Kaufs binnen zwanzig (20) Geschäftstagen nach dem Datum der Verkaufs-
anzeige (letzteres nicht eingerechnet) stattfinden wird.
6.3.2.3.7 Der Abschluss des Verkaufs und des Kaufs gemäß einer Verkaufsanzeige findet am eingetragenen Sitz der
Gesellschaft zu der in der Verkaufsanzeige angegebenen Zeit statt, zu der der in Verzug geratene Aktionär, nachdem ein
Kaufender Aktionär ihm für die zugeteilten Aufgerufenen Aktien den Preis bei Verzug gezahlt hat, die Übertragung des
betreffenden Teils der Aufgerufenen Aktien an diesen Kaufenden Aktionär (und/oder sonstige Dokumente und Verzicht-
erklärungen, die nach den Gründungsurkunden der Gesellschaft oder nach luxemburgischem Recht zur Übertragung der
Aufgerufene Aktien nötig sind) ordnungsgemäß ausgefertigt hat. Die Aufgerufenen Aktien werden samt aller mit ihnen
verbundenen Rechte zum Datum der Ankündigung der Optionsausübung verkauft, einschließlich des Rechts auf Aus-
schüttungen, die nach diesem Datum für diese Aufgerufenen Aktien der Gesellschaft erklärt werden oder zahlbar sind.
6.3.2.3.8 Sollte der in Verzug geratene Aktionär aus irgendeinem Grunde versäumen, hinsichtlich der Aufgerufene
Aktien eine Abtretung (und/oder sonstige Dokumente und Verzichterklärungen, die nach den Gründungsurkunden der
Gesellschaft oder nach luxemburgischem Recht zur Übertragung der Aufgerufene Aktien nötig sind) ordnungsgemäß
auszufertigen, falls dies nach Klausel 6.3.2.2. erforderlich ist,
- kann die Gesellschaft den Kaufpreis für diese Aufgerufene Aktien von dem Kaufenden Aktionär (den Kaufenden
Aktionären) in Empfang nehmen und nach dem Empfang den Kaufenden Aktionär (die Kaufenden Aktionäre) als Inhaber
der Aufgerufenen Aktien eintragen;
- wird die Gesellschaft diesen Kaufpreis auf einem separaten Bankkonto treuhänderisch für den in Verzug geratenen
Aktionär einzahlen, ist jedoch nicht verpflichtet, für den Betrag auf diesem Konto Zinsen zu beziehen oder zu zahlen;
- die von der Gesellschaft ausgestellte Quittung für diesen Kaufpreis ist eine gültige Entlastung des Kaufenden Aktionärs
(der Kaufenden Aktionäre), der (die) nicht verpflichtet ist (sind), sich um dessen Verwendung zu kümmern; und
- nachdem in beabsichtigter Ausübung der durch diese Klausel 6.3.2.3 erteilten Vollmacht der Name des Kaufenden
Aktionärs (die Namen der Kaufenden Aktionäre) in das Aktionärsregister eingetragen worden ist (sind), darf niemand
die Gültigkeit des Verfahrens in Frage stellen.
6.3.2.3.9 Falls die Gesellschaft gemäß den obigen Bestimmungen dieser Klausel 6.3.2.3 Angebotsempfänger findet, die
bereit sind, alle Aufgerufenen Aktien zu kaufen, ist der in Verzug geratene Aktionär verpflichtet, sie zu verkaufen oder
für ihren Verkauf zu sorgen, und der Kaufende Aktionär ist (die Kaufenden Aktionäre sind) verpflichtet, im gleichen
Verhältnis wie die Aufgerufenen Aktien sämtliche Darlehen zu kaufen, die der in Verzug geratene Aktionär der Gesellschaft
gewährt hat (gegebenenfalls und ob in verbriefter Form oder nicht), zum Nennwert zuzüglich den gegebenenfalls darauf
aufgelaufenen Zinsen zu kaufen. Dieser Kauf und Verkauf wird zur gleichen Zeit abgeschlossen wie der Kauf und Verkauf
der Aufgerufenen Aktien gemäß Klausel 6.3.2.3.7 und, soweit angebracht, gelten die Bestimmungen der Klauseln 6.3.2.3.8
und 6.3.2.3.9 mutatis mutandis für den Verkauf solcher Darlehen.
6.3.2.3.10 Falls die Kaufoption nicht hinsichtlich aller Aufgerufenen Aktien gemäß den obigen Bestimmungen der Klausel
6.3.2.3 binnen der in Klausel 6.3.2.3.4 vorgeschriebenen Frist ausgeübt wurde,
- wird die Gesellschaft binnen fünf (5) Geschäftstagen ab dem Datum, an dem die Angebotsanzeige abläuft, jeden
Aktionär entsprechend benachrichtigen; und
- unter Umständen gelten die Bestimmungen einer Vereinbarung mit den Aktionären, die die Gesellschaft von Zeit zu
Zeit abgeschlossen hat-
90116
Art. 7. Kapitalerhöhung.
7.1. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der Aktionäre, der wie in Artikel 8 dieser Satzung vorgeschrieben,
in der für Satzungsänderungen erforderlichen Weise angenommen wird.
7.2. Die Gesellschaft kann, soweit im Rahmen des Company Act zulässig, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
Art. 8. Hauptversammlungen.
8.1. Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung vertritt sämtliche Aktionäre der Gesellschaft.
Die Hauptversammlung hat umfassende Befugnis, jede die Gesellschaft betreffende Maßnahme zu verabschieden oder
zu ratifizieren. Insbesondere ist die Hauptversammlung für alle Angelegenheiten zuständig, in denen der Verwaltungsrat
nach alleinigem Ermessen die formelle Genehmigung der Hauptversammlung wüscht.
8.2. Eine Hauptversammlung wird gemäß Company Act einberufen, indem zwei Mitglieder des Verwaltungsrats an
jeden Aktionär eine Einberufungsbekanntmachung schicken.
8.3. Außer wenn im Company Act oder in der Satzung etwas anderes vorgeschrieben ist, ist eine Hauptversammlung
beschlussfähig, wenn zwei Aktionäre anwesend sind, sofern einer dieser Aktionäre ein A-Aktionär ist.
8.4. Jeder Aktionär ist hat ein Stimmrecht je Aktie in seinem Besitz. Ein Aktionär kann auf jeder Aktionärsversammlung
handeln, indem er einer anderen Person durch Schreiben oder Fax, Telegramm oder Fernschreiben eine Stimmrechts-
vollmacht erteilt.
8.5. Außer wenn der Company Act und die Satzung etwas anderes vorschreiben, werden Beschlüsse auf einer ord-
nungsgemäß einberufenen Aktionärsversammlung mit einfacher Mehrheit der Anwesenden und Abstimmenden verab-
schiedet, ungeachtet des Anteils des Kapitals, das vertreten ist.
Die nachstehenden Entscheidungen können jedoch nur einstimmig von allen Aktionären und unter Einhaltung etwaiger
sonstiger Rechtsvorschriften vorgenommen werden:
h. die Änderung der Nationalität der Gesellschaft;
i. die Erhöhung der Verpflichtungen ihrer Aktionäre;
j. Änderungen der Satzung;
k. die Änderungen des Stammkapitals der Gesellschaft, einschließlich der Herabsetzung, des Kaufs oder der Einziehung
eines Teils des Stammkapitals oder Schaffung von Optionen, Zeichnungsrechten oder Wandlungsrechten über einen Teil
des Stammkapitals der Gesellschaft.. mit Ausnahme einer vom Verwaltungsrat im Rahmen des genehmigten Kapitals
beschlossenen Kapitalerhöhung;
l. ein Beschluss zur Liquidation der Gesellschaft.
m. das Treffen einer allgemeinen Vereinbarung mit Gläubigern, um die Insolvenz zu vermeiden (concordat préventif
de la faillite), die Vereinbarung, einer kontrollierten Geschäftsleitung zu unterliegen (gestion contrólée), die Vereinbarung
zur Stundung von Zahlungsfristen (sursis de paiement), der Beschluss, einer gerichtlichen Liquidation zu unterliegen (li-
quidation judiciaire), die Vornahme einer Insolvenzanmeldung in Bezug auf die Gesellschaft, der Abschluss einer allge-
meinen Vereinbarung oder eines Vergleichs der Gesellschaft mit ihren Gläubigern, oder die Beantragung eines anderen
ähnlichen Gerichtsverfahrens, Liquidations-, Konkurs- oder Insolvenzverfahrens in Bezug auf die Gesellschaft oder die
Beantragung eines vom Gericht ernannten Verwalters (commissaire à la gestion contrólée), eines gerichtlichen Liquidators
(liquidation judiciaire), eines Treuhänders oder Vermögensverwalters im Insolvenzfall (curateur), eines Commissaire oder
ähnlichen Amtsträgers, der in Bezug auf die Gesellschaft zu ernennen ist.
n. die Änderung der vereinbarten Obergrenze, wie in der Vereinbarung mit den Aktionären definiert, die die Gesell-
schaft unter Umständen von Zeit zu Zeit mit ihren Aktionären geschlossen hat.
8.6. Der Verwaltungsrat kann durch einstimmigen Beschluss etwaige sonstige Bedingungen festlegen, die die Aktionäre
erfüllen müssen, damit sie an einer Hauptversammlung teilnehmen können.
8.7. Wenn alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend sind oder vertreten werden, und wenn sie angeben,
dass sie im Voraus Informationen über die Tagesordnung der Versammlung erhalten haben, können die Aktionäre wirksam
auf etwaige Einberufungsformalitäten verzichten.
Art. 9. Verwaltungsrat.
9.1. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der sich aus sechs Mitgliedern zusammensetzt (jeweils
ein «Verwaltungsratsmitglied»), die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.
9.2. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gemäß nachstehenden Regeln ernannt:
9.2.1. Ein Verwaltungsratsmitglied wird aus einer Liste von mindestens zwei Kandidaten ernannt, die von dem A-
Aktionär vorgeschlagen werden (das «A-Verwaltungsratsmitglied»);
9.2.2. Ein Verwaltungsratsmitglied wird aus einer Liste von mindestens zwei Kandidaten ernannt, die von dem B-
Aktionär vorgeschlagen werden (das «B-Verwaltungsratsmitglied»).
9.2.3. Bis zu einem Verwaltungsratsmitglied wird aus einer Liste von mindestens zwei Kandidaten ernannt, die von dem
C-Aktionär vorgeschlagen werden (das «C-Verwaltungsratsmitglied»).
9.2.4. Drei Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gemäß den Vorschriften der Satzung und
des Company Act ernannt (die «D-Verwaltungsratsmitglieder»).
90117
9.3. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren ernannt und bleiben im
Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind.
9.4. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mit oder ohne Grund durch Beschluss der Hauptversammlung seines Amtes
enthoben und jederzeit ersetzt werden. Im Falle, dass ein Verwaltungsratsmitglied entfernt oder ersetzt wird, oder im
Falle, dass ein Verwaltungsratsmitglied zurücktritt, stirbt, in Pension geht, oder im Falle einer anderen Vakanz, wird sein/
ihr Nachfolger unter Einhaltung der Vorschriften des vorstehenden Artikels 9.2 ernannt.
1. 9.5. Im Falle einer oder mehrerer Vakanzen im Verwaltungsrat aufgrund von Tod, Pensionierung oder aus anderen
Gründen müssen die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder innerhalb von dreißig Geschäftstagen einen oder mehrere
Nachfolger ernennen, um diese Vakanz bis zur nächsten Aktionärsversammlung zu füllen.
2. 9.6. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für ihre Leistungen als Verwaltungsratsmitglied nicht vergütet, es sei
denn, dass die Hauptversammlung etwas anderes beschließt. Die Gesellschaft wird die Verwaltungsratsmitglieder für
angemessene Aufwendungen entschädigen, die ihnen durch ihr Amt entstanden sind, einschließlich angemessener Reise-
und Lebenshaltungskosten, die für die Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats entstanden sind.
Art. 10. Verfahren der Sitzung des Verwaltungsrats.
10.1. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden
wählen. Es kann auch einen Sekretär wählen, der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss, und der für die Protokollführung
bei der Sitzung des Verwaltungsrat und der Aktionärsversammlung verantwortlich ist.
10.2. Der Verwaltungsrat trifft mindestens vierteljährlich je Kalenderjahr auf die Aufforderung des Vorsitzenden oder
zwei der Verwaltungsratsmitglieder an dem Ort zusammen, der in der Einberufungsmitteilung angegeben ist, jedoch in
jedem Fall in Luxemburg. Die Einberufungsmitteilung, die unter anderem eine Tagesordnung enthält, in der die in der
Sitzung zu erörternden Angelegenheiten angemessen detailliert angegeben sind, wird spätestens sieben (7) Geschäftstage
vor dem für die Sitzung festgelegten Datum per Brief (gesendet durch Express-Brief oder besonderen Kurier), Telegramm,
Fax, Email an jeden Verwaltungsratsmitglied gesendet, außer wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder vereinbart,
die Mitteilungsfrist zu verkürzen, oder unter Umständen, bei denen Notfall vorliegt, wobei die Art dieser Umstände in
der Einberufungsmitteilung dargelegt werden soll und eine Frist von mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem
für diese Sitzung festgelegten Zeitpunkt per Telefax und/oder Telegramm ausreichend ist. Der Verwaltungsrat kann sich
ohne vorherige Mitteilung beraten und Entscheidungen vornehmen, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend sind
oder vertreten werden und auf die Einberufungserfordernisse und Formalitäten schriftlich oder per Fax, Telegramm oder
Email durch jedes Verwaltungsratsmitglied verzichtet wurde. Es werden alle angemessenen Anstrengungen unternommen,
damit jedes Verwaltungsratsmitglied ausreichend im Voraus einer Sitzung des Verwaltungsrats eine Kopie der Dokumente
und/oder Materialien übermittelt wird, die von dem Verwaltungsrat bei dieser Sitzung zu erörtern sind, oder über die
ein Beschluss zu fassen ist.
10.3. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann bei einer Sitzung des Verwaltungsrats durch die schriftlich oder per Fax,
Telegramm oder Email erfolgte Ernennung eines anderen Verwaltungsratsmitglieds zu seinem Bevollmächtigten handeln.
Die Nutzung einer Videokonferenzeinrichtung und einer Telefonkonferenz ist erlaubt, und die Verwaltungsratsmitglieder,
die diese Technologie nutzen, sind als anwesend anzusehen und autorisiert per Video oder Telefon abzustimmen. Nach
der Beratung können Stimmen auch schriftlich oder per Fax, Telex oder Telefon abgegeben werden, vorausgesetzt, dass
diese Stimme in den letzteren Fällen schriftlich bestätigt wird.
10.4. Das Quorum für die Abwicklung einer Transaktion bei einer Sitzung des Verwaltungsrats besteht, wenn eine
Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend ist oder von einem anderen Verwaltungsratsmitglied vertreten wird,
wobei diese Mehrheit mindestens ein (1) A-Verwaltungsratsmitglied und entweder mindestens ein (1) B-Verwaltungs-
ratsmitglied oder ein C-Verwaltungsratsmitglied umfassen muss. Vorbehaltlich des Vorstehenden wird die Sitzung, wenn
der Verwaltungsrat nicht binnen 1 Stunde nach der Uhrzeit, an der sie beginnen sollte, beschlussfähig ist oder während
der Sitzung beschlussunfähig wird, auf den nächstfolgenden fünften Geschäftstag zur gleichen Zeit am gleichen Ort vertagt.
10.5. Unbeschadet der in diesem Artikel festgelegten Vorschriften hinsichtlich Wichtiger Entscheidungen, der Mehr-
heitsentscheidungen dargelegten Anforderungen werden Entscheidungen von einer Mehrheit der Stimmen der bei dieser
Sitzung anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder vorgenommen werdengetroffen. Im Falle einer Stim-
mengleichheit verfügt der Vorsitzende über keine ausschlaggebende Stimme.
Darüber hinaus erfordern Entscheidungen über die in diesem zweiten Absatz des Artikels 10.5 aufgeführten Angele-
genheiten (die «Wichtigen Entscheidungen»), die Einstimmigkeit der auf der Sitzung des Verwaltungsrats anwesenden
oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder:
1. Mit Ausnahme der Entscheidungen gemäß Kreditverträgen in der von Zeit zu Zeit geänderten Fassung, die die
Gesellschaft vor der Verabschiedung dieser Satzung abgeschlossen hätte, über die Ausgabe einer Schuldurkunde oder das
Eingehen von Verbindlichkeiten oder Aufnahmen von Fremdmitteln in der Art von Verbindlichkeiten.
2. Die Aufnahme von Fremdmitteln.
3. Die Schaffung einer Hypothek, einer Verpfändung, eines Pfandrechts, einer Belastung, einer Sicherheitsabtretung,
einer Treuhandvereinbarung oder anderen dinglichen Belastung oder Vereinbarung mit der Wirkung einer Sicherheit auf
ihr Unternehmen, Eigentum oder Vermögenswerte oder einen Teil davon - ob jetzt oder in der Zukunft.
4. Die hypothekarische Belastung einer Beteiligung an unbeweglichem Vermögen.
90118
5. Das wesentliche Entfernen aus dem gewöhnlichen Verlauf des täglichen Geschäfts der Gesellschaft, entweder hin-
sichtlich des Wesens oder des Geltungsbereichs oder der Art und Weise, in der sie dies führt.
6. Die Gewährung von Darlehen oder Zahlungen oder die Einräumung eines Kredits oder die Abgabe von Garantien
oder anderen Verpflichtungen der Gesellschaft, auf andere Weise als im normalen Geschäftsverlauf der Gesellschaft.
7. Der Verkauf, die Lizenzierung, die Übertragung oder die anderweitige Verfügung über ihr Geschäft, ihre Vermö-
genswerte oder ihr Unternehmen oder einen wesentlichen Teil davon, abweichend vom normalen Geschäftsverlauf der
Gesellschaft.
8. Der Abschluss, die Beendigung oder die Änderung eines Dienstvertrags oder anderer Bestimmungen der Leistungen
eines leitenden Verwaltungsratsmitglieds oder einer Führungskraft der Gesellschaft.
9. Die Erweiterung oder die Entwicklung des Geschäfts der Gesellschaft, außer durch sich selbst oder ein Mitglied des
Konzerns.
10. Der Abschluss eines Dienst- oder anderen Vertrags mit einem Verwaltungsratsmitglied oder einer verbundenen
Person, oder die wesentliche Änderung eines solchen Vertrages.
11. Die Anpassung oder die Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze und Grundlagen, auf die die jährliche Gewinn-
und Verlustrechnung und die Bilanz der Gesellschaft und des Konzerns gestützt werden.
12. Die Änderung oder Beendigung von Bankfazilitäten oder die Vornahme einer Handlung, um dies zu tun, oder die
Zulassung der Beendigung ihrer Verfügbarkeit.
13. Die Änderung der Bestimmungen einer Managementvereinbarung, die die Gesellschaft von Zeit zu Zeit abschließt;
14. Die Einrichtung von Pensions-, Prämien-, Gewinnbeteiligungs- oder anderen Anreizplänen für Verwaltungsrats-
mitglieder und/oder Mitarbeiter der Gesellschaft.
15. Die Vornahme von Schritten zur Abwicklung eines Mitglieds des Konzerns.
16. Die Zeichnung, der Kauf oder der Erwerb von Aktien, Schuldverschreibungen oder anderen Beteiligungen an einem
anderen Unternehmen, einer Treuhandgesellschaft oder einer anderen Institution.
17. Der Abschluss von Joint Ventures, Partnerschaften, Konsortien oder anderen ähnlichen Vereinbarungen.
18. Außer wie in dieser Satzung dargelegt, eine Vereinbarung mit den Aktionären, die die Gesellschaft und alle Aktionäre
von Zeit zu Zeit über die Ernennung eines Ausschusses ihres Verwaltungsrats oder eines anderen Ausschusses der
Gesellschaft treffen können.
19. Die Beschäftigung oder die Vereinbarung der Beschäftigung eines Mitarbeiters.
20. Die Vereinbarung einer Änderung oder eines Verzichts auf eine der Vorschriften einer Vereinbarung mit den
Aktionären, die die Gesellschaft von Zeit zu Zeit getroffen haben kann.
21. Die Änderung oder Ergänzung der Bestimmungen des Business Plans.
22. Das Eintreten in eine Transaktion oder die Vornahme einer Sache in Bezug auf eine Angelegenheit des Investiti-
onsausschusses, die nicht von der Mehrheit des Investitionsausschusses genehmigt wurde.
10.6 Ungeachtet des Vorstehenden, erfordern die nachstehenden Entscheidungen die vorherige gutachtliche Stellung-
nahme Beratung (die «»Beratunggutachtliche Stellungnahme des «Investitionsausschusses») des Investitionsausschusses,
wie nachstehend definiert:
Der Erwerb einer neuen Immobilienbeteiligung (ob direkt oder indirekt durch den Erwerb von Aktien oder einer
anderen Beteiligung)
23. Der Verkauf einer Immobilienbeteiligung oder der Verkauf von Beteiligungen an einem Mitglied des Konzerns.
24. Die Gewährung oder die Erneuerung einer Mietbeteiligung, wenn der Gesamtwert der Miete (eine Prämie und die
über die Laufzeit zahlbare Miete) 20 % der Erwerbskosten der gesamten Immobilie übersteigt, aus der die Mietbeteiligung
gewährt wird.
25. Der Eintritt in einen Vertrag in Bezug auf Vermögenswerte (mit Ausnahme einer Immobilienbeteiligung).
26. Die Vornahme anderer Geschäftstätigkeiten oder Aktivitäten als das Geschäft.
27. Die Genehmigung des Business Plans oder Änderungen desselben zum jeweiligen Zeitpunkt.
Die Beratung des Investitionsausschusses ist für den Verwaltungsrat nicht verbindlich.
10.7 Von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnete Beschlüsse haben die gleiche Wirkung wie während
einer Sitzung vorgenommene Beschlüsse.
10.8 Im Sinne der Satzung bezeichnet «Geschäftstag» einen Kalendertag (mit Ausnahme eines Samstags oder eines
Sonntags), an dem Banken für ihre Geschäftstätigkeit in Luxemburg geöffnet sind.
10.9. Im Falle, dass ein Verwaltungsratsmitglied oder eine Führungskraft der Gesellschaft ein nachteiliges persönliches
Interessen an einer Transaktion der Gesellschaft haben könnte, hat dieses Verwaltungsratsmitglied oder diese Führungs-
kraft dem Verwaltungsrat dieses persönliche Interesse zur Kenntnis zu bringen, und wird, sofern nicht durch einstimmige
Billigung der Aktionäre etwas anderes beschlossen wird, diese Transaktion nicht in Erwägung ziehen oder darüber ab-
stimmen, und der Verwaltungsrat wird dieses Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder der Führungskraft der
nächstfolgenden Aktionärsversammlung gemeldet, es sei denn, dass der Verwaltungsrat dafür zuständig ist.
90119
Art. 11. Protokoll der Sitzungen des Verwaltungsrats.
11.1 Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in dem Protokoll aufgezeichnet, dass von allen bei der Sitzung an-
wesenden Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen ist, und werden in den Unternehmensbüchern der Gesellschaft
aufgezeichnet.
11.2 Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die in gerichtlichen Verfahren oder auf andere Weise vorgelegt werden,
werden von dem Vorsitzenden, dem Sekretär oder von zwei Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet.
Art. 12. Befugnisse des Verwaltungsrats.
12.1 Dem Verwaltungsrat werden die umfassenden Befugnisse zur Erbringung aller Handlungen der Verwaltung und
Verfügung im Interesse der Gesellschaft verliehen. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich vom Company Act oder von
der Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.
12.2 Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Durchführung der täglichen Leitung und der Angelegenheiten der
Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft für diese Leitung und Angelegenheiten auf eines der Mitglieder des
Verwaltungsrats übertragen, das Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (Managing Director) genannt wird. Er kann
auch sämtliche Befugnisse und Sondermandate auf eine Person übertragen, die kein Verwaltungsratsmitglied sein muss,
alle Führungskräfte und Mitarbeiter ernennen und entlassen und ihre Einkünfte bestimmen.
Art. 13. Verbindliche Unterschirft. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwal-
tungsratsmitgliedern der Gesellschaft, oder durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift einer Person verpflichtet,
auf die diese Unterschriftsbefugnis mit einstimmiger Billigung der Mitglieder des Verwaltungsrat übertragen wurde.
Art. 14. Investitionsausschuss.
14.1 Die Gesellschaft wird einen Investitionsausschuss haben, der sich anfänglich aus bis zu vier (4) Mitgliedern zu-
sammensetzt, die keine Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind. Für die Ernennung des Investitionsausschusses
und jede Angelegenheit, die sich auf seine Verfahren bezieht, gelten die Bedingungen einer Vereinbarung mit den Aktio-
nären, die von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft und allen Aktionären geschlossen wurde; in Ermangelung derartiger
Bedingungen gelten die Bestimmungen von Artikel 14.2 bis 14.7.
14.2. Die Mitglieder des Investitionsausschusses (die «Ausschussmitglieder») werden von der Hauptversammlung ge-
mäß nachstehenden Regeln ernannt:
14.2.1. Zwei Ausschussmitglieder werden aus einer Liste von vier Kandidaten ernannt, die von dem A-Aktionär vor-
geschlagen wurden;
14.2.2. Ein Ausschussmitglied wird aus einer Liste von zwei Kandidaten ernannt, die von dem B-Aktionär vorgeschlagen
wurden;
14.2.3. Ein Ausschussmitglied wird aus einer Liste von zwei Kandidaten ernannt, die von dem C-Aktionär vorgeschlagen
wurden.
14.3 Der Investitionsausschuss wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen (der «Präsident»). Er wird
auch einen Sekretär wählen, der kein Mitglied sein muss und für die Aufnahme des Sitzungsprotokolls des Investitions-
ausschusses verantwortlich ist.
14.4 Die Amtszeit für jedes Mitglied des Investitionsausschusses beträgt zwei (2) Jahre und kann um zwei weitere 2-
Jahreszeiträume verlängert werden..
14.5 Ein Mitglied des Investitionsausschusses wird von der Hauptversammlung seines Amts enthoben, wenn die Akti-
onäre, die anfänglich seine oder ihre Ernennung vorgeschlagen haben, dies fordern.
14.6 Die Ausschussmitglieder erhalten für ihre Arbeit als Mitglieder keine Vergütung. Die Gesellschaft wird den Aus-
schussmitgliedern angemessene Aufwendungen erstatten, die ihnen durch ihr Amt entstanden sind, einschließlich ange-
messener Reise- und Lebenshaltungskosten, die durch Teilnahme an Sitzungen des Investitionsausschusses entstanden
sind.
14.7 Sitzungen des Investitionsausschusses werden in den Geschäftsräumen der Gesellschaft abgehalten, sofern nicht
die Ausschussmitglieder einstimmig beschließen, die Sitzung an einem anderen Ort in Luxemburg abzuhalten.
14.8 Ein Mitglied des Investitionsausschusses, ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Verwaltungsratsmitglied eines
Konzernmitglieds kann Sitzungen des Investitionsausschusses einberufen. Sitzungen des Investitionsausschusses werden
so oft abgehalten, wie das Geschäft der Gesellschaft dies erfordert, jedoch mindestens vierteljährlich je Kalenderjahr.
Jedes Mitglied des Investitionsausschusses sowie jedes Mitglied des Verwaltungsrats oder ein Verwaltungsratsmitglied
oder Manager einer Tochtergesellschaft (wie unter Umständen von Zeit zu Zeit in einer Vereinbarung der Gesellschaft
mit den Aktionären definiert) kann verlangen, dass eine Sitzung einberufen wird. Sitzungen werden schriftlich einberufen.
Die Einberufungsmitteilung, die unter anderem eine Tagesordnung enthält, in der die bei der Sitzung zu erörternden
Angelegenheiten angemessen detailliert angegeben sind, und die von Kopien relevanter bei der Sitzung zu erörternder
Schriftstücke begleitet wird, wird per Brief (durch Express-Brief oder Sonderkurier gesendet), Telegramm, Fax, Email an
jedes Mitglied mindestens sieben (7) Geschäftstage vor dem für die Sitzung festgesetzten Datum gesendet, außer in Fällen,
wenn die Mehrheit der Ausschussmitglieder vereinbaren, die Frist zu verkürzen, oder unter Umständen eines Notfalls,
wobei in diesem Fall die Art dieser Umstände in der Einberufungsmitteilung dargelegt wird, und eine Einberufungsfrist
von mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für diese Sitzung festgelegten Zeitpunkt per Telefax und/oder
90120
Telegramm ausreichend ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Tag, an dem die Einladung verschickt wird.
Der Sitzungstag zählt nicht zur Ankündigungsfrist.
14.9 Abwesende Mitglieder des Investitionsausschusses können durch andere Mitglieder oder Nicht-Mitglieder ver-
treten werden, denen eine schriftliche Vollmacht erteilt wurde.
14.10 Mitglieder des Verwaltungsrats, Sachverständige und andere Personen können von dem Präsidenten oder einem
entsprechend von dem Präsidenten autorisierten Mitglied eingeladen werden, an der Sitzung teilzunehmen. Es haben
jedoch nur die Ausschussmitglieder das Recht, bei Sitzungen des Investitionsausschusses abzustimmen.
14.11 Die Nutzung einer Videokonferenzeinrichtung und einer Telefonkonferenz ist erlaubt, und die Ausschussmit-
glieder, die diese Technologie nutzen, sind als anwesend anzusehen und sind autorisiert über Video oder das Telefon
abzustimmen. Nach der Beratung können Stimmen auch schriftlich oder per Fax oder Telegramm oder Telex oder per
Telefon abgegeben werden, vorausgesetzt, dass in diesen letzteren Fällen diese Stimme schriftlich bestätigt wird.
14.12 Protokolle sind (zwecks Nachweis) bei jeder Sitzung des Investitionsausschusses unter Angabe des Ortes und
des Datums der Sitzung, der Teilnehmer, der Tagesordnungspunkte und des wesentlichen Inhalts der Beschlüsse des
Investitionsausschusses zu führen. Das Protokoll wird von dem Präsidenten oder einem Mitglied des Ausschusses unter-
zeichnet, dem dieses Amt von dem Präsidenten übertragen wird. Eine Kopie des Protokolls wird an jedes Mitglied des
Investitionsausschusses und an jedes Mitglied des Verwaltungsrats gesendet.
14.13 Beschlüsse des Investitionsausschusses werden auf Sitzungen des Investitionsausschusses gefasst. Beschlüsse des
Investitionsausschusses können jedoch außerhalb von Sitzungen schriftlich, per Fax oder Videokonferenz unter Verzicht
auf etwaige Bestimmungen dieser Satzung über Einberufung dieser Sitzungen verabschiedet werden, wenn jedes Mitglied
des Investitionsausschusses an der Abstimmung teilnimmt.
14.14 Eine Sitzung des Investitionsausschusses kann Beschlüsse nur verabschieden, wenn mindestens zwei (2) Aus-
schussmitglieder anwesend sind - von denen eines ein auf die Empfehlung des A- Aktionärs ernanntes Ausschussmitglied
sein muss, und von denen eines ein auf die Empfehlung des B-Aktionärs oder des C-Aktionärs ernanntes Ausschussmitglied
sein muss. Bei Fehlen dieses Quorums wird die Sitzung des Investitionsausschusses für 48 Stunden unterbrochen.
14.15 Beschlüsse des Investitionsausschusses werden mit einfachen Stimmenmehrheit seiner auf dieser Sitzung anwe-
senden Mitglieder verabschiedet. Im Falle einer Stimmengleichheit verfügt der Vorsitzende des Aktionärsausschusses nicht
über eine entscheidende Stimme.
14.16 Die auf Empfehlung der A-Aktionäre ernannten Ausschussmitglieder haben - ungeachtet der Anzahl der Aus-
schussmitglieder, die von dem A-Aktionär ernannt wurden, oder der Anzahl, die an einer Sitzung teilnimmt - insgesamt
zwei Stimmen; und die auf Empfehlung des B-Aktionärs und des C-Aktionärs ernannten Ausschussmitglieder haben -
ungeachtet der Anzahl der Ausschussmitglieder, die von dem B-Aktionär und dem C-Aktionär ernannt wurden, oder der
Anzahl, die an einer Sitzung teilnimmt - insgesamt zwei Stimmen.
14.17 Weder der Investitionsausschuss noch seine Mitglieder noch die Aktionäre haften für Ratschläge oder Empfeh-
lungen, die dem Verwaltungsrat erteilt wurden, der allein für eine Maßnahme verantwortlich ist, die er auf Empfehlung
des Investitionsausschusses getroffen hat. Weder die Mitglieder des Investitionsausschusses noch die Aktionäre sind unter
irgendwelchen Umständen als Verwaltungsratsmitglieder, de facto Verwaltungsratsmitglieder, Manager, Mitarbeiter, Or-
gan, Beauftragter oder Vertreter der Gesellschaft anzusehen.
15. Gesetzlicher Prüfer. Wie im Company Act vorgesehen, ist der Betrieb der Gesellschaft ist von einem oder meh-
reren gesetzlichen Prüfern zu beaufsichtigen, der/die nicht Aktionär(e) zu sein brauchen. Die gesetzlichen Prüfer werden
von der Hauptversammlung bestellt, die bestimmt, wie viele Prüfer bestellt werden und die Dauer ihres Auftrags.
16. Gewinnverwendung.
16.3 Gesetzliche Rücklage
Aus dem Jahresüberschuss der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) der vom Company Act vorgeschriebenen
Rücklage zugewiesen. Diese Zuteilung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange diese Überschussrücklage zehn
Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft beträgt.
16.4 Dividenden
16.4.1 Der die Hauptversammlung wird auf Empfehlung des Verwaltungsrats bestimmen, wie der Rest des Jahres-
überschusses verwendet werden soll, und kann zum jeweiligen Zeitpunkt eine Stammdividende beschließen, ohne dass
diese jemals den von dem Verwaltungsrat vorgeschlagenen Betrag übersteigt.
16.4.2 Zwischendividenden können vorbehaltlich der im Company Act festgelegten Bedingungen nach Entscheidung
des Verwaltungsrats und Bericht der gesetzlichen Prüfer ausgeschüttet werden.
17. Auflösung und Liquidation.
17.3 Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden, der wie in Artikel 8
dieser Satzung für eine Satzungsänderung vorgeschriebenen Weise verabschiedet wird.
17.4 Bei einer Auflösung der Gesellschaft wird ihre Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt,
die von der Hauptversammlung, die diese Auflösung vornimmt, ernannt werden; sie bestimmt auch ihre Befugnisse und
Vergütung...
90121
18. Jahreshauptversammlungen.
18.3 Die Jahreshauptversammlung beschließt die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft.
18.4 Die Jahreshauptversammlung wird gemäß dem Company Act jedes Jahr am 20. November um 16.00 Uhr am
eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg, der in der Ankündigung der Versammlung
angegeben werden kann, abgehalten.
18.5 Ist der Tag, auf den die Jahreshauptversammlung anberaumt wurde, kein Geschäftstag, wird die Jahreshauptver-
sammlung am folgenden Geschäftstag abgehalten. Die Jahreshauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn
- nach unabänderlichem und endgültigem einstimmigem Urteil des Verwaltungsrats - außerordentliche Umstände dies
erfordern.
18.6 Andere ordentliche und außerordentliche Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abge-
halten werden, die in der jeweiligen Ankündigung dieser Versammlungen angegeben sind. Sie können am eingetragenen
Sitz oder an einem anderen Ort abgehalten werden.
19. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am ersten Tag des Monats Juli und endet am
letzten Tag des Monats Juni jedes Jahres, mit Ausnahme des aktuellen Geschäftsjahres, das am Datum der Gründung der
Gesellschaft begonnen hat und am 30. Juni 2008 endet.
Der unterzeichnete Notar, der englisch spricht, gibt an, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen
Partei auf englisch formuliert ist, gefolgt von einer deutschen Version, und im Falle von Widersprüchen zwischen dem
englischen und dem deutschen Text ist die englische Version verbindlich.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die folgenden Personen mit sofortiger Wirkung als Mitglieder des Verwaltungs-
rates mit den folgenden Bezeichnungen zu ernennen:
- Derek McDonald, geboren am 9 August 1967 in Paisely, Scotland, Geschäftsführer, mit Geschäftsadresse in 4th Floor,
Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh, EH12 5RD als A-Mitglied des Verwaltungsrates;
- Ian Blake, geboren am 29 January 1963 in Stafford (United Kingdom), mit Geschäftsadresse in One Jermyn Street,
London, SW1Y 4UH, United Kingdom als B-Mitglied des Verwaltungsrates;
- Hille-Paul Shut, geboren am 29 September 1977 in The Hague (Netherlands), mit Geschäftsadresse in 20, rue de la
Poste, L-2346 Luxemburg als C-Mitglied des Verwaltungsrates;
- François Pfister, geboren am 25 October 1961 in Uccle (Belgium), mit Geschäftsadresse in 20, avenue Monterey,
L-2016 Luxembourg als D-Mitglied des Verwaltungsrates;
- Jacques de Patoul, geboren am 10 January 1980 in Luxemburg, mit Geschäftsadresse in 20, rue de la Poste, L-2346
Luxemburg als D-Mitglied des Verwaltungsrates;
- Godfrey Abel, geboren am 2 July 1960 in Brixworth, Northampton, England, mit Geschäftsadresse in 30, rue de
Crecy, L-1364 Luxemburg als D-Mitglied des Verwaltungsrates;
Ohne Erneuerung wird ihre Amtszeit nach der jährlichen Generalversammlung der Gesellschaft welche die Geneh-
migung der Bilanzen der Gesellschaft für das am 30 Juni 2008 beendete Jahr beschließt, ablaufen.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Aktionärsversammlung beschliesst, KPMG AUDIT, mit Gesellschatssitz in 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg,
zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens zu wählen.
Ohne Erneuerung wird seine Amtszeit nach der jährlichen Generalversammlung der Gesellschaft welche die Geneh-
migung der Bilanzen der Gesellschaft für das am 30 Juni 2008 beendete Jahr beschließt, ablaufen.
<i>Kosteni>
Die Gesamtkosten, Auslagen und Honorare, welche die Gesellschaft in welcher Form auch immer übernimmt oder
die der Gesellschaft in Rechnung gestellt wird, aufgrund von dieser ausserordentliche Generalversammlung, wird ohne
Nachteil auf die Summe von EUR 5.000,- geschätzt.
Da es keine weiteren Tagesordnungspunkte gibt, wurde die Versammlung vertagt.
Worüber Urkunde errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben sie dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar
unterschrieben.
Der unterzeichnende Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparenten die gegen-
wärtige Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Ersuchen derselben Komparenten und
im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
Gezeichnet: J. De Patoul, A. Siebenaler, N. Ronzel, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2007, Relation: LAC/2007/10288. — Reçu 890 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Für gleichlautende Kopie, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
90122
Luxemburg, den 15. Juni 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007088424/242/1389.
(070098858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.
Balo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 101.393.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007088210/2329/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG03144. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070098347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.
Constant Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 73.099.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007088209/2329/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG03146. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070098345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.
White Knight S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 103.497.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
B. Zech.
Référence de publication: 2007088206/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09585. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070098365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.
Quadriga Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 18.467.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale annuelle des actionnairesi>
<i>tenue en date du 28 juin 2007i>
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine
assemblée générale statutaire, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
- Michael Korrodi, Genferstrasse 8, CH-8002 Zurich, Suisse
- Nicholas Dale, Nidelbadstrasse 98, CH-8803 Rüschlikon, Suisse
- CORDICO MANAGEMENT AG, Cura Treuinstitut 36, 9490 Vaduz, Principauté du Liechtenstein
90123
<i>Commissaire aux comptes:i>
- DR. W. MEILI + PARTNER AG, Lavaterstrasse 40, CH-8002 Zurich, Suisse
Luxembourg, le 12 juillet 2007.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007087685/631/23.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2007, réf. LSO-CG07106. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
214 Wilson S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 18-20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 111.369.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2007.
ATOZ
Signature
Référence de publication: 2007087693/4170/16.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2007, réf. LSO-CG07339. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Kruger Brent Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 76.014.
Par jugement du 12 juillet 2007, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
section, siégeant en matière
commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leur
conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:
KRUGER BRENT LUXEMBOURG HOLDING SA - RC B 76014.
Pour extrait conforme
M
e
P. Luciani
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2007087694/6739/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09552. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
NSA, North & South Airlogistics, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.774.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2007i>
L'assemblée, à l'unanimité des voix présentes et représentées, accepte la démission de M. Toufik Djafer au poste de
gérant.
En remplacement, l'assemblée décide de nommer la société ABC IMPORT-EXPORT Sàrl, R.C.S. Luxembourg: B
24.112, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant que gérant avec pouvoir de signature seule.
90124
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007087696/734/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2007, réf. LSO-CG02515. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Itstream S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 12, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 22.007.
Par jugement du 12 juillet 2007, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
section, siégeant en matière
commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leur
conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:
ITSTREAM S.A. - RC B 22 007.
Pour extrait conforme
M
e
P. Luciani
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2007087700/6739/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09550. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Pharos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue de Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg B 104.932.
L'an deux mille sept, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Valérie Wesquy, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme
PHAROS S.A., ayant son siège social à L-1227 Luxembourg, 3, rue de Belle-Vue, R.C.S. Luxembourg section B numéro
104.932, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, alors de résidence à Remich en date du 9 décembre
2004, publié au Mémorial C numéro 255 du 22 mars 2005, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire Maître Martine Schaeffer, de résidence à Luxembourg en date du 12 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 713 du 26 avril 2007, en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil
d'administration, prise en sa réunion du 21 juin 2007.
L'extrait dudit procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire ins-
trumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que le capital social de la société anonyme PHAROS S.A., prédésignée, s'élève actuellement à trente et neuf cent
trente et un mille euros (931.000,- EUR), représenté par neuf mille trois cent dix (9.310) actions d'une valeur nominale
de cent euros (100,- EUR) chacune.
II.- Qu'aux termes de l'article trois des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à trois millions cent mille
euros (3.100.000,- EUR) et le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de
capital, l'article trois des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital inter-
venue.
III.- Que le conseil d'administration,
1. en sa réunion du 21 juin 2007 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes de l'article cinq des statuts,
a réalisé l'augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à concurrence de deux cent cinquante mille
euros (250.000,- EUR), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de neuf cent trente et un mille
euros (931.000,- EUR) à un million cent quatre-vingt-un mille euros (1.181.000,- EUR), par la création et l'émission de
deux mille cinq cents (2.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ces actions
nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.
90125
IV.- Que le conseil d'administration, après avoir constaté que tous les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel
de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société de droit américain ABYSS
CONSULTING LLC, ayant son siège social à 101 Main Street, Suite One Tappan New York
V.- Que les deux mille cinq cents (2.500) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées
intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société anonyme PHAROS S.A., prédé-
signée, de sorte que la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) a été mise à la libre disposition de
cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de souscription
et libération.
VI.- Que suite à la réalisation de ces augmentations dans les limites du capital autorisé, l'article trois des statuts est
modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
« Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à un million cent quatre-vingt-un mille euros (1.181.000,- EUR) divisé en
onze mille huit cent dix (11.810) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à trois millions cent mille euros (3.100.000,- EUR) représenté par trente et un mille (31.000)
actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, ainsi qu'il est précisé à
l'article 6 ci-après.
En outre, le conseil d'administration st, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts dans
le mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le
conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sous réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille euros (5.000,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Wesquy, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, LAC/2007/15427. — Reçu 2.500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2007.
P. Serres.
Signée par Maître Patrick Serres, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d'un mandat verbal, en remplacement
de sa collègue Maître Martine Schaeffer, momentanément absent.
Référence de publication: 2007090060/5770/76.
(070100555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2007.
Fondation Pauline de Faillonnet, Etablissement d'Utilité Publique.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 21, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg G 96.
BILAN 2006
<i>Comptei>
<i>Actifi>
<i>Passifi>
(€)
(€)
10 Capital et réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.359.045,34
121 Résultat de l'exercice (bénéfice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
597.077,73
Total classe 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.956.123,07
46 Débiteurs et créditeurs divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.696.009,51
Total classe 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.696.009,51
90126
51 Banques, établissements financiers et assimiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.634.132,58
52 Placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.018.000,00
Total classe 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.652.132,58
22.652.132,58 22.652.132,58
Signatures.
Référence de publication: 2007089008/504/22.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06490. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Transnational Financial Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R.C.S. Luxembourg B 34.227.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007089004/6053/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08694. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
diffusion saint-paul, Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.
R.C.S. Luxembourg B 65.930.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007089001/1196/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2007, réf. LSO-CG07331. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070098084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Gallo S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 50.280.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087640/604/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06481. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Restaurant-Brasserie des Bateliers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 80.162.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
90127
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007087698/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06301. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Wong's S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4351 Esch-sur-Alzette, 47, rue Arthur Useldinger.
R.C.S. Luxembourg B 31.983.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007087699/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06299. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070097679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Kiffer Impress, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7545 Mersch, 18, rue Lohr.
R.C.S. Luxembourg B 75.533.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007087701/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06298. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
MGP Pope S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 116.812.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 29 juin 2007i>
Il résulte des dites résolutions que:
L'assemblée a réélu PricewaterhouseCoopers S.à r.l. demeurant à 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg comme
commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2008.
<i>Pour MGP POPE S.àr.l.
i>J. Mossong
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2007087706/3648/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06533. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
MGP Europe (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 114.151.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 29 juin 2007i>
Il résulte des dites résolutions que:
90128
L'assemblée a réélu PricewaterhouseCoopers S.à r.l. demeurant à 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg comme
commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2008.
<i>Pour MGP EUROPE (LUX) S.à r.l.
i>J. Mossong
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2007087709/3648/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06499. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
MGP Europe Parallel (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 114.150.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 29 juin 2007i>
Il résulte des dites résolutions que:
L'assemblée a réélu PricewaterhouseCoopers S.à r.l. demeurant à 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg comme
commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2008.
<i>Pour MGP EUROPE PARALLEL (LUX) S.à r.l.
i>J. Mossong
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2007087711/3648/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06486. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Lumedia Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 78.209.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087849/664/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2007, réf. LSO-CG06062. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Anglo Coal Cerrejon, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 108.656.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Signature
<i>Administrateuri> / <i>Géranti>
Référence de publication: 2007087835/1115/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG02074. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
90129
Damode-MG Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 83.721.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 mars 2007i>
Monsieur Norbert Schmitz et les sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs
pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle
période de 6 ans.
<i>Pour DAMODE-MG HOLDING S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007087836/1023/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2007, réf. LSO-CF03659. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070097380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Cadanor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 46.106.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2007i>
Renouvellement des mandats venus à échéance le 3 mai 2005 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2011. Madame
Rachel Backes, Monsieur Jean Bintner et la société S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs. Monsieur Eric
Herremans est réélu Commissaire.
<i>CADANOR S.A.
i>S.G.A. SERVICES S.A. / R. Backes
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007087840/1023/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2007, réf. LSO-CF01415. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
SBS European Pay TV Services, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 129.854.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the fourth day of July.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SBS BROADCASTING EUROPE BV, a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered
office at Rietlandpark 353, NL-1019 EM Amsterdam, registered to the trade and companies register of Amsterdam under
the number 34232207,
duly represented by Mrs Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal in Amsterdam on the 25th May 2007.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain
attached to this document in order to be registered therewith.
Such appearing party has requested the notary to draw up the following articles of association of a société à respon-
sabilité limitée, which they declare organised as follows:
A. Purpose - duration - name - registered office
Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), as well
as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is any activity of television broadcasting, including pay-television, on demand or
not, encrypted or not, by any means currently known or not, including by satellite, cable, hertzian transmission or network
90130
(Internet). The further purpose of the Company is to provide services on Internet, to operate and develop all activities
in connection with the realisation of media projects in the fields of audio-visual media, in particular television broadcasting.
It may produce television programmes and carry out all ancillary services directly or indirectly related to its purpose.
The purpose of the Company is also the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.
The Company may also carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of SBS EUROPEAN PAY TV SERVICES.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
B. Share capital - shares
Art. 6. The Company's share capital is set at two hundred and fifty thousand euro (EUR 250,000.-) represented by
two thousand five hundred (2,500) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one (1) or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the joint signature of two managers, one of them being the holder of the business licence.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five (5) days in advance
of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by
mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by mail or facsimile, or any
other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his
colleagues.
90131
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by mail or facsimile, or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of
the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole partner - collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the Law.
E. Financial year - annual accounts - distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first January and ends on the thirty-first December of the same year.
Art. 21. Each year on the thirty-first December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.
<i>Subscription and paymenti>
The two thousand five hundred (2,500) shares have been subscribed by SBS BROADCASTING EUROPE BV, prenamed.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of two hundred and fifty thousand euro (EUR
250,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of December
2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately four thousand euro.
90132
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, SBS BROADCASTING EUROPE BV, representing the entirety
of the subscribed capital has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are elected as managers of the company for an indefinite period:
a) Mr Bart Soepnel, Senior Vice-president Programming and Acquisition, born on 11 February 1958 in Haarlem (The
Netherlands), residing at NL-1217 TA Hilversum, Couperusweg 11,
b) Mr Casper Plantinga, Financial Controller, born on 18 August 1977 at Nairobi (Kenya), residing at NL-2596 VA The
Hague, Paul Gabrielstraat, 29,
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status
and residences, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le quatre juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
SBS BROADCASTING EUROPE BV, une société de droit néerlandais, ayant son siège social à Rietlandpark 353,
NL-1019 EM Amsterdam, enregistrée au registre de commerce et des sociétés d'Amsterdam sous le numéro 34232207,
ici représentée par Madame Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une
procuration sous seing privé donnée à Amsterdam en date du 25 mai 2007.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - durée - dénomination - siège
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. L'objet de la société est toute activité de diffusion télévisuelle, y compris de télévision payante, sur demande
ou non, cryptée ou non, par tous moyens actuellement connus ou non, y compris par satellite, par câble, par ondes
hertziennes ou réseau (Internet). L'objet de la Société est également de gérer et de développer toutes activités en relation
avec la réalisation de projets médiatiques dans le domaine de l'audio-visuel, en particulier la diffusion de programmes de
télévision. Elle peut fournir des services sur Internet, produire des programmes de télévision et fournir tous services
auxiliaires se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qu'elle estime utiles au développement de son
activité.
La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés lu-
xembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société pourra également exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles
pour l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de SBS EUROPEAN PAY TV SERVICES.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en
vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) représenté par deux
mille cinq cents (2.500) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
90133
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un (1) ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature conjointe de deux gérants, dont un est le titulaire de l'autorisation d'établissement.
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres
un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq (5) jours avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit,
envoyé par courrier ou télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit envoyé par
courrier ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, un autre gérant comme son mandataire. Un
gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits, envoyés par courrier ou par télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
90134
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
P. Décisions de l'associe unique - décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la Loi.
E. Année sociale - bilan - répartition
Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 21. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l'inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
F. Dissolution - liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Souscription et libérationi>
L'intégralité des deux mille cinq cents (2.500) parts sociales a été souscrite par SBS BROADCASTING EUROPE BV,
préqualifiée.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de deux cent cinquante mille euros
(EUR 250.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Provisions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de
décembre 2007.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ quatre mille euros.
<i>Résolutionsi>
Et aussitôt, SBS BROADCASTING EUROPE BV, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions sui-
vantes:
Le siège social de la Société est établi aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
Les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Bart Soepnel, Senior Vice-President Programming and Acquisition, né le 11 février 1958 à Haarlem (Pays-
Bas), demeurant à NL-1217 TA Hilversum, Couperusweg 11,
b) Monsieur Casper Plantinga, Financial Controller, né le 18 août 1977 à Nairobi (Kenya), demeurant à NL-2596 VA
La Haye, Paul Gabrielstraat, 29.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la mandataire de la partie compa-
rante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et
en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-
taire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire.
90135
Signé: S. Wagner-Chartier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 10 juillet 2007. Relation: EAC/2007/7898. — Reçu 2.500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 12 juillet 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007088214/239/298.
(070097800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Montemar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 80.872.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007088232/2329/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG03153. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070098339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.
Permalux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 93.390.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2007088246/50/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09929. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070098314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.
Auto Media Group S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 115.627.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2007088248/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09932. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070098316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.
90136
Resultatsystem Internationell, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 91.910.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2007088250/50/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09957. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070098323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.
Framsteget S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 85.651.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2007088244/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09919. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070098312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.
Agrion d'Or, Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 114.797.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 27 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007088544/2980/12.
Enregistré à Diekirch, le 4 juillet 2007, réf. DSO-CG00053. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070098408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.
Videofin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.
R.C.S. Luxembourg B 30.293.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007088986/1196/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2007, réf. LSO-CG07322. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070098107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
90137
Omaha International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 88.776.
Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 août 2002,
publié au Mémorial, Recueil C n
o
1500 du 17 octobre 2002.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 16 avril 2007 que, suite au décès
de Mademoiselle Elisabeth Antona survenu en date du 10 décembre 2006, Monsieur Lionel Capiaux, employé privé,
demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été coopté comme administrateur en
remplacement de Mademoiselle Elisabeth Antona. Monsieur Lionel Capiaux terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 16 avril 2007.
<i>Pour OMAHA INTERNATIONAL S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
<i>Cabinet d'Experts Comptables
i>Signature
Référence de publication: 2007087637/687/21.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2007, réf. LSO-CG02631. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Gallo Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 50.282.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087638/604/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06474. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Gallo S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 50.280.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de1 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087639/604/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06477. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Jack (Cologne 20) S. à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.949.025,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 114.140.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 29 juin 2007i>
Il résulte des dites résolutions que:
L'assemblée a réélu PricewaterhouseCoopers S.à r.l. demeurant à 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg comme
réviseurs d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2008.
90138
<i>Pour JACK (COLOGNE 20) S à.r.l.
i>J. Mossong
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2007087712/3648/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06547. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Jack (Cologne 21) S. à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 999.025,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 114.139.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 29 juin 2007i>
Il résulte des dites résolutions que:
L'assemblée a réélu PricewaterhouseCoopers S.à r.l. demeurant à 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg comme
réviseurs d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2008.
<i>Pour JACK (COLOGNE 21 ) S. à.r.l.
i>J. Mossong
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2007087717/3648/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06552. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Accounting Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7540 Rollingen, 113, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 100.588.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007087718/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06276. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Centre Comptable S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7540 Rollingen, 113, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 50.948.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007087719/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06230. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Cobelpin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 41.075.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
90139
F. Mangen
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007087770/750/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08721. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070098162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
HAWK Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 108.359.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2007.
<i>HAWK GROUP S.A.
i>V. Graffé
<i>CFOi>
Référence de publication: 2007087754/7962/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09863. - Reçu 131 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
HAWK Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 108.931.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A Luxembourg, le 26 juillet 2007.
<i>HAWK MANAGEMENT S.A.
i>V. Graffé
<i>CFOi>
Référence de publication: 2007087753/7962/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09866. - Reçu 123 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Hobbes Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 84.156.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2007i>
- L'Assemblée révoque Monsieur Jürg Fedier de son poste d'administrateur de la société. Conformément à l'article 7
des statuts de la sociétés, les actionnaires détenant des actions de catégorie B proposent de nommer Monsieur Ignacio
Molina, avec adresse au Waidlistrasse 80, CH-8810 Horgen au poste d'administrateur. L'Assemblée décide de nommer
Monsieur Ignacio Molina, avec adresse au Waidlistrasse 80, CH-8810 Horgen jusqu'à l'Assemblée qui statuera sur les
comptes de l'exercice 2007.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Bérénice Kunnari, employée privée, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Henk Heijs, Sector Head/Sr Relationshipman,
avec adresse professionnelle au Bijlmerplein, 888 in NL-1102 MG Amsterdam et de Monsieur Ahmet Gokcen, demeurant
au Rotweg 6, CH-8820 Waedenswill (Suisse) ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A.,
ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2007.
- L'Assemblée confirme que conformément aux statuts de la société, la société est valablement engagée par la signature
conjointe des 5 administrateurs.
90140
Luxembourg, le 29 juin 2007.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007087739/655/29.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG03955. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
MYTransfer Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3380 Noertzange, 91, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 81.859.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087740/3038/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2007, réf. LSO-CG05963. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Fortis Luxembourg-Vie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 30.415.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087750/1856/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07657. - Reçu 58 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Eurostar Overseas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 98.213.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
C. Reuter.
Référence de publication: 2007087769/750/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08713. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070098163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Bartz Constructions S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2323 Luxembourg, 2, boulevard John-Joseph Pershing.
R.C.S. Luxembourg B 22.526.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
90141
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087851/664/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2007, réf. LSO-CG06064. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
4Climate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7248 Bereldange, 21, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 110.580.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087852/664/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2007, réf. LSO-CG06067. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070097538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Valessore Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 29.489.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087853/664/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2007, réf. LSO-CG06069. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Marbre Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22, rue du X Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 60.299.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087854/664/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2007, réf. LSO-CG06079. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Anglo American Ferrous Investments, Société à responsabilité limitée,
(anc. Anglo American Investments 7).
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 122.501.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
90142
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Signature
<i>Administrateuri> / <i>Géranti>
Référence de publication: 2007087828/1115/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG02064. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
STEPEC PROMOTION Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.342.
Il résulte d'une décision du gérant au 1
er
juin 2007 que le siège social de la société est transféré de c/o FIDUCIAIRE
VINCENT LA MENDOLA S.àr.l, L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2007.
<i>Pour STEPEC PROMOTION LUXEMBOURG S.àr.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007087829/2352/16.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2007, réf. LSO-CG07203. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Anglo American International, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 41.552.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Signature
<i>Administrateuri> / <i>Géranti>
Référence de publication: 2007087830/1115/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG02066. - Reçu 40 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Anglo American Investments 6, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 122.491.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Signature
<i>Administrateuri> / <i>Géranti>
Référence de publication: 2007087831/1115/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG02067. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
90143
Capellen Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 87.449.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F. Mangen.
Référence de publication: 2007087772/750/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08725. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070098160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
Luxlorbois, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4772 Pétange, 42, rue de la Piscine.
R.C.S. Luxembourg B 111.058.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Weber
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007087363/236/11.
(070096755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
CB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 105.266.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Weber
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007087365/236/11.
(070096751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Jumbio S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9221 Diekirch, 173, rue Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 124.207.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Weber
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007087369/236/11.
(070096748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
90144
214 Wilson S.à.r.l.
4Climate S.à r.l.
Accounting Partners S.à r.l.
Agrion d'Or
Anglo American Ferrous Investments
Anglo American International
Anglo American Investments 6
Anglo American Investments 7
Anglo Coal Cerrejon
Auto Media Group S.A.
Balo S.A.
Bartz Constructions S.àr.l.
Cadanor S.A.
Capellen Invest S.A.
CB S.A.
Centre Comptable S. à r.l.
Cobelpin S.A.
Constant Shipping S.A.
Damode-MG Holding S.A.
diffusion saint-paul
Eurostar Overseas S.A.
Fondation Pauline de Faillonnet
Fortis Luxembourg-Vie S.A.
Framsteget S.à r.l.
Gallo S.A.H.
Gallo S.A.H.
Gallo Services S.à r.l.
HAWK Group S.A.
HAWK Management S.A.
Hobbes Capital S.A.
Itstream S.A.
Jack (Cologne 20) S. à.r.l.
Jack (Cologne 21) S. à.r.l.
Jumbio S.A.
Kiffer Impress
Kruger Brent Luxembourg Holding S.A.
Lumedia Europe S.A.
Luxlorbois, s.à r.l.
Marbre Investissements S.A.
Matrix Dynamic Real Estate Portfolio S.A.
MGP Europe (Lux) S.à r.l.
MGP Europe Parallel (Lux) S.à r.l.
MGP Pope S.àr.l.
Montemar S.A.
MYTransfer Luxembourg S.A.
North & South Airlogistics
Omaha International S.A.
Permalux Sàrl
Pharos S.A.
Quadriga Holdings S.A.
Restaurant-Brasserie des Bateliers S.à r.l.
Resultatsystem Internationell
SBS European Pay TV Services
STEPEC PROMOTION Luxembourg S.àr.l.
Transnational Financial Investments S.A.
Universal Immobilière S.A.
Valessore Holding S.A.
Videofin S.A.
White Knight S.A.
Wong's S.à r.l.
WSC S. à r.l.