logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 896

16 mai 2007

SOMMAIRE

Abelia Concept Group S.A.  . . . . . . . . . . . . .

43008

Aéroclub de Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43007

Agemina Gest.Investment S.A.  . . . . . . . . . .

43000

Alcyone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43000

Alex-Ander S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43000

Alizées S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42966

Alphalinea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42999

Angerbach S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42994

Arpio- Société Etrangère de Participation

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43007

Asia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43007

Asor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43006

Association des Patrons Menuisiers du

Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l.  . . .

42990

Aurore Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43006

Avenir Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43006

Bridle S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43005

Bronipar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43005

Café Um Bur S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42965

Capinvest S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43005

Centrobank Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42967

Chrystal Blue S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43004

C.M. Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43004

Coastline Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

43004

Credit Suisse Asset Management Fund

Service (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . .

42988

Credit Suisse Asset Management Holding

Europe (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . .

42968

Cypress Semiconductor Corporation (Lu-

xembourg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42998

Delima S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43008

Düsseldorf-Airport Hotel Investment S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43000

Ecoenergy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43003

Elecfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43003

Electromind S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42999

Elim S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43003

Furnitures Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

42964

GH Retail Portfolio S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

42969

GPL International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43002

Hilton Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43002

Hostcare Investissement S.A.  . . . . . . . . . . .

43001

IBI Fund Advisory S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42994

Immobiliare Altop S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43001

Immodream S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43002

Interimmo 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43001

KBC Renta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42989

Kredietrust Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . .

42962

Kytime Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42967

La Concorde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42989

M.E.R Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42996

MHI Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42996

Picoty Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42993

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka I Al-

pha S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43008

Waste Solutions Luxembourg S.A.  . . . . . .

42998

WH Luxembourg Intermediate Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42966

42961

Kredietrust Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 65.896.

EXTRAIT

Art. 10. Pouvoirs du Conseil. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles

à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Art. 11. Délégation des Pouvoirs. Le Conseil peut, en se conformant à l'article soixante de la loi sur les sociétés

commerciales, déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents.

Il pourra notamment charger de l'administration journalière de la société et de l'exécution des décisions du conseil,

un comité de direction ou un ou plusieurs administrateurs-délégués, et/ou un ou plusieurs administrateurs-directeurs,
nommer un ou plusieurs directeurs.

Le conseil d'administration et le comité de direction pourront, dans la limite de leurs pouvoirs et attributions respectifs,

donner à des mandataires de leur choix tous pouvoirs spéciaux ou consentir telles délégations qu'ils jugeront convenir,
en vue de la signature des actes et documents relatifs à des opérations courantes et de la correspondance qui s'y rapporte.

Les pouvoirs et la rémunération des membres du comité de direction, des administrateurs-délégués, des directeurs

et mandataires sont fixés par le conseil d'administration ou par un organe qu'il désignera.

Art. 12. Signatures. Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations sont, à défaut de mandats particuliers

ou de délégation donnée par le conseil d'administration ou le comité de direction, valablement signés au nom de la société,
par deux administrateurs. Une des signatures peut être remplacée par celle d'un membre de la direction jusqu'au rang
de fondé de pouvoir principal inclus.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'admi-

nistration agissant par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

<i>Pouvoirs

Délégation des pouvoirs de signature de KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., conformément aux articles 11 et 12

des statuts (valable pour toute opération effectuée avec la KREDIETBANK).

Conformément aux articles 11 et 12 des statuts de la société, et en vertu d'une décision du Conseil d'Administration,

les mandataires mentionnés ci-après ont pouvoir de représenter la société.

Ce pouvoir de représentation est limité aux opérations indiquées ci-dessous et est précisé par les lettres A, B ou C

figurant en regard du nom de chaque mandataire.

Un mandataire d'une catégorie supérieure est toujours habilité à représenter KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

dans une opération pour laquelle un pouvoir de représentation a été accordé à une catégorie inférieure.

Opération (1)

Signature(s) minimum requises

C<B<A

Opération pour compte de client dans le cadre d'une procuration reçue par KTL

voir dispositions particulières

Demande de dépassement à KBL

B + B

Tout acte, document et correspondance, accordant, confirmant, modifiant, sus-

pendant ou dénonçant un contrat

B + B

Tout ordre et/ou confirmation de souscription d'achat, de vente de valeurs mo-

bilières (2)

Jusqu'à EUR 800.000,-: B + C

Au-delà de EUR 800.000,-: B + B

Reçus, quittances, accusés de réception

C + C

Correspondance n'impliquant aucun engagement

C

(1) Les procurations spéciales données en rapport avec les opérations énumérées ci-dessus seront valablement don-

nées sous les signatures requises pour ces opérations.

(2) Pour toutes les opérations qui, suivant les usages bancaires, font l'objet d'une confirmation imprimée de façon

automatique, l'avis de confirmation ne portera aucune signature

<i>Dispositions particulières

1. KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Les opérations sur compte courant de KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. (084070) ne seront valablement engagées

que par les signatures autorisées suivantes:

Principes:
- 2 classes de signataires
- signature conjointe (2 personnes de la classe I 

ère

 ou 1 personne de la classe I 

ère

 et 1 personne de la classe II)

42962

<i>Classe I 

<i>ère

<i> :

Jean-Paul Loos
Rafïk Fischer
Amal Wagner-Sennai
Michel Meert

<i>Classe II:

Wouter Gesquiere
Philippe Alexandre
Patrick Vander Eecken
Patrizia De Cia
Eric Zwickel
2. Activités OPC
Pour le paiement de dividendes et de factures externes relatives aux OPC, aux Sociétés de gestion et aux Sociétés de

conseil domiciliés auprès de KTL, ceux-ci ne seront valablement engagés vis-à-vis de la Banque que par la signature de
leurs organes ou par deux (2) des signatures suivantes:

Jean-Paul Loos
Rafik Fischer
Patrizia De Cia
André Schmit
Lionel Nittler
Amal Wagner-Sennai
Wouter Gesquiere
Philippe Alexandre
Michel Meert
Eric Zwickel
Patrick Vander Eecken
3. Activités Gestion
Ordres qui ne diminuent pas le patrimoine (ordres relatifs à une même racine)
Ces ordres (changes, ordres de bourse, dépôts à terme,...) requièrent une seule signature autorisée, à partir de C.
Ordres qui diminuent le patrimoine (ordres relatifs à des numéros de racine différents).
Règle générale: un ordre écrit du client est requis.
Exception: les ordres relatifs aux commissions de gestion perçues par KTL en faveur de son compte 084070 requièrent

2 signatures B.

<i>Pouvoirs

Délégation des pouvoirs de signature de KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., conformément aux articles 11 et 12

des nouveaux statuts

Conformément aux articles 11 et 12 des statuts de la société, et en vertu d'une décision du Conseil d'Administration,

les mandataires mentionnés ci-après ont pouvoir de représenter la société.

Ce pouvoir de représentation est limité aux opérations indiquées ci-dessous et est précisé par les lettres A, B ou C

figurant en regard du nom de chaque mandataire.

Un mandataire d'une catégorie supérieure est toujours habilité à représenter KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

dans une opération pour laquelle un pouvoir de représentation a été accordé à une catégorie inférieure.

Opération (1)

Signature(s) minimum requises

C<B<A

Tout acte, document et correspondance, accordant, confirmant, modifiant, sus-

pendant ou dénonçant un contrat

B + B

Tout ordre et/ou confirmation de souscription d'achat, de vente de valeurs mo-

bilières (2)

Jusqu'à EUR 800.000,-: B + C

Au-delà de EUR 800.000,-: B + B

Reçus, quittances, accusés de réception

C + C

Correspondance n'impliquant aucun engagement

C

(1) Les procurations spéciales données en rapport avec les opérations énumérées ci-dessus seront valablement don-

nées sous les signatures requises pour ces opérations.

(2) Pour toutes les opérations qui, suivant les usages bancaires, font l'objet d'une confirmation imprimée de façon

automatique, l'avis de confirmation ne portera aucune signature

42963

Pouvoir de

signature

Alexandre Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Auquier Nathalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Berchem Claudine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Capocci Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Costa Claude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

De Cia Patrizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

De Gantes Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Gesquiere Wouter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

Gueth Frédérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Henneaux Michaël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Ide Greta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Jacquet Jean-François . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Klein Stephan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Mauquoi Rudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Meert Michel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

Nittler Lionel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Paquet Carole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Pons Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Schmit André . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Vander Eecken Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Vanderborght Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Wagner-Sennai Amal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Zipp Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Zwickel Eric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

<i>Administrateurs:

Meert Michel
Fischer Rafik
Loos Jean-Paul

<i>Président du Conseil d'Administration:

Loos Jean-Paul
Référence de publication: 2007040698/526/147.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02683. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Furnitures Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 129, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 108.211.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue au siège social

<i>en date du 6 décembre 2006

Lors de cette Assemblée Générale extraordinaire, les actionnaires ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Joseph Pierrard, domicilié à B-6642 Vaux-Sur-Sûre, route de

Neufchâteau, numéro 20, de ses postes d'administrateur et d'administrateur délégué à compter du 5 décembre 2006 et
décide de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

En remplacement, il est décidé de nommer Monsieur Robert Lahaye, domicilié à L-1521 Luxembourg, rue Adolphe

Fischer, numéro 129, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2010. Monsieur Robert Lahaye accepte le mandat.

L'Assemblée  prend  également  acte que  Monsieur  Pierrard était l'administrateur  délégué  et qu'il  sera  demandé au

Conseil d'Administration de pourvoir à son remplacement à ce poste dans les plus brefs délais.

42964

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007041100/800/1004/22.
Enregistré à Diekirch, le 7 mars 2007, réf. DSO-CC00042. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070037729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Café Um Bur S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4976 Bettange-sur-Mess, 9, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 105.371.

L'an deux mille sept, le huit janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Gabrielle Muser, épouse Sturm, gérante de société, née à Luxembourg, le 9 avril 1961, demeurant à L-6186

Gonderange, 12, rue de l'Eglise.

2.- Monsieur Sebastian Badowski, barman, né à Lodz (Pologne), le 28 avril 1979, demeurant à L-4945 Bascharage, 58,

rue de Schouweiler.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée CAFE UM BUR S.à r.l., avec siège social à L-4976 Bettange-sur-Mess, 9, rue

du Château, R.C.S. Luxembourg section B numéro 105.371, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 23 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 315 du 9 avril 2005.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés constatent qu'en vertu de deux cessions de parts sociales du 7 décembre 2006:
- Madame Manon Schmit, gérante de société, née à Differdange, le 9 août 1969, demeurant à L-4945 Bascharage, 58,

rue de Schouweiler, a cédé ses trente-quatre (34) parts sociales dans la prédite société CAFE URN BUR S.à r.l., à Madame
Gabrielle Muser, épouse Sturm, préqualifiée.

- Madame Françoise Kapweiler, épouse Hansen, gérante de société, née à Esch-sur-Alzette, le 26 mars 1965, demeurant

à L-8357 Goeblange, 44, Domaine du Beau Regard, a cédé ses trente-trois (33) parts sociales dans la prédite société CAFE
UM BUR S.à r.l., à Monsieur Sebastian Badowski, préqualifié.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article six (6) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

Parts

sociales

1.- Madame Gabrielle Muser, épouse Sturm, gérante de société, née à Luxembourg, le 9 avril 1961, de-

meurant à L-6186 Gonderange, 12, rue de l'Eglise, soixante-sept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

2.- Monsieur Sebastian Badowski, barman, né à Lodz (Pologne), le 28 avril 1979, demeurant à L-4945 Ba-

scharage, 58, rue de Schouweiler, trente-trois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Total: cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident d'accepter la démission de Madame Manon Schmit comme gérante technique et de Mesdames

Gabrielle Muser, épouse Sturm et Françoise Kapweiler comme gérantes administratives de la société et de leur donner
décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.

42965

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de nommer comme nouveaux gérants de la société:
- Madame Gabrielle Muser, épouse Sturm, gérante de société, née à Luxembourg, le 9 avril 1961, demeurant à L-6186

Gonderange, 12, rue de l'Eglise, gérante technique et

- Monsieur Sebastian Badowski, barman, né à Lodz (Pologne), le 28 avril 1979, demeurant à L-4945 Bascharage, 58,

rue de Schouweiler, gérant administratif.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de modifier le régime actuel de signature des gérants de la société pour lui donner la teneur

suivante:

«La société est engagée en toutes circonstances par la signature d'un gérant jusqu'à concurrence de mille deux cent

cinquante euros (1.250,- EUR); pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature conjointe de la gérante
technique et du gérant administratif est nécessaire.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de sept cent cinquante

euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Muser, S. Badowski, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 janvier 2007, vol. 540, fol. 72, case 6, GRE / 2007 / 288. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 13 mars 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007040866/231/70.
(070037716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

WH Luxembourg Intermediate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 88.008.

Le Rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Les comptes annuels à rectifier sont enregistrés auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous la référence

L060074131.04.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007041756/6675/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2007, réf. LSO-CC04713. - Reçu 91 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070039224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2007.

Alizées S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 80.461.

L'an deux mille sept, le deux mars,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

Monsieur Philippe Pellizzari, directeur commercial, demeurant à F-13369 Rocquevaire, Quartier de la Bégude,
ici représenté par Monsieur Claude Prat, employé privé, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 31,

Val Sainte Croix,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 22 février 2007,

42966

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:
1. Monsieur Philippe Pellizzari, prénommé, est le seul associé de la société à responsabilité limitée ALIZEES S.à r.l.,

ayant son siège social (dénoncé) à L-3403 Dudelange, 1, rue du Commerce, constituée suivant acte reçu par le notaire
Georges d'Huart, de résidence à Pétange, en date du 5 février 2001,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 750 du 12 septembre 2001, modifiée suivant acte

reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 20 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 1251 du 27 août 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg sous la section B et le numéro 80.461, au capital social de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00),
représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,00) chacune.

2. L'associé unique, représenté comme dit, décide de transférer le siège social de la société à L-1371 Luxembourg, 31,

Val Sainte Croix, et de modifier, par conséquent, la première phrase de l'article deux des statuts, pour lui donner la teneur
suivante:

« Art. 2. (première phrase). Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant du comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Prat, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007. LAC/ 2007/1144. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2007.

E. Schlesser.

Référence de publication: 2007040826/227/36.
(070037554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Centrobank Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 71.399.

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der ordentlichen Generalversammlung vom 30. November 2006 in Luxemburg.

- die Herren Gerhard Grund mit beruflichem Wohnsitz in 1 Tegetthofstrasse A-1015 Wien, Alfred Michael Spiss, mit

beruflichem Wohnsitz 1 Tegetthofstrasse A-1015 Wien und Frau Monika Jung mit beruflichem Wohnsitz Leonard 4-6
Bermstein Strasse A-1220 Wien werden als Verwaltungsratsmitglieder für das neue Geschäftsjahr wiedergewählt.

- DELOITTE S.A., Luxemburg wird als Abschlussprüfer für das neue Geschäftsjahr wiedergewählt.

Für beglaubigten Auszug
<i>Für CENTROBANK SICAV
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2007040919/526/18.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02626. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Kytime Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 98.757.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le douze janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société de droit panaméen SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'EST S.A., ayant son siège social à Panama-City, 54th

Street, Arango-Orillac Building (République du Panama),

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher,

42967

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit

ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme KYTIME HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 98.757, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21
janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 290 du 12 mars 2004.

II.- Que le capital social de la société anonyme KYTIME HOLDING S.A., prédésignée, s'élève actuellement à trente et

un mille euro (31.000,- EUR), représenté par trente et une mille (31) actions avec une valeur nominale de mille euros
(1.000,- EUR) chacune.

III.- Que la comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la susdite société KYTIME

HOLDING S.A.

IV.- Que l'activité de la société KYTIME HOLDING S.A. ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution

anticipée de la prédite société avec effet au 31 décembre 2006 et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.
VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la

société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme KYTIME HOLDING S.A. est à considérer comme faite et

clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il n'a jamais été procédé à la création matérielle des actions et du registre des actionnaires.
XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social de la société dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 janvier 2007, vol. 540, fol. 82, case 3, GRE/2007/411. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 13 mars 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007040827/231/51.
(070037615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 45.630.

Monsieur Glenn Wellman avec adresse professionnelle à Beaufort House, St. Botolph Street, 15, EC3A7JJ, Londres,

Grande-Bretagne et Monsieur Mario Seris avec adresse professionnelle à Giesshiibelstrasse, 30, CH-8070 Zürich, Suisse,
ont démissionné comme Membre du Conseil d'Administration de la société CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
HOLDING EUROPE (LUXEMBOURG) S.A. avec effet au 31 décembre 2006.

Monsieur Karl Huwyler avec adresse professionnelle à Giesshübelstrasse, 30, CH-8070 Zürich, Suisse, a démissionné

de la société avec effet au 14 novembre 2006.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 10 janvier 2007, Monsieur Mark Burgess, avec adresse

professionnelle à One Cabot Square, London E14 4QJ, Grande-Bretagne et Monsieur Hans-Ulrich Hügli avec adresse
professionnelle à 56, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, ont été nommés comme nouveau Membre du Conseil d'Admi-
nistration, et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 5 mars 2007.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 janvier 2007, Monsieur Gerhard Lohmann avec adresse profes-

sionnelle à Giesshübelstrasse, 30, CH-8070 Zürich, Suisse, a été nommé comme Membre du Conseil d'Administration.

42968

Par conséquent, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
Lawrence Haber, Londres
Raymond Melchers, Luxembourg
Mark Burgess, Londres
Hans-Ulrich Hügli, Luxembourg
Gerhard Lohmann, Zurich
Bernard Wester, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2007.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT HOLDING EUROPE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger

Référence de publication: 2007040870/736/32.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC02946. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

GH Retail Portfolio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 124.901.

In the year two thousand and seven on the fourteenth day of the month of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of GH RETAIL PORTFOLIO S.à r.l., a société à respon-

sabilité limitée, having its registered office at 25 B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated by a notarial deed
on February 7, 2007, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is called to order at Luxembourg by Mr Gael Castex, attorney-at-law, residing in Luxembourg who took

the chair of the Meeting.

The Chairman appoints as secretary to the meeting Mr Thomas Sarpcan, attorney-at-law, residing in Luxembourg
The meeting elects as scrutineer Mrs Anne Loubet, attorney-at-law, residing in Luxembourg
The Chairman then declared and requested that it be recorded:
(i) That the agenda of the meeting is the following:
1. To create two (2) classes of shares: «A Ordinary Shares» and «B Ordinary Shares».
2. To consequently convert four hundred and twenty-five share quotas (425) representing eighty-five percent of the

share capital, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, into four hundred and twenty-five (425) A Ordinary
Shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

3. To consequently convert seventy-five share quotas (75) representing fifteen percent of the share capital, with a

nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, into seventy-five (75) B Ordinary Shares with a nominal value of
twenty-five euro (EUR 25.-) each.

4. To amend Article 2 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth be read as follows:
«The Company's object is to acquire or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in Lux-

embourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests and to invest
in real estate directly or indirectly in Luxembourg and abroad.

The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect
shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the
«Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause
it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not

enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

42969

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all

transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.

5. To fully restate the Company's articles of incorporation.
6. Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain

annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly delib-

erate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to create two (2) classes of shares: the «A Ordinary Shares» and the «B Ordinary Shares».

<i>Second resolution

The general meeting resolves to consequently convert four hundred and twenty-five share quotas (425) representing

eighty-five percent of the share capital, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, into four hundred and
twenty-five (425) A Ordinary Shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to consequently convert seventy-five share quotas (75) representing fifteen percent of

the share capital, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, into seventy-five (75) B Ordinary Shares (75)
with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to amend Article 2 of the articles of incorporation of the Company, which shall hence-

forth be read as follows:

«The Company's object is to acquire or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in Lux-

embourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests and to invest
in real estate directly or indirectly in Luxembourg and abroad.

The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect
shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the
«Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause
it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not

enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the

42970

performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all

transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves to fully restate the articles of association of the Company, which shall forthwith be read

as follows:

Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate name.
1.1 There is formed a private limited liability company under the name GH RETAIL PORTFOLIO S.à r.l. which will be

governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th,
1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), by the present articles of association (hereafter the
«Articles») as well as by the Shareholders' Agreement.

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised

to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to acquire or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests and to invest
in real estate directly or indirectly in Luxembourg and abroad.

3.2 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect
shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the
«Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause
it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.3 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.

3.4 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital is fixed at twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by four hundred

and twenty-five (425) A Ordinary Shares and seventy-five (75) B Ordinary Shares, with a nominal value of twenty-five
euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up (the «Shares», each a Share).

5.2 The capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder (where there is only one Shareholder)

or by a decision of the Shareholders' meeting, in accordance with Article 16 of the Articles.

42971

5.3 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.4 All Shares will have equal rights.
5.5 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per

Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 Shareholder A may not Transfer its A Ordinary Shares prior to the first anniversary of the date of the Shareholders'

Agreement except:

(a) in each case, if the Transfer is a Permitted Transfer; or
(b) for a Transfer regulated by the Shareholders' Agreement.
Following the first anniversary of the date of the Shareholders' Agreement, Shareholder A may in addition Transfer

its Shares to any person, subject to Article 9 and Article 10 of the present Articles (if applicable).

7.3 Shareholder B may not transfer its B Ordinary Shares during the term of the Shareholders' Agreement except for

a Transfer pursuant to Article 9 and Article 10 of the Articles or except with the prior written consent of Shareholder
A or unless the Transfer is a Permitted Transfer.

7.4 Each Shareholder shall procure that the Board of Managers only approves for registration a Transfer of Shares

carried out in accordance with the Shareholders' Agreement and the Articles.

7.5 According to Article 189 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended,

any transfer of Shares to a person other than a Shareholder must be approved by Shareholders representing 3/4 of the
share capital of the Company, provided that the Permitted Transfer Shareholder A and Shareholder B are deemed to
have approved such transfer.

Change of Control and Call Option.
8.1 On the occurrence of a Change of Control Event, the Shareholder A may require the Shareholder B to sell all (but

not some only) of its B Ordinary Shares (the «Call Option»).

8.2 Prior to the occurrence of a Change of Control Event, the Shareholder B will, as soon as practicable, and in any

event no later than 3 months prior to the occurrence of the Change of Control Event give notice in writing to the
Shareholder A (the «Change of Control Notice») that such an event may occur.

8.3 Shareholder A may, by notice in writing (the «Option Notice») to be given at any time within 2 months of receipt

of notice of a Change of Control Notice (or in the event that such notice is not delivered to Shareholder A then within
3 months of becoming aware that a Change in Control Event has occurred), exercise the Call Option. The date of service
of the Option Notice is hereinafter referred to as the «Exercise Date». Such Option Notice shall specify:

(a) the total price payable for the B Ordinary Shares in accordance with Article 8.4 (the «Option Price»); and
(b) a date for completion of the sale and purchase of the B Ordinary Shares pursuant to exercise of the Call Option

which shall be on a Business Day between 15 and 20 Business Days after service of the Option Notice by Shareholder
A, or, if later, on the 7th Business Day after the price payable has been agreed or resolved in accordance with Article
8.7.

8.4 The price for the B Ordinary Shares to be sold pursuant to the Call Option shall be the market value of the B

Ordinary Shares as at the Exercise Date (the market value being determined on the basis of the Shareholder A's best
estimate in accordance with Article 8.7).

8.5 Shareholder B shall be bound to sell (or to procure the sale of) the B Ordinary Shares specified in the Option

Notice subject only to the receipt of the Option Price and Shareholder A shall be bound to purchase, or procure the
purchase by a member of the Shareholder A Group of the Shares specified in the Option Notice.

8.6 If, on exercise of the Call Option, Shareholder B does not agree with the market value for the relevant Shares

proposed by Shareholder A, it shall serve notice in writing on Shareholder A within 7 days of receipt of the Option Notice
setting out its alternative proposal for market value (the «Objection Notice»). Failure to give an Objection Notice within
such time limit will mean that Shareholder B is deemed to have accepted the market value proposed by Shareholder A.
If the Shareholders do not agree on market value within 15 Business Days after service of an Objection Notice, any
Shareholder may refer the matter to an independent chartered accountant (the «Valuer») (acting as an expert and not
as an arbitrator). The Valuer shall be agreed upon by the Shareholders or in default of agreement within 20 Business Days
after service of an Objection Notice appointed by the President of the Institute of Chartered Accountants in England and
Wales on the application of any Shareholder (whoever shall first apply). The Valuer shall determine the market value of
the B Ordinary Shares being sold on a going concern basis and arm's length basis between a willing seller and a willing
buyer and on the basis that each Share whatever its class has the same value corresponding to its proportion of the value
of all the Shares taken as a whole and that no additional or reduced value is attached to any holding of Shares by virtue
only of that holding comprising or after purchase conferring or giving rise to a majority or minority of the total issued

42972

share capital of the Company. Any costs of the Valuer shall be borne by the Shareholder whose proposal for market
value (as set out in the Option Notice and Objection Notice) differs most from that determined by the Valuer.

Art. 9. Drag Along Rights.
9.1 It is understood and agreed that only the Shareholder A shall have the right to initiate a Transfer pursuant to this

Article 9.

9.2 If, after the first anniversary of the date of the Shareholders' Agreement, Shareholder A wishes to sell all or part

of its A Ordinary Shares (the «Offered Securities») other than pursuant to a Permitted Transfer then such Shareholder
A shall give 20 Business Days written notice to the Shareholder B and shall consult with the Shareholder B regarding the
proposed transfer.

9.3 If following such 20 Business Day period Shareholder A decides to proceed with the sale of the Offered Securities

to a bona fide independent third party (the «Buyer») on arm's length terms then Shareholder A shall by notice given in
writing to Shareholder B and to the Company (the «Sale Notice») set out all relevant details of the Buyer and the general
terms on which the sale is expected to proceed and may accompany the Sale Notice by a further notice (the «Drag
Notice») requiring Shareholder B to sell the same proportion of its B Ordinary Shares to the Buyer on terms which are
no less favourable including as to price (on a per Share basis) that is applicable to the Shares being transferred by Share-
holder A (the «Drag Along Right») as set out in the Sale Notice.

9.4 Completion of the sale of Shares pursuant to an exercise of the Drag Along Right shall take place at the same time,

place and on terms no less favourable including as to price (on a per Share basis) as the sale of Shares by Shareholder A
to the Buyer. The Shareholders agree that the proceeds for the Shares due pursuant to the previous provisions of this
clause 9.4 shall be applied in accordance with the priority of Distributions set out in the Shareholders' Agreement as if
such proceeds were Distributions. Should a dispute arise in relation to the Distributions, it shall be settled as set out in
the Shareholders' Agreement.

Tag Along Rights.
10.1 If following delivery of a Sale Notice and unless Shareholder A has also delivered a Drag Notice, Shareholder B

may, within 21 days of the Sale Notice, deliver a written notice to Shareholder A (the «Tag Along Notice») advising it
that it wishes the Buyer to acquire the same proportion of its B Ordinary Shares. If Shareholder B has served a Tag Along
Notice,Shareholder A will not transfer, or procure the transfer of, any A Ordinary Shares to the Buyer without first
requiring the Buyer to acquire the same proportion of the B Ordinary Shares held by Shareholder B on terms no less
favourable including as to price (on a per Share basis) as set out in the Sale Notice (the «Tag Along Right»).

10.2 If the Tag Along Right is exercised, no Shareholder will enter into any agreement, commitment or understanding

with any person which has the effect of providing to any Shareholder consideration of greater value or terms which are
more favourable than those in the Sale Notice. The sale of any B Ordinary Shares by Shareholder B or the relevant
members of the Shareholder B Group (as the case may be) to the Buyer shall take place at the same time, place and on
terms no less favourable (or which are consistent with the following provision of this clause) including as to the price (on
a per Share basis) as the sale of A Ordinary Shares by the Shareholder A (or parties) or the relevant members of the
Shareholder A Group (as the case may be) to the Buyer. The Shareholders agree that the proceeds for the Shares due
pursuant to the previous provisions of this Article 10.2 shall be applied in accordance with the priority of Distributions
set out in the Shareholders' Agreement as if such proceeds were Distributions. Should a dispute arise in relation to the
Distributions, it shall be settled as set out in the Shareholders' Agreement.

10.3 In the event that the Shareholder B fails to comply with the requirements of this Article 10, the Shareholder A

shall be entitled to sell all of their Shares without complying with the Shareholder B's Tag Along Right.

Chapter III.- Management

Art. 11. Management.
11.1 The Company is managed by up to four (4) manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case

of plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance») (the «Board of Managers»).

11.2 Shareholder A shall be entitled from time to time to nominate for appointment at least four (4) persons out of

which the general meeting of the Shareholders shall appoint three (3) Managers (the «A Managers») and Shareholder B
shall be entitled from time to time to nominate for appointment at least two (2) persons out of which the general meeting
of the Shareholders shall appoint one (1) Manager (the «B Manager»).

11.3 The general meeting of the Company will at all times be free to vote on any dismissal or suspension of any Manager,

it being understood that (i) the right of a party to propose a candidate for appointment to the Board includes the right
to propose the dismissal or suspension of the Manager appointed in accordance with Article 11.2 of the Articles at the
nomination of that party and (ii) the provisions of Article 11.2 of the Articles shall apply equally to the replacement of a
Manager.

11.4 The Managers shall not be entitled to any remuneration in their capacity as Managers of the Company.

Art. 12. Powers of the Sole Manager or of the Board of Managers.
12.1 In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, without

prejudice to Article 11 and Article 13 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in

42973

all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this Article shall have been complied with.

12.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers. The Board has
responsibility for the supervision and management of the Company and its business, but shall obtain the prior written
consent of Shareholder A and Shareholder B before making a Substantial Acquisition.

12.3 The Board of Managers' approval is required for each of the following decisions:
(a) agreeing on the annual Business Plan and any amendments thereto;
(b) any member of the Company Group entering into or amending any lease contract with an annual gross rental value

in excess of EUR 100,000.-;

(c) any proposal to amend the Articles or other constitutional documents of the Company or SPVs;
(d) material deviations by any member of the Company Group from the Business Plan including with regard to, but

not limited to, property acquisitions, disposals, financings, lease contracts, entering into or varying the terms of contracts
with a value of € 50,000.- or above, all capital expenditure above € 10,000.- and Distributions;

(e) determining the amount of Distributable Cash at any time and whether or not to distribute;
(f) the creation of any Encumbrance over any uncalled capital of, or any other asset of, any member of the Company

Group or the giving of any guarantee, indemnity or security, or the entry into of any agreement or arrangement having
a similar effect by any member of the Company Group or the assumption by any member of the Company Group of any
liability, whether actual or contingent, in respect of any obligation of any person;

(g) (to the extent permitted by law) the variation, creation, increase, re-organisation, consolidation, sub-division, con-

version, reduction, redemption, repurchase, re-designation or other alteration of the authorised or issued share or loan
capital of any member of the Company Group or the variation, modification, abrogation or grant of any rights attaching
to any such share or loan capital except, in each case, as may be expressly required by Shareholders' Agreement;

(h) (to the extent permitted by law) the entry into or creation by any member of the Company Group of any agreement,

arrangement or obligation requiring the creation, allotment, issue, Transfer, redemption or repayment of, or the grant
to a person of the right (conditional or not) to require the creation, allotment, issue, Transfer, redemption or repayment
of, a share in the capital of any member of the Company Group (including, without limitation, an option or right of pre-
emption or conversion) except, in each case, as may be expressly required or permitted by the Shareholders' Agreement;

(i) (to the extent permitted by law) the reduction, capitalisation, repayment or distribution of any amount standing to

the credit of the share capital, share premium account, capital redemption reserve or any other reserve of any member
of the Company Group, or the reduction of any uncalled liability in respect of partly paid shares of any member of the
Company Group;

(j) (to the extent permitted by law) to pass any resolution for the dissolution or winding up of any Company Group;
(k) the alteration of the accounting reference date of any member of the Company Group or the alteration of the

accounting policies except as required by law or applicable regulation;

(l) the entry by any member of the Company Group into any partnership or joint venture arrangement with any person;
(m) any member of the Company Group incurring or refinancing, or the entry by any member of the Company Group

into any agreement or facility to obtain or refinance, any borrowing or any other indebtedness or liability in the nature
of borrowing (including, without limitation, Third Party Finance and amendments to the Facility Agreement);

(n) forming any subsidiary or acquire shares in any company or participate in, or terminate any participation in, any

partnership, joint venture or like arrangement;

(o) the issue of any Call Notice;
(p) the disposal of any Property or shares in an SPV;
(q) entering into and renewing the Management Agreement; and
(r) any member of the Company Group entering into or amending any contract (other than the lease).

Art. 13. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager,

bound by the sole signature of the sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of one A
Manager and one B Manager or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a sole
Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers.

Art. 14. Delegation and Agent of the Sole Manager or of the Board of Managers.
14.1 The sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate its powers for specific

tasks to one or more ad hoc agents.

14.2 The sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent's

responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of its agency.

42974

Art. 15. Meeting of the Board of Managers.
15.1 Meetings of the Board of Managers shall be properly convened by one A Manager and one B Manager with not

less than seven Business Days' notice, (or on a shorter period of notice if at least one A Manager and one B Manager
agree so in writing and are in the opinion that the interest of the Company be likely to be adversely affected to a material
extent if the business to be transacted at such Board meeting were not dealt with as a matter of urgency) and such notice
shall be accompanied by an agenda specifying in reasonable detail the matters to be raised at the meeting and copies of
any papers to be discussed at the meeting.

15.2 Properly convened Board of Managers meetings may be held at such times as may be determined by the Board

of Managers and in any event not less than four times annually at the Company's principal place of business in Luxembourg
or such other place as the Board of Managers may from time to time determine (if possible under applicable law).

15.3 The post of chairman of the Board of Managers (the «Chairman») shall always be held by an A Manager. If the

Chairman is not present at any meeting of the Board of Managers, the A Managers present may appoint another A Manager
to act as chairman for the purposes of the meeting.

15.4 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

15.5 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented including at least one A Manager and one B Manager. Decisions of the Board of Managers shall be adopted
by a simple majority including at least one A Manager voting in favour.

15.6 An A Manager or a B Manager who may not attend to a meeting may appoint in writing or by telegram or telefax

or email or letter any other Manager (except a manager representing the other party) to represent him at the meeting
and vote in his place as his proxy holder.

15.7 Meetings of the Board of Managers may be held by video-conferencing equipment and conference to the extent

permitted by applicable law and to an extent which does not adversely affect the tax position of a Shareholder and the
Company provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers
whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by telephone.

15.8 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

15.9 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the

meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of
the Board of Managers.

Chapter IV.- General Meeting of Shareholders

Art. 16. Powers of the General Meeting of Shareholder(s) - Votes.
16.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'

meeting and takes the decisions in writing.

16.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

16.3 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders

owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

16.4 If all the Shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

16.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken

and cast its vote in writing.

16.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

Chapter V.- Business year

Art. 17. Business year.
17.1 The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.
17.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the sole Manager or in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

17.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Distribution Right of Shares.
18.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

42975

18.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's
nominal capital.

18.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed as set out in the Shareholders' Agreement.

18.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a

majority vote of the Shareholders.

18.5 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s). Such interim distributions are subject to the ultimate
decision of the Shareholder(s) on a majority vote by Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a
statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI.- Liquidation

Art. 19. Dissolution and liquidation.
19.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

19.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable

legal provisions.

19.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 20. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

Definitions

Art. 21. Definitions. Unless otherwise defined in the Articles:
A Manager has the meaning ascribed to it under Article 11.2.
Article means an article of the present Articles.
B Manager has the meaning ascribed to it under Article 11.2.
Board of Managers has the meaning ascribed to it under Article 11.1.
Business Day means any day (other than a Saturday or Sunday) when banks in London and Luxembourg are open for

the transaction of normal business;

Business Plan means an annual business plan for the members of the Company Group prepared by the Manager setting

out a five years budget as described in the Shareholders' Agreement.

Buyer has the meaning ascribed to it under Article 9.3. of these Articles.
Call Notice has the meaning ascribed to it under the Shareholders' Agreement.
Call option has the meaning ascribed to it under Article 8.1. of these Articles.
Change of Control Event means at any time after the date of the Shareholders' Agreement Mr Fabrice Varoqui (i) no

longer being the active Chief Executive Officer of the Asset Manager, or (ii) beneficially owning less than 51% of the issued
share capital of ARTA LIMITED or (iii) controlling the Manager.

Company Group means the Company and the SPV and «member of the Company Group» shall be construed ac-

cordingly.

Disposal means a sale of any interest in the Company, the SPVs, or all, or any part, of the Properties.
Distributable Cash means in respect of each of the Company and the SPVs, all of the cash available to them after taking

into account, according to present and future requirements outlined in the Business Plan:

(i) working capital requirements;
(ii) requirements to service Third Party Finance;
(iii) taxes and regulatory fees payable; and
(iv) capital expenditure reserves;
which may be distributed by it in accordance with applicable law and in compliance with any contractual undertaking

which they have given in relation to Third Party Finance or otherwise and, for the avoidance of doubt, to the extent such
cash may lawfully be distributed through repayment of Shareholder Loan or interest thereon, such distribution shall be

42976

regarded as being in compliance with applicable law notwithstanding that such cash could not be distributed lawfully by
means of a dividend.

Distribution means a payment to Shareholders or to the relevant member of the Shareholder A Group or the Share-

holder B Group (as the case may be) other than a payment in respect of the Asset Management Fee, the Acquisition
Savings Fee or the Brokerage Fee (as defined in the Shareholders' Agreement) but including any payment arising in respect
of the following:

(i) payment of principal and interest on any Shareholder Loan (whether from the SPVs or Company);
(ii) payment of any dividend on any Shares;
(iii) payment on any redemption of any Shares; and
(iv) any return of capital on any Shares (including in the case of liquidation), and «Distributed» shall be construed

accordingly.

Drag Along Right means the right described under Article 9 of the Articles.
Encumbrance means a mortgage, charge, pledge, lien, option, restriction, right of first refusal, right of pre-emption,

third  party  right  or  interest,  other  encumbrance  or  security  interest  of  any  kind,  or  another  type  of  agreement  or
arrangement having similar effect.

Exercise Date has the meaning ascribed to it under Article 8.3 of these Articles.
Group means in relation to a company (wherever incorporated), that company, any company of which it is a Subsidiary

(its holding company) and any other Subsidiaries of any such holding company; and each company in a Group is a member
of the Group.

Managers means collectively the A Managers and B Manager.
Objection Notice has the meaning ascribed to it under Article 8.6 of these Articles.
Offered Securities has the meaning ascribed to it under Article 9.2. of these Articles.
Option Notice has the meaning ascribed to it under Article 8.3 of these Articles.
Option Price has the meaning ascribed to it under Article 8.3. of these Articles.
Permitted Transfer means a transfer of relevant Shares to a member of Shareholder A Group or a member of Share-

holder B Group at the time of transfer.

Properties has the meaning ascribed to it under the Shareholders' Agreement.
Sale Notice has the meaning ascribed to it under Article 9.3. of these Articles.
Shares has the meaning ascribed to it under Article 5.1. of the Articles.
Shareholder means an A Shareholder or a B Shareholder, collectively, the «Shareholders»;
Shareholder A means the holder of the A Ordinary Shares i.e. CPI GH PORTFOLIO S.à r.l., a company incorporated

in Luxembourg (with pending registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies), whose registered
office is at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg or, at any time, any transferee or buyer of the A Ordinary Shares
(each individually referred as a «Shareholder A»).

Shareholders' Agreement means a shareholders' agreement as may be entered into from time to time between the

Shareholders, the Company and certain other parties.

Shareholder A Group means Shareholder A Group, i.e. means in relation to Shareholder A, any person directly or

indirectly controlling, controlled by or under common (direct or indirect) control with Shareholder's A from time to
time and shall include, for the avoidance of doubt, any fund or entity sponsored or managed by CITIGROUP INC. or any
of its affiliates from time to time, or any entity owned or controlled by any such fund or entity;

Shareholder B means the holder of the B Ordinary Shares, i.e. ARTA LIMITED, a company incorporated under the

laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar or any of its affiliates from time to time,
or any entity owned or controlled by any such fund or entity;

Shareholder B Group means, in relation to the Shareholder B, any person directly or indirectly controlling, controlled

by or under common (direct or indirect) control with the Shareholder B from time to time and shall include Mr. Fabrice
Varoqui, and «member of the Shareholder B Group» shall be construed accordingly.

Shareholder B Related Party Agreements means any agreement or arrangement of any kind (whether or not legally

enforceable) between the Company or the SPVs and any member of the Shareholder B Group.

Shareholder Loans means the loans which may be made from time to time by the Shareholders to the Company.
SPVs has the meaning ascribed to it under the Shareholders' Agreement.
Subsidiary means in relation to a company (wherever incorporated) (the holding company), any other company in

which the holding company (or a person acting on its behalf) directly or indirectly holds or controls either:

(a) a majority of the voting rights exercisable at general meetings of the shareholders of the company; or
(b) the right to appoint or remove managers (or equivalent) having a majority of the voting rights exercisable at meetings

of the board of managers of the company,

42977

and any company which is a Subsidiary of another company is also a Subsidiary of that company's holding company.

Unless the context otherwise requires, the application of the definition of Subsidiary to any company at any time shall
apply to that company as it is at that time.

Substantial Acquisition means the purchase of any real estate with a value in excess of EUR 500,000.- or which would

take the aggregate value of all such real estate purchases over such amount (for the avoidance of doubt this excludes
capital and revenue expenditure on any of the Properties).

Tag Along Notice has the meaning ascribed to it under Article 10.1. of these Articles.
Tag Along Right has the meaning ascribed to it under Article 10.1. of these Articles.
Third Party Finance means, in relation to the Company Group, any indebtedness in the nature of borrowing to a person

not being a member of a Shareholder Group save where that indebtedness relates to a back-to-back deposit arrangement.

Transfer means, in relation to any share or any legal or beneficial interest in any share, to:
(a) sell, assign, transfer or otherwise dispose of it;
(b) create or permit to subsist any Encumbrance over it;
(c) direct (by way of renunciation or otherwise) that another person should, or assign any right to, receive it;
(d) enter into any agreement in respect of the votes or any other rights attached to the share; or
(e) agree, whether or not subject to any condition precedent or subsequent, to do any of the foregoing;
and Transferred shall be construed accordingly.
Valuer has the meaning ascribed to it under Article 8.6 of these Articles.
There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at three thousand five hundred euro (3,500.- EUR).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present

deed  is  worded  in  English  followed  by  a  German  version;  on  request  of  the  same  appearing  parties,  and  in  case  of
discrepancies between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the proxy holder, in its above stated capacity, known to the notary by his surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendsieben, den vierzehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter

der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GH RETAIL PORTFOLIO S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, 25b, boulevard Royal,
gegründet durch notarielle Urkunde vom 7. Februar 2007, noch nicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
veröffentlicht.

Die Versammlung wird in Luxemburg durch Herrn Gael Castex, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg einberufen,

der den Vorsitz der Sitzung übernimmt.

Der  Vorsitzende  ernannt  zum  Schriftführer  der  Versammlung  Herrn  Thomas  Sarpcan,  Rechtsanwalt,  wohnhaft  in

Luxemburg.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Frau Anne Loubet, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende hat hiernach erklärt und eine diesbezügliche Aufzeichnung gefordert:
(i) dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt ist:
1. Begründung zweier (2) Anteilsklassen: «Stammanteile A» und «Stammanteile B».
2. Nachfolgende Umwandlung von vierhundertfünfundzwanzig (425) Anteile, die fünfundachtzig Prozent des Grund-

kapitals darstellen, mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), in vierhundertfünfundzwanzig (425)
Stammanteile A mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

3. Nachfolgende Umwandlung von fünfundsiebzig (75) Anteile, die fünfzehn Prozent des Grundkapitals darstellen, mit

einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), in fünfundsiebzig (75) Stammanteile B mit einem Nennwert
von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

4. Die Abänderung des Gegenstandes der Gesellschaft wie folgt:
«Der Gegenstand der Gesellschaft besteht in der Übernahme, dem Verkauf oder der sonstigen Verfügung sowie dem

direkten oder indirekten Halten von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, u. a. durch die
Zeichnung oder den Erwerb jedweder Sicherheiten und Rechte durch Beteiligung, Beitrag, Übernahme, Firmenkauf oder
Option, Verhandlung oder auf jedwede sonstige Art und Weise, bzw. Finanzschuldinstrumente in jedweder Form, sowie

42978

in der Verwaltung, Entwicklung und Führung dieser Beteiligungen und direkten sowie indirekten Investitionen in Luxem-
burg und im Ausland.

Die Gesellschaft ist ebenfalls berechtigt, ihren Tochtergesellschaften oder Unternehmen, an denen sie eine direkte

oder indirekte Beteiligung hält, selbst, wenn diese unwesentlich ist, oder jedweder Gesellschaft, die ein direkter oder
indirekter Anteilseigner der Gesellschaft ist bzw. jedweder Gesellschaft, die zum gleichen Konzern, wie die Gesellschaft
gehört,  jedwede  Unterstützung  zu  erbringen,  unabhängig  davon,  ob  durch  Darlehen,  Bürgschaften  oder  anderweitig
(nachfolgend als «Verbundene Unternehmen» bezeichnet), wobei vorausgesetzt wird, dass die Gesellschaft keine Trans-
aktion  abschließen  wird,  die  ihre  Beteiligung  an  jedweder  Tätigkeit  zur  Folge  hätte,  die  als  geregelte  Tätigkeit  des
Finanzsektors betrachtet werden würde.

Die Gesellschaft ist berechtigt, insbesondere die nachstehenden Transaktionen abzuschließen, wobei vorausgesetzt

wird, dass die Gesellschaft keine Transaktion abschließen wird, die ihre Beteiligung an jedweder Tätigkeit zur Folge hätte,
die als geregelte Tätigkeit des Finanzsektors betrachtet werden würde:

- Gelder in jedweder Form zu leihen oder jedwede Form der Kreditfazilität zu erhalten sowie Mittel aufzunehmen

durch, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf die Ausgabe, auf privater Basis, von Schuldverschreibungen, Solawech-
seln und sonstigen Schuldtiteln oder Kapitalbeteiligungsinstrumenten, die Verwendung von Finanzderivativen oder auf
eine sonstige Art und Weise;

- Vorschuss, Verleih oder Einzahlung von Geldern bzw. Gewährung von Kredit an ein oder bei einem luxemburgischen

oder ausländischen Unternehmen, bzw. Zeichnung oder Kauf eines jedweden durch diese Unternehmen ausgestellten
Schuldtitels, zu den Bedingungen, die für geeignet erachtet werden, und zwar mit oder ohne Sicherheit;

- Eingehen einer jedweder Garantie, Pfandrecht oder jedweden sonstigen Form der Sicherheit, unabhängig davon, ob

durch persönliche Zusage oder Hypothekenurkunde bzw. vollständige oder teilweise Belastung der Verpflichtung, Ver-
mögenswerte (bestehend oder zukünftig) oder durch sämtliche oder jedwede dieser Methoden, für die Erfüllung jedweder
Verträge oder Verpflichtungen der Gesellschaft und jedwede der Verbundenen Unternehmen, oder jedweder Geschäfts-
führer oder Führungskräfte der Gesellschaft oder jedweder Verbundenen Unternehmen, im Rahmen der Beschränkungen
des luxemburgischen Rechts.

Die Gesellschaft berechtigt, sämtliche rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Anlagen oder Tätig-

keiten auszuführen, und im Allgemeinen, sämtliche Transaktionen, die für die Erfüllung ihres Gegenstands erforderlich
sind, sowie sämtliche Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Erleichterung der Erfüllung ihres Zwecks in sämtlichen
vorstehend beschriebenen Bereichen verbunden sind.»

5. Vollständige Umformulierung der Satzung der Gesellschaft.

6. Sonstiges.

(ii) Dass die anwesenden oder vertretenen Anteilseigner, die Bevollmächtigten der vertretenen Anteilseigner und die

Anzahl deren Anteile auf eine Anwesenheitsliste angeführt werden; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die
Anteilseigner, die Bevollmächtigten der vertretenen Anteilseigner und den Vorstand der Sitzung, an die vorliegende Ur-
kunde angeheftet bleibt, die gleichzeitig bei den Registrierungsbehörden einzureichen ist.

(iii) Dass die Bevollmächtigten der vertretenen Anteilseigner, paraphiert ne varietur durch die erschienenen Parteien

ebenfalls an die vorliegende Urkunde angeheftet bleiben.

(iv) Dass das gesamte Firmenkapital, welches auf dieser Sitzung anwesend oder vertreten ist und sämtliche anwesenden

oder vertretenen Anteilseigner erklären, dass die vor dieser Sitzung über die Tagesordnung ordnungsgemäß unterrichtet
wurden und Kenntnis erlangt, und keine Einberufungsbekanntmachungen erforderlich waren.

(v) Dass diese Sitzung, die das gesamte Firmenkapital vertritt, ordnungsmäßig einberufen ist und rechtsgültig im Hinblick

auf sämtliche Tagesordnungspunkte beraten kann.

Die Hauptversammlung hat hiernach nach Beratung einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, zwei (2) Anteilsklassen zu schaffen: «Stammanteile A» und «Stammanteile B».

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt nachfolgend die Umwandlung von vierhundertfünfundzwanzig (425) Anteilen, die

fünfundachtzig Prozent des Grundkapitals darstellen, mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-),
in vierhundertfünfundzwanzig (425) Stammanteile A mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

<i>Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt nachfolgend die Umwandlung von fünfundsiebzig (75) Anteile, die fünfzehn Prozent

des Grundkapitals darstellen, mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), in fünfundsiebzig (75)
Stammanteile B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

42979

<i>Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Satzung der Gesellschaft vollständig umzuformulieren, die ab sofort wie folgt

zu lesen ist:

Kapitel I.- Form, Name, Geschäftssitz, Gegenstand, Laufzeit

Art. 1. Form - Firma.
22.1 Es ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma GH RETAIL PORTFOLIO S.à r.l. errichtet, die

dem ein solches Unternehmen betreffenden Recht unterliegen wird (nachfolgend «Gesellschaft»), und insbesondere dem
Recht vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils geänderten Fassung (nachfolgend «Recht»), der
vorliegenden Satzung (nachfolgend «Satzung») sowie der Anteilseignervereinbarung.

Art. 2. Geschäftssitz.
23.1 Der Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).
23.2 Er kann auf jedweden sonstigen Ort im Großherzogtum Luxemburg mittels eines Beschlusses einer außeror-

dentlichen Hauptversammlung ihrer Anteilseigner verlegt werden, die auf die in der Satzung für Änderungen vorgesehene
Art und Weise beraten.

23.3 Es sind jedoch der einzige Geschäftsführer, bzw. bei mehreren Geschäftsführern, der Vorstand der Gesellschaft,

berechtigt, den Geschäftssitz der Gesellschaft innerhalb der Stadt Luxemburg zu verlegen.

Art. 3. Gegenstand.
24.1 Der Gegenstand der Gesellschaft besteht in der Übernahme, dem Verkauf oder der sonstigen Verfügung sowie

dem direkten oder indirekten Halten von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, u. a. durch
die Zeichnung oder den Erwerb jedweder Sicherheiten und Rechte durch Beteiligung, Beitrag, Übernahme, Firmenkauf
oder Option, Verhandlung oder auf jedwede sonstige Art und Weise, bzw. Finanzschuldinstrumente in jedweder Form,
sowie in der Verwaltung, Entwicklung und Führung dieser Beteiligungen und direkten sowie indirekten Investitionen in
Luxemburg und im Ausland.

24.2 Die Gesellschaft ist ebenfalls berechtigt, ihren Tochtergesellschaften oder Unternehmen, an denen sie eine direkte

oder indirekte Beteiligung hält, selbst, wenn diese unwesentlich ist, oder jedweder Gesellschaft, die ein direkter oder
indirekter Anteilseigner der Gesellschaft ist bzw. jedweder Gesellschaft, die zum gleichen Konzern, wie die Gesellschaft
gehört,  jedwede  Unterstützung  zu  erbringen,  unabhängig  davon,  ob  durch  Darlehen,  Bürgschaften  oder  anderweitig
(nachfolgend als «Verbundene Unternehmen» bezeichnet), wobei vorausgesetzt wird, dass die Gesellschaft keine Trans-
aktion  abschließen  wird,  die  ihre  Beteiligung  an  jedweder  Tätigkeit  zur  Folge  hätte,  die  als  geregelte  Tätigkeit  des
Finanzsektors betrachtet werden würde.

24.3 Die Gesellschaft ist berechtigt, insbesondere die nachstehenden Transaktionen abzuschließen, wobei vorausge-

setzt wird, dass die Gesellschaft keine Transaktion abschließen wird, die ihre Beteiligung an jedweder Tätigkeit zur Folge
hätte, die als geregelte Tätigkeit des Finanzsektors betrachtet werden würde:

- Gelder in jedweder Form zu leihen oder jedwede Form der Kreditfazilität zu erhalten sowie Mittel aufzunehmen

durch, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf die Ausgabe, auf privater Basis, von Schuldverschreibungen, Solawech-
seln und sonstigen Schuldtiteln oder Kapitalbeteiligungsinstrumenten, die Verwendung von Finanzderivativen oder auf
eine sonstige Art und Weise;

- Vorschuss, Verleih oder Einzahlung von Geldern bzw. Gewährung von Kredit an ein oder bei einem luxemburgischen

oder ausländischen Unternehmen, bzw. Zeichnung oder Kauf eines jedweden durch diese Unternehmen ausgestellten
Schuldtitels, zu den Bedingungen, die für geeignet erachtet werden, und zwar mit oder ohne Sicherheit;

- Eingehen einer jedweder Garantie, Pfandrecht oder jedweden sonstigen Form der Sicherheit, unabhängig davon, ob

durch persönliche Zusage oder Hypothekenurkunde bzw. vollständige oder teilweise Belastung der Verpflichtung, Ver-
mögenswerte (bestehend oder zukünftig) oder durch sämtliche oder jedwede dieser Methoden, für die Erfüllung jedweder
Verträge oder Verpflichtungen der Gesellschaft und jedwede der Verbundenen Unternehmen, oder jedweder Geschäfts-
führer oder Führungskräfte der Gesellschaft oder jedweder Verbundenen Unternehmen, im Rahmen der Beschränkungen
des luxemburgischen Rechts.

24.4 Die Gesellschaft berechtigt, sämtliche rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Anlagen oder

Tätigkeiten auszuführen, und im Allgemeinen, sämtliche Transaktionen, die für die Erfüllung ihres Gegenstands erforderlich
sind, sowie sämtliche Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Erleichterung der Erfüllung ihres Zwecks in sämtlichen
vorstehend beschriebenen Bereichen verbunden sind.

Art. 4. Dauer.
25.1 Die Gesellschaft wird für einen unbestimmten Zeitraum errichtet.

Kapitel II.- Kapital, Anteile

Art. 5. Grundkapital.
26.1 Das Grundkapital ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt, vertreten durch vierhundert-

fünfundzwanzig (425) Stammanteile A und fünfundsiebzig (75) Stammanteile B mit einem Nennwert von jeweils fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25,-), die sämtlich vollständig eingezahlt sind («Anteile», einzeln ein «Anteil»).

42980

26.2 Das Kapital kann jederzeit durch einen Beschluss eines einzigen Anteilseigner (wenn nur ein Anteilseigner besteht)

oder durch einen Beschluss der Anteilseignerversammlung im Einklang mit Artikel 16 der Satzung geändert werden.

26.3 Zusätzlich zu dem Firmenkapital kann ein Prämienkonto eingerichtet werden, auf das jedweder auf jedweden

Anteil gezahlte Aufschlag überwiesen wird. Der Betrag des bezeichneten Prämienkontos steht dem/den Anteilseigner(n)
zur freien Verfügung.

26.4 Sämtliche Anteile verfügen über die gleichen Rechte.
26.5 Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Anteile im Rahmen der von Rechts wegen festgelegten Grenzen

übergehen.

Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile. In Bezug auf die Gesellschaft sind die Anteile unteilbar, da lediglich ein Halter pro

Anteil zulässig ist. Gemeinsame Miteigentümer werden eine einzige Person zu ihrem Vertreter gegenüber der Gesellschaft
ernennen.

Art. 7. Übertragung der Anteile.
28.1 Im Falle eines einzigen Anteilseigners sind die durch den einzigen Anteilseigner gehaltenen Anteile frei übertragbar.
28.2 Anteilseigner A darf seine Stammanteile A nicht vor dem ersten Jahrestag des Datums der Ausfertigung des

Konsortialvertrages übertragen, es sei denn:

(a) die Übertragung ist jeweils eine Genehmigte Übertragung; oder
(b) für eine durch den Konsortialvertrag regulierte Übertragung.
Nach dem ersten Jahrestag des Datums der Ausfertigung des Konsortialvertrages ist Anteilseigner A berechtigt, zu-

sätzlich seine Anteile an jedwede Person zu übertragen, vorbehaltlich Artikel 9 und Artikel 10 der vorliegenden Satzung
(falls anwendbar).

28.3 Anteilseigner B darf seine Stammanteile B nicht während der Laufzeit des Konsortialvertrages übertragen, abge-

sehen von einer Übertragung gemäß Artikel 9 und Artikel 10 der Satzung oder vorbehaltlich der vorherigen schriftlichen
Zustimmung von Anteilseigner A oder in dem Fall, dass die Übertragung eine Genehmigte Übertragung ist.

28.4 Die Anteilseigner werden jeweils erwirken, dass der Vorstand lediglich die Eintragung einer Übertragung von

Anteilen genehmigt, die im Einklang mit der Anteilseignervereinbarung und der Satzung erfolgt.

28.5 Gemäß § 189 des luxemburgischen Rechts über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der jeweils ge-

änderten Fassung, ist jedwede Übertragung von Anteilen an eine Person, mit Ausnahme eines Anteilseigners, durch die
Anteilseigner zu genehmigen, die 3/4 des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten, vorausgesetzt, dass für eine Geneh-
migte Übertragung davon ausgegangen wird, dass Anteilseigner A und Anteilseigner B diese Übertragung genehmigt haben.

Änderung der Kontrolle und Kaufoption.
29.1 Bei Eintreten eines Ereignisses der Änderung der Kontrolle ist Anteilseigner A berechtigt, Anteilseigner B aufzu-

fordern (jedoch nicht nur), seine Stammanteile B sämtlich zu verkaufen («Kaufoption»).

29.2 Vor Einteten eines Ereignisses der Änderung der Kontrolle wird Anteilseigner B so schnell wie durchführbar, und

in keinem Fall später als 3 Monate vor dem Eintreten eines Ereignisses der Änderung der Kontrolle, Anteilseigner A
schriftlich davon in Kenntnis setzen («Inkenntnissetzung über die Änderung der Kontrolle»), dass dieses Ereignis eintreten
kann.

29.3 Anteilseigner A ist berechtigt, durch schriftliche Mitteilung («Optionsmitteilung»), die jederzeit innerhalb von 2

Monaten nach Erhalt einer Mitteilung über eine Inkenntnissetzung über die Änderung der Kontrolle (oder in dem Fall,
dass diese Mitteilung nicht an Anteilseigner A zugestellt wird, innerhalb von 3 Monaten nach Feststellung dessen, dass ein
Ereignis der Änderung der Kontrolle eingetreten ist) zu erstellen ist, die Kaufoption auszuüben. Das Datum der Zustellung
der Optionsmitteilung wird nachfolgend als «Ausübungsdatum» bezeichnet. In dieser Optionsmitteilung wird Folgendes
angegeben:

(a) der für die Stammanteile B in Übereinstimmung mit Artikel 8.4 zahlbare Gesamtpreis («Optionspreis»); und
(b) ein Datum für den Abschluss des Kaufs und Verkaufs der Stammanteile B gemäß der Ausübung der Kaufoption,

die an einem Werktag, 15 bis 20 Werktage nach Zustellung der Optionsmitteilung durch Anteilseigner A erfolgt, bzw.,
wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt ist, am 7. Werktag, nachdem der zahlbare Preis in Übereinstimmung mit Artikel
8.7 vereinbart oder beschlossen wurde.

29.4 Der Preis für gemäß der Kaufoption zu verkaufende Stammanteile B ist der Marktwert der Stammanteile B zum

Ausübungsdatum (der Marktwert wird auf der Grundlage der besten Schätzung des Anteilseigners in Übereinstimmung
mit Artikel 8.7 bestimmt).

29.5 Anteilseigner B ist verpflichtet, die in der Optionsmitteilung bezeichneten Stammanteile B zu verkaufen (bzw.

deren Verkauf zu erwirken), lediglich vorbehaltlich des Erhalts des Optionspreises, und Anteilseigner A ist verpflichtet,
die in der Optionsmitteilung angeführten Anteile zu kaufen, bzw. den Kauf durch ein Mitglied des Konzerns des Anteil-
seigners A zu erwirken.

29.6 Falls sich Anteilseigner B bei der Ausübung der Kaufoption nicht mit dem durch Anteilseigner A vorgeschlagenen

Marktwert für die betreffenden Anteile einverstanden erklärt, wird er Anteilseigner A innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt
der Optionsmitteilung eine Mitteilung unter Darlegung seines alternativen Vorschlags für den Marktwert zukommen lassen

42981

(«Einwandsmitteilung»). Eine Unterlassung, eine Einwandsmitteilung innerhalb dieses Zeitrahmens zuzustellen, bedeutet,
dass Anteilseigner B den durch Anteilseigner A vorgeschlagenen Marktwert akzeptiert hat. Einigen sich die Anteilseigner
nicht innerhalb von 15 Werktagen nach Zustellung einer Einwandsmitteilung auf den Marktwert, ist jedweder Anteils-
eigner  berechtigt,  die  Angelegenheit  an  einen  unabhängigen  Wirtschaftsprüfer  («Bewerter»)  zu  übergeben  (der  als
Schiedsgutachter und nicht als Schiedsrichter handelt). Der Bewerter wird durch die Anteilseigner ernannt, bzw. bei nicht
erfolgter Ernennung innerhalb von 20 Werktagen nach Zustellung einer Einwandsmitteilung, wird er durch den Vorsit-
zenden des Instituts der Wirtschaftsprüfer in England und Wales auf Ersuchen eines jedweden Anteilseigners ernannt
(wobei das erste Ersuchen maßgeblich sein wird). Der Bewerter wird den Marktwert der Stammanteile auf einem Un-
ternehmensfortführungsprinzip und zu Marktbedingungen zwischen einem bereitwilligen Verkäufer und einem bereitwil-
ligen Käufer bestimmen sowie auf der Grundlage, dass jeder Anteil jedweder Klasse über den gleichen Wert entsprechend
seines Anteils am Wert sämtlicher Anteile als Ganzes gesehen verfügt, und dass kein zusätzlicher oder geringerer Wert
jedwedem Halten von Anteilen lediglich Kraft dieses Haltens anhaftet, welches einer Mehrheit oder Minderheit des ge-
samten, gezeichneten Grundkapitals der Gesellschaft darstellt oder nach dem Kauf verleiht bzw. zur Folge hat. Jedwede
Kosten des Bewerters werden durch den Anteilseigner übernommen, dessen Marktwertvorschlag (wie in der Options-
mitteilung und Einwandsmitteilung dargelegt) am meisten von dem durch den Bewerter bestimmten Wert abweicht.

Art. 9. Mitverkaufsrechte.
30.1 Es wird vorausgesetzt und vereinbart, dass lediglich Anteilseigner A berechtigt ist, eine Übertragung gemäß dieses

Artikels 9 auszulösen.

30.2  Falls  Anteilseigner  A  nach  dem  ersten  Jahrestag  des  Datums  der  Ausfertigung  des  Konsortialvertrages  seine

Stammanteile A ganz oder teilweise verkaufen möchte («Angebotene Wertpapiere»), ausgenommen gemäß einer Ge-
nehmigten Übertragung, wird dieser Anteilseigner A Anteilseigner B mit einer Frist von 20 Werktagen schriftlich hierüber
in Kenntnis setzen und sich mit Anteilseigner B bezüglich der geplanten Übertragung beraten.

30.3  Beschließt  Anteilseigner  A  nach  Ablauf  dieses  Zeitraums  von  20  Werktagen,  den  Verkauf  der  Angebotenen

Wertpapieren an einen gutgläubigen, unabhängigen Dritten («Käufer») zu Marktbedingungen zu tätigen, wird Anteilseigner
A durch schriftliche Mitteilung an Anteilseigner B und die Gesellschaft («Verkaufsmitteilung») sämtliche relevanten An-
gaben des Käufers und die allgemeinen Bedingungen anführen, zu denen der Verkauf erfolgen soll, und ist berechtigt, der
Verkaufsmitteilung eine weitere Mitteilung beizufügen («Mitverkaufsmitteilung»), die Anteilseigner B auffordert, den glei-
chen  Teil  seiner  Stammanteile  B  an  den  Käufer  zu  Bedingungen  zu  verkaufen,  die  nicht  weniger  vorteilhaft  sind,
einschließlich im Hinblick auf den Preis (auf einer Anteilsgrundlage), der auf die durch Anteilseigner A zu übertragenden
Anteile anwendbar ist («Mitverkaufsrecht»), wie in der Verkaufsmitteilung dargelegt.

30.4 Der Abschluss des Verkaufs von Anteilen gemäß einer Ausübung des Mitverkaufsrechts erfolgt zur gleichen Zeit,

am gleichen Ort und zu den Bedingungen, die nicht weniger vorteilhaft sind, einschließlich im Hinblick auf den Preis (auf
einer Anteilsgrundlage), wie der Verkauf von Anteilen durch Anteilseigner A an den Käufer. Die Anteilseigner vereinbaren,
dass die Erlöse für die gemäß der vorhergehenden Bestimmung dieser Klausel 9.4 fälligen Anteile in Übereinstimmung
mit der Priorität der in dem Konsortialvertrag dargelegten Ausschüttungen ausgewiesen werden, als ob diese Erlöse
Ausschüttungen wären. Bei Entstehen einer Streitigkeit in Bezug auf die Ausschüttungen ist diese wie im Konsortialvertrag
dargelegt, beizulegen.

Mitnahmerechte.
31.1 Nach Zustellung einer Verkaufsmitteilung und vorbehaltlich der Zustellung einer Mitverkaufsmitteilung seitens

Anteilseigner  A  ist  Anteilseigner  B  berechtigt,  innerhalb  von  21  Tagen  nach  Zustellung  der  Verkaufsmitteilung,  eine
schriftliche Mitteilung an Anteilseigner Azu senden («Mitnahmemitteilung») unter Angabe dessen, dass er möchte, dass
der Käufer den gleichen Teil seiner Stammanteile B erwirbt. Hat Anteilseigner B eine Mitnahmemitteilung zugestellt, wird
Anteilseigner A keine Stammanteile A an den Käufer übertragen oder deren Übertragung erwirken, ohne vom Käufer
zuerst zu fordern, den gleichen Teil der durch Anteilseigner B gehaltenen Stammanteile B zu Bedingungen zu erwerben,
die nicht weniger vorteilhaft sind, einschließlich im Hinblick auf dem Preis (auf einer Anteilsbasis), wie in der Verkaufs-
mitteilung dargelegt («Mitnahmerecht»).

31.2 Bei Ausübung des Mitnahmerechts wird kein Anteilseigner eine Vereinbarung, Verpflichtung oder Zusage mit

jedweder Person tätigen, aus denen sich jedwede Anteilseignervergütung von höherem Wert oder zu Bedingungen ergibt,
die vorteilhafter sind, als diejenigen in der Verkaufsmitteilung. Der Verkauf jedweder Stammanteile B durch Anteilseigner
B bzw. die betreffenden Mitglieder des Konzerns von Anteilseigner B an den Käufer erfolgt zur gleichen Zeit, am gleichen
Ort und zu Bedingungen, die nicht weniger vorteilhaft sind (oder die der folgenden Bestimmung dieser Klausel entspre-
chen),  einschließlich  im  Hinblick  auf  den  Preis  (auf  einer  Anteilsbasis),  wie  der  Verkauf  von  Stammanteilen  A  durch
Anteilseigner A (oder Parteien) bzw. die betreffenden Mitglieder des Konzerns von Anteilseigner A an den Käufer. Die
Anteilseigner vereinbaren, dass die Erlöse für die gemäß den vorhergehenden Bestimmungen dieses Artikels 10.2 fälligen
Anteile in Übereinstimmung mit der Priorität der in dem Konsortialvertrag dargelegten Ausschüttungen erfolgen, als ob
diese Erlöse Ausschüttungen wären. Bei Entstehen einer Streitigkeit in Bezug auf die Ausschüttungen ist dieser wie im
Konsortialvertrag dargelegt, beizulegen.

31.3 Erfüllt Anteilseigner B nicht die Anforderungen dieses Artikels 10, ist Anteilseigner A berechtigt, seine sämtlichen

Anteile ohne Beachtung des Mitnahmerechts von Anteilseigner B zu verkaufen.

42982

Kapitel III.- Geschäftsführung

Art. 11. Geschäftsführung.
32.1 Die Gesellschaft wird durch bis zu vier (4) Geschäftsführer geleitet, die durch einen Beschluss des/der Anteils-

eigner(s) ernannt werden. Bei mehreren Geschäftsführern werden diese einen Vorstand bilden («conseil de gérance»)
(«Vorstand»).

32.2 Anteilseigner A ist berechtigt, zu gegebener Zeit zumindest vier (4) Personen zur Wahl vorzuschlagen, von denen

die Anteilseigner-Hauptversammlung drei (3) Geschäftsführer («Geschäftsführer A») ernennen wird, und Anteilseigner
B ist berechtigt, zu gegebener Zeit zumindest zwei (2) Personen zur Wahl vorzuschlagen, von denen die Anteilseigner-
Hauptversammlung einen (1) Geschäftsführer («Geschäftsführer B») ernennen wird.

32.3 Der Hauptversammlung der Gesellschaft wird es jederzeit freistehen, im Hinblick auf jedwede Abberufung oder

Absetzung eines jedweden Geschäftsführers abzustimmen, wobei vorausgesetzt wird, dass (i) das Recht einer Partei, einen
Kandidaten zur Wahl in den Vorstand vorzuschlagen, das Recht beinhaltet, die Abberufung oder Absetzung der in Über-
einstimmung mit Artikel 11.2 der Satzung auf Vorschlag dieser Partei ernannten Geschäftsführer vorzuschlagen, und (ii)
die Bestimmungen von Artikel 11.2 der Satzung gelten in gleicher Weise für den Austausch eines Geschäftsführers.

32.4 Die Geschäftsführer sind nicht berechtigt, eine Vergütung in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft

zu erhalten.

Art. 12. Befugnisse des einzigen Geschäftsführers oder des Vorstands.
33.1 Bei Verhandlungen mit Dritten haben der einzige Geschäftsführer bzw. bei mehreren Geschäftsführern, der Vor-

stand, unbeschadet Artikel 11 und Artikel 13 der vorliegenden Satzung, sämtliche Befugnisse, namens der Gesellschaft
unter sämtlichen Umständen zu handeln sowie sämtliche Handlungen und Transaktionen im Einklang mit den Gegen-
ständen der Gesellschaft, und vorausgesetzt, dass die Bedingungen dieses Artikels zu beachten sind, auszuführen und zu
genehmigen.

33.2 Sämtliche nicht ausdrücklich durch das Recht oder diese Satzung der Anteilseigner-Hauptversammlung vorbe-

haltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit des einzigen Geschäftsführers bzw. bei mehreren Geschäftsführern, des
Vorstands. Der Vorstand ist für die Aufsicht und Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Geschäftstätigkeit zuständig, wird
jedoch die vorherige schriftliche Zustimmung von Anteilseigner A und Anteilseigner B einholen, bevor eine Wesentliche
Übernahme erfolgt.

33.3 Die Genehmigung des Vorstands wird jeweils für die folgenden Beschlüsse benötigt:
(a) Verabschiedung des jährlichen Unternehmensplans und jedweder diesbezüglichen Änderungen;
(b) Abschluss oder Änderung eines jedweden Mietvertrages seitens eines jedweden Mitglieds der Unternehmensgruppe

mit einem jährlichen Bruttomietwert von mehr als EUR 100.000,-;

(c) jedweden Vorschlag auf Änderung der Satzung oder sonstige verfassungsrechtliche Unterlagen der Gesellschaft

oder SPVs (Anmerkung: der Beschluss, die Änderung der Satzung zu genehmigen, obliegt lediglich der Anteilseigner-
Hauptversammlung);

(d)  wesentliche  Abweichungen  vom  Unternehmensplan  durch  jedwedes  Mitglied  der  Unternehmensgruppe,  ein-

schließlich im Hinblick auf, aber ohne Beschränkung auf, Eigentumserwerb, -veräußerungen, Finanzierungen, Mietverträge,
Abschluss oder Änderung der Bedingungen von Verträgen mit einem Wert von € 50.000,- oder mehr, sämtliche Inves-
titionen von mehr als € 10.000,- sowie Ausschüttungen;

(e) Bestimmung der Höhe der Verteilungsfähigen Barmittel zu jedwedem Zeitpunkt und Entscheidung über deren

Ausschüttung;

(f) Schaffung einer jedweden Belastung über jedwede ausstehenden Einlagen, jedwedes sonstigen Vermögenswerts

eines jedweden Mitglieds der Unternehmensgruppe, bzw. Gewährung einer jedweden Garantie, Entschädigung oder Si-
cherheit bzw. Abschluss einer jedweden Vereinbarung oder Vergleichs mit einer vergleichbaren Folge durch jedwedes
Mitglied der Unternehmensgruppe, oder Übernahme jedweder Haftung durch jedwedes Mitglied der Unternehmens-
gruppe, unabhängig davon, ob tatsächlich oder bedingt, in Bezug auf jedwede Verpflichtung jedweder Person;

(g) (soweit durch das Recht zulässig) Veränderung, Schaffung, Erhöhung, Umstrukturierung, Konsolidierung, Unter-

teilung, Umwandlung, Verringerung, Einlösung, Rückkauf, Neubezeichnung oder sonstige Veränderung des genehmigten
oder  ausgegebenen  Anteils  oder  Darlehenskapitals  jedwedes  Mitglieds  der  Unternehmensgruppe,  bzw.  Veränderung,
Modifizierung,  Abschaffung  oder  Gewährung  jedweder  jedwedem  solchen  Anteil  oder  Darlehenskapital  anhaftenden
Rechte, jeweils vorbehaltlich einer ausdrücklichen Anforderung durch den Konsortialvertrag;

(h) (soweit durch das Recht zulässig) Abschluss oder Schaffung jedweder Vereinbarung, Vergleich oder Verpflichtung

durch jedwedes Mitglied der Unternehmensgruppe, die eine Schaffung, Zuweisung, Ausgabe, Übertragung, Einziehung
oder Rückzahlung eines bzw. Gewährung des Rechts an einen Dritten (mit Vorbehalt oder ohne) fordert, um die Schaffung,
Zuweisung, Ausgabe, Übertragung, Einziehung oder Rückzahlung eines Anteils am Kapital jedwedes Mitglieds der Unter-
nehmensgruppe zu fordern (einschließlich u. a. einer Option oder eines Prioritätsrechts oder einer Umwandlung). jeweils
vorbehaltlich einer ausdrücklichen Anforderung oder Genehmigung durch den Konsortialvertrag;

(i) (soweit durch das Recht zulässig) Verringerung, Kapitalisierung, Rückzahlung oder Verteilung eines jedweden sich

im Guthaben des Grundkapitals, des Anteils-Prämienkontos, der Kapitaltilgungsrücklage oder jedweder sonstigen Rück-

42983

lage eines jedweden Mitglieds der Unternehmensgruppe befindlichen Anteils, bzw. Verringerung jedweder ausstehenden
Haftung in Bezug auf teilweise gezahlte Anteile jedwedes Mitglieds der Unternehmensgruppe;

(j) (soweit durch das Recht zulässig) Fassung eines jedweden Beschlusses in Bezug auf die Auflösung oder Abwicklung

jedweder Unternehmensgruppe;

(k) Veränderung des Buchhaltungsreferenzdatums jedwedes Mitglieds der Unternehmensgruppe oder Veränderung

der Buchhaltungsgrundsätze, vorbehaltlich einer Anforderung durch das Recht oder eine anwendbare Bestimmung;

(l) Abschluss einer jedweder Partnerschaft oder Jointventurevereinbarung mit jedweder Person;
(m) jedwedes Mitglied der Unternehmensgruppe, welches eine jedwede Vereinbarung oder Fazilität eingeht bzw. re-

finanziert, bzw. der diesbezügliche Abschluss durch jedwedes Mitglied der Unternehmensgruppe, um jedwede Kredit-
aufnahme oder jedwede sonstige Verschuldung oder Verbindlichkeit im Rahmen einer Kreidtaufnahme zu erhalten bzw.
zu refinanzieren (einschließlich u. a. Drittfinanzierung und Änderungen des Kreditvertrages);

(n) Bildung jedweder Tochtergesellschaft oder Erwerb von Anteilen an jedweder Gesellschaft bzw. Beteiligung an

jedweder Partnerschaft, Joint Venture oder vergleichbaren Vereinbarung bzw. der Kündigung jedweder Beteiligung;

(o) Ausstellung jedweder Tilgungsankündigung;
(p) Veräußerung jedwedes Vermögens oder Anteile an einem SPV;
(q) Abschluss und Verlängerung des Geschäftsführungsvertrages; und
(r) jedwedes Mitglied der Unternehmensgruppe, welches einen jedweden Vertrag abschließt oder ändert (mit Aus-

nahme des Mietvertrages).

Art. 13. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten ist die Gesellschaft, im Falle eines einzigen Geschäftsführers,

durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführer gebunden, bzw. im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch
die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers A und eines Geschäftsführers B bzw. durch die Unterschrift jedweder
Person, an welche diese Befugnis übertragen werden kann, im Falle eines einzigen Geschäftsführers, durch den einzigen
Geschäftsführer, bzw. im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch jedweden den Vorstand.

Art. 14. Übertragung und Vertreter des einzigen Geschäftsführers oder des Vorstands.
35.1 Der einzige Geschäftsführer ist, bzw. im Falle mehrerer Geschäftsführer, ist der Vorstand berechtigt, seine Be-

fugnisse für bestimmte Aufgaben auf einen oder mehrere Ad hoc-Vertreter übertragen.

35.2 Der einzige Geschäftsführer wird, bzw. im Falle mehrerer Geschäftsführer, wird der Vorstand die Verantwort-

lichkeiten  und  Vergütung  (ggf.),  die  Dauer  des  Vertretungszeitraums  und  jedwede  sonstigen  relevanten  Bedingungen
dieser Vertretung eines jedweden solchen Vertreters bestimmen.

Art. 15. Vorstandssitzung.
36.1 Vorstandssitzungen sind ordnungsgemäß durch einen Geschäftsführer A und einen Geschäftsführer B mit einer

Vorabmitteilung von mindestens sieben Werktagen einzuberufen (bzw. einer kürzeren Einberufungsfrist, wenn dem zu-
mindest ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B schriftlich zustimmen und der Ansicht sind, dass die Interessen
der Gesellschaft wahrscheinlich auf wesentliche Art und Weise nachteilig beeinträchtigt werden würden, wenn das auf
dieser Vorstandssitzung zu behandelnde Geschäft nicht als Dringlichkeitsfall behandelt werden würde), und dieser Mit-
teilung  wird  eine  Tagesordnung  beigefügt,  in  der  angemessen  ausführlich  die  auf  der  Sitzung  zu  erörternden  Punkte
angeführt sowie Kopien jedweder auf der Sitzung zu besprechenden Unterlagen enthalten sind.

36.2 Ordnungsgemäß einberufene Vorstandssitzungen können zu den Zeiten abgehalten werden, die durch den Vor-

stand  bestimmt  werden,  und  in  keinem  Fall  weniger  als  vier  Mal  im  Jahr  am  Hauptgeschäftssitz  der  Gesellschaft  in
Luxemburg oder einem sonstigen Ort, den der Vorstand zu gegebener Zeit bestimmen kann (falls gemäß dem anwend-
baren Recht zulässig).

36.3 Der Posten des Vorstandsvorsitzenden («Vorsitzender») wird stets durch einen Geschäftsführer A gehalten. Ist

der Vorsitzende auf jedweder Vorstandssitzung nicht anwesend, ist der anwesende Geschäftsführer A berechtigt, einen
sonstigen Geschäftsführer A zu ernennen, damit dieser als Vorsitzender im Rahmen der Sitzung handelt.

36.4 Der Vorstand ist berechtigt, ohne vorherige Mitteilung rechtsgültig zu beraten und Beschlüsse zu fassen, wenn

sämtliche Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Einberufungsanforderungen und -formalitäten ver-
zichtet haben.

36.5 Der Vorstand kann lediglich in dem Fall rechtsgültig beraten und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner

Mitglieder anwesend oder vertreten ist, einschließlich zumindest eines Geschäftsführers A und eines Geschäftsführers B.
Beschlüsse des Vorstands sind durch eine einfache Mehrheit anzunehmen, einschließlich zumindest eines Geschäftsführer
A, der dafür stimmt.

36.6 Ein Geschäftsführer A oder ein Geschäftsführer B, die an einer Sitzung nicht teilnehmen, können schriftlich oder

per Telegramm, Telefax, E-Mail oder Brief jedweden sonstigen Geschäftsführer ernennen (ausgenommen des Geschäfts-
führers  A,  der  die  jeweils  andere  Partei  vertritt),  um  ihn  auf  der  Sitzung  zu  vertreten  und  an  seiner  Stelle  als  sein
Bevollmächtigter abzustimmen.

36.7 Vorstandssitzungen können mittels Videokonferenzanlagen und -konferenz abgehalten werden, soweit dies durch

das anwendbare Recht zulässig ist und soweit diese nicht die steuerliche Stellung eines Anteilseigners und der Gesellschaft

42984

nachteilig beeinträchtigen, vorausgesetzt, dass jeder teilnehmende Geschäftsführer in der Lage ist, sämtliche sonstigen
teilnehmenden Geschäftsführer zu hören und von diesen gehört zu werden, unabhängig von dem Einsatz dieser Tech-
nologie, und jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und per Video oder Telefon stimmberechtigt.

36.8 Ein schriftlicher Beschluss, unterzeichnet durch sämtliche Geschäftsführer, ist ordnungsgemäß und rechtsgültig,

als ob er auf einer Vorstandssitzung gefasst worden wäre, die ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre.
Dieser Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in einzelnen gesonderten Dokumenten mit dem gleichen Inhalt
und durch sämtliche Vorstandsmitglieder unterzeichnet niedergeschrieben sein.

36.9 Das Protokoll einer Vorstandssitzung ist durch sämtliche auf der Sitzung anwesenden oder vertretenen Ge-

schäftsführer zu  unterzeichnen. Auszüge  sind  durch jedweden  Geschäftsführer oder  durch  jedwede durch  jedweden
Geschäftsführer während einer Vorstandssitzung ernannte Person zu bestätigen.

Kapitel IV.- Hauptversammlung

Art. 16. Befugnisse der Anteilseigner - Hauptversammlung - Abstimmungen.
37.1  Bei  lediglich  einem  Anteilseigner  übernimmt  der  einzige  Anteilseigner  sämtliche  der  Anteilseigner-Hauptver-

sammlung verliehenen Befugnisse und trifft die Beschlüsse schriftlich.

37.2 Im Falle mehrerer Anteilseigner ist jeder Anteilseigner berechtigt, an gemeinsamen Beschlüssen, unabhängig von

der Anzahl der Anteile, die er hält, teilzunehmen. Jeder Anteilseigner verfügt über Stimmrechte entsprechend seiner
Beteiligung. Gemeinsame Beschlüsse sind lediglich dann rechtsgültig gefasst, wenn Anteilseigner, die mehr als die Hälfte
des Grundkapitals halten, diese annehmen.

37.3 Beschlüsse zur Änderung der Satzung können jedoch lediglich durch die Mehrheit (in der Anzahl) der Anteilseigner

gefasst werden, die mindestens dreiviertel des Grundkapitals der Gesellschaft halten, vorbehaltlich jedweder sonstigen
Bestimmungen des Rechts.

37.4 Sind sämtliche Anteilseigner anwesend oder vertreten, können sie auf jedwede Einberufungsformalitäten ver-

zichten und die Sitzung kann rechtsgültig ohne vorherige Mitteilung abgehalten werden.

37.5 Bei weniger als fünfundzwanzig Anteilseignern kann jeder Anteilseigner den Text der zu fassenden Beschlüsse

erhalten und seine Stimme schriftlich abgeben.

37.6 Ein Anteilseigner kann auf einer Anteilseignerversammlung durch schriftliche Ernennung (oder per Fax, E-Mail

oder jedwede gleichartigen Mittel) eines Anwalts, der kein Anteilseigner sein muss, vertreten werden.

Kapitel V.- Geschäftsjahr

Art. 17. Geschäftsjahr.
38.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. eines jeden Jahres.
38.2 Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird der Abschluss der Gesellschaft durch den einzigen Geschäftsführer,

oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch den Vorstand und den einzigen Geschäftsführer festgestellt, und erarbeitet
der Vorstand im Falle mehrerer Geschäftsführer eine Bestandsaufnahme, einschließlich der Angabe des Werts der Aktiva
und Passiva der Gesellschaft.

38.3 Jeder Anteilseigner ist berechtigt, die vorstehende Bestandsaufnahme und die Bilanz am Geschäftssitz der Ge-

sellschaft einzusehen.

Art. 18. Anteils - Ausschüttungsansprüche.
39.1 Die Erlöse in Bezug auf ein Geschäftsjahr stellen nach Abzug der allgemeinen und betrieblichen Aufwendungen,

Gebühren und Abschreibungen den Nettoerlös der Gesellschaft für diesen Zeitraum dar.

39.2 Von dem auf diese Art und Weise bestimmten Nettoerlös sind fünf Prozent abzuziehen und einer gesetzlichen

Rücklage zuzuweisen. Dieser Abzug ist nicht mehr zwingend, wenn der Betrag des gesetzlichen Rücklagefonds ein Zehntel
des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht.

39.3 Soweit die Mittel der Gesellschaft für Ausschüttung zur Verfügung stehen und soweit durch das Recht und diese

Satzung zulässig, werden der einzige Geschäftsführer, oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand die für die
Ausschüttung anzuweisenden verfügbaren Barmittel bestimmen, wie in dem Konsortialvertrag dargelegt.

39.4 Der Beschluss, Fonds auszuschütten und die Bestimmung der Höhe dieser Ausschüttung, erfolgen durch einen

Mehrheitsbeschluss der Anteilseigner.

39.5 Unbeschadet der vorherigen Bestimmungen sind der einzige Geschäftsführer, oder, im Falle mehrerer Geschäfts-

führer,  der  Vorstand  berechtigt,  zu  beschließen,  Abschlagsdividenden  an  den/die  Anteilseigner  zu  zahlen.  Diese  Ab-
schlagsdividenden unterliegen der endgültigen Entscheidung der Anteilseigner durch Mehrheitsbeschluss der Anteilseigner
vor Ende des Geschäftsjahres auf der Grundlage einer Abrechnung, in der ausgewiesen wird, dass ausreichende Mittel
zur Ausschüttung verfügbar sind, wobei vorausgesetzt wird, dass (i) der auszuschüttende Betrag nicht die seit dem Ende
des letzten Geschäftsjahres ggf. erzielten Gewinne übersteigen darf, erhöht um die Gewinnvorträge und verteilungsfähigen
Rücklagen, jedoch vermindert um die Verlustvorträge und einer Rücklage zuzuweisende Summen, die gemäß dem Recht
oder dieser Satzung zu bilden ist, und dass (ii) diese ausgeschütteten Summen, die nicht den tatsächlich erzielten Gewinnen
entsprechen, durch den/die Anteilseigner zu erstatten sind.

42985

Kapitel VI.- Liquidation

Art. 19. Auflösung und liquidation.
40.1 Die Gesellschaft ist nicht auf Grund von Tod, Aussetzung der Bürgerrechte, Insolvenz oder Konkurs eines einzigen

Anteilseigners oder einer der Anteilseigner aufzulösen.

40.2 Die Liquidation der Gesellschaft ist durch die Anteilseignerversammlung in Übereinstimmung mit den anwend-

baren Rechtsvorschriften zu beschließen.

40.3 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Konkursverwalter durchgeführt, die Anteilseigner oder keine

Anteilseigner sind, und durch den Anteilseigner ernannt werden, der deren Befugnisse und Vergütung festlegen wird.

Kapitel VII.- Anwendbares Recht

Art. 20. Anwendbares Recht. Es wird auf die Bestimmungen des Rechts für sämtliche Sachverhalte verwiesen, für die

in dieser Satzung keine spezifische Bestimmung besteht.

Begriffsbestimmungen

Art. 21. Begriffsbestimmungen. Vorbehaltlich einer anderweitigen Definition in der Satzung:
Geschäftsführer A hat die ihm gemäß Artikel 11.2 zugewiesene Bedeutung.
Artikel bezeichnet einen Artikel der vorliegenden Satzung.
Geschäftsführer B hat die ihm gemäß Artikel 11.2 zugewiesene Bedeutung.
Vorstand hat die ihm gemäß Artikel 11.1 zugewiesene Bedeutung.
Werktag bezeichnet jedweden Tag (außer Samstag oder Sonntag), an dem die Banken in London und Luxemburg für

den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind;

Unternehmensplan bezeichnet einen durch die Geschäftsführer ausgearbeiteten jährlichen Unternehmensplan für die

Mitglieder der Unternehmensgruppe, in dem ein Fünfjahresbudget ausgewiesen wird, wie in dem Konsortialvertrag dar-
gelegt.

Käufer hat die ihm gemäß Artikel 9.3. dieser Satzung zugewiesene Bedeutung.
Tilgungsankündigung hat die ihr im Rahmen des Konsortialvertrages zugewiesene Bedeutung.
Kaufoption hat die ihr gemäß Artikel 8.1. dieser Satzung zugewiesene Bedeutung.
Ereignis der Änderung der Kontrolle bezeichnet jederzeit nach dem Datum der Ausfertigung des Konsortialvertrages,

dass Herr Fabrice Varoqui (i) nicht länger als Chief Executive Officer von Asset Manager aktiv ist, oder (ii) seine wirt-
schaftliche Berechtigung unter 51% des ausgegebenen Grundkapitals von ARTA LIMITED fällt, (iii) den Geschäftsführer
kontrolliert.

Unternehmensgruppe bezeichnet die Gesellschaft und die SPV und «Mitglied der Unternehmensgruppe» ist entspre-

chend auszulegen.

Veräußerung bezeichnet einen Verkauf jedweder Beteiligung an der Gesellschaft, den SPVs oder sämtlicher bzw. eines

Teils der Vermögenswerte.

Verteilungsfähige Barmittel bezeichnet in Bezug auf jede Gesellschaft und die SPVs sämtliche ihnen zur Verfügung

stehenden Barmittel nach Berücksichtigung der bestehenden und zukünftigen Anforderungen, die in dem Unternehmens-
plan dargelegt sind:

(i) Betriebskapitalanforderungen;
(ii) Anforderungen an die Bedienung der Drittfinanzierung;
(iii) zahlbare Steuern und gesetzliche Gebühren; und
(iv) Investitionsrücklagen;
die durch sie in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht und in Beachtung jedweder vertraglichen Verpflichtung

in Bezug auf die Drittfinanzierung oder anderweitig ausgeschüttet werden können, und, zur Vermeidung von Missvers-
tändnissen, soweit diese Barmittel rechtmäßig durch Rückzahlung des Anteilseignerdarlehens oder diesbezüglichen Zinsen
ausgeschüttet werden können, wobei diese Ausschüttung als mit dem anwendbaren Recht übereinstimmend gilt, unbe-
schadet dessen, das diese Barmittel rechtmäßig nicht mittels einer Dividende ausgeschüttet werden konnten.

Ausschüttung bezeichnet eine Zahlung an die Anteilseigner oder das betreffende Mitglied der Gruppe des Anteilseig-

ners A bzw. der Gruppe des Anteilseigners B, ausgenommen einer Zahlung in Bezug auf die Vermögensverwaltungsgebühr,
die Abschlussrücklagengebühr oder die Maklerprovision (wie im Konsortialvertrag definiert), jedoch einschließlich jed-
weder Zahlung, die in Bezug auf Folgendes entsteht:

(i) Zahlung der Darlehenssumme und Zinsen auf jedwedes Anteilseignerdarlehen (unabhängig davon, ob von den SPVs

oder der Gesellschaft);

(ii) Zahlung jedweder Dividende auf jedwede Anteile;
(iii) Zahlung im Hinblick auf jedwede Einziehung jedweder Anteile; und
(iv) jedwede Kapitalerträge im Hinblick auf jedwede Anteile (einschließlich im Falle der Liquidation),
und «Ausgeschüttet» ist entsprechend auszulegen.

42986

Mitverkaufsrecht bezeichnet das in Artikel 9 der Satzung beschriebene Recht.
Belastung bezeichnet eine Grundschuld, Hypothek, Pfandrecht, Zurückbehaltungsrecht, Option, Beschränkung, Vor-

kaufsrecht, Prioritätsrecht, Recht oder Beteiligung Dritter, eine sonstige Belastung oder ein Sicherungsrecht jedweder
Art, oder eine andere Art von Vertrag oder Vereinbarung mit vergleichbarer Wirkung.

Ausübungsdatum hat die ihm gemäß Artikel 8.3 dieser Satzung zugewiesene Bedeutung.
Gruppe bezeichnet in Bezug auf eine Gesellschaft (unabhängig vom Ort ihrer Errichtung), diese Gesellschaft, jedwede

Gesellschaft, deren Tochtergesellschaft sie ist (ihre Holdinggesellschaft) und jedwede sonstigen Tochtergesellschaften
jedweder solchen Holdinggesellschaft; und jede Gesellschaft in einer Gruppe ist Mitglied der Gruppe.

Geschäftsführer bezeichnet gemeinsam die Geschäftsführer A und Geschäftsführer B.
Einwandsmitteilung hat die ihr gemäß Artikel 8.6 dieser Satzung zugewiesene Bedeutung.
Angebotene Wertpapiere hat die ihnen gemäß Artikel 9.2. dieser Satzung zugewiesene Bedeutung.
Optionsmitteilung hat die ihr gemäß Artikel 8.3 dieser Satzung zugewiesene Bedeutung.
Optionspreis hat die ihm gemäß Artikel 8.3. dieser Satzung zugewiesene Bedeutung.
Genehmigte Übertragung bezeichnet eine Übertragung der relevanten Anteile an ein Mitglied der Gruppe des Anteil-

seigners A oder ein Mitglied der Gruppe des Anteilseigners B zum Zeitpunkt der Übertragung.

Vermögenswerte haben die ihnen im Rahmen des Konsortialvertrages zugewiesene Bedeutung.
Verkaufsmitteilung hat die ihr gemäß Artikel 9.3. dieser Satzung zugewiesene Bedeutung.
Anteile haben die ihnen gemäß Artikel 5.1. der Satzung zugewiesene Bedeutung.
Anteilseigner bezeichnet einen Anteilseigner A oder einen Anteilseigner B, gemeinsam als «Anteilseigner» bezeichnet;
Anteilseigner A bezeichnet den Halter der Stammanteile A, d. h. CPI GH PORTFOLIO S.à r.l., eine Gesellschaft er-

richtet  in  Luxemburg  (mit  anhängiger  Eintragung  im  luxemburgischen  Handels-  und  Unternehmensregister),  mit  Ge-
schäftssitz  in  25B,  boulevard  Royal,  L-2449  Luxemburg  oder,  jederzeit,  jedweden  Übernehmer  oder  Käufer  der
Stammanteile A (jeweils einzeln als «Anteilseigner A») bezeichnet.

Konsortialvertrag bezeichnet einen Konsortialvertrag, der zu gegebener Zeit zwischen dem/den Anteilseigner(n), der

Gesellschaft und bestimmten sonstigen Parteien abgeschlossen werden kann.

Gruppe des Anteilseigners A bezeichnet die Gruppe des Anteilseigners A, d. h. bezeichnet in Bezug auf Anteilseigner

A, jedwede Person, die zu gegebener Zeit direkt oder indirekt kontrolliert, kontrolliert wird oder sich unter gemein-
schaftlicher (direkter oder indirekter) Kontrolle mit dem Anteilseigner A befindet, und umfasst, zur Vermeidung von
Missverständnissen, jedweden durch Citigroup Inc. oder jedwede ihrer verbundenen Unternehmen zu gegebener Zeit
finanzierten oder verwalteten Fonds oder Unternehmen, oder jedwedes sich im Eigentum oder unter der Kontrolle dieses
jedweden Fonds oder Unternehmens befindliches Unternehmen;

Anteilseigner B bezeichnet den Halter der Stammanteile B, d. h. ARTA LIMITED, eine Gesellschaft errichtet nach dem

Recht von Gibraltar, mit Geschäftssitz in 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, oder jedwede ihrer verbundenen Unternehmen
zu gegebener Zeit, bzw. jedwedes sich im Eigentum oder unter der Kontrolle dieses jedweden Fonds oder Unternehmens
befindliches Unternehmen;

Gruppe des Anteilseigners B bezeichnet, in Bezug auf Anteilseigner B, jedwede Person, die zu gegebener Zeit direkt

oder indirekt kontrolliert, kontrolliert wird oder sich unter gemeinschaftlicher (direkter oder indirekter) Kontrolle mit
dem Anteilseigner B befindet, und umfasst Herrn Fabrice Varoqui, und «Mitglied der Gruppe des Anteilseigners B» ist
entsprechend auszulegen.

Vereinbarungen Verbundener Parteien von Anteilseigner B bezeichnet jedweden Vertrag oder Vereinbarung jedweder

Art (unabhängig davon, ob rechtlich erzwingbar oder nicht) zwischen der Gesellschaft oder den SPVs und jedwedem
Mitglied der Gruppe des Anteilseigners B.

Anteilseignerdarlehen bezeichnet die Darlehen, die zu gegebener Zeit durch den Anteilseigner an die Gesellschaft

getätigt werden können.

SPVs hat die ihnen im Rahmen des Konsortialvertrages zugewiesene Bedeutung.
Tochtergesellschaft bezeichnet in Bezug auf eine Gesellschaft (unabhängig vom Ort ihrer Errichtung) (die Holdingge-

sellschaft) jedwede sonstige Gesellschaft, an der die Holdinggesellschaft (oder eine in ihrem Namen handelnde Person)
direkt oder indirekt Folgendes entweder hält oder kontrolliert:

(a) Mehrheit der auf den Hauptversammlungen der Anteilseigner der Gesellschaft ausübbaren Stimmrechte; oder
(b) Recht zur Ernennung oder Absetzung von Geschäftsführern (oder vergleichbaren Personen), die über eine Mehrheit

der auf den Vorstandssitzungen der Gesellschaft ausübbaren Stimmrechten verfügen,

und jedwede Gesellschaft, die eine Tochtergesellschaft einer sonstigen Gesellschaft ist, ist ebenfalls eine Tochterge-

sellschaft der Holdinggesellschaft dieser Gesellschaft. Soweit der Kontext nicht etwas anderes fordert, gilt die Begriffs-
bestimmung einer Tochtergesellschaft einer jedweden Gesellschaft jederzeit auf diese Gesellschaft, wie sie zu diesem
Zeitpunkt besteht.

Wesentliche Übernahme bezeichnet den Kauf jedwedes unbeweglichen Vermögens mit einem Wert von mehr als EUR

500.000,- bzw. der den Gesamtwert dieser gesamten Käufe des unbeweglichem Vermögens über diesen Betrag bringen

42987

würde (zur Vermeidung von Missverständnissen sind hierin Investitions- und Erlösaufwand im Hinblick auf die Vermö-
genswerte ausgeschlossen.

Mitnahmemitteilung hat die ihr gemäß Artikel 10.1. dieser Satzung zugewiesene Bedeutung.
Mitnahmerecht hat die ihm gemäß Artikel 10.1. dieser Satzung zugewiesene Bedeutung.
Finanzierung Dritter bezeichnet, in Bezug auf die Unternehmensgruppe, jedwede Verschuldung in Form einer Kredit-

aufnahme an eine Person, die kein Mitglied einer Anteilseignergruppe ist, es sei denn, diese Verschuldung bezieht sich auf
eine gegenseitige Einlagevereinbarung.

Übertragung bezeichnet, in Bezug auf jedweden Anteil oder jedwede rechtliche oder wirtschaftliche Beteiligung an

jedwedem Anteil:

(a) diesen zu verkaufen, abzutreten, zu übertragen oder anderweitig hierüber zu verfügen;
(b) jedwede Belastung hierauf zu schaffen oder deren Weiterbestehen zulassen;
(c) anzuweisen (durch Verzicht oder anderweitig), dass ein Dritter diesen erhalten soll oder jedwedes Recht hieran

an diesen Dritten abzutreten;

(d)  jedwede  Vereinbarung  im  Hinblick  auf  die  Stimm-  oder  jedwede  sonstigen  diesem  Anteil  anhaftenden  Rechte

abzuschließen; oder

(e) sich zu verpflichten, unabhängig davon, ob vorbehaltlich einer jedweden aufschiebenden oder auflösenden Bedin-

gung, keine der vorstehenden Handlungen vorzunehmen;

und Übertragen ist entsprechend auszulegen.
Bewerter hat die ihm gemäß Artikel 8.6 dieser Satzung zugewiesene Bedeutung.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

<i>Kosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten

fallen oder sonst aufgrund dieser Urkunde von ihr getragen werden, wird auf dreitausendfünfhundert Euro (EUR 3.500,-)
geschätzt.

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten

ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der
deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese Komparenten mit dem Notar

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Castex, T. Sarpcan, A. Loubet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, vol. 32CS, fol. 2, case 10. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

Luxemburg, den 12. März 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007041249/220/1089.
(070038394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 45.727.

Monsieur Glenn Wellman avec adresse professionnelle à Beaufort House, St. Botolph Street, 15, EC3A7JJ, London,

Grande-Bretagne et Monsieur Mario Seris avec adresse professionnelle à Giesshübelstrasse, 30, CH-8070 Zürich, Suisse,
ont démissionné comme Membre du Conseil d'Administration de la société CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
HOLDING EUROPE (LUXEMBOURG) S.A. avec effet au 31 décembre 2006.

Monsieur Karl Huwyler avec adresse professionnelle à Giesshübelstrasse, 30, CH-8070 Zürich, Suisse, a démissionné

de la société avec effet au 14 novembre 2006.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 10 janvier 2007, Monsieur Mark Burgess, avec adresse

professionnelle à Londres, One Cabot Square, London E14 4QJ, Grande-Bretagne et Monsieur Hans-Ulrich Hügli avec
adresse professionnelle à 56, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, ont été nommés comme nouveau Membre du Conseil
d'Administration, et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 5 mars 2007.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 janvier 2007, Monsieur Gerhard Lohmann avec adresse profes-

sionnelle à Giesshübelstrasse, 30, CH-8070 Zürich, Suisse, a été nommé comme Membre du Conseil d'Administration.

42988

Par conséquent, le conseil d'administration se compose comme suit:
Lawrence Haber, Londres
Raymond Melchers, Luxembourg
Mark Burgess, Londres
Hans-Ulrich Hügli, Luxembourg
Gerhard Lohmann, Zurich
Bernard Wester, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2007.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller/D. Breger

Référence de publication: 2007040873/736/32.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC02948. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

La Concorde, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 54.078.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 6 mars 2007 que:
- La démission de Messieurs David De Marco, Bruno Beernaerts et Alain Lam en qualité d'administrateur a été acceptée.

- Ont été nommés administrateurs avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2007:

- Monsieur Giovanni Vittore, né le 29 mai 1955 à Turi, Italie, demeurant professionnellement au 4, rue de l'Eau, L-1449

Luxembourg.

- Monsieur Rémy Meneguz, né le 22 mai 1950 à Tressange, France, demeurant professionnellement au 4, rue de l'Eau,

L-1449 Luxembourg.

- Monsieur Cyril Lamorlette, né le 1 

er

 septembre 1974 à Metz, France, demeurant professionnellement au 65, rue

des Romains, L-8041 Strassen.

- Monsieur Pierre François Wery, né le 30 octobre 1965 à Liège, Belgique, demeurant professionnellement au 65, rue

des Romains, L-8041 Strassen.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007040876/799/25.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02852. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

KBC Renta, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 23.669.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 8 décembre 2006

- La démission de Monsieur Guido Segers est acceptée.
- La réélection du Réviseur d'Entreprises ERNST &amp; YOUNG pour un nouveau terme de 1 an, jusqu'à l'Assemblée

Générale Statutaire de 2007 est acceptée.

42989

Certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC RENTA
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007040922/526/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02614. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Association des Patrons Menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg F 4.682.

STATUTS

Titre I 

er

 - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  L'association est dénommée ASSOCIATION DES PATRONS MENUISIERS DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG a.s.b.l.

Art. 2. Son siège social est établi à Luxembourg-Kirchberg, 2 Circuit de la Foire Internationale. Il peut être transféré

par décision du comité dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. L'association a pour objet
- de servir de lien permanent entre ses membres et de développer l'esprit de l'honneur professionnel ainsi que de

promouvoir la solidarité entre les ressortissants de la même profession ou de professions apparentées, connexes ou
similaires;

- de conseiller ses membres et de défendre sur le plan national ou international par tous les moyens jugés adéquats

les intérêts communs professionnels, économiques et sociaux de ses membres et des métiers dont ils ressortent.

A cet effet, elle peut étudier tout sujet et tout problème relatif à la profession et aux entreprises du secteur qu'elle

représente et elle prendra toute initiative qu'elle jugera nécessaire au développement et à la promotion des métiers.

Dans l'accomplissement de sa mission elle agira en étroite collaboration avec la Fédération des Artisans et lui soumettra

toute proposition utile contribuant à l'amélioration de la situation de ses membres ou à celle de l'artisanat.

L'association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle est neutre du point de vue politique et confessionnel.
Elle s'abstiendra de toute activité contraire à l'intérêt général de l'artisanat et des autres fédérations du secteur artisanal.

Art. 4. La durée de l'association est illimitée

Titre II - Admission

Art. 5. L'association comprend:
a) des membres effectifs,
b) des membres adhérents,
c) des membres pensionnés ou retirés d'affaire,
d) des membres d'honneur.
Le nombre des membres est illimité. Celui des membres effectifs ne pourra être inférieur à trois.

Art. 6. Peut devenir membre effectif la personne ou entreprise qui est légalement établie sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg dans le métier de menuisier et inscrite au rôle artisanal de la Chambre des Métiers.

Les succursales n'ayant pas de statut juridique distinct de l'entreprise principale ne sont pas considérées comme mem-

bre effectif.

Art. 7. Peut être admise comme membre adhérent, la personne ou le représentant de l'entreprise qui est inscrite au

rôle artisanal de la Chambre des Métiers sans cependant être légalement établie sur le territoire même du Grand-Duché
de Luxembourg.

Art. 8. Peuvent être admises comme membres pensionnés, les personnes qui ont cessé l'activité professionnelle in-

dépendante pour raison d'âge ou d'invalidité et qui ne sont plus inscrites au rôle artisanal.

Art. 9. Peut être admise comme membre d'honneur, toute personne physique ou morale admise par le comité en

raison de son soutien à la profession.

Seuls les membres effectifs ont le droit de vote et sont éligibles au comité en raison d'une personne par entreprise

affiliée.

42990

Art. 10. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote aux assemblées générales.
Pour être éligible au comité, le candidat doit être détenteur du diplôme de brevet de maîtrise luxembourgeois dans

le métier de menuisier (408-00) ou d'un diplôme équivalent, reconnu par le Ministère des Classes Moyennes et être en
mesure de faire preuve d'un engagement sensible dans le capital de l'entreprise qu'il représente.

Un membre pensionné pourra cependant terminer son mandat. Aucun membre du comité ne pourra dépasser l'âge

de 72 ans.

Art. 11. L'admission ou, le cas échéant, le refus d'admission des membres est décidée souverainement par le comité.

Sa décision doit cependant être motivée.

Titre III - Démission, Exclusion, Suspension

Art. 12. Les membres effectifs, adhérents, pensionnés et d'honneur sont libres de se retirer à tout moment de l'asso-

ciation en adressant par écrit leur démission au comité.

Est réputé d'office démissionnaire, le membre qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe, dans les deux mois du rappel

qui lui a été adressé par simple lettre à la poste.

Art. 13. Le comité peut suspendre, jusqu'à décision de la prochaine assemblée générale, tous les membres de l'asso-

ciation ou du comité qui se seraient rendus coupables d'une infraction grave aux statuts, aux règlements intérieurs ou
aux décisions des organes de l'association, mettant par là en cause, l'existence et la bonne renommée de celle-ci.

L'exclusion d'un membre effectif ou adhérent ne peut être prononcée pour les mêmes raisons définies ci-avant que

par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix présentes.

Art. 14. L'associé démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit du membre décédé n'ont

aucun droit sur l'avoir social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de
scellés, ni inventaire. Les cotisations versées restent acquises à l'association.

Titre IV - Cotisations

Art. 15. Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé par le comité. Les cotisations sont payables dans

le mois qui suit l'appel de cotisation pour l'année en cours. Les cotisations des membres effectifs ne peuvent dépasser le
montant de 495,79 EUR (indice 100 du coût de la vie).

Titre V - Assemblée générale

Art. 16. L'assemblée générale est composée de tous les membres effectifs.
Les membres pensionnés et les membres adhérents peuvent assister à l'assemblée générale sans que pour autant qu'ils

aient le droit de vote.

L'assemblée générale est présidée par le président du comité, ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ou, à

défaut, par le secrétaire général.

Art. 17. L'assemblée générale est le pouvoir souverain de l'association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expres-

sément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:
- les modifications aux statuts sociaux;
- la nomination et la révocation des membres du comité;
- l'approbation des budgets et des comptes;
- la dissolution volontaire de l'association;
- les exclusions d'associés.

Art. 18. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée toutes les fois que les intérêts de l'association l'exigent,

par décision du comité. Elle doit l'être à la demande d'un cinquième des membres effectifs au moins.

Art. 19. L'assemblée générale est convoquée par le comité par simple information écrite adressée à tous les membres

effectifs, adhérents et pensionnés au moins huit jours avant l'assemblée.

L'ordre du jour est mentionné dans la convocation.
L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf disposition contraire prévue par la loi ou les statuts.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l'ordre du jour.

Art. 20. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal, chacun disposant d'une voix.
Chaque membre effectif a le droit de se faire représenter par un membre effectif moyennant procuration écrite. Chaque

membre effectif ne peut être titulaire que d'une procuration qui est à remettre au président avant l'ouverture de l'as-
semblée.

42991

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où il en est décidé

autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix, un deuxième vote devient nécessaire. Lors d'un
deuxième partage des voix, la résolution, est considérée comme rejetée.

Art. 21. Le vote se fait à main levée à moins que le scrutin secret soit proposé par le comité ou demandé par un

cinquième au moins des membres présents.

Art. 22. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'association ou la modification des

statuts que conformément aux stipulations y relatives de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Titre VI - Administration

Art. 23. L'association est administrée par un conseil d'administration également dénommé comité et composé de cinq

membres au moins et de onze au plus, nommés parmi les membres effectifs détenteurs d'un brevet de maîtrise luxem-
bourgeois ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Ministère des Classes Moyennes dans le métier de menuisier (408-00)
présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et élus par l'assemblée générale pour un terme de deux ans.
Les candidatures pour un poste au sein du comité sont à adresser par écrit au moins sept jours ouvrables avant la date
de l'assemblée au secrétariat de l'association.

Le comité est renouvelé tous les ans par moitié. Les membres sortants sont rééligibles, sans demande écrite prévue

au paragraphe (1) du présent article.

La première série des membres sortants est tirée au sort.

Art. 24. En cas de vacance au cours d'un mandat, un membre de comité provisoire peut être nommé par l'assemblée

générale. Il achève dans ce cas le mandat de celui qu'il remplace.

Le comité désigne parmi ses membres, le président de l'association, le vice-président, le secrétaire général et le tré-

sorier pour la durée de leur mandat.

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou, à défaut, par le secrétaire

général ou encore par le trésorier de l'association.

Art. 25. Le comité se réunit sur convocation du président. Il ne peut statuer que si la majorité des membres est

présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix; une majorité des voix étant toujours requise pour qu'un projet
soit accepté. Les décisions sont consignées par le secrétariat sous forme de procès-verbaux, conservés au secrétariat où
chaque membre pourra en prendre connaissance.

Le vote se fait à main levée ou par scrutin secret à la demande d'un seul membre du comité au moins.

Art. 26. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association.
Il est notamment habilité à établir un règlement d'ordre intérieur qui complétera, si nécessaire, les présents statuts

pour assurer le bon déroulement de l'activité de l'association. Il désigne les délégués représentant l'association dans le
cadre de l'assemblée des délégués et de l'assemblée générale de la FEDERATION DES ARTISANS.

Art. 27. Tout membre du comité qui aura été absent au comité sans motif valable à trois séances au cours d'un exercice

sera considéré comme démissionnaire de son poste au comité.

Titre VII- Surveillance

Art. 28. Chaque année, l'assemblée générale désigne une commission d'au moins deux membres ne faisant pas partie

du comité, à l'effet de vérifier à la fin de l'exercice les écritures, les recettes et les dépenses et la consistance du capital.
Cette commission soumettra son rapport à l'assemblée générale qui est appelée à délibérer sur le décompte de l'exercice
écoulé.

Titre VIII - Les rapports avec la Fédération des Artisans

Art. 29. L'ASSOCIATION DES PATRONS MENUISIERS ainsi que ses membres sont affiliés à la FEDERATION DES

ARTISANS a.s.b.l., organisation centrale des fédérations relevant directement ou indirectement du secteur artisanal et
représentant effectif de l'artisanat.

Par son adhésion à la Fédération des Artisans, l'association et ses membres reconnaissent se soumettre aux statuts

actuels et futurs de la première nommée.

Art. 30. Sont notamment prévus par les statuts de la FEDERATION DES ARTISANS:
- les droits et les devoirs des membres;
- la représentation de l'association dans l'assemblée des délégués et dans l'assemblée générale de la FEDERATION

DES ARTISANS;

- les cotisations à verser par les fédérations affiliées.

Art. 31. Les travaux administratifs journaliers sont confiés au secrétariat de la FEDERATION DES ARTISANS qui

mettra à la disposition de l'association un secrétaire employé par elle.

42992

Le  secrétaire  assiste  aux  réunions  du  comité  et  aux  assemblées  et  en  dressera  rapport.  Il  est  habilité  à  signer  la

correspondance de l'association ensemble avec le président ou avec un membre du comité spécialement délégué à cette
fin.

Art. 32. Le secrétaire général de la FEDERATION DES ARTISANS ou en cas d'empêchement son représentant peut

participer à toutes les réunions de l'association. Celui-ci ainsi que le secrétaire délégué par le secrétariat de la Fédération
des Artisans ont voix consultative dans les réunions.

Art. 33. Le service de la comptabilité de la FEDERATION DES ARTISANS est chargé de l'exécution de toutes les

opérations financières de l'association en liaison avec le président et le trésorier.

La comptabilité de l'association est tenue par le service de la comptabilité de la FEDERATION DES ARTISANS.
La surveillance de ces opérations sera exercée par la commission de surveillance visée à l'article 28 des présents statuts

ainsi que par la commission de surveillance de la FEDERATION DES ARTISANS.

Art. 34. Des délégués de la FEDERATION DES ARTISANS spécialement mandatés peuvent assister aux assemblées

de l'association. Ils peuvent y prendre la parole.

En cas d'urgence ou de nécessité impérieuse à motiver dans la convocation, le comité de la FEDERATION DES AR-

TISANS peut convoquer une assemblée générale de l'association.

Titre IX - Modification des statuts, dissolution, liquidation

Art. 35. Il sera procédé aux modifications des statuts et à la dissolution de l'association conformément aux dispositions

de la loi du 21 avril 1928. En cas de dissolution de l'association, le capital social restera à la disposition de la FEDERATION
DES ARTISANS en vue de créer une nouvelle association ou de l'affecter, après un délai de 10 ans, à une œuvre sociale
au bénéfice de l'artisanat luxembourgeois.

Signatures.

Référence de publication: 2007041170/1975/174.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03748. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Picoty Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 88.386.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 9 mars 2007 que:
Les administrateurs suivants ont été réélus pour un an, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2008.
- Monsieur Giovanni Vittore, né le 29 mai 1955 à Turi, Italie, demeurant professionnellement au 4, rue de l'Eau, L-1449

Luxembourg.

- Monsieur Rémy Meneguz, né le 22 mai 1950 à Tressange, France, demeurant professionnellement au 4, rue de l'Eau,

L-1449 Luxembourg.

- Monsieur Cyril Lamorlette, né le 1 

er

 septembre 1974 à Metz, France, demeurant professionnellement au 65, rue

des Romains, L-8041 Strassen.

- Monsieur Pierre François Wery, né le 30 octobre 1965 à Liège, Belgique, demeurant professionnellement au 65, rue

des Romains, L-8041 Strassen.

- Monsieur Christian Ridoire, né le 17 septembre 1931 à Le Blanc-Indre, France, demeurant à 23, rue de la République,

F-23300, La Souterraine, France.

Est réélu Commissaire pour la même période:
- Monsieur Olivier Dorier, demeurant professionnellement au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007040878/799/27.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02845. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

42993

IBI Fund Advisory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 65.741.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 Décembre 2006

Il est décidé:
- de réélire Messieurs Roland Hess, résidant professionnellement 50, Talacker CH-8022 Zurich, André Schmit résidant

professionnellement 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, et Peter Rückstuhl, résidant professionnellement 50, Ta-
lacker Postfach, CH-8022 Zurich en tant qu'Administrateur pour un nouveau terme d'un an, expirant à l'Assemblée
Générale Statutaire de 2007.

- de réélire ERNST &amp; YOUNG, LUXEMBOURG, en tant que Commissaire aux Comptes pour un nouveau terme d'un

an, expirant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour IBI FUND ADVISORY S.A.
KREDIETRUST LUXEMURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007040926/526/21.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02609. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Angerbach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 112.531.

In the year two thousand and seven, on the thirteenth day of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of ANGERBACH S.à.r.l., a «société à responsabilité limitée»,

having its registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, incorporated by deed enacted on the December 5,
2005, registered at the Luxembourg trade register section B number 112.531, published in the Luxembourg Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 464 dated March 3, 2006. The articles of incorporation have been amended
for the last time, by virtue of a notarial deed enacted in front of the undersigned notary, Maître Jean-Joseph Wagner,
residing in Sanem, on the December 29, 2005, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations number 912 dated May 10, 2006

The meeting is presided by Flora Gibert, private employee residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Sonia Almeida residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list.

That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 18.260 (eighteen thousand two hundred and sixty) shares of EUR 125.-

(one hundred and twenty-five euros) each representing the whole capital of the company, are represented so that the
meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items on the agenda of which the partners
have been informed beforehand.

III.- That the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Amendment and redrafting of Article ten of the Articles of Incorporation
2. Miscellaneous
After the foregoing was approved by the meeting, the sole partner unanimously decides what follows:

<i>First resolution

The meeting resolves to amend and redraft article ten of the articles of association to read as follows:
« Art. 10. The Shares may only be transferred, as applicable on a valuation day (hereafter referred to as «Valuation

Day» and being, for the purposes of this clause, the last day that banks are open for business in London of each calendar
month), provided that, for the avoidance of doubt, the entering into by the partners of an agreement on a date other
than a Valuation Day providing for such transfer to occur on a Valuation Day shall not be in breach of such restriction

42994

and provided further that (a) such restriction shall not apply where the Company holds less than four real estate assets
directly or indirectly and (b) such restriction shall not apply to any transfer resulting from the enforcement of security
by a creditor of the Company or a creditor of the partner in the Company. The Company shall determine and notify to
the partner of its equity gains (Aktiengewinn) on any Valuation Day.

Only partners that are institutional investors (being investors that are not natural persons) shall be allowed to invest,

hold or be the beneficial owner of a unit in the Company.

Partnerships shall not be allowed to invest, hold or be the beneficial owner of a unit in the Company, unless the

Company confirms in writing that it does not object to such participation of a partnership.

There shall be no more than 30 institutional investors (being investors that are not natural persons) investing, holding

or being the beneficial owner of a unit in the Company at any one time.»

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result

of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendsieben, am dreizehnten Tag des Monats Februar, vor dem unterzeichneten Notar, Maître Joseph

Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, erschienen

Wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter der ANGERBACH S.à r.l., gehalten, eine Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, gegründet gemäß notarieller Urkunde
aufgenommen am 5. Dezember 2005, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer
B 112.531, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 464 vom 3. März 2006. Die
Satzung der Gesellschaft wurde am 29. Dezember 2005 abgeändert, gemäß notarielle Urkunde des Notars Jean-Joseph
Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 912
vom 10. Mai 2006.

Die Versammlung ist geöffnet mit Flora Gibert wohnhaft in Luxemburg im Vorsitz.
Als Sitzungssekretär und als Stimmzähler wird Sonia Almeida wohnhaft in Luxemburg gewählt. Der Vorsitzende ersucht

den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

I.- Der hier vertretene alleinige Gesellschafter sowie die Anzahl der von ihm besitzten Anteile sind in einer Anwesen-

heitsliste  aufgetragen.  Diese  Liste,  sowie  die  Vollmächte,  vom  amtierenden  Notar  und  den  erschienenen  Personen
unterzeichnet bleiben dieser Urkunde zwecks Registrierung beigefügt.

II.- Der Anwesenheitsliste wird entnommen, dass die 18.260 (achtzehntausendzweihundertsechzig) Anteile mit einem

Nominalwert von EUR 125,- (einhundertfünfundzwanzig Euro), die das gesamte Aktienkapital repräsentieren, vollständig
vertreten sind, und somit die außerordentliche Hauptversammlung rechtskräftig über die Tagesordnungspunkte, welche
dem Bevollmächtigten bekannt sind, entscheiden kann.

III.- Tagesordnung:
1. Umänderung von Artikel 10 der Satzung.
2. Verschiedenes

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt Artikel 10 der Satzung umzuändern, um ihn mit folgendem Wortlaut zu ersetzen:
« Art. 10. Die Anteile können nur von den Gesellschaftern an jedem Auswertungsdatum (das «Auswertungsdatum»,

welches zum Zweck dieses Artikels, der letzte Arbeitstag eines jeden Kalendermonats der Londoner Banken bedeutet)
veräußert werden, vorausgesetzt, dass die Abschließung eines solchen Übertragungsvertrages zu einem Datum welcher
nicht dem Auswertungsdatum entspricht, aber an einem Auswertungsdatum in Kraft treten soll nicht als Verletzung dieser
Beschränkung angesehen werden. Weitere Voraussetzungen sind a) solche Beschränkung ist nicht gültig falls die Gesell-
schaft weniger als vier Grundeigentum-Vermögen direkt oder indirekt besitzt und b) solche Beschränkung ist nicht gültig
im Zusammenhang mit einer Anteilübertragung welche durch die Erzwingung einer Sicherheit durch einen Gläubiger der
Gesellschaft oder seines Gesellschafters in Kraft tritt. Die Gesellschaft bestimmt und informiert den Gesellschafter an
jedem Auswertungstag über ihren Aktiengewinn.

42995

Nur Gesellschaftern (Institutionskapitalanleger, welche also keine natürliche Personen sind) ist es erlaubt in die Ge-

sellschaft zu investieren oder einen Anteil der Gesellschaft auf irgendeine Weise zu besitzen.

Teilhaberschaften ist es nicht erlaubt in die Gesellschaft zu investieren oder Anteile der Gesellschaft auf irgendeine

Weise zu besitzen, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft einer solchen Anteilnahme schriftlich zustimmt.

Es sollen zu keiner Zeit mehr als 30 Institutionalkapitalanleger in die Gesellschaft investieren oder Anteile der Gesell-

schaft besitzen.»

<i>Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Satzungs-

änderung entstehen, werden auf 1.200,- EUR geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben

genannten erschienenen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst ist;
auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und des deutschen Textes, wird
die englische Fassung vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: F. Gibert, S. Almeida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, vol. 157S, fol. 96, case 10. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und

Vereinigungen.

Luxemburg, den 9. März 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007041488/211/114.
(070038380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

MHI Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 76.792.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société MHI INVESTMENT S.A. qui s'est exceptionnellement

tenue en date du 31 janvier 2007 au siège social que:

Les mandats de Monsieur Johan Alexander Harder; Monsieur Jens Harder et Madame Margrethe Harder tout les trois

demeurant à 134, Portland Road; W11 4LX Londres en tant qu'administrateurs de la société et que le mandat de FIDU-
CIAIRE  NATIONALE  S.à.r.l.  avec  adresse  professionnelle  à  2,  rue  de  l'Avenir,  L-1147  Luxembourg,  en  tant  que
Commissaire aux Comptes de la société sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2007040930/803/19.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06410. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

M.E.R Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 95.874.

DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh of February.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary public residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr Marts Ramneskog, having its registered office at Tranbogatan 5, SE-212 32 Malmö, (Sweden), here represented by

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., with headoffice in L- Luxembourg, by virtue of a proxy given in
Malmö (Suède), on 14 February, 2007.

42996

The prenamed proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed

to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact the following declarations and

statements:

That the company M.E.R. HOLDING, S.a r.l., with registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, regis-

tered in the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg under the number B 95.874 has been incorporated
according to a deed of the notary Gérard Lecuit, residing in Hesperange, dated August 26th, 2003, which deed has been
published in the Luxembourg official gazette «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» number 1079, dated
October 16th, 2003.

That the issued share capital of the Company is set at fifteen thousand euros (15,000.- EUR), represented by one

hundred (100) shares with a par value of one hundred and fifty euros (150.- EUR) each, fully subscribed and paid-up.

That Mr Marts Romneskog prenamed, is and will continue to be the owner of all the issued parts of the Company.
That in its quality of sole participant of the company, Mr Marts Romneskog hereby expressly states to proceed to the

dissolution and the liquidation of the Company, as per to day.

He declares further on to take over on his own account, all the assets and liabilities whether known or unknown of

the company M.E.R. HOLDING, S.a r.l. and that he will undertake under its own liability any steps which are required to
fulfil said commitments taken by itself in relation with the assets and liabilities of the Company.

That full and entire discharge is granted to the managers of the Company for the execution of their mandates until

the dissolution.

That the books and corporate documents relating to the Company will remain at the registered office, where they

will be kept in custody during a period of five (5) years.

That Mr Marts Romneskog is authorized in the name and on behalf of the sole Partner to file any tax declaration,

notice to the trade register and any other documents necessary or useful for the finalisation of the liquidation.

Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the

present deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

entity, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing entity
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Marts Romneskog, demeurant à Tranbogatan 5, SE-212 32 Malmö (Suède), ici représentée par LUXEM-

BOURG CORPORATION COMPANY S.A., en vertu d'une procuration délivrée le 14 février 2007, à Malmö (Suède).

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui

suit:

Que la société à responsabilité limitée M.E.R. HOLDING S.a r.l., établie et ayant son siège social à L-2346 Luxembourg,

20, rue de la Poste, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 95.874, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange le 26 août 2003, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1079 du 16 octobre 2003.

Que le capital social de la Société s'élève actuellement à quinze mille euros (15.000,- EUR), représenté par cent (100)

parts sociales d'une valeur nominale de cent cinquante euros (150,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.

Que le comparant Monsieur Marts Romneskog, prénommé, est et restera propriétaire de toutes les parts sociales de

ladite Société.

Qu'en tant qu'associé unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la

susdite Société, avec effet à ce jour.

Il déclare en outre prendre à sa propre charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de la société M.E.R. HOLDING,

S.a r.l. et qu'il entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue de l'engagement
qu'il a pris à cet effet.

42997

Que  décharge  pleine  et  entière  est  accordée  aux  gérants  pour  l'exercice  de  leur  mandat  jusqu'au  moment  de  la

dissolution.

Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq (5) années.

Que Monsieur Marts Romneskog est autorisé au nom et pour le compte de l'associée unique de déposer toute dé-

claration fiscale, notification au registre de commerce et tout autre document nécessaire ou utile pour la finalisation de
la liquidation.

Pour les dépôts et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Canova, G. Lecomte, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 mars 2007. REM 2007/430. — Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 12 mars 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007042011/5770/89.
(070039020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2007.

WSL, Waste Solutions Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 108.046.

<i>Auszug des Protokolls der ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten in Münsbach am 31. Januar 2007

<i>«Beschlussfassung

Nach eingehender Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:
Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die alleinige Unterschrift des De-

legierten des Verwaltungrates verpflichtet.»

Münsbach, den 31. Januar 2007.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Schriftführer / Stimmenzähler

Référence de publication: 2007040940/820/18.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05143. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Cypress Semiconductor Corporation (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 102.731.

<i>Extrait des décisions prises lors des résolutions de l'associé unique du 6 mars 2007

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Brad Buss, demeurant professionnellement au 198, Champion Court, San Jose, 95134-1599 Californie,

Etats-Unis;

- Monsieur Christopher Seams, demeurant professionnellement au 198, Champion Court, San Jose, 95134-1599 Ca-

lifornie, Etats-Unis;

- Monsieur Neil Weiss, demeurant professionnellement au 3901, N. First Street, San Jose, 95134-1599 Californie,

Etats-Unis.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

42998

Luxembourg, le 7 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007041070/534/19.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC01907. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Alphalinea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 72.818.

Monsieur Santiago Campos Martines, né le 29 juin 1945 - Espagne
Administrateur de sociétés
Demeurant: E-58 avenido Nostra Senora Del Vinyet, 08870 Sitges - Espagne.
Donne par la présente, à compter du 8 janvier 2007 avec effet immédiat, démission de sa fonction d'Administrateur

de la société anonyme de droit luxembourgeois inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro B 72.818.

Ayant pour dénomination:
ALPHALINEA S.A.
Constituée en date du 23 novembre 1999
(en vertu d'un acte reçu par-devant Maître Doerner, Notaire de résidence à Bettembourg)
Ayant son siège à L-1840 Luxembourg - 11C, bd Joseph II.
Fait et signé à Barcelone / Espagne, en trois exemplaires originaux.

Barcelone, le 8 janvier 2007.

Lu et approuvé
Signature

Référence de publication: 2007041114/4690/24.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2007, réf. LSO-CC03823. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Electromind S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 76.547.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 14 février 2007

Les administrateurs de la société anonyme ELECTROMIND ont pris les résolutions suivantes:
1. Les administrateurs nomment au poste de Président du Conseil d'Administration Monsieur Jean-Claude Bernard,

demeurant à rue de l'Esplanade, 6 à B-6700 Arlon, pour une durée de six ans.

Pour extrait conforme
<i>Pour ELECTROMIND S.A.
VO CONSULTING LUX S.A.
<i>Mandataire
Signature

Référence de publication: 2007041101/1427/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00586. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

42999

Alcyone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.309.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041102/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00518. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Düsseldorf-Airport Hotel Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 119.685.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 46462 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007041917/211/11.
(070039312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2007.

Alex-Ander S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.283.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041104/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00522. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Agemina Gest.Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.650.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

43000

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041105/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00525. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Immobiliare Altop S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 105.644.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041107/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00531. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Hostcare Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 68.101.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041108/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00532. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Interimmo 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.938.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 19 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2007.

43001

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041109/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00539. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Hilton Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.785.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041110/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00534. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

GPL International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 120.914.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 février 2007 que:
- Monsieur Marco Cameroni, employé privé, né le 20 septembre 1963 à Novara (Italie), demeurant professionnellement

à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions de Président du Conseil d'Administration, en
remplacement de Monsieur Andrea Giovanni Carini, Président démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041111/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00536. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Immodream S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.577.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

43002

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041112/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00540. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Elim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.498.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 23 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041117/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00489. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Elecfin S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 61.629.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 23 février 2007 que:
- Monsieur Marco Cameroni, employé privé, né le 20 septembre 1963 à Novara (Italie), demeurant professionnellement

à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions de Président du Conseil d'Administration, en
remplacement de Monsieur Andrea Giovanni Carini, Président démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041118/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00490. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Ecoenergy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 119.289.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 23 février 2007 que:
- Monsieur Marco Cameroni, employé privé, né le 20 septembre 1963 à Novara (Italie), demeurant professionnellement

à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions de Président du Conseil d'Administration, en
remplacement de Monsieur Andrea Giovanni Carini, Président démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

43003

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041120/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00491. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Coastline Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 80.738.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 23 février 2007 que:
- Monsieur Marco Cameroni, employé privé, né le 20 septembre 1963 à Novara (Italie), demeurant professionnellement

à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions de Président du Conseil d'Administration, en
remplacement de Monsieur Andrea Giovanni Carini, Président démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041121/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00495. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

C.M. Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 117.828.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041122/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00503. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Chrystal Blue S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.333.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

43004

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041124/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00505. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Capinvest S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.893.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041125/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00508. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Bronipar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 104.904.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041127/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00511. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Bridle S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.161.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

43005

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041129/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00512. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Avenir Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 105.372.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041132/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00513. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Aurore Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.321.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041133/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00514. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Asor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 92.170.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 février 2007 que:
Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

43006

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041135/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00515. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Asia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.550.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 février 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
Andrea Giovanni Carini, Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041137/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00516. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Arpio- Société Etrangère de Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.758.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 février 2007 que:
- Monsieur Marco Cameroni, employé privé, né le 20 septembre 1963 à Novara (Italie), demeurant professionnellement

à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions de Président du Conseil d'Administration, en
remplacement de Monsieur Andrea Giovanni Carini, Président démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007041139/58/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00529. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Aéroclub de Dudelange, Association sans but lucratif.

Siège social: Dudelange,

R.C.S. Luxembourg F 4.999.

<i>Changement des statuts de l'AEROCLUB DE DUDELANGE

Les paragraphes 4 et 10 seront remplacés par les paragraphes suivants:

<i>-§4-

Les membres d'honneur paient une cotisation annuelle de 6,20 €. Un droit d'inscription unique de 12,39 € est à payer

par chaque membre actif. La cotisation annuelle pour les membres actifs est portée à 31,00 €.

Le Conseil d'Administration se réserve le droit de modifier ces montants si les conditions l'exigent mais le taux maxi-

mum de cotisation ne peut pas dépasser 100,00 €.

43007

Le Conseil d'Administration peut réduire de moitié le montant de la cotisation à payer par les jeunes jusqu'à 15 ans

et les étudiants.

<i>-§10-

L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre. Chaque année, entre le premier janvier et le 31

mars, les associés sont convoqués en Assemblée générale aux fins d'approbation du rapport du Conseil d'Administration,
des comptes de l'exercice écoulé et de l'examen du budget de l'exercice en cours. Le Conseil d'Administration peut en
tout temps convoquer une Assemblée Générale pour lui soumettre des propositions. Sur demande fondée et signée par
un cinquième des membres actifs, il doit convoquer une Assemblée Générale. L'Assemblée Générale prend ses décisions
à la majorité relative. Le vote a lieu au scrutin secret, sauf décision contraire à prendre par l'Assemblée. Les résolutions
de l'Assemblée Générale sont inscrites au registre ad hoc et signés par les membres qui ont rempli les fonctions de
président et secrétaire de l'Assemblée.

Signature.

Référence de publication: 2007041242/7498/28.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2007, réf. LSO-CC04521. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Abelia Concept Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 84.733.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 8 février 2007, reçu par M 

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

U. Tholl
<i>Notaire

Référence de publication: 2007041940/232/11.
(070039130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2007.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka I Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 120.510.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 2 mars 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007041935/239/12.
(070039090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2007.

Delima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 98.331.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 février 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007041933/239/12.
(070039048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

43008


Document Outline

Abelia Concept Group S.A.

Aéroclub de Dudelange

Agemina Gest.Investment S.A.

Alcyone S.A.

Alex-Ander S.A.

Alizées S.àr.l.

Alphalinea S.A.

Angerbach S.à r.l.

Arpio- Société Etrangère de Participation S.A.

Asia S.A.

Asor S.A.

Association des Patrons Menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l.

Aurore Holding S.A.

Avenir Invest S.A.

Bridle S.A.H.

Bronipar S.A.

Café Um Bur S.à r.l.

Capinvest S.A.H.

Centrobank Sicav

Chrystal Blue S.A.

C.M. Invest S.A.

Coastline Investment S.A.

Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A.

Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A.

Cypress Semiconductor Corporation (Luxembourg)

Delima S.A.

Düsseldorf-Airport Hotel Investment S.à r.l.

Ecoenergy S.A.

Elecfin S.A.

Electromind S.A.

Elim S.A.

Furnitures Trading S.A.

GH Retail Portfolio S.à r.l.

GPL International S.A.

Hilton Lux S.A.

Hostcare Investissement S.A.

IBI Fund Advisory S.A.

Immobiliare Altop S.A.

Immodream S.A.

Interimmo 2 S.A.

KBC Renta

Kredietrust Luxembourg S.A.

Kytime Holding S.A.

La Concorde

M.E.R Holding S.à r.l.

MHI Investment S.A.

Picoty Europe S.A.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka I Alpha S.à r.l.

Waste Solutions Luxembourg S.A.

WH Luxembourg Intermediate Holdings S.à r.l.