logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

112273

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2340

15 décembre 2006

S O M M A I R E

ABN  AMRO  Bank  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

HUB Industries S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

112315

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112314

I.C. Interconsult AG, Dudelange . . . . . . . . . . . . . . 

112317

Alchemy Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

112320

Immeurope S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

112317

Araich Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

112297

Immo Real S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

112314

Araich Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

112297

Interlac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112313

Audit & Compliance, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . 

112313

Interligne, S.à r.l., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112312

Auditeurs & Administrateurs Associés  S.A.,  Lu- 

Interligne, S.à r.l., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112315

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112305

IRACO,  Comptoir  d’Importations,  Représenta- 

Aver Associates Luxembourg S.A., Garnich . . . . . 

112314

tions et Agences S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

112306

Bayamo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112305

Irman International Holding S.A., Luxembourg. . 

112297

BNP  Paribas  InstiCash,  Sicav,   Howald-Hespe-

ISDC Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

112305

range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112315

Islali Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

112306

Bulgari (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . 

112277

J.  Hermans  &  Co  (Succursale  de  Luxembourg), 

Bus Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

112317

Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112315

Caesar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

112275

JCBO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112279

Caesar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

112275

JCBO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112307

Carbon Trade & Finance SICAR S.A.,  Senninger- 

JCBO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112307

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112280

Likipi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

112310

Carolis International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

112310

Lubra S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112316

Casa Investments S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . 

112297

Maggi Controls Group S.A., Luxembourg. . . . . . . 

112319

Comparco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

112276

Maramco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112278

CPI Kildare, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

112276

Martur Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

112279

Dialna S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112307

Merlac, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112318

Diaruse Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

112304

Misys   Overseas   Investments,   S.à r.l.,   Luxem- 

Ecotrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112306

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112313

Elna S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112314

Miwwelhaus Koeune S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . 

112308

Eurinox S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112274

Mood Media Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

112309

Flandre Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

112312

Mora S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112318

FS Invest II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

112317

Nexcom International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

112318

FS Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

112318

Nexcom International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

112319

GC International S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . 

112316

Onyx International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

112308

GSCP  2000  Eurovision  Holding,  S.à r.l.,  Luxem- 

Opal Corporation (NFR), S.à r.l., Luxembourg  . . 

112277

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112274

Patri Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

112275

GSMP 2006 Onshore, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

112274

Patri Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

112296

GSMP 3, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

112320

Pelican Holdco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

112320

HCEPP II Luxembourg Master II, S.à r.l., Luxem- 

PHI Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

112306

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112276

Post Office Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112275

Hines Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

112306

Protec International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

112297

Honotimber Company S.A., Steinfort . . . . . . . . . . 

112310

Quadriga  Luxembourg  Historic  Military  Vehicle 

Honotimber Company S.A., Steinfort . . . . . . . . . . 

112316

Collectors, A.s.b.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . 

112311

112274

GSCP 2000 EUROVISION HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.065.700,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 104.805. 

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de GSCP 2000 EUROVISION HOLDING, S.à r.l. en date

du 24 octobre 2006 que le siège social de GSCP 2000 EUROVISION HOLDING, S.à r.l. a été transféré du 31, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, avec effet à partir du 1

er

 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02991. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121844.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

GSMP 2006 ONSHORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 113.776. 

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de GSMP 2006 ONSHORE, S.à r.l. en date du 24 octobre

2006 que le siège social de GSMP 2006 ONSHORE, S.à r.l. a été transféré du 31, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, avec effet à partir du 1

er

 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02989. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121845.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

EURINOX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 33.844. 

Il résulte d’un courrier adressé à la société EURINOX S.A. que la société WOOD, APPLETON OLIVER EXPERTS-

COMPTABLES, S.à r.l., en sa qualité d’agent domiciliataire a dénoncé le siège social avec effet au 31 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121864.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Rapin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112305

Steeg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112308

Real Espana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

112296

Systemat (Luxembourg) S.A., Capellen. . . . . . . . .

112275

Resinex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112296

Tyree Financing S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

112312

SINTRAL,  Société Internationale d’Alimentation

Union Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

112316

S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112319

Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg m.b.H., 

Sloane Gardens, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

112298

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112278

Snowdonia (NFR), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

112276

Vontobel Europe S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . .

112307

Société  d’Investissement  Quincieux,  S.à r.l.,  Lu- 

Whitehall  Street  International  Repia  Fund  2005, 

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112305

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112319

Société  Européenne  de  Boissons  S.A.,   Luxem- 

Wisson Investment Group S.A., Luxembourg  . . .

112316

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112279

Worldwide Mounts, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

112278

Sopaf Asia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

112309

WP IX Luxco III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

112309

Starsun S.A., Troisvierges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112315

Zitol Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

112277

<i>Pour <i>GSCP 2000 EUROVISION HOLDING, S.à r.l.
G. Meijssen
<i>Gérant

<i>Pour <i>GSMP 2006 ONSHORE, S.à r.l.
R. Villalobos
<i>Gérante

Signature
<i>Le domiciliataire

112275

PATRI IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 88.812. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02622, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121400.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

CAESAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.092. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00914, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121537.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

CAESAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.092. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00913, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121538.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

SYSTEMAT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8303 Capellen, 77-79, Parc d’activités de Capellen.

R. C. Luxembourg B 41.226. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02911, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121553.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

POST OFFICE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 68.621. 

Société constituée le 19 février 1999 par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, publié au 

Mémorial C N

°

 353 du 19 mai 1999. 

Messieurs Vincenzo Arno’ et Angelo De Bernardi et Madame Romaine Scheifer-Gillen, administrateurs, ainsi que

Monsieur Adrien Schaus, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société POST OFFICE HOLDING S.A., établi au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, a été dé-

noncé le 6 novembre 2006.

Luxembourg, le 6 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01754. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121576.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le Domiciliataire

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le Domiciliataire

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Signature.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

112276

HCEPP II LUXEMBOURG MASTER II, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 97.609. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 6 novembre 2006.

(121582.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

SNOWDONIA (NFR), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 116.771. 

<i>Extrait de la résolution prise par les gérants de la Société, datée du 21 août 2006

Les gérants de la Société ont décidé en date du 21 août 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet au 21 août 2006.

Les gérants de la Société font remarquer en outre que l’adresse professionnelle du gérant suivant de la Société est

désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 21 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07046. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121590.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

CPI KILDARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 116.774. 

<i>Extrait de la résolution prise par les gérants de la Société, datée du 21 août 2006

Les gérants de la Société ont décidé en date du 21 août 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet au 21 août 2006.

Les gérants de la Société font remarquer en outre que l’adresse professionnelle du gérant suivant de la Société est

désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 21 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07028. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121594.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

COMPARCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.696. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2006

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale Extraordinaire nomme comme administrateur, suite au décès de Mon-

sieur Lucien Vanhay, Monsieur Georges Cyrille Rapaille, administrateur, demeurant 77, avenue Mutsaard, B-1020
Bruxelles.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121634.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

H. Hellinckx
<i>Notaire

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

112277

OPAL CORPORATION (NFR), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 116.772. 

<i>Extrait de la résolution prise par les gérants de la Société, datée du 21 août 2006

Les gérants de la Société ont décidé en date du 21 août 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet au 21 août 2006.

Les gérants de la Société font remarquer en outre que l’adresse professionnelle du gérant suivant de la Société est

désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 21 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07039. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121597.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

BULGARI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.734. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration tenu le 29 mai 2006

<i>Résolution

Le Conseil décide de coopter administrateur M. Marco Sterzi, conseil économique, demeurant à Luxembourg, 18,

avenue de la Porte-Neuve, qui terminera le mandat de M. Greco expirant à l’assemblée Générale qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Cette cooptation prend effet le 10 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121608.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

ZITOL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 98.582. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2006

1. L’assemblée accepte la démission des administrateurs:
- LOUV, S.à r.l. avec siège social à 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, 
- DMC, S.à r.l. avec siège social à 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,
- EFFIGI, S.à r.l. avec siège social à 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
2. L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs, pour une période de 6 ans (jusqu’à l’assemblée générale

de 2012):

- M. Yves Mertz, demeurant professionnellement à 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- Monsieur Patrick Rochas, demeurant professionnellement à 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- Monsieur Maurice Houssa, demeurant professionnellement à 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
3. L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes FIN-CONTROLE S.A. avec siège social au 13,

Beaumont, L-1219 Luxembourg. 

4. L’assemblée nomme nouveau commissaire aux comptes, pour une période de 6 ans (jusqu’à l’assemblée générale

de 2012), la société MAZARS avec siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

5. L’assemblée décide de transférer le siège social de 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg à 10A, rue Henri M.

Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02026. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121751.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
BULGARI (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

ZITOL HOLDING S.A.
Signature

112278

WORLDWIDE MOUNTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 99.977. 

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 24 juillet 2006

Au Conseil d’Administration de WORLDWIDE MOUNTS, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au Carré Bonn, 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg et ce avec effet au 3 juillet 2006.

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01948. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121639.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT KIRCHBERG m.b.H., 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 17.574. 

Gemäß einem Gesellschafterbeschluss vom 30. September 2006 nahm die Gesellschaft die Rücktrittsschreiben von

Frau Evelyn Laqua und von Frau Nicole Strunkheide als Geschäftsführer der Gesellschaft zur Kenntnis und Frau Sandra
Bünting, geschäftsansässig in D-60329 Frankfurt am Main, Taunusanlage 1, und Herrn Dieter Roth, geschäftsansässig in
D-60329 Frankfurt am Main, Taunusanlage 1, wurden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft bes-
tellt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02348. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121644.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

MARAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.289. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 novembre 2006

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Eric Scussel, décidée par le conseil d’administration lors de sa réunion

du 17 juillet 2006, en remplacement de Madame Pascale Mariotti, démissionnaire.

Les mandats de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de

les réélire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02424. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121785.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président; 

Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 
Eric Scussel, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 

Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur. 

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

112279

SOCIETE EUROPEENNE DE BOISSONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 55.649. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 13 juillet 2006 à 15h30

L’assemblée annule la décision prise en date du 1

er

 juillet 2005 de nommer M. Eric Herremans, demeurant profes-

sionnellement au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes de la société. La société
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, assurera la charge de Commissaire
aux Comptes et ce jusqu’à l’Assemblée Générale statutaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04706. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121648.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

JCBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 86.148. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 20 juin 2006 à 15h

L’assemblée ratifie la cooptation de:
- Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires demeurant professionnellement au

3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;

- FMS SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;
- S.G.A. SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
aux postes d’administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires suivant le Conseil d’Administra-

tion du 27 décembre 2005 enregistré à Luxembourg le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05571, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C N

°

 821 du 25 avril 2006.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04693. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121651.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

MARTUR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.516. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juin 2006 a 14.30 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée. 
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de ne pas renouveler les mandats de Madame Denise Vervaet

et Mme Joëlle Lietz et LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC, Administrateurs. Elle décide à l’unanimité de re-
nouveler le mandat de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux Comptes, pour une période qui viendra à échéance à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2006. Elle nomme à l’unanimité.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer à l’unanimité M. Jean Quintus, M. Koen Lozie et COSAFIN S.A.
comme administrateurs pour une période qui viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire approu-
vant les comptes au 31 décembre 2006.

Adresse des Administrateurs:
Jean Quintus, 11, route de Fischbach, L-7391 Blaschette;
Koen Lozie, 18, rue des Sacrifiés, L-8356 Garnich;
COSAFIN S.A., 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02020. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121822.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour copie conforme
Signature / Signature

Pour copie conforme
<i>Administrateur
Signature / Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

112280

CARBON TRADE &amp; FINANCE SICAR S.A., Société d’Investissement en Capital à Risque.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 121.118. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirtieth day of October.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) GAZPROMBANK, THE BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK, a closed joint stock company organ-

ised and existing under the laws of the Russian Federation, having its registered office at 16, building 1, Nametkina Street,
Moscow 117420, Russia,

here represented by Dr. Marcel Bartnik, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Moscow, on 19 October 2006.
2) DRESDNER BANK AG LUXEMBOURG BRANCH, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633

Senningerberg, the Luxembourg Branch of DRESDNER BANK AG, an «Aktiengesellschaft» existing and organised under
the laws of the Federal Republic of Germany, having its registered office at Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am
Main, Germany,

here represented by Dr. Gerd J.H. Otte, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg-Senningerberg, on 12 October 2006.
The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their here above stated capacities, have required the officiating notary to enact the

deed of incorporation of a société anonyme (S.A.) qualifying as a société d’investissement en capital à risque (SICAR)
which they declare organized among themselves and the articles of incorporation of which shall be as follows:

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the

shares of the Company hereafter issued (the «Shares»), a company in the form of a société anonyme (S.A.) with variable
capital qualifying as a société d’investissement en capital à risque (SICAR) under the name of CARBON TRADE &amp; FI-
NANCE SICAR S.A. (the «Company»).

The Company shall be governed by the law of 15 June 2004 concerning the société d’investissement en capital à ris-

que.

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of

Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by a decision of the board of directors of the Company (the «Board of Directors»). Within the same borough,
the registered office may be transferred through simple resolution of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social events have oc-

curred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no
effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
corporation.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the investment of the funds available to it in risk capital within the

widest meaning of Article 1 of the law of 15 June 2004 concerning the société d’investissement en capital à risque.

The Company may also invest the funds available to it in any other assets permitted by law and consistent with its

purpose.

Furthermore, the Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the

fulfilment and development of its purpose to the fullest extent permitted under the law of 15 June 2004 concerning the
société d’investissement en capital à risque.

Art. 5. Determination of the investment objectives and policies. The Board of Directors shall determine the

investment objectives and policies of the Company as well as the course of conduct of the management and the business
affairs of the Company in relation thereto, as set forth in the Memorandum, in compliance with applicable laws and reg-
ulations. 

Art. 6. Share Capital.
(a) The capital of the Company shall be represented by Shares of no par value and shall at any time be equal to the

total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The minimum capital of the Company, which must be
achieved within twelve (12) months after the date on which the Company has been authorized as a société d’investisse-
ment en capital à risque (SICAR) under Luxembourg law, is one million euro (EUR 1,000,000.-).

(b) The share capital of the Company shall be represented by the following two classes (the «Classes») of Shares of

no par value:

(i) «Ordinary Shares» which entitle the holders thereof to specific distributions rights as further described in the

Memorandum; and

(ii) «Preferred Shares» which entitle the holders thereof to specific distribution rights as further described in the

Memorandum and which do not have any voting rights.

112281

Preferred Shares and Ordinary Shares may be issued in each Pool.
The Classes of Shares may, as the Board of Directors shall determine, be of one or more different series, the features,

terms and conditions of which shall be established by the Board of Directors and disclosed in the Memorandum.

The Board of Directors may create additional Classes and/or series of Shares in accordance with the provisions and

subject to the requirements of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

(c) The Company has been incorporated with a subscribed share capital of thirty two thousand euro (EUR 32,000)

divided into thirty-two (32) Ordinary Shares of no par value. Upon incorporation, the Shares were entirely paid-up. 

(d) The Board of Directors is authorized to issue, in accordance with Article 9 hereof and the provisions of the Mem-

orandum, an unlimited number of Shares within existing Classes/series of Shares or new Classes/series of Shares to be
created provided that the existing Shareholders have a preferential right to subscribe for the Shares to be issued.

Art. 7. Shares.
(a) Shares are exclusively restricted to Eligible Investors within the meaning of article 2 of the law of 15 June 2004

concerning the société d’investissement en capital à risque.

(b) All Shares shall be issued in registered form.
The inscription of the Shareholder’s name in the register of registered Shares evidences his right of ownership of such

registered Shares. Share certificates in registered form may be issued at the discretion of the Board of Directors.

All issued Shares of the Company shall be registered in the register of shareholders (the «Register»), which shall be

kept by the Company or by a person designated therefore by the Company. The Register shall contain the name of each
Shareholder, his residence, registered office or elected domicile, the number and Class of Shares held by him, the
amount paid in on each such Share and banking references. Until notices to the contrary shall have been received by
the Company, it may treat the information contained in the Register as accurate and up to date and may in particular
use the inscribed addresses for the sending of notices and announcements and the inscribed banking references for the
making of any payments.

(c) Transfers of Shares shall be effected by inscription of the transfer to be made in the Register upon delivery to the

Company of the transfer form along with other instruments of transfer satisfactory to the Company and if Share certif-
icates have been issued, the relevant Share certificates.

(d) Each Share grants the right to one vote at every meeting of Shareholders and at separate Class meetings of the

holders of Shares of each of the Classes issued.

(e) The Company recognizes only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the

ownership of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one single attorney
to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights
attached to such Share(s).

Art. 8. Transfer of Shares. Any transfer or assignment of Preferred Shares is subject to the purchaser or assignee

thereof fully and completely assuming in writing prior to the transfer or assignment, all outstanding obligations of the
seller under the subscription agreement entered into by the seller.

Except for transfers by a Shareholder to an entity which is controlled by or which controls the transferring Share-

holder, any transfer of Preferred Shares by their holder to another person, whether already a holder or not is subject
to prior approval from the Board of Directors which may not be unreasonably withheld.

The Company will not give effect to any transfer of Shares to any investor who may not be considered as an Eligible

Investor within the meaning of article 2 of the law of 15 June 2004 concerning the société d’investissement en capital à
risque.

The existing Shareholders have a preferential right to acquire the Shares to be sold by other existing Shareholders.
In the event that one or more Shareholders intend to transfer all or part of their Shares, such Shareholders shall not

effect such Transfer unless they have obtained from the candidate-transferee the right for the other Shareholders to
transfer all their Shares to that person.

Art. 9. Issue of Shares. Existing Shareholders and potential Shareholders shall be proposed to subscribe to Shares

on one or more dates or periods as determined by the Board of Directors (each a «Closing») and which shall be indi-
cated and more fully described in the Memorandum.

Payments for subscriptions to Shares shall be made in whole or in part on a Closing or on any other date as deter-

mined by the Board of Directors and as indicated and more fully described in the Memorandum. The modes of payment
in relation to such subscriptions shall be determined by the Board of Directors and precised and more fully described
in the Memorandum.

The Board of Directors may determine any other subscription conditions such as minimum subscription on Closings,

default interests or restrictions on ownership. Such other conditions shall be disclosed and more fully described in the
Memorandum.

Shareholders shall have, in proportion to their shareholding a preferential right to subscribe for new Shares to be

issued provided that the Board of Directors may always decide to issue Shares without preferential right and reserve
the right to subscribe for a determined issued of Shares to specified Shareholders or third parties.

The Board of Directors may delegate to any duly authorised person the power to accept subscriptions, to receive

payment of the price of the new Shares to be issued and to deliver them.

Art. 10. Redemption of Shares. The Company is a closed-ended company and thus unilateral redemption re-

quests by the Shareholders may be refused by the Company.

Subject to the approval of the majority of Shareholders of any Class of Shares within the relevant Pool, Shares of any

Pool may be redeemed upon proposition of the Board of Directors, on a pro rata basis from all existing Shareholders
according to the terms and conditions provided for in the Memorandum.

112282

In addition thereto, the Shares may be redeemed compulsorily if a Shareholder ceases to be or is found not to be an

Eligible Investor within the meaning of the law of 15 June 2004 concerning the société d’investissement en capital à ris-
que. Such compulsory redemption shall be made under the conditions set forth in the Memorandum.

The Company shall have the right to satisfy payment of the redemption price to any Shareholder who agrees in specie

by allocating to the Shareholder investments from the portfolio of assets of the Company equal to the value of the
Shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and
reasonable basis and without prejudicing the interests of the other Shareholders of the Company and the valuation used
shall be confirmed by a special report of the auditor of the Company. The costs of any such transfers shall be borne by
the transferee.

Art. 11. Determination of the Net Asset Value. 

(A) - General
The net asset value of each Class (the «Net Asset Value»), will be determined by the corporate agent under the re-

sponsibility of the Board of Directors in the Company’s reference currency (as determined in the Memorandum) on
each Valuation Day as further defined in the Memorandum.

In determining the Net Asset Value per Share, income and expenditure are treated as accruing daily.
The Valuation of the Company’s assets and liabilities shall be determined in accordance with generally accepted val-

uation principles in compliance with article 5(3) of the law dated 15 June 2004 concerning the société d’investissement
en capital à risque:

(i) Liquid assets shall be valued at their nominal value with interest accrued;
(ii) Investments in Investment Structures shall be valued on the basis of their latest available net asset value adjusted

notably for net capital activity and for any material events or developments affecting either Underlying Investments or
the Investment Structures themselves; and

(iii) Other investments and other property and assets of the Company shall be valued according to the valuation prin-

ciples as set forth by the European Venture Capital Association.

Other fair valuation methods may be used if the Board of Directors considers that another method better reflects

the value of the assets if circumstances and market conditions so warrant and provided that such other methods aim at
the valuation of the assets on the basis of the reasonably and foreseeable sales price determined prudently and in good
faith.

(B) - Allocations of the assets of the Company
Specific Pools shall be established as follows in relation to each Investment Program in the accounts of the Company:
a) the proceeds to be received from the issue of Shares of different Classes of Shares (as allocated to a Investment

Program) shall be applied in the books of the Company to the Pool established for such Investment Program and, as the
case may be, the assets and liabilities and income and expenditure attributable to such Pool shall be applied to the cor-
responding Pool subject to the following provisions of this Article;

b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company

to the same Pool as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant Pool;

c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Pool or to any action taken in con-

nection with an asset of a particular Pool, such liability shall be allocated to the relevant Pool, provided that all liabilities
whatever pool are attributable to, will be binding upon the Company as a whole vis-à-vis third party;

d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular

Pool, such asset or liability shall be allocated to all the Pools pro rata to the net asset values of the relevant Pools.

Assets and liabilities not yet allocated to a Investment Program shall be accounted for separately.

(C) - Pool Net Asset Value and Net Asset Value per share
The Company will compute the Net Asset Value per Class within each Pool as follows: each Class participates in the

Pool according to the portfolio and distribution entitlements attributable to each such Class within the relevant Pool.
The value of the total portfolio and distribution entitlements attributed to a particular Class within a Pool on a given
Valuation Day adjusted with the liabilities relating to that Class on that Valuation Day represents the total Net Asset
Value attributable to that Class on that Valuation Day.

The Net Asset Value per Share of a Class within a Pool on a Valuation Day equals the total Net Asset Value of that

Class on that Valuation Day divided by the total number of Shares of that Class then outstanding in that Pool on that
Valuation Day.

The Net Asset Value per each Class as of any Valuation Day shall be made available to the Shareholders at the reg-

istered office of the Company within a period of time following the relevant Valuation Day as disclosed in the Memo-
randum.

Art. 12. Suspension of the Determination of the Net Asset Value. The Board of Directors may suspend the

determination of the Net Asset Value:

a) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Board of Directors

as a result of which disposals or valuation of assets owned by the Company would be impracticable; 

b) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any

of the investments of the Company attributable to any Pool or the current price or value on any stock exchange or
other market price in respect of the assets attributable to any Pool;

c) if restrictions on foreign exchange or with regard to capital transactions prevent the settlement of transactions on

behalf of a Pool within the Company;

112283

d) when for any other reason the prices of any investments owned by a Pool within the Company cannot promptly

or accurately be ascertained;

Any request for subscription shall be irrevocable except in the event of a suspension of the determination of the Net

Asset Value per Share.

Art. 13. Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of nine members, who need

not to be Shareholders of the Company.

They shall be elected for a term not exceeding six years. The Directors shall be elected by the Shareholders at a

general meeting of Shareholders; the latter shall further determine the number of Directors, their remuneration and
the term of their office.

Any Director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general

meeting.

In the event of a vacancy in the office of Director, the remaining Directors may temporarily fill such vacancy (co-

optation); the Shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.

Art. 14. Board Meetings. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman. It may choose

a secretary, who need not be a Director, who shall write and keep the minutes of the meetings of the Board of Directors
and of the Shareholders. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or any two Directors, at the place
indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at the meetings of the Directors and of the Shareholders. In his absence, the Shareholders

or the board members shall decide by a majority vote that another Director, or in case of a Shareholders’ meeting, that
any other person shall be in the chair of such meetings.

The Board of Directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as

well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such
appointments may be cancelled at any time by the Board of Directors. The officers need not be Directors or Sharehold-
ers of the Company. Unless otherwise stipulated by the present articles of incorporation, the officers shall have the
rights and duties conferred upon them by the Board of Directors.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least five Business Days

prior to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circum-
stances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex,
telefax, electronic mails or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings
held at times and places fixed in a resolution adopted by the Board of Directors.

Any Director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or telefax, electronic mails or any

other similar means of communication another Director as his proxy. A Director may represent several of his col-
leagues.

Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of commu-

nications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting. 

The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. The Directors may not bind the

Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the Directors, or any other number

of Directors that the Board of Directors may determine, are present or represented. If such quorum is not reached, a
new meeting shall be called, which shall be able to decide irrespective of the number of Directors present or represent-
ed.

Resolutions of the Board of Directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or by any

two Directors. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly
signed by the chairman of the meeting or any two Directors.

Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented at such meeting.
Without prejudice to mandatory provisions of Luxembourg law, the following list of decisions will require the ap-

proval by at least 6 directors:

- Unless authorized in the Company’s approved business plan and not provided by existing shareholders of the Com-

pany, new loans (including the extension of existing loans) and bank overdrafts, the issue of bonds or other debt instru-
ments over EUR 10 million, and the granting of security interests over assets other than budgeted in the approved
business plan;

- Enter into, amend or terminate any joint venture, partnership, profit sharing or any similar agreement or arrange-

ment;

- Determine and propose the annual statements to the General Meeting;
- Unless authorized in the Company’s approved business plan incurrence of a capital expenditure over EUR 10 million;
- Give any guarantee to secure any liability;
- Sale, transfer or acquisition of enterprises, companies, businesses and participations except within the framework

of the normal course of business; 

- Adoption and/or implementation of the Rules of Internal Procedure;
- Change in accounting rules and methods;
- Appointment of new directors to the extent that the Board of Directors is empowered to do so (co-optation);
- Recruitment of key people with yearly salary above 50,000.- EUR (total cost to the Company);
- Nomination and remuneration of the chairman of the Board of Directors, and remuneration of the managing direc-

tors/daily managers of the Company;

- Entering into an agreement with any of the Shareholders,

112284

- Setting-up of the annual accounts
Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the

Directors’ meetings; each Director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax, electronic mails
or any other similar means of communication.

Art. 15. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts of administration and disposition within the purpose of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of incorporation to the general meeting of Share-

holders are in the competence of the Board of Directors.

Art. 16. Signatory Authority. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any

two Directors acting pursuant to a decision of the Board of Directors or by the joint or single signature(s) of any other
person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 17. Investment Manager. The Company may enter into a management services agreement (the «Manage-

ment Services Agreement») with an investment manager, which shall notably supply the Company with recommenda-
tions and advice with respect to the Company’s investment objective and strategy as described in the Memorandum.

Art. 18. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is
interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm.

Any Director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.

In the event that any Director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest

opposite to the interests of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such
opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or
officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of Shareholders.

The term «opposite interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without

interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be
determined by the Board of Directors in its discretion.

Art. 19. Indemnification of Directors. The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, exec-

utors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding
to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its
request, of any other company of which the Company is a Shareholder or a creditor and from which he is not entitled
to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 20. Depositary. The Company will enter into a depositary agreement with a Luxembourg bank (the «Depos-

itary») which meets the requirements of the law of 15 June 2004 concerning the société d’investissement en capital à
risque.

In compliance with usual bank practices, the Depositary may under its responsibility and in good faith, entrust part

or all of the assets that are placed under its custody to other banking institutions or financial intermediaries.

The Company’s securities, cash and other permitted assets will be held in custody by or in the name of the depositary,

which will fulfil the obligations and duties provided for by the law of 15 June 2004 concerning the société d’investisse-
ment en capital à risque.

If the Depositary desires to withdraw, the Company shall use its best efforts to find a successor Depositary within

two months of the effectiveness of such withdrawal. Until the Depositary is replaced, which must happen within such
period of two months, the Depositary shall take all necessary steps for the good preservation of the interests of the
Shareholders of the Company.

The Company may terminate the appointment of the Depositary but shall not remove the Depositary unless and until

a successor depositary shall have been appointed to act in the place thereof.

The duties of the Depositary shall respectively cease:
a) in the case of voluntary withdrawal of the Depositary or of its removal by the Company; until it is replaced, which

must happen within two months, the Depositary shall take all necessary steps for the good preservation of the interests
of the Shareholders of the Company;

b) where the Depositary or the Company have been declared bankrupt, have entered into a composition with cred-

itors, have obtained a suspension of payment, have been put under court controlled management or have been the sub-
ject of a similar proceedings or have been put into liquidation;

c) where the Luxembourg Supervisory Authority withdraws its authorization of the Company or the Depositary.

Art. 21. Corporate Agent. The Company may appoint a corporate agent (the «Corporate Agent») responsible

for all administrative duties required by Luxembourg law, and in particular for the book-keeping and calculation of the
Net Asset Value of the Shares, for all and any secretarial and administrative tasks, for handling the processing of sub-
scription for - and redemption of - Shares, and accepting transfers of funds, for the safe keeping of the register of Share-
holders and the corporate documents of the Company, providing the administrative support for the meetings of the

112285

Board of Directors, providing and supervising the mailing of statements, reports, notices and other documents to the
Shareholders. The Corporate Agent will further be responsible for controlling that Shareholders are Eligible Investors
within the meaning of article 2 of the law dated 15 June 2004 concerning the société d’investissement en capital à risque.

Art. 22. General Meeting of Shareholders. The general meeting of Shareholders shall represent all the Share-

holders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the Shareholders of the Company. It shall have the
broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

General meetings of Shareholders shall be convened by the Board of Directors.
It may also be called upon the request of Shareholders representing at least one fifth of the share capital.
The annual general meeting shall be held on the second Thursday of the month of May at 11:00 at the registered office

or at a place specified in the notice of meeting. If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held
on the next following Business Day.

Other meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices

of meeting.

General meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by regis-

tered letter at least eight (8) Business days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder’s address re-
corded in the register of registered shares. The giving of such notice to registered Shareholders need not be justified
to the meeting. The agenda shall be prepared by the Board of Directors except in the instance where the meeting is
called on the written demand of the Shareholders in which instance the Board of Directors may prepare a supplemen-
tary agenda.

If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the

agenda, general meetings may take place without notice of meeting.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders in order to attend

any meeting of Shareholders.

The business transacted at any meeting of the Shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda

(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each Ordinary Share of whatever Class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and the present

articles of incorporation.

A Shareholder may act at any general meeting by giving a written proxy to another person, who need not be a Share-

holder and who may be a Director of the Company.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote

of the Shareholders present or represented.

Without prejudice to mandatory provisions of Luxembourg law, decisions referred to in the following list can only

be taken by the General Meeting subject to a majority of all voting shares held by the Shareholders:

- Any change in the articles of association;
- Approval and modification of business plans (including the budget);
- Approval of the annual accounts;
- The appointment and removal of the auditor;
- The appointment and removal of the depositary;
- Any change of name;
- Issue shares, warrants, convertible bonds or any securities which give the right to obtain such securities;
- The presentation of any petition for winding-up or similar procedure;
- Distribute any profit (whereby the General Meeting shall take into account the business needs communicated by

the executive directors), a dividend or interim dividend;

- Decide on the appointment and the remuneration of the board members and of the statutory auditor.
- Any material change in the nature or scope of the Company business or the way in which the Company business is

carried on if it is not already approved in the business plan or the relevant budget;

- Acquisition, opening, disposal or closing of a new subsidiary or business; and
- Decisions on escalation procedure (disputes between shareholders of the Company).
Any resolution of a meeting of Shareholders to the effect of amending the present articles of incorporation must be

passed with (i) a presence quorum of fifty (50) percent of the Share capital and if such a quorum is not obtained at a
first meeting there shall be no quorum requirement at the adjourned meeting and (ii) the approval of a majority of at
least two-thirds (2/3) of the Shareholders present or represented at any meeting.

Art. 23. Fiscal Year. The Company’s fiscal year commences on 1 January and ends on 31 December.

Art. 24. Annual Report. The Company shall publish one annual report within a period of six (6) months as of the

end of the fiscal year concerned.

Art. 25. Distributions. The rights to dividends or distributions attached to any Class of Shares are determined by

the Board of Directors and further described in the Memorandum.

Art. 26. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the

law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies and the law of 15 June 2004 concerning the société d’in-
vestissement en capital à risque as such laws have been or may be amended from time to time.

Art. 27. Definitions.
«Articles» The articles of incorporation of the Company.
«Board of Directors» The board of directors of the Company.
«Business Day» A day on which banks are generally open for business in Luxembourg.

112286

«Class» Each class of Shares within each Pool of the Company.
«Company» CARBON TRADE &amp; FINANCE SICAR S.A. is organized as a société anonyme and registered as a société

d’investissement en capital à risque in Luxembourg.

«Directors» The directors of the Company.
«Eligible Investors» Institutional Investors, Professional Investors or Well-informed Investors within the meaning of

article 2 of the Law of 15 June 2004 concerning the société d’investissement en capital à risque.

«Institutional Investors» Investors who qualify as institutional investors according to the Luxembourg laws and reg-

ulations.

«Investment Program» Shall have the meaning ascribed to that term in the sections of the Memorandum headed

«Definitions» and «Investment Objective and Strategy».

«Investment Structure» Investment Structures in which the Company intends to invest whose primary purpose is the

investment and financing of private equity, including venture capital. These Investment Structures may be of any kind
and nature, having the legal personality or not, whether listed or unlisted, being regulated or not and based in any juris-
diction.

«Memorandum» The placement memorandum of the Company as amended from time to time.
«Net Asset Value» The net asset value per Share of the relevant Class within the relevant Pool as determined pur-

suant to the section «Net Asset Value».

«Ordinary Shares» Shares which entitle the holders thereof to distribution rights as further described in the section

of the Memorandum headed «Distribution and Capital Reimbursement Policy».

«Portfolio Company» Any company in which the Company has made an investment, directly or through an Invest-

ment Structure.

«Pool» A portfolio comprising all the assets acquired in the context of a specific Investment Program or directly or

indirectly deriving there from as well as all liabilities directly or indirectly deriving from such Investment Program.

«Preferred Shares» Shares without voting rights which entitle the holders thereof to distribution rights as further

described in the section of the Memorandum headed «Distribution and Capital Reimbursement Policy».

«Professional Investors» Investors who qualify as professional investors under Annex II of Directive 2004/39 on in-

vestment services and regulated markets as amended.

«Reference Currency» The currency of calculation of the Net Asset Value as determined under the section «Net

Asset Value».

«Series» Each series of Ordinary Shares.
«Shareholder» A registered holder of Shares.
«Shares» Shares issued by the Company.
«Underlying Investments» Shall have the meaning ascribed to that term in the section of the Memorandum headed

«Investment Objective and Strategy».

«Well-informed Investors» Investors who (i) adhere in writing to the status of well-informed investors and (ii) either

invest a minimum of EUR 125,000.- in the Company or benefit from a certificate delivered by a credit institution, another
professional of the financial sector subject to rules of conduct within the meaning of Article 11 of Directive 93/22/EEC,
or a management company within the meaning of Directive 2001/107/CE stating that they are experienced enough to
appreciate in an adequate manner an investment in risk capital.

<i>Subscription and payment

The capital has been subscribed as follows: 

Upon incorporation, the Shares were paid-up up to 100%, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31 December 2007.
The first general annual meeting of Shareholders shall be held in 2008.
The first annual report of the Company will be dated 31 December 2007.
The Company shall not start trading until fully licensed in accordance with article 12 of the law of 15 June 2004 and

until it has been authorised to do so by the European Commission in accordance with the provisions of Council Regu-
lation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately eight thousand euro.

<i>General meeting of shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholders have resolved that:
I. The following are elected as Directors for a term to expire at the close of the annual general meeting of Sharehold-

ers which shall deliberate on the annual accounts of the Company as at 31 December 2007.

<i>Members:

- Otto Steinmetz
Chief Risk Officer / Member of the Board of Directors of DRESDNER BANK AG

Name of Subscriber

Number of subscribed

shares

1.- GAZPROMBANK, pre-qualified . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 Ordinary Shares

2.- DRESDNER BANK AG LUXEMBOURG BRANCH, pre-qualified . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 Ordinary Shares

112287

Gallusanlage 8, 60301 Frankfurt, Germany
born on 13 May 1944 in Teplitz-Schönau (Czech Republic)
- Martin Ernst Fraenkel
Banker
62 Primrose Gardens, London, NW3 4TP
born on 2 April 1960 in London
- Ramming, Ingo
Banker
30 Gresham Street London EC 2p 2xy
born on 1 November 1971 in Würzburg (Germany)
- Chlodwig Reuter
Directeur Général of the DRESDNER BANK AG, Luxembourg branch
26, rue du Marché-aux-Herbes, L-2097 Luxembourg
born on 2 March 1948 in Zemmer
- Andrey Akimov
Banker
16, Bldg. 1, Nametkina St., Moscow, 117420, Russia;
born on September 22, 1953 in Leningrad
- Alexei Obozintsev
Banker
16, Bldg. 1, Nametkina St., Moscow, 117420, Russia;
born on June 9, 1964 in Simferopol (USSR)
- Alexei Khavin
Banker
16, Bldg. 1, Nametkina St., Moscow, 117420, Russia;
born on July 28, 1975 in Moscow
- Matthew Shaw
Consultant
Suite 304, 8 Stasinou Street, Nicosia, CY-1060, Cyprus;
born on February 24, 1960 in Newton Longville (UK)
- Paul Mousel
Lawyer
14, rue Erasme, L-2010 Luxembourg
born on 15 October 1953 in Luxembourg
II. The registered office of the Company shall be at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
III. The independent auditor for the Company shall be KPMG, S.à r.l. with registered office at 31, allée Scheffer, L-

2520 Luxembourg. The term of office of the auditor shall expire at the close of the annual general meeting of Share-
holders approving the accounts as of 31 December 2007.

IV. The depositary shall be DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A. with registered office at 26, rue du Marché-aux-

Herbes, L-1728 Luxembourg. 

V. In compliance with Article 60 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the general

meeting authorizes the Board of Directors to delegate the day-to-day management of the Company as well as the rep-
resentation of the Company in connection therewith to one or more of its members.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-

ing person, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between
the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, said persons signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung vorbezeichneten Textes:

Im Jahre Zweitausend und sechs, am dreißigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. GAZPROMBANK, DIE BANK DER GAS INDUSTRY GAZPROMBANK, einer nach dem Recht der Russischen

Föderation gegründeten und existierenden, geschlossenen Aktiengesellschaft mit Sitz in 16, Gebäude 1, Nametkina
Street, Moskau 117420, Russland,

hier ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Marcel Bartnik, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Moskau, am 19. Oktober 2006.
2. DRESDNER BANK AG LUXEMBOURG BRANCH, mit Geschäftssitz in 6A, route de Trèves, L-2633 Senninger-

berg, die Luxemburger Niederlassung der DRESDNER BANK AG, einer «Aktiengesellschaft» deutschen Rechts mit Ge-
schäftssitz in Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, Deutschland,

hier ordnungsgemäß vertreten durch Dr.Gerd J.H. Otte, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg-Senningerberg, am 12. Oktober 2006.

112288

Die Vollmachten werden, nach Unterzeichnung und Paraphierung ne varietur durch die erschienenen Parteien und

den unterzeichneten Notar der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselbigen bei den für Registrie-
rungen zuständigen Behörden eingereicht zu werden.

Die erschienenen Parteien haben den beurkundenden Notar ersucht, die nachfolgende Satzung einer Aktiengesell-

schaft in Form einer Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital (société d’investissement en capital à risque, SI-
CAR), zu beurkunden, die wie folgt unter den Parteien gegründet werden soll:

Art. 1. Name. Zwischen den gegenwärtigen Zeichnern von Aktien und den nachfolgenden Eigentümern zukünftig

auszugebender Aktien (die «Aktien») besteht eine Aktiengesellschaft (AG) in der Form einer Investmentgesellschaft zur
Anlage in Risikokapital (société d’investissement en capital à risque, SICAR) unter dem Namen CARBON TRADE &amp;
FINANCE SICAR S.A. (die «Gesellschaft»).

Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital.

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder sonstige Büros können durch Beschluss des Verwaltungsrates der
Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden. In-
nerhalb ein und derselben Gemeinde kann der Sitz durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden.

Sollten nach Ansicht des Verwaltungsrates außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse vor-

liegen oder bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die ungestörte
Kommunikation zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigen, so kann bis zur vollständigen Behebung dieser
ungewöhnlichen Umstände der Sitz zeitweilig ins Ausland verlegt werden; diese provisorische Maßnahme hat jedoch kei-
ne Auswirkung auf die Zugehörigkeit der Gesellschaft zu Luxembourg; letztere bleibt ungeachtet einer solchen zeitwei-
ligen Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 4. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft ist die Anlage der ihr zur Verfügung stehenden Gelder

in Risikokapital im weitesten Sinne von Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur
Anlage in Risikokapital.

Die Gesellschaft kann die ihr zur Verfügung stehenden Gelder auch in andere gesetzlich zulässige und im Einklang mit

der Satzung stehenden Vermögenswerten anlegen.

Überdies kann die Gesellschaft solche Maßnahmen ergreifen und solche Geschäfte durchführen, die sie für die Erfül-

lung und Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks für angebracht erachtet und die im Sinne des Gesetzes vom 15. Juni
2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital in seiner weitesten Auslegungsmöglichkeit zulässig sind.

Art. 5. Bestimmung der Anlageziele sowie der Anlagepolitik. Der Verwaltungsrat bestimmt sowohl die An-

lageziele und die Anlagepolitik der Gesellschaft als auch die Art und Weise der diesbezüglichen Geschäftsleitung und
Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft, dem Inhalt des Verkaufsprospektes und den Bestimmungen vorliegend anwend-
barer Gesetze und Rechtsvorschriften entsprechend.

Art. 6. Kapital.
(a) Das Kapital der Gesellschaft wird durch Aktien ohne Nennwert verkörpert und entspricht zu jeder Zeit dem Ge-

samtwert des Nettovermögens der Gesellschaft gemäß Artikel 11 dieser Satzung. Der Mindestbetrag des Kapitals der
Gesellschaft liegt gemäß den gesetzlichen Vorschriften bei einer Million Euro (EUR 1.000.000,-) und ist innerhalb von
zwölf (12) Monaten nach Zulassung der Gesellschaft als Investmentgesellschaft zur Anlage von Risikokapital gemäß den
Bestimmungen des Luxemburger Rechts zu erreichen.

(b) Das Kapital der Gesellschaft wird durch die beiden nachfolgenden Aktienklassen ohne Nennwert (die «Klassen»)

verkörpert:

(i) «Stammaktien» gewähren ihrem Inhaber die im Verkaufsprospekt beschriebenen Ausschüttungsrechte.
(ii) «Vorzugsaktien» gewähren ihrem Inhaber die im Verkaufsprospekt beschriebenen Ausschüttungsrechte, haben

jedoch keine Stimmrechte.

Stammaktien und Vorzugsaktien können hinsichtlich jeder Vermögensmasse (Pool) ausgegeben werden.
Der Verwaltungsrat kann die beiden Aktienklassen in einer oder in mehreren Aktienserien ausgeben, deren Merk-

male, Modalitäten und Bedingungen durch den Verwaltungsrat bestimmt und in den Verkaufsprospekt aufgenommen
werden.

Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den Bestimmungen und entsprechend den Anforderungen des abgeänderten

Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften zusätzliche Aktienklassen und/oder Aktienserien bilden.

(c) Die Gesellschaft wird mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von zweiunddreißigtausend Euro (EUR 32.000,-)

gegründet. Dieses Kapital besteht aus zweiunddreißig (32) Stammaktien jeweils ohne Nennwert. Bei der Gesellschafts-
gründung wurden die Aktien in Höhe von 100% eingezahlt.

(d) Gemäß Artikel 9 der Satzung und entsprechend den Bestimmungen des Verkaufsprospektes ist der Verwaltungs-

rat berechtigt eine unbegrenzte Anzahl von Aktien innerhalb einer bereits bestehenden oder einer noch neu zu errich-
tenden Aktienklasse/Aktienserie auszugeben, vorausgesetzt dass bestehenden Aktionären diesbezüglich ein
Vorzugszeichnungsrecht eingeräumt wird.

Art. 7. Aktien.
(a) Die Aktien sind ausschließlich sachkundigen Anlegern im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über

die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital vorbehalten

(b) Sämtliche Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.

112289

Der Eintrag des Namens des Aktionärs in das Aktionärsregister dient als Nachweis der Berechtigung des Aktionärs

an den eingetragenen Namensaktien. Nach dem Ermessen des Verwaltungsrates können Aktienzertifikate, die einen sol-
chen Eintrag bestätigen, ausgegeben werden.

Alle ausgegebenen Aktien der Gesellschaft werden in das Aktionärsregister eingetragen, welches bei der Gesellschaft

oder bei einer hierfür von der Gesellschaft bezeichneten Person geführt wird. In dieses Register werden die Namen
jedes Aktionärs, sein Wohnsitz, eingetragener Firmensitz oder frei gewählter Sitz, die Aktiennummer und die Aktien-
klasse der von ihm gehaltenen Aktien, den auf diese Aktien bezahlten Betrag sowie seine Bankverbindungen eingetragen.
Die Gesellschaft behandelt die im Register eingetragenen Daten als zutreffend und aktuell, und sie wird insbesondere
die eingetragene Adresse als Empfängeradresse für Mitteilungen und Ankündigungen nutzen sowie die eingetragenen
Bankverbindungsdaten im Rahmen von Überweisungen verwenden, solange bis ihr eine Mitteilung anders lautender In-
formationen durch den Aktionär zugeht.

(c) Jede Übertragung von Aktien wird mit Eintragung derselbigen in das Aktionärsregister wirksam; sie setzt voraus,

dass der Gesellschaft ein Übertragungsformular oder auch jedes weitere Dokument, welches die Übertragung der Ge-
sellschaft in zufrieden stellender Weise nachweist, oder unter Umständen und soweit vorhanden die betreffenden Ak-
tienzertifikate übergeben wird.

(d) Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme bei jeder Aktionärshauptversammlung und bei solchen Versammlungen, die

separat für jede ausgegebene Klasse abgehalten werden.

(e) Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Sofern ein oder mehrere Aktie(n) im gemeinsamen Ei-

gentum mehrerer Personen steht/stehen oder wenn das Eigentum an (einer) Aktie(n) strittig ist, haben die Personen,
die eine Berechtigung an (einer) solchen Aktie(n) behaupten, einen Bevollmächtigten zu benennen, der diese Aktie(n)
gegenüber der Gesellschaft repräsentiert. Das Fehlen einer solchen Bevollmächtigung führt zum Verlust sämtlicher
Rechte, die mit der (den) Aktie(n) verbunden ist (sind).

Art. 8. Übertragung von Aktien. Jede Übertragung oder Abtretung von Vorzugsaktien setzt voraus, dass der Er-

werber oder Zessionar zuvor eine schriftliche Erklärung dahingehend abgibt, dass die Verpflichtungen des Verkäufers
bzw. Zedenten, die aus der Aktienzeichnung herrühren, im Ganzen und uneingeschränkt auf ihn übergehen.

Mit Ausnahme der Übertragung seitens des Inhabers an eine Person, welche den Zedenten kontrolliert oder durch

diesen kontrolliert wird, setzt jede Übertragung von Vorzugsaktien seitens des Inhabers zu Gunsten einer anderen Per-
son, die bereits Aktionär ist oder nicht die vorherige Zustimmung des Verwaltungsrates voraus, wobei letzterer die Zu-
stimmung nicht ohne das Vorliegen eines wichtigen Grundes verweigern kann.

Die Gesellschaft wird eine Übertragung jedoch dann nicht ausführen, wenn der Erwerber nicht als sachkundiger An-

leger im Sinne des Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital
qualifiziert werden kann.

Den bestehenden Aktionären steht ein Vorkaufsrecht an durch andere Aktionäre zum Verkauf angebotenen Aktien

zu.

Wenn einer oder mehrere Aktionäre beabsichtigen, alle oder einen Teil ihrer Aktien zu übertragen, werden diese

Aktionäre diese Übertragung nicht vornehmen, solange sie nicht von dem zukünftigen Zessionar zugunsten der anderen
Aktionäre das Recht erhalten haben, dass diese ihre Anteile ebenfalls an diesen abtreten können.

Art. 9. Ausgabe von Aktien. Die Zeichnung von Aktien ist sowohl für bestehende als auch für potentielle Aktio-

näre einem oder mehreren bestimmten Zeichnungszeitpunkt(en) oder Zeichungszeitra(ä)um(e) unterworfen (jede(r)
eine «Zeichungsfrist»). Sie werden durch den Verwaltungsrat festgelegt und im Verkaufsprospekt sowohl genannt als
auch ausführlich beschrieben.

Der Ausgabepreis der Aktien ist gänzlich oder teilweise bis zum Ablauf der Zeichnungsfrist oder jeder anderen Frist,

die der Verwaltungsrat bestimmt hat, und die im Verkaufsprospekt genannt und ausführlich beschrieben werden, zu ent-
richten.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt zusätzliche Zeichnungsbedingungen zu bestimmen, wie beispielsweise das Errei-

chen von Mindestzeichnungsbeträgen innerhalb der Zeichnungsfrist, die Zahlung von Verzugszinsen oder das Bestehen
von Eigentumsbeschränkungen. Diese Bedingungen werden im Verkaufsprospekt genannt und ausführlich beschrieben.

Bestehende Aktionäre verfügen im Verhältnis zu der Anzahl ihrer Aktien über ein Vorrecht zur Zeichnung neu aus-

gegebener Aktien, es sei denn der Verwaltungsrat beschließt, dass die Aktien ohne ein solches Vorrecht zur Zeichnung
ausgegeben werden und reserviert auf diese Weise das Zeichnungsrecht für eine begrenzte Aktienausgabe für spezifi-
sche Aktionäre oder Dritte.

Der Verwaltungsrat kann jeder ordnungsgemäß hierzu ermächtigten Person die Aufgabe übertragen, Zeichnungsan-

träge und Zahlungen auf den Aktienpreis neu auszugebender Aktien entgegenzunehmen, sowie die Aktien an die ent-
sprechenden Zeichner auszuliefern.

Art. 10. Rücknahme von Aktien. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft des geschlossenen Typs; sie ist dement-

sprechend berechtigt ein einseitiges Verlangen des Aktionärs auf Rücknahme von Aktien zurückzuweisen.

Auf Vorschlag des Verwaltungsrates und vorbehaltlich einer Genehmigung durch die Mehrheit der Aktionäre einer

Aktienklasse innerhalb der betreffenden Vermögensmasse, kann jedoch beschlossen werden, dass eine bestimmte An-
zahl von Aktien der relevanten Vermögensmasse entsprechend den im Verkaufsprospekt vorgesehenen Modalitäten
verhältnismäßig von sämtlichen bestehenden Aktionären zurückgenommen wird.

Überdies müssen Aktien zwingend zurückgenommen werden, sofern sich herausstellt, dass ein Aktionär nicht oder

nicht mehr den Anforderungen eines zulässigen Anlegers im Sinne des Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über
die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital entspricht. Solche Rücknahmen sind entsprechend den Bestim-
mungen des Verkaufsprospektes vorzunehmen.

112290

Die Gesellschaft ist berechtigt den Rücknahmepreis an jeden Aktionär, der dem zustimmt, unbar auszuzahlen, indem

dem Aktionär aus dem Portfolio der Gesellschaft Vermögenswerte zu dem jeweiligen Wert der zurückgenommenen
Aktien übertragen werden. Natur und Art der zu übertragenden Vermögenswerte werden in einem solchen Fall auf
einer angemessenen und sachlichen Grundlage und ohne Beeinträchtigung der Interessen der übrigen Aktionäre der Ge-
sellschaft bestimmt und die angewandte Bewertung wird durch einen gesonderten Bericht des Wirtschaftsprüfers der
Gesellschaft bestätigt. Die Kosten einer solchen Übertragung trägt der Erwerber.

Art. 11. Berechnung des Nettoinventarwertes. 

(A) - Allgemeine Bestimmungen
Der Nettoinventarwert jeder Klasse (der «Nettoinventarwert») wird durch die Verwaltungsstelle unter der Verant-

wortung des Verwaltungsrates an jedem Bewertungstag - definiert in dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft - berech-
net und in der Referenzwährung (entsprechend den Bestimmungen des Verkaufsprospektes) ausgedrückt.

Im Rahmen der Bestimmung des Nettoinventarwertes pro Aktie werden Einnahmen und Ausgaben als täglich anfal-

lend behandelt.

Die Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden entsprechend allgemein anerkann-

ter Bewertungsmethoden und unter Beachtung von Artikel 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Invest-
mentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital bestimmt:

(i) Der Wert flüssiger Mittel entspricht ihrem Nennwert inklusive angewachsener Zinsen;
(ii) Der Wert der Anteile an Beteilungsgesellschaften wird an Hand ihres letzten zur Verfügung stehenden Nettoin-

ventarwertes bestimmt; dieser ist insbesondere im Fall von Kapitaltransaktionen sowie von wesentlichen materiellen
Ereignissen oder Entwicklungen betreffend die zugrunde liegenden Vermögenswerte oder die Beteiligungsgesellschaften
selbst anzupassen; und 

(iii) Andere Beteiligungen oder Vermögenswerte der Gesellschaft werden entsprechend der durch den Europäischen

Venture Capital Verband entwickelten Bewertungsgrundsätzen bestimmt.

Der Verwaltungsrat kann sich anderer Bewertungsmethoden bedienen, sofern er der Ansicht ist, dass jene den Wert

des Vermögens zutreffender wiedergeben, sofern die Umstände und Bedingungen des Marktes dies erfordern und vor-
ausgesetzt, dass diese Bewertungsmethoden darauf abzielen das Vermögen entsprechend dem Vorsichtsprinzip und dem
Grundsatz von Treu und Glauben auf der Basis von vernünftigerweise vorhersehbaren Markwerten zu bewerten.

(B) - Vermögenswerte der Gesellschaft
Spezifische Vermögensmassen (Pools) werden wie folgt im Rahmen jedes Anlageprogramms auf den Konten der Ge-

sellschaft eingerichtet:

a) die Erträge, die aufgrund der Ausgabe von Aktien innerhalb einer Aktienklasse (als Teil eines Anlageprogramms)

erzielt werden, sind in den Büchern der Gesellschaft innerhalb der Vermögensmasse zu verbuchen, die für dieses Anla-
geprogramm errichtet wurde; sofern erforderlich, werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Erträ-
ge und Aufwendungen, die einer solchen Vermögensmasse zugeordnet werden können, innerhalb der betreffenden
Vermögensmasse und im Einklang mit nachfolgenden Bestimmungen dieses Artikels verbucht;

b) sofern sich ein Vermögenswert von einem anderen Finanzinstrument ableitet, werden diese abgeleiteten Vermö-

genswerte der Gesellschaft in derselben Vermögensmasse verbucht wie das andere Finanzinstrument selbst und bei je-
der Wiederbewertung eines Vermögenswertes wird jede Werterhöhung oder Wertminderung in der betreffenden
Vermögensmasse verbucht;

c) sofern die Gesellschaft eine Verbindlichkeit eingeht, die einem Vermögenswert innerhalb einer bestimmten Ver-

mögensmasse zugeordnet werden kann, oder die im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfalls innerhalb einer be-
stimmten Vermögensmasse steht, wird diese Verbindlichkeit in der betreffenden Vermögensmasse verbucht,
vorausgesetzt, dass sämtliche Verbindlichkeiten, unabhängig davon welcher Vermögensmasse sie angehören, die Gesell-
schaft gegenüber Dritten vollumfänglich binden;

d) sofern Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht einer bestimmten Vermögensmasse zuge-

ordnet werden können, sind diese Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten anteilig des Nettoinventarwertes der be-
treffenden Vermögensmasse auf alle Vermögensmassen zu verteilen. 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht Bestandteil des Anlageprogramms sind, werden gesondert gebucht.

(C) - Nettoinventarwert je Vermögensmasse (Pool) und je Aktie
Die Gesellschaft wird den Nettoinventarwert je Klasse innerhalb einer Vermögensmasse (Pool) wie folgt berechnen:

jede Klasse gehört in diejenige Vermögensmasse (Pool), die dem Portfolio und den Ausschüttungsanwartschaften dieser
Klasse entspricht. Der Wert des Gesamtportfolios und der Gesamtausschüttungsanwartschaften, die an einem be-
stimmten Bewertungstag einer bestimmten Klasse innerhalb einer Vermögensmasse zugeordnet werden können - unter
Berücksichtigung der Verbindlichkeiten dieser Klasse an diesem Bewertungstag - verkörpert den Gesamtnettoinventar-
wert, der dieser Klasse an diesem Bewertungstag zugeordnet werden kann.

Der Nettoinventarwert je Aktie einer Klasse innerhalb einer Vermögensmasse (Pool) an einem bestimmten Bewer-

tungstag entspricht dem Gesamtnettoinventarwert dieser Klasse an diesem Bewertungstag geteilt durch die Gesamtzahl
der Aktien dieser Klasse, die in dieser Vermögensmasse (Pool) an diesem Bewertungstag ausstehen.

Der Nettoinventarwert je Klasse jedes Bewertungstages wird den Aktionären am Sitz der Gesellschaft innerhalb ei-

nes auf den Bewertungstag folgenden Zeitraumes, wie in dem Verkaufsprospekt beschrieben zur Verfügung stehen.

Art. 12. Aussetzung der Nettoinventarwertberechnung. Der Verwaltungsrat kann die Bestimmung des Net-

toinventarwertes aussetzen:

(a) in Notfällen, wenn nach Einschätzung des Verwaltungsrates Verfügungen oder die Bewertungen von Vermögens-

werten der Gesellschaft nicht vorgenommen werden können;

112291

(b) während eines Zusammenbruchs von Kommunikationswegen, die normalerweise im Zusammenhang mit der Be-

stimmung des Preises oder des Wertes von Beteiligungen der Gesellschaft innerhalb einer Vermögensmasse Verwen-
dung finden, oder solcher Kommunikationswege, die im Zusammenhang mit der Kurs- oder Wertbestimmung von
Vermögenswerten, die an einer Börse oder an einem sonstigen Markt gehandelt werden und einer Vermögensmasse
zuzuordnen sind.

(c) falls Deviseneinschränkungen oder Einschränkungen betreffend Kapitaltransaktionen die Ausführung von Trans-

aktionen im Zusammenhang mit einer Vermögensmasse der Gesellschaft verhindern;

(d) sofern aus anderen Gründen die Preise von Vermögensanlagen der Gesellschaft, welche einer Vermögensmasse

zuzuordnen sind, nicht zeitnah und genau festgestellt werden können;

Jeder Zeichnungsantrag ist unwiderruflich, es sei denn es läge ein Fall vorbenannter Aussetzung der Nettoinventar-

wertberechnung pro Aktie vor.

Art. 13. Verwaltungsratsmitglieder. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus neun

Mitgliedern besteht, welche nicht notwendigerweise Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Frist von höchstens sechs Jahren gewählt. Die Verwaltungsratsmit-

glieder werden von den Aktionären im Rahmen der Hauptversammlung gewählt; letztere beschließt außerdem die Zahl
der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Haupt-

versammlung abberufen oder ersetzt werden.

Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes kann die freiwerdende Stelle vorläufig durch die verbleiben-

den Mitglieder des Verwaltungsrates besetzt werden (Kooptation); die Aktionäre werden bei der nächsten Hauptver-
sammlung eine endgültige Entscheidung über eine solche Ernennung treffen.

Art. 14. Verwaltungsratsitzungen. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestim-

men. Er kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss, und der die Protokolle der
Verwaltungsratssitzungen und Hauptversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des
Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusam-
men.

Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Hauptversammlungen. In seiner Abwe-

senheit können die Aktionäre oder die Mitglieder des Verwaltungsrates durch Mehrheitsbeschluss ein anderes Mitglied
des Verwaltungsrates - oder im Falle der Hauptversammlung, jede andere Person - mit der Leitung beauftragen.

Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte, einschließlich eines Geschäftsführers und beigeordneter Geschäftsfüh-

rer sowie sonstige Angestellte ernennen, sofern die Gesellschaft diese für die Ausführung der Geschäftsführung und Lei-
tung der Gesellschaft für erforderlich hält. Diese Ernennungen können jederzeit vom Verwaltungsrat rückgängig
gemacht werden. Die leitenden Angestellten müssen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates oder Aktionäre der Gesell-
schaft sein. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen dieser Satzung haben die leitenden Angestellten die Rechte und
Pflichten, welche ihnen vom Verwaltungsrat übertragen wurden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens fünf Geschäftstage vor dem

entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, sofern die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt
wird. Auf eine solche Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder andere, ähn-
liche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine Einladung ist auch dann nicht notwendig, wenn der Zeitpunkt und
der Ort zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden sind.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung schriftlich, durch Telegramm, Telex,

Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Ein Verwal-
tungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen gleichzeitig vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telephonischen Konferenz-

schaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung
einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates können nur im Rahmen ordnungsgemäß einberufener Verwaltungsratssitzungen

handeln. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, es sei
denn es läge eine ausdrückliche entsprechende Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss vor.

Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen wirksam vornehmen, wenn wenigstens

die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder
vertreten ist. Wenn dieses Quorum nicht erreicht wird, wird eine neue Verwaltungsratssitzung einberufen, welches un-
geachtet der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder entscheiden kann.

Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert; die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssit-

zung unterzeichnet. Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweiszwecken für gerichtliche oder sonstige Verfahren
erstellt werden, sind nur dann rechtsgültig, wenn sie vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwal-
tungsratsmitgliedern unterzeichnet worden sind.

Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz können die folgenden Entscheidungen nur mit Zustim-

mung von wenigstens 6 Verwaltungsratsmitgliedern getroffen werden:

- Sofern nicht im genehmigten Geschäftsplan der Gesellschaft bewilligt und soweit nicht durch die existierenden Ak-

tionäre der Gesellschaft bereitgestellt, das Eingehen neuer Darlehen (einschliesslich der Verlängerung existenter Dar-
lehen) und Überziehungskredite, die Ausgabe von Anleihen oder anderen Schuldtitel von mehr als EUR 10 Millionen,
sowie die nicht im genehmigten Geschäftsplan vorgesehene Stellung von Sicherheiten über Vermögenswerte;

- Das Eingehen, Ändern oder Kündigen von Joint Ventures, Teilhaberschaften, Gewinnbeteiligungen oder anderen

ähnlichen Vereinbarungen oder Abmachungen;

112292

- Die Erstellung und der Vorschlag des Jahresabschlusses im Rahmen der Hauptversammlung;
- Sofern nicht im genehmigten Geschäftsplan der Gesellschaft vorgesehen, jeglicher Kapitaleinsatz von über EUR 10

Millionen;

- Die Stellung von Sicherheiten zur Absicherung von Verbindlichkeiten;
- Der Verkauf, die Übertragung oder der Erwerb von Unternehmen, Firmen, Gesellschaften und Beteiligungen, ausser

im Rahmen der normalen Geschäftsführung;

- Die Verabschiedung oder Einführung von Regeln über interne Prozessabläufe;
- Eine Veränderung der Regeln und Methoden der Buchführung;
- Die Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds, insoweit der Verwaltungsrat hierzu ermächtigt ist (Kooptati-

on);

- Die Einstellung von Schlüsselpersonen mit einem Jahresgehalt von mehr als EUR 50.000,- (Gesamtkosten für die

Gesellschaft);

- Ernennung und Bezahlung des Vorsitzenden des Verwaltungsrates, sowie Bezahlung der Geschäftsführer der Ge-

sellschaft;

- Das Eingehen einer Vereinbarung mit einem der Aktionäre;
- Die Erstellung des Jahresabschlusses.
Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unter-

zeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche
Beschlüsse schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen.

Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Ver-

fügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Hauptversammlung vorbe-

halten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.

Art. 16. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinschaftliche

Unterschrift zweier gemäß einer Entscheidung des Verwaltungsrates handelnder Mitglieder des Verwaltungsrates oder
durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift von Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt
wurden, verpflichtet.

Art. 17. Investment Manager. Der Verwaltungsrat kann einen Investmentmanagementvertrag abschließen, auf

Grundlage der Investment Manager dem Verwaltungsrat Ratschläge und Empfehlungen entsprechend den im Verkaufs-
prospekt beschriebenen Anlagezielen und Anlagestrategien unterbreitet.

Art. 18. Interessenkonflikt. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesell-

schaft oder einem anderen Unternehmen werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder meh-
rere Verwaltungsratsmitglieder oder leitende Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder an
diesem anderen Unternehmen ein persönliches Interesse haben, oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, lei-
tender oder sonstiger Angestellter sind.

Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, der als Verwaltungsratsmitglied, leiten-

der Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder einem Unternehmen, mit dem die Gesellschaft
Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen unterhält, fungiert, wird durch diese Verbindung mit dieser an-
deren Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen nicht daran gehindert, im Rahmen eines solchen Vertrages oder
einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Ge-

schäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird
dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellter dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persön-
liche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen
teilnehmen, und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder
leitenden Angestellten der nächstfolgenden Hauptversammlung berichtet.

Der Begriff «Entgegengesetztes Interesse», wie vorstehend verwendet, bezieht sich nicht auf solche Verbindungen im

Zusammenhang mit einer Angelegenheit, Stellung oder einem Geschäftsvorfall besteht, die/der eine bestimmte Person,
Gesellschaft oder Einheit umfasst, welche vom Verwaltungsrat nach dessen Ermessen bezeichnet werden.

Art. 19. Entschädigung des Verwaltungsrates. Die Gesellschaft wird jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder

jeden leitenden Angestellten ebenso wie dessen Erben, Testamentsvollstrecker und Verwalter von angemessenen Aus-
lagen freihalten, welche ihm im Zusammenhang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem Verfah-
ren entstanden sind, an welchem er aufgrund seiner Stellung als Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter der
Gesellschaft, oder auf Antrag der Gesellschaft hin, auch einer anderen Gesellschaft, an welcher die Gesellschaft als Ak-
tionär beteiligt ist oder deren Gläubigerin sie ist und von der er keine Entschädigung erhält, beteiligt ist. Dies gilt nicht,
wenn er aufgrund solcher Klagen, Rechtsverfolgungsmaßnahmen oder Verfahren wegen grob fahrlässigen oder fehler-
haften Verhaltens rechtskräftig verurteilt wird. Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammen-
hang mit den Angelegenheiten, welche von dem Vergleich abgedeckt werden und sofern die Gesellschaft von einem
Rechtsberater bestätigt bekommt, dass die zu entschädigende Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorste-
hende Recht auf Entschädigung schließt andere Rechtsansprüche nicht aus.

Art. 20. Depotbank. Die Gesellschaft wird einen Depotbankvertrag mit einer luxemburgischen Bank gemäß den

Anforderungen des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital abschließen.

Entsprechend üblicher Bankpraxis, kann die Depotbank die bei ihr verwahrten Vermögenswerte der Gesellschaft

ganz oder teilweise anderen Banken oder sonstigen Dritten anvertrauen.

112293

Die Depotbank ist mit der Verwahrung des Gesellschaftsvermögens ihrer Wertpapiere, ihrer flüssigen Mittel und ih-

rer sonstiger Vermögenswerte beauftragt. Ihre Aufgaben und Pflichten ergeben sich aus dem Gesetz vom 15. Juni 2004
über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital.

Beschließt die Depotbank den Depotbankvertrag zu kündigen, wird die Gesellschaft alle Anstrengungen unterneh-

men, um innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Wirksamwerden dieser Kündigung eine andere Bank zur Depot-
bank zu bestellen. Die bisherige Depotbank hat, bis sie durch die andere Bank ersetzt wird, was zwingend innerhalb der
vorgenannten Frist von zwei Monaten zu erfolgen hat, ihrerseits alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die Inter-
essen der Aktionäre der Gesellschaft zu bewahren.

Die Gesellschaft ist berechtigt den Depotbankvertrag zu kündigen; bis zur Bestellung einer neuen Depotbank kann

die bisherige Depotbank ihrer Pflichten jedoch nicht entbunden werden.

Der Depotvertrag gilt als beendet:
a) für den Fall, der Kündigung des Depotbankvertrages seitens der Depotbank selbst oder seitens der Gesellschaft;

die Depotbank hat dann innerhalb der Neubesetzungsfrist von zwei Monaten alle notwendigen Maßnahmen zu treffen,
um die Interessen der Aktionäre der Gesellschaft zu bewahren;

b) falls die Depotbank oder die Gesellschaft Insolvenz anmeldet, in ein Gläubigerausgleichsverfahren eintritt, ihre Zah-

lungen einstellt, ihre Geschäftsleitung gerichtlich eingesetzten Kontrollorganen unterliegt oder anderen ähnlichen Ver-
fahren unterworfen ist oder sie in Liquidation gesetzt wird;

c) falls die luxemburgische Aufsichtsbehörde die Zulassung für die Gesellschaft oder die Depotbank zurücknimmt.

Art. 21. Verwaltungsstelle. Die Gesellschaft kann eine Verwaltungsstelle bestimmen. Diese übernimmt sämtliche

Verwaltungsaufgaben, die in den luxemburgischen Gesetzen vorgesehen sind, insbesondere die Buchführung und die
Nettoinventarwertberechnung der Aktien, sonstige Sekretariats- und Verwaltungsaufgaben, die Ausführung der Ausga-
be und Rücknahme von Aktien, Annahme von Fondsübertragungen, Verwahrung des Aktionärsregisters und der Grün-
dungsunterlagen der Gesellschaft, die Vorbereitung der Verwaltungsratssitzungen, Ermöglichung und Überwachung
elektronischer Sendungen an die Aktionäre in Form von Auszügen, Berichten, Mitteilungen und anderer Unterlagen. Die
Verwaltungsstelle kontrolliert ferner, ob die Aktionäre zu dem Kreis berechtigter Anleger im Sinne von Artikel 2 des
Gesetzes vom 15. Juni 2004 über Investmentgesellschaften zur Anlage in Risikokapital gehören

Art. 22. Hauptversammlung. Die Hauptversammlungrepräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesell-

schaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusam-
menhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.

Die Hauptversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Fünftel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren,

zusammentreten.

Die jährliche Hauptversammlung wird am zweiten Donnerstag des Monats Mai um 11 Uhr am Sitz der Gesellschaft

oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort abgehalten. Sollte dieser Tag kein Geschäftstag sein, so wird
die jährliche Hauptversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten.

Andere Hauptversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der

entsprechenden Einladung angegeben wird.

Die Aktionäre treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht Ge-

schäftstage vor der Hauptversammlung an jeden Aktionär an dessen in dem Aktionärsregister eingetragene Adresse ver-
sandt werden muss, zusammen. Die Mitteilung an die Inhaber von Namensaktien muss auf der Versammlung nicht
nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Ver-
sammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche
Tagesordnung vorbereiten kann.

Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die

Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Hauptversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.

Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an

einer Hauptversammlung erfüllt werden müssen.

Auf der Hauptversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind

(die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten) sowie Vorgänge, welche zu solchen
Vorgängen gehören.

Gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts und dieser Satzung, ist jede Stammaktie, unabhängig von der Ak-

tienklasse, zu einer Stimme berechtigt.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung aufgrund schriftlicher Vollmacht durch eine andere Person, wel-

che kein Aktionär sein muss und welche Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein kann, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung, werden die Beschlüsse im Rahmen

der Hauptversammlung durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz, müssen die im Folgenden aufgeführten Beschlüsse im

Rahmen der Hauptversammlung mit der Mehrheit aller ausgegebenen Aktien gefasst werden:

- Jede Änderung der Satzung;
- Genehmigung und Änderung des Geschäftsplans (einschliesslich des Budgets);
- Genehmigung des Jahresabschlusses;
- Bestellung und Entlassung des Wirtschaftsprüfers;
- Bestellung und Entlassung der Depotbank;
- Jede Namensänderung;
- Die Ausgabe von Aktien, Optionsscheinen, Wandelanleihen oder anderen Wertpapieren, welche zum Erhalt dieser

Wertpapiere berechtigen;

112294

- Die Vorlage eines Antrages auf Abwicklung oder einer vergleichbaren Maßnahme;
- Die Verteilung des Gewinns (wobei die Hauptversammlung die durch die Geschäftsführer mitgeteilten Geschäfts-

bedürfnisse berücksichtigt), einer Dividende oder einer Zwischendividende;

- Die Entscheidung über die Ernennung und die Bezahlung der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Wirtschaftsprü-

fers;

- Jegliche erhebliche Änderung des Wesens oder des Zweckes der Gesellschaft oder der Art, in welcher die Geschäf-

te der Gesellschaft geführt werden, soweit dies nicht bereits im Geschäftsplan oder dem betreffenden Budget genehmigt
ist;

- Erwerb, Eröffnung, Veräußerung oder Schließung einer Tochtergesellschaft oder eines Geschäftszweiges; und
- Entscheidungen betreffend das Eskalationsverfahren (Streitfragen zwischen Aktionären der Gesellschaft).
Soweit Beschlüsse der Hauptversammlung die Modifizierung der vorliegenden Satzung zum Gegenstand haben, bedarf

es (i) eines Anwesenheitsquorums von fünfzig Prozent (50%) des Kapitals - falls dieses Quorum bei einer ersten Ver-
sammlung jedoch nicht erreicht wird, bedarf es bei der nachfolgenden Versammlung dieses Quorums nicht - und in je-
dem Fall (ii) einer Zustimmungsmehrheit von mindestens Zwei-Dritteln (2/3) der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre.

Art. 23. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 24. Jahresbericht. Die Gesellschaft veröffentlicht ihren Jahresbericht jeweils innerhalb von sechs (6) Monaten

nach Ende des entsprechenden Geschäftsjahres.

Art. 25. Ausschüttungen. Rechte betreffend Dividenden oder Ausschüttungen im Zusammenhang mit einer Akti-

enklasse, werden vom Verwaltungsrat bestimmt und im Verkaufsprospekt näher beschrieben.

Art. 26. Anwendbares Recht. In dieser Satzung nicht geregelte Fragen werden durch die Bestimmungen des ab-

geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die
Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital einschließlich der Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Geset-
ze geregelt.

Art. 27. Begriffsbestimmungen.
«Satzung» bezeichnet die Satzung der Gesellschaft.
«Verwaltungsrat» bezeichnet den Verwaltungsrat der Gesellschaft.
«Geschäftstag» bezeichnet einen Tag, an welchem Handelsbanken in Luxemburg für Geschäfte gewöhnlich geöffnet

haben.

«Klasse» bezeichnet jede Aktienklasse im Zusammenhang mit einer Vermögensmasse der Gesellschaft.
«Gesellschaft» bezeichnet die CARBON TRADE &amp; FINANCE SICAR S.A., eine Aktiengesellschaft in der Form einer

Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital in Luxemburg.

«Verwaltungsratsmitglied» bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft.
«Zulässige Anleger» bezeichnet institutionelle Anleger, professionelle Anleger und sachkundige Anleger im Sinne von

Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital.

«Institutionelle Anleger» bezeichnet Anleger, die entsprechend luxemburgischer Gesetze und Vorschriften als insti-

tutionelle Anleger qualifiziert werden.

«Anlageprogramm» bezeichnet das im Verkaufsprospekt im Rahmen der Abschnitte «Begriffsbestimmungen» und

«Anlageziel und Anlagestrategie» beschriebene Anlageprogramm.

«Beteiligungsgesellschaft» bezeichnet die Beteiligungsgesellschaften, in die Gesellschaft anzulegen gedenkt, und deren

vornehmlicher Zweck die Anlage und Finanzierung von Private Equity inklusive Venture Capital - Projekten ist. Diese
Anlagestrukturen können von jeder Art und Natur sein, unabhängig davon, ob sie eine eigene Rechtspersönlichkeit ha-
ben, ob sie an der Börse gehandelt werden, ob sie auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und ob sie
einen Gerichtsstand haben.

«Verkaufsprospekt» bezeichnet den Verkaufsprospekt der Gesellschaft, der sich von Zeit zu Zeit ändern kann.
«Nettoinventarwert» bezeichnet den Nettoinventarwert pro Aktie jeder Klasse innerhalb der entsprechenden Ver-

mögensmasse gemäß den Bestimmungen des Abschnittes «Nettoinventarwert».

«Stammaktien» bezeichnen Aktien, die ihren Inhabern das im Verkaufsprospekt unter Abschnitt «Ausschüt- tungen

und Kapitalrückerstattungspolitik» beschriebene Ausschüttungsrecht gewähren.

«Portfolio-Gesellschaft» bezeichnet jede Gesellschaft, an welcher sich die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar

durch eine Anlagestruktur beteiligt.

«Vermögensmasse (Pool)» bezeichnet ein Portfolio, das aus allen Aktiva, die im Zusammenhang mit einem spezifi-

schen Anlageprogramm erworben oder unmittelbar oder mittelbar von diesem abgeleitet wurden, sowie sämtliche Pas-
siva, die unmittelbar oder mittelbar aus diesem Anlageprogramm abgeleitet wurden, zusammengesetzt ist.

«Vorzugsaktien» bezeichnen stimmrechtslose Aktien, die ihren Inhabern das im Verkaufsprospekt unter Abschnitt

«Ausschüt- tungen und Kapitalrückerstattungspolitik» beschriebene Ausschüttungsrecht gewähren.

«Professionelle Anleger» bezeichnet Anleger, die als professionelle Anleger im Sinne von Anhang II der Richtlinie

2004/39 über Märkte für Finanzinstrumente, in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

«Referenzwährung» bezeichnet die Währung der Nettoinventarwert- berechnung, wie innerhalb des Abschnitts

«Nettoinventarwert» bestimmt.

«Serie» bezeichnet jede Serie von Stammaktien.
«Aktionäre» bezeichnet jeden Inhaber von Namensaktien.
«Aktien» bezeichnet die von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien. 

112295

«Zugrundeliegende Vermögenswerte» haben die Bedeutung, die ihnen im Rahmen des Verkaufsprospektes unter des

Abschnittes «Anlageziel und Anlagestrategie» zukommt.

«Sachkundige Anleger» bezeichnet Anleger, die (i) schriftlich ihr Einverständnis mit der Einordnung als sachkundige

Anleger erklärt haben, (ii) die mindestens 125.000,- Euro in die Gesellschaft investieren, oder die über eine Einstufung
seitens eines Kreditinstituts, eines anderen Professionellen des Finanzsektors, der den Wohlverhaltensregeln im Sinne
des Artikels 11 der Richtlinie 93/22/EWG unterliegt, oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/
107/EG, die ihm bescheinigt, den Sachverstand, die Erfahrung und Kenntnis zu besitzen, um auf angemessene Weise eine
Anlage in Risikokapital einschätzen zu können.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Das Grundkapital wurde wie folgt gezeichnet: 

Nach der Gründung wurden die Aktien in Höhe von 100% einbezahlt, so dass dieser Betrag von nun an zum Beweis

des unterzeichneten Notars frei zur Verfügung steht.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.
Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet 2008 statt.
Der erste Jahresbericht der Gesellschaft wird mit Datum 31. Dezember 2007 erscheinen.
Die Gesellschaft wird keine Aktivitäten aufnehmen bis sie dazu gemäß Artikel 12 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 voll

ermächtigt ist und bis sie hierzu durch die Europäische Kommission in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Ver-
ordnung (EG) Nr. 139/2004 vom 20. January 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen ermächtigt
ist.

<i>Kostenschätzung

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen, welcher Art auch immer, welche von der Gesellschaft zu tragen

sind und ihr in Verbindung mit der Gründung entstanden sind, werden auf achttausend Euro geschätzt.

<i>Aktionärshauptversammlung

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft haben die Aktionäre folgendes beschlossen:
I. Die nachfolgenden Personen werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates bis zum Abhalten der Generalversamm-

lung welche über die Bilanz zum 31. Dezember 2007 befindet bestellt:

<i>Mitglieder des Verwaltungsrates:

- Otto Steinmetz
Chief Risk Officer / Member of the Board of Directors of DRESDNER BANK AG
Gallusanlage 8, 60301 Frankfurt, Germany
geboren am 13. Mai 1944 in Teplitz-Schönau (Tschechische Republik)
- Martin Ernst Fraenkel
Banker
62 Primrose Gardens, London, NW3 4TP
geboren am 2. April 1960 in London
- Ramming, Ingo
Banker
30 Gresham Street, London EC 2p 2xy
geboren am 1. November 1971 in Würzburg (Germany)
- Chlodwig Reuter
Directeur Général of the DRESDNER BANK AG, Luxembourg branch
26, rue du Marché-aux-Herbes, L-2097 Luxembourg
geboren am 2. März 1948 in Zemmer
- Andrey Akimov
Banker
16, Bldg. 1, Nametkina St., Moscow, 117420, Russia; 
geboren am 22. September 1953 in Leningrad
- Alexei Obozintsev
Banker
16, Bldg. 1, Nametkina St., Moscow, 117420, Russia;
geboren am 9. Juni 1964 in Simferopol (UdSSR)
- Alexei Khavin
Banker
16, Bldg. 1, Nametkina St., Moscow, 117420, Russia;
geboren am 28. Juli 1975 in Moskau
- Matthew Shaw
Consultant
Suite 304, 8 Stasinou Street, Nicosia, CY-1060, Cyprus; 

Aktionär

Anzahl der gezeichne-

ten Aktien

1. GAZPROMBANK, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 Stammaktien

2. DRESDNER BANK AG LUXEMBOURG BRANCH, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 Stammaktien

112296

geboren am 24. Februar 1960 in Newton Longville (UK)
- Paul Mousel
Rechtsanwalt
14, rue Erasme, L-2010 Luxembourg
geboren am 15 Oktober 1953 in Luxembourg
II. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
III. Die nachfolgende Person wird zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer bis zum Abhalten der nächsten Generalver-

sammlung welche über die Bilanz zum 31. Dezember 2007 befindet bestellt: KPMG, S.à r.l. mit Geschäftssitz in 31, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.

IV. In Übereinstimmung mit den Bedingungen des Artikels 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesell-

schaften, wird der Verwaltungsrat dazu ermächtigt, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung
der Gesellschaft nach außen in diesem Zusammenhang, auf eines oder mehrere seiner Mitglieder zu übertragen.

IV. Zur Depotbank der Gesellschaft wird die DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A. mit Geschäftssitz in 26, rue

du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxemburg bestellt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit dass auf Anfrage der oben erwähn-

ten Personen diese Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Fassung, verfasst wurde; auf Anfrage
derselben erschienen Personen wird im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung
die englische Fassung maßgebend sein.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, welche dem instrumentierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben zusammen mit uns, dem
Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Bartnik, G.J.H. Otte, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch/Alzette, am 3. November 2006, Band 907, Blatt 83, Feld 10. – Erhalten 1.250 euros.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(122195.3/239/1053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.

PATRI IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 88.812. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02623, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121402.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

REAL ESPANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 88.228. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02624, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121404.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

RESINEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 80.606. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02104, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121257.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Beles, den 7. November 2006.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

RESINEX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

112297

ARAICH LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.621. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02101, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121259.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

ARAICH LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.621. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02099, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121261.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

CASA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.022. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01917, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121397.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

IRMAN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 80.596. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02763, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121456.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

PROTEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 59.856. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires dûment convoquée et tenue à Luxembourg le 8 novembre 2006 à 10 heures

Le siège social est transféré avec effet immédiat au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121662.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

ARAICH LIMITED S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

ARAICH LIMITED S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Signatures.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le Conseil d’Administration

112298

SLOANE GARDENS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 121.103. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirtieth of October.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, a foundation established and existing under the laws of The Neth-

erlands, registered with the trade register of the Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam, The Nether-
lands, under number 34226972, having its registered office at Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, The Netherlands,

here represented by Mr François Deprez, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Amsterdam, on 9 October 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name of

SLOANE GARDENS (the «Company») which shall have the status of a securitisation company (société de titrisation)
within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation (the «Securitisation Law») and which shall be subject
to and be governed by the Securitisation Law, the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended
(the «Companies Law») and by the present articles of incorporation.

Art. 2. The sole purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transaction(s) within the mean-

ing of the Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the hold-
ing of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations
assumed by third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a
continuous basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by com-
mitting itself in any other way. The Company may also transfer, to the extent permitted by law and these articles of
incorporation, or otherwise dispose of the claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more
transactions or on a continuous basis.

The Company may, in this same purpose, acquire, dispose of and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obliga-

tions, notes, advances, shares, warrants and other securities. The Company may only grant pledges, other guarantees
or security of any kind to Luxembourg or foreign entities within the above-mentioned purpose.

The Company may create one or several Compartments (as defined hereafter) in accordance with article 10 of the

present articles of incorporation.

The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all

transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as, all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above. The assets of the Company
may only be assigned in accordance with the terms of the securities issued to finance the acquisition of such assets.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several

managers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in

case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

112299

Art. 8. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dis-

solution of the Company.

C. Compartments

Art. 10. The manager or the board of managers of the Company may create one or more compartments within the

Company (the «Compartment» or the «Compartments»). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in
the resolution of the manager or of the board of managers creating such compartment, correspond to a distinct part of
the assets and liabilities of the Company. The resolution of the manager or of the board of managers creating one or
more Compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto, shall be binding as of the
date of such resolution against any third party.

As between investors and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights

of investors and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating to a
Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment
are, except if otherwise provided for in the resolution of the manager or the board of managers having created the
relevant Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and shall be exclusively available to satisfy
such investors and creditors.

Unless otherwise provided for in the resolution of the manager or the board of managers of the Company having

created such Compartment, no resolution of the manager or the board of managers of the Company may be taken to
amend the resolution having created such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of
the investors and of the creditors whose rights relate to such Compartment without the prior approval of all investors
and of all creditors whose rights relate to this Compartment. Any decision of the manager or the board of managers
taken in breach of this provision shall be void.

Each Compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation

of another Compartment or of the Company itself.

The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific Compartments, assets or risks, or whose

repayment is subject to the repayment of other instruments or certain claims.

D. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is(are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its(their) office. He(they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager. 

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

112300

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its(their) mandate, any personal liability in relation to any

commitments validly and regularly made by him(them) in the name of the Company, provided that such commitment is
in compliance with the present articles of association as well as with the Securitisation Law and the Companies Law.
They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

E. Independent auditor

Art. 17. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an independent au-

ditor (réviseur d’entreprises) appointed by the manager(s) and remunerated by the Company.

The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by the Company Law and the Securitisation Law.

F. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the Companies Law.

G. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.

Art. 22. Each year on December 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners. The remainder of
the annual net profits, if any, shall be distributed as dividends to the partners in accordance with the Securitisation Law.

H. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Se-

curitisation Law and the Companies Law.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31st, 2006.

112301

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately three thousand euro.

<i>General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Godfrey Abel, employee, born on July 2, 1960, in Brixworth, England, with professional address at 46A, avenue

John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. 

- Mr. Michael S. Thomas, executive, born on March 9, 1967, in Alleghely, United States of America, with private ad-

dress at 9, rue Geischleid, L-9184 Schrondweiler, Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the
present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, une fondation établie et existante selon les lois des Pays-Bas, enre-

gistrée auprès du registre de la Chambre de Commerce et des Industries d’Amsterdam, Pays-Bas (trade register of the
Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam), sous le numéro 34226972, ayant son siège social à Naritaweg
165, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas,

ici représentée par Monsieur François Deprez, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé donnée à Amsterdam, le 9 octobre 2006.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire restera annexée au pré-

sent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SLOANE GARDENS (la «Société»)

qui aura le statut d’une société de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation (la «Loi sur la
Titrisation») et qui sera soumise à et régie par les dispositions de la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août 1915 concer-
nant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»), ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La Société a pour objet exclusif de conclure une ou plusieurs opération(s) de titrisation conformément à la

Loi sur la Titrisation et la Société peut, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession
d’actifs mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles, ainsi que les risques résultant d’engagements assumés par des
tiers ou liés à toutes ou partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régu-
lière. La Société assumera ces risques en acquérant des actifs, en garantissant les engagements ou en s’engageant par
tout autre manière. La Société peut également céder, dans les limites prévues par la loi et par les présents statuts, dis-
poser des créances et autres actifs qu’elle détient, présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon
régulière.

La Société peut, dans ce même contexte, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres, actifs,

obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres sûretés. La Société peut seulement octroyer
des gages, autres garanties ou sûretés, de quelque nature que ce soit à des sociétés luxembourgeoises ou étrangères,
conformément à l’objet susmentionné.

La Société peut ouvrir un ou plusieurs Compartiments (tel que défini ci-après) en conformité avec l’article 10 des

présents statuts.

La Société peut effectuer tout investissement ou opération de nature légale, commerciale, technique ou financière,

et en général, toute transaction nécessaire ou utile à l’accomplissement de son objet, ainsi que toute opération facilitant
directement ou indirectement l’accomplissement et au développement de son objet dans tous les domaines décrits ci-
dessus. Les actifs de la Société ne pourront être cédés qu’en conformité avec les dispositions régissant les titres émis
en vue de financer l’acquisition de tels actifs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

112302

Le siège social peut être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs

gérants, par décision du conseil de gérance.

Des succursales ou bureaux peuvent être établis tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par simple

décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économi-

que ou social, de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée
avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il peut transférer provisoirement
le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société
luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 8. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être

cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Compartiments

Art. 10. Le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société pourront créer un ou plusieurs compartiments au

sein de la Société (le «Compartiment» ou les «Compartiments»). Chaque Compartiment devra, sauf disposition con-
traire dans la résolution du gérant ou du conseil de gérance créant un tel compartiment, correspondre à une partie
distincte de l’actif et du passif de la Société. La résolution du gérant ou du conseil de gérance créant un ou plusieurs
Compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, lieront les tiers, à compter de la date
de la résolution.

Par rapport aux investisseurs et aux créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une

entité séparée. Les droits des investisseurs et des créanciers de la Société (i) qui lorsqu’ils sont entrés en existence, ont
été désignés comme rattaché à un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise
en liquidation d’un Compartiment sont, sauf disposition contraire dans la résolution du gérant unique ou du conseil de
gérance créant un tel Compartiment, strictement limitées aux actifs de ce Compartiment et seront exclusivement dis-
ponibles pour satisfaire ces investisseurs et créanciers.

Sauf disposition contraire dans la résolution du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société ayant créé un

tel Compartiment, aucune résolution du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société ne pourra être prise afin
de modifier la résolution ayant créé un tel Compartiment ou afin de prendre tout autre décision affectant directement
les droits des investisseurs et des créanciers dont les droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement
préalable de l’ensemble des investisseurs et des créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute
décision prise par le gérant unique ou par le conseil de gérance en violation de cette disposition sera nulle et non avenue.

Chaque Compartiment de la Société pourra être liquidé séparément sans que cette liquidation n’entraîne la liquida-

tion d’un autre Compartiment ou de la Société elle-même.

La Société pourra émettre des valeurs mobilières dont la valeur ou l’intérêt est lié à des Compartiments, actifs ou

autres engagements spécifiques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d’autres instruments ou de cer-
tains droits.

D. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

112303

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 15. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur mandat, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans le mesure où un tel engagement est en conformité
avec les présents statuts ainsi qu’avec la Loi sur la Titrisation et la Loi sur les Sociétés Commerciales. Simples manda-
taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

E. Le réviseur d’entreprises

Art. 17. Les données comptables liées au rapport annuel de la Société seront examinées par un réviseur d’entrepri-

ses nommé par le(s) gérant(s) et rémunéré par la Société.

Le réviseur d’entreprises accomplira toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur les Sociétés Commer-

ciales et par la Loi sur la Titrisation.

F. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

G. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

112304

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
surplus des profits annuels sera distribué comme dividendes aux associés conformément à la Loi sur la Titrisation.

H. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la Loi

sur la Titrisation et la Loi sur les Sociétés Commerciales.

<i>Souscription et libération

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à trois mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associée, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Godfrey Abel, employé privé, né le 2 juillet 1960, à Brixworth, Angleterre, ayant son adresse profession-

nelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Michael S. Thomas, executive, né le 9 mars 1967, à Alleghely, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse

privée au 9, rue Geischleid, L-9184 Schrondweiler, Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

taire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Deprez, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2006, vol. 907, fol. 83, case 9. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(122134.3/239/410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.

DIARUSE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 108.501. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 octobre 2006, que le mandat d’ad-

ministrateur de M. Eddy Dôme, a été reconduit jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur
les comptes clos au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02202. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121668.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Belvaux, le 7 novembre 2006.

J.-J. Wagner.

<i>Pour <i>DIARUSE REAL ESTATE S.A.
B. Akhertous
<i>Mandataire

112305

AUDITEURS &amp; ADMINISTRATEURS ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1240 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 93.937. 

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01968, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 13 novembre 2006.

(121709.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

RAPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 86.939. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02625, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121407.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

BAYAMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 93.961. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02779, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121458.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

ISDC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 74.929. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02774, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121460.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT QUINCIEUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 103.971. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 17 octobre 2006

<i>Quatrième résolution

L’Associé unique approuve la démission de M. Alain Heinz de son poste de gérant de la société avec effet immédiat.
L’Associé unique décide de nommer Mlle Marjoleine Van Oort, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe,

L-1116 Luxembourg au poste de gérante de la société avec effet au 5 mai 2006.

<i>Cinquième résolution

L’Associé unique décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00443. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121706.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Signatures.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Signatures.

Pour extrait 
<i>Pour la société
Signature

112306

ISLALI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 74.930. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02768, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121461.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

IRACO, COMPTOIR D’IMPORTATIONS, REPRESENTATIONS ET AGENCES, Société Anonyme.

Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.

R. C. Luxembourg B 6.026. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03294, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

(121545.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

PHI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 68.326. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04717, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121652.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

ECOTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.186. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04716, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121653.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

HINES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 106.807. 

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société du 16 octobre 2006

En date du 16 octobre 2006, le gérant unique de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société vers

l’adresse suivante: 205, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg avec effet au 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02094. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121682.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Signatures.

IRACO S.A.
Signature

Signatures.

Signature.

HINES LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

112307

JCBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 86.148. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04715, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121654.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

DIALNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 54.213. 

Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04690, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121658.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

JCBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 86.148. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04714, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121659.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

VONTOBEL EUROPE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1450 Luxemburg, 1, Côte d’Eich.

H. R. Luxemburg B 78.142. 

AUSZUG

Anlässlich der am 16. März 2006 abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammlung wurde beschlossen,
- Herrn Christoph Ledergerber,
- Herrn Martin de Quervain,
- Herrn Dr Ulrich Behm,
als Verwaltungsräte bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahre 2007 wiederzuernennen, sowie
- Herrn Dr Zeno Staub
Adresse:
Dianastrasse 5, Ch-8022 Zürich, Schweiz
als Verwaltungsratmitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahre

2007 neu zu ernennen.

Herr Dr Staub wird Herrn Serdar Aktasli im Verwaltungsrat ablösen.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ERNST &amp; YOUNG S.A. mit eingetragenem Sitz in 7, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Munsbach, R.C.S. Luxemburg B 47.771, wurde als Abschlussprüfer (réviseur d’entreprises) für das am 31. De-
zember 2006 endende Geschäftsjahr ernannt.

Zwecks Veröffentlichung des Vorstehenden im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. November 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00880. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121847.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Signatures
<i>Administrateurs

Signature.

Signatures
<i>Administrateurs

VONTOBEL EUROPE S.A.
Unterschrift

112308

STEEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 116.815. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg en date du 6 octobre 2006

que:

1. Il a été décidé d’accepter la démission de la société COMPAGNIE DE RESTAURATION OUTRE MER LIMITEE en

tant qu’administrateur de la société; 

2. Il a été décidé d’élire Monsieur Philippe Pedrini, né le 15 novembre 1958 à Longwy, France, demeurant au 27, rue

de la Gare, L-8229 Mamer, Luxembourg, en tant qu’administrateur. Son mandat prend fin à l’issue de l’assemblée géné-
rale annuelle de l’an 2011.

Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07624. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(121669.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

MIWWELHAUS KOEUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mersch, 4, Um Mierscherbierg.

R. C. Luxembourg B 64.400. 

Par décision de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration en date du 18 mai 2005 ont été nommés, jusqu’à

l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2008: 

<i>Administrateurs:

- Christiane Nickels, née le 3 juin 1958 à Ettelbrück, employée privée, demeurant 53, Cité Waarkdall, L - 9030 War-

ken, Président

- François Koeune, né le 1

er

 octobre 1947 à Esch sur Alzette, commerçant, demeurant 53, Cité Waarkdall, L - 9030

Warken, Administrateur-délégué

- Simon Fernand, né le 23 août 1962 à Ettelbrück, employé privé, demeurant 1A, rue J.P. Gaspard, L- 9142 Burden,

Administrateur

<i>Commissaire aux comptes: 

EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00444. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121670.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

ONYX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 117.087. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 24 octobre 2006

<i>Première résolution

L’Assemblée prend note de la démission de M. Thierry Triboulot en tant qu’administrateur de la Société.
Elle nomme en remplacement M. Fabio Mazzoni, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe L-1116 Luxem-

bourg, avec effet au 25 juillet 2006.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00446. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121702.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour extrait conforme
HOOGEWERF &amp; CIE
<i>Agent domiciliataire
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

112309

MOOD MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon.

R. C. Luxembourg B 112.404. 

<i>Extrait de la résolution du Conseil d’administration du 1

<i>er

<i> octobre 2006

En date du 1

er

 octobre 2006 le Conseil d’administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la So-

ciété vers l’adresse suivante: 56, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg, avec effet au 1

er

 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02090. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121687.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

SOPAF ASIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 117.339. 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société dans sa réunion du 11 octobre 2006 a décidé:
- D’augmenter le nombre des Gérants de la Société de 3 (trois) à 4 (quatre); 
- De nommer comme gérant avec effet à partir du 11 octobre 2006, Monsieur Fabio De Rosa, né le 17 février 1963

à Napoli (Italie), résidant 37 Barker Road, Hong Kong, pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121710.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

WP IX LUXCO III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 118.066. 

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique prises en date du 8 novembre 2006

En date du 8 novembre 2006, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
de nommer
* Mme Cheryl Nicholson, née le 16 février 1975 à Poughkeepsie, Etats-Unis, avec adresse professionnelle au 466

Lexington Avenue, New York, NY-10017, Etats-Unis, en tant que gérant de classe A de la Société avec effet au 8 no-
vembre 2006 et à durée indéterminée.

* Mme Ute Bräuer, née le 1

er

 décembre 1956 à Oberhausen, Allemagne, avec adresse professionnelle au 14, rue Eras-

me, L-1468 Luxembourg, en tant que gérant de classe B de la Société avec effet au 8 novembre 2006 et à durée indé-
terminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance la Société est désormais composé des personnes suivantes:

Gérants de classe A:
Monsieur Timothy Joseph Curt;
Madame Tara Kerley;
Madame Cheryl Nicholson.

Gérants de classe B:
Monsieur Michel Raffoul;
Monsieur Guy Harles;
Madame Ute Bräuer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02745. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121858.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

MOOD MEDIA GROUP S.A.
Signature

SOPAF ASIA, S.à r.l.
Signature

WP IX LUXCO III, S.à r.l.
Signature

112310

CAROLIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 117.192. 

Modification de l’adresse professionnelle de plusieurs administrateurs:
James Yates, Brettenham House, 5, Lancaster Place, WC2E 7EN London, United Kingdom
Andrew Crankshaw, Brettenham House, 5, Lancaster Place, WC2E 7EN London, United Kingdom
Christopher Masek, Brettenham House, 5, Lancaster Place, WC2E 7EN London, United Kingdom
Dan Soundry, Brettenham House, 5, Lancaster Place, WC2E 7EN London, United Kingdom
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02180. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(122106.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.

LIKIPI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.806. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 août 2006

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour la période expirant à l’assemblée

générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00448. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(122122.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.

HONOTIMBER COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort.

R. C. Luxembourg B 51.348. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 août 2006

Il ressort de l’assemblée générale extraordinaire du 17 août 2006 que celle-ci a:
1/ accepté la démission:
- de Madame Claudine Wattier-Depiesse de son poste d’administrateur, 
- du BUREAU COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS S.A. de son poste de commissaire.
2/ désigné pour une durée de 6 ans soit jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2012:
- Mademoiselle Lison Miest, administrateur de société, née à Libramont (Belgique), le 12 décembre 1983 et demeu-

rant 47, route d’Orval à B-6820 Florenville au poste d’ administrateur,

- Monsieur Frédéric Marloye, ouvrier, né à Ougrée (Belgique), le 30 novembre 1959 et demeurant 79, rue de Virton,

Valansart B-6810 Chiny au poste de commissaire aux comptes.

3/ renouvelé les mandats d’administrateurs de Messieurs Paul-Emile Miest et Bastien Miest pour une durée de 6 ans

soit jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2012.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06990. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121744.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Signature.

MM. Massimo Magnoni, avocat, demeurant à Calle Muntaner 454, E-08006, Barcelone (Espagne) président;

Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Pascale Mariotti, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

P.-E. Miest 
<i>Administrateur-délégué

112311

QUADRIGA LUXEMBOURG HISTORIC MILITARY VEHICLE COLLECTORS, 

Association sans but lucratif.

Siège social: Bereldange.

R. C. Luxembourg F 6.484. 

STATUTS 

Chapitre 1

er

. Dénomination, objet et durée

1) L’association prend la dénomination QUADRIGA LUXEMBOURG HISTORIC MILITARY VEHICLE COLLEC-

TORS, et a été constituée le 31 décembre 1984.

2) Elle a pour objet de collectionner, de restaurer et de conserver des véhicules militaires historiques, d’établir des

liens d’amitié entre ses membres et ceux d’associations poursuivant le même but, d’organiser et de participer à des ma-
nifestations se rattachant à cet objet.

3) L’association a son siège social à Bereldange.
4) L’association est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre 2. Des membres

5) L’association se compose de membres associés, qui seuls jouissent des droits et avantages prévus par la loi du 21

avril 1928.

6) La qualité de membre associé se perd,
a) par la démission volontaire du membre en question;
b) qui nuit à la réputation de l’association;
c) qui perturbe les liens d’amitié entre ses membres;
d) qui organise et s’engage envers des tiers sous le nom de l’association, sans que le conseil d’administration l’ait dé-

légué.

Chapitre 3. Administration

7) L’administration est administrée par un conseil d’administration composée de 5 à 7 membres. Le conseil d’admi-

nistration est élu par l’assemblée générale.

8) La durée du mandat des administrateurs est de 4 ans. Pourtant la moitié des administrateurs sortiront tous les

deux ans. La première fois sortiront: le président, le trésorier et un ou plusieurs membres adjoints à déterminer par
tirage au sort. 

9) Les administrateurs sortants sont rééligibles. Les autres candidatures pour un mandat d’administrateur doivent

être adressées par écrit au président au moins 24 heures avant le début de l’assemblée générale. Les élections auront
lieu par vote secret à la majorité des voix absolue. En cas de ballottage, la simple majorité décide. En cas de voix égales,
la décision sera prise par tirage au sort. 

10) En cas de vacance d’une place de membre du conseil d’administration pendant une période en cours, il sera pro-

cédé au remplacement qu’à la prochaine assemblée générale. Le membre élu alors en dernier lieu ne demeurera en fonc-
tion que pour la durée du mandat de celui qu’il remplace.

11) Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier et de

1 à 3 membres adjoints. Le président est élu séparément. Le vote du président par acclamation est autorisé. Le conseil
d’administration élit dans son sein le vice-président, le secrétaire et le trésorier.

12) Les décisions du conseil d’administration sont valables lorsque la moitié de ses membres sont présents. Les dé-

cisions sont prises à la majorité des suffrages et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

13) Le conseil d’administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale par

la loi ou par les statuts. Il gère les affaires de l’association et la représente dans les actes judiciaires et extrajudiciaires,
dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs publics.

14) Les signatures conjointes de deux administrateurs désignés par le conseil d’administration engagent valablement

l’association.

Chapitre 4. Exercice social, règlement des comptes

15) L’exercice social commence le 1

er

 janvier et clôture le 31 décembre.

16) Tous les membres associés doivent être convoqués par avis postal aux assemblées générales. L’ordre du jour doit

être joint à la lettre de convocation. L’assemblée générale ordinaire est convoquée à l’occasion de la clôture de l’année
sociale (au mois de janvier). Elle peut être convoquée extraordinairement par le conseil d’administration, celui-doit la
convoquer lorsque la moitié des membres associés le demandent par lettre adressée au président un mois avant la date
prévue pour cette assemblée.

17) L’assemblée générale du mois de janvier désigne 2 commissaires chargés du contrôle de la comptabilité et de la

gestion administrative. Leur mandat dure une année. Ils sont rééligibles. Ils soumettront leur rapport à l’approbation de
l’assemblée générale.

18) L’assemblée générale entend le rapport du conseil d’administration sur l’activité et la situation matérielle et mo-

rale de l’association; elle approuve le budget de l’exercice suivant et statue sur toutes les propositions qui lui sont sou-
mises par le conseil d’administration. Il ne peut être statué sur des questions qui ne figurent pas à l’ordre du jour;
toutefois, l’assemblée générale peut décider, à la majorité absolue, que l’une ou l’autre question soulevée au cours de
la réunion, est à considérer comme étant à l’ordre du jour.

19) L’assemblée générale délibère quel que soit le nombre des membres associés présents ou représentés. Elle prend

ses décisions à la majorité absolue des votes émis, sauf le cas ou il est décidé autrement par les statuts ou par la loi. Le
vote par procuration est admis, le mandataire doit être lui-même membre associé; il ne peut cependant accepter plus

112312

d’une procuration. Le vote a lieu au scrutin secret, sauf décision contraire à prendre par l’assemblée. Les décisions de
l’assemblée générale sont inscrites dans un registre ad hoc et signées par les membres qui ont rempli les fonctions de
président et de secrétaire de l’assemblée générale. Tous les membres associés peuvent en prendre connaissance.

20) Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables à tous les cas non prévus par les présents statuts.
21) Dès la présentation de sa demande d’admission, chaque membre associé déclare adhérer aux présents statuts,

ne pas rendre responsable l’association pour des accidents survenus pendant des excursions ou manifestations mises au
programme par l’association, ni exiger de celle-ci le paiement d’indemnités pour dommages encourus. 

Chapitre 5. Dissolution et liquidation

22) La dissolution et liquidation de l’association sera réglée par chapitre 18 à 25 de la loi du 21 avril 1928. 
L’assemblée générale délibère sur les déterminations de la fortune de l’association.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03446. – Reçu 164 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121736.3//78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

TYREE FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.800. 

L’adresse professionnelle de Monsieur Eric Biren, Administrateur C de la Société, qui était au 43, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg, a changé et est désormais la suivante:

68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

Fait à Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02798. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(122126.5//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.

FLANDRE EUROPE, Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 62.400. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 septembre 2006

1. L’Assemblée Générale prend acte de la démission, en date de ce jour, de la société FIDALUX S.A. de son mandat

de liquidateur

2. L’Assemblée Générale décide de nommer liquidateur avec effet immédiat, la société DELANOE TRADING LTD,

ayant son siège social Wickham’s Cay à Tortola (Panama) en remplacement du liquidateur démissionnaire.

Le mandat du liquidateur nouvellement élu prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire ratifiant la

liquidation définitive de la société.

3.Néant. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW03058. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(122128.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.

INTERLIGNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 99.709. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04761, ont

été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés le 13 novembre 2006, conformément
à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121760.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

<i>TYREE FINANCING S.A.
Signature

<i>Pour extrait conforme 
Signature 
<i>Le liquidateur 

Signature.

112313

INTERLAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.555. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 2 novembre 2006.

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Mmes. Sarah Bravetti et Sophie Jacquet décidée par le conseil d’admi-

nistration en ses réunions du 10 avril 2006 et 6 septembre 2006. 

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur la mise en liquidation de la société comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L - 1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02846. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(122127.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.

MISYS OVERSEAS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.849. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée des associés tenue le 18 octobre 2006

Il résulte dudit procès-verbal que:
PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg est nommé en tant que réviseur d’entreprises. Son

mandat expirera à l’issue de l’assemblée des associés statuant sur les comptes de l’exercice se clôturant au 31 mai 2007.

Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00918. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121711.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

AUDIT &amp; COMPLIANCE, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,-.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 115.834. 

Par la présente, nous vous notifions notre changement de siège social, à compter du 1

er

 novembre 2006, au:

65, rue des Romains, L-8041 Strassen.
Notre siège social était auparavant au 93 de la même rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03472. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121759.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

MM.

Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme. Sarah Bravetti, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Sophie Jacquet, employé e privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

AUDIT &amp; COMPLIANCE, S.à r.l.
C. Lamorlette / P.-F. Wéry 
<i>Associé-gérant / Associé

112314

IMMO REAL S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 27.323. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 7 septembre

2006, enregistré à Luxembourg A.C., le 11 septembre 2006, volume 29CS, folio 55, case 7, que l’assemblée a décidé de
clôturer la liquidation et à pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relative aux sociétés com-
merciales et conformément à l’article 9 de ladite loi:

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société:

23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121732.3/211/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 19.116. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège de la société, le 28 septembre 2006

Le Conseil d’Administration coopte M. Paul Lembrechts, demeurant ABN AMRO BANK N.V., De Entrée, 99, NL-

1101 HE Amsterdam, en remplacement de M. Jos ter Avest, demeurant ABN AMRO BANK N.V., De Entrée, 99, NL-
1101 HE Amsterdam, démissionnaire.

Le mandat de M. Paul Lembrechts fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale d’ABN AMRO

BANK (LUXEMBOURG) S.A. qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06126. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121733.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

ELNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 54.785. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01088, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121671.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

AVER ASSOCIATES LUXEMBOURG, Société Anonyme,

(anc. KOEN LOZIE &amp; PARTNERS LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-8356 Garnich, 18, rue des Sacrifiés.

R. C. Luxembourg B 73.420. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06977, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121780.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

<i>Pour la société
J. Elvinger
<i>Notaire

Pour extrait et traduction conformes
ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Signature.

 

Signature.

112315

BNP PARIBAS InstiCash, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Howald-Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R. C. Luxembourg B 65.026. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution circulaire du Conseil d’Administration du 18 août 2006 que Madame Annyse Guillaume a

démissionné de ses mandats d’Administrateur et de Secrétaire Général en date du 18 août 2006.

Le Conseil d’Administration a décidé de ne pas remplacer, pour le moment, les mandats d’Administrateur et de Se-

crétaire Général laissés vacants par Madame Annyse Guillaume.

Luxembourg, le 12 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04584. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121777.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

INTERLIGNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 99.709. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04768, ont

été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés, le 13 novembre 2006, conformément
à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121784.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

HUB INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 93.896. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01084, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121673.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

STARSUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle In den Allern.

R. C. Luxembourg B 107.569. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04769, ont

été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés, le 13 novembre 2006, conformément
à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121788.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

J. HERMANS &amp; CO (SUCCURSALE DE LUXEMBOURG).

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 106.060. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06983,

ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés, le 13 novembre 2006, conformé-
ment à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121794.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

<i>Le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Signatures

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

112316

GC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 108.535. 

Les comptes annuels au 31 mai 2006, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06981, ont été

déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés, le 13 novembre 2006, conformément à
l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121797.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

UNION SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 72.160. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de gérance tenu le 19 septembre 2006

Le Conseil constate que suit au transfert de siège de AUTOGRILL OVERSEAS S.A., les 200 parts détenues dans la

société ont été vendues à EDIZIONE FINANCE INTERNATIONAL S.A., détenteur de 500 parts sociales UNION SER-
VICES, S.à r.l. Cette dernière détient par conséquent au total 700 parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02357. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121798.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

LUBRA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 56.017. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03510,

ont été déposés, dans leur vesion abrégée, au registre de commerce et des sociétés, le 13 novembre 2006, conformé-
ment à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121801.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

HONOTIMBER COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort, 2, rue de Kleinbettingen.

R. C. Luxembourg B 51.348. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06985,

ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés, le 13 novembre 2006, conformé-
ment à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121803.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

WISSON INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha.

R. C. Luxembourg B 62.004. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00441, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121807.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Signature.

UNION SERVICES, S.à r.l.
Signature

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Signature.

112317

I.C. INTERCONSULT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-3542 Dudelange, 46, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 79.395. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00439, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121810.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

IMMEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.027. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 2 octobre 2006 à 10.00 heures

- Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Monsieur Koen Lozie, Monsieur Jean Quin-

tus et de COSAFIN S.A., Administrateurs et de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux Comptes.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée

générale qui approuvera les comptes arrêtés au 30 juin 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02557. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121811.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

BUS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.168.450,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 72.121. 

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de BUS HOLDINGS, S.à r.l. en date du 24 octobre 2006

que le siège social de BUS HOLDINGS, S.à r.l., a été transféré du 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
au 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, avec effet à partir du 1

er

 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02958. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121814.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

FS INVEST II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 1.511.018.200,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 107.850. 

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de FS INVEST II, S.à r.l. en date du 24 octobre 2006 que

le siège social de FS INVEST II, S.à r.l. a été transféré du 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 9-11,
Grand-rue, L-1661 Luxembourg, avec effet à partir du 1

er

 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02968. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121821.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Signature.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour <i>BUS HOLDINGS, S.à r.l.
G. Meijssen
<i>Gérant

<i>Pour <i>FS INVEST II, S.à r.l.
A. Steichen
<i>Gérant

112318

MORA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.659. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 26 octobre 2006 à 11.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- Par ailleurs, l’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat des administrateurs de Messieurs J. Quintus,

K. Lozie et de la société COSAFIN S.A., ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier
pour une nouvelle durée d’un an.

- Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 30 juin

2007.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02562. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121819.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

FS INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 1.537.489.600,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 107.851. 

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de FS INVEST, S.à r.l. en date du 24 octobre 2006 que le

siège social de FS INVEST, S.à r.l. a été transféré du 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 9-11, Grand-
rue, L-1661 Luxembourg, avec effet à partir du 1

er

 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02965. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121823.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

MERLAC, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 106.515. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des associés qui s’est tenue le 10 mai 2006 à 10.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat du Gérant Unique, Madame Rosa Mortelmans, pour un terme venant

à échéance à l’assemblée ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07308. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121829.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

NEXCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.436. 

Le bilan au 31 décembre 2005 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01508,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(122671.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2006.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour <i>FS INVEST, S.à r.l.
A. Steichen
<i>Gérant

Pour extrait conforme
Signature
<i>Gérant

Luxembourg, le 14 novembre 2006.

Signature.

112319

SINTRAL, SOCIETE INTERNATIONALE D’ALIMENTATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.716. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 4 octobre 2006 à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateurs de M. Jean Quin-

tus, de M. Joseph Winandy et de la société GILDA PARTICIPATIONS S.A. représentée par M. Jean Quintus;

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide a l’unanimité de renouveler le mandant de Commissaire aux Comptes de

Monsieur Noël Didier;

- Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire qui

statuera sur les comptes arrêtés au 31 juillet 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04533. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121825.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

WHITEHALL STREET INTERNATIONAL REPIA FUND 2005, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 118.575,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 107.557. 

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de WHITEHALL STREET INTERNATIONAL REPIA

FUND 2005, S.à r.l. en date du 24 octobre 2006 que le siège social de WHITEHALL STREET INTERNATIONAL REPIA
FUND 2005, S.à r.l. a été transféré du 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 9-11, Grand-rue, L-1661
Luxembourg, avec effet à partir du 1

er

 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02961. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121826.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

NEXCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.436. 

Le bilan au 31 décembre 2004 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01505,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(122673.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2006.

MAGGI CONTROLS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.124. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02190, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2006.

(122692.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2006.

Pour copie conforme
Signature

<i>Pour <i>WHITEHALL STREET INTERNATIONAL REPIA FUND 2005, S.à r.l.
G. Meijssen
<i>Gérant

Luxembourg, le 14 novembre 2006.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

112320

GSMP 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 96.136. 

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de GSMP 3, S.à r.l. en date du 24 octobre 2006 que le siège

social de GSMP 3, S.à r.l. a été transféré du 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 9-11, Grand-rue,
L-1661 Luxembourg, avec effet à partir du 1

er

 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02997. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121832.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

ALCHEMY HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 9.798.000,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 112.479. 

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de ALCHEMY HOLDING, S.à r.l. en date du 24 octobre

2006 que le siège social de ALCHEMY HOLDING, S.à r.l. a été transféré du 31, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, avec effet à partir du 1

er

 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02996. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121839.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

PELICAN HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 116.857. 

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de PELICAN HOLDCO, S.à r.l. en date du 24 octobre

2006 que le siège social de PELICAN HOLDCO, S.à r.l. a été transféré du 31, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, avec effet à partir du 1

er

 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02993. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121841.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

<i>Pour <i>GSMP 3, S.à r.l.
R. Villalobos
<i>Gérante

<i>Pour <i>ALCHEMY HOLDING, S.à r.l.
G. Meijssen
<i>Gérant

<i>Pour <i>PELICAN HOLDCO, S.à r.l.
G. Meijssen
<i>Gérant

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

GSCP 2000 Eurovision Holding, S.à r.l.

GSMP 2006 Onshore, S.à r.l.

Eurinox S.A.

Patri Immo S.A.

Caesar Holding S.A.

Caesar Holding S.A.

Systemat (Luxembourg) S.A.

Post Office Holding S.A.

HCEPP II Luxembourg Master II, S.à r.l.

Snowdonia (NFR), S.à r.l.

CPI Kildare, S.à r.l.

Comparco S.A.

Opal Corporation (NFR), S.à r.l.

Bulgari (Luxembourg) S.A.

Zitol Holding S.A.

Worldwide Mounts, S.à r.l.

Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg m.b.H.

Maramco S.A.

Société Européenne de Boissons S.A.

JCBO S.A.

Martur Finance S.A.

Carbon Trade &amp; Finance SICAR S.A.

Patri Immo S.A.

Real Espana S.A.

Resinex S.A.

Araich Limited S.A.

Araich Limited S.A.

Casa Investments S.A.

Irman International Holding S.A.

Protec International S.A.

Sloane Gardens

Diaruse Real Estate S.A.

Auditeurs &amp; Administrateurs Associés S.A.

Rapin S.A.

Bayamo S.A.

ISDC Finance S.A.

Société d’Investissement Quincieux, S.à r.l.

Islali Invest S.A.

IRACO, Comptoir d’Importations, Représentations et Agences

PHI Participations S.A.

Ecotrade S.A.

Hines Luxembourg, S.à r.l.

JCBO S.A.

Dialna S.A.

JCBO S.A.

Vontobel Europe S.A.

Steeg S.A.

Miwwelhaus Koeune S.A.

Onyx International S.A.

Mood Media Group S.A.

Sopaf Asia, S.à r.l.

WP IX Luxco III, S.à r.l.

Carolis International S.A.

Likipi Holding S.A.

Honotimber Company S.A.

Quadriga Luxembourg Historic Military Vehicle Collectors

Tyree Financing S.A.

Flandre Europe

Interligne, S.à r.l.

Interlac S.A.

Misys Overseas Investments, S.à r.l.

Audit &amp; Compliance

Immo Real S.A.

ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.

Elna S.A.

Aver Associates Luxembourg

BNP Paribas InstiCash

Interligne, S.à r.l.

HUB Industries S.A.

Starsun S.A.

J. Hermans &amp; Co (Succursale de Luxembourg)

GC International S.A.

Union Services, S.à r.l.

Lubra S.A.

Honotimber Company S.A.

Wisson Investment Group S.A.

I.C. Interconsult AG

Immeurope S.A.

Bus Holdings, S.à r.l.

FS Invest II, S.à r.l.

Mora S.A.

FS Invest, S.à r.l.

Merlac

Nexcom International S.A.

SINTRAL, Société Internationale d’Alimentation

Whitehall Street International Repia Fund 2005, S.à r.l.

Nexcom International S.A.

Maggi Controls Group S.A.

GSMP 3, S.à r.l.

Alchemy Holding, S.à r.l.

Pelican Holdco, S.à r.l.